This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1516
26 juin 2013
SOMMAIRE
Acronyme S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72729
Bainbridge Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
72735
BCF Photonics II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
72730
Immobilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72734
KRW Schindler Investment Management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72754
LBB Re Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
72736
Legacy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72737
Leopard Germany Holding Hotels S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72749
LREDS II (LBF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72738
Lukos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72737
Lux. Ouvrage d'Art S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
72737
Lux Santé S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72737
Management & Advisory Sàrl . . . . . . . . . . .
72733
May Fixation S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72768
MGP Europe (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
72722
MGP Europe Parallel (Lux) S.à r.l. . . . . . . .
72722
M&T's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72737
Paquita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72728
Partners Group Global Mezzanine 2005
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72731
Patron Capital Alpentherme S.à r.l. . . . . .
72723
Patron Capital Schweiz S.à r.l. . . . . . . . . . .
72731
Patron Carlo Felice Holdings S. à r.l. . . . . .
72723
Patron Furnas S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72724
Patron Generator S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
72724
Patron Jupiter Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
72725
Patron Karua S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72725
Patron Marina Velca Properties S.à r.l. . . .
72726
Patron Milan Properties S.à r.l. . . . . . . . . . .
72726
Patron Pipera Realty S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
72727
Patron Project III Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72727
Patron Project XVI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
72728
Patron Project XV S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
72728
Patron Romanian Realty S.à r.l. . . . . . . . . .
72729
Patron Sirius S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72729
Patron Sports Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
72730
Poblenou Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
72730
Polytech Industries S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
72732
Polytech Investment (SPF) S.A. . . . . . . . . .
72732
Roundabout S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72732
RP Complex Holding III S.à r.l. . . . . . . . . . .
72723
RPTRE I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72735
RP XVIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72733
RP XXII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72734
RP XXI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72734
RP XX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72733
Sapient Asia Holdings Luxembourg S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72735
Sapient Holdings Luxembourg S. à r.l. . . .
72754
Sapient Operations Luxembourg S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72736
Scala IRP Capital Partners . . . . . . . . . . . . . .
72736
SE Investmentfund-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
72727
SE Investmentfund-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
72732
ServiceMagic International S.à r.l. . . . . . . .
72736
Silverfleet Sixth Investment Company S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72724
Simplify S.C.A., SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . .
72725
Soccerworld Europe S. à r. l. . . . . . . . . . . . .
72726
Soloback S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72722
Stadsfeestzaal Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
72731
Trans-Immo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72722
Washington Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
72749
72721
L
U X E M B O U R G
MGP Europe (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 114.151.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 30 avril 2013.
<i>Pour MGP Europe (Lux) S.à r.l.
i>Delloula Aouinti
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013058129/16.
(130071196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
MGP Europe Parallel (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 114.150.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 30 avril 2013.
<i>Pour MGP Europe Parallel (Lux) S.à r.l.
i>Delloula Aouinti
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013058131/16.
(130071194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Soloback S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 156.899.
Monsieur Etienne Mouthon, administrateur de la société anonyme SOLOBACK S.A., ayant son siège social au 8, rue
Philippe II, L-2340 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B 156899, a pour adresse professionnelle 1, place Saint-Gervais CH-1201 Genève, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058308/11.
(130071233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Trans-Immo, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 12.184.
Le Bilan abrege au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06/05/2013.
Référence de publication: 2013058361/10.
(130071787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72722
L
U X E M B O U R G
Patron Capital Alpentherme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 82.604.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058164/19.
(130071502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Patron Carlo Felice Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 160.449.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058165/19.
(130070891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
RP Complex Holding III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.
R.C.S. Luxembourg B 140.565.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société en date du 2 avril 2013 que:
- M. Brian Borg a démissionné de sa fonction de gérant de type B de la Société en date du 1
er
avril 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 6 Mai 2013.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2013058250/15.
(130071717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72723
L
U X E M B O U R G
Patron Furnas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 164.337.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058168/19.
(130070914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Patron Generator S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 123.327.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058169/19.
(130070975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Silverfleet Sixth Investment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 152.513.
Par résolutions signées en date du 25 avril 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation, avec effet immédiat, de la démission de Yves Cheret, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant;
- nomination de Damien BECKEL, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2013.
Référence de publication: 2013058274/15.
(130071231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72724
L
U X E M B O U R G
Patron Jupiter Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 156.724.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058170/19.
(130070974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Patron Karua S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 164.335.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058171/19.
(130070973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Simplify S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 141.489.
Société anonyme fondée le 14 Août 2008 et publication dans le Mémorial C-N° 2384.
Les comptes annuels de 2012 ont été clôturés au 31 Décembre 2012 et approuvés lors de l’assemblée ordinaire des
actionnaires le 17 Avril 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24/04/2013.
Paddock Fund Administration
Gerry Salucci
Référence de publication: 2013058275/15.
(130071111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72725
L
U X E M B O U R G
Patron Marina Velca Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 119.918.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058172/19.
(130070972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Patron Milan Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 152.614.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058173/19.
(130071015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Soccerworld Europe S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 103.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 134.769.
Par résolutions prises en date du 20 mars 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Alan DUNDON, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, de son mandat de Gérant, avec effet immédiat;
- nomination de Chafai BAIHAT, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de Gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
Référence de publication: 2013058303/15.
(130071167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72726
L
U X E M B O U R G
Patron Pipera Realty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 123.475.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058174/19.
(130071014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Patron Project III Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 142.185.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058175/19.
(130071013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
SE Investmentfund-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 133.298.
Die Bilanz zum 30. September 2012 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2012 abgelaufene
Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 04. April 2013.
<i>Für SE Investmentfund – FIS
i>Die Zentralverwaltungsstelle:
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Référence de publication: 2013058291/15.
(130071790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72727
L
U X E M B O U R G
Patron Project XV S.àr.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 152.617.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058176/19.
(130071012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Patron Project XVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 154.169.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058177/19.
(130071025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Paquita, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 23, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 132.951.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement N° 327/13 du 28 février 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section,
siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations dans la liquidation suivante:
De la société PAQUITA, B132951, ayant eu son siège social à 23, rue du Commerce, L-3450 Dudelange.
Luxembourg, le 6 mars 2013.
Pour extrait conforme
Michèle STOFFEL
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013058436/15.
(130071795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72728
L
U X E M B O U R G
Patron Romanian Realty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 154.174.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058178/19.
(130071024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Patron Sirius S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 156.721.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058179/19.
(130071023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Acronyme S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 81.434.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07.05.2013.
<i>Pour: ACRONYME S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Johanna Tenebay
Référence de publication: 2013058477/15.
(130072612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.
72729
L
U X E M B O U R G
Patron Sports Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 147.439.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058180/19.
(130071022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Poblenou Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 149.998.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058183/19.
(130071501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
BCF Photonics II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.936.950,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 79.960.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 18 mars 2013i>
L'associé unique de la Société a décidé:
- de révoquer Madame Corinne Bitterlich en tant que gérant B de la Société avec effet au 1
er
mars 2013,
- de nommer Monsieur Lorenzo Barcaglioni, né le 18 avril 1974 à Rome, Italie, ayant son adresse professionnelle au
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 1
er
mars 2013 et pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058539/15.
(130072143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.
72730
L
U X E M B O U R G
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 108.922.
<i>Auszug aus dem Beschluss der Managementgesellschaft vom 25. April 2013i>
Am 25. April 2013 hat die Managementgesellschaft der Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR in einem
entsprechenden Beschluss einstimmig beschlossen, den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 01. Mai 2013 von 16,
Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg nach 55, avenue de la Gare, L - 161 Luxembourg zu verlegen.
Ferner wurde beschlossen, Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., RCS B 107 523, für einen unbestimmten Zeitraum
als Conseil d'administration / Administrateur zu bestellen. Die ursprüngliche Bestellung erfolgte bereits zum 29. Juni 2007.
Luxemburg, den 06. Mai 2013.
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2013058198/17.
(130071640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Patron Capital Schweiz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 82.252.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2013i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013058200/19.
(130070892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Stadsfeestzaal Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 123.434.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 30 avril 2013i>
L'associé unique de Stadsfeestzaal Lux S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- de nommer Luxembourg Corporation Company S.A, une société incorporée le 29 aout 1991, régie par les lois du
Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B37974, en tant que Gérant de la Société et ce avec effet au
2 Mai, 2013 pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 6 Mai, 2013.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013058280/17.
(130071821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72731
L
U X E M B O U R G
Polytech Industries S.A., Société Anonyme,
(anc. Polytech Investment (SPF) S.A.).
Siège social: L-3378 Livange, Z.I.C., rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 72.023.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 février 2013.
<i>Pour la société
i>Anja HOLTZ
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2013058211/14.
(130071342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Roundabout S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 55.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 140.745.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 30 avril 2013.
<i>Pour Roundabout S.à r.l.
i>Joanne Fitzgerald
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013058235/16.
(130071252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
SE Investmentfund-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 133.298.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung die am 14. März 2013 in Luxemburg stattfand:i>
1. Die Generalversammlung beschließt die folgenden Personen bis zur nächsten Generalversammlung, die über den
Jahresabschluss der SE Investmentfund - FIS für das am 30. September 2013 endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder zum
Verwaltungsrat zu ernennen:
- Stefan Schneider (Verwaltungsratsvorsitzender)
- Achim Welschoff (Verwaltungsratsmitglied)
- Jean-Marie Schomer (Verwaltungsratsmitglied)
2. Die Generalversammlung beschließt den Wirtschaftsprüfer, KPMG Luxembourg S.à r.l., wieder zum Wirtschafts-
prüfer der SE Investmentfund - FIS bis zur nächsten Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der SE Invest-
mentfund - FIS für das am 30. September 2013 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 04. April 2013.
<i>Für SE Investmentfund - FIS
i>Die Zentralverwaltungsstelle:
Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
Référence de publication: 2013058290/23.
(130071789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72732
L
U X E M B O U R G
Management & Advisory Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 163.664.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058927/9.
(130072290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.
RP XVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 132.332.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société en date du 2 avril 2013 que:
- M. Gregory J. Hartman et M. Brian Borg ont démissionné de leurs fonctions de gérant de type B de la Société en
date du 1
er
avril 2013;
et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1
er
avril 2013 et pour une
durée indéterminée:
- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953
Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);
- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953
Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 6 mai 2013.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2013058260/22.
(130071122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
RP XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 134.781.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société en date du 2 avril 2013 que:
- M. Gregory J. Hartman et M. Brian Borg ont démissionné de leurs fonctions de gérant de type B de la Société en
date du 1
er
avril 2013;
et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1
er
avril 2013 et pour une
durée indéterminée:
- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953
Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);
- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953
Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 6 mai 2013.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2013058261/22.
(130071139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72733
L
U X E M B O U R G
RP XXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 134.764.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société en date du 2 avril 2013 que:
- M. Gregory J. Hartman et M. Brian Borg ont démissionné de leurs fonctions de gérant de type B de la Société en
date du 1
er
avril 2013;
et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1
er
avril 2013 et pour une
durée indéterminée:
- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953
Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);
- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953
Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 6 mai 2013.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2013058262/22.
(130071149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
RP XXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 134.763.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société en date du 2 avril 2013 que:
- M. Gregory J. Hartman et M. Brian Borg ont démissionné de leurs fonctions de gérant de type B de la Société en
date du 1
er
avril 2013;
et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1
er
avril 2013 et pour une
durée indéterminée:
- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953
Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);
- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953
Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 6 mai 2013.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2013058263/22.
(130071165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Immobilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8364 Hagen, 22, Op der Gewan.
R.C.S. Luxembourg B 169.761.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058785/9.
(130072326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.
72734
L
U X E M B O U R G
RPTRE I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.
R.C.S. Luxembourg B 140.024.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société en date du 2 avril 2013 que:
- M. Brian Borg a démissionné de sa fonction de gérant de type B de la Société en date du 1
er
avril 2013;
et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet immédiat au 1
er
avril 2013
et pour une durée indéterminée:
- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953
Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);
- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953
Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 6 Mai 2013.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2013058265/21.
(130071401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Sapient Asia Holdings Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 247.500,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 145.138.
<i>Extrait sincère et conforme des résolutions de l'associé unique de Sapient Asia Holdings Luxembourg S.à.r.l. (La société") adoptéesi>
<i>le 2 mai 2013i>
<i>Résolutioni>
L'associé unique DECIDE de nommer, à durée indéterminée:
Mie. Elizabeth CONDER, née le 27 Novembre 1976 à Welwyn Garden City, Royaume Uni et avec adresse à 16 Frognal
Gardens, Fiat 4, Londres NW3 6UX, Royaume Uni,
comme nouveau gérant au conseil de gérance de la Société, avec effet au 2 Mai 2013.
<i>Pour & au nom de SAPIENT ASIA HOLDINGS LUXEMBOURG S.A.R.L.
Mandatairei>
Référence de publication: 2013058271/17.
(130071460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Bainbridge Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 105.017.
Suite à un contrat de cession de parts sociales conclu en date du 1
er
juillet 2012, il a été convenu que la société LDV
Management Bainbridge Holding S.C.A., ayant son siège social à 6A Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B104.028 à cédé l'intégralité des parts
sociales détenues dans la Société (500), représentant 100% du capital social de la Société, à la société Coop 17 Holding
S.à r.l., ayant son siège social à 6A Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B162.325.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058523/15.
(130072417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.
72735
L
U X E M B O U R G
Scala IRP Capital Partners, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 92-1A, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 144.614.
Avec effet au 19 juillet 2011, Monsieur Hans-Jürgen Bornefeld a démissionné de son poste de gérant de la Société.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Scala IRP Capital Partners
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013058272/13.
(130071658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
ServiceMagic International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 187.700,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 142.539.
Il est porté à connaissance des tiers que le nom de l'Associé Unique de la Société est modifié comme suit, avec effet
au 21 septembre 2012:«ServiceMagic, Inc.» devient «HomeAdvisor, Inc.».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 30 avril 2013.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2013058273/14.
(130070906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Sapient Operations Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 145.139.
<i>Extrait sincère et conforme des résolutions de l'associé unique de Sapient Operations Luxembourg S.à.r.l. (La société") adoptées lei>
<i>2 mai 2013i>
<i>Résolutioni>
L'associé unique DECIDE de nommer, à durée indéterminée:
Mie. Elizabeth CONDER, née le 27 Novembre 1976 à Welwyn Garden City, Royaume Uni et avec adresse à 16 Frognal
Gardens, Fiat 4, Londres NW3 6UX, Royaume Uni,
comme nouveau gérant au conseil de gérance de la Société, avec effet au 2 Mai 2013.
<i>Pour & au nom de SAPIENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.R.L.
Mandatairei>
Référence de publication: 2013058288/17.
(130071461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
LBB Re Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 138.710.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058864/9.
(130072484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.
72736
L
U X E M B O U R G
Lux Santé S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 112.632.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059690/10.
(130073323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Lukos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 49.279.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2013.
Référence de publication: 2013059689/10.
(130073215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Legacy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 140.859.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2013.
Chotin Barbara.
Référence de publication: 2013059674/10.
(130073673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Lux. Ouvrage d'Art S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 99.067.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059691/10.
(130073332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
M&T's, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 33, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 170.828.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 20 avril 2013 que:
- Monsieur Toni Fernandes, demeurant à L-5214 Sandweiler, 18, rue du Cimetière, a cédé 50 (cinquante) parts sociales
qu'il détient dans la société M&T's S.àr.l. ayant son siège social à L-1221 Luxembourg, 33, rue de Beggen à Monsieur
Madame Sandra Cristina Lopes Batista, demeurant à L-6165 Ernster, 8b, rue Principale, qui accepte.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2013.
<i>Pour M&T's S.àr.l.i>
Référence de publication: 2013059704/14.
(130073188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
72737
L
U X E M B O U R G
LREDS II (LBF) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 177.034.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fifth day of April.
Before Us Maitre Leonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
"Stichting LREDS II", a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, having its statutory office
in Spoorhaven 88, 2651 AV Berkel en Rodenrijs, The Netherlands, and registered with the Dutch Chamber of Commerce
(Handelsregister) under number 57585318.
here represented by Monique Drauth, employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg,
by virtue of a proxy given under private seal given on 24 April 2013,
which proxy, after been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following
articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which it declared to establish.
BY-LAWS:
Chapter I. - Name, Registered office, Object, Compartments, Duration
1. Form, Corporate Name.
1.1 There is hereby formed a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) (the "Company") go-
verned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the Luxembourg law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended (the "1915 Law") and by the present articles of incorporation (the "Articles"). The
Company shall be subject to the Luxembourg law dated 22 March 2004 on securitisation, as amended (the "Securitisation
Law").
1.2 The Company exists under the name of "LREDS II (LBF) S.A.".
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder" or the "Shareholder") or in case of plurality of shareholders
by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles.
2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") is authorised to change the address of the
Company inside the municipality of the Company's registered office.
2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely
to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.
3. Object.
3.1 The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the context of one or several
securitisation operations governed by and under the Securitisation Law.
3.2 The Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through
another entity or synthetically, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or
part of the activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be
financed by the issuance of securities by itself or by another securitisation entity the value or return of which depend on
the risks acquired or assumed by the Company. For the avoidance of doubt, the Company is not subject to any risk-
diversification requirements.
3.3 Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:
(a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense
of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies;
(b) subscribe or acquire any other participations in companies, partnerships or other undertakings, which do not qualify
as securities or financial instruments, provided that the Company will not actively intervene with the management of such
undertakings in which it holds a holding, directly or indirectly;
72738
L
U X E M B O U R G
(c) acquire loan receivables which may or may not be embedded in securities;
(d) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial ins-
truments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security
rights, by way of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;
(e) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options)
and any similar transactions;
(f) issue bonds, notes or any other form of debt securities (including by way of participation interest) and
(g) enter into loan agreements as borrower within the scope of the Securitisation Law, in particular in order to fund
the acquisition or assumption of risks (i.e. prior to the issuance of the securities or, more generally, where the Company
acts as acquisition entity), to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or any
agreement entered into within the context of its activities and insofar it seems to be useful and necessary within the
context of the transaction.
3.4 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are
directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or
development.
4. Compartments.
4.1 In accordance with the Securitisation Law, the Board of Directors is entitled to create one or more compartments
corresponding each to a separate part of the Company's estate.
4.2 Subject to article 4.4 below, all assets allocated to a compartment are exclusively available to investors thereunder
and the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment.
4.3 Notwithstanding the foregoing, if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company
attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other
creditors whose claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that
compartment, there remain assets under such compartment, the Board of Directors may allocate such assets to one or
several other compartments or to the general estate of the Company.
4.4 Claims which are not incurred in relation to the creation, operation or liquidation of a specific compartment may
be paid out of the general estate of the Company or may be apportioned by the Board of Directors between the Com-
pany's compartments on a pro rata basis of the assets of those compartments or on such other basis as it may deem
more appropriate.
4.5 The Board of Directors or their delegates, shall establish and maintain separate accounting records for each
compartment of the Company.
4.6 The liquidation of a compartment is decided by the Board of Directors.
5. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II - Capital
6. Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three hundred and
ten (310) registered shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.
7. Form of the shares. The shares are in registered form and subject to the relevant legal conditions.
The ownership of the shares is evidenced by the entry in the share register, held at the registered office of the Company.
8. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and
upon conditions, which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will
be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.
9. Modification of capital.
9.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the Sole Shareholder or by
resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.
9.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.
Chapter III - Bonds, Notes and Other debt instruments.
10. Registered form. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered form. Bonds,
notes, certificates or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer
form.
Chapter IV - Directors, Board of directors, Approved statutory Auditor(s)
11. Board of directors.
11.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least
three members (the "Directors" and each a "Director"), who need not be shareholders.
72739
L
U X E M B O U R G
11.2 In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders,
it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors
consisting of two Directors, until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more
than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of the Board of Directors. In such
case, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf
of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints its successor at
the same time.
11.3 The Directors are appointed by the general meeting of shareholders deciding on the remuneration and the term
of appointment for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution
of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case
a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date
of his election.
11.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement, resignation or
otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy
until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election. In case of resignation, the
resigning Director will remain in function until his/her successor has been appointed.
12. Meetings of the board of directors.
12.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman
may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced
by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.
12.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the
Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
12.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented
by proxies.
12.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his
proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later
stage.
12.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman
has a casting vote.
12.6 The use of video-conferencing equipment or the use of telecommunication means shall be allowed, provided that
each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology,
shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
12.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the
Directors in person (résolutions circulaires). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by
fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings,
duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.
12.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event
such vote is confirmed in writing.
12.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts
shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.
13. General powers of the board of directors.
13.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the Board of Directors.
13.2 The Board of Directors is authorised to sell, transfer, assign, charge or otherwise dispose of the assets of the
Company in such manner and for such compensation as the Board of Directors deems appropriate.
14. Delegation of powers.
14.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company
and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board
of Directors, Directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms
and with such powers as the Board of Directors shall determine.
14.2 The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be
Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
15. Representation of the company.
Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be bound by the joint signatures of any two Directors
or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors of the
Company, but only within the limits of such power.
72740
L
U X E M B O U R G
16. Approved statutory Auditor(s).
16.1 The accounts of the Company are audited by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises
agréé(s)) appointed by the Board of Directors.
16.2 The approved statutory auditor(s) is/are appointed for a determined period amongst the auditors registered with
the Commission de Surveillance du Secteur Financier.
16.3 The approved statutory auditor(s) is/are re-eligible.
Chapter V - General Meeting of shareholders
17. Powers of the sole shareholder / General Meeting of shareholders.
17.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be
held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the company.
17.2 If there is only one shareholder, that Sole Shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting
of shareholders and shall take the decision in writing.
17.3 In the event of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of
shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. Its resolutions are binding for all shareholders of the Company, irrespective of classes of shares they
hold.
17.4 Any general meeting shall be convened in accordance with the 1915 Law by means of convening notice sent to
each registered shareholder by registered letter at least fifteen days before the meeting. It must be convened following
the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. In the event that all
the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting,
they may waive all convening requirements and formalities of publication. Shareholders representing at least ten per cent
(10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general
meeting of shareholders. Such request must be addressed to the Company's registered office be registered mail at least
five (5) days before the date of the meeting.
17.5 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
17.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive
or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, only the forms received by the company three
(3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to, shall be taken into account.
17.7 The shareholders are entitled to participate in the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means of
communication must comply with technical features guaranteeing effective participation in the meeting whereof the de-
liberations and resolutions are transmitted on a continuous basis.
17.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
shareholders shall be taken by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.
17.9 When the Company has a Sole Shareholder, his decisions are written resolutions.
17.10 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles
or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by two-thirds of the votes cast of the shareholders present
or represented.
17.11 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be
increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal
requirement.
18. Place and Date of the annual General Meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is held
in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg, on the first Monday
of June of each year at 03.00 p.m., If such day is a public holiday, the annual general meeting of shareholders will be held
on the next following business day.
19. Other General Meetings. Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened
at the written request of the shareholders which together represent one tenth of the capital of the Company with an
indication of the agenda.
20. Votes.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of
shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.
72741
L
U X E M B O U R G
Chapter VI - Business year, Distribution of profits
21. Business year.
21.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of
each year.
21.2 The Board of Directors shall draw up the balance sheet and the profit and loss account. It shall submit these
documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general
meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.
22. Distribution of profits.
22.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This
allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the
Company.
22.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and
distribution of net profits.
22.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Chapter VII - Dissolution, Liquidation
23. Dissolution, Liquidation.
23.1 The Company may be dissolved by a decision of the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders
voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.
23.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders.
23.3 If no liquidators are appointed by the Sole Shareholder or general meeting of shareholders, the Directors shall
be deemed to be liquidator(s) vis-à-vis third parties.
Chapter VIII - Applicable law
24. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law
and the Securitisation Law.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends exceptionally on 31 December
2013.
The first annual general meeting shall be held on the first Monday of June 2014.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for three hundred and ten (310)
shares as follows:
"Stichting LREDS II", prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares
All these shares have been partly paid up, each as to twenty-five percent (25%), so that the sum of seven thousand
seven hundred fifty Euro (€ 7,750.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand one hundred and fifty Euro
(€ 1,150.-).
<i>First resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, Stichting LREDS II, considering itself as
duly convened, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting of
the shareholders passed the following resolutions:
1. The Company's address is fixed at 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors, each with a mandate expiring on occasion of the annual general
meeting of shareholders to be held in 2014:
72742
L
U X E M B O U R G
(a) Mr. Peter Dickinson, company director, born on 01 March 1966 in Nuneaton, United Kingdom, with professional
address at 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(b) Mr. Philip Godley, company director, born on 21 March 1974 in Sheffield,United Kingdom, with professional address
at 51, avenue John F. Kennedy, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
(c) Mrs. Genevieve Blauen-Arendt, company director, born on 28 September 1962 in Arlon, Belgium, with professional
address at 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the said person signed together with Us,
the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausenddreizehn, am fünfundzwanzigsten April.
Vor Uns Maitre Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
"Stichting LREDS II", eine Stiftung (Stichting) gegründet nach dem Recht der Niederlande mit Sitz in Spoorhaven 88,
2651 AV Berkel en Rodenrijs, die Niederlande, eingetragen bei der Handelskammer der Niederlande (Handelsregister)
unter der Nummer 57585318,
hier vertreten durch Monique Drauth, Angestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
aufgrund einer ihm, am 24. April 2013 erteilten privatschriftlichen Vollmacht, die, durch die Erschienene und den
unterzeichneten Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde beigefügt bleibt und zeitgleich mit dieser bei den
Registerstellen eingereicht wird.
Die Erschienene, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, hat den Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer
Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen, die sie nach eigener Aussage zu errichten wünscht.
SATZUNG:
Kapitel I. - Firma, Sitz, Gesellschaftszweck, Sondervermögen, Dauer des Bestehens
1. Rechtsform, Name der Gesellschaft.
1.1 Die Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) (die "Gesellschaft"), gegründet nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") und der vorliegenden Satzung. Die Gesellschaft unterliegt
dem Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung in seiner aktuellen Fassung (das "Verbriefungsgesetz").
1.2 Die Gesellschaft handelt unter dem Firmennamen "LREDS II (LBF) S.A.".
2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).
2.2 Der Sitz kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs der Gesellschaft (der "Alleinaktionär" oder der "Aktionär"),
beziehungsweise im Falle des Vorhandenseins mehrerer Aktionäre durch einen den Anforderungen an Satzungsänderun-
gen genügenden Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung in eine andere Gemeinde innerhalb des Groß-
herzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.3 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") ist ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb
der Gemeinde zu verlegen, in der sich der Sitz der Gesellschaft befindet.
2.4 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorste-
hen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem
Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände
vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt,
die ungeachtet der Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Sitzverlegung ins
Ausland trifft der Verwaltungsrat.
3. Gesellschaftszweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende
und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbergesellschaft und/oder Emittentin zu fungieren.
3.2 Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar oder über eine andere
Gesellschaft oder synthetisch Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder
Verbindlichkeiten Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der
Erwerb oder die Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst
72743
L
U X E M B O U R G
oder eine andere Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere ausgeben, deren Wert oder Rendite von den seitens der Gesell-
schaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft
keinen Risikodiversifizierungsanforderungen unterliegt.
3.3 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung darf die Gesellschaft insbesondere:
(a) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital- oder Personengesellschaften
begebene Wertpapiere und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwer-
ben;
(b) andere Unternehmensbeteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder anderen Unternehmen
erwerben, die nicht die Kriterien für Wertpapiere oder Finanzinstrumente erfüllen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft
nicht aktiv in das Management solcher Unternehmen eingreift, in welchen sie, direkt oder indirekt, Unternehmensbetei-
ligungen hält;
(c) Darlehensforderungen zu erwerben, die verbrieft oder unverbrieft sein können;
(d) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente
verwalten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Abs. 3 des Verbriefungsgesetzes an
den von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Pfand-
rechten, Grundpfandrechten, Gebühren oder jeder andere Form von Sicherheit bestellen;
(e) Derivatgeschäfte (einschließlich jedoch nicht beschränkt auf Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und
vergleichbare Transaktionen abschließen und durchführen;
(f) Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten) und
(g) als Kreditnehmer Darlehensvereinbarungen im Rahmen des Verbriefungsgesetzes eingehen, insbesondere zum
Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner,
sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungs-oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr auf-
grund der von ihr gehaltenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit ihren
Tätigkeiten abgeschlossen hat und insoweit diese im Rahmen der jeweiligen Transaktion als sinnvoll und erforderlich
erscheinen.
3.4 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen,
die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen
und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.
4. Sondervermögen.
4.1 Gemäß dem Verbriefungsgesetz ist der Verwaltungsrat berechtigt, ein oder mehrere Sondervermögen zu bilden,
die jeweils einem gesonderten Teil des Gesamtvermögens der Gesellschaft entsprechen.
4.2 Unter Vorbehalt des Artikels 4.4, stehen sämtliche Vermögenswerte, die einem Sondervermögen zugeordnet sind,
ausschließlich den diesbezüglichen Aktionären und denjenigen Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche im Zusam-
menhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung dieses Sondervermögens entstanden sind.
4.3 Unbeschadet dessen gilt, dass, falls nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Kreditverbindlichkeiten der
Gesellschaft, die einem Sondervermögen zuzuordnen sind und nach vollständiger Erfüllung und vollständigem Erlöschen
aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber sonstigen Gläubigern, deren Ansprüche in Zusammenhang mit solchen
Kreditverbindlichkeiten oder Gründung, Verwaltung oder Auflösung des betreffenden Sondervermögens entstanden sind,
noch Vermögenswerte des betreffenden Sondervermögens übrig bleiben, der Verwaltungsrat diese überschüssigen Ver-
mögenswerte auf ein beziehungsweise mehrere andere Sondervermögen oder die allgemeine Vermögensmasse der
Gesellschaft umverteilen darf.
4.4 Ansprüche die nicht im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung eines bestimmten
Sondervermögens entstanden sind, können aus der allgemeinen Vermögensmasse der Gesellschaft gezahlt werden oder
von dem Verwaltungsrat auf die Aktiva der einzelnen Sondervermögen auf pro rata Basis oder auf jede andere Weise
aufgeteilt werden, die als geeignet erscheint.
4.5 Der Verwaltungsrat beziehungsweise deren Bevollmächtigte sollen einzelne Kontenführungsberichte für jedes
Sondervermögen der Gesellschaft erstellen und führen.
4.6 Die Auflösung von Sondervermögen kann von dem Verwaltungsrat beschlossen werden.
5. Dauer des Bestehens. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Kapitel II. - Kapital
6. Kapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR), eingeteilt in drei-
hundertzehn (310) Anteile als Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100.- EUR).
7. Form der Anteile. Die Anteile lauten auf den Namen und unterliegen den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen.
Das Eigentum an den Anteilen wird durch die Eintragung in das Aktienregister nachgewiesen, das am Sitz der Gesell-
schaft geführt wird.
72744
L
U X E M B O U R G
8. Zahlungen auf Anteile. Zahlungen auf Anteile, die zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht voll eingezahlt waren,
können zu dem Zeitpunkt und zu den Bedingungen erfolgen, wie von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwal-
tungsrat jeweils festgelegt. Eingeforderte Einzahlungen auf Anteile werden von allen in Umlauf befindlichen und nicht voll
eingezahlten Anteilen zu gleichen Teilen eingefordert.
9. Kapitalerhöhungen oder - Herabsetzungen.
9.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Ak-
tionäre erhöht oder herabgesetzt werden, wobei dieser den rechtlichen Anforderungen an eine Satzungsänderung
entsprechen muss.
9.2 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen der rechtlich vorgesehenen Grenzen zurückkaufen.
Kapitel III - Anleihen, Schuldverschreibungen und Andere schuldtitel
10. Namens - Oder Inhaberpapiere. Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel
als Namenspapiere begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate oder andere Schuldtitel, die als Namenspapiere
begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht oder umgewandelt werden.
Kapitel IV. - Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat, Zugelassener Wirtschaftsprüfer
11. Verwaltungsrat oder Alleiniger Verwaltungsrat.
11.1 Im Falle des Vorhandenseins einer Mehrzahl von Aktionären, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen
Verwaltungsrat zu führen, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht (die "Verwaltungsratsmitglieder" und jeder ein
"Verwaltungsratsmitglied"), bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss.
11.2 Soweit die Gesellschaft durch einen Alleinaktionär gegründet wurde oder während einer Hauptversammlung der
Aktionäre festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur noch einen einzigen Aktionär hat; sind die Geschäfte der Gesellschaft
durch einen Verwaltungsrat zu führen, der aus zwei Mitgliedern besteht. Dies gilt solange, bis die nächste ordentliche
Hauptversammlung die Existenz von mehr als nur einem einzigen Aktionär feststellt. Eine juristische Person kann Mitglied
des Verwaltungsrats sein. In einem solchen Falle muss die juristische Person einen ständigen Vertreter benennen, der
diese Aufgabe namens und im Auftrag der juristischen Person erfüllt. Die jeweilige juristische Person kann ihren ständigen
Vertreter nur seines Amtes entheben, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt.
11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt. Diese legt sowohl
deren Vergütung als auch die jeweilige Amtszeit fest. Die Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, wobei eine
Wiederwahl der jeweiligen Mitglieder zulässig ist. Sie können jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung
ihres Amtes enthoben werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt worden sind. Wenn ein Verwal-
tungsratsmitglied ohne Angabe der Amtsdauer ernannt wird, gilt es als für einen Zeitraum von sechs Jahren ab Ernennung
ernannt.
11.4 Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes, Ausscheidens, Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds oder
aus anderen Gründen frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung abhalten und mit einer
Mehrheit der Stimmen ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz ausfüllt, bis die nächste Hauptversammlung
stattfindet, die zur Bestätigung dieser Wahl aufgefordert werden wird. Im Fall des Rücktritts eines Verwaltungsratsmitg-
lieds, bleibt das zurücktretende Verwaltungsratsmitglied solange im Amt, bis sein/ihr Nachfolger ernannt worden ist.
12. Sitzungen des Verwaltungsrats.
12.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der erste Vorsitzende kann
von der ersten Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann,
wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden
Verwaltungsratsmitglieder gewählt wird.
12.2 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglied
einberufen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Ein-
haltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten.
12.3 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner
Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte ordnungsgemäß vertreten ist.
12.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich ein anderes
Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes
Verwaltungsratsmitglied auch telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.
12.5 Sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei
Abstimmungen ist im Fall von Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
12.6 Die Teilnahme per Videokonferenz oder Benutzung von Telekommunikationsmedien ist erlaubt, vorausgesetzt,
dass jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen diese
Technologie verwendenden Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt
per Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.
12.7 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrates kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Un-
terschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen (résolutions circulaires). Die Zustimmung kann in
72745
L
U X E M B O U R G
einem oder mehreren gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Auf diesem
Wege gefasste Beschlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen des Verwal-
tungsrats gefasste Beschlüsse. Das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.
12.8 Stimmabgaben können weiterhin auf anderem Wege erfolgen, wie beispielsweise per Fax, E-Mail oder Telefon,
wobei im letzteren Falle die Stimmabgabe einer schriftlichen Bestätigung bedarf.
12.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrats wird von allen bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmit-
gliedern unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebigen Verwaltungsrats-
mitgliedern beglaubigt.
13. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats.
13.1 Dem Verwaltungsrat stehen die weitestgehenden Befugnisse zur Vornahme von Verwaltungs- und Verfügungs-
maßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von Rechts wegen oder durch diese Satzung
ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.
13.2 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Vermögenswerte der Gesellschaft in einer Weise und für eine solche Aus-
gleichszahlung zu verkaufen, übertragen, abzutreten, belasten oder anderweitig darüber zu verfügen, wie sie der
Verwaltungsrat für angemessen erachtet.
14. Übertragung von Befugnissen.
14.1 Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und zur Vertretung
der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder andere Hand-
lungsbevollmächtigte übertragen, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft handeln muss; die näheren
Bedingungen und die übertragenen Befugnisse legt der Verwaltungsrat fest.
14.2 Der Verwaltungsrat kann sämtliche Befugnisse oder speziellen Aufgaben auch an Personen übertragen, die keine
Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sein müssen, Handlungsbevollmächtigte und Angestellte anstellen und entlas-
sen und deren Bezüge festlegen.
15. Vertretung der Gesellschaft. Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt durch die gemeinsame
Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift der Person, die eine solche Unter-
schriftsbefugnis von zwei Verwaltungsratsmitgliedern übertragen wurde, jedoch nur, soweit diese Befugnis reicht.
16. Zugelassener Wirtschaftsprüfer.
16.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren zugelassenen Wirtschaftsprüfern (ré-
viseur(s) d'entreprises agréé(s)) geprüft, welche(r) vom Verwaltungsrat gewählt wird.
16.2 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer werden/wird aus dem Kreis der bei der Commission de Surveil-
lance du Secteur Financier registrierten Wirtschaftsprüfer gewählt und für eine bestimmte Zeit bestellt.
16.3 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer kann/können wiedergewählt werden.
Kapitel V. - Hauptversammlung
17. Befugnisse des Alleinaktionärs / der Hauptversammlung.
17.1 Die Gesellschaft kann bei ihrer Gründung mit einem Alleinaktionär errichtet werden oder entstehen, wenn alle
Anteile von einer einzigen Person gehalten werden. Tod oder Auflösung des Alleinaktionärs führt nicht zur Auflösung
der Gesellschaft.
17.2 Hat die Gesellschaft einen Alleinaktionär, soll dieser sämtliche Befugnisse erhalten, die der Hauptversammlung
zustehen; Beschlussfassungen sollen schriftlich durch den Alleinaktionär erfolgen.
17.3 Soweit die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Hauptversammlung die Gesamtheit der Aktionäre
der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von
Angelegenheiten der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft, ohne Rücksicht darauf, welche
Klassen von Anteilen sie halten.
17.4 Die Einberufung der Hauptversammlung soll mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung durch den Verwal-
tungsrat und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 an jeden Inhaber von Namensaktien durch schriftliche Einberufungs-
mitteilung per Einschreiben erfolgen. Eine Hauptverhandlung muss einberufen werden, wenn dies ein oder mehrere
Aktionäre, die zusammen mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals halten, verlangen Sofern sämtliche
Aktionäre während der Hauptversammlung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und sie alle erklären, dass sie
von der Tagesordnung ordnungsgemäß unterrichtet wurden, können diese auf die Einhaltung sämtlicher Anforderungen
bezüglich Einberufung der Versammlung und Veröffentlichung der Tagesordnung verzichten. Ein oder mehrere Aktionäre,
die zusammen mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals halten, können verlangen dass ein oder mehrere
zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung für eine Hauptversammlung gesetzt werden. Ein solcher Antrag ist mindestens
fünf (5) Tage vor der Versammlung per Einschreiben an den Sitz der Gesellschaft zu schicken.
17.5 Ein Aktionär kann sich bei einer Aktionärsversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder
durch andere entsprechende elektronische Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss,
72746
L
U X E M B O U R G
und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten zu
lassen.
17.6 Die Aktionäre sind berechtigt, mittels eines Abstimmungsformulars, das eine Zustimmung, Ablehnung oder
Stimmenthaltung vorsieht, im Umlaufverfahren abzustimmen. Nur die Formulare, die spätestens drei (3) Tage vor der
Hauptversammlung bei dem Sitz der Gesellschaft oder der Adresse, auf die in dem Einberufungsschreiben verwiesen wird,
eingegangen sind, werden bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschaft berücksichtigt.
17.7 Die Aktionäre sind berechtigt, per Videokonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie
identifizieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit
und Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht
geeignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen
ständig zu übertragen sind.
17.8 Soweit nicht durch Gesetz oder durch die Satzung abweichend geregelt, werden Beschlüsse in den ordnungsgemäß
einberufenen jährlichen oder ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, ungeachtet des durch diese Stimmen jeweils vertretenen Kapitals.
17.9 Sofern die Gesellschaft einen Alleinaktionär hat, ergehen dessen Beschlüsse schriftlich.
17.10 Eine zur Änderung der Satzungsbestimmungen einberufene außerordentliche Hauptversammlung kann nur wirk-
sam beraten, wenn mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten ist und die geplante Satzungsänderung sich der
Tagesordnung entnehmen lässt. Wenn die erste der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Ver-
sammlung in der gemäß der Satzung oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgeschriebenen Weise einberufen
werden. In der Einberufungsmitteilung ist die Tagesordnung erneut mitzuteilen und das Datum und die Ergebnisse der
vorangegangenen Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung kann ungeachtet des Anteils des bei der Versamm-
lung vertretenen Kapitals wirksam beraten. Bei beiden Hauptversammlungen bedarf eine gültige Beschlussfassung einer
Zweidrittelmehrheit aller abgegebenen Stimmen.
17.11 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung oder Verringerung der Verbindlichkeiten
der Aktionäre kann dagegen nur einvernehmlich durch alle Aktionäre, unter Einhaltung aller weiteren rechtlichen Erfor-
dernisse beschlossen werden.
18. Zeit und Ort der Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung wird jeweils am ersten Montag im Juni
um 15.00 Uhr, an einem Ort in der Stadt Luxemburg abgehalten, der in der Einberufungsmitteilung näher angegeben wird.
Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, so wird die Jahreshauptversammlung an dem nächstfolgenden Geschäftstag
abgehalten.
19. Weitere Hauptversammlungen. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Eine
Hauptversammlung ist auf schriftliches Verlangen von Aktionären einzuberufen, die gemeinsam ein Zehntel des Kapitals
der Gesellschaft vertreten unter Angabe der Tagesordnung.
20. Stimmen. Jeder Anteil gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung, selbst bei der Jah-
reshauptversammlung, handeln, indem er schriftlich eine andere Person bevollmächtigt.
Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
21. Geschäftsjahr.
21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats
Dezember des jeweiligen Jahres.
21.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat soll die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung er-
stellen. Er soll diese Unterlagen zusammen mit einem Geschäftsbericht der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der
Jahreshauptversammlung den externen Wirtschaftsprüfern vorlegen, die einen Bericht mit einer Bewertung der vorge-
legten Unterlagen erstellen.
22. Gewinnausschüttung.
22.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent (5%) des Nettogewinns den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisen. Eine
solche Zuweisung zu den Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindestens
ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.
22.2 Nachdem die Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen erfolgt ist, entscheidet die Hauptversammlung über Ver-
wendung und Ausschüttung der Nettogewinne.
22.3 Der Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den rechtlich vorgeschriebenen Bedingungen Interimsdividenden
auszuschütten.
Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation
23. Auflösung, Liquidation.
23.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst
werden, wobei dieselben Anforderungen an Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gelten wie für die Änderung
der Satzung.
72747
L
U X E M B O U R G
23.2 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere vom Alleinaktionär
beziehungsweise von der Hauptversammlung bestellte Liquidatoren.
23.3 Wenn keine Liquidatoren von dem Alleinaktionär oder der Hauptversammlung bestellt werden, gelten die Ver-
waltungsratsmitglieder gegenüber Dritten als Liquidator(en).
Kapitel VIII. - Geltendes Recht
24. Geltendes Recht. Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des
Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet ausnahmsweise am 31. Dezember 2013.
Die erste Generalversammlung findet am ersten Montag im Monat Juni 2014 statt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei 310 (dreihundertzehn) Anteile wie nachstehend
angegeben gezeichnet:
"Stichting LREDS II", vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Anteile
TOTAL: dreihundertzehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Anteile
Diese Anteile sind teilweise eingezahlt, jeder zu fünfundzwanzig Prozent (25%), so dass der Betrag von siebentausend-
siebenhundertundfünfzig Euro (7.750,-EUR) der Gesellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar
nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von
1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer
Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf eintausendeinhundertfünfzig Euro
(€ 1.150,-) geschätzt.
<i>Erste Beschlüsse des alleinaktionärsi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei, "Stichting LREDS II", die die Ver-
sammlung als ordnungsgemäß einberufen erachtet, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals und in Ausübung
der Befugnisse der Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Als Anschrift der Gesellschaft wird L-1855 Luxemburg, 51, avenue John F. Kennedy, Großherzogtum Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg vorgesehen.
2. Die folgenden Personen wurden als Verwaltungsratsmitglieder gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre
2014 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:
(a) Herr Peter Dickinson, Geschäftsführer, geboren am 1. März 1966, in Nuneaton, Großbritannien, geschäftsansässig
in 51, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
(b) Herr Philip Godley, Geschäftsführer, geboren am 21. März 1974, in Sheffield, Großbritannien, geschäftsansässig in
51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und
(c) Frau Genevieve Blauen-Arendt, Geschäftsführerm, geboren am 28. September 1962, in Arlon, Belgien, geschäfts-
ansässig in 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache mächtig, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten
erschienenen Person, die vorliegende Ausfertigung in Englisch verfasst ist, welcher eine deutsche Übersetzung beiliegt.
Auf Anfrage derselben erschienenen Person und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen
Text, wird der englische Text maßgebend sein.
Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn genannten Tage in Luxemburg
errichtet.
Nachdem die Urkunde dem Vollmachtnehmer der erschienenen Person vorgelesen wurde, unterzeichnete der Voll-
machtnehmer gemeinsam mit dem amtierenden Notar diese Originalurkunde.
Gezeichnet: Drauth,GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 avril 2013. Relation: LAC/2013/19443. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
72748
L
U X E M B O U R G
Luxemburg, den 6. Mai 2013.
Référence de publication: 2013059685/604.
(130073612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Washington Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 79.652.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013059166/9.
(130072298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.
Leopard Germany Holding Hotels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 155.841.
<i>Rectificatif au L130068447i>
In the year two thousand and thirteen, on the twenty sixth day of March,
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Leopard Guernsey Leonardo Hotels Limited, a limited company organized under the laws of Guernsey, with registered
office at St Peter Port, 1, Le Truchot, Guernsey GY1 1WD, registered with the Guernsey Company Registry under
number 55772 (the Sole Partner),
here represented by Géraldine Nucera, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 22 March 2013.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Sole Partner and the undersigned notary,
shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as aforesaid, is the sole partner of Leopard Germany Holding Hotels S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsibilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
with registered office at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under number B 155.841 and having a
share capital of one million Euro (EUR 1,000,000.-) (the Company).
The Company was incorporated on September 9, 2010 pursuant to a deed of Maître Joëlle Baden, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2441, on November 12, 2010. The articles of association of the Company (the "Articles") were last amended on March
20, 2013 pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
pending publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The proxyholder of the Sole Partner has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Shortening of the first accounting year to March 28, 2013 and subsequent amendment to article 16 of the Articles
to align accordingly the subsequent accounting year of the Company;
2. Amendment to article 13 of the Articles to read as follows;
" Art. 13. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers ("conseil de gérance"). The manager(s) need not to be partners. The manager(s) are
appointed, revoked - at any time, with or without cause - and replaced by the general meeting of partners, by a decision
adopted by partners owning more than half of the share capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 13 shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
individual signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.
The general meeting of partners or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
72749
L
U X E M B O U R G
The general meeting of partners or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any
manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Notwithstanding anything else in these Articles, the managers shall refer any of the following matters to be determined
by the partner(s):
1 The sale by the Company, or any of its subsidiaries (including, for the avoidance of doubt, LF Hotels Acquico I (GP)
S.d r.l., the JV Company and any subsidiary thereto), during the Lock-in Period, of any interests in:
(a) The JV Company;
(b) QMH;
(c) the Property Companies; or
(d) any asset of the JV Company, QMH, or any of the Property Companies.
2 The sale by the Company, or any of its subsidiaries, i(ncluding, for the avoidance of doubt, LF Hotels Acquico I (GP)
S.d r.l., the JV Company and any subsidiary thereto),following the Lock-in Period of part-only (i.e. not the whole) of:
(a) any Subsidiary (as defined in the Joint Venture Agreement of the JV Company); or
(b) the Property Companies or the Hotels.
3 The acquisition by the JV Company or its general partner of any assets or property at a total cost (per transaction)
of more than €250,000 (exclusive of value added tax), specifically excluding any capex or fixtures, furniture and fittings
investments in accordance with the Leases.
4 The making by the JV Company or its general partner of any loan or payment (other than payments originating from
Emergency Funding (as defined in the Joint Venture Agreement) and for the purpose thereof) in an amount greater than
€250,000 or the entry into any contract or commitment under which the JV Company or its general partner may incur
costs greater than €250,000 per contract (exclusive of value added tax).
5 Any amendment to articles 11 or 13.
Any decisions above, if resolved by the managers shall be null and void. All powers not expressly reserved by these
Articles or by the law of 10
th
August 1915, as amended, to the general meeting of partner(s) or to the auditor(s) shall
be within the competence of the managers."
3. Miscellaneous
II. That the Sole Partner has taken the following resolutions:
<i>First Resolution:i>
The Meeting resolves to shorten the current accounting year to March 28, 2013 and to subsequently amend article
16 of the Articles to align accordingly the subsequent accounting years of the Company which shall read as follows:
" Art. 16. The accounting year of the Company shall begin on March twenty-ninth (29
th
) of each year and ends on
March twenty-eight (28
th
) of the following year."
<i>Second Resolution:i>
The Meeting resolves to amend 13 of the Articles to read as follows:
" Art. 13. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers ("conseil de gérance"). The manager(s) need not to be partners. The manager(s) are
appointed, revoked - at any time, with or without cause - and replaced by the general meeting of partners, by a decision
adopted by partners owning more than half of the share capital.
72750
L
U X E M B O U R G
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 13 shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
individual signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.
The general meeting of partners or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general meeting of partners or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any
manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Notwithstanding anything else in these Articles, the managers shall refer any of the following matters to be determined
by the partner(s):
1 The sale by the Company, or any of its subsidiaries (including, for the avoidance of doubt, LF Hotels Acquico I (GP)
S.à r.l., the JV Company and any subsidiary thereto), during the Lock-in Period, of any interests in:
(a) The JV Company;
(b) QM H;
(c) the Property Companies; or
(d) any asset of the JV Company, QMH, or any of the Property Companies.
2 The sale by the Company, or any of its subsidiaries, including, for the avoidance of doubt, LF Hotels Acquico I (GP)
S.d r.l., the JV Company and any subsidiary thereto), following the Lock-in Period of part-only (i.e. not the whole) of:
(a) any Subsidiary (as defined in the Joint Venture Agreement of the JV Company); or
(b) the Property Companies or the Hotels.
3 The acquisition by the JV Company or its general partner of any assets or property at a total cost (per transaction)
of more than €250,000 (exclusive of value added tax), specifically excluding any capex or fixtures, furniture and fittings
investments in accordance with the Leases.
4 The making by the JV Company or its general partner of any loan or payment (other than payments originating from
Emergency Funding (as defined in the Joint Venture Agreement) and for the purpose thereof) in an amount greater than
€250,000 or the entry into any contract or commitment under which the JV Company or its general partner may incur
costs greater than €250,000 per contract (exclusive of value added tax).
5 Any amendment to articles 11 or 13.
Any decisions above, if resolved by the managers shall be null and void. All powers not expressly reserved by these
Articles or by the law of 10
th
August 1915, as amended, to the general meeting of partner(s) or to the auditor(s) shall
be within the competence of the managers."
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately nine hundred and six euros (EUR 906.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.
72751
L
U X E M B O U R G
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the proxyholder of the Sole Partner, who is known to the undersigned notary by
his surname, name, civil status and residence, the said proxyholder signed the present deed together with the undersigned
notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mil treize, le vingt-sixième jour du mois de mars,
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Leopard Guernsey Leonardo Hotels Limited, une limited company organisée selon les lois de Guernesey, ayant son
siège social à St Peter Port, 1, Le Truchot, Guernesey GY1 1WD, immatriculée auprès du Guernsey Company Registry
sous le numéro 55772 (l'Associé Unique),
ici représentée par Géraldine Nucera, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 22 mars 2013.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique ainsi que par le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est l'associée unique de Leopard Germany Holding Hotels S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 155.841 et ayant un capital social de vingt mille Euros (EUR 20.000,-)
(la Société). La Société a été constituée le 9 septembre 2012 suivant un acte de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2441,
page 117154, le 12 novembre 2010. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le 20
mars 2013 suivant un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le mandataire de l'Associé Unique a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Raccourcissement de l'exercice social en cours au 28 mars 2013 et modification de l'article 16 des Statuts pour
aligner en conformité les exercices sociaux subséquents de la Société.
2. Modification de l'article 13 des Statuts.
3. Divers.
II. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolution:i>
L'Associé Unique décide d'écourter l'exercice social en cours au 28 mars 2013 et de modifier l'article 16 des Statuts
pour aligner en conformité les exercices sociaux subséquents de la Société, qui aura désormais le teneur suivante:
« Art. 16. L'exercice social de la Société commence le 29 mars de chaque année et se termine le 28 mars de l'année
suivante.»
<i>Deuxième Résolution:i>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 13 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 13. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un
Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués - à
tout moment, avec ou sans justification - et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 13.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature individuelle de l'un quelconque des membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi
ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
72752
L
U X E M B O U R G
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu
parmi les membres présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par
écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil
de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date
de la dernière signature.
Nonobstant toute autre stipulation des Statuts, les gérants devront référés n'importe laquelle des matières suivantes
aux associé(s):
1 La vente par la Société, ou l'une de ses Filiales (y compris, pour lever toute ambiguité, LF Hotels Acquico I (GP) S.à
r.l., la Société JV n'importe quelle autre Fililale), pendant la durée de la Période de Blocage de n'importe quel intérêt dans:
(a) La Société JV;
(b) QM H;
(c) les Sociétés Immobilières; ou
(d) tout actif de la Société JV, QM H, ou de toute Société Immobilière.
2 La vente par la Société, ou l'un de ses Affiliés, (y compris pour lever tout doute, LF Hotels Acquico I (GP) S.à r.l., la
Société JV et n'importe qu'elle autre filiale) à la suite de la Période de Blocage d'une partie seulement (et non de la totalité)
de:
(a) toute Filiale (comme définit dans le contrat JV des Sociétés JV); ou
(b) les Sociétés Immobilières ou les Hôtels.
3 L'acquisition par la Société JV ou son associé commandité de tous actifs ou bien pour un coût total (eut égard à ladite
opération) de plus de €250,000 (exclusion faite de la taxe sur la valeur ajoutée), à l'exclusion en particulier de toutes
dépenses d'ameublement, de maintenance, de travaux et d'aménagements conformément aux Baux.
4 Le consentement par la Société JV ou son associé commandité de tout prêt ou paiement (autre que ceux provenant
des Financement d'Urgence comme définit dans le JV Agreement et à cet effet uniquement) d'un montant supérieur à
€250,000 ou la conclusion de tout contrat ou engagement selon lequel la Société JV ou son associé commandité devrait
supporter des coûts supérieurs à €250,000 par contrat (exclusion faite de la taxe sur la valeur ajoutée).
5 Toute modification des articles 11 ou 13.
Toutes les décisions ci-dessus seront nulles et non avenues si elles sont prises par les gérants. Tous pouvoirs non
expressément réservés par ces Statuts ou par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, à l'assemblée générale de l'associé
unique/des associés ou au(x) commissaire(s) aux comptes sera de la compétence des gérants.»
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison
du présent acte sont estimés à approximativement neuf cent six Euros (EUR 906,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction en français. A la demande de la même partie comparante, et
en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, connu du notaire soussigné par son nom, prénom, état civil
et demeure, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: G. NUCERA, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mars 2013. Relation: LAC/2013/14168. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.
72753
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 08 mai 2013.
Référence de publication: 2013059659/268.
(130073277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Sapient Holdings Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 77.640.622,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 145.246.
<i>Extrait sincère et conforme des résolutions de l'associé unique de Sapient Holdings Luxembourg S.à.r.l. (La société") adoptées lei>
<i>30 avril 2013i>
<i>Résolutioni>
L'associé unique DECIDE de nommer, à durée indéterminée:
Mie. Elizabeth CONDER, née le 27 Novembre 1976 à Welwyn Garden City, Royaume Uni et avec adresse à 16 Frognal
Gardens, Fiat 4, LONDRES NW3 6UX, Royaume Uni,
comme nouveau gérant au conseil de gérance de la Société, avec effet au 2 Mai 2013.
<i>Pour & au nom de SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG S.A.R.L.
Mandatairei>
Référence de publication: 2013058287/17.
(130071462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
KRW Schindler Investment Management, Société Coopérative.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 177.022.
In the year two thousand and thirteen, on the twelfth day of April,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1) KRW Capital AG, a public limited liability company (Aktiengesellschaft) incorporated and organised under the laws
of Switzerland, with registered office at Poststrasse 3, 8001 Zurich, Switzerland, registered with the commercial register
of the local court of Zurich under number CH-020.3.037.069-3; and
2) Schindler & Schindler GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorpo-
rated and organised under the laws of Germany, with registered office at Im Dol 67, D-14195 Berlin, Germany, registered
with the commercial register of the local court of Charlottenburg under number HRB 146530 B,
hereby both represented by Ms. Claire Guilbert, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of proxies given. The said proxies, initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed.
The appearing parties, represented as above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles
of association of a cooperative company organized as a public limited liability company (société coopérative organisée
comme une société anonyme), which is hereby incorporated:
ARTICLES OF ASSOCIATION
A. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name.
1.1 There is hereby established a coopérative company organized as a public limited liability company (société coo-
pérative organisée comme une société anonyme) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
in particular by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "Law")
and by the present articles of association (the "Articles").
1.2 The company exists under the name of "KRW Schindler Investment Management" (the "Company").
Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven (Grand Duchy of Luxem-
bourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of these
72754
L
U X E M B O U R G
Articles. However, the board of directors (the "Board of Directors") of the Company is authorized to transfer the
registered office of the Company within the municipality of its registered office.
Art. 3. Object.
3.1 The purpose of the Company shall be the creation, holding, development and realization of a portfolio, consisting
of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg
and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by
purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as equity instruments, debt instruments,
patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
3.2 The Company may further:
(a) grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds
a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
(b) lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in
which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,
the Company may in particular:
(a) raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including
bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;
(b) participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; or
(c) act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
4.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company
( the "General Meeting") adopted in the manner required for amendments of these Articles.
B. Classes of shares - Share capital - Shares - Admission, Issuance of shares and Voting rights - Resignation,
Exclusion, Death and Redemption of shares - Liability of the shareholders
Art. 5. Classes of Shares.
5.1 The Company will issue two (2) classes of shares, namely the class A shares (the "Class A Shares") and the class
B shares (the "Class B Shares" and together with Class A Shares, the "Shares").
5.2 The Shares will be issued at any time.
5.3 Each Share entitles its holder to one (1 ) vote during the General Meeting.
Art. 6. Share Capital.
6.1 The share capital is set at a minimum of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) (the "Minimum Share Capital")
divided into thirty-one thousand (31,000) Class A Shares, with a par value of one euro (EUR 1.-) each. Each Share must
be entirely subscribed and fully paid-up at the time of its subscription.
6.2 The Minimum Share Capital may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting adopted in the
manner required for amendments of these Articles.
6.3 Upon incorporation, the Class A Shares have been subscribed as follows:
(a) KRW Capital AG has subscribed for fifteen thousand five hundred (15,500) Class A Shares; and
(b) Schindler & Schindler GmbH has subscribed for fifteen thousand five hundred (15,500) Class A Shares.
6.4 Together with the Minimum Share Capital, the share capital of the Company as increased or reduced from time
to time, constitute the share capital of the Company (the "Share Capital") being provided that the Share Capital shall in
no circumstances fall below the Minimum Share Capital,
6.5 Class B Shares will be issued, cancelled or redeemed, as the case may be, by the Board of Directors pursuant to
Articles VIII and IX below, provided that the Share Capital does not fall below the Minimum Share Capital.
Art. 7. Shares.
7.1 All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the register of Shares in
accordance with the applicable law.
7.2 A register of Shares will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection
by any shareholder. Ownership of Shares will be established by inscription in such register.
72755
L
U X E M B O U R G
7.3 The Company recognizes only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the title
of ownership to such Share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such Share(s) has/have to
appoint one single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies
a suspension of all rights attached to such Share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct
holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
7.4 Shares may neither be transferred nor pledged or assigned. They may however be redeemed by the Company in
accordance with Article X below. Moreover, the redemption proceeds thereof may be pledged.
Art. 8. Admission, Issuance of shares and Voting rights.
8.1 Subject to Articles V and VI above, the Board of Directors is authorized without limitation to issue an unlimited
number of fully paid up Class B Shares at any time.
8.2 Subscription requests for Class B Shares shall be addressed to the Board of Directors which may accept or reject
them in its absolute discretion.
8.3 The numbers of Class B Shares to issue in the event of a subscription will be determined by the Board of Directors
considering the value of the Class B Shares to be issued.
8.4 Each new Class B Share subscribed may be subject to an issuance fee or a premium, determined at the sole discretion
of the Board of Directors.
8.5 Class B Shares have one (1) vote each.
Art. 9. Resignation, Exclusion, Death and Redemption of shares.
9.1 Shareholders cease to be part of the Company through resignation, exclusion or death. In all cases, the Company
will redeem their Shares. Redeemed Shares will be automatically cancelled and the Share Capital will be reduced accor-
dingly within the limit of the Minimum Share Capital.
9.2 A shareholder may resign from the Company only in the cases and under the conditions set forth by the Board of
Directors. The resignation shall be communicated in writing.
9.3 Moreover, any shareholder may be excluded for any misconduct to be assessed by the Board of Directors. The
exclusion is decided by the Board of Directors and shall be communicated in writing.
9.4 The redemption price per Share shall be equal to its value resulting from the balance sheet of the financial year
during which the end of the shareholdership occurred and shall be paid within a period determined by the Board of
Directors, which shall not exceed ten (10) business days after funds are available since the determination of the redemption
price.
Art. 10. Liability of the shareholders. The shareholders shall only be liable for payment to the Company of the value
and, as the case be, of the issuance premium of each subscribed Share. In particular, shareholders shall not be liable for
the debts, liabilities and/or obligations of the Company or of any other shareholder.
C. Meetings of the shareholders of the company
Art. 11. Convening of general meeting of shareholders.
11.1 The General Meeting may at any time be convened by the Board of Directors or, as the case may be, by the
statutory auditor(s).
11.2 It must be convened by the Board of Directors or the statutory auditor(s) upon written request of shareholders
representing at least ten percent (10%) of the Company's Share Capital. In such case, the General Meeting shall be held
within a period of one (1) month from receipt of such request.
11.3 The convening notices for every General Meeting shall contain the date, time, place and agenda of the meeting
and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and eight (8) days
before the meeting, in the Mémorial and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight (8) days before
the meeting to the registered shareholders, but no proof needs to be given that this formality has been complied with.
11.4 Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only and
shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date scheduled for the meeting.
11.5 If all of the shareholders are present or represented at a General Meeting, and have waived any convening
requirement the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 12. Conduct of general meetings of shareholders.
12.1 The annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such
other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on the third Friday in June of each
year at 10 a.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting.
12.2 A board of the meeting shall be formed at any General Meeting, composed of a chairman, a secretary and a
scrutineer, each of whom shall be appointed by the General Meeting and who need neither be shareholders, nor members
of the Board of Directors.
72756
L
U X E M B O U R G
12.3 If all the shareholders present at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the
shareholders may unanimously decide to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume
the role of the board and in such case there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the "board
of the meeting" shall be construed as a reference to the "chairman and secretary" or, as the case may be to the "single
person who assumes the role of the board", depending on the context and as applicable.
12.4 The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and,
in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation
of shareholders.
12.5 An attendance list must be kept at any General Meeting.
12.6 A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile,
electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even all shareholders.
The Board of Directors may determine other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in
any General Meeting.
12.7 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video¬conference or by any other means of
communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on
a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present
for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place
of the meeting.
12.8 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile
or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening
notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and
time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each
proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed
resolution by ticking the appropriate box.
12.9 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the
proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into
account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.
Art. 13. Quorum and Vote.
13.1 Each Share is entitled to one (1) vote except as otherwise provided herein.
13.2 Except as otherwise required by the Law or these Articles, resolutions at a General Meeting duly convened shall
not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the
portion of the Share Capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
Art. 14. Amendments of the Articles. Except as otherwise provided herein, these Articles may be amended by a
majority of at least two-thirds of the votes validly cast at a general meeting at which more than half of the Company's
Share Capital is present or represented. In case the second condition is not satisfied, a second meeting may be convened
in accordance with the Law and these Articles which may deliberate regardless of the proportion of the Share Capital
represented and at which resolutions are taken at a majority of at least two-thirds of the votes validly cast. Abstentions
and nil votes shall not be taken into account.
Art. 15. Change of nationality. The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by
unanimous consent of all shareholders.
Art. 16. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the Board of Directors
may adjourn any General Meeting for four (4) weeks. The Board of Directors shall do so at the request of shareholders
representing at least twenty percent (20%) of the Share Capital of the Company. By such an adjournment of a General
Meeting, any resolution already adopted shall be cancelled.
Art. 17. Minutes of general meetings of shareholders.
17.1 The board of any General Meeting shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by the members
of the board of the meeting as well as by any shareholder upon request.
17.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the Board of Directors or by any
two of its members.
D. Management
Art. 18. Composition and Powers of the Board of Directors.
18.1 The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) members. However,
where the Company has been formed by a single shareholder or where it appears at a shareholders' meeting that all the
Shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the
72757
L
U X E M B O U R G
next General Meeting following the increase of the number of shareholders. In such case and to the extent applicable and
where the term "sole director" is not expressly mentioned in these Articles, a reference to the "Board of Directors" used
in these Articles is to be construed as a reference to the "sole director".
18.2 The Board of Directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by
the Law or by these Articles to the General Meeting.
Art. 19. Daily management.
19.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily
management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other
agents, shareholder or not, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by
a resolution of the Board of Directors.
19.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 20. Election, Removal and Term of office of directors.
20.1 The directors shall be elected by the General Meeting which shall determine their remuneration and term of
office.
20.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor
is elected. Directors may be re-elected for successive terms.
20.3 The directors are elected by a simple majority vote of the Shares present or represented in a general meeting.
20.4 Any director may be removed at any moment with or without cause by the General Meeting at a simple majority
vote of the Shares present or represented.
20.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as
permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal
entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only
be a permanent representative of one (1) director and may not be a director at the same time.
Art. 21. Vacancy in the office of a director.
21.1 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the per-
manent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
21.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue
delay by the General Meeting.
Art. 22. Convening meetings of the Board of Directors.
22.1 The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or by any director, at the place indicated in the
notice of meeting. The meetings of the Board of Directors shall be held at the registered office of the Company unless
otherwise indicated in the notice of meeting.
22.2 Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to directors twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the Board of Directors.
22.3 No prior notice shall be required in case all the members of the Board of Directors are present or represented
at such meeting and have waived any convening requirement, or in the case of resolutions in writing approved and signed
by all members of the Board of Directors.
Art. 23. Conduct of meetings of the Board of Directors.
23.1 The Board of Directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.
23.2 The chairman shall chair all meetings of shareholders and of the Board of Directors, but in his absence, the Board
of Directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
23.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another director as his proxy in
writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A director may represent one or more, but not all of his colleagues.
23.4 Meetings of the Board of Directors may also be held by conference-call or video conference or by any other
telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
72758
L
U X E M B O U R G
23.5 The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or
represented at a meeting of the Board of Directors.
23.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. The chairman
shall not have a casting vote.
23.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction
submitted to the approval of the Board of Directors which conflicts with the Company's interest, must inform the Board
of Directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The
relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict
of interest must be reported to the next General Meeting prior to taking any resolution on any other item.
23.8 The Board of Directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. The directors may express their
consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions
shall be the date of the last signature.
Art. 24. Minutes of the meeting of the Board of Directors - Minutes of the decisions of the sole director.
24.1 The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore, or by any two (2) directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in
judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or by any two (2) directors.
24.2 The decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies
or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole
director.
Art. 25. Dealing with third parties.
25.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any two (2)
directors or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have
been delegated by the Board of Directors.
25.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of
any person(s) to whom such power may have been delegated acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.
E. Supervision of the company
Art. 26. Auditor(s).
26.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s) aux
comptes). The General Meeting shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office, which may
not exceed six (6) years.
26.2 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the General
Meeting.
26.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor'(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed with cause or with his approval by the General Meeting.
F. Financial year - Allocation of profits
Art. 27. Financial year. The financial year of the Company shall begin on first January of each year and shall end on
thirty-first December of the same year.
Art. 28. Annual accounts - Allocation of profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board of Directors draws up an inventory of
assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account in accordance with the law.
28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the Share Capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a Share Capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the Share Capital.
28.5 Upon recommendation of the Board of Directors, the General Meeting shall determine how the remainder of
the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these Articles.
72759
L
U X E M B O U R G
28.6 Unless otherwise provided in these Articles, each Share is entitled to the same fraction of such balance.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation.
29.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who
are appointed by the General Meeting, deciding such dissolution and which shall determine their powers and their com-
pensation. Unless otherwise provided, the liquidator(s) shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
29.1 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed to
the holders of shares of a Class of Shares in accordance with the principles laid out in Article 28 above.
H. Final clause - Governing law
Art. 30. Governing law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The Share Capital has been subscribed as follows:
Name of Subscriber
Number of
subscribed
shares
Value
1.- KRW Capital AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500 Shares EUR 15,500
2.- Schindler & Schindler GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500 Shares EUR 15,500
The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of thirty-one thousand
euro (EUR 31,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
1. The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
December 2013.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or
which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>General Meeting of shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire Share Capital of the Company and considering themselves
duly convened, have immediately hold a general meeting and has adopted the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;
2. The following persons are appointed as directors of the Company until the general meeting of shareholders convened
to approve the Company's annual accounts for the financial year ended on December 31, 2018:
- Mr. Serge Dollendorf, Director, born in Sankt Vith, on February 2, 1972, with professional address at 5, Heieinhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Jean-Claude Michels, Director, born in Malmedy, on June 30, 1972, with professional address at, 5, Heieinhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Frank Keske,, born in Braunschweig, on May 20, 1966, with professional address at Valentinskamp 70, 20355
Hamburg, Germany.
3. The independent auditor for the Company shall be BDO Audit S.A., with registered office at 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The auditor shall remain in office until the close of the annual
general meeting approving the accounts of the Company as of December 31, 2013.
WHEREOF, this deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary this
deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausenddreizehn, am zwölften April.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxem-
burg,
SIND ERSCHIENEN:
72760
L
U X E M B O U R G
1. KRW Capital AG, eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Poststrasse 3, 8001 Zürich, Schweiz, eingetragen im
Register vom Handelsgericht von Zürich mit der Nummer CH-020.3.037.069-3;
2. Schindler & Schindler GmbH, eine Deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Im Dol 67, D-14195
Berlin, eingetragen im Register vom Handelsgericht von Charlottenburg mit der Nummer HRB 146530 B,
hier beide vertreten durch Frau Claire Guilbert, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund von ausgestellten Voll-
machten.
Besagte Vollmachten, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienenen Parteien haben den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer in Form einer Aktiengesellschaft
organisierte Genossenschaft (société coopérative organisée sous forme de société anonyme) zu beurkunden, welche sie
mit der folgenden Satzung gründen wollen:
A. Name - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Name.
1.1 Es besteht eine in Form einer Aktiengesellschaft organisierte Genossenschaft (société coopérative organisée sous
forme de société anonyme), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung (die „Satzung") unterliegt.
1.2 Die Gesellschaft besteht mit dem Namen „KRW Schindler Investment Management" (die "Gesellschaft").
Art. 2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Niederanven, Großherzogtum Luxemburg.
2.2 Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erfor-
derlichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates (der
„Verwaltungsrat") verlegt werden.
Art. 3. Zweck.
3.1 Zweck der Gesellschaft ist die Bildung, das Halten, die Entwicklung und die Realisierung eines Portfolios, bestehend
auf Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und Form an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, obgleich
diese bereits existieren oder zu gründen sind, vor allem durch Zeichnung, Erwerb durch Kauf, Verkauf oder Umtausch
von Wertpapieren oder Rechten jeder Art, wie Eigenkapitalinstrumenten, Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen,
sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.
3.2 Die Gesellschaft kann ebenfalls:
(a) jede Form Sicherheiten gewähren, im Rahmen der Ausführung durch die Gesellschaft von Verpflichtungen der
Gesellschaft oder jeglicher Gesellschaft, in der die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen oder Rechte jeglicher
Art hält, in die die Gesellschaft in irgendeiner Art investiert hat oder die derselben Unternehmensgruppe angehört,
beziehungsweise von jedes Geschäftsführers oder leitenden Angestellten oder Vertreters der Gesellschaft oder jeglicher
Gesellschaft, in der die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen oder Rechte jeglicher Art hält, in die die Ge-
sellschaft in irgendeiner Art investiert hat oder die derselben Unternehmensgruppe angehört;
und
(b) Gelder leihen oder sonstig jede Gesellschaft unterstützen, in der die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteili-
gungen oder Rechte jeglicher Art hält, in die die Gesellschaft in irgendeiner Art investiert hat oder die derselben
Unternehmensgruppe angehört.
3.3 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten vornehmen, die direkt oder indirekt die Erfüllung ihres Zwecks fördern. Im
Rahmen ihres Gesellschaftszwecks, kann die Gesellschaft insbesondere:
(a) in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen jeglicher Form oder mittels Ausgabe
aller Arten von Sicherheiten, Schuldinstrumenten, einschließlich Anleihen, sowie durch Annahme jeglicher Form von
Investition oder Rechten jeder Art;
(b) an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle von luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften teil-
nehmen; oder
(c) als Aktionär/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für die Schulden und Verpflichtungen
jeglicher luxemburgischen und ausländischen Gesellschaft handeln.
Art. 4. Dauer.
4.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
4.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die „Haupt-
versammlung") aufgelöst werden, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit
gefasst wird.
72761
L
U X E M B O U R G
B. Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Aktienklassen.
5.1 Die Gesellschaft wird zwei (2) Aktienklassen ausgeben, das heißt die Aktien von Aktienklasse A (die „Klasse A
Aktien") und die Aktien von Aktienklasse B (die „Klasse B Aktien" und zusammen mit den Klasse A Aktien, die "Aktien").
5.2 Die Aktien werden zu jeder Zeit ausgegeben.
5.3 Jede Aktie berechtigt ihren Inhaber zu einer (1) Stimme in der Hauptversammlung.
Art. 6. Gesellschaftskapital.
6.1 Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) (das „Minimum Gesellschaftskapital")
bestehend aus einunddreißigtausend (31.000) Klasse A Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Aktie.
6.2 Das Minimum Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
6.3 Bei der Gründung der Gesellschaft wurden die Aktien wie folgt gezeichnet:
(a) KRW Capital AG hat fünfzehntausendfünfhundert (15.500) Kasse A Aktien gezeichnet; und
(b) Schindler & Schindler GmbH hat fünfzehntausendfünfhundert (15.500) Kasse A Aktien gezeichnet.
6.4 Zusammen mit dem Minimum Gesellschaftskapital, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft, wie ab und zu erhöht
oder herabgesetzt, ist der Gesellschaftskapital der Gesellschaft (das „Gesellschaftskapital"), das nie unten das Minimum
Gesellschaftskapital runterfallen darf.
6.5 Die Aktien werden von dem Verwaltungsrat gemäß Artikel VII und IX unten ausgegeben, zurückgekauft oder
eingezogen, wie gegeben, sofern das Gesellschaftskapital nicht unter dem Minimum Gesellschaftskapital runterfällt.
Art. 7. Aktien.
7.1 Die Aktien sind Namensaktien, auf den Namen einer bestimmten Person, und in dem Aktienregister nach dem
geltenden Recht registriert.
7.2 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von jedem Aktionären eingesehen werden kann.
Der Nachweis über das Eigentum an Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden.
7.3 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine oder mehrere Aktien von mehreren
Personen gemeinsam gehalten werden oder wenn das Eigentumsrecht einer/der Aktie(n) aufgeteilt oder umstritten ist,
müssen alle Personen die ein Recht auf jene Aktie(n) beanspruchen, eine einzelne Person benennen, die diese Aktie(n)
gegenüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit
einer derartigen Aktie auszusetzen, sofern kein solcher Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet
worden ist. Dasselbe gilt im Falle eines Konflikts zwischen einem Nutznießer (usufrutier) und einem Nießbrauchgeber
(nu-propriétaire) oder zwischen einen Pfandgläubiger und einen Pfandschuldner.
7.4 Aktien können weder übertragen noch verpfändet oder abgetreten werden. Sie können aber gemäß dem unten-
genannten Artikel X von der Gesellschaft eingezogen werden. Darüber hinaus können die Einzugserlöse verpfändet
werden.
Art. 8. Zulassung, Ausgabe, Stimmerechte.
8.1 Vorbehaltlich Artikeln V und VI, ist der Verwaltungsrat dazu ermächtigt, ohne Beschränkung jederzeit eine unbe-
grenzte Anzahl von vollständig bezahlten Klasse B Aktien auszugeben.
8.2 Zeichnungsanträge für Klasse B Aktien müssen an den Verwaltungsrat gerichtet werden, welcher diese im eigenen
Ermessen akzeptieren oder ablehnen kann.
8.3 Die Anzahl der im Falle eines Zeichnungsantrags auszugebenden Klasse B Aktien wird von dem Verwaltungsrat
unter Berücksichtigung des Wertes der Klasse B Aktien festgelegt.
8.4 Jede neu gezeichnete Klasse B Aktie kann die Zahlung einer vom Verwaltungsrat im eigenen Ermessen bestimmten
Emissionsgebühr oder Prämie erfordern.
8.5 Jede Klasse B Aktie berechtigt zu einer (1) Stimme.
Art. 9. Rücktritt, Ausschluss, Tod und Rücknahme.
9.1 Die Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft erlischt durch Rücktritt, Ausschluss oder Tod. In jedem Falle
wird die Gesellschaft deren Aktien einziehen. Eingezogene Aktien werde automatisch annulliert und das Gesellschafts-
kapital wird unter Berücksichtigung des Minimum Gesellschaftskapitals entsprechend herabgesetzt.
9.2 Ein Aktionär kann nur im Fälle und unter den vom Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen aus der Gesellschaft
austreten. Der Austritt muss schriftlich mitgeteilt werden.
9.3 Desweiteren kann jeder Aktionär aufgrund von Fehlverhalten ausgeschlossen werden, welches vom Verwaltungsrat
beurteilt wird. Der Ausschluss wird vom Verwaltungsrat beschlossen und schriftlich mitgeteilt.
9.4 Der Einzugspreis pro Aktie entspricht deren Wert, so wie dieser aus der Bilanz des Geschäftsjahres, in dem die
Beteiligung endete, hervorgeht und muss innerhalb eines vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitraums, welcher zehn (10)
Tage, ab Verfügbarkeit von Geldern folglich der Festlegung des Einzugspreises, nicht überschreiten darf, bezahlt werden.
72762
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Haftung der Aktionäre. Die Aktionäre sind nur für die Zahlung des Gegenwertes und gegebenenfalls der Prämie
jeder gezeichneten Aktie an die Gesellschaft verantwortlich. Insbesondere haften die Aktionäre nicht für Schulden, Ver-
bindlichkeiten und/oder Auflagen der Gesellschaft oder eines anderen Aktionärs.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 11. Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre.
11.1 Die Hauptversammlung kann jederzeit durch den Verwaltungsrat oder, soweit vorhanden, durch den/die Buch-
prüfer einberufen werden.
11.2 Sie muss auf schriftliche Aufforderung von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Pro-
zent (10%) des Gesellschaftskapitals halten, vom Verwaltungsrat oder vom Buchprüfer/den Buchprüfern einberufen
werden. In einem derartigen Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines (1) Monats ab Zugang des
Ersuchens abgehalten werden.
11.3 Die Einberufungsbekanntmachung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss das Datum, die Uhrzeit, den
Ort und die Tagesordnung der Versammlung enthalten und zweimal in Form einer Einberufungsbekanntmachung im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und in einer Luxemburger Tageszeitung mit einem Zeitabstand von
mindestens acht (8) Tagen und acht (8) Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum erfolgen. Einbe-
rufungsbekanntmachungen per Post sind acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Inhaber
von Namensaktien zu versenden, wobei kein Beweis der Einhaltung dieser Formvorschrift erbracht werden muss. Handelt
es sich bei allen Aktien um Namensaktien, so kann die Einberufungsbekanntmachung ausschließlich durch Einschreiben
erfolgen, die mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Aktionär zu versenden
sind.
11.4 Wenn alle Aktien Namensaktien sind können die Einberufungsbekanntmachung nur in Form von Einschreiben
gemacht werden und sollen per eingeschriebenen Post mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anbe-
raumten Datum an jeden Aktionäre versendet werden.
11.5 Falls alle Aktionäre in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf Ladungsformalitäten verzichtet
haben, kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einladung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 12. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.
12.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird in der Gemeinde, in der sich der Gesellschaftssitz befindet, oder
an einem anderen in der Einberufungsbekanntmachung bestimmten Ort am dritter Freitag von Juni jedes Jahres um 10
Uhr abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf
folgenden Werktag abzuhalten. Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können an dem in der Einberufungsbe-
kanntmachung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit abgehalten werden.
12.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird ein Rat der Versammlung bestimmt, der aus einem Vorsitzenden,
einem Schriftführer und einem Stimmzähler besteht, die weder Aktionäre, noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein
müssen.
12.3 Wenn alle bei der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre entscheiden, dass eine ordnungsgemässe Abstim-
mung derart gewährleisten werden kann, so können sie einstimmig beschließen, lediglich (i) einen Vorsitzenden und einen
Schriftführer oder (ii) eine Person zu ernennen, die die Rolle des Rates der Versammlung übernimmt und in einem solchen
Fall ist die Ernennung eines Stimmzählers nicht erforderlich. Soweit anwendbar und je nach Zusammenhang so ist jeder
Bezug auf den „Rat der Versammlung" in dieser Satzung als Verweis auf den „Vorsitzenden und Schriftführer" oder
gegebenenfalls als Verweis auf die „Einzelperson, die die Rolle des Rates übernommen hat", zu verstehen.
12.4 Der Rat der Versammlung soll sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und vor allem
im Einklang mit den Regeln betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktio-
nären abgehalten wird.
12.5 In jeder Hauptversammlung wird eine Anwesenheitsliste geführt.
12.6 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person, Aktionär
oder nicht Aktionär, durch ein unterzeichnetes Dokument, das per Post, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kom-
munikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre
vertreten.
12.7 Aktionäre, die an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Versammlung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Bestimmung des Quorums und des
Stimmrechts, insofern diese Kommunikationsmittel am Ort der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt werden.
12.8 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch ein unterzeichnetes Stimm-
karte abgeben, welches per Post, E¬Mail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft
oder an die in der Einberufungsbekanntmachung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche
Stimmkartee verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und
die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen ent-
72763
L
U X E M B O U R G
halten, die es dem Aktionären ermöglichen, seine Stimme für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder
sich zu enthalten, indem er das entsprechende Kästchen ankreuzt.
12.9 Stimmkarten, die für einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen
den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungültig. Die
Gesellschaft wird nur Stimmkarten berücksichtigen, die sie vor der entsprechenden Hauptversammlung der Aktionäre
erhalten hat.
Art. 13. Quorum und Stimmrecht.
13.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre.
13.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in
einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesell-
schaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Art. 14. Änderungen der Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der
Satzung einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der
abgegebenen gültigen Stimmen, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist. Falls
die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung
eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, die unabhängig von einem Anwesenheitsquorum be-
schlussfähig ist und in welcher Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen gültigen
Stimmen gefasst werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915
kann der Verwaltungsrat jede sich im Gange befindliche Hauptversammlung der Aktionäre um vier (4) Wochen vertagen.
Der Verwaltungsrat muss eine Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder mehreren Aktio-
nären, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals halten, gefordert wird. Durch derartige Vertagung
wird jeder bereits gefasste Beschluss in dieser Versammlung annulliert.
Art. 17. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.
17.1 Der Rat der Versammlung nimmt ein Protokoll jeder Versammlung auf, welches vom Rat der Versammlung sowie
von jedem Aktionär, der darum ersucht, unterzeichnet wird.
17.2 Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht
werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der
die Originalurkunde verwahrt, beglaubigt werden, oder ansonsten vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei be-
liebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 18. Zusammensetzung und Befugnisse des Verwaltungsrates.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusam-
mensetzt. Sollte die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionären gegründet worden sein oder wird in einer Hauptver-
sammlung der Aktionäre festgestellt werden, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionären hat, so kann die
Gesellschaft bis zu der Hauptversammlung der Aktionäre durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geleitet werden, die
auf die Feststellung folgt, dass es wieder mehr als einen Aktionär gibt. in einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo
der Begriff „einziges Verwaltungsratsmitglied" nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf
den „Verwaltungsrat" als Verweis auf das „einzige Verwaltungsratsmitglied" auszulegen.
18.2 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle
Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der
durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 19. Tägliche Geschäftsführung.
19.1 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung
der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitende Angestellte oder anderen Personen, mit
gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse wer-
den durch Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.
19.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.
Art. 20. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
20.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
20.2 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten und jedes Verwaltungsrats-
mitglied übt sein Amt aus, bis sein/ihr Nachfolger gewählt ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann wiedergewählt werden.
72764
L
U X E M B O U R G
20.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen in einer Hauptversamm-
lung gewählt.
20.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund mit einfache Mehrheit der in einer Hauptver-
sammlung der Aktionäre abgegebenen Stimmen abberufen werden.
20.5 Wird eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied gewählt, so muss diese eine natürliche Person als ihren
ständigen Vertreter benennen, die ihr Mandat in ihrem Namen und für ihre Rechnung ausübt. Die betreffende juristische
Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche
Person kann nur ständiger Vertreter eines (1) Verwaltungsratsmitglieds und nicht gleichzeitig persönlich Verwaltungs-
ratsmitglied sein.
Art. 21. Vakanz des Amtes eines Verwaltungsratsmitglieds.
21.1 Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen
Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten
Hauptversammlung der Aktionäre vorübergehend für die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Verwaltungsrats-
mitglieds nicht übersteigenden Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
21.2 Für den Fall, dass das einzige Verwaltungsratsmitglied aus seinem Amt scheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Hauptversammlung der Aktionäre neu besetzt werden.
Art. 22. Einladung zu Verwaltungsratssitzungen.
22.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder eines beliebigen Verwaltungsrats-
mitglieds. Die Verwaltungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft
statt.
22.2 Die Verwaltungsratsmitglieder werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anbe-
raumten Datum zu jeder Sitzung des Verwaltungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Verwaltungs-
ratsmitglieder schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung
abgegeben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen
des Verwaltungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Verwaltungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Verwaltungsratsmitgliedern übermittelt wurde.
22.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und diese
alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des
Verwaltungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 23. Durchführung von Verwaltungsratssitzungen.
23.1 Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen
Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokoll-
führung der Verwaltungsratssitzungen verantwortlich ist.
23.2 Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. In dessen Abwesenheit
kann der Verwaltungsrat ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder
vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
23.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied
des Verwaltungsrats schriftlich, per Fax, E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt,
wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
23.4 Eine Verwaltungsratssitzung kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kom-
munikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und
tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleich-
bedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
abgehalten erachtet.
23.5 Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mit-
glieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
23.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Verwaltungsratssitzung teilnehmenden
oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat im Falle von Stimmgleich-
heit nicht die entscheidende Stimme.
23.7 Soweit nicht gesetzlich anders bestimmt muss jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an einem Geschäft, das dem
Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein Interesse, welches den Interessen der Gesellschaft
entgegen steht, hat, den Verwaltungsrat über diesen Interessenskonflikt informieren; die Erklärung wird im Protokoll der
betreffenden Sitzung aufgenommen. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied darf weder an der Beratung über das in
Frage stehende Geschäft teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Hauptversammlung der Aktionäre muss von
derartigen Interessenkonflikten informiert werden, bevor Beschlüsse zu anderen Tagesordnungspunkten gefasst werden.
72765
L
U X E M B O U R G
23.8 Der Verwaltungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax,
E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Zustim-
mung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlus-
ses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 24. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen - Protokoll der Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds.
24.1 Das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder, im Falle seiner
Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore oder von zwei (2) beliebigen anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern
unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind,
werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
24.2 Die Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom
einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.
Art. 25. Geschäfte mit Dritten.
25.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2)
beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, verpflichtet.
25.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder
Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der/denen diese Vollmacht übertragen wurde.
E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire
(s)). Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre
nicht überschreiten darf.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen wer-
den.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen,
in der jeweils gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s))
ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit
den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der
gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den gesetz-
lichen Vorschriften und Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.
28.6 Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen
Aktien.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation.
29.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,
welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt
72766
L
U X E M B O U R G
und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquida-
toren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft.
29.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 30. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Aktionär
Zahl der
Aktien
Wert
1.- KRW Capital AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500 Aktien EUR 15.500
2.- Schindler & Schindler GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500 Aktien EUR 15.500
Die Einlage für die so gezeichneten Aktien wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in
Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2013.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit, dass er das Vorliegen der Vorschriften, die in Artikel 26 des Gesetzes
von 1915 aufgeführt sind und auf die verwiesen wird, geprüft hat und erklärt, dass diese erfüllt sind.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.200,-.
<i>Beschlüsse der Aktionärei>
Die Gründer, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren und welche auf eine formelle Einberufungsbe-
kanntmachung verzichten, haben daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg;
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ernannt, bis zur Hauptversammlung
der Aktionäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr bis zum 31. December 2018 verabschiedet:
- Herr Serge Dollendorf, Direktor, geboren in Sankt Vith am 2. Februar 1972, mit geschäftsansässig in 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Jean-Claude Michels, Direktor, geboren in Malmedy am 30. June 1972 mit geschäftsansässig in 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg; und
- Herr Frank Keske, geboren in Braunschweig am 20. Mai 1966 mit geschäftsansässig in Valentinskamp 70, 20355
Hamburg, Deutschland.
3. BDO Audit S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft mit Sitz in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Großher-
zogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg mit der Nummer B 147570 wird als zugelassene
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur Hauptversammlung der Aktionäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft
für das erste Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2013 verabschiedet ernannt.
WORÜBER diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Parteien, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, hat der Bevollmächtigte
die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: C. GUILBERT und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 avril 2013. Relation: LAC/2013/18251. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
72767
L
U X E M B O U R G
Luxemburg, den 7. Mai 2013.
Référence de publication: 2013059652/753.
(130073233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
May Fixation S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8612 Pratz-Préizerdaul, 1A, rue de Buschrodt.
R.C.S. Luxembourg B 82.051.
Im Jahre zweitausend und dreizehn, am siebenzehnten Tag des Monats April.
Vor dem unterzeichneten Notar Edouard DELOSCH mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
1.- Herr Marcel KLEIS, Kaufmann, geboren am 19. Februar 1963 in Sankt Vith (Belgien), wohnhaft in L-7562 Mersch,
Um lecker 3.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchte, Nachfolgendes zu beurkunden:
I. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „MAY FIXATION S.à r.l.", mit Sitz in L-7526 Mersch, Allée John W.
Léonard 17 A, wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Aloyse BIEL, damals mit Amtssitz in Capellen,
am 13. April 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1087 vom 29. November
2001, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B und Nummer 82.051. Die Satzung
der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch Notar Henri HELLINCKX, damals mit Amtssitz in Mersch, am 21.
Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1011 am 23. Mai 2006.
II. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euros und siebenundsechzig Cents, (EUR
12.394,67), aufgeteilt in einhundert Anteile (100) von je einhundertdreiundzwanzig Euros und vierundneunzig Cents (EUR
123,94), alle dem Herrn Marcel KLEIS (der „Alleingesellschafter"), vorbenannt, zugeteilt.
Somit ist das gesamte Kapital hier vertreten.
III. Der Alleingesellschafter erklärt vollständig über die Beschlüsse unterrichtet worden zu sein, die auf Basis der
folgenden Tagesordnung zu fassen sind:
<i>Tagesordnungi>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von der aktuellen Adresse in L-7526 Mersch, Allée John W. Léonard 17 A nach
L-8612 Pratz-Preizerdaul, rue de Buschrodt, 1A;
2. Abänderung des Artikel 3, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft, um sie dem obigen Beschluss anzupassen;
3. Sonstiges.
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen den Gesellschaftssitz von L-7526 Mersch, Allée John W. Léonard 17 A nach L-8612
Pratz-Préizerdaul, rue de Buschrodt, 1A zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Gemäß dem vorerwähnten Beschluss wird Artikel 1, Absatz 2 der Satzung wie folgt abgeändert:
Art. 1. (Absatz 2). „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Préizerdaul."
<i>Kostenabschätzungi>
Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf unge-
fähr neunhundert Euro (EUR 900,-) geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch, zum Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-
nenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar,
unterzeichnet.
Gezeichnet: M. KLEIS, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 19 avril 2013. Relation: DIE/2013/5129. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveur p.d.i> (signé): RECKEN.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, den 6. Mai 2013.
Référence de publication: 2013058116/48.
(130071290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
72768
Acronyme S.A.
Bainbridge Properties S.à r.l.
BCF Photonics II S.à r.l.
Immobilux S.à r.l.
KRW Schindler Investment Management
LBB Re Luxembourg S.A.
Legacy S.A.
Leopard Germany Holding Hotels S.à r.l.
LREDS II (LBF) S.A.
Lukos S.A.
Lux. Ouvrage d'Art S.à r.l.
Lux Santé S.A.
Management & Advisory Sàrl
May Fixation S.à.r.l.
MGP Europe (Lux) S.à r.l.
MGP Europe Parallel (Lux) S.à r.l.
M&T's
Paquita
Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR
Patron Capital Alpentherme S.à r.l.
Patron Capital Schweiz S.à r.l.
Patron Carlo Felice Holdings S. à r.l.
Patron Furnas S.à r.l.
Patron Generator S.à r.l.
Patron Jupiter Holdings S.à r.l.
Patron Karua S.à r.l.
Patron Marina Velca Properties S.à r.l.
Patron Milan Properties S.à r.l.
Patron Pipera Realty S.à r.l.
Patron Project III Sàrl
Patron Project XVI S.à r.l.
Patron Project XV S.àr.l.
Patron Romanian Realty S.à r.l.
Patron Sirius S.à r.l.
Patron Sports Holding S.à r.l.
Poblenou Holding S.à r.l.
Polytech Industries S.A.
Polytech Investment (SPF) S.A.
Roundabout S.à r.l.
RP Complex Holding III S.à r.l.
RPTRE I S.à r.l.
RP XVIII S.à r.l.
RP XXII S.à r.l.
RP XXI S.à r.l.
RP XX S.à r.l.
Sapient Asia Holdings Luxembourg S. à r.l.
Sapient Holdings Luxembourg S. à r.l.
Sapient Operations Luxembourg S. à r.l.
Scala IRP Capital Partners
SE Investmentfund-FIS
SE Investmentfund-FIS
ServiceMagic International S.à r.l.
Silverfleet Sixth Investment Company S.à r.l.
Simplify S.C.A., SICAV-FIS
Soccerworld Europe S. à r. l.
Soloback S.A.
Stadsfeestzaal Lux S.à r.l.
Trans-Immo
Washington Immo S.A.