This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1503
25 juin 2013
SOMMAIRE
Aedificium Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72133
AGIS s.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72111
Balaton Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
72109
Belval Plaza I Apartments S.à r.l. . . . . . . . .
72110
Belval Plaza I Mall S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
72110
Blackstone Perpetual Topco S.à r.l. . . . . . .
72112
B.R. Opticiens S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72109
Global Climate Partnership Fund SA, SI-
CAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72101
H&F Sensor Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
72098
H&F Wings Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
72099
Honeywell FT Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
72098
Icar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72100
International Financial Data Services (Lu-
xembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72099
IT Realty (Cantalupo) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
72100
JMF Transports S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72100
JRS SICAV - SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72103
Kalle Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
72099
KEDI 1 Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
72104
Kedi 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72104
KEDI 2 & 3 Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
72105
Kikinoa Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72102
Kujtesa Max S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72103
Makemake Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
72098
MEMC International Finance S.à r.l. . . . . .
72107
MEMC Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
72107
MGP Artemis II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
72107
MGP Asia III LLC 1 Holdings S.à r.l. . . . . .
72109
MGP Asia III TMK 1 Holdings S.à r.l. . . . . .
72109
MGP Asia Japan TMK 2 Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72110
MGP Asia (Lux) III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
72108
MGP Asia (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
72108
MGP Harbour Exchange S.à r.l. . . . . . . . . .
72101
MGP HoldCo Craven S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
72101
MGP Idaho S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72101
MGP Jack S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72102
MGP Japan Core Plus LLC Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72111
MGP Japan Core Plus (Lux) S.àr.l. . . . . . . .
72110
MGP Japan Core Plus TMK 2 Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72112
MGP Japan Core Plus TMK Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72111
MGP June II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72102
MGP June S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72102
OG Enterprises S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72107
Oracle CAPAC Finance S.à r.l. . . . . . . . . . .
72106
Oracle Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72106
Paladin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72144
Patron Holding (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
72104
Patron Pipera Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
72105
PGE Europe one S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72100
Prolilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72103
Pyracantha Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72105
Pyrum Innovations International S.A. . . . .
72144
Romania Waterfront (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72108
Société d'Investissement AMBARES S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72106
Stackpole International, S.à r.l. . . . . . . . . . .
72144
Tempyr S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72108
Valorinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72099
Way LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72111
72097
L
U X E M B O U R G
H&F Sensor Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 680.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 140.979.
Par résolutions signées en date du 30 avril 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Yves Cheret, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, de son mandat de Gérant de classe B, avec effet immédiat;
- nomination de Annick Clérinx, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de Gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2013.
Référence de publication: 2013057190/15.
(130070192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Honeywell FT Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 67.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 152.377.
<i>Cession de partsi>
Avec effet au 25 mars 2013, un changement dans l'actionnariat de la société ci-dessus a eu lieu comme suit:
First Technology Overseas Ltd., détenant 67.500 parts sociales dans la société ci-haut mentionée, a cédé la totalité de
ses parts à:
Honeywell Technologies S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Suisse, avec adresse
à Zone d'activités La Pièce 16, 1180 Rolle, Suisse et enregistrée au Registre de Commerce de Suisse sous le numéro
CH-550.1.035.825-1.
Dès lors, l'associé unique et la répartition de parts sociales est à inscrire comme suit:
Honeywell Technologies S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.500 parts sociales
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 2 mai 2013.
Référence de publication: 2013057196/19.
(130069942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Makemake Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 175.895.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 30 avril 2013, que l'associé unique de la Société, BRE/
Europe 6Q S.à r.l., a transféré la totalité des 750 parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière suivante:
(1) Makemake Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant
son siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et pas encore immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés, 750 parts sociales;
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
1. Makemake Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013057349/19.
(130070386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
72098
L
U X E M B O U R G
H&F Wings Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.629,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 147.172.
Par résolutions prises en date du 30 avril 2013, les associés ont pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Yves Cheret, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, de son mandat de Gérant de catégorie B, avec effet immédiat;
- nomination de Annick Clérinx, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de Gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2013.
Référence de publication: 2013057191/15.
(130070179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Kalle Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 42.000.000,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 117.303.
Par résolutions signées en date du 25 avril 2013, les associés ont pris les décisions suivantes:
- acceptation, avec effet immédiat, de la démission de Yves CHÉRET, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de classe A;
- nomination de Damien BECKEL, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2013.
Référence de publication: 2013057268/15.
(130070132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 81.997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
Signature
<i>L’agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2013057218/12.
(130070060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Valorinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 53.010.
Le bilan consolidé au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VALORINVEST
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2013057605/11.
(130070289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
72099
L
U X E M B O U R G
IT Realty (Cantalupo) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 108.081.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 25 avril 2013i>
L’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013057242/19.
(130070332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
JMF Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 155.149.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L-4831 Rodange, le 02 mai 2013.
Monsieur De Simone Jean-Marie
<i>Gérant techniquei>
Référence de publication: 2013057261/12.
(130069912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
PGE Europe one S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.124.
Les comptes annuels du 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013057458/10.
(130070499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Icar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 34-36, rue de Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 101.121.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L-2543 Luxembourg, le 02 mai 2013.
Monsieur Zupanoski Robert
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013057229/12.
(130069961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
72100
L
U X E M B O U R G
MGP Harbour Exchange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 149.116.
Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. dénonce sa fonction d’agent domiciliataire de MGP Harbour Exchange S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le No B149116 et domiciliée au 2-8,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1
er
mai 2013.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2013057387/12.
(130070166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
MGP HoldCo Craven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 162.464.
Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. dénonce sa fonction d’agent domiciliataire de MGP HoldCo Craven S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le No B162464 et domiciliée au 2-8, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1
er
mai 2013.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2013057388/12.
(130070165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
MGP Idaho S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 129.110.
Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. dénonce sa fonction d’agent domiciliataire de MGP Idaho S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le No B129110 et domiciliée au 2-8, Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1
er
mai 2013.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2013057389/12.
(130070164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Global Climate Partnership Fund SA, SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 150.193.
<i>Résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire de la SICAV-SIF en date du 3 mai 2013i>
L'Assemblée Générale Ordinaire a pris les décisions suivantes:
1. de renouveler le mandat de
- Madame Monika BECK
- Madame Claudia ARCE
- Madame Ritu KUMAR
comme administrateurs de la SICAV-SIF jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014
2. de renouveler le mandat de Ernst & Young en tant que Réviseur d'entreprises agréé de la SICAV-SIF jusqu'à l'As-
semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013057935/18.
(130071380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72101
L
U X E M B O U R G
Kikinoa Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 24.000,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 109.654.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 avril 2013 que:
- Monsieur Stef Oostvogels a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 29 Avril 2013;
- Monsieur Gérard Maîtrejean, né le 13 juin 1967 à Charleroi (Belgique), demeurant au 291, route d'Arlon, L-1150
Luxembourg a été nommé en remplacement de Monsieur Stef Oostvogels, avec effet au 30 Avril 2013 et pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 03 mai 2013.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013058036/18.
(130070987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
MGP Jack S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 114.137.
Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. dénonce sa fonction d’agent domiciliataire de MGP Jack S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le No B114137 et domiciliée au 2-8, Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1
er
mai 2013.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2013057390/12.
(130070145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
MGP June II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 149.622.
Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. dénonce sa fonction d’agent domiciliataire de MGP June II S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le No B149622 et domiciliée au 2-8, Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1
er
mai 2013.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2013057398/12.
(130070163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
MGP June S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 149.624.
Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. dénonce sa fonction d’agent domiciliataire de MGP June S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le No B149624 et domiciliée au 2-8, Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1
er
mai 2013.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2013057399/12.
(130070162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
72102
L
U X E M B O U R G
JRS SICAV - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 148.348.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 3 avril 2013i>
L’assemblée générale ordinaire a décidé de:
- renouveler les mandats d’administrateurs de tous les membres actuels du conseil d’administration pour une période
prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2014, de sorte que le conseil d’administration de la Société
se compose des personnes suivantes:
* Monsieur Anders Malcolm avec adresse professionnelle à L-2370 Howald, 4 rue Peternelchen, président du conseil
d’administration
* Monsieur Olivier Scholtes avec adresse professionnelle à L-2370 Howald, 4 rue Peternelchen
* Monsieur Peter Nygren avec adresse professionnelle à S-103 90 Stockholm, Birger Jarlsgatan 14
* Monsieur Mats Ekström avec adresse professionnelle à S-103 90 Stockholm, Birger Jarlsgatan 14
- renouveler le mandat de réviseur indépendant d’entreprises de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Le
mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013057265/20.
(130069869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Kujtesa Max S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 133.028.
Veuillez noter que l’associée de la société, Southeast Europe Equity Fund II (B), L.P. a changé d’adresse avec effet au
10 décembre 2012 et se situe désormais à KY1-9005 George Town, Grand Cayman (Iles Caïmanes), 190, Elgin Avenue.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Kujtesa Max S.A.R.L.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013057269/13.
(130070029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Prolilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 125.168.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 20 septembre 2012i>
Les mandats des administrateurs de catégorie A et B à savoir Monsieur Marc LIEGEOIS, né le 22/05/1968 à Kinshasa
(République Démocratique du Congo), demeurant à Gottes 2, B-1390 GREZ-DOICEAU (Belgique), Monsieur Luc LIE-
GEOIS, né le 24/05/1971 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), demeurant au 12, Bosweidelaan, B-1640 Sint-
Genesius-Rode (Belgique), Monsieur Jean-Marc FABER, né le 07/04/1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement
au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Monsieur Christophe MOUTON, né le 20/11/1971 à Saint-Mard (Belgique),
demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, ainsi que le mandat du Commissaire aux
Comptes à savoir la Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
PROLILUX S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013057471/21.
(130069927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
72103
L
U X E M B O U R G
KEDI 1 Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.579.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
L'Assemblée générale extraordinaire de la Société du 30 avril 2013 a décidé de clôturer la liquidation volontaire. Les
livres et documents sociaux seront déposés pour une période d'au moins 5 années au bureau de la société Avega Services
(Luxembourg) S.à r.l., 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
Pour extrait
Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.
Signatures
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2013057276/17.
(130070837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Kedi 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.590.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
L'Assemblée générale extraordinaire de la Société du 30 avril 2013 a décidé de clôturer la liquidation volontaire. Les
livres et documents sociaux seront déposés pour une période d'au moins 5 années au bureau de la société Avega Services
(Luxembourg) S.à r.l., 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
Pour extrait
Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.
Signatures
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2013057277/17.
(130070835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Patron Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 82.605.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 25 avril 2013i>
L’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013057438/19.
(130070424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
72104
L
U X E M B O U R G
KEDI 2 & 3 Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.580.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
L'Assemblée générale extraordinaire de la Société du 30 avril 2013 a décidé de clôturer la liquidation volontaire. Les
livres et documents sociaux seront déposés pour une période d'au moins 5 années au bureau de la société Avega Services
(Luxembourg) S.à r.l., 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
Pour extrait
Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.
Signatures
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2013057278/17.
(130070836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Pyracantha Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 15.713.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 05/04/2013 à Luxembourgi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir
Messieurs JACQUEMART Laurent, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, GILLET Etienne, 3A, Boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, MARECHAL Joël, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en tant
qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG en tant que
commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2019.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013057475/17.
(130070570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Patron Pipera Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 122.758.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 25 avril 2013i>
L’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Robert Brimeyer de son poste de gérant de la société avec effet au 21 avril 2013.
- Nomination de M. Emmanuel Mougeolle, directeur de sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, résidant pro-
fessionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 21 avril
2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- M. Emmanuel Mougeolle, gérant, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2013057439/19.
(130070425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
72105
L
U X E M B O U R G
Oracle CAPAC Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 139.273.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 26 avril 2013 que Madame Séverine Lambert,
née le 20 septembre 1980 à Virton (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 412F, route d’Esch, L-1030 Luxem-
bourg, a été nommée gérant B de la Société avec effet au 29 avril 2013, pour une durée indéterminée, en remplacement
de M. Alessandro Maiocchi, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
<i>Pour Oracle CAPAC Finance S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013057427/17.
(130070040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Oracle Finance, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.323.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 26 avril 2013 que Madame Séverine Lambert,
née le 20 septembre 1980 à Virton (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 412F, route d’Esch, L-1030 Luxem-
bourg, a été nommée gérant B de la Société avec effet au 29 avril 2013, pour une durée indéterminée, en remplacement
de M. Alessandro Maiocchi, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
<i>Pour Oracle Finance
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013057428/17.
(130070403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Société d'Investissement AMBARES S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 104.013.
Par résolutions prises en date du 13 mars 2013, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Gilles Paul Pierre Guinchard, avec adresse au 22, avenue de la Gare, 1095 Lutry,
Suisse, de son mandat de gérant A, avec effet immédiat;
- acceptation de la démission de Dolorès Carmen Collet, avec adresse au 7, Chemin de Vertefeuille, Le Rocher, 60350
Pierrefonds, France, de son mandat de gérant B, avec effet immédiat;
- nomination de Delphine André, avec adresse professionnelle au Grand Chemin du Barrié, 13440 Cabannes, France,
au mandat de gérant A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
- nomination de Jacques Duvauchelle, avec adresse professionnelle au Chemin de Bellevue, 26780 Espeluche, France,
au mandat de gérant B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2013.
Référence de publication: 2013057517/19.
(130066406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
72106
L
U X E M B O U R G
MEMC International Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 135.612.
Par la presente, je vous informe de ma demission en tant que gerant de categorie A de la societe MEMC Luxembourg
Sarl avec effet du 26 avril 2013.
Le 2 mai 2013.
Bradley D. Kohn.
Référence de publication: 2013057370/11.
(130070636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
MEMC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 135.611.
Par la presente, je vous informe de ma demission en tant que gerant de categorie A de la societe MEMC Luxembourg
Sarl avec effet du 26 avril 2013.
Le 2 mai 2013.
Bradley D. Kohn.
Référence de publication: 2013057371/11.
(130070637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
MGP Artemis II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 157.131.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 30 avril 2013.
<i>Pour MGP Artemis II S.à r.l.
i>Delloula Aouinti
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013057373/16.
(130070700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
OG Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 164.741.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 mai 2013.
<i>Pour: OG ENTERPRISES S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Christine Racot
Référence de publication: 2013057432/15.
(130070472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
72107
L
U X E M B O U R G
MGP Asia (Lux) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 128.964.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour MGP Asia (Lux) III S.à r.l.
i>Bernardine Vos
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013057374/16.
(130070601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
MGP Asia (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.241.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour MGP Asia (Lux) S.à r.l.
i>Bernardine Vos
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013057375/16.
(130070593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Romania Waterfront (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 125.890.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
Référence de publication: 2013057487/10.
(130070431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Tempyr S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 123.803.
Les comptes annuels au au 31 Decembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02/05/2013.
Référence de publication: 2013057578/11.
(130069946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
72108
L
U X E M B O U R G
MGP Asia III LLC 1 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 168.047.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour MGP Asia III LLC 1 Holdings S.à r.l.
i>Bernardine vos
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013057376/16.
(130070600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
MGP Asia III TMK 1 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 168.083.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour MGP Asia III TMK 1 Holdings S.à r.l.
i>Bernardine Vos
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013057377/16.
(130070599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
B.R. Opticiens S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4470 Soleuvre, 195, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 173.668.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour B.R. OPTICIENS S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013057730/11.
(130071649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Balaton Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 171.676.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Balaton Properties S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013057733/11.
(130071597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72109
L
U X E M B O U R G
Belval Plaza I Apartments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 120.931.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Ce dépôt remplace le dépôt L130055955 du 10 avril 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013057738/11.
(130070945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
Belval Plaza I Mall S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 120.932.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Ce dépôt remplace le dépôt L130055953 du 10 avril 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013057739/11.
(130070944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
MGP Asia Japan TMK 2 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.530.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour MGP Asia Japan TMK 2 Holdings S.à r.l.
i>Bernardine Vos
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013057380/16.
(130070595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
MGP Japan Core Plus (Lux) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 2.334.720,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 117.656.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour MGP Japan Core Plus (Lux) S.à r.l.
i>Bernardine Vos
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013057391/16.
(130070606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
72110
L
U X E M B O U R G
MGP Japan Core Plus LLC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 2.334.720,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 117.657.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour MGP Japan Core Plus LLC Holding S.à r.l.
i>Bernardine Vos
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013057392/16.
(130070602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
MGP Japan Core Plus TMK Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 2.334.720,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 117.658.
<i>Extrait des résolutions des associés du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour MGP Japan Core Plus TMK Holdings S.à r.l.
i>Bernardine Vos
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013057393/16.
(130070603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Way LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.888.
Les statuts coordonnés au 15 avril 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013057618/11.
(130070584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
AGIS s.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 32.585.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AGIS s.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013057711/11.
(130071447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
72111
L
U X E M B O U R G
MGP Japan Core Plus TMK 2 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 2.334.800,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 124.151.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 31 janvier 2013i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour MGP Japan Core Plus TMK 2 Holdings S.à r.l.
i>Bernardine Vos
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013057394/16.
(130070605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 933.692,50.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 173.008.
In the year two thousand and thirteen on the second of April.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI - ESC L.P., a limited partnership existing under the laws of
the Cayman Islands, with registered office at 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands,
registered with the Registrar of Limited Partnerships, Cayman Islands under number WK-47430,
here represented by Mrs Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal;
2) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P. is an exempted limited partnership incorporated under the laws
of the Cayman Islands, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue,
George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships
in the Cayman Islands under number WK-68503,
here represented by Mrs Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal;
3) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-B L.P. is an
exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at In-
tertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-68509,
here represented by Mrs Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal;
4) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P. is an exempted limited partnership incorporated under the laws
of the Cayman Islands, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue,
George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships
in the Cayman Islands under number WK-68506,
here represented by Mrs Johanna WITTEK, Rechtsanwàltin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal;
5) Perpetual Management Investment II L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership having its registered office
at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-71186,
represented by its general partner Perpetual Management Investments Manager Ltd, a limited company incorporated
under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman
KY1-9005, Cayman Islands,
here represented by Mrs Johanna WITTEK, Rechtsanwàltin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal;
72112
L
U X E M B O U R G
6) Stichting Administratiekantoor Perpetual, a Stichting organised under the laws of the Netherlands, with its registered
office at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands, and registered with the trade register of the
Netherlands Chamber of Commerce under number 57360405,
here represented by Mrs Johanna WITTEK, Rechtsanwàltin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal.
These proxies, after having been initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing persons are all the shareholders of Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., (hereinafter the "Company")
a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and which is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 173.008, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on
November 22
nd
, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 21, dated January 4
th
, 2013. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary on April 2
nd
, 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Such appearing parties representing the whole corporate capital of the Company, the general meeting of partners is
regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to increase the share capital of the Company.
2. Decision to create two classes of managers to be named A Manager and B Manager and change the signing power
of the Company.
3. Restatement of the articles of association of the Company.
The appearing persons representing the whole corporate capital require the notary to enact the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders of the Company resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred
and forty-four thousand six hundred and seventy-five euro (EUR 244,675) in order to raise it from its current amount of
seven hundred and forty-nine thousand seventeen euro and fifty cent (EUR 749,017.50) up to nine hundred and ninety-
three thousand six hundred and ninety-two euro and fifty cents (EUR 993,692.50), through the issue of twenty-four million
four hundred and sixty-seven thousand five hundred (24,467,500) shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each.
The Shareholders resolve to allocate the newly issued twenty-four million four hundred and sixty-seven thousand five
hundred (24,467,500) shares to the share classes as follows:
(a) two million four hundred and forty-six thousand seven hundred and fifty (2,446,750) shares allocated to the Class
A Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(b) two million four hundred and forty-six thousand seven hundred and fifty (2,446,750) shares allocated to the Class
B Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(c) two million four hundred and forty-six thousand seven hundred and fifty (2,446,750) shares allocated to the Class
C Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(d) two million four hundred and forty-six thousand seven hundred and fifty (2,446,750) shares allocated to the Class
D Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(e) two million four hundred and forty-six thousand seven hundred and fifty (2,446,750) shares allocated to the Class
E Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(f) two million four hundred and forty-six thousand seven hundred and fifty (2,446,750) shares allocated to the Class
F Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(g) two million four hundred and forty-six thousand seven hundred and fifty (2,446,750) shares allocated to the Class
G Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(h) two million four hundred and forty-six thousand seven hundred and fifty (2,446,750) shares allocated to the Class
H Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(i) two million four hundred and forty-six thousand seven hundred and fifty (2,446,750) shares allocated to the Class
I Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each; and
(j) two million four hundred and forty-six thousand seven hundred and fifty (2,446,750) shares allocated to the Class
J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon,
1) Perpetual Management Investment I L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership having its registered office
at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-71178,
72113
L
U X E M B O U R G
represented by its general partner Perpetual Management Investments Manager Ltd, a limited company incorporated
under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman
KY1-9005, Cayman Islands,
here represented by Mrs Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal,
declares to subscribe for
(a) one million two hundred thousand (1,200,000) Class A Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(b) one million two hundred thousand (1,200,000) Class B Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(c) one million two hundred thousand (1,200,000) Class C Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(d) one million two hundred thousand (1,200,000) Class D Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(e) one million two hundred thousand (1,200,000) Class E Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(f) one million two hundred thousand (1,200,000) Class F Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(g) one million two hundred thousand (1,200,000) Class G Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(h) one million two hundred thousand (1,200,000) Class H Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;
(i) one million two hundred thousand (1,200,000) Class I Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each; and
(j) one million two hundred thousand (1,200,000) Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each,
and to pay them up by a contribution in kind consisting of a claim that the subscriber holds against Blackstone Perpetual
Bidco B.V. in an amount of one million two hundred thousand euro (EUR 1,200,000). The total contribution of one million
two hundred thousand euro (EUR 1,200,000) is allocated as follows:
- one hundred and twenty thousand euros (EUR 120,000) to the share capital of the Company; and
- one million eighty thousand euro (EUR 1,080,000) to the share premium account of the Company.
2) Perpetual Management Investment II L.P., prenamed,
declares to subscribe for:
(a) five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty (528,250) Class A Shares with a par value of one
cent (EUR 0.01) each;
(b) five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty (528,250) Class B Shares with a par value of one
cent (EUR 0.01) each;
(c) five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty (528,250) Class C Shares with a par value of one
cent (EUR 0.01) each;
(d) five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty (528,250) Class D Shares with a par value of one
cent (EUR 0.01) each;
(e) five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty (528,250) Class E Shares with a par value of one
cent (EUR 0.01) each;
(f) five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty (528,250) Class F Shares with a par value of one cent
(EUR 0.01) each;
(g) five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty (528,250) Class G Shares with a par value of one
cent (EUR 0.01) each;
(h) five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty (528,250) Class H Shares with a par value of one
cent (EUR 0.01) each;
(i) five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty (528,250) Class I Shares with a par value of one cent
(EUR 0.01) each; and
(j) five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty (528,250) Class J Shares with a par value of one cent
(EUR 0.01) each,
and to pay them up by a contribution in kind consisting of a claim that the subscriber holds against Blackstone Perpetual
Bidco B.V. in an amount of five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty euro (EUR 528,250). The total
contribution of five hundred and twenty-eight thousand two hundred and fifty euro (EUR 528,250) is allocated as follows:
- fifty-two thousand eight hundred and twenty-five euro (EUR 52,825) to the share capital of the Company; and
- four hundred and seventy-five thousand four hundred and twenty-five euro (EUR 475,425) to the share premium
account of the Company.
3) Stichting Administratiekantoor Perpetual, prenamed, declares to subscribe for:
(a) seven hundred and eighteen thousand five hundred (718,500) Class A Shares with a par value of one cent (EUR
0.01) each;
(b) seven hundred and eighteen thousand five hundred (718,500) Class B Shares with a par value of one cent (EUR
0.01) each;
(c) seven hundred and eighteen thousand five hundred (718,500) Class C Shares with a par value of one cent (EUR
0.01) each;
72114
L
U X E M B O U R G
(d) seven hundred and eighteen thousand five hundred (718,500) Class D Shares with a par value of one cent (EUR
0.01) each;
(e) seven hundred and eighteen thousand five hundred (718,500) Class E Shares with a par value of one cent (EUR
0.01) each;
(f) seven hundred and eighteen thousand five hundred (718,500) Class F Shares with a par value of one cent (EUR
0.01) each;
(g) seven hundred and eighteen thousand five hundred (718,500) Class G Shares with a par value of one cent (EUR
0.01) each;
(h) seven hundred and eighteen thousand five hundred (718,500) Class H Shares with a par value of one cent (EUR
0.01) each;
(i) seven hundred and eighteen thousand five hundred (718,500) Class I Shares with a par value of one cent (EUR 0.01)
each; and
(j) seven hundred and eighteen thousand five hundred (718,500) Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01)
each,
and to pay them up by a contribution in kind consisting of a claim that the subscriber holds against Blackstone Perpetual
Bidco B.V. in an amount of seven hundred and eighteen thousand five hundred euro (EUR 718,500). The total contribution
of seven hundred and eighteen thousand five hundred euro (EUR 718,500) is allocated as follows:
- seventy-one thousand eight hundred and fifty euro (EUR 71,850) to the share capital of the Company; and
- six hundred and forty-six thousand six hundred and fifty euro (EUR 646,650) to the share premium account of the
Company.
The above proxies, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proof of the existence of the above contributions has been produced to the undersigned notary. The existence,
value and transferability of the contributed claims have been proved to the undersigned notary.
Following the above, Perpetual Management Investment I L.P., prenamed, enters the meeting to resolve with the other
shareholders on the subsequent items of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The shareholders of the Company resolve to create two classes of managers to be named A Manager and B Manager
and to provide that the Company will be bound in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, (ii) if the
Company has several managers, by the sole signature of one (1) A manager, or (iii) by the joint signatures or the sole
signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers.
<i>Third resolutioni>
Inter alia as a consequence of the above resolutions, the shareholders of the Company resolve to fully restate the
articles of association of the Company, which shall now read as follows:
"A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Blackstone
Perpetual Topco S.à r.l. which shall be governed by the Law, as well as by the present Articles and the Agreement.
Capitalized terms used herein have the meanings set out in Article 29.
Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, public offering, exchange or otherwise.
2.2. The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3. The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful in accomplishment of these purposes.
2.5. The Company may also act as partner/shareholder of any Luxembourg or foreign entity(-ies) with unlimited or
limited liability for the debts and obligations of such entity(-ies).
Art. 3. Duration.
3.1. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
72115
L
U X E M B O U R G
3.2. It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of Shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these Articles.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the Board. It may be trans-
ferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the Shareholders, adopted in the
manner required for an amendment of these Articles.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the Board.
4.4 In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural
disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary
circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at nine hundred and ninety-three thousand six hundred and ninety-two euros
and fifty cents (EUR 993,692.50) represented by
- nine million nine hundred and thirty-six thousand nine hundred and twenty-five (9,936,925) Class A Shares,
- nine million nine hundred and thirty-six thousand nine hundred and twenty-five (9,936,925) Class B Shares,
- nine million nine hundred and thirty-six thousand nine hundred and twenty-five (9,936,925) Class C Shares,
- nine million nine hundred and thirty-six thousand nine hundred and twenty-five (9,936,925) Class D Shares,
- nine million nine hundred and thirty-six thousand nine hundred and twenty-five (9,936,925) Class E Shares,
- nine million nine hundred and thirty-six thousand nine hundred and twenty-five (9,936,925) Class F Shares,
- nine million nine hundred and thirty-six thousand nine hundred and twenty-five (9,936,925) Class G Shares,
- nine million nine hundred and thirty-six thousand nine hundred and twenty-five (9,936,925) Class H Shares,
- nine million nine hundred and thirty-six thousand nine hundred and twenty-five (9,936,925) Class I Shares and
- nine million nine hundred and thirty-six thousand nine hundred and twenty-five (9,936,925) Class J Shares,
each Share with a nominal value of one cent (EUR 0.01) and with such rights and obligations as set out in the present
Articles.
Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these Articles. The share capital of the Company may be reduced
through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire classes of Shares through the
repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class(es), provided that redemptions of Shares will be effected
first by the redemption of the Class J Shares, then Class I Shares, then Class H Shares, then Class G Shares, then Class
F Shares, then Class E Shares, then Class D Shares, then Class C Shares, then Class B Shares, then Class A Shares, in each
case on a pari passu basis, until, in each case, all Shares of such class have been redeemed in full, it being understood that
under no circumstances can the redemptions result in the share capital of the Company falling below the minimum amount
required by law.
5.3 The Company may redeem its own Shares subject to the provisions of the Law and the Agreement. The amount
payable with respect to a Class of Shares on a redemption shall in the case of redemption on an Liquidity Event, correspond
to the amount that such Class of Shares is entitled to receive on such Liquidity Event in accordance with Article 24.2 and
Article 26 and the Agreement. When Shares are to be redeemed in accordance with the terms hereof and the provisions
of the Agreement, the Company may call for redemption, in whole or in part, of the relevant Shares by notice sent by
registered mail at the address of the relevant Shareholder which appears in the register of Shareholders of the Company
mentioning (i) the date of the redemption, (ii) the number of Shares called for redemption, (iii) the redemption price and
(iv) the method of payment of the redemption price. Shares redeemed by the Company shall subsequently be cancelled.
5.4 In addition to the share capital, a premium account may be set up into which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. In accordance with and subject to Luxembourg law, these Articles and the
Agreement, an amount of the premium account may, inter alia, be used for the purpose of the repurchase of any class of
shares as per articles 5.2 and 5.3 of these Articles, to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder
or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
72116
L
U X E M B O U R G
6.3 The Company may have one or several Shareholders, with a maximum number of Shareholders not exceeding
forty (40).
6.4 The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any
of the Shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office, where it shall be available for inspection by any Share-
holder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued
upon request and at the expense of the relevant Shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as representative in relation to the
Company.
C. Management
Art. 8. Powers of the sole manager; composition and powers of the Board.
8.1 The Company is managed by one or several managers, who do not need to be Shareholders. If the Company is
managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in
these Articles, a reference to the "Board" used in these Articles is to be construed as a reference to the "sole manager".
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least one (1) A
manager and one (1) B manager.
8.2 The Board is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary
or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these
Articles to the general meeting of Shareholders.
Art. 9. Election, removal and term of office of managers.
9.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of Shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
9.2 The managers are elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a vote of the
Shareholders in accordance with the provisions of the Law.
Art. 10. Committees of the Board. The Board may establish committees as approved by the Board, the authority of
each to be determined from time to time by the Board.
Art. 11. Convening meetings of the Board.
11.1 The board of managers shall meet upon call by any manager, including its chairman, at the place indicated in the
notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company, unless
otherwise indicated in the notice of meeting.
11.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers, either personally, by mail,
by electronic mail or by any other similar means of communication, five (5) Business Days at least in advance of the date
scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency
must be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile,
electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof
thereof, or will be deemed waived by any manager who is present at a meeting and does not protest the lack of a notice.
No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers.
11.3 No prior notice shall be required in case all the members of the Board are present or represented at such meeting,
or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the Board.
Art. 12. Quorum and Acts of the Board.
12.1 The Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at
a meeting of the Board, among which at least one (1) A manager and one (1) B manager must be present or represented.
12.2 If a quorum shall not be present at any meeting of the Board (or any committee thereof) the managers present
thereat may adjourn the meeting from time to time until a quorum shall be present.
Art. 13. Conduct of meetings of the Board.
13.1 The Board may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be
a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board.
13.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the Board, but in his absence, the Board may appoint another
manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
72117
L
U X E M B O U R G
13.3 Any manager may act at any meeting of the Board by appointing another manager as his proxy in writing, or by
facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof
thereof. A manager may represent one or more, but not all of his colleagues.
13.4 Meetings of the Board may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication
means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an
effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
13.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at a meeting provided that
at least an A manager and a B manager vote in favour of a resolution. The chairman, if any, shall not have a casting vote.
13.6 The Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by
facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately,
the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of
the last signature.
Art. 14. Minutes of the meeting of the Board; Minutes of the decisions of the sole manager.
14.1 The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman, if any, or, in his absence, by the chairman
pro tempore. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be
signed by the chairman, if any, or by any manager.
14.2 The decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies
or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole
manager.
Art. 15. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, (ii) if the Company has several managers, by the sole signature of one (1) A manager,
or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been
delegated by the Board.
D. Decisions of the shareholders
Art. 16. Collective decisions of the Shareholders. Each Shareholder may participate in collective decisions irrespective
of the number of Shares which he owns. Each Shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents Shares.
Art. 17. Powers of the general meeting of Shareholders; written Shareholders' resolutions.
17.1 In case the Company has more than twenty-five (25) Shareholders on such date, an annual general meeting of
Shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office
of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting. Other
meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of
meeting.
17.2 The general meeting of Shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
Articles. Save a higher majority as provided herein, collective decisions of the Company's Shareholders are only validly
taken in so far as they are adopted by Shareholders owning more than half of the share capital.
17.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25), collective decisions otherwise conferred
on the general meeting of Shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each Share-
holder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.
Such written resolutions are only validly taken in accordance with the Law in so far as such written resolutions are
approved by Shareholders owning more than half of the share capital.
Art. 18. Change of nationality. The Shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by
unanimous consent.
Art. 19. Amendments of the Articles. Any amendment of the Articles requires the approval of (i) a majority of Sha-
reholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 20. Powers of the sole Shareholder. In the case of a sole Shareholder, such Shareholder exercises the powers
granted to the general meeting of Shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of Shareholders" shall be construed as a reference to the sole Shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of Shareholders shall be exercised by
the sole Shareholder.
E. Pre-emptive rights - Transfer of shares
Art. 21. Pre-emptive Rights - General. If it is proposed that the Company issues any New Securities to, or enters into
any contracts, commitments, agreements, understandings or arrangements of any kind relating to the issuance of any
New Securities with, any person (other than any member of the Group), each Shareholder shall be entitled to subscribe
for any number of such New Securities in accordance with the procedure and subject to the exceptions set out in the
72118
L
U X E M B O U R G
Agreement. For the avoidance of doubt and in compliance with the provisions of the Law, the Company shall under no
circumstances issue shares, bonds or other securities to the public.
Art. 22. Transfer of Shares.
22.1 The Shares are only transferable among Shareholders in accordance with the transfer procedure set out in the
Agreement.
22.2 Inter vivos, they may only be transferred to new Shareholders subject to the approval of such transfer given by
the Shareholders, at a majority of three quarters of the share capital. The Company will only recognize a transferee of
Shares in the Company as the owner of such Shares and such transferee may only exercise the rights attached to such
Shares, if such transfer is in compliance with and if the transferee has expressly agreed to be bound by the Agreement.
22.3 Any transfer of Shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg
civil code.
22.4 In the event of death, the Shares of the deceased Shareholder may only be transferred to new Shareholders
subject to the approval of such transfer given by the other Shareholders at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents, to his wife/husband
or any other legal heir of the deceased Shareholder.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 23. Financial year. The financial year of the Company shall begin on first January of each year and shall end on
thirty-first December of the same year.
Art. 24. Annual accounts and allocation of profits.
24.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board draws up an inventory of the Company's
assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
24.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
In any year in which the Company resolves to make distributions, drawn from net profits and from available reserves
derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distributed in
the following order of priority:
- First, the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,
- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,
- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,
- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,
- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then,
- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then
- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then
- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then
- the holders of Class I Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the Class I Shares, and then,
- the holders of Class J Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding Class of Shares (by alphabetical order, e.g., initially the Class J Shares) have been
repurchased and cancelled in accordance with Article 5.2 at the time of the distribution, the remainder of any dividend
distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding Class of Shares in the reverse alphabetical order
(e.g., initially the Class I Shares).
24.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a Shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing Shareholder agrees with such allocation.
24.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
72119
L
U X E M B O U R G
24.5 Upon recommendation of the Board, the general meeting of Shareholders shall determine how the remainder of
the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law, these Articles and the Agreement.
Art. 25. Interim dividends - Share premium.
25.1 The Board may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the Board
showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits
since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by
losses carried forward and sums to be allocated to an reserve which the law or these Articles do not allow to be
distributed.
25.2 Any share premium or other distributable reserve may be freely distributed to the Shareholders subject to the
foregoing provisions.
Art. 26. Distributions upon a Liquidity Event. Distributions of all amounts to be paid on the Shares upon a Liquidity
Event shall be made to the holders of Shares on a per Share basis, in accordance with their entitlements under these
Articles and the Agreement, by way of capital redemption in accordance with and subject to Article 5.2.
F. Supervision of the Company
Art. 27. Auditor(s).
27.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of Shareholders shall
appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.
27.2 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general
meeting of Shareholders.
27.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
27.4 If the Shareholders of the Company appoint one or more independent auditor'(s) (reviseur(s) d'entreprises agree
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
27.5 Any independent auditor may only be removed with cause or with its approval by the general meeting of Share-
holders.
G. Liquidation
Art. 28 Liquidation.
28.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who
are appointed by the general meeting of Shareholders, deciding such dissolution and which shall determine their powers
and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the reali-
sation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
28.2 Unless otherwise provided in these Articles, the surplus resulting from the realisation of the assets and the
payment of the liabilities shall be distributed among the Shareholders in proportion to the number of Shares of the
Company held by them.
H. Definitions - Governing law
Art. 29. Definitions. When used in the present Articles, the following terms have the following meanings:
"Affiliate" shall mean, with respect to any person, another person Controlled directly or indirectly by such first person,
Controlling directly or indirectly such first person or directly or indirectly under the same Control as such first person,
and "Affiliated" shall have a meaning correlative to the foregoing;
"Agreement" shall mean any subscription and shareholders' agreement as may be entered into between, amongst
others, the Shareholders of the Company from time to time, as it may be amended, restated, supplemented or otherwise
modified from time to time;
"Articles" shall mean the present articles of association of the Company, as the same may be amended, restated,
modified or supplemented from time to time;
"Bidco" shall mean Blackstone Perpetual Bidco B.V., a private limited liability company (Besloten Vennootschap), or-
ganised under the laws of the Netherlands, with its registered office at Naritaweg 165, Telestone 8, Teleport 1043BW
Amsterdam, the Netherlands
"Blackstone" shall mean the Blackstone Funds and, as the context may permit, includes any Permitted Transferees to
which Interests may have been transferred in accordance with the Agreement from time to time;
"Blackstone Funds" shall mean Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P., Blackstone Capital Partners (Cay-
man) VI IT-B L.P., Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P., Blackstone Family Investment Partnership (Cayman)
VI L.P. and Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI-ESC L.P.;
"Board" shall mean the board of managers of the Company as constituted from time to time;
72120
L
U X E M B O U R G
"Business Day" shall mean a day on which banks are open for business in London, Amsterdam and Luxembourg (which,
for avoidance of doubt, shall not include Saturdays, Sundays and public holidays in London, Amsterdam and Luxembourg);
"Class A Shares" shall mean the A ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;
"Class B Shares" shall mean the B ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;
"Class C Shares" shall mean the C ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;
"Class D Shares" shall mean the D ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;
"Class E Shares" shall mean the E ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;
"Class F Shares" shall mean the F ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;
"Class G Shares" shall mean the G ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;
"Class H Shares" shall mean the H ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;
"Class I Shares" shall mean the I ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;
"Class J Shares" shall mean the J ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;
"Company" shall mean Blackstone Perpetual Topco S.à r.l.;
"Company Subsidiary" shall mean, for so long as it is a direct or indirect subsidiary of the Company, (a) Midco; (b)
Holdco; (c) Investmentco; (d) Bidco and (e) each other direct or indirect subsidiary of the Company from time to time;
"Control" shall mean with respect to a person (other than an individual) (a) direct or indirect ownership of more than
50% of the voting securities of such person, (b) the right to appoint, or cause the appointment of, more than 50% of the
members of the board of directors (or similar governing body) of such person or (c) the right to manage, or direct the
management of, on a discretionary basis, the assets of such person, and, for avoidance of doubt, a general partner is
deemed to Control a limited partnership and, solely for the purposes of the Agreement, a fund advised or managed
directly or indirectly by a person shall also be deemed to be Controlled by such person (and the terms "Controlling" and
"Controlled" shall have meanings correlative to the foregoing);
"Exit" shall mean:
(a) a Listing that results in Blackstone ceasing to hold, directly or indirectly, more than 50% of the Listed Shares;
(b) a sale of Interests or shares in the Company, or any Company Subsidiary that directly or through other Company
Subsidiaries owns all or substantially all of the business (being more than 50% of the assets, or revenue or earnings
generating capacity) of the Group and, in any such case, that results in the acquirer or acquirers (other than an Affiliate
of Blackstone) holding, in aggregate, more than 50% of the Shares or the shares in the Company or such Company
Subsidiary, as applicable;
(c) a sale of any Interests which gives rise to tag-along rights or a drag-along right under the Agreement; or
(d) the disposal by one or more transactions of all or substantially all of the business (being more than 50% of the
assets, or revenue or earnings generating capacity) of the Group;
in each case, at the time the consideration from such transaction is received in cash by the seller or disposing party,
provided that, in the case of such a transaction involving non-cash consideration, an Exit shall have been deemed to have
taken place when such portion of such non-cash consideration as would have constituted an "Exit" if the consideration
had originally been paid in cash has been disposed of for cash;
"Group" shall mean the Company and its direct and indirect subsidiaries from time to time;
"Holdco" shall mean Blackstone Perpetual Holdco B.V., a private limited liability company (Besloten Vennootschap),
organised under the laws of the Netherlands, with its registered office at Naritaweg 165, Telestone 8, Teleport 1043BW
Amsterdam, the Netherlands;
"Interests" shall mean the Shares or PECs, or all of them, as the context may require;
"Investmentco" shall mean Blackstone Perpetual Investmentco B.V., a private limited liability company (Besloten Ven-
nootschap), organised under the laws of the Netherlands, with its registered office at Naritaweg 165, Telestone 8,
Teleport 1043BW Amsterdam, the Netherlands;
"Law" shall mean the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended;
"Liquidity Event" shall mean an Exit or a Recapitalisation;
"Listed Shares" shall mean the (class of) shares to be listed pursuant to a Listing and, for the avoidance of doubt, to
the extent any share or shares of a class of shares is admitted to trading on recognised stock exchange, the entire class
of such shares shall be deemed to be Listed Shares;
"Listing" shall mean the admission to listing of a class of shares of the Company, any Company Subsidiary or, if applicable,
any Parent, as determined by the board of directors/board of managers of such entity;
"Midco" shall mean Blackstone Perpetual Midco S.à r.l., à société à responsabilité limité organised under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 173 039;
"New Securities" shall mean any shares, preferred equity securities or options, warrants or other securities or rights
convertible or exchangeable into or exercisable for shares or common equity equivalents, including Shares and PECs as
well as any convertible or non-convertible shareholder debt instruments;
72121
L
U X E M B O U R G
"Parent" shall mean a person that Controls, directly or indirectly, the Group from time to time and does not own
material assets or businesses that are not related to the business of the Group;
"PECs" shall mean each class or series of preferred equity certificates of the Company;
"Permitted Transferee" shall mean, in relation to Blackstone, (i) any Affiliate of or successor entity of Blackstone (not
being a third party transferee), (ii) any investment fund or funds, or any Affiliate of any such investment fund or funds,
advised by an adviser or sub-adviser of Blackstone or its Affiliates, any successor thereof, any adviser, sub-adviser thereof
or Affiliate of any of the foregoing;
"Recapitalisation" shall mean any alteration to the equity and/or debt structure of the Group for the purpose of enabling
cash to be returned to the holders of Interests;
"Shareholder" or "Shareholders" shall mean any holder or holders of Interests, provided that and as long as it or they
hold shares in the Company;
"Shares" shall mean the Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares,
Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, and Class J Shares;
Art. 30 Governing Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law
and the Agreement."
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to three thousand five hundred euro (EUR 3,500).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendunddreizehn, den zweiten April.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Martine SCHAEFFER, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum
Luxembourg.
SIND ERSCHIENEN:
1) Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI - ESC L.P., eine limited partnership existierend unter dem
Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman
KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer
WK-47430,
hier rechtmäßig vertreten durch Frau Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß
privatschriftlicher Vollmacht;
2) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P. eine exempted limited partnership gegründet unter dem Recht
der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin
Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Part-
nerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-68503,
hier rechtmäßig vertreten durch Frau Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß
privatschriftlicher Vollmacht;
3) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-B L.P. eine exempted limited partnership gegründet unter dem Recht
der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin
Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Part-
nerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-68509,
hier rechtmäßig vertreten durch Frau Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß
privatschriftlicher Vollmacht;
4) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P. eine exempted limited partnership gegründet unter dem Recht
der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin
Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Part-
nerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-68506,
hier rechtmäßig vertreten durch Frau Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß
privatschriftlicher Vollmacht;
5) Perpetual Management Investment II L.P., eine limited partnership existierend unter dem Recht der Cayman Inseln,
mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Georgetown,
72122
L
U X E M B O U R G
Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Limited Partnerships, Cayman Islands unter der
Nummer WK-71186, vertreten durch den Komplementär Perpetual Management Investments Manager Ltd., eine limited
company gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in 190 Elgin Avenue,
Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln
hier rechtmäßig vertreten durch Frau Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß
privatschriftlicher Vollmacht;
6) Stichting Administratiekantoor Perpetual, eine Stichting organisiert unter dem Recht der Niederlande, mit einge-
tragener Geschäftsanschrift in Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, eingetragen im Handelsregister der
Niederlande Netherlands Chamber of Commerce unter Nummer 57360405, hier rechtmäßig vertreten durch Frau Jo-
hanna WITTEK, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
Diese Vollmachten bleiben nach Zeichnung "ne varietur" durch den unterzeichnenden Notar und durch die für die
Erschienenen Bevollmächtigte der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die erschienenen Parteien sind alle die Gesellschafter (die „Gesellschafter") der Blackstone Perpetual Topeo S.à r.l.,
(nachstehend, die "Gesellschaft") eine société à responsabilité limitée gegründet in Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister
unter Nummer B 173.008, wirksam gegründet am 22. November 2012 gemäß notarieller Urkunde von Maître Henri
HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 21
am 4 Januar 2013 veröffentlicht. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal geändert gemäß notarieller Urkunde
der unterzeichnenden Notarin vom 2. April 2013 noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ver-
öffentlicht.
Die erschienenen Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft repräsentieren, können in gültiger
Weise über die folgende Tagesordnungspunkte beraten:
<i>Agendai>
1. Entscheidung über die Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft.
2. Entscheidung zwei Klassen an Geschäftsführern zu schaffen, die A Manager und B Manager genannt werden und die
Zeichnungsvollmacht zu ändern.
3. Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft.
Die erschienenen Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft repräsentieren, ersuchen den Notar,
die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter der Gesellschaft beschließen das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von
zweihundert vierundvierzig tausend sechshundert fünfundsiebzig Euro (EUR 244.675) zu erhöhen, um es von seinem
gegenwärtigen Betrag von siebenhundert neunundvierzig tausend siebzehn Euro und fünfzig Cent (EUR 749.017,50) auf
einen Betrag von neunhundert dreiundneunzig tausend sechshundert zweiundneunzig Euro und fünfzig Cent (EUR
993.692,50) durch die Ausgabe von vierundzwanzig Millionen vierhundert siebenundsechzig tausend fünfhundert
(24.467.500) Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), anzuheben.
Der alleinige Gesellschafter beschließt, die neu ausgegebenen vierundzwanzig Millionen vierhundert siebenundsechzig
tausend fünfhundert (24.467.500) Anteile den Anteilsklassen wie folgt zuzuordnen:
(a) zwei Millionen vierhundert sechsundvierzig tausend siebenhundert fünfzig (2.446.750) Anteile, den Klasse A Anteilen
zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(b) zwei Millionen vierhundert sechsundvierzig tausend siebenhundert fünfzig (2.446.750) Anteile, den Klasse B Anteilen
zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(c) zwei Millionen vierhundert sechsundvierzig tausend siebenhundert fünfzig (2.446.750) Anteile, den Klasse C An-
teilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(d) zwei Millionen vierhundert sechsundvierzig tausend siebenhundert fünfzig (2.446.750) Anteile, den Klasse D An-
teilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(e) zwei Millionen vierhundert sechsundvierzig tausend siebenhundert fünfzig (2.446.750) Anteile, den Klasse E Anteilen
zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(f) zwei Millionen vierhundert sechsundvierzig tausend siebenhundert fünfzig (2.446.750) Anteile, den Klasse F Anteilen
zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(g) zwei Millionen vierhundert sechsundvierzig tausend siebenhundert fünfzig (2.446.750) Anteile, den Klasse G An-
teilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(h) zwei Millionen vierhundert sechsundvierzig tausend siebenhundert fünfzig (2.446.750) Anteile, den Klasse H An-
teilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(i) zwei Millionen vierhundert sechsundvierzig tausend siebenhundert fünfzig (2.446.750) Anteile, den Klasse I Anteilen
zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01); und
72123
L
U X E M B O U R G
(j) zwei Millionen vierhundert sechsundvierzig tausend siebenhundert fünfzig (2.446.750) Anteile, den Klasse J Anteilen
zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01).
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Darauf erklären:
1) Perpetual Management Investment I L.P., eine exempted limited partnership existierend unter dem Recht der Cay-
man Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue,
Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships,
Cayman Islands unter der Nummer WK-71178,vertreten durch den Komplementär Perpetual Management Investments
Manager Ltd., eine limited company gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift
in 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln,
hier rechtmäßig vertreten durch Frau Johanna WITTEK, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß
privatschriftlicher Vollmacht,
(a) eine Million zweihundert tausend (1.200.000) Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent
(EUR 0,01);
(b) eine Million zweihundert tausend (1.200.000) Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent
(EUR 0,01);
(c) eine Million zweihundert tausend (1.200.000) Klasse C Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent
(EUR 0,01);
(d) eine Million zweihundert tausend (1.200.000) Klasse D Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent
(EUR 0,01);
(e) eine Million zweihundert tausend (1.200.000) Klasse E Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent
(EUR 0,01);
(f) eine Million zweihundert tausend (1.200.000) Klasse F Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR
0,01);
(g) eine Million zweihundert tausend (1.200.000) Klasse G Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent
(EUR 0,01);
(h) eine Million zweihundert tausend (1.200.000) Klasse H Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent
(EUR 0,01);
(i) eine Million zweihundert tausend (1.200.000) Klasse I Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR
0,01); und
(j) eine Million zweihundert tausend (1.200.000) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR
0,01);
zu zeichnen und deren Gegenwert im Wege einer Sacheinlage bestehend aus einer Forderung der Zeichnenden gegen
Blackstone Perpetual Bidco B.V. im Wert von einer Million zweihundert tausend Euro (EUR 1.200.000), zu bezahlen. Der
Gesamtwert der Einlage von einer Million zweihundert tausend Euro (EUR 1.200.000) soll wie folgt zugeteilt werden:
- einhundert zwanzig tausend Euro (EUR 120.000) dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft; und
- eine Million achtzig tausend Euro (EUR 1.080.000) dem Agio der Gesellschaft.
2) Perpetual Management Investment II L.P., vorbenannt,
(a) fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig (528.250) Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von
jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(b) fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig (528.250) Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von
jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(c) fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig (528.250) Klasse C Anteile mit einem Nominalwert von
jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(d) fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig (528.250) Klasse D Anteile mit einem Nominalwert von
jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(e) fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig (528.250) Klasse E Anteile mit einem Nominalwert von
jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(f) fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig (528.250) Klasse F Anteile mit einem Nominalwert von
jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(g) fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig (528.250) Klasse G Anteile mit einem Nominalwert von
jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(h) fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig (528.250) Klasse H Anteile mit einem Nominalwert von
jeweils einem Cent (EUR 0,01);
(i) fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig (528.250) Klasse I Anteile mit einem Nominalwert von
jeweils einem Cent (EUR 0,01); und
72124
L
U X E M B O U R G
(j) fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig (528.250) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von
jeweils einem Cent (EUR 0,01);
zu zeichnen und deren Gegenwert im Wege einer Sacheinlage bestehend aus einer Forderung der Zeichnenden gegen
Blackstone Perpetual Bidco B.V. im Wert von fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig Euro (EUR
528.250), zu bezahlen. Der Gesamtwert der Einlage von fünfhundert achtundzwanzig tausend zweihundert fünfzig Euro
(EUR 528.250) soll wie folgt zugeteilt werden:
- zweiundfünfzig tausend achthundert fünfundzwanzig Euro (EUR 52.825) dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft;
und
- vierhundert fünfundsiebzig tausend vierhundert fünfundzwanzig Euro (EUR 475.425) dem Agio der Gesellschaft.
3) Stichting Administratiekantoor Perpetual, vorbenannt,
(a) siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert (718.500) Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Cent (EUR 0,01);
(b) siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert (718.500) Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Cent (EUR 0,01);
(c) siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert (718.500) Klasse C Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Cent (EUR 0,01);
(d) siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert (718.500) Klasse D Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Cent (EUR 0,01);
(e) siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert (718.500) Klasse E Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Cent (EUR 0,01);
(f) siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert (718.500) Klasse F Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Cent (EUR 0,01);
(g) siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert (718.500) Klasse G Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Cent (EUR 0,01);
(h) siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert (718.500) Klasse H Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Cent (EUR 0,01);
(i) siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert (718.500) Klasse I Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Cent (EUR 0,01); und
(j) siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert (718.500) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Cent (EUR 0,01);
zu zeichnen und deren Gegenwert im Wege einer Sacheinlage bestehend aus einer Forderung der Zeichnenden gegen
Blackstone Perpetual Bidco B.V. im Wert von siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert Euro (EUR 718.500), zu
bezahlen. Der Gesamtwert der Einlage von siebenhundert achtzehn tausend fünfhundert Euro (EUR 718.500) soll wie
folgt zugeteilt werden:
- einundsiebzig tausend achthundert fünfzig Euro (EUR 71.850) dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft; und
- sechshundert sechsundvierzig tausend sechshundert fünfzig Euro (EUR 646.650) dem Agio der Gesellschaft.
Die obigen Vollmachten bleiben nach Zeichnung "ne varietur" durch den unterzeichnenden Notar und durch die für
die Erschienenen Bevollmächtigte der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Nachweis über die Existenz der oben genannten Einlagen wurde dem Notar erbracht. der Nachweis über die Existenz,
den Wert und die Übertragbarkeit der eingebrachten Forderung wurde dem unterzeichneten Notar erbracht.
Folgend dem oben Genannten, tritt Perpetual Management Investment I L.P., vorbenannt, in die Sitzung ein um ge-
meinsam mit den anderen Gesellschaftern der Gesellschaft die nachfolgenden Tagesordnungspunkte zu beschließen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter der Gesellschaft beschließen zwei Managerklassen zu schaffen, die A Manager und B Manager ge-
nannt werden sollen und vorzusehen, dass die Gesellschaft unter allen Umständen (i) durch die Unterschrift des
Einzelgeschäftsführers oder, (ii) für den Fall, dass die Gesellschaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, durch die ein-
zelne Unterschrift eines (1) A Geschäftsführers, oder (iii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unter-
schrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden
ist, gebunden ist.
<i>Dritter Beschlussi>
Als Konsequenz der obenstehenden Beschlüsse, beschließen die Gesellschafter der Gesellschaft die Satzung der Ge-
sellschaft umzuformulieren, so dass sie fortan wie folgt lautet:
"A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Firmenname. Nunmehr besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
unter dem Firmennamen Blackstone Perpetual Topco S.à r.l. nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes, dieser
72125
L
U X E M B O U R G
Satzung und der Vereinbarung. Definierte Begriffe, die hierin verwendet werden, haben die Bedeutung wie in Artikel 29
dargelegt.
Art. 2. Zweck.
2.1 Gesellschaftszweck ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
sonstigen Vermögensanlagen in jeder Form; der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, ein öffentliches Angebot, Tausch
oder auf sonstige Art.
2.2 Die Gesellschaft kann weiter für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Recht
jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten
einräumen, Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, Finanzmittel beschaffen, insbesondere Auf-
nahme von Darlehen oder Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen,
Obligationen und generell jede Form von Schuldscheinen.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie im
Zusammenhang mit gewerblichem Rechtsschutz oder Grundbesitz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.
2.5 Die Gesellschaft kann ebenfalls als Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden oder
Verpflichtungen von luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen handeln.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher
in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Er kann durch Beschluss der Generalversammlung, welcher in der für eine Änderung dieser Satzung erforderli-
chen Form gefasst wird, in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunhundert dreiundneunzig tausend sechshundert zweiund-
neunzig Euro und fünfzig Cent (EUR 993.692,50), aufgeteilt in
- neun Millionen neunhundert sechsunddreißig tausend neunhundert fünfundzwanzig (9.936.925) Klasse A Anteile,
- neun Millionen neunhundert sechsunddreißig tausend neunhundert fünfundzwanzig (9.936.925) Klasse B Anteile,
- neun Millionen neunhundert sechsunddreißig tausend neunhundert fünfundzwanzig (9.936.925) Klasse C Anteile,
- neun Millionen neunhundert sechsunddreißig tausend neunhundert fünfundzwanzig (9.936.925) Klasse D Anteile,
- neun Millionen neunhundert sechsunddreißig tausend neunhundert fünfundzwanzig (9.936.925) Klasse E Anteile,
- neun Millionen neunhundert sechsunddreißig tausend neunhundert fünfundzwanzig (9.936.925) Klasse F Anteile,
- neun Millionen neunhundert sechsunddreißig tausend neunhundert fünfundzwanzig (9.936.925) Klasse G Anteile,
- neun Millionen neunhundert sechsunddreißig tausend neunhundert fünfundzwanzig (9.936.925) Klasse H Anteile,
- neun Millionen neunhundert sechsunddreißig tausend neunhundert fünfundzwanzig (9.936.925) Klasse I Anteile, und
- neun Millionen neunhundert sechsunddreißig tausend neunhundert fünfundzwanzig (9.936.925) Klasse J Anteile,
mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) pro Anteil und mit solchen Rechten und Verpflichtungen,
wie in dieser Satzung dargelegt.
Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme an ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.
5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung, welcher in der für
eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden. Das Gesellschafts-
72126
L
U X E M B O U R G
kapital der Gesellschaft kann durch die Einziehung von Anteilen einschließlich der Einziehung durch Rückkauf von einer
oder mehreren gesamten Klassen von Anteilen und die Einziehung von allen ausgegebenen Anteilen in einer solchen Klasse
herabgesetzt werden, vorausgesetzt, dass Rückkäufe von Anteilen zuerst durch den Rückkauf von Klasse J Anteilen, dann
Klasse I Anteilen, dann Klasse H Anteilen, dann Klasse G Anteilen, dann Klasse F Anteile, dann Klasse E Anteile, dann
Klasse D Anteile, dann Klasse C Anteile, dann Klasse B Anteile, dann Klasse A Anteile erfolgen, jeweils auf einer par/'-
passu-Basis, bis jeweils alle Anteile einer solchen Klasse vollständig zurückgekauft wurden, wobei Einverständnis darüber
herrscht, dass unter keinen Umständen die Rückkäufe dazu führen dürfen, dass das Gesellschaftskapital der Gesellschaft
unter das gesetzliche Minimum fällt.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes und der Vereinbarung
zurückkaufen. Der Betrag, der in Bezug auf eine Anteilsklasse im Falle eines Rückkaufs zu zahlen ist, soll im Falle eines
Rückkaufs nach einem Liquiditätsereignis dem Betrag entsprechen, der einer solchen Anteilsklasse entsprechend Artikel
24.2 und Artikel 26 und der Vereinbarung nach einem Liquiditätsereignis zu erhalten zusteht. Wenn Anteile in Überein-
stimmung mit den hier dargelegten Bedingungen und den Bestimmungen der Vereinbarung zurückgekauft werden sollen,
kann die Gesellschaft den Rückkauf der entsprechenden Anteile durch Mitteilung ganz oder teilweise einfordern, die per
Einschreiben an die Adressen der entsprechenden Gesellschafter der Gesellschaft gesendet wird und, die (i) das Datum
des Rückkaufs, (ii) die Anzahl der Anteile, die zum Rückkauf eingefordert werden, (iii) den Rückkaufpreis und (iv) die
Zahlungsmethode des Rückkaufpreises enthält. Anteile, die von der Gesellschaft zurückgekauft werden, sollen anschlie-
ßend eingezogen werden.
5.4 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann eine Agiorücklage begründet werden, in welche jegliches Agio, das auf
einen Anteil zusätzlich zu seinem Nominalwert gezahlt wird, überweisen wird. In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich
Luxemburgischen Rechts, dieser Satzung und der Vereinbarung, kann die Agiorücklage unter anderem dafür verwendet
werden, eine Anteilsklasse gemäß Artikel 5.2 und 5.3 dieser Satzung zurückzukaufen, realisierte Nettoversluste auszu-
gleichen, Dividenden an die Gesellschafter auszuschütten oder Geldmittel der gesetzlichen Rücklage zuzuweisen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit gleichem Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder
ein anderes, ähnliches, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, das von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.
Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des be-
treffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem von mehreren Personen gehaltenen Anteil aus-
zusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
C. Geschäftsführung
Art. 8. Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
8.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die keine Gesellschafter sein müssen.
Sofern die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäftsführer"
nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis auf
den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft von einem Geschäftsführungsrat geleitet, der aus min-
destens einem (1) A Geschäftsführer und einem (1) B Geschäftsführer zusammengesetzt ist.
8.2 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und
alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbehaltenen Handlungen.
Art. 9. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
9.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und Amtszeit
festlegt.
9.2 Geschäftsführer können jederzeit ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Gesellschafter entspre-
chend den Vorschriften des Gesetzes, abberufen werden.
Art. 10. Ausschuss des Geschäftsführungsrates. Der Geschäftsführungsrat kann Ausschüsse, wie vom Geschäftsfüh-
rungsrat beschlossen, gründen, deren Befugnisse jeweils vom Geschäftsführungsrat festgelegt werden.
72127
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Einladung zu Sitzung des Geschäftsführungsrats.
11.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer, einschließlich des Vor-
sitzenden an dem in der Ladung angegebenen Ort. Die Geschäftsführungsratssitzungen finden, soweit in der Ladung nichts
anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
11.2 Die Geschäftsführer werden mindestens fünf (5) Werktage vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder
Sitzung des Geschäftsführungsrats, entweder persönlich, per Brief, per elektronischer Post oder ein anderes vergleich-
bares Kommunikationsmittel geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Ladung zu
bezeichnen sind. Eine solche Ladung ist nicht notwendig, falls alle Geschäftsführer per Post, Faxschreiben, E-Mail oder
mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels, ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie des unter-
zeichneten schriftlichen Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist, oder soll von jedem Geschäftsführer, der an
einer Sitzung anwesend ist und nicht das Fehlen einer Mitteilung reklamiert, als Verzichtserklärung angesehen werden.
Eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats dann auch dann nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem
vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind.
11.3 Eine Ladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen und von allen Mitgliedern des Geschäftsführungsrats unterzeichneten Umlaufbeschlüssen.
Art. 12. Quorum und Handlungen des Geschäftsführungsrates.
12.1 Der Geschäftsführungsrat kann wirksam verhandeln und beschließen, wenn zumindest eine Mehrheit der Ge-
schäftsführer bei einer Sitzung des Geschäftsführungsrates anwesend oder vertreten sind, darunter muss zumindest ein
(1) A Geschäftsführer und ein (1) B Geschäftsführer anwesend oder vertreten sein.
12.2 Wenn kein Quorum an einer Sitzung des Geschäftsführungsrates (oder einem Ausschuss davon) anwesend ist,
können die dort anwesenden Geschäftsführer die Sitzung solange vertagen bis ein Quorum anwesend ist.
Art. 13. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
13.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweises Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
13.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats geleitet, sofern
dieser anwesend ist. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat jedoch ein anderes Mitglied des Geschäfts-
führungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
13.3 Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es ein
anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch ein unterzeichnetes Dokument, welches per Faxschreiben, E-Mail oder
ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Be-
vollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber
nicht alle Kollegen aus dem Geschäftsführungsrats vertreten.
13.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich
an der Sitzung teilzunehmen, abgehalten werden. Eine solche Teilnahme ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teil-
nahme an einer solchen Sitzung und eine derartig abgehaltene Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.
13.5 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, vorausgesetzt, dass zumindest ein A Geschäftsführer und ein
B Geschäftsführer für einen solchen Beschluss stimmen. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats hat im Falle von
Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme.
13.6 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung per
Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines so gefassten Beschlusses.
Art. 14. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
14.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates oder,
im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore unterzeichnet. Jede Kopie und jeder Auszug solcher
Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgezeigt werden müssen, müssen vom Vorsitzenden
des Geschäftsführungsrates, unterzeichnet werden.
14.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers sollen in ein Protokoll aufgenommen werden, welches von dem
Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden soll. Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder aus sonstigen Gründen benötigt werden, sollen vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden.
Art. 15. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unter-
schrift des Einzelgeschäftsführers oder, (ii) für den Fall, dass die Gesellschaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, durch
die einzelne Unterschrift eines (1) A Geschäftsführers, oder (iii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige
Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen
worden ist.
72128
L
U X E M B O U R G
D. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 16. Kollektive Entscheidungen der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von
ihm gehaltenen Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie
er Anteile hält oder vertritt.
Art. 17. Befugnisse der Generalversammlung; schriftliche Gesellschafterbeschlüsse.
17.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, soll eine jährliche General-
versammlung innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ende jedes Geschäftsjahres in Luxembourg am eingetragenem
Sitz der Gesellschaft, oder an jedem anderen in der Ladung bezeichneten Ort in Luxemburg, stattfinden. Andere Gene-
ralversammlungen finden an demjenigen Ort und zu demjenigen Zeitpunkt statt, der in der Ladung festgelegt worden ist.
17.2 Die Generalversammlung verfügt über die vom Gesetz und von dieser Satzung vorgesehene Befugnisse. Außer
im Fall von durch diese Satzung vorgesehenen strengeren Mehrheitserfordernissen, sind Gesellschafterbeschlüsse nur
dann wirksam gefasst, wenn eine Anzahl von Gesellschaftern zustimmt, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Gesell-
schaftskapitals hält.
17.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, können gemeinschaftliche
Entscheidungen, die an sich der Generalversammlung vorbehalten sind, wirksam im Wege eines Umlaufbeschlusses ge-
troffen werden. Diese gemeinschaftlichen Entscheidungen sind nur dann im Sinne des Gesetzes wirksam getroffen, wenn
der betreffende Umlaufbeschluss von Gesellschaftern unterzeichnet wird, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Gesell-
schaftskapitals halten.
Art. 18. Änderung der Nationalität. Die Nationalität der Gesellschaft kann nur durch einstimmigen Beschluss der
Gesellschafter geändert werden.
Art. 19. Änderung der Satzung. Jede Änderung der Satzung erfordert einen Beschluss (i) der Mehrheit der Gesell-
schafter und (ii) einer Mehrheit von mindestens Dreiviertel des gehaltenen Gesellschaftskapitals.
Art. 20. Befugnisse des Einzelgesellschafters. Für den Fall, dass ein Einzelgesellschafter die Gesellschaft hält, übt dieser
die Befugnisse der Generalversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes aus. Für diesen Fall ist jeder Hinweis auf die
„Generalversammlung" je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, als Verweis auf den Einzelgesellschafter zu ver-
stehen, und die Befugnisse, die an sich der Generalversammlung zustehen, stehen in diesem Fall dem Einzelgesellschafter
zu.
E. Bezugsrechte - Anteilsübertragung
Art. 21. Bezugsrechte - Allgemein. Wenn vorgeschlagen wird, dass die Gesellschaft Neue Sicherheiten ausgibt oder
Verträge, Verpflichtungen, Vereinbarungen, Abmachungen oder Absprachen jeglicher Art in Bezug auf die Ausgabe von
Neuen Sicherheiten, schließt oder eingeht mit Personen (anderen als Mitgliedern der Gruppe), soll jeder Gesellschafter
das Recht haben, eine solche Anzahl an Neuen Sicherheiten entsprechend dem Verfahren und vorbehaltlich der Ausnah-
men, die in der Vereinbarung dargelegt sind, zu zeichnen. Um Zweifel zu vermeiden und gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes, soll die Gesellschaft unter keinen Umständen Anteile, Bonds oder andere Sicherheiten an die Öffentlichkeit
ausgeben.
Art. 22. Übertragung von Anteilen.
22.1 Die Anteile sind nur frei übertragbar zwischen Gesellschaftern gemäß dem Übertragungsverfahren, das in der
Vereinbarung dargelegt ist.
22.2 Die Anteile dürfen /nter v/vos neuen Gesellschaftern nur mit der Zustimmung von Gesellschaftern in einer Ge-
neralversammlung, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, übertragen werden. Die Gesell-
schaft erkennt nur einen Erwerber von Anteilen in der Gesellschaft als Eigentümer solcher Anteile an und ein solcher
Erwerber kann nur die Rechte, die diesen Anteilen zugeordnet sind ausüben, wenn eine solche Übertragung in Überein-
stimmung mit der Vereinbarung ist und der Erwerber ausdrücklich zugestimmt hat, an die Vereinbarung gebunden zu
sein.
22.3 Jegliche Übertragungen von Anteilen sollen gegenüber der Gesellschaft und Dritten wirksam sein, nachdem die
Gesellschaft von der Übertragung gemäß Artikel 1690 des Luxemburger Bürgerlichen Gesetzbuchs in Kenntnis gesetzt
wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
22.4 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur mit Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Rechte vertreten, an neue Gesellschafter übertragen werden.
Ein derartiger Beschluss ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/
n Ehepartner/in oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
F. Geschäftsjahr - Gewinne - Gewinnverteilung - Zwischendividenden
Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
72129
L
U X E M B O U R G
Art. 24. Jahresabschluss und Gewinne.
24.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Bedingungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.
24.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme
der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.
Jedes Jahr, in dem die Gesellschaft beschließt Dividenden auszuschütten, die aus den Nettogewinnen und aus verfüg-
baren Reserven, die aus Gewinnrücklagen, einschließlich des Agios, abgeleitet worden sind, gezogen werden, soll der
Betrag, der diesbezüglich zugeteilt worden ist, in der folgenden Prioritätenfolge ausgeschüttet werden:
- Erstens sollen die Inhaber von Klasse A Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses
Jahres in einem Betrag von null Komma sechzig Prozent (0,06%) des Nominalwerts der Klasse A Anteile, die von ihnen
gehalten werden, zu erhalten, dann
- sollen die Inhaber von Klasse B Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in
einem Betrag von null Komma fünfundfünfzig Prozent (0,55%) des Nominalwerts der Klasse B Anteile, die von ihnen
gehalten werden, zu erhalten, dann
- sollen die Inhaber von Klasse C Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in
einem Betrag von null Komma fünfzig Prozent (0,50%) des Nominalwerts der Klasse C Anteile, die von ihnen gehalten
werden, zu erhalten, dann
- sollen die Inhaber von Klasse D Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in
einem Betrag von null Komma fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nominalwerts der Klasse D Anteile, die von ihnen
gehalten werden, zu erhalten, dann
- sollen die Inhaber von Klasse E Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in
einem Betrag von null Komma vierzig Prozent (0,40%) des Nominalwerts der Klasse E Anteile, die von ihnen gehalten
werden, zu erhalten, dann
- sollen die Inhaber von Klasse F Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in
einem Betrag von null Komma fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nominalwerts der Klasse F Anteile, die von ihnen
gehalten werden, zu erhalten, dann
- sollen die Inhaber von Klasse G Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in
einem Betrag von null Komma dreißig Prozent (0,30%) des Nominalwerts der Klasse G Anteile, die von ihnen gehalten
werden, zu erhalten, dann
- sollen die Inhaber von Klasse H Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in
einem Betrag von null Komma fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nominalwerts der Klasse H Anteile, die von ihnen
gehalten werden, zu erhalten, dann
- sollen die Inhaber von Klasse I Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in
einem Betrag von null Komma zwanzig Prozent (0,20%) des Nominalwerts der Klasse I Anteile, die von ihnen gehalten
werden, zu erhalten, dann
- sollen die Inhaber von Klasse J Anteilen das Recht haben, den Rest jeder Dividendenausschüttung, zu erhalten.
Sollte die letzte unbezahlte Anteilsklasse (in alphabetischer Reihenfolge, d.h. zuerst die Klasse J Anteile) gemäß Artikel
5.2 zur Zeit der Ausschüttung zurückgekauft oder eingezogen worden sein, soll der Restbetrag einer Dividendenaus-
schüttung der vorhergehenden unbezahlten Anteilsklasse in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge zugeteilt werden
(d.h. zuerst die Klasse I Anteile).
24.3 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können mit Zustimmung dieses Gesell-
schafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
24.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann im Verhältnis dazu die gesetzliche Rücklage der Ge-
sellschaft herabgesetzt werden, so dass sie stets zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
24.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Generalversammlung, wie der verbleibende Rest des
Jahresnettogewinns der Gesellschaft nach den Regelungen des Gesetzes, den Regelungen dieser Satzung und der Ver-
einbarung verwendet werden soll.
Art. 25. Zwischendividenden - Ausgabeagio.
25.1 Der Geschäftsführungsrat kann Zwischendividenden zahlen auf Grundlage von durch den Geschäftsführungsrat
vorzulegenden Zwischenabschlüssen, welche belegen, dass ausreichende Mittel für eine Zwischendividende zur Verfügung
stehen. Der ausgegebene Betrag darf die seit Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht durch vorgetragene Gewinne und Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder
Beiträge, welche nach den Regelungen dieser Satzung und des Gesetzes einer Rücklage zugeführt werden müssen, nicht
übersteigen.
25.2 Das Ausgabeagio und andere ausschüttbare Rücklagen können vorbehaltlich der vorangehenden Bestimmungen
frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
72130
L
U X E M B O U R G
Art. 26. Dividendenausschüttungen auf ein Liquiditätsereignis. Dividendenausschüttungen von sämtlichen Beträgen, die
auf Anteile nach einem Liquiditätsereignis bezahlt werden, sollen an die Inhaber von Anteilen zu einer Basis je Anteil,
entsprechend ihrer Berechtigungen unter dieser Satzung und der Vereinbarung, durch Rückkauf von Gesellschaftskapital
entsprechend und vorbehaltlich Artikel 5.2, gemacht werden.
G. Aufsicht der Gesellschaft
Art. 27. Rechnungsprüfer.
27.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Rechnungsprüfer beaufsichtigt
(commissaire(s)), vorausgesetzt, sie hat mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter. Die Generalversammlung ernennt
die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
27.2 Jeder satzungsmäßige Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Generalversammlung der Ge-
sellschafter abberufen werden.
27.3 Die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht zur Aufsicht und Kontrolle bezüglich aller
Geschäfte der Gesellschaft.
27.4 Wenn die Generalversammlung im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, einen oder
mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, ersetzen diese die satzungsmäßigen
Rechnungsprüfer.
27.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Generalversammlung der Gesellschafter abberufen werden.
G. Liquidation
Art. 28. Liquidator.
28.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator ausgeführt,
welche von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt
und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquida-
toren unbegrenzte Rechte bei Verwertung der Vermögenswerten und Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
28.2 Soweit in dieser Satzung nicht anderes bestimmt ist, wird der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und
Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der
Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Definitionen - Anwendbares Recht
Art. 29. Definitionen. Die folgenden Begriffe, wenn sie in dieser Satzung verwendet werden, haben die folgende Be-
deutung:
„Zweiggesellschaft" heißt, gegenüber jeder Person, eine andere Person, die direkt oder indirekt von der ersten Person
Kontrolliert wird, die direkt oder indirekt eine solche erste Person Kontrolliert oder direkt oder indirekt unter derselben
Kontrolle steht wie die erste Person und „Angegliedert" soll die Bedeutung entsprechend dem vorgehenden haben;
„Vereinbarung" bedeutet jede Gesellschafter- und Zeichnungsvereinbarung, die gegebenenfalls, unter anderem, zwi-
schen den jeweiligen Gesellschafter der Gesellschaft geschlossen wurde, in seiner jeweiligen geänderten, umformulierten,
ergänzten oder sonst abgeänderten Fassung;
„Satzung" heißt die vorliegende Satzung der Gesellschaft, in ihrer jeweiligen geänderten, umformulierten, ergänzten
Fassung;
„Bidco" heißt Blackstone Perpetual Bidco B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Besloten Vennootschap),
organisiert unter dem Recht der Niederlande, mit eingetragenem Sitz in Naritaweg 165, Telestone 8, Teleport 1043BW
Amsterdam, Niederlande;
„Blackstone" heißt die Blackstone Fonds und, wenn es der Kontext erlaubt, einschließlich jeglichen Erlaubten Erwer-
bern an die jeweils Beteiligungen gemäß der Vereinbarung übertragen wurden;
„Blackstone Fonds" bedeutet Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P., Blackstone Capital Partners (Cayman)
VI IT-B L.P., Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P., Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI
L.P. und Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI-ESC L.P.;
"Geschäftsführungsrat" bedeutet der Geschäftsführungsrat der Gesellschaft in seiner jeweiligen Zusammensetzung;
„Werktag" bedeutet ein Tag an dem Banken in London, Amsterdam und Luxemburg geöffnet sind (um Zweifel zu
vermeiden, Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage in London, Amsterdam und Luxemburg sind nicht erfasst);
„Klasse A Anteile" bedeutet Klasse A Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR
0,01;
„Klasse B Anteile" bedeutet Klasse B Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;
„Klasse C Anteile" bedeutet Klasse C Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR
0,01;
72131
L
U X E M B O U R G
„Klasse D Anteile" bedeutet Klasse D Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR
0,01;
„Klasse E Anteile" bedeutet Klasse E Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;
„Klasse F Anteile" bedeutet Klasse F Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;
„Klasse G Anteile" bedeutet Klasse G Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR
0,01;
„Klasse H Anteile" bedeutet Klasse H Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR
0,01;
„Klasse I Anteile" bedeutet Klasse I Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;
„Klasse J Anteile" bedeutet Klasse J Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;
„Gesellschaft" bedeutet Blackstone Perpetual Topco S.à r.l.;
„Tochtergesellschaft" bedeutet, (a) Midco; (b) Holdco; (c) Investmentco; (d) Bidco, solange sie eine direkte oder
indirekte Tochtergesellschaft der Gesellschaft sind und (e) jede andere jeweils direkte oder indirekte Tochtergesellschaft
der Gesellschaft;
„Kontrolle" bedeutet gegenüber jeder Person (andere als natürliche Personen) (a) direkte oder indirekte Beteiligung
von mehr als 50 % der Stimmrechtanteile einer solchen Person, (b) das Recht mehr als 50% der Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrates einer solchen Person zu ernennen oder die Ernennung zu veranlassen, (c) das Recht das Betriebs-
vermögen einer solchen Person auf Ermessensbasis zu verwalten, oder dessen Verwaltung anzuweisen, um Zweifel zu
vermeiden, ein Komplementär wird angesehen, als Kontrolliere er die Kommanditgesellschaft und, ausschließlich zum
Zweck der Vereinbarung, gilt ein Fonds, der direkt oder indirekt von einer Person beraten oder verwaltet wird, auch als
Kontrolliert von solch einer Person (und die Begriffe „Kontrolliert", „Kontrolliere" und „Kontrollieren" sollen die Be-
deutung entsprechend dem Vorgehenden haben;
„Ausscheiden" bedeutet:
(a) eine Börsennotierung, die dazu führt, dass Blackstone nicht mehr direkt oder indirekt mehr als 50% der Börsen-
notierten Anteile hält;
(b) ein Verkauf von Beteiligungen oder Anteilen in der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft, die direkt oder
durch andere Tochtergesellschaften des gesamten oder im Wesentlichen des gesamten Betriebs (mehr als 50% des Be-
triebsvermögens oder Betriebseinkommen oder Ertragspotential) der Gruppe und, in diesem Fall, das dazu führt, dass
der oder die Erwerber (andere als Zweiggesellschaften von Blackstone) zusammen mehr als 50% der Anteile oder Anteile
in der Gesellschaft oder, je nachdem, solchen Tochtergesellschaften, halten;
(c) der Verkauf von jeglicher Beteiligung, die zu Tag-along und Drag-along Rechten unter der Vereinbarung führen;
oder
(d) die Veräußerung durch eine oder mehrere Transaktionen des gesamten oder im Wesentlichen des gesamten
Betriebs (mehr als 50% des Betriebsvermögens, oder Betriebseinkommen oder Ertragspotential) der Gruppe;
jeweils, zu dem Zeitpunkt, an dem die Gegenleistung einer solchen Transaktion in bar vom Käufer oder der verfügenden
Partei empfangen wird, sofern im Fall einer solchen Transaktion, die eine Gegenleistung nicht in bar umfasst, ein Aus-
scheiden dann als erfolgt gelten soll, wenn ein Teil einer solchen Sachleistung ein „Ausscheiden" dargestellt hätte, sofern
die Gegenleistung, die ursprünglich in bar bezahlt wurde, für eine Vergütung in bar veräußert wurde;
„Gruppe" bedeutet die Gesellschaft und ihre jeweiligen direkten oder indirekten Tochtergesellschaften;
„Holdco" bedeutet Blackstone Perpetual Holdco B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Besloten Vennoot-
schap), organisiert unter dem Recht der Niederlande, mit eingetragenem Sitz in Naritaweg 165, Telestone 8, Teleport
1043BW Amsterdam, Niederlande;
„Beteiligungen" bedeutet Anteile oder PECs, oder alle zusammen, je nach Kontext;
„Investmentco" bedeutet Blackstone Perpetual Investmentco B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Bes-
loten Vennootschap), organisiert unter dem Recht der Niederlande, mit eingetragenem Sitz in Naritaweg 165, Telestone
8, Teleport 1043BW Amsterdam, Niederlande;
„Gesetz" bedeutet das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung;
„Liquiditätsereignis" bedeutet das Ausscheiden oder die Kapitalaufstockung;
„Börsennotierte Anteile" bedeutet die Anteile (Anteilsklasse), die gemäß einer Börsennotierung börsennotiert werden
und, um Zweifel zu vermeiden, soweit alle Anteile oder Anteile einer Anteilsklasse zum Handel an einer anerkannten
Börse zugelassen werden, die gesamte Anteilsklasse als Börsennotierte Anteile gelten soll;
„Börsennotierung" bedeutet die Zulassung einer Klasse von Anteilen der Gesellschaft, einer Tochtergesellschaft oder,
gegebenenfalls jede Muttergesellschaft zu einer Börsennotierung, wie vom Verwaltungsrat/Geschäftsführungsrat einer
solchen Gesellschaft entschieden;
„Mido" bedeutet Blackstone Perpetual Midco S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsa-
bilité limité) organisiert unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 2-4,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 173 039;
72132
L
U X E M B O U R G
„Neue Sicherheiten" bedeutet jegliche Anteile, preferred equity Sicherheiten oder Optionen, Optionsscheine oder
andere Sicherheiten oder Rechte, die in Anteile oder gebräuchliche Kapitalähnliche Mittel umwandelbar, austauschbar
oder ausübbar sind, einschließlich der Anteile oder PECs, sowie alle umwandelbaren oder nicht umwandelbaren Gesell-
schafterschuldinstrumente;
„Muttergesellschaft" bedeutet eine Person die direkt oder indirekt die Gruppe Kontrolliert und die kein wesentliches
Betriebsvermögen oder Wirtschaftsleben besitzt, das sich nicht auf das Geschäft der Gruppe beziehen;
„PECs" bedeutet jede Klasse oder Serie von preferred equity certificates der Gesellschaft;
„Erlaubte Erwerber" bedeutet, in Bezug auf Blackstone, (i) jede Zweiggesellschaft von Blackstone oder Nachfolgege-
sellschaft von Blackstone (die kein Drittparteierwerber ist), (ii) jegliche Investmentfonds oder Fonds oder sämtliche
Zweiggesellschaften solcher Investmentfonds oder Fonds, die von einem Berater oder Sub-Advisor von Blackstone oder
Blackstones Zweiggesellschaften beraten werden, sämtliche Nachfolger davon, sämtliche Berater, Sub-Advisor davon oder
Zweiggesellschaften aller vorangehenden;
„Kapitalaufstockung" bedeutet jegliche Veränderung der Kapital-und/oder Schuldstruktur der Gruppe um zu ermög-
lichen, dass Barmittel an die Inhaber von Beteiligungen zurückgeben werden kann;
„Gesellschafter" bedeutet sämtliche Inhaber von Beteiligungen vorausgesetzt, dass und solange er oder sie Anteile in
der Gesellschaft hält/halten;
„Anteile" bedeutet die Klasse A Anteile, Klasse B Anteile, Klasse C Anteile, Klasse D Anteile, Klasse E Anteile, Klasse
F Anteile, Klasse G Anteile, Klasse H Anteile, Klasse I Anteile und Klasse J Anteile.
Art. 30. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes und der Vereinbarung."
<i>Kostenschätzungi>
Die im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde entstehenden Auslagen, Kosten Gebühren und Belastungen,
gleich welcher Art, die von der Gesellschaft getragen werden oder die der Gesellschaft in Rechnung gestellt werden sollen
in Verbindung mit der Kapitalerhöhung, betragen schätzungsweise drei tausend fünfhundert Euro (EUR 3.500).
Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der
erschienen Parteien, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung; im Falle von
Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, soll die englische Fassung maßgeblich sein.
Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde
erwähnt wird.
Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienen Parteien vorgelesen, dem Notar mit Nachnamen, Vorn-
amen, Zivilstand und Wohnsitz bekannt, ferner haben der Bevollmächtigte und der Notar die vorliegende Urkunde
unterschrieben.
Signé: J. Wittek et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 avril 2013. LAC/2013/16751. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
Référence de publication: 2013058530/1191.
(130072216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.
Aedificium Capital, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 176.991.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the eighth day of April.
Before the undersigned, Maître Francis Kesseler, a notary resident in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Robin Binks, Chartered Accountant, born on 25 November 1952 in Horsforth, Yorkshire, England, residing at 6
Liskeard Gardens London SE3 OPN, United Kingdom,
here represented by Rocío García-Santiuste, lawyer, whose professional address is 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London, on 4 April 2013,
2. Damien Brady, Professional Manager, born on 24 March 1967 in Brisbane, Australia, residing at 58 Ullswater Road
Barnes, London SW13 9PN, United Kingdom,
72133
L
U X E M B O U R G
here represented by Rocío García-Santiuste, lawyer, whose professional address is 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London, on 5 April 2013,
3. Gary Russell, Solicitor of the Supreme Court of England and Wales, born on 17 January 1952 in Harrow, England,
residing at 2, Boulevard du Jardin Exotique, Monaco 98000,
here represented by Rocío García-Santiuste, lawyer, whose professional address is 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Monaco, on 4 April 2013,
4. Jeffrey Pulsford, Accountant, born on 31 August 1959 in Bridgwater, United-Kingdom, residing at Denesfield, 16
Lytton Park, Cobham, Surrey, KT11 2HB, United-Kingdom,
here represented by Rocío García-Santiuste, lawyer, whose professional address is18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London, on 5 April 2013,
5. Reas Kondraschow, CEO of private company, born on 13 August 1953 in Frankfurt, Germany, residing at 34477
Holly Tree Lane, Dagsboro, Delaware, USA 19939,
here represented by Rocío García-Santiuste, lawyer, whose professional address is 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Washington D.C., on 5 April 2013,
6. Brookwood Hotel Ventures LLC, a limited liability company incorporated under the laws of Delaware, having its
registered office at 72 Cherry Hill Drive, Beverly, Massachusetts 01915, registered with the Secretary of State of the State
of Delaware, Division of Corporations, under number 5028284,
here represented by Rocío García-Santiuste, lawyer, whose professional address is 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Beverly, Massachusetts, on 4 April 2013.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing parties and the undersigned notary, the
powers of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing parties, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "Aedificium Capital" (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in the municipality of Luxembourg city, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to
any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
72134
L
U X E M B O U R G
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600), represented by twelve thousand six
hundred (12,600) shares in registered form without nominal value.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors.
6.6. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.7. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.8. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Représentation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty- four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented. Board resolutions
shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the
managers present or represented.
72135
L
U X E M B O U R G
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Représentation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article resolutions of the shareholders shall be adopted at a general
meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
72136
L
U X E M B O U R G
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following
the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders' Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
72137
L
U X E M B O U R G
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2013.
<i>Subscription and Paymenti>
Robin Binks, represented as stated above, subscribes for four thousand seven hundred and twenty five (4,725) shares
in registered form, without a nominal value, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of four thousand
seven hundred and twenty five euro (EUR 4,725),
Damien Brady, represented as stated above, subscribes for four thousand seven hundred and twenty five (4,725) shares
in registered form, without a nominal value, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of four thousand
seven hundred and twenty five euro (EUR 4,725),
Gary Russell, represented as stated above, subscribes for six hundred and thirty (630) shares in registered form,
without a nominal value, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of six hundred and thirty euro (EUR
630),
Jeff Pulsford, represented as stated above, subscribes for one thousand two hundred and sixty (1,260) shares in re-
gistered form, without a nominal value, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of one thousand two
hundred and sixty euro (EUR 1,260),
Reas Kondraschow, represented as stated above, subscribes for six hundred and thirty (630) shares in registered form,
without a nominal value, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of six hundred and thirty euro (EUR
630), and
Brookwood Hotel Ventures LLC, represented as stated above, subscribes for six hundred and thirty (630) shares in
registered form, without a nominal value, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of six hundred and thirty
euro (EUR 630).
The amount of twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600) is at the Company's disposal.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one five hundred euro (EUR 1,500,-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
Robin Binks, Chartered Accountant, born on 25 November 1952 in Horsforth, Yorkshire, England, residing at 6
Liskeard Gardens London SE3 OPN, United Kingdom; and
Damien Brady, Professional Manager, born on 24 March 1967 in Brisbane, Australia, residing at 58 Ullswater Road
Barnes, London SW13 9PN, United Kingdom.
2. The registered office of the Company is located at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing parties that this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing parties.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le huitième jour d'avril,
Par devant le soussigné Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-su-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Robin Binks, expert comptable, né le 25 novembre 1952 à Horsforth, Yorkshire, Royaume- Uni, résidant à 6 Liskeard
Gardens Londres SE3 OPN, Royaume-Uni,
72138
L
U X E M B O U R G
représenté par Rocío García-Santiuste, avocate, avec adresse professionnelle à 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 4 avril 2013.
2. Damien Brady, gérant, né le 24 mars 1967 à Brisbane, Australie, résidant à 58 Ullswater Road Barnes, Londres SW13
9PN, Royaume-Uni,
représenté par Rocío García-Santiuste, avocate, avec adresse professionnelle à 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 5 avril 2013.
3. Gary Russell, Avocat à la Cour Suprême d'Angleterre et du pays de Galles, né le 17 janvier 1952 à Harrow, Royaume-
Uni, résidant à 2, Boulevard du Jardin Exotique, Monaco 98000,
représenté par Rocío García-Santiuste, avocate, avec adresse professionnelle à 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Monaco, le 4 avril 2013.
4. Jeffrey Pulsford, comptable, né le 31 août 1959 à Bridgwater, Royaume-Uni, résidant à Denesfield, 16 Lytton Park,
Cobham, Surrey, KT11 2HB, Royaume Uni,
représenté par Rocío García-Santiuste, avocate, avec adresse professionnelle à 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 5 avril 2013.
5. Reas Kondraschow, dirigeant d'entreprise, né le 13 août 1953 à Francfort, Allemagne, résidant à 34477 Holly Tree
Lane, Dagsboro, Delaware, États-Unis 19939,
représenté par Rocío García-Santiuste, avocate, avec adresse professionnelle à 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Washington D.C., le 5 avril 2013.
6. Brookwood Hotel Ventures LLC, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Delaware, dont le siège
social se situe au 72 Cherry Hill Drive, Beverly, Massachusetts 01915, inscrite auprès du Secrétariat de l'Etat du Delaware,
Division des sociétés, sous le numéro 5028284,
représenté par Rocío García-Santiuste, avocate, avec adresse professionnelle à 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Beverly, Massachusetts, le 4 avril 2013.
Après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, lesdites
procurations resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter de la façon
suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Aedificium Capital" (la Société). La Société est une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société sœur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés
sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
72139
L
U X E M B O U R G
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille six cents euro (EUR 12.600), représenté par douze mille six cents (12.600)
parts sociales sous forme nominative sans valeur nominale.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les
trois-quarts des droits détenus par les survivants.
6.6. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à
la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.7. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.8. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,
sera au Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
72140
L
U X E M B O U R G
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et
de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement
convoquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont
adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
72141
L
U X E M B O U R G
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
des gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
Art. 14. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux
réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.
72142
L
U X E M B O U R G
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Robin Binks, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quatre mille sept cents vingt cinq (4.725) parts
sociales sous forme nominative, sans valeur nominale, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un
montant de quatre mille sept cents vingt cinq euro (EUR 4.725),
Damien Brady, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quatre mille sept cents vingt cinq (4.725) parts
sociales sous forme nominative, sans valeur nominale, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un
montant de quatre mille sept cents vingt cinq euro (EUR 4.725),
Gary Russell, répresenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à six cents trente (630) parts sociales sous forme
nominative, sans valeur nominale, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de six cents
trente euro (EUR 630),
Jeff Pulsford, répresenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à mille deux cents soixante (1.260) parts sociales
sous forme nominative, sans valeur nominale, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant
de mille deux cents soixante euro (EUR 1.260),
Reas Kondraschow, répresenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à six cents trente (630) parts sociales sous
forme nominative, sans valeur nominale, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de six
cents trente euro (EUR 630),
et
Brookwood Hotel Ventures LLC, répresenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à six cents trente (630) parts
sociales sous forme nominative, sans valeur nominale, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un
montant de six cents trente euro (EUR 630),
Le montant de douze mille six cents euro (EUR 12.600) est à la disposition de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1,500.-).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indeterminée:
Robin Binks, expert comptable, né le 25 novembre 1952 à Horsforth, Yorkshire, Royaume-Uni, résidant à 6 Liskeard
Gardens Londres SE3 OPN, Royaume-Uni; and
Damien Brady, gérant, né le 24 mars 1967 à Brisbane, Australie, résidant à 58 Ullswater Road Barnes, Londres SW13
9PN, Royaume-Uni.
2. Le siège social de la Société est établi au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête des parties comparantes que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire des parties comparantes.
Signé: Garcfa-Santiuste, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 avril 2013. Relation: EAC/2013/4861. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
72143
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013058462/558.
(130071963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.
Pyrum Innovations International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 145.120.
Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg que le siège social de PYRUM
INNOVATIONS INTERNATIONAL S.A. est transféré avec effet au 25 février 2013 à l’adresse suivante:
L-2210 Luxembourg, 38 boulevard Napoléon 1
er
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2013.
<i>Pour PYRUM INNOVATIONS INTERNATIONAL S.A.i>
Référence de publication: 2013057445/13.
(130069933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Paladin Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 25.356.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2013057447/13.
(130070550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Stackpole International, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 538.446,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 162.412.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 avril 2013i>
En date du 30 avril 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Kent WALLACE de son mandat de gérant A de la Société avec effet au 2 mai
2013;
- de nommer Monsieur Peter BALLANTYNE, né le 3 avril 1962 à Peterborough, Ontario, Canada, ayant comme adresse
professionnelle: 1325, Cormorant Road, L9G 4V5, Ancaster, Ontario, Canada, en tant que nouveau gérant A de la Société
avec effet au 2 mai 2013 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Michel RAFFOUL, gérant B
- Madame Anne-Catherine GRAVE, gérant B
- Monsieur Peter BALLANTYNE, gérant A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
Stackpole International, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013057523/23.
(130070694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
72144
Aedificium Capital
AGIS s.à r.l
Balaton Properties S.à r.l.
Belval Plaza I Apartments S.à r.l.
Belval Plaza I Mall S.à r.l.
Blackstone Perpetual Topco S.à r.l.
B.R. Opticiens S.à r.l.
Global Climate Partnership Fund SA, SICAV-SIF
H&F Sensor Lux 1 S.à r.l.
H&F Wings Lux 1 S.à r.l.
Honeywell FT Holding S.à r.l.
Icar S.à r.l.
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
IT Realty (Cantalupo) S.à r.l.
JMF Transports S.à r.l.
JRS SICAV - SIF
Kalle Luxembourg S.à r.l.
KEDI 1 Holdings S.à.r.l.
Kedi 1 S.à r.l.
KEDI 2 & 3 Holdings S.à.r.l.
Kikinoa Holding Sàrl
Kujtesa Max S.à.r.l.
Makemake Holding S.à r.l.
MEMC International Finance S.à r.l.
MEMC Luxembourg S.à r.l.
MGP Artemis II S.à r.l.
MGP Asia III LLC 1 Holdings S.à r.l.
MGP Asia III TMK 1 Holdings S.à r.l.
MGP Asia Japan TMK 2 Holdings S.à r.l.
MGP Asia (Lux) III S.à r.l.
MGP Asia (Lux) S.à r.l.
MGP Harbour Exchange S.à r.l.
MGP HoldCo Craven S.à r.l.
MGP Idaho S.à r.l.
MGP Jack S.à r.l.
MGP Japan Core Plus LLC Holding S.à r.l.
MGP Japan Core Plus (Lux) S.àr.l.
MGP Japan Core Plus TMK 2 Holdings S.à r.l.
MGP Japan Core Plus TMK Holdings S.à r.l.
MGP June II S.à r.l.
MGP June S.à r.l.
OG Enterprises S.à r.l.
Oracle CAPAC Finance S.à r.l.
Oracle Finance
Paladin Holding S.A.
Patron Holding (Luxembourg) S.à r.l.
Patron Pipera Holding S.à r.l.
PGE Europe one S.A.
Prolilux S.A.
Pyracantha Spf S.A.
Pyrum Innovations International S.A.
Romania Waterfront (Luxembourg) S.à r.l.
Société d'Investissement AMBARES S.à r.l.
Stackpole International, S.à r.l.
Tempyr S.à r.l.
Valorinvest
Way LuxCo S.à r.l.