This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1428
17 juin 2013
SOMMAIRE
ABOM Diffusion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68544
AIM Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68543
Anglo Venezuela Investments . . . . . . . . . . .
68544
Ango Telecom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68543
Avenue Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
68516
BNP Paribas L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68513
BPVN Enhanced Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68536
BRE/Management 5 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
68527
Carmel Capital V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
68537
ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l. . . .
68536
ContourGlobal Development S.à r.l. . . . . .
68536
ContourGlobal Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
68537
Deutsche Post Reinsurance S.A. . . . . . . . . .
68516
DP&AC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68544
Dufranc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68544
Electroengine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68534
Fill Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68511
Fluid Movement Investment S.A. . . . . . . . .
68527
Flying Wings AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68529
Fngrade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68525
Forest Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68526
Glenda 1980 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68526
Göta Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68526
Innovative Solutions s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
68537
Iso Deco Heinen Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68514
Jedoso S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68538
LeverageSource S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
68542
L Real Estate S.C.A. SICAR . . . . . . . . . . . . .
68542
MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l. . . .
68541
MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l. . . .
68539
NPS European Property Holdings (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68538
Okeïna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68538
PAMM Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68517
Parma Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
68541
Petro Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68540
PHND S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68539
PH Trust S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68539
Pic Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
68540
Rockhampton Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68542
Sal. Oppenheim Private Equity Partners
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68542
San Angelo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68535
Santander Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68498
Sapin Laroche S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
68535
Sat-Elec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68512
Saturne Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68512
Senslight S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68512
S. Michele S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68541
Top Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68522
TreeTop Portfolio SICAV . . . . . . . . . . . . . . .
68523
TreeTop Scolea SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . .
68523
Trufidee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68517
Trufilux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68517
UTI Investment Luxembourg S.à r.l. . . . . .
68527
Vader S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68525
Vattenfall Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . .
68525
Viande - Luxembourg, Société Anonyme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68513
Viking Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
68523
Votre Cordonnier Thiry S.àr.l. . . . . . . . . . .
68534
Wahoo Atlanticus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
68512
Zademar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68534
68497
L
U X E M B O U R G
Santander Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 45.337.
In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of the month of May.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of SANTANDER SICAV,a société
anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable, having its registered office at 16, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg and registered under R.C.S. Luxembourg B 45.337 (the "Company"). The Company was incorporated
pursuant to a notarial deed on 27 October 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
"Mémorial"), number 564 on 27 November 1993. The articles of association of the Company (the "Articles") were last
amended on 9 December 2005 pursuant to a notarial deed, published in the Mémorial C, number 1424 on 20 December
2005.
The Meeting was presided by Mrs Marie-José Fernandes, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Séverine Dassenoy, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting appointed as scrutineer Mr Benjamin Poujol, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
Restatement of the articles of association of the Company (the "Articles") in order to, inter alia:
(i) Amend article 3 of the Articles to reflect the submission of the Company to the law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment (the "2010 Law") so as to read as follows:
"The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and
other permitted liquid financial assets under Part I of the Law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law"), with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders the results of the management of its portfolios.
The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.";
(ii) Amend article 4 of the Articles to allow the Board of Directors to transfer the registered office of the Company
to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg;
(iii) Amend article 5 of the Articles in respect of the cancellation, liquidation or the merger of a sub-fund or a class of
shares;
(iv) Amend article 6 of the Articles to remove the possibility for the Company to issue bearer shares and provide the
possibility for the Company to issue dematerialised shares, if and to the extent permitted, and under the conditions
provided for, by law:
(v) Amend article 8 of the Articles in order to expand the restrictions to the issue and transfer of shares to certain
investors to reflect recent legal and regulatory developments;
(vi) Amend article 10 of the Articles to allow the convening of the annual general meeting of shareholders at a date,
time or place other than those set forth in the article and to change the date of this meeting currently set forth in the
article so as to be the last business day of the month of April in each year at 3.00 pm as from the financial year ending 31
December 2013;
(vii) Amend article 11 of the Articles in order to:
a. allow a shareholder to participate at any meeting of shareholders by videoconference or any other means allowing
to identify such shareholder;
b. determine that resolutions at the meeting of shareholders or to a meeting of a sub-fund or class of shares will be
passed at the majority of the votes cast;
c. determine a record date preceding the shareholder meeting according to which the exercise of the voting rights
attaching to the shares shall be determined by reference to the shares held by the shareholder as at the record date;
(viii) Amend article 16 of the Articles in order to:
a. include any OECD member state, any member state of the Group of Twenty and Singapore to the list of countries
acceptable to the Luxembourg supervisory authority which issue or guarantee transferable securities and money market
instruments in which the Company may invest up to 100% of its total net assets of each sub-fund;
b. allow (i) a sub-fund of the Company to invest in other subfunds of the Company to the widest extent permitted by
Luxembourg law and (ii) allow the set-up of master-feeder sub-funds within the Company;
(ix) Amend article 22 of the Articles in order to (i) redefine conditions for deferral of redemption or conversion
requests and (ii) expand the cases of compulsory redemption of shares of sub-funds;
68498
L
U X E M B O U R G
(x) Amend article 23 of the Articles in order to expand the list of cases of suspension of the valuation net asset value,
issue, conversion and repurchase of shares of sub-funds;
(xi) Amend article 24 of the Articles in order to clarify the rules applicable to the valuation of the Company's assets;
(xii) Amend article 25 of the Articles in order to allow the introduction of dilution levy;
(xiii) Generally update the Articles by amending, amongst others, articles 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 27, 28 and 30;
(xiv) Deletion of French translation as authorized by the 2010 Law.
II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders
of the represented shareholders and by the members of the Bureau, will remain annexed to the present deed to be filed
at the same time with the registration authorities.
III. That all the shares outstanding are registered shares and that the shareholders have been informed of the present
Meeting by a convening notice sent by registered mail on 17 May 2013.
IV. It appears from the attendance list that, out of the twenty-six million two hundred and ninety-seven thousand five
hundred and forty-three point three three three (26,297,543.333) shares in issue, twenty million one hundred thousand
three hundred and eighty-six point three six (20,100,386.36) shares are represented at the Meeting.
V. That, as a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the
following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The shareholders decided with twenty million one hundred thousand one hundred and ninety (20,100,190) votes in
favour and one hundred and sixty-five (165) abstentions to restate the articles of association of the Company (the "Ar-
ticles") in order to, inter alia:
(i) Amend article 3 of the Articles to reflect the submission of the Company to the law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment (the "2010 Law") so as to read as follows:
"The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and
other permitted liquid financial assets under Part I of the Law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law"), with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders the results of the management of its portfolios.
The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.";
(ii) Amend article 4 of the Articles to allow the Board of Directors to transfer the registered office of the Company
to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg;
(iii) Amend article 5 of the Articles in respect of the cancellation, liquidation or the merger of a sub-fund or a class of
shares;
(iv) Amend article 6 of the Articles to remove the possibility for the Company to issue bearer shares and provide the
possibility for the Company to issue dematerialised shares, if and to the extent permitted, and under the conditions
provided for, by law:
(v) Amend article 8 of the Articles in order to expand the restrictions to the issue and transfer of shares to certain
investors to reflect recent legal and regulatory developments;
(vi) Amend article 10 of the Articles to allow the convening of the annual general meeting of shareholders at a date,
time or place other than those set forth in the article and to change the date of this meeting currently set forth in the
article so as to be the last business day of the month of April in each year at 3.00 pm as from the financial year ending 31
December 2013;
(vii) Amend article 11 of the Articles in order to:
a. allow a shareholder to participate at any meeting of shareholders by videoconference or any other means allowing
to identify such shareholder;
b. determine that resolutions at the meeting of shareholders or to a meeting of a sub-fund or class of shares will be
passed at the majority of the votes cast;
c. determine a record date preceding the shareholder meeting according to which the exercise of the voting rights
attaching to the shares shall be determined by reference to the shares held by the shareholder as at the record date;
(viii) Amend article 16 of the Articles in order to:
a. include any OECD member state, any member state of the Group of Twenty and Singapore to the list of countries
acceptable to the Luxembourg supervisory authority which issue or guarantee transferable securities and money market
instruments in which the Company may invest up to 100% of its total net assets of each sub-fund;
b. allow (i) a sub-fund of the Company to invest in other subfunds of the Company to the widest extent permitted by
Luxembourg law and (ii) allow the set-up of master-feeder sub-funds within the Company;
(ix) Amend article 22 of the Articles in order to (i) redefine conditions for deferral of redemption or conversion
requests and (ii) expand the cases of compulsory redemption of shares of sub-funds;
68499
L
U X E M B O U R G
(x) Amend article 23 of the Articles in order to expand the list of cases of suspension of the valuation net asset value,
issue, conversion and repurchase of shares of sub-funds;
(xi) Amend article 24 of the Articles in order to clarify the rules applicable to the valuation of the Company's assets;
(xii) Amend article 25 of the Articles in order to allow the introduction of dilution levy;
(xiii) Generally update the Articles by amending, amongst others, articles 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 27, 28 and 30;
(xiv) Deletion of French translation as authorized by the 2010 Law.
The articles of incorporation of the Company shall therefore read as follows:"
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares hereafter issued, a
corporation in the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name
of "SANTANDER SICAV" (the "Corporation").
Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period. The Corporation may be dissolved at any moment by
a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 3. The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind
and other permitted liquid financial assets under Part I of the Law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law"), with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders the results of the management of its portfolios.
The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.
Art. 4. The registered office of the Corporation is established in the City of Luxembourg, in the Grand Duchy of
Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board
of Directors.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may
transfer the registered office of the Corporation to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military deve-
lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. The capital of the Corporation shall be represented by the shares of no par value ("the Shares”) and shall be
at any time equal to the net assets of the Corporation as defined in Article twenty-four hereof.
Such Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes within the meaning of article 181
of the 2010 Law ("the Classes") corresponding to separate portfolios of assets (each a "Portfolio") (which may, as the
Board shall determine, be denominated in different currencies) and the proceeds of the issue of Shares of each Class shall
be invested pursuant to Article three hereof in transferable securities or other permitted assets corresponding to such
geographical areas, industrial sectors or monetary zones or such specific types of equity or debt securities as the Board
of Directors shall from time to time determine in respect of each Class of Shares.
The Board of Directors may further decide if and from which date Shares of other categories (the "Categories") shall
be offered for sale within each Portfolio, those Shares to be issued on terms and conditions as shall be decided by the
Board and whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Class concerned but
where a specific sales and redemption charge structure, fee structure, hedging policy, distribution policy or other speci-
ficity is applied to each Category.
The Board of Directors may create at any moment additional Classes and/or Categories, provided that the rights and
duties of the shareholders of existing Classes and Categories will not be modified by such creation.
Any reference herein to "Classes" or "Portfolio" shall also mean a reference to "Categories" unless the context requires
otherwise.
For the purpose of determining the capital of the Corporation, the net assets attributable to each Portfolio shall in
the case of a relevant class, if not expressed in EUR be converted into EUR and the capital shall be the total of the net
assets of all the Portfolios. Reference in these Articles to Shares shall be construed as meaning a share of any category
of a class corresponding to a Portfolio. Reference to a class of Shares shall be construed as meaning Shares of any category
of the relevant class corresponding to a Portfolio.
The minimum capital of the Corporation shall be not less than EUR 1,250,000.
The Board of Directors is authorized to issue further fully paid Shares at any time, at a price based on the Net Asset
Value per share of the relevant Category of the relevant Class determined in accordance with Article twentyfour hereof
without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the additional Shares to be issued.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Corporation or to any other
duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such new shares.
68500
L
U X E M B O U R G
The Board of Directors may decide to merge one or several Classes or Categories of Shares or may decide to cancel
one or several Classes of Shares or Categories of Shares by cancellation of the relevant Classes of Shares or Categories
of Shares and refunding to the shareholders of such Classes the full net asset value of the Shares of such Classes. Such a
decision of the Board of Directors may result from substantial unfavorable changes of the social or economic situation
in countries where investments for the relevant Class(es)) are made, or shares of the relevant Class(es) or Categories
are distributed.
The Board of Directors may decide to submit such a decision to a meeting of the shareholders of the Class of Shares
a Category of shares concerned.
The decision to liquidate or cancel a Class of Shares or a Category of Shares will be published (or notified as the case
may be) by the Corporation prior to the effective date of the liquidation and the publication (or notice) shall indicate the
reasons for, and the procedures of, the liquidation operation.
Pending the completion of a merger, shareholders of the Class or Category concerned to be merged may continue
to ask for the redemption of their shares, this redemption being made without cost to the shareholders during a minimum
period of one month beginning on the date of publication of the decision of merger. At the end of that period, all the
remaining shareholders will be bound by the decision of merger.
The same applies in case of merger of a Class or Category of Shares with a class or category of shares of another
Luxembourg undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to part I of the Luxembourg Law
of 2010.
In case of a merger of one or more Class(es) where, as a result, the Corporation ceases to exist, the merger shall be
decided by a meeting of shareholders for which no quorum is required and that may decide with a simple majority of
votes cast.The provisions on mergers of UCITS set forth in the 2010 Law and any implementing regulation (relating in
particular to the notification to the shareholders concerned) shall apply.
In the circumstances provided in the ninth paragraph of this Article, the Board of Directors may also, subject to
regulatory approval (if required), decide to consolidate or split any Category of Shares within a Class. To the extent
required by Luxembourg law, such decision will be published and, if needed, notified in the same manner as described
above and the publication and/or notification will contain information in relation to the proposed split or consolidation.
The Board of Directors may also decide to submit the question of the consolidation or split of Categories of Shares to
a meeting of holders or such Category of Shares. No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the
simple majority of the votes cast.
Art. 6. The Corporation will issue new shares in registered form only and will no longer issue bearer shares. If and to
the extent permitted, and under the conditions provided for, by law, the Board of Directors may at its discretion decide
to issue, in addition to shares in registered form, shares in dematerialised form if requested by their holder(s). Under the
same conditions, holders of registered shares may also request the conversion of their shares into dematerialised shares.
The costs resulting from the conversion of registered shares at the request of their holders will be borne by the latter
unless the Board of Directors decides at its discretion that all or part of these costs must be borne by the Corporation.
Ownership of registered shares is evidenced by the entry in the register of shareholders of the Corporation and
shareholders shall receive a confirmation of their shareholding. The Board of Directors may however decide to issue
share certificates, as disclosed in the sales document of the Corporation. Share certificates, if issued, shall be signed by
two directors. Both such signatures may be manual, printed, by facsimile or electronic. However, one of such signatures
may be by a person delegated to this effect by the Board of Directors. In such latter case, the signature shall be manual.
The Corporation may issue temporary share certificates in such form as the Board of Directors may from time to time
determine.
Shares shall be issued only upon acceptance of the purchase instruction and payment of the purchase price. The
purchaser will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price, obtain delivery
of a confirmation of his shareholding or a definitive share certificate (if applicable).
All issued shares of the Corporation other than dematerialised shares (if issued) shall be inscribed in the register of
shareholders, which shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated by the Corporation for such
purpose and such register of shareholders shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or
elected domicile so far as notified to the Corporation, the Class of Shares, the number of shares held by him and the
amount paid in on each such share.
Transfer of registered shares shall be effected by inscription in the register of shareholders of the transfer to be made
by the Corporation upon delivery of a duly signed share transfer form or any other instruments of transfer satisfactory
to the Corporation, together with, if issued, the relevant share certificate to be cancelled. The instruction must be dated
and signed by the transferor(s), and if requested by the Corporation or its designated agent also signed by the transferee
(s), or by persons holding suitable powers of attorney to act in that capacity. The transfer of dematerialised shares (if
issued) shall be made in accordance with applicable laws.
Holders of registered shares may not request conversion of their shares into bearer shares.
In case registered shares the Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the
register of shareholders, as full owner of the shares.
68501
L
U X E M B O U R G
Every registered shareholder must provide the Corporation with an address to which all notices and announcements
from the Corporation may be sent. Such address will be entered in the register of shareholders. In the case of joint
holders of shares, only one address will be inserted in the register of shareholders and notices and announcements will
be sent to that address only.
In the event that a shareholder does not provide an address or notices and announcements are returned as undeli-
verable to the address in the register of shareholders, the Corporation may permit a notice to this effect to be entered
in the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Cor-
poration, or such other address as may be so entered by the Corporation from time to time, until another address is
provided to the Corporation by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in
the register of shareholders by means of a written notification to the Corporation at its registered office, or at such other
address as may be set by the Corporation from time to time. The shareholder shall be responsible for ensuring that his
details, including his address, for the register of shareholders are kept up to date and shall bear any and all responsibility
should any details be incorrect or invalid.
Holders of dematerialised shares must provide, or must ensure that registrar agents shall provide, the Corporation
with information for identification purposes of the holders of such shares in accordance with applicable laws. If on a
specific request of the Corporation, the holder of dematerialised shares does not furnish the requested information, or
furnishes incomplete or erroneous information within a time period provided for by law or determined by the Board of
Directors at its discretion, the Board of Directors may decide to suspend voting rights attached to all or part of the
dematerialised shares held by the relevant person until satisfactory information is received.
The Corporation will recognize only one holder in respect of a Share in the Corporation. In the event of joint ownership
or bare ownership and usufruct, the Corporation may suspend the exercise of any right deriving from the relevant Share
or Shares until one person shall have been designated to represent the joint owners or bare owners and usufructuaries
vis-à-vis the Corporation.
Subject to applicable local laws and regulations, the address of the shareholders as well as all other personal data of
shareholders collected by the Corporation and/or any of its agents may be collected, recorded, stored, adapted, trans-
ferred or otherwise processed and used ("processed") by the Corporation, its agents and other companies of the
Santander Group, any subsidiary or affiliate thereof, which may be established outside Luxembourg and/or the European
Union, and the financial intermediary of shareholders. Such data may be processed for the purposes of account adminis-
tration, anti-money laundering and counter-terrorist financing identification, tax identification (including, but not limited
to, for the purpose of compliance with the Foreign Account Tax Compliance Act, as might be amended, completed or
supplemented ("FATCA") as well as, to the extent permissible and under the conditions set forth in Luxembourg laws
and regulations and any other local applicable regulations, the development of business relationships including sales and
marketing of Santander Group investment products.
Art. 7. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Corporation that his share certificate has been mislaid
or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees,
including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Corporation may determine.
On the issue of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate
in place of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated or defaced share certificates may be exchanged for new ones by order of the Corporation. The mutilated
or defaced certificates shall be delivered to the Corporation and shall be annulled immediately.
The Corporation may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate
and all reasonable expenses undergone by the Corporation in connection with the issuance and registration thereof, or
in connection with the annulment of the old share certificate.
Art. 8. The Board of Directors may restrict or prevent the ownership of Shares in the Corporation by any person,
firm or corporate body, if it appears to the Corporation that such ownership results in a breach of law or regulation in
Luxembourg or abroad, may make the Corporation or its shareholders subject to liabilities (including tax liabilities) in a
country other than the Grand-Duchy of Luxembourg or any other disadvantages that it or they would not have otherwise
incurred or be exposed to or may otherwise be detrimental to the Corporation or to the majority of its shareholders.
More specifically, the Corporation may restrict or prevent the ownership of Shares in the Corporation, by any person,
firm or corporate body, and without limitation, by any "U.S. person", as defined hereafter or if as a result thereof it may
expose the Corporation or its shareholders to adverse regulatory, tax or fiscal (including any tax liabilities that might
derive, inter alia, from any breach of the requirements imposed by the Foreign Account Compliance Act ("FATCA") and
related US regulations) consequences, and in particular if the Corporation may become subject to tax laws other than
those of the Grand Duchy of Luxembourg (or to any other disadvantages that it or they would not have otherwise
incurred or been exposed to).
For such purposes the Corporation may:
a) decline to issue any Share and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registration
or transfer would or might result in beneficial ownership of such Shares by a person who is precluded from holding Shares
in the Corporation;
68502
L
U X E M B O U R G
b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares
on, the Register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's Shares rests or will rest in a
person who is precluded from holding Shares in the Corporation;
c) where it appears to the Corporation that any person, who is precluded from holding Shares in the Corporation,
either alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of Shares, compulsorily purchase from any
such shareholder all Shares held by such shareholder or where it appears to the Corporation that one or more persons
are the owners of a proportion of the Shares in the Corporation which would make the Corporation subject to tax or
other regulations of jurisdictions other than Luxembourg, compulsorily redeem all or a proportion of the Shares held by
such shareholders, as may be necessary, in the following manner:
1) The Corporation shall serve a notice (hereinafter called the "purchase notice") upon the shareholder bearing such
Shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to
be purchased as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the purchase price in respect of
such Shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Corporation.
The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Corporation the share certificate or
certificates, if any, representing the Shares specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on
the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the Shares specified in such
notice and, in the case of registered Shares, his name shall be removed as the holder of such Shares from the Register of
Shareholders;
2) The price at which the Shares specified in any purchase notice shall be purchased (herein called "the purchase price")
shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of the relevant Class and Categories determined in accordance
with Article twenty-four hereof, as at the date of the purchase notice;
3) Payment of the purchase price will be made to the owner of such Shares in the currency of the Class of Shares and
Category concerned, except during periods of exchange restrictions, and will be deposited by the Corporation with a
bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such owner upon surrender of
the share certificate or certificates, if issued, representing the Shares specified in such notice.
Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the Shares specified in such purchase notice shall have
any further interest in such Shares or any of them, or any claim against the Corporation or its assets in respect thereof,
except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest)
from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates, if issued, as aforesaid;
4) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in
any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of any Shares by any person or that the true
ownership of any Shares was otherwise than appeared to the Corporation at the date of any purchase notice, provided
that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith; and
d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Corporation at any meeting
of shareholders of the Corporation.
Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall mean any national, citizen or resident of the United
States of America or of any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction or any person who is
normally resident therein (including the estate of any such person or corporations or partnerships created or organized
therein). The Board of Directors may, from time to time, amend or clarify this meaning in the sales document of the
Corporation.
In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of shares of a Class of Shares
to institutional investors within the meaning of Article 174 (2) of the 2010 Law ("Institutional Investor(s)"). The Board of
Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of a Class of Shares
reserved for Institutional Investors until such time as the Corporation has received sufficient evidence that the applicant
qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of shares of a Class of Shares reserved to
Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant shares into shares
of a Class of Shares which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Class of Shares
with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant shares in accordance with the provisions set forth above
in this Article. The Board of Directors will refuse to give effect to any transfer of shares and consequently refuse for any
transfer of shares to be entered into the Register of Shareholders in circumstances where such transfer would result in
a situation where shares of a Class of Shares restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a
person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each shareholder who
does not qualify as an Institutional Investor, and who holds shares in a Class of Shares restricted to Institutional Investors,
shall hold harmless and indemnify the Corporation, the Board of Directors, the other shareholders of the relevant Class
of Shares and the Corporation’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding
circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading
or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Corpo-
ration of its loss or change of such status.
68503
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of
shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.
Art. 10. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the last business day of the month of April in each year at 3.00 p.m.. If such day is not a bank business day in
Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional cir-
cumstances so require.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of
shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time
or place to be decided by the Board of Directors.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 11. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders
of the Corporation, unless otherwise provided herein.
Each Share of whatever Class or Category and regardless of its net asset value is entitled to one vote. A Shareholder
may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, facsimile
transmission or any other electronic means capable of evidencing such proxy. Such proxy shall be deemed valid, provided
that it is not revoked, for any reconvened shareholders meeting.)
The Board of Directors may determine that a shareholder may also participate at any meeting of shareholders by
videoconference or any other means of telecommunication allowing to identify such shareholder. Such means must allow
the shareholder to effectively act at such meeting of shareholders, the proceedings of which must be retransmitted
continuously to such shareholder.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of votes cast.
Resolutions with respect to any Class or Category will also be passed, unless otherwise required by law or provided
herein, by a simple majority of the votes cast.
Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders
may provide that the quorum and the majority at this general meeting shall be determined according to the shares issued
and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the “Record Date”), whereas the right of a
shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/its/her shares
shall be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
Art. 12. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or upon the written request of Shareholders
representing at least one tenth of the share capital of the Corporation. Notices setting forth the agenda shall be sent
prior to the meeting to each shareholder in accordance with Luxembourg law.
To the extent required by law, notices shall, in addition, be published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper, and in such other newspapers as the Board of Directors may
decide.
Art. 13. The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members;
members of the Board of Directors need not be shareholders of the Corporation.
The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next
annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 14. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members one or more vicechairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall
meet upon call by the chairman, or any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the share-
holders or the Board of Directors may appoint another director and, in the absence of any director at a shareholders'
meeting, any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a general manager,
a secretary, any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation
68504
L
U X E M B O U R G
and management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors.
Officers need not be Directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise stipulated
in these Articles, shall have the powers and duties given them by the Board of Directors.
Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors in writing or by cable, telegram, facsimile
or email advise at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of
emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may
be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission or email advise of each director.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director or his proxy in writing
or by cable, telegram, or facsimile transmission or any other electronic means capable of evidencing the proxy another
director as his proxy.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Cor-
poration by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
Any director may attend a meeting of the Board of Directors using teleconference means, provided that (i) the director
attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii)
the transmission is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate. The participation in a
meeting by such means shall constitute presence in person at the meeting and the meeting is deemed to be held at the
registered office of the Corporation.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least fifty per cent of the Directors are present or
represented at a meeting of the Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors
present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution
shall be equal, the chairman shall have a casting vote.
Resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened
and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmissions or similar means.
Art. 15. The minutes of any meeting of the Board of Directors and of any general meeting of shareholders shall be
signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by two Directors.
Art. 16. The Board of Directors of the Corporation shall, based upon the principle of spreading risks have power to
determine the corporate and investment policy for the investments relating to each Class of the Corporation and the
assets relating thereto and the course of conduct of the management and business affairs of each Class of the Corporation.
The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the in-
vestments of the Corporation.
The Board of Directors may decide that investments of the Corporation be made
(i) in transferable securities and money market instrument admitted to or dealt in on a regulated market as defined
by the Law of 2010,
(ii) in transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in a Member State
of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public,
(iii) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-
Member State of the European Union or dealt in on another regulated market in a non-Member State of the European
Union, provided that such market is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public,
(iv) in recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include
an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or other regulated markets
referred to above and such admission is achieved within a year of the issue,
(v) in any other securities, instruments or other permitted assets within the restrictions as shall be set forth by the
Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Cor-
poration.
The Board of Directors of the Corporation may decide to invest up to 100% of the net assets of each Class, in
accordance with the principle of risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued
or guaranteed by any Member State as defined in the Law of 2010, its local authorities, a non member state of the European
Union, as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Corporation
(such as but not limited to OECD member states, any member state of the Group of Twenty and Singapore) or by public
international bodies of which one or more of those member states of the European Union are members, provided that
in the case where the Corporation decides to make use of this provision, it must hold, on behalf of the Class concerned,
securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than 30% of the
total net assets of the Class
68505
L
U X E M B O U R G
The Board of Directors of the Corporation may decide that investments of the Corporation be made in financial
derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the
Law of 2010 and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying
consists of instruments covered by article 41 (1) of the Law of 2010, financial indices, interest rates, foreign exchange
rates or currencies, in which the Corporation may invest according to its investment objectives as disclosed in its sales
documents.
The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Fund be made with the aim to replicate a certain stock
or bond index provided that the relevant index is recognized by the Luxembourg supervisory authority on the basis that
it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark or the market to which it refers and is published in any
appropriate manner.
The Corporation will not invest more than 10% of the net assets of any Sub-Fund in undertakings for collective
investment as defined in article 41 (e) of the Law of 2010 unless specifically permitted to do so by the investment policy
applicable to a Sub-Fund as published in the sales documents of the Corporation.
Any Class may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in applicable Luxembourg laws
and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Corporation, subscribe,
acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more Classes of the Corporation. In this case and subject
to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these shares
are suspended for as long as they are held by the Class concerned. In addition and for as long as these shares are held
by a Class, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Corporation for
the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law.
Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may, at any time it deems
appropriate and to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with
the provisions set forth in the sales documents of the Corporation, (i) create any Class qualifying either as a feeder UCITS
or as a master UCITS, (ii) convert any existing Class into a feeder UCITS Class or (iii) change the master UCITS of any
of its feeder UCITS Classes.
Art. 17. The Board of Directors of the Corporation may delegate its powers to conduct the daily management and
affairs of the Corporation (including the right to act as authorized signatory for the Corporation) and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, who
need not be members of the Board, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if
the Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers. If delegation is made to a Board Member under this
Article, the Board must have received authorisation from the General Meeting of Shareholders.
The Corporation may designate a management company submitted to chapter 15 of the Law of 2010 (the “Management
Company”) to provide it with management services as referred to in article 101 (2) of the Law of 2010.
The appointment and revocation of the Corporation’s service providers, including the Management Company (if any),
will be decided by the Board of Directors of the Corporation at the majority of the Directors present or represented.
Art. 18. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Corporation is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.
Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm
with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction submitted
for approval of the board of Directors conflicting with that of the Corporation, that director or officer shall make such
conflict known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction,
and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next meeting of sharehol-
ders.
The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board of Directors or by the single director relates
to current operations entered into under normal conditions.
The term "personal interest", as used above, shall not include any relationship with or interest in any matter, position
or transaction involving the promoter's group and custodian's group as specified in the sales document of the Corporation
and their subsidiaries and associated companies or such other corporation or entity as may from time to time be deter-
mined by the Board of Directors on its discretion.
Art. 19. The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or, at its request, of any other corporation
of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence
or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
68506
L
U X E M B O U R G
covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled.
Art. 20. The Corporation will be bound by the joint signature of any two Directors or by the individual signature of
any director duly authorized or by the individual signature of any duly authorized officer of the Corporation or by the
individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 21. The operations of the Corporation and its financial situation including particularly its books shall be supervised
by one or several statutory approved auditors who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honorableness
and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the Law of 2010. The statutory approved
auditors shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual
general meeting of shareholders and until their successors are elected.
Art. 22. As is more especially prescribed herein below, the Corporation has the power to redeem its own Shares at
any time within the sole limitations set forth by law.
A shareholder may request the redemption of all part or his Shares by the Corporation. The redemption price shall
be paid not later than 5 bank business days in Luxembourg after the relevant valuation day, and shall be equal to the per
share net asset value of the relevant Class and Category, as determined in accordance with the provisions of Article
twenty-four hereof less a redemption charge, if any, as determined by the Board of Directors. Any such request must be
filed by such shareholder in written form at the registered office of the Corporation in Luxembourg or with any other
person or entity appointed by the Corporation as its agent for redemption of Shares, together with the delivery of the
certificate(s) (if issued) for such Shares in proper form and accompanied by proper evidence of transfer or assignment.
Shares of the capital of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.
If, as a result of a redemption, the value of a shareholder's holding would become less than the minimum subscription
amount specified in the relevant Class Appendix, that shareholder may be deemed (if the Board so decides) to have
requested redemption of all of his shares. Also, the Board of Directors may, at any time, decide to compulsorily redeem
all shares from shareholders whose holding is less than the minimum subscription amount specified in the relevant Class
Appendix. In the case of such compulsory redemption, the shareholder concerned will receive one month's prior notice
so as to be able to increase his holding above such amount.
Shareholders are required to notify the Corporation immediately in the event that they become US Persons or hold
shares for the account or benefit of US Persons or otherwise hold shares in breach of any law or regulation or otherwise
in circumstances having, or which may have, adverse regulatory tax or fiscal consequences for the Corporation or the
shareholders or otherwise be detrimental to the interests of the Corporation. Where the Directors become aware that
a shareholder (a) is a US Person or is holding shares for the account of a US Person, (b) is holding shares in breach of
any law or regulation or otherwise in circumstances having, or which may have, adverse regulatory, tax or fiscal conse-
quences for the Corporation or the shareholders or otherwise be detrimental to the interest of the Corporation, the
Directors may redeem the shares in accordance with the provisions of the Articles of Incorporation of the Corporation.
Additionally, if requests for the redemption or conversion of more than a percentage of the total shares in issue of
any Class to be determined by the Board of Directors from time to time and disclosed in the sales documents of the
Corporation are received on any Valuation Date, the Board of Directors may decide that, subject to applicable regulatory
requirements, redemptions and/or conversion shall be suspended. In such circumstances, the sale or conversion may be
deferred as further described in the sales documents of the Corporation. These instructions to sell or switch Shares will
be executed in accordance with the procedures described in the sales documents of the Corporation.
The Board of Directors or any duly appointed agent may further decide to compulsorily redeem Shares the subscription
of which would not be made in accordance with the sales documents of the Corporation or whose wired subscription
amounts would be insufficient to cover the relevant subscription price (including, for the avoidance of doubt, any applicable
subscription charge). Such redemption will be carried out under the most favourable conditions for the Company, in-
cluding among other the possibility for the Corporation to keep the difference between the redemption price and the
subscription price when the latter is lower than the former or claim to the relevant investor that difference when the
latter is higher than the former.
Whenever the Board of Directors decides to cancel one or several Classes or Categories, shareholders may continue
to request the redemption of all or part of their shares, until the effective date of such cancellation. Redemptions made
under these circumstances will be without any cost to the shareholders concerned.
Any shareholder may request conversion of all or part of his Shares of the relevant Category corresponding to a
certain Class into Shares of the same Category of another Class, based on a conversion formula as determined from time
to time by the Board of Directors and disclosed in the current sales documents of the Corporation.
However, the right to convert Shares of one Category into the Shares of another Category is subject to compliance
with the conditions described in the sales documents of the Corporation.
Art. 23. For the purpose of determining the issue, redemption and conversion price per Share, the Net Asset Value
of Shares of each class and Category in the Corporation shall be determined by the Corporation from time to time, but
68507
L
U X E M B O U R G
in no instance less than twice monthly, as the Board of Directors by regulation may direct (every such day for determi-
nation of Net Asset Value being referred to herein as a "valuation day") provided that in any case where any valuation
day would fall on a day observed as a holiday by banks in Luxembourg, such valuation day shall then be the next following
bank business day in Luxembourg.
The Corporation may suspend the determination of the net asset value of Shares of any Portfolio and the issue and
redemption of the Shares in such Portfolios as well as the conversion from and to Shares of such Portfolios during:
(a) any period when any of the principal markets or stock exchange on which a substantial portion of the investments
of such Portfolio of the Corporation from time to time is quoted, is closed, or during which dealings thereon are restricted
or suspended;
(b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of
assets owned by the relevant Portfolio of the Corporation would be impracticable;
(c) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the
investments attributable to any of the relevant Portfolios or the current prices of values on any market or stock exchange;
(d) any period when the Corporation is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the re-
demption of shares of the relevant Portfolio or during which any transfer of funds involved in the realization or acquisition
of investments or payments due on redemption of Shares of the relevant Portfolio cannot in the opinion of the Directors
be effected at normal prices or rates of exchange;
(e) during any period when in the opinion of the Board of Directors there exists unusual circumstances where it would
be impractical or unfair towards the shareholders to continue dealing in the shares of the Corporation or of any Sub-
Fund or any other circumstances, or circumstances where a failure to do so might result in the shareholders of the
Corporation, a Sub-Fund incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantage or other detriment
which the shareholders of the Corporation, or a Sub-Fund might not otherwise have suffered; or
(f) if the Corporation, or a Sub-Fund is being or may be woundup, on or following the date on which such decision is
taken by the Board of Directors or notice is given to shareholders of a general meeting of shareholders at which a
resolution to wind-up the Corporation, or a Sub-Fund is to be proposed; or
(g) in the case of a merger, if the Board of Directors deems this to be justified for the protection of the shareholders;
or
(h) in the case of a suspension of the calculation of the net asset value of one or several underlying investment funds
in which a Sub-Fund has invested a substantial portion of assets.
Any such suspension of the calculation of the net asset value of the Shares of Class or Category does not entail the
suspension of the calculation of the net asset value of the Shares of other Classes or Categories if the circumstances
referred to above do not exist in respect of the assets relating to the other Classes or Categories.
Any such suspension shall be notified to investors requesting issue, redemption or conversion of Shares by the Cor-
poration at the time of the application for such issue, redemption or conversion and shall be published by the Corporation
if, in the opinion of the Board of Directors, it is likely to exceed fourteen days.
Art. 24. The Net Asset Value of Shares of each Category in each Class of Shares shall be expressed as a per Share
figure in the currency of the relevant Category of Shares as determined by the Board and shall be determined in respect
of any Valuation Day by dividing the net assets of the relevant Class corresponding to such Category, being the value of
the assets of the relevant Class attributable to such Category less its liabilities attributable to such Category at such time
or times as the Board of Directors may determine, by the number of shares of the relevant Category then outstanding
and by rounding the resulting sum to the nearest smallest unit of the currency concerned.
A. The assets of the Corporation shall be deemed to include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all bills and demands notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all bonds, time notes, shares, stocks, debenture stocks, subscription rights, options and other investments and
securities owned or contracted for by the Corporation;
d) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the
Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights, or by similar practices);
e) all interest accrued of any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
68508
L
U X E M B O U R G
arrived at after making such discount as the Directors may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof.
2) The value of securities and/or money market instruments, which are quoted or dealt in on any stock exchange shall
be in respect of each security and/or money market instrument, the latest available publicized price, and where appro-
priate, the middle market price on the stock exchange which is normally the principal market for such security and/or
money market instrument.
3) Securities and/or money market instruments dealt in on another regulated market are valued in a manner as near
as possible to that described in the preceding sub-paragraph.
4) In the event that any of the securities and/or money market instruments held by any Portfolio on the relevant
valuation day are not quoted or dealt in on a stock exchange or another regulated market or, for any of the securities
and/or money market instruments, no price quotation is available, or if the price as determined pursuant to sub-paragraphs
2) and/or 3) is not in the opinion of the Directors representative of the fair market value of the relevant securities and/
or money market instruments, the value of such securities and/or money market instruments will be determined based
on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.
5) Investments in open-ended UCIs will be valued on the basis of the last available net asset value of the units or shares
of such UCIs.
6) All other assets will be valued at their respective fair values as determined in good faith by the Directors in accor-
dance with generally accepted valuation principles and procedures.
7) if any of the aforementioned valuation principles do not reflect the valuation method commonly used in specific
markets or if any such valuation principles do not seem accurate for the purpose of determining the value of the Cor-
poration's assets, the Board of Directors may fix different valuation principles in good faith and in accordance with
generally accepted valuation principles and procedures.
B. The liabilities of the Corporation shall be deemed to include:
a) all loans, bills and account payable;
b) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Corporation where the valuation day falls on the
record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
c) an appropriate provision for future taxed based on capital and income to the valuation day, as determined from
time to time by the Corporation, and other reserves if any authorized and approved by the Board of Directors; and
d) all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the
Corporation. In determining the amount of such liabilities the Corporation shall take into account all expenses payable
by the Corporation comprising formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers,
accountant, custodian, administrative, domiciliary, registrar and transfer agents, paying agents and permanent represen-
tatives in places of registration, any other agent employed by the Corporation, fees for legal and auditing services, stock
exchange listing costs, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or pre-
paring and printing of certificates, prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, taxes or govern-
mental charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges
and brokerage, postage, telephone and telex.
The Corporation may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated
figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.
C. The net assets of the Corporation shall mean the assets of the Corporation as herein above defined less the liabilities
as herein above defined, on the valuation day on which the Net Asset Value of the shares is determined. The capital of
the Corporation shall be at any time equal to the net assets of the Corporation. The net assets of the Corporation are
equal to the aggregate of the net assets of all Portfolios, such assets being converted into EUR when expressed in another
currency.
In relation between shareholders, each Class is treated as a separate legal entity.
With regard to third parties, the Corporation shall constitute one single legal entity, but by derogation from article
2093 of the Luxembourg Civil Code, the assets of a particular Class are only applicable to the debts, engagements and
obligations of that Class. The assets, commitments, charges and expenses which, due to their nature or as a result of a
provision of the Prospectus, cannot be allocated to one specific Class will be charged to the different Classes propor-
tionally to their respective net assets, or prorata to their respective net assets, if appropriate due to the amounts
considered.
D. Allocation of assets and liabilities:
The Board of Directors shall establish a portfolio of assets for each class of Shares in the following manner:
a) the proceeds from the issue of Shares of each class of Shares shall be applied in the books of the Corporation to
the portfolio of assets established for that class of shares and the assets and liabilities and income and expenditure
attributable thereto shall be applied to such portfolio, subject to the provisions of this Article;
68509
L
U X E M B O U R G
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Corporation
to the same portfolio as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease
in value shall be applied to the relevant portfolio;
c) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular portfolio or to any action taken
in connection with an asset of a particular portfolio, such liability will be allocated to the relevant portfolio. d) in the case
where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular portfolio, such
asset or liability shall be allocated to all portfolios in equal parts or, if the amounts so require, pro rata to the value of
the respective net assets of each portfolio.
e) upon the payment of the dividends to the shareholders in any class of shares, the Net Asset Value of such Category
of Shares shall be reduced by the amount of such dividends.
E. Pooling.
a) For the purpose of effective management and proper internal administrative, custodial and accounting treatment,
the Corporation may invest and manage all or part of the assets relating to two or more Portfolios on a pooled basis.
b) Such pools may not be considered as separate legal entities and any notional accounting units of a pool of assets
shall not be considered as shares. Shares of the Corporation do not relate to such pools of assets, but only to each
relevant Portfolio which may participate therein with certain assets for internal purposes stated above.
c) Any such asset pool(s) shall be formed by transferring from time to time from the participating Portfolios to the
pool(s) cash, securities or other permitted assets (subject to such assets being appropriate with respect to the investment
objective and policies of the relevant Portfolios). Thereafter, the Board of directors may from time to time make further
transfers to each asset pool. Assets may also be withdrawn from the asset pool and transferred back to the relevant
Portfolio up to their entitlement therein, which shall be measured by reference to notional accounting in the asset pool
(s).
d) Such accounting units shall upon the formation of the asset pool be expressed in EUR or in such currency as the
Board of directors shall consider appropriate and shall be allocated to each participating Portfolio in an aggregate value
equal to the cash, securities and/or other permitted assets contributed; the value of the notional accounting units of a
pool of assets shall be determined on each relevant valuation day by dividing its net assets (being its total asset less its
relating total liabilities) by the number of notional units issued and/or subsisting and shall be rounded to the nearest
fraction as determined by the Board of Directors.
e) When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an asset pool, the allocation of units of the
participating Portfolio concerned will be increased or reduced, as the case may be, by the number of units determined
by dividing the amounts of cash or the value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit. Where a
contribution is made in cash, it will be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the
Board of directors consider appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred
in investing the cash concerned; in the case of cash withdrawal, a corresponding addition will be made to reflect costs
which may be incurred in realizing securities or other assets of the asset pool.
f) Dividends, interest and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an asset pool
may be immediately credited to the participating Portfolios in proportion to their respective participation in the assets
pool at the time of receipt. Upon the dissolution of the Corporation, the assets in an asset pool will (subject to the claims
of the creditors) be allocated to the participating Portfolios in proportion to their respective participation in the asset
pool.
F. For the purposes of this Article:
a) Shares of the Corporation to be redeemed under Article twenty-two hereof shall be treated as existing and taken
into account until immediately after the close of business on the valuation day referred to in this Article, and from such
time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;
b) Shares to be issued by the Corporation pursuant to the subscription applications received shall be treated as being
in issue as from the close of business on the valuation day referred to in this Article and such price, until received by the
Corporation, shall be deemed a debt due to the Corporation;
c) all investments, cash balances and other assets of the Corporation shall be valued after taking into account the
market rates or rates of exchange in force at the date for determination of the net asset value of Shares; and
d) effect shall be given on any valuation day to any purchases or sales of securities contracted for by the Corporation
on such valuation day, to the extent practicable.
Art. 25. Whenever the Corporation shall offer Shares for subscription, the price per share at which such Shares shall
be offered and sold, shall be the Net Asset Value per Share as herein above defined for the relevant Class and Category
plus such commission (including but not limited to the dilution levy as described hereafter) as the sales documents may
provide. Any remuneration to agents active in the placing of shares shall be paid out of such commission. The price so
determined shall be payable not later than 5 bank business days in Luxembourg after the relevant day.
A dilution levy may be imposed on shareholder transactions as specified in the sales documents of the Corporation.
Such dilution levy should not exceed a certain percentage of the net asset value determined from time to time by the
Board of Directors and disclosed in the sales documents of the Corporation. This dilution levy will be calculated taking
68510
L
U X E M B O U R G
into account the estimated costs, expenses and potential impact on security prices that may be incurred to meet sale and
switch instructions.
Art. 26. The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January in each year and shall terminate
on the last day of December of the same year.
Art. 27. For each Category of shares of any Class adopting a policy of dividend distribution, the general meeting of
shareholders may, upon the proposal of the Board of Directors and within the limits provided by law, resolve a distribution
of dividends to shareholders concerned.
The Board of Directors may also declare interim dividends in respect of any Category of Shares of any class adopting
a policy of dividend distribution.
Any resolution of a general meeting of shareholders deciding whether or not, dividends are to be distributed to
shareholders of any Category of Shares of any Class, shall, in addition, be subject to a prior vote to shareholders of the
relevant Category of Shares of a Class, in accordance with Article eleven here above.
No distribution of dividends may be made if as a result thereof the Capital of the Corporation would become less
than the minimum prescribed by law.
For the Categories of Shares for which the Board of Directors does not intend the payment of a dividend, no dividend
declaration will be made.
Art. 28. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the
Luxembourg Law of 2010.
The net proceeds of liquidation corresponding to Shares of the respective Categories and Classes shall be distributed
by the liquidators to the holders of Shares of such Category and Classes in proportion of their holding of Shares therein.
Liquidation proceeds not claimed by the Shareholders at the close of the liquidation shall be deposited for the persons
entitled thereto at the Caisse de Consignation in Luxembourg. If not claimed, they shall be forfeited in accordance with
Luxembourg law.
Art. 29. The Articles of Incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders, subject
to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Any amendment affecting the rights of the holders of Shares of any Category and Class vis-à-vis those of any other
Category and Class shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant
Category and Class as far as the shareholders of the relevant Category and Class are present or represented.
Art. 30. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the
Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto and the Luxembourg Law of
2010.
The Meeting noted that the French translation of the Articles is not required anymore in accordance with Article 26
(2) of the 2010 Law and therefore no French translation of this deed will follow the English version.
There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English only in accordance with Article 26 (2) of the 2010 Law.
Whereof, the present notarial deed is drawn in [Luxembourg], on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the parties appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Signé: M.J. FERNANDES, S. DASSENOY, B. POUJOL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 juin 2013. Relation: EAC/2013/7176. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2013076693/801.
(130094069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2013.
Fill Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1713 Luxembourg, 217, rue de Hamm.
R.C.S. Luxembourg B 145.949.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013050588/9.
(130061860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.
68511
L
U X E M B O U R G
Saturne Sicav, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 157.264.
Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2013.
<i>Pour SATURNE SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Corinne ALEXANDRE / Marc-André BECHET
<i>- / Directeuri>
Référence de publication: 2013050900/15.
(130062325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.
Sat-Elec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5410 Beyren, 4, rue Hiel.
R.C.S. Luxembourg B 165.426.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013050874/9.
(130061886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.
Senslight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.724.
Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Sasa MIHAILOVIC
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2013050877/11.
(130061922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.
Wahoo Atlanticus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 176.092.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 7 mars 2013i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a été révoqué de son mandat de gérant de catégorie A.
2. Monsieur José Carlos REIS DE MAGALHAES NETO, né à Sao Paulo (Brésil), le 21 janvier 1978, demeurant pro-
fessionnellement à 01451-011 Sao Paulo (Brésil), Rua Iguatemi, 151, 23
ème
étage, a été nommé comme gérant de catégorie
A pour une durée indéterminée.
3. Monsieur Mark VRIJHOEF, administrateur de sociétés, né à Zaanstad (Pays-Bas), le 12 septembre 1974, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
catégorie B pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26 avril 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Wahoo Atlanticus S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013054413/19.
(130066613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
68512
L
U X E M B O U R G
Viande - Luxembourg, Société Anonyme, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 38.081.
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenant lieu d’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 14 marsi>
<i>2013i>
Les actionnaires de la société VIANDE-LUXEMBOURG S.A. réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 14 mars
2013, ont décidé à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
L’Assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs de:
- Monsieur Rik RENMANS, administrateur de société, demeurant à B-1653 Beersel, Beukenlaan 50
- Monsieur Nicolas RENMANS, administrateur de société, demeurant à B-1840 Londerzeel, Stuikberg 134
- Monsieur Richard BOVY, administrateur de sociétés, demeurant à B-7000, Mons, 40 rue Guy de Brès
étant arrivés à échéance, ils sont renouvelés pour une période de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2019.
D’autre part,
- Monsieur Rik RENMANS, administrateur de société, demeurant à B-1653 Beersel, Beukenlaan 50
est reconduit dans ses mandats d'administrateur-délégué et de président du conseil d'administration de la société
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.
Par ailleurs, le mandat du commissaire aux comptes de la société, à savoir:
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 25.797 étant
arrivé à échéance, il est renouvelé pour une période de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2019.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 14 mars 2013.
Référence de publication: 2013054410/27.
(130066259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
BNP Paribas L1, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 32.327.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 avril 2013 a décidé les résolutions suivantes:
Elle renouvelle les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Philippe MARCHESSAUX, Président du Conseil d’Administration
- Monsieur Marnix ARICKX, Administrateur,
- Monsieur Vincent CAMERLYNCK, Administrateur,
- Monsieur Christian DARGNAT, Administrateur,
- Monsieur Marianne DEMARCHI, Administrateur,
- Monsieur William DE VIJLDER, Administrateur,
- Monsieur Andrea FAVALORO, Administrateur,
- Monsieur Anthony FINAN, Administrateur,
- Monsieur Marc RAYNAUD, Administrateur,
- Monsieur Christian VOLLE, Administrateur
pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en
2014.
L'Assemblée Générale a reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en sa qualité de Réviseur d'Entre-
prises de la Société pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
en 2014.
Pour extrait conforme
BNP PARIBAS L1
Référence de publication: 2013054555/27.
(130067176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
68513
L
U X E M B O U R G
Iso Deco Heinen Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8551 Noerdange, 3, Niederpallenstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 176.783.
STATUTS
L'an deux mil treize, le dix-huit avril.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Madame Claudine PHILIPPY, infirmière, née le 5 mars 1955 à Arlon (Belgique), demeurant à L-8551 Noerdange, 3
Niederpallenstrooss.
2) Monsieur Nils HEINEN, menuisier, né le 11 janvier 1990 à Messancy (Belgique), demeurant à B-6700 Arlon, rue du
Walschbour 40.
Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la pose et le montage d'éléments préfabriqués et de parquets, le montage d'échafaudage,
la menuiserie ainsi que la peinture.
Elle a également pour objet toutes activités artisanales diverses travaillant le bois et la peinture.
La société peut faire toutes opérations industrielles, civiles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet social précité ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le
développement tant sur le marché national qu'international.
Art. 3. La société prend la dénomination de «ISO DECO HEINEN Sàrl», société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Beckerich.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-€) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.-€) chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l'assemblée des associés.
L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
68514
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mil treize.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Madame Claudine PHILIPPY, infirmière, née le 5 mars 1955 à Arlon (Belgique),
demeurant à L-8551 Noerdange, 3 Niederpallenstrooss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 parts
2) Monsieur Nils HEINEN, menuisier, né le 11 janvier 1990 à Messancy (Belgique),
demeurant à B-6700 Arlon, rue du Walschbour 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Toutes les parts ont été entièrement libérées par des apports en nature constitués par:
- une remorque de type Walt TD 1,500 N° châssis 3524081125, évaluée à la somme de mille euros (1.000,- €);
- un échafaudage Altrex 2x245cm et garde corps, évalué à la somme de cinq mille euros (5.000,- €);
- un appareil de marque Storch pour découpe à bois, évalué à la somme de mille cinq cents euros (1.500,- €);
- un combiné à bois de marque Robland, évalué à la somme de deux mille euros (2.000,- €);
- un lot de petit matériel évalué forfaitairement à une valeur de trois mille euros (3.000,- €), ce lot comprenant une
tronçonneuse Dolmar Ps 400, un mélangeur béton 1200 W, un nettoyeur haute pression K 4,600 MD, un nettoyeur
haute pression Bosch Aquatac 160 Prox, un nettoyeur haute pression Bosch Aquatac 150 Prox, une fraiseuse domino,
un porte outil Calibrer et roulement, un compresseur Ironside, un aspirateur Spa 1200 et un lot d'outils et pinceaux.
Les apports en nature ci-avant défini sont évalués aux montants respectifs suivant factures annexées aux présentes.
Les associés certifient la valeur réelle des éléments apportés et donnent pleine et entière décharge au notaire instru-
mentant à cet égard et s'engagent à faire toutes démarches administratives ou autres aux fins de valider l'apport
présentement effectué.
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille trois cent cinquante euros (1.350,-
euros). A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au
paiement des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du
capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et,
après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à un:
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Nils HEINEN, menuisier, né le 11 janvier 1990 à Messancy (Belgique), demeurant à B-6700 Arlon, rue du
Walschbour 40.
68515
L
U X E M B O U R G
La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du
gérant unique.
3. L'adresse de la société est fixée à L-8551 Noerdange, 3 Niederpallenstrooss.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale
peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société pré-
sentement constituée.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signés: C. PHILIPPY, N. HEINEN, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 avril 2013. Relation: EAC/2013/5249. Reçu soixante-quinze euros 75,-
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME.
PETANGE, LE 23 avril 2013.
Référence de publication: 2013052739/120.
(130064741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.
Avenue Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 9-11, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 139.232.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 15 mars 2013, que:
Le siège social de la Société est transféré du L-1920 Luxembourg, 1, Avenue Gaston Diderich vers l’adresse suivante:
L-2227 Luxembourg, 9-11, Avenue de la Porte Neuve avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 mars 2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>L. Neuhengen
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013052392/15.
(130064568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.
Deutsche Post Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 28.411.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 25 avril 2013 Au siège social, 74, rue de Merl L-2146i>
<i>Luxembourg à 15.00 heuresi>
1) L'Assemblée décide de nommer comme administrateurs:
- Mr Geoff Cruikshanks, Deutsche Post Headquarters, ZB71, Charles-de-Gaullestrasse 20, 53250 Bonn, Allemagne,
Président;
- Mr Hugh O'Neill, DHL GBS (UK) Limited, 61 Queen Street, 5
th
Floor London, EC4R 1AF, Administrateur;
- Mr Mark Jones, DHL GBS (UK) Limited, 61 Queen Street, 5
th
Floor London, EC4R 1AF, Administrateur;
- Mr Bill Fitzpatrick, 24 Garrick Close, Hersham, Walton On Thames, Surrey KT12 5PA, Royaume Uni, Administrateur;
- Mr Lars Landewee, Bergwiese 10, 53343 Wachtberg, Allemagne, Administrateur;
- Mr Claude Weber, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Administrateur;
Leur mandai viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2014 délibérant sur les comptes
annuels de 2013.
2) L'Assemblée nomme comme réviseur d'entreprises indépendant
PriceWaterHouseCoopers, 400 route d'Esch L-1014 LUXEMBOURG.
Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2014 délibérant sur les comptes
annuels de 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
68516
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013054611/27.
(130067331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
Trufidee, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 1.363.
Le bilan de Sofina S.A. du 31.12.2012 et la déclaration d'accord conformément à l'article 70 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013054389/10.
(130066278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
Trufilux, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 94.345.
Le bilan de Sofina S.A. du 31.12.2012 la déclaration d'accord conformément à l'article 70 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013054390/10.
(130066280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
PAMM Consulting, Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 176.778.
STATUTS
L'an deux mille treize, le dix-septième jour du mois d'avril.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. Monsieur Paul DE COOMAN, retraité, né le 29 août 1950 à La Louvière (Belgique), demeurant à L-1750 Luxem-
bourg, 24, avenue Victor Hugo («l'usufruitier»);
2. Madame Monique WERY, retraitée, née le 16 mai 1949 à Haine-Saint-Paul (Belgique), demeurant à L-1750 Luxem-
bourg, 24, avenue Victor Hugo («l'usufruitier»),
ici représenté par Monsieur Paul DE COOMAN, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en
date du 20 mars 2013;
3. Monsieur Mathieu DE COOMAN, indépendant, né le 19 janvier 1977 à La Louvière (Belgique), demeurant à B-1410
Waterloo, 18, avenue Alexandre Dumas («le nu-propriétaire»),
ici représenté par Monsieur Paul DE COOMAN, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en
date du 20 mars 2013;
4. Madame Amélie DE COOMAN, infirmière, née le 12 juillet 1974 à Haine-Saint-Paul (Belgique), demeurant à B-5101
Erpent, 4, allée des Chanterelles («le nu-propriétaire»),
ici représentée par Monsieur Paul DE COOMAN, pré-qualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé
en date du 19 mars 2013.
Lesdites procurations, après signature «ne varietur» par le comparant présent et mandataire des autres parties com-
parantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les
présents statuts («les Statuts»).
68517
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination «PAMM Consulting».
Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d'adminis-
tration, et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Objet. La Société a pour objet d'exercer les activités de consultance en management.
La Société a également pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers.
La Société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute
société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.
La Société pourra exercer des fonctions d'administrateur dans d'autres sociétés.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter ou favoriser la réalisation.
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par
trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Prime d'émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront
transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.
Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société
a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s)
ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.
Art. 8. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions sont émises sans valeur nominale.
En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre
énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur
chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit
de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Les actions peuvent faire l'objet d'un démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété), soit à la souscription, soit
par constitution d'un usufruit par un associé sur une ou plusieurs actions qu'il détient.
En cas de démembrement des actions, l'usufruitier aura les droits d'usufruit des actions, ce qui inclut tous les droits
rattachés à la qualité d'actionnaire de la Société, notamment:
- le droit aux dividendes;
- le droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires;
- le droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital social;
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque action sont ceux qui sont déterminés par
le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société, étant précisé que l'usufruitier con-
servera son droit d'usufruit sur le produit de la liquidation par subrogation.
68518
L
U X E M B O U R G
La titularité de l'usufruit et de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
a) Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l'usufruitier de la mention «usufruit»;
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention «nue-propriété».
b) Si les actions sont au porteur:
- les actions démembrées seront déposées auprès d'un tiers séquestre, désigné de commun accord par le nu-pro-
priétaire et l'usufruitier.
Ce tiers séquestre aura la charge de vérifier la correcte application des dispositions relatives aux droits attachés à la
qualité de nu-propriétaire et d'usufruitier.
Art. 9. Composition du Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration com-
posé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à
un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un associé.
Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat
qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment
par une résolution des actionnaire(s).
Art. 10. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent
de la compétence du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et
à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.
Art. 11. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature
individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la
signature conjointe d'au moins deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce
qui concerne la gestion journalière.
La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la
signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 12. Acompte sur dividende. Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base
d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices
reportés ainsi que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi
que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.
Art. 13. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil de d'Administration nommera parmi ses membres un
président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des
procès-verbaux du Conseil d'Administration.
Le Conseil de d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et
date indiqués dans la convocation.
Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir
été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit
en original, par fax ou par e-mail.
Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués
dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-
tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit,
transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme
son mandataire.
68519
L
U X E M B O U R G
Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Adminis-
tration.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément les unes avec les autres.
Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si
elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par
un ou plusieurs administrateurs.
Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en
fonction est présente ou représentée.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Art. 14. Rémunération et Débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent
recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 15. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une
transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part
aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.
Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Art. 16. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas
leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.
Art. 17. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans,
rééligibles et toujours révocables.
Art. 18. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée
générale des actionnaires.
Art. 19. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la
Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois de juin à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 20. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social
ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les
Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement,
des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un
texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.
Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts
ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modifi-
cation des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre
d'actions représentées.
Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont
l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum
68520
L
U X E M B O U R G
sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au
moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les
résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.
Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Art. 22. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Adminis-
tration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux
Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.
Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.
Art. 23. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-
tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale
(«la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).
Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale
atteindra dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 24. Affectations des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du
solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en
le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission
aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Art. 25. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de Statuts.
Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés
par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de
liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).
Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions
suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.
Art. 26. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Dispositions transitoiresi>
(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2014.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés, déclarent sou-
scrire intégralement les trois cent dix (310) actions comme suit:
1) Usufruit:
- Monsieur Paul DE COOMAN, pré-qualifié, usufruitier de cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
- Madame Monique WERY, pré-qualifiée, usufruitier de cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions en usufruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
2) Nue-propriété
- Monsieur Mathieu DE COOMAN, pré-qualifié, nu-propriétaire de cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . 155
- Mademoiselle Amélie DE COOMAN, pré-qualifiée, nu-propriétaire de cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions en nue-propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Les actions ont été libérées à hauteur de 25% par les comparants par des versements en espèces, de sorte que la
somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société,
preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant.
68521
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants pré-qualifiés, présents ou représentés, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant
qu'actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4), celui des administrateurs-délégués à un (1) et celui des com-
missaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Paul DE COOMAN, retraité, né le 29 août 1950 à La Louvière (Belgique), demeurant à L-1750 Luxembourg,
24, avenue Victor Hugo;
- Madame Monique WERY, retraitée, née le 16 mai 1949 à Haine-Saint-Paul (Belgique), demeurant à L-1750 Luxem-
bourg, 24, avenue Victor Hugo;
- Monsieur Mathieu DE COOMAN, indépendant, né le 19 janvier 1977 à La Louvière (Belgique), demeurant à B-1410
Waterloo, 18, avenue Alexandre Dumas;
- Mademoiselle Amélie DE COOMAN, infirmière, née le 12 juillet 1974 à Haine-Saint-Paul (Belgique), demeurant à
B-5101 Erpent, 4, allée des Chanterelles.
L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Paul DE COOMAN aux fonctions de président du conseil
d'administration.
3. A été appelé aux fonctions d'administrateur-délégué:
- Monsieur Paul DE COOMAN, retraité, né le 29 août 1950 à La Louvière (Belgique), demeurant à L-1750 Luxembourg,
24, avenue Victor Hugo.
4. La durée du mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué prendra fin à l'assemblée générale des ac-
tionnaires qui se tiendra en l'an 2017.
5. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui
concerne la gestion journalière.
6. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Jacques DECHARNEUX, pré retraité, né le 21 décembre 1948 à Liège (Belgique), demeurant à B-1450
Chastre, 23, Chemin Mahy.
7. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en l'an 2017.
8. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-1750 Luxembourg, 24, Avenue Victor Hugo.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. DE COOMAN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 18 avril 2013. Relation: DIE/2013/4913. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): pd: RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 24 avril 2013.
Référence de publication: 2013052920/293.
(130064699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.
Top Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 90.536.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
68522
L
U X E M B O U R G
D. FONTAINE
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2013054385/11.
(130066611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
TreeTop Scolea SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 134.098.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2013.
<i>Pour TreeTop Scolea SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Corinne ALEXANDRE / Marc-André BECHET
<i>- / Directeuri>
Référence de publication: 2013054372/15.
(130066105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
TreeTop Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.731.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2013.
<i>Pour TreeTop Portfolio SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Corinne ALEXANDRE / Marc-André BECHET
<i>- / Directeuri>
Référence de publication: 2013054369/15.
(130066131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
Viking Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 68.237.
In the year two thousand and thirteen.
On the ninth day of April.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
Mr. Dag LANDVIK, born in Oscar, Stockholm (Sweden), on July 27, 1943, residing in S-13237 Saltsjô-boo (Sweden),
49, Vikingshillvàgen,
represented by Mrs. Ekaterina DUBLET, jurist, residing professionally in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg),
by virtue of powers substituted to her.
Such powers, after having been signed "ne varietur" by the notary and the empowered, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
The appearing party, represented as above stated, declared and requested the notary to act:
I.- That the appearing party is the sole present partner of the private limited company (société à responsabilité limitée)
"VIKING INVESTMENTS S.à r.l.", having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 68237, incorporated by deed of the undersigned notary, on December
30, 1998, published in the Mémorial C number 262 of April 15, 1999, and whose articles of association have been amended
for the last time by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg), on
February 12, 1999, published in the Mémorial C number 338 of May 12, 1999,
68523
L
U X E M B O U R G
II.- That the appearing party has taken the following sole resolution:
<i>Sole resolutioni>
The appearing party decides to adopt an accounting year that shall henceforth begin on May 1
st
and end on April 30
of the following year, acknowledges that as an exception, the accounting year which has begun on January 1
st
, 2013 will
end on April 30, 2013, and decides to amend subsequently article 16 of the articles of association which will have hen-
ceforth the following wording:
" Art. 16. The fiscal year shall begin on the first of May and terminate on the thirtieth of April of the following year.".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately nine hundred fifty Euro (EUR 950,-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the empowered, known to the notary by her surname, Christian name, civil status
and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille treize.
Le neuf avril.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Monsieur Dag LANDVIK, né à Oscar, Stockholm (Suède), le 27 juillet 1943, demeurant à S-13237 Saltsjô-boo (Suède),
49, Vikingshillvàgen,
représenté par Madame Ekaterina DUBLET, juriste, ayant son domicile professionnel à Junglinster (Grand-Duché de
Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé, lui subsitituée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et la mandataire comparante, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée "VIKING INVESTMENTS
S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 68237, constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial
C numéro 262 du 15 avril 1999, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Jean-Joseph
WAGNER, notaire de résidence à Belvaux (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 12 février 1999, publié au Mémorial
C numéro 338 du 12 mai 1999,
II.- Que le comparant a pris la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
Le comparant décide d'adopter un exercice social commençant le 1
er
mai et se terminant le 30 avril de l'année suivante,
constate qu'exceptionnellement, l'exercice social en cours, lequel a commencé le 1
er
janvier 2013, prendra fin le 30 avril
2013, et décide de modifier dès lors l'article 16 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 16. L'année sociale commence le premier mai et finit le trente avril de l'année suivante.".
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de neuf cent
cinquante Euros (EUR 950,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
68524
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire comparante, connue du notaire par son nom, prénom
usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Ekaterina DUBLET, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 avril 2013. Relation GRE/2013/1591. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013053690/78.
(130065349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.
Vader S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 159.682.
Les comptes annuels au 30 Septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Vader S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013054398/11.
(130066168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
Vattenfall Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 49.528.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 10 avril 2013i>
L'Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Berndt KOCKUM, demeurant professionnellement Evenmangsgatan 13, Solna, SE-169 92 Stockholm, Suède
- Monsieur Johan GYLLENHOFF, demeurant professionnellement Evenmangsgatan 13, Solna, SE-169 92 Stockholm,
Suède
- Monsieur Thomas WRANDE, demeurant professionnellement Evenmangsgatan 13, Solna, SE-169 92 Stockholm,
Suède
L’Assemblée élit comme nouvel Administrateur:
- M. Thomas HALLQVIST, demeurant professionnellement Evenmangsgatan 13, Solna,SE- 169 92 Stockholm, Suède
Leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2013.
L’Assemblée nomme comme Réviseur d'Entreprise Indépendant jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui
statuera sur les comptes au 31 décembre 2013:
ERNST & YOUNG
7, Parc d’Activité Syrdall
L-5365 Munsbach
<i>Pour la société VATTENFALL REINSURANCE S.A.
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013054405/24.
(130066216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
Fngrade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 113.727.
<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration prises en date du 25 mars 2013i>
Il résulte des résolutions écrites du Conseil d'administration tenu en date du 25 mars 2013, que:
Après avoir constaté que Monsieur Andrea La Magra s'est démis de ses fonctions d'Administrateur, en date du 25
mars 2013, les Administrateurs restants décident, conformément aux statuts de la Société et à l'article 51 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de coopter Madame Magali Fetique, employée privée, née à Metz (France)
le 1
er
février 1981, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,
68525
L
U X E M B O U R G
en tant qu'Administrateur de la Société, avec effet au 25 mars 2013, en remplacement de Monsieur Andrea La Magra,
Administrateur démissionnaire, dont elle achèvera le mandat.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par résolutions de l'actionnaire unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2013.
FNGRADE S.A.
Référence de publication: 2013054679/19.
(130067455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
Glenda 1980 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 174.299.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2013.
Référence de publication: 2013054711/10.
(130067252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
Göta Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 46.444.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le mercredi 10 avril 2013 à 16.00 heures au 74, rue de Merl,i>
<i>L-2146 Luxembourg.i>
- L'Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
* Mr. Leif Pagrotsky
* Mr. Roland Rydin
* Mr. Peter Krantz
Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2014 et qui aura à statuer sur les comptes
de l'exercice de 2013.
- L'Assemblée nomme Deloitte S.A. comme Réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à
l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2014 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice de 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013054710/21.
(130067354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
Forest Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 115.201.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2013.
Référence de publication: 2013054671/11.
(130067117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
68526
L
U X E M B O U R G
Fluid Movement Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 53.501.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fluid Movement Investment S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013054684/12.
(130067404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
UTI Investment Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 112.413.
Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013054397/12.
(130066515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
BRE/Management 5 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 151.600.
In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of the month of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
was held an extraordinary general meeting of the société anonyme BRE/Management 5 S.A. (the "Company") having
its registered office in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated by deed before Maître Francis Kessler,
notary, residing in Esch-sur-Alzette, on 18
th
February 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (the "Mémorial"), number 744 on 9
th
May 2010. The articles of incorporation of the Company have never been
amended (the "Articles").
The meeting was presided by Mr. Régis Galiotto, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs. Solange Wolter, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Joe Zeaiter, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
II. This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration
authorities.
III. It appears from the said attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and
that the shareholders declare having been duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted
and may validly deliberate on the agenda set out below:
<i>Agendai>
1. Amendment of the first paragraph of article 9 of the Articles so as to read as follows:
"The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not be
shareholders of the Company. The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine
their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the
directors shall hold office until their successors are elected."
68527
L
U X E M B O U R G
2. Renewal of the mandates of each of Mrs Diana Hoffmann, Mr Jean-François Bossy, Mr Robert W. Simon and Mr
Dennis J. McDonagh, as directors of the Company, for a period of six (6) years from the date hereabove mentioned.
After deliberation the sole shareholder passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to amend the 1
st
paragraph of article 9 of the Articles so as to read as set forth in the
agenda above.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to renew the mandates of each of:
- Mrs Diana Hoffmann, born on 18
th
March 1971 in Guben, Germany and having her professional address at 2-4, rue
Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Mr Jean-François Bossy, born on 10
th
May 1975 in Rocourt, Belgium and having his professional address at 2-4, rue
Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Mr Robert W. Simon, born on 20
th
February 1929 and having his professional address at 2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg; and
- Mr Dennis J. McDonagh, born on 10
th
April 1956 and having his professional address at Park Avenue 345 New York
10154 UNITED STATES,
as directors of the Company, for a period of six (6) years from the date hereabove mentioned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the appearing parties
hereto, this deed is drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party in case
of discrepancies between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading this deed the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BRE/Management 5 S.A. (la «Société») avec
siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, constituée suivant acte passé par-devant Maître Francis
Kessler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, le 18 février 2010 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (le «Mémorial»), numéro 744 du 9 mai 2010. Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés (les «Statuts»).
L'assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Madame Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Joe Zeaiter, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre d'actions détenus par chacun d'entre eux figurent sur la liste de présence,
signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.
II. Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte, pour être soumises avec
lui aux formalités de l'enregistrement.
III. Il ressort de ladite liste de présence que l'entièreté du capital social était représentée à cette assemblée et que les
actionnaires déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de sorte que la présente assemblée est régulièrement
constituée et peut régulièrement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour décrit ci-après:
<i>Agendai>
1. Modification du 1
er
paragraphe de l'article 9 des Statuts pour prendre la teneur suivante:
"La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin
d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur
nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas
six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus."
2. Renouvellement du mandat de Mme Diana Hoffmann, M. Jean- François Bossy, M. Robert W. Simon et M. Dennis
J. McDonagh, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date susmentionnée et pour une période de six (6)
ans.
Après délibération l'associé unique a adopté les résolutions suivantes:
68528
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de modifier le 1
er
paragraphe de l'article 9 des Statuts pour prendre la teneur telle que
décrite à l'agenda ci-dessus.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de:
- Madame Diana Hoffmann, née le 18 mars 1971 à Guben, Allemagne et ayant son adresse professionnelle à 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Jean-François Bossy, né à 10 mai 1975 à Rocourt, Belgique et ayant son adresse professionnelle à 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Robert W. Simon, né le 20 février 1929 à Wiesbaden, Allemagne et ayant son adresse professionnelle à
2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg; et
- Monsieur Dennis J. McDonagh, né le 10 avril 1956 à New-York, Etas-Unis et ayant son adresse professionnelle Park
Avenue 345 New York 10154 Etats-Unis,
en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date susmentionnée et pour une période de six (6) ans.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties
comparantes, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de ce procès-verbal, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
signé: S. WOLTER, J. ZEAITER, R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 avril 2013. Relation: LAC/2013/18263. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2013.
Référence de publication: 2013053239/107.
(130065151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.
Flying Wings AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 152.631.
L'an deux mil treize, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de «FLYING WINGS AG» (la Société),
une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est fixé à L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.631.
La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 mars 2010, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1159 du 3 juin 2010 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Michael RENNIG, administrateur de société, demeurant à D-66540 Neunkir-
chen, 10, Schiffweilerstrasse,
qui désigne comme Secrétaire Madame Véronique GILSON-BARATON, clerc de notaire, demeurant à Garnich.
L'Assemblée choisit comme Scrutateur Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
(le Président, le Secrétaire et le Scrutateur formant ensemble le Bureau).
Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée, après avoir été signées ne varietur par le notaire et les
comparants, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec l'acte auprès des autorités compétentes.
Le Bureau étant ainsi constitué, le Président a exposé et a prié le notaire d'acter:
Qu'il résulte d'une liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que 3.100 (trois mille cent) actions
ayant une valeur nominale de € 10 chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société s'élevant à € 31.000,-
sont dûment représentées à l'Assemblée qui est dès lors valablement constituée et peut délibérer sur les points portés
à l'ordre du jour, tels que mentionnés ci-après, et ce, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à l'As-
semblée ayant accepté de tenir l'Assemblée après examen de l'ordre du jour.
La liste de présence qui a été signée par l'ensemble des actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau
et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être soumise avec la procuration aux formalités d'en-
registrement.
68529
L
U X E M B O U R G
Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes, approuvées à l'unanimité:
1. Le projet de scission soumis à l'approbation de la présente assemblée générale a été publié au Mémorial C numéro
3038 du 17 décembre 2012.
2. L'assemblée entend le rapport du conseil d'administration de la société FLYING WINGS AG sur le projet de scission.
3. L'assemblée approuve les comptes intermédiaires arrêtés au 30 septembre 2012 tels qu'ils ont été annexés au projet
de scission publié comme dit ci-avant.
4. L'assemblée donne décharge de leurs mandats aux administrateurs et au commissaire de la société FLYING WINGS
AG pour l'exercice de leurs mandats
5. L'assemblée approuve le projet de scission tel qu'il a été publié au Mémorial C numéro 3038 du 17 décembre 2012
en conformité avec l'article 290 de la loi sur les sociétés commerciales.
L'assemblée générale constate qu'ainsi la scission de la société, par laquelle celle-ci transfère par suite de sa dissolution
sans liquidation l'universalité de son patrimoine actif et passif, sans exception ni réserve, aux deux sociétés nouvellement
constituées sous les dénominations de FLYING WINGS FRAPORT s.à r.l. et FLYING WINGS GERMANY s.à r.l., devient
effective à compter de ce jour.
D'un point de vue comptable, les opérations de la société scindée sont considérées comme accomplies pour le compte
des deux nouvelles sociétés à partir de ce jour.
Les nouvelles parts sont attribuées sans soulte aux actionnaires de la société scindée à raison d'une part nouvelle dans
chacune des nouvelles sociétés pour une action de la société scindée.
L'assemblée générale approuve l'apport et la répartition des éléments actifs et passifs du patrimoine total de la société
aux deux sociétés nouvelles, tels que proposés dans le projet de scission.
7. L'assemblée générale approuve la constitution sous forme authentique des deux sociétés à responsabilité limitée
nouvelles et leurs statuts tels que proposés dans le projet de scission; elle requiert le notaire instrumentant de constater
authentiquement la constitution de ces deux nouvelles sociétés ainsi que leurs statuts comme suit:
1. FLYING WINGS FRAPORT S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
(Capital: EUR 12.500.-)
Siège social: 20, rue de l'Eau
L-1449 Luxembourg
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a encore pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière, et notamment le développement ainsi que l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur
de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter, de même que l'octroi
aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes
opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d'émission
et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.
La société aura encore pour objet la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son
compte propre. Elle pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution
réelle d'engagement en faveur de tiers.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de «FLYING WINGS FRAPORT S.à r.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- €) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- €) chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
68530
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés dur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l'assemblée des associés.
L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Libération - Souscriptioni>
Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au
moyen d'un certificat bancaire au notaire qui le constate expressément, en sus de l'apport de la société scindée et toutes
souscrites par l'associée unique: la société de droit luxembourgeois SELECTA-EUROPEAN FRANCHISE DISTRIBUTION
SYSTEMS AG en abrégé SEFRADIS avec siège à L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil treize.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du
capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et,
après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes
1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Michael RENNIG, administrateur de société, né à Ottweiler, Allemagne, le 4 octobre 1970, demeurant à
D-66540 Neunkirchen, 10, Schiffweilerstrasse.
La société est engagée en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du
gérant.
3. L'adresse de la société est fixée à L-1449 Luxembourg, 20 rue de l'Eau.
2. FLYING WINGS GERMANY S.à rl. Société à responsabilité limitée (Capital: EUR 12.500.-)
Siège social: 20, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
68531
L
U X E M B O U R G
Art. 2. La société a encore pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière, et notamment le développement ainsi que l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur
de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter, de même que l'octroi
aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes
opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d'émission
et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.
La société aura encore pour objet la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son
compte propre. Elle pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution
réelle d'engagement en faveur de tiers.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de «FLYING WINGS GERMANY S.à r.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- €) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- €) chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés dur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l'assemblée des associés.
L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
68532
L
U X E M B O U R G
<i>Libération - Souscriptioni>
Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au
moyen d'un certificat bancaire au notaire qui le constate expressément, en sus de l'apport de la société scindée et toutes
souscrites par l'associée unique: la société de droit luxembourgeois SELECTA-EUROPEAN FRANCHISE DISTRIBUTION
SYSTEMS AG en abrégé SEFRADIS avec siège à L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du
capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et,
après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes
1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Michael RENNIG, administrateur de société, né à Ottweiler, Allemagne, le 4 octobre 1970, demeurant à
D-66540 Neunkirchen, 10, Schiffweilerstrasse.
La société est engagée en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du
gérant.
3. L'adresse de la société est fixée à L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.
<i>Constatationi>
L'assemblée constate que la scission est réalisée au sens de l'article 301 de la loi sur les sociétés commerciales avec
effet à ce jour, sans préjudice des dispositions de l'article 302 de ladite loi sur l'effet de la scission vis-à-vis des tiers.
Elle constate encore la dissolution sans liquidation de la société suite à la réalisation de la scission suivant les modalités
décrites dans le projet de scission.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales
avoir vérifié et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée ainsi que du projet
de fusion.
La scission de la société par l'apport de l'universalité de son patrimoine actif et passif aux deux nouvelles sociétés est
faite en application de l'article 4-1 de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les
rassemblements de capitaux.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison des présentes à la somme de €
Ensuite, l'associée unique des deux nouvelles sociétés s'est constituée en deux assemblées générales distinctes et a
pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
Pour FLYING WINGS FRAPORT s.à r.l.
1- Le premier exercice commence le jour de la scission et se termine le 31 décembre 2013.
2- Le siège social est fixé à L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.
3- Le nombre des gérants est fixé à un.
4- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Michael RENNIG, administrateur de société, né à Ott-
weiler, Allemagne, le 4 octobre 1970, demeurant à D-66540 Neunkirchen, 10, Schiffweilerstrasse.
5- La société est engagée en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle
du gérant.
6. L'assemblée ratifie tous les actes passés au nom et pour le compte de FLYING WINGS FRAPORT s.à r.l. avant les
présentes.
Pour FLYING WINGS GERMANY s.à r.l.:
1. Le premier exercice commence le jour de la scission et se termine le 31 décembre 2013.
2. Le siège social est fixé à L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.
3. Le nombre des gérants est fixé à un.
4. Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Michael RENNIG, administrateur de société, né à Ott-
weiler, Allemagne, le 04 octobre 1970, demeurant à D-66540 Neunkirchen, 10, Schiffweilerstrasse.
5. La société est engagée en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle
du gérant.
6. L'assemblée ratifie tous les actes passés au nom et pour le compte de FLYING WINGS GERMANY s.à r.l. avant les
présentes.
68533
L
U X E M B O U R G
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,
celui-ci a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: M. RENNIG, V. BARATON, R. REDING, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 21 janvier 2013. Relation: CAP/2013/181. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Entringer.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Capellen, le 16 avril 2013.
Camille MINES.
Référence de publication: 2013053756/249.
(130065707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.
Votre Cordonnier Thiry S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4761 Pétange, 23-25, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 40.922.
Le Bilan abrege au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/04/2013.
Référence de publication: 2013054411/10.
(130066203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
Electroengine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1240 Luxembourg, 18, rue Charles Bernhoeft.
R.C.S. Luxembourg B 164.386.
<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration de la société prises en date du 27 mars 2013i>
Le conseil d'administration prend acte de la démission par Monsieur Alain Mestat ayant son adresse professionnelle
au 18 rue Charles Bernhoeft, 1240 Luxembourg - Luxembourg, de sa fonction de délégué à la gestion journalière en date
du 25 mars 2013.
Le conseil d'administration de la société décide de nommer au poste d'administrateur-délégué Monsieur Thomas
Bergfjord ayant son adresse professionnelle au 207 Halmby, 755 98 Uppsala - Suède.
Ce mandat a été octroyé pour une durée indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013054450/17.
(130066838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
Zademar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 87.934.
Les comptes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ZADEMAR S.A.
Alexis DE BERNARDI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013054429/12.
(130066445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.
68534
L
U X E M B O U R G
San Angelo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 82.818.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale tenue en date du 24 avril 2013i>
Il résulte du Procès -Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 avril 2013 que:
1. Est nommé en tant qu’administrateur pour une année de six ans, Monsieur Gianluca Ninno, né à Policoro (Italie),
le 7 avril 1975, demeurant au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale
qui se tiendra en l’an 2019.
2. Est nommé en tant qu’administrateur pour une année de six ans, Monsieur Natale Capula, né à Villa San Giovanni
(Italie), le 1
er
novembre 1961, demeurant au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de
l'assemblée générale qui se tiendra en l’an 2019.
3. Est nommé en tant qu’administrateur pour une année de six ans, Monsieur Xavier Vincent, né le 9 novembre 1984
à Messancy (Belgique), demeurant au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l'assemblée
générale qui se tiendra en l’an 2019.
4. Est nommée en tant que commissaire aux comptes pour une période de six années, la société FGS CONSULTING
LLC, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Las Vegas sous le numéro E0048502007-1, ayant son siège social
à NV 89101, 520 S. 7
th
Street, Suite C, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2019.
5. Le siège de la société est établi à Luxembourg, au, 44 rue de la Vallée, L–2661 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 24 avril 2013.
Référence de publication: 2013055047/25.
(130067480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
Sapin Laroche S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 61.618.
En date du 17 Avril 2013, l'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité la décision suivante:
Organe: Conseil d'Administration
- Nomination: Schreuders, Bastiaan,Lodewijk Melchior,
Fonction: Administrateur, Administrateur Délégué
Mandat: Du 17/04/2013 Jusque à l'assemblée générale dans le courant de 2019
Adresse: 10/12 Rue de Medernach, L-7619 Larochette
- Confirmation:
Raymonde J. Gokke
Fonction: Administrateur
Mandat: Du 17/04/2013 Jusque à l'assemblée générale dans le courant de 2019
Adresse: 17, Leedebach, L-7618 larochette
Albert Seen
Fonctions: Administrateur, Président du Conseil d'administration,
Mandat: Du 17/04/2013 Jusque à l'assemblée générale dans le courant de 2019
Adresse: 17, Leedebach, L-7618 larochette
- Démission: Autonome de Revision
Fonction: Commissaire aux Comptes
- Nomination: a&c Management Services SàrL
Fonction: Commissaire aux Comptes
Mandat: Du 17/04/2013 Jusque à l'assemblée générale dans le courant de 2019
Adresse: 80, Rue des Romains, L-8041 Strassen
- Ancienne dénomination: Suxeskey S.A.
- Nouvelle dénomination: Andreas Capital Suxeskey S.A.(effectif depuis 27/12/2012
Fonction: Administrateur, Représentée par: Schreuders Bastiaan Lodewijk Melchior
Mandat: Du 17/04/2013 Jusque à l'assemblée générale dans le courant de 2019
68535
L
U X E M B O U R G
Adresse: 10/12 Rue de Medernach, L-7619 Larochette
Raymonde Gokke
<i>Le Conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2013055048/35.
(130065946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
ContourGlobal Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 155.446.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 29 avril 2013i>
L'associé unique de ContourGlobal Development S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Mrs. Laetitia Ambrosi en tant que Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet au
19 avril 2013;
- de nommer Luxembourg Corporation Company S.A., une société anonyme Luxembourgeoise, ayant son siège social
au 20, Rue de la poste, L-2346 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B37974, en tant que Gérant de catégorie B de la Société avec effet au 19 avril 2013, et ce pour
une durée illimitée.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013055349/19.
(130068321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.
ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 156.688.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 29 avril 2013i>
L'associé unique de ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Mrs. Laetitia Ambrosi et Mrs. Alexandra Petitjean en tant que Gérants de catégorie B de
la Société et ce avec effet au 19 avril 2013;
- de nommer Luxembourg Corporation Company S.A., une société anonyme Luxembourgeoise, ayant son siège social
au 20, Rue de la poste, L-2346 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B37974, en tant que Gérant de catégorie B de la Société avec effet au 19 avril 2013, et ce pour
une durée illimitée.
- de nommer T.C.G. Gestion S.A., une société anonyme Luxembourgeoise, ayant son siège social au 20, Rue de la
poste, L-2346 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B67822, en tant que Gérant de catégorie B de la Société avec effet au 19 avril 2013, et ce pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013055348/22.
(130068281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.
BPVN Enhanced Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 110.607.
Les comptes annuels au 31 décembre ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
68536
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour BPVN ENHANCED FUND
i>Banque Degroof Luxembourg S.A.
Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE
<i>Directeur / -i>
Référence de publication: 2013055318/14.
(130067713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.
ContourGlobal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 140.282.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 29 avril 2013i>
L'associé unique de ContourGlobal Luxembourg S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Mrs. Laetitia Ambrosi en tant que Gérant de la Société et ce avec effet au 19 avril 2013;
- de nommer Luxembourg Corporation Company S.A., une société anonyme Luxembourgeoise, ayant son siège social
au 20, Rue de la poste, L-2346 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B37974, en tant que Gérant de la Société avec effet au 19 avril 2013, et ce pour une durée
illimitée.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013055350/18.
(130068383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.
Carmel Capital V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: AUD 3.147.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 125.079.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 10 avril 2013 que:
- Madame Anne Sheedy a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 10 Avril 2013;
- Madame Clarissa Beresford, née le 28 Novembre 1980 à Watford (Royaume-Uni), demeurant au 2 More London
Riverside, London, SE1 2AP, Royaume-Uni a été nommé en remplacement de Madame Anne Sheedy, avec effet au 10
Avril 2013 et pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais des gérants suivants:
1. M. Dominic Spiri, gérant;
2. M. Gérard Maîtrejean, gérant;
3. Mme Clarissa Beresford, gérante;
4. M. Stef Oostvogels, gérant; et
5. M. Stéphane Hadet, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013055332/24.
(130067952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.
Innovative Solutions s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5831 Hesperange, 27, Cité Holleschberg.
R.C.S. Luxembourg B 155.640.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
68537
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 26/04/2013.
Référence de publication: 2013054768/10.
(130066745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
Jedoso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame.
R.C.S. Luxembourg B 169.810.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 26 avril 2013i>
En date du 26 avril 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Christophe GAMMAL, né le 9 août 1967 à Uccle, Belgique, résidant à l'adresse suivante: 35,
rue des Merisiers, L-8253 Mamer, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée
indéterminée;
- de transférer le siège social de la Société du 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg au 8, rue Notre Dame, L-2240
Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2013.
Jedoso S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013054797/20.
(130067534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
NPS European Property Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.561.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels pour la période du 24 mai 2011 au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro L120076159 en date du 10 mai 2012 sont remplacés par les comptes ci-
joint.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait au Luxembourg, le 29 avril 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013054939/16.
(130067465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
Okeïna S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 61.983.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 18 avril 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme
OKEÏNA, dont le siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, a été dénoncé en date du 26 septembre 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
68538
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Petra MAGEROTTE (née MALA)
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013054950/17.
(130066971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
PH Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 87.812,28.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 141.280.
EXTRAIT
En date du 19 avril 2013, le mandat de gérant de classe A de M. John E. Viola et le mandat de gérant de classe B de M.
Pedro Fernandes das Neves ont pris fin et M. Dylan Davies, né le 16 novembre 1966 à Swansea (Royaume-Uni), demeurant
professionnellement au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg a été nommé gérant de classe A, pour
une durée indéterminée, et M. Ronan Carroll, né le 11 novembre 1971 à Dublin (Irlande), demeurant professionnellement
au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg a été nommé gérant de classe B, pour une durée indéter-
minée, de sorte que le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
<i>Gérant de classe A:i>
- M. Dylan Davies
<i>Gérant de classe B:i>
- M. Ronan Carroll
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2013.
Référence de publication: 2013054972/21.
(130066762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
PHND S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 88.480,93.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 139.205.
EXTRAIT
En date du 19 avril 2013, le mandat de gérant de classe A de M. John E. Viola et le mandat de gérant de classe B de M.
Pedro Fernandes das Neves ont pris fin et M. Cedric Bradfer, né le 2 août 1978 à Chambéry (France), demeurant pro-
fessionnellement au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg a été nommé gérant de classe A, pour une
durée indéterminée, et M. Elli Stevens, né le 7 mai 1974 à Bournemouth (Royaume-Uni), demeurant professionnellement
au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg a été nommé gérant de classe B, pour une durée indéter-
minée, de sorte que le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
<i>Gérant de classe A:i>
- M. Cedric Bradfer
<i>Gérant de classe B:i>
- M. Elli Stevens
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2013.
Référence de publication: 2013054973/21.
(130066761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 122.880.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
68539
L
U X E M B O U R G
<i>Pour MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l.
i>Delloula Aouinti
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013054911/13.
(130066777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
Pic Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 56.990.
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires en date du 15 avril 2013i>
1. Madame Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat d’administrateur.
2. Monsieur Vincent REGNAULT a démissionné de son mandat d’administrateur.
3. Madame Katia CAMBON, administrateur de sociétés, née à Le Raincy (France), le 24 mai 1972, demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2014.
4. Madame Ingrid CERNICCHI, administrateur de sociétés, née à Metz (France), le 18 mai 1983, demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2014.
Luxembourg, le 29 avril 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PIC INVESTISSEMENT S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013054974/20.
(130067206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
Petro Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.270.780,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.127.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 17 avril 2013.i>
Il est à noter ce qui suit:
1. Acceptation avec effet au 17 avril 2013 de la démission de Monsieur Romain Leroy, avec adresse professionnelle au
174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg de son mandat de gérant de classe C de la Société.
2. Nomination avec effet au 17 avril 2013 et pour une durée illimitée, de Madame Séverine Lesgardeur, née le 26 juillet
1979 à Libramont-Chevigny, Belgique, avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg en tant
que gérante de classe C de la Société en remplacement de Monsieur Romain Leroy, gérant de classe C démissionnaire.
A partir du 17 avril 2013 le conseil de gérance se compose comme suit:
- Daniel R. Revers- Gérant de classe A
- Christopher J. Picotte - Gérant de classe A
- Rob Nijst - Gérant de classe B
- Simon Robert Hale - Gérant de classe B
- Frédéric Lemoine - Gérant de classe C
- Christophe Gammal - Gérant de classe C
- Yeliz Bozkir - Gérante de classe C
- Séverine Lesgardeur - Gérante de classe C
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2013054970/25.
(130066922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
68540
L
U X E M B O U R G
Parma Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 88.410.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires en date du 28 mars 2013i>
1. Madame Valérie PECHON a démissionné de son mandat d’administrateur.
2. Monsieur Andrew O’SHEA, administrateur de sociétés, né à Dublin (Irlande), le 13 août 1981, demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2014.
Luxembourg, le 29 avril 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PARMA INVESTMENTS S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013054965/16.
(130067657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 122.880.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l.
i>Delloula Aouinti
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013054909/13.
(130066775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
S. Michele S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 77.143.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale tenue en date du 15 avril 2013i>
Il résulte du Procès -Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 avril 2013 que:
1. Est nommé en tant qu’administrateur pour une année de six ans, Monsieur Gianluca Ninno, né à Policoro (Italie),
le 7 avril 1975, demeurant au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale
qui se tiendra en l’an 2019.
2. Est nommé en tant qu’administrateur pour une année de six ans, Monsieur Natale Capula, né à Villa San Giovanni
(Italie), le 1
er
novembre 1961, demeurant au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de
l'assemblée générale qui se tiendra en l’an 2019.
3. Est nommé en tant qu’administrateur pour une année de six ans, Monsieur Xavier Vincent, né le 9 novembre 1984
à Messancy (Belgique), demeurant au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l'assemblée
générale qui se tiendra en l’an 2019.
4. Est nommée en tant que commissaire aux comptes pour une période de six années, la société FGS CONSULTING
LLC, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Las Vegas sous le numéro E0048502007-1, ayant son siège social
à NV 89101, 520 S. 7
th
Street, Suite C, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2019.
5. Le siège de la société est établi à Luxembourg, au, 44 rue de la Vallée, L–2661 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 15 avril 2013.
Référence de publication: 2013055021/25.
(130067483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
68541
L
U X E M B O U R G
Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.099.
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 19. März 2013i>
Das Mandat des alleinigen Verwaltungsratsmitglied wird um ein weiteres Jahr verlängert:
- Frau Michele Valenti, Director, geschäftsansässig in 280 Park Avenue 10017 1216, New York, USA
Das Mandat des Rechnungskomissars FIN-CONTRÔLE S.A. wird ebenfalls um ein weiteres Jahr verlängert.
Beide Mandate laufen somit anlässlich der ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2014 stattfinden wird,
aus.
Luxemburg, den 19. März 2013.
Für beglaubigten Auszug
Référence de publication: 2013055026/15.
(130066681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
Rockhampton Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 3.062.491,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.646.
Veuillez noter que l'adresse de l'associé Mme Elisabeth Dorothy Johnston est désormais la suivante:
9 Abbey Park, Newtownabbey, BT37 9PB Belfast, Ireland
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013055000/14.
(130067123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
LeverageSource S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 137.624.
Par résolutions prises en date du 28 mars 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Wendy Friedman DULMAN, avec adresse professionnelle au 9, West 57
th
Street,
10019 New York, Etats-Unis, de son mandat de Gérant A, avec effet immédiat;
- nomination de Shari Verschell-Silverman, avec adresse professionnelle au 9, West 57
th
Street, 48
th
Floor, 10019
New York, Etats-Unis, au mandat de Gérant A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2013.
Référence de publication: 2013054822/15.
(130067050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
L Real Estate S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investis-
sement en Capital à Risque.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 144.783.
EXTRAIT
Il résulte de la résolution du conseil d'administration de la société L Real Estate, une société anonyme de droit Lu-
xembourgeois, dont le siège social est situé au 26, Boulevard Royal L- 2449 Luxembourg, immatriculée auprès du registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.610, agissant en qualité d'associé-gérant-commandité
de la Société, prise en date du 28 mars 2012 que Ernst & Young, société anonyme, dont le siège social est situé au 7, Parc
68542
L
U X E M B O U R G
d'Activité Syrdall L- 5365 Munsbach, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 47.771, a été nommé réviseur d'entreprises de la Société pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre
2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour L REAL ESTATE S.C.A. SICAR
Le mandatairei>
Référence de publication: 2013054810/19.
(130067017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2013.
Ango Telecom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 143.741.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 mars 2013 que:
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l'issue de l'Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015:
- Monsieur Claude LE MONNIER, demeurant Rue du 8 Mai 1945 P-78220 Viroflay,
- Monsieur Thierry JACOB, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch L-1471 Luxembourg,
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch L-1471 Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux comptes, pour la même période, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015:
- H.R.T. Révision S.A., dont le siège social de la société est sis 163, rue du Kiem L-8030 Strassen
Luxembourg, le 29 avril 2013.
Certifié Sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2013055269/20.
(130068358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.
AIM Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg B 74.676.
<i>Extrait des résolutions circulaires prises par les associés de la Société en date du 23 avril 2013i>
En date du 23 avril 2013, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Madame Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI, de son mandat de gérant de la
Société avec effet au 15 avril 2013;
- de nommer Madame Catherine KOCH, née le 12 février 1965 à Sarreguemines, France, ayant comme adresse
professionnelle: 19, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 15 avril
2013 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Michel RAFFOUL
- Madame Anne Catherine GRAVE
- Madame Catherine KOCH
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
AIM Services S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013055246/23.
(130068441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.
68543
L
U X E M B O U R G
ABOM Diffusion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 154.879.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre société, tenue en date du 25 avril 2013
que:
- Décision a été prise d’accepter la démission de la société Fidu-Concept SARL de son mandat de commissaire aux
comptes et cela avec effet immédiat.
- Décision a été prise de nommer en son remplacement la société EP International S.A. (RCS Luxembourg B130232),
avec siège social au 20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, à la fonction de commissaire aux comptes de la société
et cela avec effet immédiat.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2019.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013055243/18.
(130067813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.
Anglo Venezuela Investments, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 116.816.
Le bilan consolidé de la société Anglo American plc au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2013.
Signature
<i>Administrateur / Géranti>
Référence de publication: 2013055233/13.
(130067772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.
DP&AC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 162.976.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 18/04/2013.
Référence de publication: 2013050541/10.
(130061753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.
Dufranc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 65.727.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2013.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2013050543/12.
(130062359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
68544
ABOM Diffusion S.A.
AIM Services S.à r.l.
Anglo Venezuela Investments
Ango Telecom S.A.
Avenue Property S.à r.l.
BNP Paribas L1
BPVN Enhanced Fund
BRE/Management 5 S.A.
Carmel Capital V S.à r.l.
ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l.
ContourGlobal Development S.à r.l.
ContourGlobal Luxembourg S.à r.l.
Deutsche Post Reinsurance S.A.
DP&AC S.A.
Dufranc S.A.
Electroengine S.A.
Fill Consulting S.à r.l.
Fluid Movement Investment S.A.
Flying Wings AG
Fngrade S.A.
Forest Luxco S.à r.l.
Glenda 1980 S.A.
Göta Re S.A.
Innovative Solutions s.à r.l.
Iso Deco Heinen Sàrl
Jedoso S.à r.l.
LeverageSource S. à r.l.
L Real Estate S.C.A. SICAR
MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l.
MGP Europe Parallel AIV (Lux) S.à r.l.
NPS European Property Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Okeïna S.A.
PAMM Consulting
Parma Investments S.A.
Petro Lux S.à r.l.
PHND S.àr.l.
PH Trust S.à r.l.
Pic Investissement S.A.
Rockhampton Sàrl
Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A.
San Angelo S.A.
Santander Sicav
Sapin Laroche S.A., SPF
Sat-Elec S.à r.l.
Saturne Sicav
Senslight S.à r.l.
S. Michele S.A.
Top Finance S.A.
TreeTop Portfolio SICAV
TreeTop Scolea SICAV
Trufidee
Trufilux
UTI Investment Luxembourg S.à r.l.
Vader S.à r.l.
Vattenfall Reinsurance S.A.
Viande - Luxembourg, Société Anonyme
Viking Investments S.à r.l.
Votre Cordonnier Thiry S.àr.l.
Wahoo Atlanticus S.à r.l.
Zademar S.A.