logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1416

14 juin 2013

SOMMAIRE

Agriculture Tourism Investment S.A.  . . . .

67937

Agri-Food S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67925

Albatros Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67937

Autonomy Real Estate Spain  . . . . . . . . . . . .

67932

Autumnleaf S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67968

Batiselect S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67938

Blue Dolphin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67924

Carina Silva S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67927

Carina Silva S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67930

Carrelages Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67925

Cetiri Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67925

Cetrel Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67924

Chinna S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67924

Cita Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67925

Clarins Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67923

Concertine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67926

Congel International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

67923

Coopération Luxembourg - Montenegro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67965

Coriolan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67926

Covent Garden Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

67924

Deutsche Bank Luxembourg S.A. . . . . . . . .

67926

Eren Groupe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67939

Floann S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67964

Freenom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67958

Glassvision S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67930

Global-Waste-Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

67956

Halcyon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67923

Inmet Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67922

Mark IV USA S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67927

Metal Group International S.à r.l. . . . . . . . .

67934

Pasta Point Pétange Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .

67967

Planalto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67922

Recypatents S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67953

Red Point Investments S.A. SPF  . . . . . . . . .

67922

Royalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67952

SES Astra 2G S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67922

SES Astra 5B S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67958

Société Internationale d'Investissements

Financiers et Technologiques S.A.  . . . . . .

67939

Spirallux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67956

Sweden Lux Incentive 2012 S.A.  . . . . . . . . .

67949

Think 2 Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67948

Una Mas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67954

VCP Jet Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67968

67921

L

U X E M B O U R G

Inmet Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 de Inmet Luxembourg, Succursale Luxembourgeoise ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2013.

Référence de publication: 2013054109/11.
(130066102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Red Point Investments S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Capital social: EUR 32.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 84.191.

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2013:-
- Est acceptée avec effet au 1 

er

 janvier 2013 la démission de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. en

tant que Commissaire aux Comptes.

- Est acceptée avec effet au 1 

er

 janvier 2013 la nomination de FIDUCIAIRE SEVE S.A. ayant son siège social 12D

Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 82421 en tant que Commissaire aux Comptes en rem-
placement de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année
2018.

Luxembourg, le 27 février 2013.

<i>Pour RED POINT INVESTMENTS S.A. SPF

Référence de publication: 2013053574/16.
(130065135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.

SES Astra 2G S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 148.246.

EXTRAIT

Suite aux résolutions de l'actionnaire unique en date du 27 mars 2013, le mandat du réviseur d'entreprises, Ernst &amp;

Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, n'a pas été renouvelé.

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg a été élu Réviseur d'Entreprise

et le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Betzdorf, le 22 avril 2013.

Référence de publication: 2013053006/15.
(130064359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Planalto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 49.431.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PLANALTO S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013053554/11.
(130065850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.

67922

L

U X E M B O U R G

Clarins Ventures S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 82.156.

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2013:-
- Est acceptée avec effet au 1 

er

 janvier 2013 la démission de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. en

tant que Commissaire aux Comptes.

- Est acceptée avec effet au 1 

er

 janvier 2013 la nomination de FIDUCIAIRE SEVE S.A. ayant son siège social 12D

Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 82421 en tant que Commissaire aux Comptes en rem-
placement de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année
2018.

Luxembourg, le 27 février 2013.

<i>Pour CLARINS VENTURES S.A.

Référence de publication: 2013053270/16.
(130065147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.

Halcyon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 165.387.

Par résolutions prises en date du 15 avril 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Alexandre Prost-Gargoz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat;

- nomination de Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2013.

Référence de publication: 2013053383/15.
(130065293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.

Congel International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 36.413.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 11 avril 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité
limitée CONGEL INTERNATIONAL s.à.r.l., dont le siège social à L-1370 Luxembourg, 16, rue Val Sainte Croix, a été
dénoncé en date du 7 juillet 1995.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, premier juge au Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Jonathan BURGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxem-

bourg avant le 3 mai 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Jonathan BURGER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2013053944/21.
(130066344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

67923

L

U X E M B O U R G

Blue Dolphin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 140.823.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BLUE DOLPHIN S.A.
GES MARITIME S.A. / NEUMANN Larissa
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013053878/12.
(130066448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Cetrel Securities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 117.298.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’administration de la Société en date du 28 février 2013

Le Conseil d’Administration de la Société a nommé Ernst &amp; Young, S.A. (sise au 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365

Munsbach, n° RCS B. 47771), en tant que réviseur d’entreprises de la Société, afin d’effectuer l’audit des comptes de la
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Le mandat d’Ernst &amp; Young, Luxembourg se terminera lors de l’as-
semblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2013.

<i>Pour CETREL Securities S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2013053896/16.
(130066439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Covent Garden Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 128.161.

Les comptes consolidés au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2013.

TMF Corporate Services S.A.
Signature
<i>Manager

Référence de publication: 2013053907/14.
(130066333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Chinna S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 72.267.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2013.

<i>Pour compte de Chinna S.A. SPF
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2013053927/12.
(130066218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

67924

L

U X E M B O U R G

Cita Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 103.258.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour CITA S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2013053935/12.
(130066035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Cetiri Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 45.148.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CETIRI HOLDING S.A.
Société anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013053919/14.
(130066127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Carrelages Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4920 Bascharage, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 168.837.

EXTRAIT

Les décisions prises par l'associé unique en assemblée générale extraordinaire du 18 février 2013 sont les suivantes:
1) acceptation de la démission de Monsieur José DA SILVA SANTOS de son poste de gérant technique
2) nomination de Monsieur Fernando BRANDAO TEIXEIRA, gérant de sociétés, né à Ribeiro Tropeço - Arouca

(Portugal), le 14 juin 1962, demeurant à F-57570 Mondorff (France), 1, rue de Paris, au poste de gérant technique pour
une durée indéterminée;

Monsieur Fernando BRANDAO TEIXEIRA peut engager la société par sa seule signature.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 26 avril 2013.

Référence de publication: 2013053913/16.
(130066674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Agri-Food S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 77.155.

Les comptes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AGRI-FOOD S.A.
Alexis DE BERNARDI / Gioacchino GALIONE
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013053791/12.
(130066441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

67925

L

U X E M B O U R G

Concertine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 109.579.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 10 avril 2013 lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société Concertine

<i>S.A.

- M. Thierry TRIBOULOT a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat.
- Mme Noeleen GOES-FARRELL, employée privée, née à Dublin (Ireland), le 28 décembre 1966, résidant profession-

nellement au 127 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été cooptée administrateur de la Société avec effet immédiat
et jusqu'à 22 août 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CONCERTINE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013053942/17.
(130066304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Coriolan, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10A, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 176.791.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013053946/11.
(130067038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Deutsche Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 9.164.

Société Anonyme constituée le 12 août 1970 par acte de Maître Carlo Funck, notaire de résidence à Luxembourg, publiée

au Mémorial C, No 142 du 27 août 1970 et modifiée par actes de Maître Carlo Funck en date des 20 octobre 1970
publiée au Mémorial C, No 180 du 26 octobre 1970 et 21 décembre 1970 publiée au Mémorial C, No 49 du 9 avril
1971 et 12 février 1973 publiée au Mémorial C, No 62 du 9 avril 1973 et 26 novembre 1973 publiée au Mémorial
C, no 14 du 23 janvier 1974 et 23 octobre 1975 publiée au Mémorial C, No 32 du 18 février 1976 et 28 mars 1977
publiée au Mémorial C, No 108 du 13 mai 1977 et 11 octobre 1978 publiée au Mémorial C, No 14 du 22 janvier
1979 et 30 octobre 1979 publiée au Mémorial C, No 3 du 4 janvier 1980 et 12 janvier 1981 publiée au Mémorial C,
No 48 du 10 mars 1981 et 26 août 1983 publiée au Mémorial C, No 287 du 22 octobre 1983 et 22 novembre 1984
publiée au Mémorial C, No 342 du 17 décembre 1984 et 16 mars 1987 publiée au Mémorial C, No 97 du 13 avril
1987 et 17 mai 1988 publiée au Mémorial C, No 215 du 9 août 1988 et 25 novembre 1992 publiée au Mémorial C,
No 59 du 8 février 1993 et 4 décembre 1996 publiée au Mémorial C, No 121 du 13 mars 1997 et 17 décembre
1998 publiée au Mémorial C, No 123 du 26 février 1999 et 31 mai 2006 publiée au Mémorial C, No 1605 du 24
août 2006 et 19 novembre 2009 publiée au Mémorial C, No 2379 du 7 décembre 2009, et 24 mai 2012 publiée au
Mémorial C, No 1441 du 9 juin 2012.

Der Jahresabschluß 2012 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang), der Lagebericht der Bank und der

Bericht der Abschlußprüfer, wurden einregistriert und beim Handels- und Firmenregister von Luxemburg hinterlegt.

Luxemburg.

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Jürgen Schweig / Stephan Thräm

Référence de publication: 2013053965/26.
(130066855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

67926

L

U X E M B O U R G

Mark IV USA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 156.610.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la société Mark IV USA S.à r.l. en date du 19 avril 2013 les décisions

suivantes:

1. Révocation du Gérant A suivant à compter du 10 avril 2013:
Monsieur Mark Gilbert Barberio, ayant pour adresse professionnelle 501, John James Audubon Parkway, bâtiment One

Town Center, USA - 14226 Amherst.

2. Nomination du nouveau Gérant A suivant à compter du 10 avril 2013 pour une durée indéterminée:
Monsieur James Craig Orchard, né le 24 août 1950 à Indiana, États Unis d'Amérique, et ayant pour adresse profes-

sionnelle 501, John James Audubon Parkway, One Town Center, 14226 Amherst, États Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mark IV USA S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant B

Référence de publication: 2013052806/21.
(130064930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Carina Silva S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5760 Hassel, 6B, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 176.736.

STATUTS

L'an deux mille treize, le neuf avril;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Madame Carina DA SILVA, esthéticienne, né à Toronto (Canada), le 10 juin 1986, demeurant à L-5760 Hassel, 6B, rue

de Luxembourg.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Objet - Durée Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "Carina Silva S.à r.l.", (ci-après la "Société"), laquelle
sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'un institut de beauté et de soins corporels avec salon wellness, esthé-

ticienne, manucure, confectionneur d'ongles artificiels et pédicure ainsi que la vente d'articles de la branche.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Weiler-la-Tour (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du

siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés

délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs

aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

67927

L

U X E M B O U R G

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'/aux associé(s) en proportion avec sa/leur participation dans le capital

de la Société.

La gérance est autorisée à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions

suivantes:

1. la gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution

des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

67928

L

U X E M B O U R G

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2013.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique

Madame Carina DA SILVA, préqualifiée, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en
numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Loi anti-blanchiment

L'associée unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

le bénéficiaire réel de la Société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas, respectivement que la Société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cents euros.

<i>Résolutions prises par l'associée unique

Et aussitôt, la comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions

suivantes en tant qu'associée unique:

1. Le siège social est établi à L-5760 Hassel, 6B, rue de Luxembourg.
2. Madame Carina DA SILVA, esthéticienne, né à Toronto (Canada), le 10 juin 1986, demeurant à L-5760 Hassel, 6B,

rue de Luxembourg, est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée.

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle de la

gérante.

4. Au sens de l'article 12 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, la signature

du présent document est réputée être qualifiée comme ratification de tous les engagements réalisés au nom et pour le
compte de la Société durant la procédure de formation.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DA SILVA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 avril 2013. LAC/2013/16679. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 18 avril 2013.

Référence de publication: 2013051886/134.
(130063593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

67929

L

U X E M B O U R G

Carina Silva S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5760 Hassel, 6B, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 176.736.

<i>Résolutions prises par l'associée unique en date du 9 avril 2013

La soussignée, Madame Carina DA SILVA, esthéticienne, né à Toronto (Canada), le 10 juin 1986, demeurant à L-5760

Hassel, 6B, rue de Luxembourg.,

agissant en sa qualité d'associée unique (l"Associée Unique"), de la société à responsabilité limitée "Carina Silva S.à r.l.",

établie et ayant son siège social à L-5760 Hassel, 6B, rue de Luxembourg, en cours d'inscription au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, (la "Société"), a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associée Unique décide de restructurer la gérance de la Société et nomme, pour une durée indéterminée, l'actuelle

gérante Madame Carina DA SILVA, préqualifiée, comme dorénavant gérante administrative de la Société,

<i>Deuxième résolution

L'Associée Unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, Madame Katty Eliane Patricia GEIMER, né à

Arlon (Belgique), le 24 septembre 1974, demeurant à L-8080 Bertrange, 11 rue de Longwy, comme gérante technique.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les pouvoirs de signature des gérants comme suit:
"Jusqu'à concurrence de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR), la Société peut être engagée par la signature

individuelle d'une gérante (administrative ou technique); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur les signa-
tures conjointes de la gérante technique et de la gérante administrative sont nécessaires.

Pour toutes opérations qui ne nécessitent pas d'autorisation du Ministère des Classes Moyennes luxembourgeois, la

Société pourra être valablement engagée, sans restrictions, par la signature individuelle de la gérante administrative."

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 avril 2013. Relation: LAC/2013/16679. Reçu douze euros 12,00 €.

Carina DA SILVA.

Référence de publication: 2013051887/28.
(130063593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Glassvision S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5441 Remerschen, 10, Wisswee.

R.C.S. Luxembourg B 176.674.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend dreizehn.
Den zwölften April.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

1.- Frau Birgit HOLBACH, geborene BAUER, Frisör-Meisterin, wohnhaft in D-54450 Freudenburg, Gartenstrasse 7.
2.- Frau Brunhilde JÄCKELS, geborene PALM, Kauffrau, wohnhaft in D-54451 Irsch/Saarburg, Schulstrasse, 4.
3.- Herr Rolf SCHNEIDER, Maschinenbauer &amp; Kaufmann, wohnhaft in D-54309 Newel, Ramsteiner Weg, 16.
Welche Komparenten hier vertreten sind durch Herrn Markus GUBERNATOR, Auszubildender zum Steuerfachan-

gestellten, beruflich ansässig in L-6776 Grevenmacher, 10, an de Längten, aufgrund von drei Vollmachten unter Privatschrift
vom 2. April 2013 respektive vom 8. April 2013,

welche Vollmachten nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden

Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschafts-

vertrag zu beurkunden, den sie miteinander abgeschlossen haben:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile

werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zu-
treffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "Glassvision S.à r.l.".

67930

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt

werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf (Handel) mit Bauelementen, insbesondere der Handel mit

Fenster- und Türelementen, Hausdächern und Fassaden.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben in irgendeiner Weise fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND SECHS HUNDERT EURO (€ 12.600.-), aufgeteilt in EIN

HUNDERT SECHSUNDZWANZIG (126) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT EURO (€ 100.-),
welche wie folgt übernommen werden:

1.- Frau Birgit HOLBACH, geborene BAUER, Frisör-Meisterin, wohnhaft in D-54450 Freudenburg,
Gartenstrasse 7, zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2.- Frau Brunhilde JÄCKELS, geborene PALM, Kauffrau, wohnhaft in D-54451 Irsch/Saarburg,
Schulstrasse, 4, zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.- Herr Rolf SCHNEIDER, Maschinenbauer &amp; Kaufmann, wohnhaft in D-54309 Newel, Ramsteiner Weg,
16, zweiundvierzig Anteile42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Total: ein hundert sechs und zwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Ge-
sellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690

des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist und jeder Anteil gibt Anrecht

auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-

gen  bezüglich  der  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  ein.  Sie  sind  jedoch  für  die  ordnungsgemässe  Ausführung  ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-

versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Vers-

torbenen weitergeführt.

67931

L

U X E M B O U R G

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Einzahlung des Gesellschaftskapitals

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND SECHS HUNDERT EURO (€

12.600.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2013.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).

<i>Erklärung

Die Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben,

dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer

ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesord-
nung nachfolgende Beschlüsse gefasst:

a) Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden für eine unbestimmte Dauer ernannt:
- Frau Birgit HOLBACH, geborene BAUER, Frisör-Meisterin, geboren in Saarburg (Deutschland), den 24. Mai 1963,

wohnhaft in D-54450 Freudenburg, Gartenstrasse 7;

- Frau Brunhilde JÄCKELS, geborene PALM, Kauffrau, geboren in Irsch (Deutschland), am 20. November 1945, wohn-

haft in D-54451 Irsch/Saarburg, Schulstrasse, 4;

- Herr Rolf SCHNEIDER, Maschinenbauer &amp; Kaufmann, geboren in Trier, am 1. September 1972, wohnhaft in D-54309

Newel, Ramsteiner Weg, 16;

b) Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig

vertreten und verpflichten.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5441 Remerschen, 10, Wisswee.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: M. GUBERNATOR, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 16 avril 2013. Relation: ECH/2013/709. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

<i>Le Receveur (signé): J. M. MINY.

FÜR  GLEICHLAUTENDE  AUSFERTIGUNG,  auf  Begehr  erteilt,  zwecks  Hinterlegung  beim  Handels-  und  Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 19. April 2013.

Référence de publication: 2013050615/121.
(130062070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

Autonomy Real Estate Spain, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 172.728.

In the year two thousand and thirteen on the twelfth day of April.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

67932

L

U X E M B O U R G

There appeared:

Autonomy  Real  Estate  Fund  III:  Spain  Opportunities  Master  LP.,  a  company  having  its  registered  office  at  Maples

Corporate Services Limited, PO BOX 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Island, registered with the
Limited Partnerships Cayman Islands under the number mc-67607, duly represented by its General Partner Autonomy
AGO General Partner LP having its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands,

duly represented by Mr. Christophe COUIC, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of one (1) proxy given under private seal, on 9 April 2013,
said proxy, after being signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed for registration purposes.

The appearing party is sole shareholder (the "Shareholder") of the company "Autonomy Real Estate Spain", a société

à responsabilité limitée having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 172.728, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph
Wagner,  on  November  7,  2012,  published  in  the  Mémorial  C  Recueil  des  Sociétés  et  Association,  number  3027  of
December 14, 2012 (the "Company").

The appearing party, represented as stated here above, representing the whole corporate capital requires the notary

to act the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to add a new third paragraph in article 6 of the Articles of Association of the Company

which shall henceforth be worded as follows:

"The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities

in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use
of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance
of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor".

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to restate Article 6 of the articles of association of the Company, which shall henceforth be

worded as follows:

Art. 6. Share capital. The capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500.-), and is

represented by FIVE HUNDRED (500) shares of a par value of TWENTY-FIVE EUROS (EUR 25.-) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said account is at the free disposal of the shareholders.

The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities

in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use
of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance
of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor".

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le douze avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Autonomy Real Estate Fund III: Spain Opportunities Master LP, une société ayant son siège social à Maples Corporate

Services Limited, PO BOX 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Island, immatriculée auprès du registre
Limited Partnerships Cayman Islands, sous le numéro MC-67607 dûment représenté par son General Partner Autonomy
AGO General Partner LP ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,

dûment représentée par Monsieur Christophe COUIC, employé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 9 avril 2013.
Cette procuration, signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, res-

teront annexées au présent acte aux fins de formalisation.

67933

L

U X E M B O U R G

Laquelle partie comparante est le seul associé ( l'«Associé») de la société «Autonomy Real Estate Spain», une société

à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.728, constituée selon un acte reçu par le notaire Jean-
Joseph WAGNER en date du 7 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
3027 du 14 décembre 2012 (la «Société»).

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'insérer un troisième alinéa de l'article 6 des statuts de la Société comme suit:
«La Société pourra, sans limite aucune, accepter tout apport de fonds propres ou toute autre contribution sans émis-

sion de Parts Sociales ou autres titres en contrepartie de l'apport, et pourra créditer ces apports sur un ou plusieurs
comptes. Les décisions quant à l'utilisation de ces comptes devront être prises par l'(les) Associé(s) et seront régies par
la Loi de 1915 et les présents statuts. Afin d'éviter toute équivoque, chacune de ces décisions pourra, sans caractère
obligatoire, allouer tout montant apporté à l'apporteur».

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique décide de reformuler l'article 6 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12,500.-) représenté

par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25.-) chacune.

Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

La Société pourra, sans limite aucune, accepter tout apport de fonds propres ou toute autre contribution sans émission

de Parts Sociales ou autres titres en contrepartie de l'apport, et pourra créditer ces apports sur un ou plusieurs comptes.
Les décisions quant à l'utilisation de ces comptes devront être prises par l'(les) Associé(s) et seront régies par la Loi de
1915 et les présents statuts. Afin d'éviter toute équivoque, chacune de ces décisions pourra, sans caractère obligatoire,
allouer tout montant apporté à l'apporteur».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-

dessus,  le  présent  acte  est  rédigé  en  langue  anglaise,  suivi  d'une  version  française,  et  qu'à  la  demande  de  la  même
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le document a été lu à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile,

laquelle comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. COUIC, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 avril 2013. Relation: EAC/2013/5095. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013051088/100.
(130063294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

Metal Group International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 175.860.

In the year two thousand thirteen,on the eighth day of March,
before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Commodities  Group  International  Pte.  Lte.,  a  private  company  limited  by  shares  incorporated  under  the  laws  of

Singapore, having its registered office at 80 Raffles Place #26-01 UOB Plaza, Singapore, 048624 and registered with the
Registrar of Companies and Businesses of Singapore, under number 201230976K (the Sole Shareholder),

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, whose professional address is in Luxembourg, by virtue

of a power of attorney given under private seal on

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. it is the sole shareholder of Metal Group International S.à r.l., a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered

67934

L

U X E M B O U R G

office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies (RCS) under number B 175860 (the Company). The Company was incorporated
pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on March
8, 2013, in the process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial). The articles
of association of the Company (the Articles) have not been amended since the incorporation;

II. the Company has a share capital of at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a nominal value one euro (EUR 1.-) each, all held by the
Sole Shareholder;

III. the agenda of the meeting is as follows:
1. Amendment and restatement of article 8.1. of the articles of association of the Company (the Articles).
2. Amendment and restatement of article 8.3. (i) of the Articles.
3. Miscellaneous.
IV. after the foregoing agenda was duly examined, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and restate article 8.1. of the Articles so that it shall read as follows:

8.1. Powers of the board of managers.
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management to the manager(s) who hold(s), for the benefit of

the Company and acting individually, the business license delivered by the Ministry of Middle Class, Tourism and Accom-
modation enabling him/her to run the day-to-day business of the Company (the Technical Manager(s)) consistent with
the Company's corporate object.

(iii) Special or limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board and, within

the scope of the day-to-day management, by the Technical Manager acting and signing individually."

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to amend and restate article 8.3. (i) of the Articles so that it shall read as follows:

8.3. Representation.
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters (x) by the joint signature of any two managers,

(y) if the shareholders have appointed managers as Class A managers or Class B managers, by the joint signatures of one
(1) Class A manager and one (1) Class B manager, and (z) within the scope of the day-to-day management of the Company,
by the signature of the Technical Manager(s), acting and signing individually."

<i>Estimate of Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,200.-.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and, in case of discrepancies between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the representative of the appearing party, the representative signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le huitième jour de janvier,
par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Commodities Group International Pte. Lte., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Singapour, dont

le siège social se situe à 80 Raffles Place #26-01 UOB Plaza, Singapore, 048624 et inscrite au registre des sociétés de
Singapour, sous le numéro 201230976K (l'Associé Unique).

Représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé le

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que:

67935

L

U X E M B O U R G

I. il est l'associé unique de Metal Group International S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (RCS)
sous le numéro B 175860 (la Société). La Société a été constituée le 8 mars 2013 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le Mémorial). Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution;

II. la Société dispose d'un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par douze mille

cinq cents parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, toutes détenues par
l'Associé Unique;

III. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Modification et refonte de l'article 8.1. des statuts de la Société (les Statuts).
2. Modification et refonte de l'article 8.3. (i) des Statuts.
3. Divers.
IV. Après que l'ordre du jour qui précède ait été dûment examiné, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier et refondre l'article 8.1. des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur

suivante:

« 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance.
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Le Conseil est autorisé à déléguer la gestion journalière au(x) gérant(s) détenant, au profit de la Société et agissant

individuellement, l'autorisation d'établissement délivrée par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Lo-
gement lui(leur) permettant de conduire les affaires journalières de la Société (le(s) Gérant(s) Technique(s)) conformé-
ment à l'objet social de la Société.

(iii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques, par

le Conseil et, dans le cadre de la gestion journalière, par le(s) Gérant(s) Technique(s) agissant et signant seul(s).»

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier et refondre l'article 8.3. (i) des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur

suivante:

« 8.3. Représentation.
(ii) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (x) par la signature conjointe de deux (2) gérants,

(y) si les associés ont nommé des gérants comme gérants de Classe A ou comme gérants de Classe B, par la signature
conjointe d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B, et (z) dans le cadre de la gestion journalière de la
Société, par la signature du(des) Gérant(s) Technique(s) agissant et signant seul(s).»

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du

présent acte sont estimés à environ EUR 1.200.-.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante

ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date et année qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire des parties comparantes

a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 avril 2013. Relation: LAC/2013/17281. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2013.

Référence de publication: 2013051442/121.
(130063297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

67936

L

U X E M B O U R G

Agriculture Tourism Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 96.148.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25.04.2013.

<i>Pour: AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Nathalie Lett

Référence de publication: 2013053792/15.
(130065933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Albatros Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 98.862.

L'an deux mille treize, le quinze avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée Générale») de la société anonyme

«ALBATROS INVEST S.A.» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 98.862, constituée suivant acte
notarié du 23 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 319 le 19 mars 2004. Les
statuts ont été modifiés en suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 août 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2031 du 30 octobre 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle au

163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Amélie BURUS, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du

Kiem, L-8030 Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Cornelia METTLEN, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue

du Kiem, L-8030 Strassen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
A) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est réguliè-

rement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec

effet immédiat et modification subséquente de l'article premier (1 

er

 ), deuxième alinéa et de l'article huit (8), premier

alinéa des statuts. Insertion de la possibilité pour le conseil d'administration de transférer le siège à l'intérieur de la
commune;

2. Mise à jour des statuts afin d'y intégrer les modifications apportées par la loi du 25 août 2006 à la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales;

3. Modification de l'article cinq (5) des statuts par l'ajout d'un nouveau cinquième alinéa introduisant la possibilité au

Conseil d'Administration de prendre des décisions par voie circulaire;

4. Divers.
L'Assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

67937

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 163,

rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat. De plus, l'Assemblée générale décide
de formaliser le pouvoir donné au conseil d'administration (ou à l'administrateur unique, le cas échéant) de transférer le
siège social à l'intérieur de la commune.

En conséquence, et avec même effet, l'article premier (1 

er

 ), deuxième alinéa et l'article huit (8), premier alinéa des

statuts de la Société sont modifiés, lesquels auront désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . (deuxième alinéa).  «Le siège social est établi dans la commune de Strassen. L'adresse du siège social peut

être transférée dans la commune de ce dernier par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique le
cas échéant.»

Art. 8. (premier alinéa). «L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de mai à quatorze

heures dans la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'adapter les statuts de la Société en tenant compte des modifications apportées à la loi

du 10 août 1915 par la loi du 25 août 2006.

En conséquence, l'article quatre (4) premier alinéa et l'article cinq (5), septième alinéa des statuts de la Société sont

modifiés et auront désormais la teneur suivante:

Art. 4. (premier alinéa). «La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires

ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des
actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut
être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire.»

Art. 5. (septième alinéa). «La société se trouve engagée soit par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs,

soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature unique
de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'admi-
nistration.  Lorsque  le  conseil  d'administration  est  composé  d'un  seul  membre,  la  société  sera  engagée  par  sa  seule
signature.»

Enfin, l'Assemblée Générale décide de supprimer le sixième alinéa de l'article cinq (5) des statuts subordonnant la

délégation à un administrateur à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société par l'ajout d'un nouveau cinquième

alinéa qui aura la teneur suivante:

Art. 5. (nouveau cinquième alinéa). «Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs,

produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.»

DONT ACTE, fait et passé à Strassen, au nouveau siège social de la société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes,
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants susmentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.L. SCHUL, A. BURUS, C. METTLEN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 avril 2013. Relation: EAC/2013/5106. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013051100/82.
(130063403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

Batiselect S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 446A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 104.729.

L'an deux mille treize, le neuf avril.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BATISELECT S.A., avec siège

social à Trintange, constituée suivant acte notarié en date du 17 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 199 du 5 mars 2005 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par
le notaire soussigné, en date du 9 mars 2011, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1280 du 14 juin 2011.

67938

L

U X E M B O U R G

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean MOUSEL, administrateur de sociétés, demeurant à L-5460

Trintange, 1A, rue des Vignes,

Le  Président  désigne  comme  secrétaire  et  scrutateur  Monsieur  Victor  VANGELISTA,  administrateur  de  sociétés,

demeurant à L-4930 Bascharage, 26, bd. J-F Kennedy,

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1) Transfert du siège social à L-1940 Luxembourg, 446A, route de Longwy.
2) Modification de l'article 2 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de Trintange à L-1940 Luxembourg, 446A, route de Longwy.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'alinéa 1 

er

 de l'article 2 des statuts comme suit:

Art. 2. (Premier alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. MOUSEL, V. VANGELISTA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 avril 2013. Relation: LAC/2013/17283. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 avril 2013.

Référence de publication: 2013051142/45.
(130063311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

Eren Groupe S.A., Société Anonyme,

(anc. SIIF TECH S.A., Société Internationale d'Investissements Financiers et Technologiques S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 39.052.

L'an deux mille treize, le onzième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SOCIETE INTERNATIONALE D'INVESTIS-

SEMENTS FINANCIERS ET TECHNOLOGIQUES S.A., en abrégé SIIF TECH S.A. (la «Société»), une société anonyme
ayant son siège social au L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, immatriculée auprès du Registre et des Sociétés
sous le numéro B 39.052, constituée suivant acte reçu le 23 décembre 1991 par Maître Marc Elter, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 237 du 3 juin 1992.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du notaire soussigné, le 21

décembre 2012 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 440, le 22 février 2013.

L'assemblée  a  été  présidée  par  Pierre  DAGALLIER,  demeurant  professionnellement  au  13  Rue  des  bains,  L-1212

Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et l'assemblée comme scrutateur Alain ROBILLARD, demeurant profes-

sionnellement au 30 Rue Ernest Béres, L-1232 Luxembourg.

67939

L

U X E M B O U R G

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Il appert de la liste de présence établie par les membres du bureau que des 147.898.651 dont 550.000 actions propres,

toutes les actions sont dûment présentes/représentées à la présente assemblée.

Cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires re-

présentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne va-

rietur" par les comparants et le notaire soussigné.

II. Tous les actionnaires, étant représentés, ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour et que

l'assemblée peut régulièrement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, sans obligation de justifier l'accomplissement
des formalités de convocation.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.  Modification  de  la  dénomination  sociale  de  la  Société  SOCIETE  INTERNATIONALE  D'INVESTISSEMENTS  FI-

NANCIERS ET TECHNOLOGIQUES S.A., en abrégé SIIF TECH S.A. en EREN GROUPE S.A. avec effet immédiat.

2. Modification de l'article premier:

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est par la présente établi, entre les actionnaires, une société anonyme sous la

dénomination de EREN GROUPE S.A. (la «Société»).

3. Adoption d'une version anglaise des statuts, la version française faisant foi en cas de divergence entre la version

anglaise et la version française.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première et Deuxième résolutions

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société en EREN GROUPE S.A. avec effet immédiat et

de modifier en conséquence l'article premier des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est par la présente établi, entre les actionnaires, une société anonyme sous la

dénomination de EREN GROUPE S.A. (la «Société»).

<i>Troisième résolution

L'assemblée a décidé d'adopter suite à la version française des statuts de la Société une version anglaise.
En cas de divergence entre la version anglaise et la version française des statuts de la Société, la version française fera

foi.

Suit la version anglaise des statuts qui se lit comme suit:

Art. 1. Form - Name. There is hereby formed between the shareholders a public limited company (société anonyme)

under the name of EREN GROUPE S.A. (the 'Company').

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time

by decision of the shareholders deliberating in the manner required for the modification of the present articles of asso-
ciation,  in  accordance  with  Article  31  hereinafter.  The  death  or  the  winding-up  of  the  single  Shareholder  or  of  the
Shareholders will not cause the liquidation of the company.

Art. 3. Object. The Company's object, both in the Grand-Duchy of Luxembourg as abroad, is to:
- Take interests and participations, directly or indirectly in any business or company existing or to be created by all

appropriate means, alliances, contributions, mergers, stock options, bonds, or other securities, acquisitions of equity
rights and under any form.

- Develop and monitor the operation of the branches and participations.
- Supply administrative, legal, accounting, financial, real estate services, but only to the Company's shareholders, the

direct or indirect branches of its shareholders, the direct or indirect branches of the Company, or to any company or
business belonging to the same group of companies as the Company (the 'Group'), as well as manage the cash of the
Group.

- Help the Group, by granting loans, advances, guarantees, security interests or in any other way.
- Use and manage by any means any property, whether real or personal, movable or immovable, any patent and

trademark got or to be got by the Company, acquired or brought to it, in any capacity.

- Take part by any means in any operation likely to relate to its corporate object by way of incorporation of new

companies, subscription or purchase of securities or equity rights, of merger or by any other way.

- Any commission or brokerage transactions related to the above mentioned corporate object.
- In general the company may carry out any financial, commercial, industrial operations and any transactions in respect

of real estate, related to the above mentioned corporate object, deemed necessary or useful for fulfilling and developing
its corporate object, provided that the Company does not enter into any transactions or operations that may result for

67940

L

U X E M B O U R G

the Company undertaking an activity for which approval would be necessary or that would be considered as a regulated
activity.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. It may be transferred to any other

place within the district of Luxembourg pursuant to a resolution of the managing board of the Company (the 'Managing
Board'). Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the
Managing Board.

4.2 In the event that the Managing Board determines that extraordinary political, economic or social events have

occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the  nationality  of  the  Company which,  notwithstanding  the  temporary  transfer of its  registered  office, will remain a
Luxembourg company.

Art. 5. Capital - Shares, Profit Shares and Certificates.
5.1 The subscribed and fully paid share capital of the Company is EUR 561,986,226.74 (five hundred and sixty-one

million nine hundred and eighty-six thousand two hundred and twenty-six Euro seventy-four Eurocents ) represented by
147,898,651 (one hundred and forty-seven million eight hundred and ninety-eight thousand six hundred and fifty-one)
shares without mention of a nominal value.

5.2 The shares carry the right to an ordinary dividend allocated in accordance with the number of shares of each

shareholder.

5.3 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form.
5.4 The Company shall consider the person on whose behalf the shares are registered in the register of shareholders

as the true owner of such shares. Certificates confirming such registrations may be delivered to the shareholders.

5.5 Any transfer of registered shares shall only be effective after registration in the Company's register of shares, after

the issuance of a one or several certificates issued with respect to the shares of the Company, with an instrument of
transfer satisfactory for the Company or with written statements of transfer registered in the register of shares, which
shall be dated and signed by the transferor and the transferee, or their representatives.

5.6 As far as the law allows it, the Company shall be entitled to redeem its own shares.
5.7 In addition to shares representing the corporate capital, profit shares or similar securities may be created (the

"Profit Shares") within the limits laid down by Article 37 of the Law of August 10, 1915, as amended. A special reserve
("the Reserve") which is not part of the corporate capital may be created specially for that purpose. The extraordinary
general meeting of shareholders may issue Profit Shares at its sole discretion without reserving any preferential right to
subscribe to the shareholders or holders of Profit Shares.

5.8 Each Profit Share will be entitled to a priority distribution, to be collected from the profits, premiums or available

reserves (including the Reserve) of the Company, for an amount calculated on the par value or, in the absence thereof,
on the accountable par of the Profit Shares, multiplied by the rate as stated by the General Meeting that shall decide upon
the issue of Profit Shares. If for any reason, the priority distribution is not paid during one given year, the payment of the
said priority distribution is be made in a priority during the following year that allows such distribution.

Distributions on Profit Shares from any net income after tax, any reserve (including the Reserve) and/or premium are

decided by the extraordinary general meeting of shareholders in compliance with legal provisions. Interim distributions
on Profit Shares may be decided and paid by the Managing Board subject to the condition of compliance with the terms
set by the law on the distributions of interim dividends to shareholders, either in cash or in kind.

Any distribution declared shall be paid to the registered office of the Company or at the counters indicated by the

Managing Board (subject to the decisions by the extraordinary general meeting of shareholders).

A distribution declared but not paid (and not claimed) after five years cannot be claimed by the concerned holder, and

shall be subject to limitation due to the holder's lack of intervention and so, shall return to the Company. No interest
shall be paid on the distributions declared, but not claimed, which are held by the Company on behalf of holders.

Distributions on Profit Shares may be declared and paid independently of any distribution on shares and shall not

entitle any shares to any proportionate distribution or any other right.

5.9 Profit Shares are no-voting and their holders cannot claim any voting right in the Company. Holders of Profit Shares

who are not shareholders may attend any meeting of shareholders, but with no voting right. Holders of Profit Shares are
not empowered to convene nor to requisition shareholder meetings.

5.10 The Company may proceed to purchase or redeem its own Profit Shares based on their par value and may hold

the said Profit Shares in cash.

5.11 Profit Shares of the Company are issued in the registered way.
5.12 The Profit Shares register shall be kept at the registered office Company, where any Profit Share holder shall be

able to control it. Ownership of Profit Shares is established by the entry in the said register.

67941

L

U X E M B O U R G

5.13 Profit Shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognise only one holder per Profit Share. The

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Profit Shares until one holder has been so
appointed. The same rule shall apply in the case of a conflict between an usufructuary and a bare owner or between a
pledgor and a pledgee.

5.14 All notifications or communications to the Profit Shares holders shall be deemed to have been validly sent to the

last address notified by the Profit Shares holder to the Company. If a Profit Shares holder does not provide a valid address
to the Company for any further sending of notification and communication for which the holder is the addressee, the
Company may give an opinion in such way in the aforementioned registers and the address of the concerned Profit Shares
holder shall be deemed to be the registered office of the Company or any other address that shall be notified by the
Profit Shares holder to the Company. The Profit Shares holder may change his address at any time by written notification
sent to the Company.

Art. 6. Increase and Reduction in capital. The Company's share capital may be increased or reduced by decision of the

shareholders deliberating in the manner required for the modification of the present articles of association, in accordance
with Article 32 hereinafter.

Art. 7. Shareholders 'meeting.
7.1 Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company (the "General Meeting" shall represent

the entire body of shareholders of the Company. It is vested with the broadest powers to order, carry out or ratify all
acts relating to the operations of the Company. When and as long as the Company has one single shareholder, the latter
shall exercise the powers granted by the law to the General Meeting.

7.2 Each share is entitled to one vote. Any shareholder of the Company may act during any General Meeting by giving

a proxy to any other person as his representative, by letter, fax, telegramme, telex or e-mail provided the authenticity
of such e-mail can be established.

7.3 Any shareholder of the Company may take part and vote in any General Meeting by videoconference or any other

similar means of communication that enables the persons participating at the General Meeting to communicate simulta-
neously and hear each other. The participation in or the holding of a meeting by these means shall be deemed equivalent
to a participation in person at or the holding of such meeting.

7.4 In compliance with the law, the yearly General Meeting shall be held at the registered office of the Company or at

any other place in Luxembourg that shall be set in the convening notice, on the third Friday of the month of May of each
year at ten (10) o'clock (Luxembourg time). If this day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general
meeting shall be held on the next business day. The yearly General Meeting may be held abroad if, in the absolute and
final judgement of the Managing Board, exceptional circumstances so require.

7.5 Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices

of meeting.

Art. 8. Notification deadlines, Quorum, Convening notices, Proxies, and Vote.
8.1 Notification deadlines and quorums required by the law shall apply to the convening notices and to the conduct

of the General Meeting, except as otherwise provided in the articles of association.

8.2 A General Meeting may be convened be the Managing Board as well as by the Supervisory Board. They shall be

obliged to convene it so that it is held within a period of one month if shareholders representing one tenth of the capital
require so in writing with an indication of the agenda. One or more shareholders who together hold at least ten percent
of the corporate capital may request that one or more additional items be put on the agenda of any General Meeting.
Such request shall be sent by registered letter and received by the Company at last five (5) days prior to holding of the
General Meeting. The Managing Board or the Supervisory Board may set any other requirement that shall have to be
fulfilled by the shareholders in order to attend a General Meeting.

8.3 Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements

published twice, with a minimum interval of eight days (8) and eight days (8) before the meeting, in the Mémorial and in
a Luxembourg newspaper.

8.4 Notices by mail shall be sent eight days before the General Meeting to registered shareholders, but no proof need

be given that this formality has been complied with.

8.5 Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made only by registered letters.
8.6 Unless otherwise provided by the law or by the articles, resolutions at a general meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of the shares.

8.7 The General Meeting shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda

indicates the proposed amendments to the articles and, where applicable, the text of those which concern the objects
or the form of the company If the first of these conditions is not satisfied, a second General Meeting may be convened,
in the manner prescribed by the articles, by means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and
fifteen (15) days before the General Meeting in the Memorial and in two (2) Luxembourg newspapers. Such convening
notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second
General Meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both General Meetings,

67942

L

U X E M B O U R G

resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders. Votes cast
shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has
abstained or has returned a blank or invalid vote.

8.8 The nationality of the company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only

with the unanimous consent of the shareholders and bondholders, whether there are bondholders.

8.9 If all the shareholders of the Company are present or represented at the General Meeting, and consider themselves

as being duly convened and informed of the agenda of the Meeting, the meeting may be held without prior notice.

8.10 The General Meeting shall be chaired by the chairman of the Managing Board, or in his absence, by another

member of the Managing Board. If no member of the Managing Board is present, the General Meeting chooses an ad hoc
chairman. The chairman appoints one secretary and the shareholders appoint one scrutineer. The chairman, the secretary
and the scrutineer make up the Bureau (Board).

8.11 Minutes of the General Meeting shall be signed by the members of the bureau of the meeting and by the share-

holders who request to do so.

8.12 However, for any resolution of the General Meeting that need to be certified, copies or extracts of such minutes

which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the Managing Board or
by two members of the Managing Board.

Art. 9. Management of the Company.
9.1 The Company is managed by a Managing Board which fulfils its duties under the supervision of a supervisory board

(the "Supervisory Board").

9.2 The Company must be managed by a Managing Board composed of at least three (3) members, who are not

required to be shareholders.

Art. 10. Appointment and Removal of the members of the Managing Board.
10.1 The members of the Managing Board shall be appointed by The General Meeting. The General Meeting may

remove any member of the Managing Board with or without proper justification.

10.2 Members of the Managing Board may be reelected.
10.3. The term of office for each member of the Managing Board shall be for one (1) year.
10.4 In case of vacancy of the office of a member of the Managing Board as a result of death, retirement, resignation

or any other cause, the Supervisory Board appoints new members to fill the vacancy."

10.5 Where a legal entity is appointed as member of the Managing Board, it shall designate a natural person as a

permanent representative who represents it as member of the Managing Board, pursuant to the law.

Art. 11. Meetings of the Managing Board.
11.1 The Managing Board must appoint one chairman (the "Chairman of the Managing Board") among its members

and may appoint one secretary, whether he or she is a member of the Managing Board or not, who shall be in charge of
keeping minutes of the meetings of the Managing Board, and of the decisions taken by the General Meeting. The Chairman
of the Managing Board shall preside at all meetings of the Managing Board. In his absence, the other members of the
Managing Board shall elect another Chairman pro tempore, who shall preside the relevant meeting, where decisions shall
be taken by a majority of votes cast of the members of the Managing Board present or represented at the relevant meeting.

11.2 The meeting of the Managing Board takes place in Luxembourg, if convened by the Chairman of the Managing

Board or by two (2) members of the Managing Board, at the time indicated in the convening notice.

11.3 A written notice of any meeting of the Managing Board is given to all the members of the Managing Board at least

twenty-four (24) hours prior the date planned for the meeting, unless there is special urgency, in which case the nature
and the reasons for the urgency shall be shortly mentioned in the convening notice.

11.4 If all the members of the Managing Board are present or represented at the meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the Meeting, the meeting may be held without prior notice. The
written convening notice may also be waived with the approval of each member of the Managing Board by writing, using
the original copy or by fax or by e-mail. No special convening notice is required for a meeting of the Managing Board
which is held at the place scheduled in a resolution previously adopted by the Managing Board.

11.5 The Managing Board shall meet as often as required by the interest of the company, but at least once every three

months.

11.6 Any member of the Managing Board may be represented at a Managing Board meeting by designating by writing,

using the original copy or by fax or by e-mail, any other member of the Managing Board as his/her proxy.

11.7 The Managing Board can validly deliberate and decide if the meeting takes place in Luxembourg and if at least half

of its members are present or represented. One member of the Managing Board may represent one or several other
members of the Managing Board, provided that two (2) members of the Managing Board are at least physically present
at the meeting. Decisions are made by a majority vote of members present or represented.

11.8 In the event of a tie, the Chair of the Managing Board will have a casting vote.

67943

L

U X E M B O U R G

11.9 Participating to the Managing Board by means of a telephone conference call, video-conference or any other form

of similar communication is allowed.

11.10 Notwithstanding the foregoing clauses, members of the Managing Board may also vote by means of a circular

document in case of emergency or under extraordinary circumstances. Such resolution shall consist of one single or
several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically, by all the members of the Managing
Board. The date of such resolution is the date of the last signature.

Art. 12. Minutes of the Managing Board meetings.
12.1 Minutes of the Managing Board meetings shall be signed by the Chairman of the Managing Board or by any other

member of the Managing Board who took the chair, or by all the members of the Managing Board presents at the meeting.

12.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman of the Managing Board or by two other members of the Managing Board.

Art. 13. Powers and Duties of the Managing Board.
13.1 The Managing Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company's interests. All powers not expressly reserved by the law, or by the articles of association, to the general
meeting or to the Supervisory Board fall within the competence of the Managing Board. Among other, the Managing
Board shall be entrusted with the task of finding new investments, checking the related analytical data, and analysing the
feasibility of such investments. It will also follow up on the investments and prepare the report on the Company invest-
ments.

13.2 At least every 3 (three) months, the Managing Board shall produce a report to the Supervisory Board, that details

the business activities of the Company in progress and their foreseeable development. In addition, the Managing Board
shall inform the Supervisory Board of any event likely to have a major impact on the operations of Company.

13.3 When an operation requires the approval of the Supervisory Board (pursuant to Article 21.3 of the present

articles of association) and in case of refusal by such Supervisory Board, the Managing Board may refer the question to
the General Meeting which shall definitively take the decision.

Art. 14. Delegation of powers.
14.1 The Managing Board may appoint one (or several) day-to-day manager, whether he/she is a shareholder or not,

a member of the Managing Board or not, with the exception of any member of the Supervisory Board, who shall be fully
vested to act on behalf of the Company with respect to day-to-day management.

14.2 The Managing Board may appoint one person, whether he/she is a shareholder or not, a member of the Managing

Board or not, with the exception of any member of the Supervisory Board, who shall act as a permanent representative
of any entity in which the Company is appointed as a member of Managing Board. In all cases, such permanent repre-
sentative shall act following consultations with the Managing Board, on behalf and for the account of the Company, and
shall  bind  such  entity  as  member  of  the  Managing  Board  of  this  entity,  provided  that  the  Managing  Board  has  been
previously consulted.

14.3 The Managing Board may also appoint a person, whether he/she is a member of the Managing Board or not, with

the exception of any member of the Supervisory Board, who shall that the performance of specific tasks for the benefit
of the Company is met.

14.4 Any delegation of powers made under that Article 14 by the Managing Board shall be subject to the provisions

of Article 21.3.

Art. 15. Authorised signatures. In any circumstances, the Company is committed to third parties by the joint signature

of two members of the Managing Board of the Company, among which the signature of the Chairman of the Managing
Board. The company is also committed by the joint signatures of any person or by the individual signature of any person
to whom such power of signature shall be delegated by the Managing Board, but only within the limits of the powers
given by the Supervisory Board to the members of the Managing Board pursuant to Article 21.3. Within the limits of daily
management, the Company is bound by the sole signature of the person appointed to such effect.

Art. 16. Liability of the members of the Managing Board.
16.1 The members of the Managing Board assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any

commitment validly made by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the
articles of association as well as the applicable provisions of the law. They shall be liable to the Company for the execution
of the mandate given to them and for any misconduct in the management of the Company's affairs.

16.2 They shall be jointly and severally liable both towards the Company and any third parties for damages resulting

from the violation of the law or the present articles of association.

Art. 17. Remuneration of the Managing Board.
17.1 The Company shall be entitled to pay special remuneration to the members of the Managing Board and to their

heirs, executors, administrators for any expense reasonably incurred by them in respect of any suit, action, or proceeding
in which they shall be involved due to the fact that they were or are members of the Managing Board or act as the Manager
of the Company or, at the request of any other company for which the Company is a shareholder or a creditor and from

67944

L

U X E M B O U R G

which they are not entitled to be indemnified, except in connection with business in which they shall be finally judged
liable for gross recklessness or mismanagement.

17.2  In  case  of  transaction,  the  remuneration  shall  only  be  paid  in  relation  with  the  business  activities  under  the

transaction and for which the Company is advised by a counsellor that the person to be remunerated has not failed to
fulfil his/her duties in the above mentioned manner. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.

Art. 18. Appointment of the Supervisory Board.
18.1 The management of the Company by the Managing Board is supervised by the Supervisory Board. The Managing

Board is supervised by a Supervisory Board made of three (3) persons at least, who do not need to be shareholders of
the Company.

18.2 Where a legal entity is appointed as member of the Supervisory Board, it shall designate a natural person as a

permanent representative who represents it as member of the Supervisory Board, pursuant to the law.

18.3 General Meetings also determine the number of members making the Supervisory Board, as well as their remu-

neration (if the mandate is remunerated) et the duration of their mandate. Any member of the Supervisory Board may
be revoked at any time pursuant to a decision by the General Meeting.

Art. 19. Meetings of the Supervisory Board.
19.1 The Supervisory Board must appoint one chairman (the "Chairman of the Supervisory Board") among its members

and may appoint one secretary, whether he or she is a member of the Supervisory Board or not, who shall be in charge
of keeping minutes of the meetings of the Supervisory Board. The Chairman of the Supervisory Board shall preside at all
meetings of the Supervisory Board. In his absence, the other members of the Supervisory Board shall elect another
Chairman pro tempore, who shall preside the relevant meeting, where decisions shall be taken by a majority of votes
cast of the members of the Managing Board present or represented at the relevant meeting.

19.2 The meeting of the Supervisory Board takes place in Luxembourg, if convened by the Chairman of the Supervisory

Board or by two members of the Supervisory Board, as often as required by the interest of the Company, at the place
indicated in the convening notice. A meeting must be called by the Chairman of the Supervisory Board if it is requested
by at least two members of the Supervisory Board or by the Managing Board.

19.3 A written notice of any meeting of the Supervisory Board is given to all the members of the Supervisory Board

at least eight (8) hours prior the date planned for the meeting, unless there is special urgency, in which case the nature
and the reasons for the urgency shall be shortly mentioned in the convening notice.

19.4 If all the members of the Supervisory Board are present or represented at the meeting, and consider themselves

as being duly convened and informed of the agenda of the Meeting, the meeting may be held without prior notice. The
written convening notice may also be waived with the approval of each member of the Supervisory Board by writing,
using the original copy or by fax or by e-mail. No special convening notice is required for a meeting of the Supervisory
Board which is held at the place scheduled in a resolution previously adopted by the Supervisory Board.

19.5 The Supervisory Board shall meet as often as required by the interest of the company, but at least once every

three months after the sending of the quarterly report of the Managing Board..

19.6 The Supervisory Board may call upon the members of the Managing Board to attend its meetings. In that particular

case, the members of the Managing Board shall be present as consultative members.

19.7 Any member of the Supervisory Board may be represented at a Supervisory Board meeting by designating by

writing, using the original copy or by fax or by e-mail, any other member of the Supervisory Board as his/her proxy.

19.8 The Supervisory Board can validly deliberate and decide if the meeting takes place in Luxembourg and if at least

half of its members are present or represented. A member of the Supervisory Board may represent more than one of
his colleagues, provided however that two members of the Supervisory Board are at least physically present at the meeting.

19.9 In the event of a tie for and against any resolution, the Chair of the Supervisory Board will have a casting vote.
19.10 Participating to the Supervisory Board by means of a telephone conference call, video-conference or any other

form of similar communication is allowed.

19.11 Notwithstanding the foregoing clauses, members of the Supervisory Board may also vote by means of a circular

document in case of emergency or under extraordinary circumstances. Such resolution shall consist of one single or
several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically, by all the members of the Supervisory
Board (circular resolution). The date of such decision is the date of the last signature.

Art. 20. Minutes of the Supervisory Board meetings.
20.1 Minutes of the Supervisory Board meetings shall be signed by the Chairman of the Supervisory Board or by any

other member of the Supervisory Board who took the chair, or by all the members of the Supervisory Board presents
at the meeting.

20.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman of the Supervisory Board or by two other members of the Supervisory Board.

67945

L

U X E M B O U R G

Art. 21. Powers and Duties of the Supervisory Board.
21.1 The Supervisory Board continuously ensures the control of the management carried out by the Managing Board,

without being authorised to interfere with such management.

21.2  The  Supervisory  Board  shall  have  an  unlimited  right  to  inspect  all  the  transactions  of  the  Company.  At  the

registered office of the Company, its members may inspect the books, accounts, correspondences, minutes and in general
all the records of the Company. Upon request of the Supervisory Board, the Managing Board must pass any information
relevant to exercise supervision of the management. In addition, the Supervisory Board may undertake or arrange for
any investigations necessary for the performance of its duties.

21.3 The Supervisory Board must give its prior approval as far as the following decisions are to be taken by the Managing

Board: (i) any significant change made to the annual budget, (ii) any investment decision related to management for an
amount equal to, or greater than EUR five million (EUR 5,000,000), other than decisions relating to internal transfers to
the Company and to relations between the Company and its direct or indirect branches, (iii) any delegation of powers
granted by the Managing Board pursuant to Article 14, (iv) conclusion of any loan or commitment with one third party
for a principal amount equal to, or greater than EUR one million (EUR 1,000,000).

Art. 22. Delegation of powers.
22.1 The Supervisory Board may entrust one or more of its members with special mandates for one or more specific

purposes. Among other, the Supervisory Board may entrust one or several of its members with its prior approval for
some actions falling under the competence of the Managing Board, as described at Article 21.3.

22.2 The Supervisory Board may decide to establish internal committees. It sets the composition and terms of office

of such committees and such committees carry out their activities under its responsibility. The attribution of such duties
may however not consist in a delegation to a committee of the powers reserved by law or by the articles to the Supervisory
Board itself or result in a reduction or limitation of the powers of the Managing Board.

Art. 23. Liabilities of the members of the Supervisory Board.
23.1 The members of the Supervisory Board assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company in relation with their duties of supervision of the
management,  so  long  as  such  commitment  is  in  compliance  with  the  articles  of  association  as  well  as  the  applicable
provisions of the law. They shall be liable to the Company for the execution of the mandate given to them and for any
misconduct in the supervision of the Company's affairs.

23.2 They shall be jointly and severally liable both towards the Company and any third parties for damages resulting

from the violation of the law or the present articles of association.

Art. 24. Remuneration of the Supervisory Board.
24.1 The Company shall be entitled to pay special remuneration to the members of the Supervisory Board and, whether

relevant, to their heirs, executors, administrators for any expense reasonably incurred by them in respect of any suit,
action, or proceeding in which they shall be involved due to the fact that they were or are members of the Supervisory
Board or act as the Manager of the Company or, at the request of any other company for which the Company is a
shareholder or a creditor and from which they are not entitled to be indemnified, except in connection with business in
which they shall be finally judged liable for gross recklessness or lack of supervision.

24.2  In  case  of  transaction,  the  remuneration  shall  only  be  paid  in  relation  with  the  business  activities  under  the

transaction and for which the Company is advised by a counsellor that the person to be remunerated has not failed to
fulfil his/her duties in the above mentioned manner. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.

Art. 25. Being a member of the Managing Board and the Supervisory Board.
25.1 No person may at the same time be a member of the Managing Board and the Supervisory Board.
25.2 However, in the event of a vacancy in the Managing Board, the Supervisory Board may appoint one of its members

to act as a member of the Managing Board. During such period, the functions of the person concerned as a member of
the Supervisory Board shall be suspended.

Art. 26. Conflicts of interest.
26.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the members of the Managing Board or Supervisory Board or proxy
holders of the Company is personally interested in, or is a member of the Managing Board, a director, associate officer
or employee of such other company or firm.

26.2 Any member of the Managing Board or Supervisory Board or proxy holder of the Company who is a member of

the Managing Board, or serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall
contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such an affiliation with such other company or firm but
subject as hereinafter provided, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

67946

L

U X E M B O U R G

26.3 In the event that any member of the Managing Board or Supervisory Board of the Company may have any personal

and opposite interest in any transaction of the Company, such member of the Managing Board or Supervisory Board shall
make known to the Managing Board or Supervisory Board such personal and opposite interest and such conflict shall be
reported in the minutes of the resolutions. The concerned person shall not take part to deliberations and vote on such
matters; such personal interest of the member of the Managing Board or Supervisory Board shall be reported to the next
succeeding meeting.

26.4 In addition, if one member of the Managing Board has a personal and conflicting interest in one operation of the

Company, the approval of the Supervisory Board is required for such operation.

26.5 The two preceding paragraphs do not apply to resolutions related to operations carried out in the normal run

of the Company, concluded on normal terms.

Art. 27. Disclosure of information.
27.1 Members of the Managing Board and the Supervisory Board, as well as any person convened to attend the meetings

of these bodies, are bound by complete discretion with respect to confidential information they have on the Company,
except where such disclosure is required or allowed by the laws or regulations in force for the public limited companies,
or is in the public interest. This obligation continues after their term of office expires.

27.2 For the purposes of this Article 27, the term "confidential information" shall mean any information disclosed by

the Company by any means and related to transactions, investments, and business operations made by the Company.

Art. 28. Auditors - Independent chartered auditors. The operations of the Company shall be supervised by one or

serveral auditors ('commissaires aux comptes') or, if required by the law, by a chartered auditor ('réviseur d'entreprises
agréé'), who shall be appointed by the General Meeting for a duration not exceeding six years.

Art. 29. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first day of the month of January and shall

end on the last day of the month of December of the same year.

In compliance with the law, each year, after the closing of the financial year, the Managing Board shall prepare an

inventory indicating the value of all the movable and immovable assets of, and all the debts owed to and by, the Company,
and the balance sheet and profit and loss account. The Managing Board submits those documents, with a report on the
activities of the Company, to the auditor or, as the case may be, to the chartered auditor, who shall prepare one report
containing his report on such documents.

Art. 30. Allocation of profits. From the net profits of the company at least five percent (5%) shall be set aside each

year to constitute the legal reserve. Such deduction shall no longer be required as soon as this legal reserve reaches one
tenth (10%) of the subscribed share capital.

Upon proposal of the Managing Board, the general meeting shall decide on the allocation of the balance of the net

profits, and may, without never exceeding the amounts proposed by the Managing Board, decide in a timely manner of
the payment of dividends, provided that the priority distribution of the Profit Shares was approved in advance.

Interim dividends can also be distributed, under conditions laid down in the law, upon decision by the Managing Board.
Dividends may be paid in any currency, at a time and place as determined by the Managing Board.
The Managing Board may make the final decision as far as the rates applicable are concerned, in order to convert the

amounts of the dividends into the currency used for their pavement.

One dividend declared but not paid for one share during five years may not subsequently be claimed by the owner of

such share, shall be lost for this owner and returned to the Company.

No interest shall be paid on the dividends declared and not paid, which are held by the Company on behalf of share-

holders.

Art. 31. Dissolution and Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation of the Company shall

be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general
meeting of shareholders in charge of such dissolution, and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 32. Amendment of the Articles of Association. The present articles of association may be amended from time to

time by the General Meeting voting in the conditions of quorum and majority foreseen by the law.

Art. 33. Applicable law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with provisions of the Law of ten August nineteen fifteen on commercial companies and of amending laws.

Art. 34. Sole Shareholder. If, and as long as all the shares of a Company come to be held by a sole shareholder, the

Company shall exist as single-member company and the sole shareholder shall exercise all the powers entrusted to the
General Meetings.

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

de l'augmentation de son capital social sont estimés à mille trois cents euros (EUR 1.300).

67947

L

U X E M B O U R G

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de

l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe
(s)) au présent acte.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, les membres du bureau et comparants ont signé ensemble avec le notaire, le présent

acte.

Signé: Pierre Dagallier, Alain Robillard, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 16 avril 2013. LAC / 2013 / 17432. Reçu 75.-€

<i>Le Receveur

 (signé): Carole Frising.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 avril 2013.

Référence de publication: 2013051618/480.
(130063255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

Think 2 Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5521 Remich, 10, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 162.214.

L'an deux mille treize, le douze avril.
Par-devant Nous Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THINK 2 CONSULT S.A.,

ayant son siège social à L-5447 Schwebsange, 79, route du Vin, inscrite sous le numéro B 162214 auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant du 11 juillet
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2097, du 8 septembre 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Stefan Zwaenepoel, demeurant à Remich.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Katja Lochtman, demeurant à Remich.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Lochtman, prénommée.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de la société à L-5521 Remich, 10, rue Dicks et modification afférente de l'article 2, première

phrase, des statuts.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  et  le  bureau  de  l'assemblée,  restera  annexée  au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregis-
trement. Il ressort de cette liste de présence que l'intégralité du capital social de la société est dûment représentée à
l'assemblée.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le président et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée

et après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, et sans abstentions, la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-5521 Remich, 10, rue Dicks et de modifier l'article 2,

première phrase, des statuts comme suit:

« Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Remich.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres

du bureau ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: S. ZWAENEPOEL, K. LOCHTMAN, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 17 avril 2013. Relation: REM/2013/628. Reçu soixante-quinze euros 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

67948

L

U X E M B O U R G

Remich, le 18 avril 2013.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2013051780/41.
(130062699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

Sweden Lux Incentive 2012 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 174.621.

In the year two thousand and thirteen, on the third day of April.
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company "SWEDEN LUX INCENTIVE 2012 S.A.",

(the "Company"). with registered office in L-8041 Strassen, 80, rue des Romains, filed at the Luxembourg Trade and
Companies Register, under section B, number 174.621 incorporated on 21 November 2012 by deed of the officiating
notary, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number 589 on 11 March 2013. The by-laws
were amended by a deed of the officiating notary, on 17 January 2013, in process of being published in the "Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations".

The meeting is opened by Mrs Cristiana SCHMIT-VALENT, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route

de Luxembourg, in the Chair.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing profes-

sionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- Amendment of article 6 and the fourth paragraph of article 8 of the By-Laws.
2.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:

<i>Sole resolution

The meeting resolves to amend article 6 and the fourth paragraph of article 8 of the by-laws, in order to give it the

following wording.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by the Law.

The Company may issue ordinary shares and/or preferred shares.
Class B Redeemable Preferred Shares, Class C Redeemable Preferred Shares and Class D Redeemable Preferred Shares

may only be subscribed by shareholders (i) holding Class A Ordinary Shares and (ii) committing to provide the Company
a certain guarantee to be agreed on between the Company, the relevant shareholders and the relevant third party.

Class B Redeemable Preferred Shares, Class C Redeemable Preferred Shares and Class D Redeemable Preferred Shares

shall not entail any voting right, subject to the provisions of the Law. They shall all together grant their holders a preferred
dividend calculated as 92% of the adjusted profits, i.e. the profits generated by the investments of the Company after
payment of all the creditors of the Company, realized by the Company (the "Total Preferred Dividend") and paid upon
decision of the board of directors of the Company as follows:

- Preferred Dividend of all Class B Redeemable Preferred Shares = 2,16 % out of the Total Preferred Dividend. Such

dividend shall further be split amongst the holders of Class B Redeemable Preferred Shares in proportion to the number
of Class B Redeemable Preferred Shares they hold in the Company.

- Preferred Dividend of all Class C Redeemable Preferred Shares = 5,86 % out of the Total Preferred Dividend. Such

dividend shall further be split amongst the holders of Class C Redeemable Preferred Shares in proportion to the number
of Class C Redeemable Preferred Shares they hold in the Company.

67949

L

U X E M B O U R G

- Preferred Dividend of all Class D Redeemable Preferred Shares = 91,98 % out of the Total Preferred Dividend. Such

dividend shall further be split amongst the holders of Class D Redeemable Preferred Shares in proportion to the number
of Class D Redeemable Preferred Shares they hold in the Company.

The preferred dividend remaining unpaid due to a lack of sufficient cash-flow shall be rolled over on the following

financial year. Class B Redeemable Preferred Shares, Class C Redeemable Preferred Shares and Class D Redeemable
Preferred Shares shall not entitle their holder to any ordinary dividend and any liquidation proceeds.

Each of Class B Redeemable Preferred Shares, Class C Redeemable Preferred Shares and Class D Redeemable Pre-

ferred Share shall be redeemed by the Company at the discretion of the board of directors at their redemption price
corresponding to their accountable par value plus any accrued and unpaid dividend.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered
shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed
by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided

for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may

be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual.
A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
must be filed in accordance with article 9 §§ 1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Company."

 Art. 8. (4 

th

 paragraph).  Each Class A Ordinary Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting

of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile."

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at nine hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

proxyholder and members of the board, the present deed is worded in English followed by a French version; on the
request of the same members of the board and proxyholder appearing and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder and members of the board appearing, known to the notary, by

their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trois avril.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SWEDEN LUX INCENTIVE

2012 S.A.», (la «Société») avec siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains, en immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 174.621, constituée le 21 novembre 2012
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 589
du 11 mars 2013. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 janvier 2013,
en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Madame Cristiana SCHMIT-VALENT, employé, demeurant professionnellement à Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé,

demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

67950

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1.- Modification de l'article 6 et du 4 

ème

 alinéa de l'article 8 des statuts.

2.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par

chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle prend à l'unanimité des voix la résolution

suivante:

<i>Unique résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 et le quatrième alinéa de l'article 8 des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

« Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La Société peut émettre des actions ordinaires et/ou des actions préférentielles.
Les Actions Préférentielles Rachetables de Classe B, les Actions Préférentielles Rachetables de Classe C et les Actions

Préférentielles Rachetables de Classe D peuvent uniquement être souscrites par des actionnaires (i) détenant des Actions
Ordinaires de Classe A et (ii) qui s'engagent à fournir à la société une garantie dont les termes ont été conclus entre la
Société, les actionnaires concernées et la tierce personne concernée.

Les Actions Préférentielles Rachetables de Classe B, les Actions Préférentielles Rachetables de Classe C et les Actions

Préférentielles Rachetables de Classe D ne comporteront aucun droit de vote, sous réserve des dispositions de la Loi.
Toutes ces actions feront bénéficier leurs détenteurs d'un dividende préférentiel équivalent à 92% des bénéfices ajustés
réalisés, i.e. les profits générés par les investissements de la Société, après paiements de tous les créanciers de la Société,
par la Société (le «Dividende Préférentiel Total») et seront versés sur décision du conseil d'administration de la manière
suivante:

- Dividende Préférentiel pour toutes les Actions Préférentielles Rachetables de Classe B = 2,16 % du Dividende Pré-

férentiel Total. Ce dividende sera divisé entre les détenteurs d'Actions Préférentielles Rachetables de Classe B, au prorata
des Actions Préférentielles Rachetables de Classe B, détenues par ces derniers dans la Société.

-  Dividende  Préférentiel  pour  toutes  les  Actions  Préférentielles  Rachetables  de  Classe  C  =  5,86  %  du  Dividende

Préférentiel Total. Ce dividende sera divisé entre les détenteurs d' Actions Préférentielles Rachetables de Classe C, au
prorata des Actions Préférentielles Rachetables de Classe C, détenues par ces derniers dans la Société.,

- Dividende Préférentiel pour toutes les Actions Préférentielles Rachetables de Classe D = 91,98 % du Dividende

Préférentiel Total. Ce dividende sera divisé entre les détenteurs d'Actions Préférentielles Rachetables de Classe D, au
prorata des Actions Préférentielles Rachetables de Classe D, détenues par ces derniers dans la Société..

Le dividende préférentiel resté impayé en raison d'un manque de trésorerie sera reporté sur l'exercice social suivant.

Les Actions Préférentielles Rachetables de Classe B, les Actions Préférentielles Rachetables de Classe C et les Actions
Préférentielles Rachetables de Classe D ne devront pas faire bénéficier leurs détenteurs de dividendes ordinaires et du
boni de liquidation.

Chacune des Actions Préférentielles Rachetables de Classe B, des Actions Préférentielles Rachetables de Classe C et

des Actions Préférentielles Rachetables de Classe D devront être rachetées par la Société à la discrétion du conseil
d'administration à leur prix de rachat correspondant à leur pair comptable plus tout dividende accumulé et impayé.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra  les  indications prévues  à l'article 39  de  la  Loi. La propriété des actions nominatives  s'établit  par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 

er

 et 2. de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de

67951

L

U X E M B O U R G

la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.»

«  Art. 8. (4 

ème

 alinéa).  Toute Action de Classe A donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux

assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme
son mandataire.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire et des

membres de bureau comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire et aux membres de bureau comparants, connus du notaire

par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cristiana SCHMIT-VALENT, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2013. Relation GRE/2013/1504. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013051640/183.
(130063329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

Royalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 143.851.

L'an deux mille treize, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER. notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de "ROYALUX S.A.". R.C.S. Luxembourg Numéro B 143.851 ayant son siège social à L-9706 Clervaux,
2A/46. route d'Eselborn, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 18 décembre 2008, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 156 du 23 janvier 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joseph DELREE, expert-comptable, demeurant professionnel-

lement à L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, domiciliée profession-

nellement au 74. Avenue Victor Hugo. L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, Maître en Droit, domicilié professionnellement au 74,

Avenue Victor Hugo. L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille deux cents

(3.200) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de
trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social à L-1331 Luxembourg, 57, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte et modification subsé-

quente du deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts.

2. Dissolution de la société et mise en liquidation.
3. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

67952

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'assemblée  générale  décide  de  transférer  le  siège  social  à  L-1331  Luxembourg,  57,  Boulevard  Grande-Duchesse

Charlotte.

En conséquence le deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Alinéa 2.  Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateurs, pour la durée de la liquidation;
- Monsieur Eric BARAKOWSKY, comptable, né le 2 juillet 1978 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 57, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

- Monsieur Dieter GROZINGER DE ROSNAY, juriste, né le 22 mai 1960 à Neuenburg am Rhein (Allemagne), de-

meurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste-Croix,

qui auront les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues

à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de la société pour

l'exécution de leur mandat.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. DELREE, C. PETIT, R. THILL et M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1er mars 2013. LAC/2013/9517. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2013.

Référence de publication: 2013051553/63.
(130062793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

Recypatents S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 140.000,00.

Siège social: L-4070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 156.925.

L'an deux mil treize, le vingt-huit mars.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Ecore Luxembourg S.A., (anciennement: RECYLUX GROUP S.A.), une société anonyme de droit luxembourgeois,

avec siège social au 462, Route de Longwy, L-4832 Rodange, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19.793,

dûment représentée par deux de ses administrateurs Monsieur Bruce MONNIER et Monsieur Guillaume DAUPHIN,

eux-mêmes ici représenté par Madame Corinne PETIT, employée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé à Bertrange le 12 mars 2013.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a déclaré être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée "RECYPATENTS S.àr.l.",

ayant  son  siège  social  au  462,  Route  de  Longwy,  L-4832  Rodange,  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Georges
D'HUART, notaire alors de résidence à Pétange en date du 11 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2858 du 29 décembre 2010 et modifié en dernier lieu en date du 4 mai 2012, suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2201 du 5 septembre
2012.

67953

L

U X E M B O U R G

Le capital social est fixé à cent quarante mille euros (140.000.- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de mille quatre cents euros (1.400.- EUR) chacune, entièrement libérées.

Ensuite le comparant déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que l'ordre du jour des présentes est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social du 462, Route de Longwy, L-4832 Rodange au 39, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,

avec effet au 4 mars 2013;

2. Modification conséquente de l'article 2 des statuts de la Société;
3. Divers.
L'associé unique siégeant en assemblée générale a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société du 462, Route de Longwy, L-4832 Rodange au 39,

rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, avec effet au 4 mars 2013.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts afin de leur donner la

teneur suivante:

« Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en

toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,

suite à la présente modification, est estimé approximativement à mille euros (1.000.- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente

minute.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 avril 2013. Relation: LAC/2013/15732. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 22 avril 2013.

Référence de publication: 2013051557/55.
(130063181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

Una Mas, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 32, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 176.701.

STATUTS

L'an deux mille treize, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Alain LORANG, né à Luxembourg le 15 mars 1967, demeurant à L-2343 Luxembourg, 115, rue des Pom-

miers,

ci-après dénommée «le comparant».
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-personnelle à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée uni-personnelle sous la dénomination de:

"UNA MAS".
L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également

prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère uni-personnel de la société.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.

67954

L

U X E M B O U R G

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées et restauration ainsi

que toutes activités connexes.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente-et-un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), représenté par

CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de

préemption.

b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu'au partage des-dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont

applicables.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs.

Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-

Duché qu'à l'étranger.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation

personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'associé.

Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mille

treize (31.12.2013).

<i>Souscription et Libération

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur Alain LORANG, né à Luxembourg le 15

mars 1967, demeurant à L-2343 Luxembourg, 115, rue des Pommiers, pré-qualifié.

67955

L

U X E M B O U R G

L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès-à-présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Alain LORANG, né à Luxembourg le 15 mars 1967, demeurant à L-2343 Luxembourg, 115, rue des Pom-

miers. La société est valablement engagée par sa seule signature.

2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
L-1648 Luxembourg, 32, Place Guillaume II.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, le comparant a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: LORANG M., MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19/04/2013. Relation: EAC/2013/5227. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 22 avril 2013.

Référence de publication: 2013051677/94.
(130062719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

Global-Waste-Energy S.A., Société Anonyme,

(anc. Spirallux S.A.).

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 156.030.

Im Jahre zweitausenddreizehn, den zehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich.
Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft "SPIRALLUX S.A.", mit Sitz zu L-5450 Stadtbredimus, 5c, route du

Vin, zu einer außerordentlichen Generalversammlung Genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschafts-
register zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 156.030, wurde gegründet durch notarielle Urkunde vom 14. September
2010, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2519 vom 19. November 2010.

Die Versammlung findet statt unter dem Vorsitz von Herrn Michael SCHERER, Hotelier, wohnhaft in D-66271 Blies-

ransbach, 71, Bliesbolchenerstrasse.

Der Vorsitzende beruft als Schriftführer Herrn Harald FORD, Kaufmann, wohnhaft in D-67697 Otterberg, Lauers-

trasse 18.

Die Versammlung wählt als Stimmzähler Herrn Urs SCHMUTZ, Geschäftsführer, wohnhaft in Oevermo Moskogsvägen

27, SE-793 92 Leksand.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar

zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in

gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktieninhabern
respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger
Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäß durch die Erschienenen
und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektive Vertretung sämtlicher Aktieninhaber,

regelmäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1. Abberufung von Herrn Lutz FRITSCH als Mitglied und Delegierter des Verwaltungsrates und Entlastung für die

Ausübung seines Mandats.

67956

L

U X E M B O U R G

2. Ernennung von Herr Harald FORD als neues Mitglied des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversamm-

lung der Aktionäre des Jahres 2016.

3. Ernennung von Herrn Harald FORD als Delegierter des Verwaltungsrates und Festlegung seiner Unterschriftsvoll-

macht.

4. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft und Anpassung von Artikel 4 der Satzung.
5. Änderung der Firmenbezeichnung in „GLOBAL-WASTE-ENERGY S.A." und Anpassung von Artikel 1 der Satzung.

Nach Vortrag dieser Punkte sowie deren Bestätigung durch die Generalversammlung beschließen die Aktionäre einstim-
mig wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abberufung von Herrn Lutz FRITSCH als Mitglied und Delegierter des Verwaltungs-

rates und erteilt ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandats.

<i>Zweiter Beschluss

Die  Versammlung ernennt als  neues  Mitglied  des  Verwaltungsrates bis  zur  ordentlichen Generalversammlung der

Aktionäre des Jahres 2016 Herr Harald FORD, vorbenannt.

<i>Dritter Beschluss

Herr Harald FORD wird als Delegierter des Verwaltungsrates ernannt bis zur ordentlichen Generalversammlung der

Aktionäre des Jahres 2016. Der Delegierte des Verwaltungsrates hat die Befugnis die Gesellschaft mit seiner alleinigen
Unterschrift zu verpflichten im Rahmen der normalen Geschäftsausübung der Gesellschaft, inklusive alle Bankoperationen.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung des Gesellschaftszwecks und Artikel 4 der Satzung folgenden Wortlaut

zu geben:

„ Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung oder Vermittlung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der

Vorbereitung, der Projektierung, der Finanzierung, der Organisation, dem Engineering und der Realisierung von Indus-
trieprojekten aller Art, ferner den Handel mit oder die Vermittlung von Ausrüstungsteilen, Maschinen und Industriean-
lagen  aller  Art,  die  Durchführung  von  projektspezifischen  Untersuchungen,  Recherchen  und  Forschungen  sowie  die
Erstellung, Beschaffung, Analyse, Aufbereitung und Vermittlung von Informationen, Beratungen und Gutachten in Bezug
auf Industrieprojekte, der Energiegewinnung sowie der Gewinnung und Verarbeitung von Energieträgern, ferner die Er-
bringung  oder  Vermittlung  verwandter  Dienstleistungen  sowie  die  Wahrnehmung  von  Schnittstellen-Funktionen  zu
externen Dienstleistungserbringern und Fertigungsunternehmen in Luxemburg und im Ausland.

Die Gesellschaft kann unter dem Oberbegriff „Intellectual Property" noch folgend aufgelistete Rechte erwerben und

in Form von Lizenz- und Franchisemodellen weltweit vermarkten:

- Patente,
- Designs,
- Modelle,
- Gebrauchsmuster,
- Marken usw.
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an an-

deren Gesellschaften im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten,
Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen und Finanzierungen vermitteln sowie alle Geschäfte ein-
gehen und Verträge abschließen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder
indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräußern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen

Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen."

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung der Firmenbezeichnung in „GLOBAL-WASTE-ENERGY S.A." und An-

passung von Artikel 1 der Satzung wie folgt:

„ Art. 1. Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „GLOBAL-

WASTE-ENERGY S.A." gegründet". Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, ist die Versammlung hiermit
geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten, dem Notar mit Namen, Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. SCHERER, H. FORD, U. SCHMUTZ, Patrick SERRES.

67957

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Remich, le 11 avril 2013. Relation: REM/2013/616 Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Remich, den 18. April 2013.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2013051778/91.
(130062723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

SES Astra 5B S.à.r.l., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 122.975.

EXTRAIT

Suite aux résolutions de l'actionnaire unique en date du 27 mars 2013, le mandat du réviseur d'entreprises, Ernst &amp;

Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, n'a pas été renouvelé.

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg a été élu Réviseur d'Entreprise

et le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Betzdorf, le 22 avril 2013.

Référence de publication: 2013053007/15.
(130064395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Freenom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 15, Gruuss Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 176.724.

STATUTES

In the year two thousand and thirteenth, on the seventeenth day of April.
Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

OpenTLD B.V., a company incorporated under the laws of Netherlands by a deed of notary Van Erp Netwerk Nota-

rissen on 28 

th

 of March 2012, having its registered office at Keizersgracht 213, 1016 DT Amsterdam, Netherlands, and

registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 54730619, represented by Mr Johannes Wilhelmus
Antonius  Zuurbier,  businessman,  having  his  professional  residence  at  Brouwersgracht  19,  1015  GA  Amsterdam,  the
Netherlands.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed

a single member limited liability company and to draw up its Articles of Incorporation as follows:

Title I. - Name - Registered office - Purpose - Duration

Art. 1. There is hereby established a single member limited liability company which will be governed by the laws in

effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies, as amended from time to time,
September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single member limited liability
companies (hereafter the "Law") as well as by the present articles (hereafter the "Articles").

Art. 2. The name of the company is "FREENOM S.a R.L.".

Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Weiswampach. It can be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the
manner provided for amendments to the Articles.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

67958

L

U X E M B O U R G

Art. 4. The company shall have as its business purpose to engage in all activities related to Internet domain name buying,

selling, trading, registration and administration, and any other lawful activities not prohibited to a corporation engaging
in such profession by applicable laws and regulations.

In general, the Company may carry out any movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as

all transactions and that aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its
purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited term.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the company.

Title II. - Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at TWELVE THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (EUR 12.400.-) divided

into ONE HUNDRED (100) parts of ONE HUNDRED AND TWENTY FOUR EURO (EUR 124.-) each.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter

vivos to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing
at least three quarters (3/4) of the share capital of the company.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.

Art. 9. The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any

circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any
way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III. - Management

Art. 10. The company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) may be revoked ad
nutum.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to

perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those
expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of participants.

Any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by

the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated for this
purpose.

In case of plurality of managers, the company shall be bound by the joint signature of any two members of the board

of managers, in case of a sole manager, the company shall be bound by his sole signature.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

In case of plurality of managers, the board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its

members is present either in person or by proxy.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either

in person or by proxy.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Title IV. - General meeting of participants

Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10 

th

 , 1915.

67959

L

U X E M B O U R G

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall

be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing
more than fifty per cent (50%) of the capital.

However, resolutions to alter the Articles of the company may only be adopted by a quorum of at least fifty per cent

(50%) of the existing share capital and the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the issued voting rights present
or represented at the general meeting amending the Articles, further subject to the provisions of the Law.

All general meetings of participants shall take place in Luxembourg.
Each part carries one vote at all meetings of participants.
Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him

at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.

Title V. - Financial year - Profits - Reserves

Art. 12. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of the

same year.

Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as

a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the pro-

visions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The remainder of the net profit is at the disposal of the general meeting of participants.

Title VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 14. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need

not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by the Law. The liquidator(s) shall
be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse

the contribution made by the participants on the parts of the company.

The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective participation in the company.

Title VII. - Varia

Art. 15. The parties refer to the existing Law and regulations for all matters not mentioned in the present Articles.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the company and shall end on the 31 

th

 of December

2013.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

OpenTLD B.V., prenamed, one hundred parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL, one hundred parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

The parts have been fully paid up to the amount of ONE HUNDRED AND TWENTY FOUR EURO (EUR 124.-) per

part by a contribution in cash of TWELVE THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (EUR 12,400.-).

As a result, the amount of TWELVE THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (EUR 12,400.-) is as of now at the disposal

of the company as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its organization, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

<i>Extraordinary general meeting

After the Articles have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an

extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is fixed at L-9991 Weiswampach, 15, Gruuss Strooss;
2) Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined term:

67960

L

U X E M B O U R G

a) Johannes Wilhelmus Antonius Zuurbier, businessman, born on 24 

th

 of January 1972, in Velsen, Netherlands, having

his professional residence at Brouwersgracht 19, 1015 GA Amsterdam, the Netherlands;

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a German version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and German text, the English version shall prevail.

The undersigned notary has drawn the attention of the appearing persons to the fact that prior to any commercial

activity of the company hereby incorporated, it has to obtain the trading permit(s) in connection with the social object,
which is hereby expressly acknowledged by the appearing persons.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

Follows the german version

Im Jahre zweitausenddreizehn, am siebzehnten Tag im Monat April.
Vor Maitre Paul BETTINGEN, Notar mit dem Amtssitz in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg.

ERSCHIEN:

OpenTLD B.V., eine nach dem niederländisches Recht durch Urkunde des Notars Van Erp Netwerk Notarissen am

28. März 2012, gegründete Gesellschaft, die ihren Sitz in Keizersgracht 213, 1016 DT Amsterdam, Netherlands hat, und
beim Amsterdam Chamber of Commerce unter der Nummer 54730619 registriert ist, vertreten durch Herrn Johannes
Wilhelmus Antonius Zuurbier, Unternehmer, beruflich wohnhaft in Brouwersgracht 19, 1015 GA Amsterdam, die Nie-
derlande vertreten werden.

Die vorgenannte Partei, vertreten wie vorerwähnt, erklärt ihre Absicht, mit dieser Urkunde eine unipersonale Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen mit folgender Satzung:

Titel I. - Firma - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgi-

schen  Gesetzen  und  insbesondere  dem  Gesetz  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften  und  dessen
Abänderungen, dem Gesetz vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wie abgeändert, und
dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung (hiernach die "Ge-
setze") und der hiernach folgenden Satzung (die "Satzung") unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft führt die Firma "FREENOM S.à R.L.".

Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist in der Gemeinde Weiswampach. Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesell-

schafter, welcher nach den Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort
innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Im Falle außergewöhnlicher politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse, welche auftreten oder sich dringlich ergeben

und die normale Aktivität oder Kommunikation am Gesellschaftssitz mit dem Ausland erschweren, kann der Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese Ereignisse oder Umstände nicht mehr vorhanden sind.

Eine solche Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Entscheidung wird durch das

Organ der Gesellschaft an Drittparteien bekannt gemacht, welches am besten dafür in der Lage ist.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Verkauf, Handel, Registrierung und

Verwaltung von Internet-Domain-Namen, sowie etwaige sonstige rechtmäßige Aktivitäten betreffend Kapitalgesellschaf-
ten, unter Vorbehalt der Aktivitäten die durch geltende Gesetze und Vorschriften verboten sind.

Ganz allgemein kann die Gesellschaft sämtliche immobilienbezogene Geschäfte, Handelsgeschäfte, gewerbliche oder

finanzielle Geschäfte tätigen sowie sämtliche Transaktionen und Geschäfte, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar
die Verwirklichung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines

Gesellschafters aufgelöst.

Titel II. - Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSENDVIERHUNDERT EURO (EUR 12.400,-), eingeteilt in EIN-

HUNDERT (100) Anteile von je EINHUNDERTVIERUNDZWANZIG EURO (EUR 124,-).

Art. 8. Die Anteile können, solange es nur einen Gesellschafter gibt, von diesem Gesellschafter ohne Beschränkungen

übertragen werden.

67961

L

U X E M B O U R G

Im Falle, dass es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Über-

tragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindes-
tens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, erfolgen.

Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handels-

gesellschaften verwiesen.

Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Sie-

gelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang
der Gesellschaft beeinträchtigen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung be-

ziehen.

Titel III. - Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche von den Gesellschaftern für eine

unbestimmte Dauer gewählt werden, verwaltet. Sofern mehrere Geschäftsführer gewählt sind, bilden sie einen Vorstand.
Die Geschäftsführer können ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit den größtmöglichen Befugnissen

ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesell-
schaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder
diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden.

Sollte die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte in einem Rechtsstreit auftreten, vertritt der Geschäftsführer, oder

im Falle des Vorstandes der vom Vorstand dafür autorisierte Geschäftsführer, die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen.

Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Mitgliedern des Vorstandes rechtswirksam verpflichtet, im Falle eines alleinigen Geschäftsführers wird die Gesellschaft
durch seine alleinige Unterschrift rechtswirksam verpflichtet.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle

Aufgaben an Unterbevollmächtigte oder an einen oder mehrere ad hoc Vertreter delegieren.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner

Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.
Alle Treffen des Vorstandes finden in Luxemburg statt.
Beschlüsse, welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, gelten als genauso wirksam angenommen,

als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären.
Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie
können durch Brief, Telefax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.

Außerdem  soll  jedes  Vorstandsmitglied  -  welches  an  einer  Vorstandssitzung  im  Wege  einer  Kommunikationshilfe

(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den (selbst, durch Vollmacht oder ebenfalls durch eine Kommunikationshilfe)
anwesenden Vorstandsmitgliedern erlaubt, das andere Vorstandsmitglied jederzeit während der Sitzung zu hören und
selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und
mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst

gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.

Titel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 11. Der einzige Gesellschafter ist mit allen Zuständigkeiten ausgestattet, die der Gesellschafterversammlung nach

Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 eingeräumt werden.

Alle Entscheidungen, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder des Vorstandes fallen, kön-

nen  vom  Gesellschafter  getroffen  werden.  Jede  solcher  Entscheidungen  muss  schriftlich  verfasst,  in  einem  Protokoll
festgehalten und in einem speziellen Register registriert werden.

Sollte mehr als ein Gesellschafter existieren, so werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterver-

sammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als ange-
nommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.

Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung können nur wirksam gefasst werden, wenn ein solcher Beschluss von zwei

Dritteln (2/3) der anwesenden oder vertretenen Stimmrechte gefasst wird, wobei mindestens fünfzig Prozent (50%) des
existierenden Gesellschaftskapitals bei der Generalversammlung anwesend sein muss, ergänzt durch die Vorschriften des
Gesetzes.

Alle Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Jeder Gesellschaftsanteil beinhaltet das Recht zur Abgabe einer Stimme auf jeder Gesellschafterversammlung.

67962

L

U X E M B O U R G

Jeder Gesellschafter kann im Wege einer schriftlichen Vollmacht eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss,

autorisieren, ihn auf einer Gesellschafterversammlung zu vertreten und in seinem Namen und auf seine Rechnung abzu-
stimmen.

Titel IV. - Geschäftsjahr - Gewinn - Reserven

Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezembertag desselben

Jahres.

Art. 13. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats September, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der

Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Das Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und

der Provisionen, stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-

ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und
aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.

Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter zur Verfügung.

Titel VI. - Liquidation - Auflösung

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,

welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit den in den Gesetzen be-
stimmten Mehrheiten, ernannt werden. Der (die) Liquidator(en) verfüg(en) über die weitestgehenden Befugnisse zur
Realisierung des existierenden Vermögens und Begleichung der Verpflichtungen.

Der nach der Begleichung aller Kosten, Schulden und Ausgaben, welche aufgrund der Liquidation entstehen, zur Ver-

fügung stehende Betrag soll verwendet werden, um die von den Gesellschaftern auf Gesellschaftsanteile eingezahlten
Beträge zurückzuzahlen.

Der danach noch bestehende Restbetrag wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung aus-

gezahlt.

Titel VII. - Verschiedenes

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-

lichen Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013.

<i>Zeichnung

Nachdem diese Satzung wie obenstehend verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, wie folgt Anteile der Gesell-

schaft zu zeichnen:

OpenTLD B.V., vorbenannt, einhundert Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile
GESAMT, einhundert Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile

Die Anteile wurden vollständig bis zu einem Betrag von EINHUNDERTVIERUNDZWANZIG EURO (EUR 124,-) je

Anteil durch Barzahlung in Höhe von ZWÖLFTAUSENDVIERHUNDERT EURO (EUR 12.400,-) eingezahlt.

Als Ergebnis steht ab dem jetzigen Zeitpunkt der Gesellschaft der Betrag von ZWÖLFTAUSENDVIERHUNDERT

EURO (EUR 12.400,-) zur Verfügung, was von dem Notar, welcher diese Urkunde unterzeichnet, bestätigt wird.

<i>Kosten

Die aufgrund dieser Gründung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form, welche

durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-) geschätzt.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Nachdem diese Satzung soeben verabschiedet wurde, entscheidet der oben erwähnte einzige Gesellschafter, eine

Gesellschafterversammlung abzuhalten. Nachdem festgestellt wurde, dass die Gesellschafterversammlung wirksam kon-
stitutiert wurde, hat diese die folgenden Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9991 Weiswampach, 15, Gruuss Strooss;
2) Als Geschäftsführer (gérant) der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer werden folgende Personen ernannt:
a) Johannes Wilhelmus Antonius Zuurbier, Unternehmer, geboren am 24. Januar 1972 in Velsen, Netherlands, beruflich

wohnhaft in Brouwersgracht 19, 1015 GA Amsterdam, die Niederlande;

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung

der oben erschienenen Partei die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Version verfasst

67963

L

U X E M B O U R G

ist, und dass auf Hinweis derselben erschienenen Partei im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen
Versionen, die englische Version massgebend sein soll.

Der Notar hat die Erschienene darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Gesell-

schaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was
die Erschienene ausdrücklich anerkennt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Fa-

milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Johannes Wilhelmus Antonius Zuurbier, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 avril 2013. LAC/2013/18045. Reçu 75,- €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

Für gleichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 22. April 2013.

Référence de publication: 2013051309/309.
(130063290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

Floann S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 4B, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 157.714.

L'an deux mille treize, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme «FLOANN S.A.», établie et ayant

son siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57 Avenue Pasteur, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés,
numéro B 157714, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, en date du 19 novembre 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 387 du 26 février 2011 (ci-après, la «Société»).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Khadigea KLINGELE, juriste, demeurant professionnellement à

Mersch (ci-après, le «Président»).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel Félix Jean Roger BOUILLON, né le 2 janvier 1969 à Bou-

logne-sur-Mer (France), demeurant à L-4360 Esch-sur-Alzette, 4B, Porte de France (ci-après le «Scrutateur»).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
2. Transfert du siège social de L-2311 Luxembourg, 55-57 Avenue Pasteur à L-4360 Esch-sur-AIzette, 4B, Porte de

France et modification, subséquente de l'article 4, alinéa 1 

er

 des statuts;

3. Modification de l'article 8 alinéa 1 

er

 des statuts.

4. Constat de la nouvelle adresse de l'administrateur unique de la Société.
4. Divers.
II.- Que l'actionnaire présent, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par l'actionnaire présent ainsi que par les membres du

bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité
de l'enregistrement.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-

cations d'usage, l'actionnaire présent se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'Ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'Ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

67964

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-2311 Luxembourg, 55-57 Avenue Pasteur à L-4360 Esch-

sur-Alzette, 4B, Porte de France. En conséquence, l'article 4, alinéa premier aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 4. Alinéa 1 

er

 .  Le siège social est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette».

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier également l'article 8 alinéa premier des statuts qui sera désormais lu comme

suit:

«  Art. 8. Alinéa 1 

er

 .  L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, ou à l'endroit indiqué

dans les convocations, le 31 mai de chaque année à 15 heures 25».

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale constate que la nouvelle adresse de l'administrateur unique est la suivante:
L-4360 Esch-sur-Alzette, 4B, Porte de France
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. KLINGELE, E. BOUILLON, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 18 avril 2013. Relation: MER/2013/830. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 23 avril 2013.

Référence de publication: 2013052016/60.
(130063647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

CLM asbl, Coopération Luxembourg - Montenegro, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4289 Esch-sur-Alzette, 15, Quartier.

R.C.S. Luxembourg F 8.574.

<i>Membres fondateurs:

- RAMDEDOVIC Munir, 3 rue principale F-57840 OTTANGE, ingénieur, né le 10 juin 1967, de nationalité Monténé-

grine;

- VILLEMIN Jean, 11 rue de Gaulle F57480 SIERCK-LES-BAINS, chargé de développement, né le 10 décembre 1953 à

Nancy, de nationalité Française;

- SIJARIC Alija, 9 rue de Moulin, L-4882 LAMADELAINE, ingénieur, né le 18 avril 1957, de nationalité Monténégrine;
- LECLERC Bernard, 1 rue Jean et Julien Noirel, F-57710 TRESSANGE, employé de bureau, né le 17 octobre 1951, de

nationalité Française;

- THEOBALD Michel, ingénieur, 21 avenue Sapinière, F- 57490 CARLING, né le 20 décembre 1970, de nationalité

Française;

créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle

a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination «Coopération Monténégro- Luxembourg» association sans but lucratif,

en abrégé «CLM asbl». Elle a son siège à «15 Quartier L - 4289 ESCH-SUR-ALZETTE». Le siège pourra être transféré à
tout autre endroit du Grand-Duché sur simple décision du Conseil d'Administration.

Art. 2. L'association a pour objet de:
- promouvoir la formation sociale et civique des membres de façon à contribuer à leur intégration au Luxembourg et

à leur participation à la vie publique.

- promouvoir l'intégration du Monténégro au sein de l'Union Européenne et des autres institutions internationales;
- promouvoir tout projet ayant pour but le développement durable,
- Sensibiliser et former la population locale dans l'esprit de la sauvegarde d'un environnement naturel intact et pro-

mouvoir des produits alimentaires naturels et une culture de vie en ce sens;

- promouvoir la coopération universitaire et scientifique entre le Luxembourg, la Belgique, la France et le Monténégro;
- organiser des activités et des échanges culturels entre le Luxembourg et le Monténégro;

67965

L

U X E M B O U R G

- organiser une coopération dans le domaine d'un tourisme à vocation écologique;
- Participer à des actions humanitaires en faveur des populations du Monténégro,
- réaliser tout projet défini par Assemblée Générale.

Art. 3. L'association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d'adminis-

tration à la suite d'une demande écrite. Saisi d'une demande d'admission, le conseil d'administration décide si octroyer
de suite le statut de membre effectif ou de membre observateur.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite

au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire après le délai de 3 mois à compter du jour de l'échéance tout membre qui refuse de payer

la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte

aux intérêts de l'association. A partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la
décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est
envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont aucun

droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 100 euros.

Art. 9. L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d'administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, moyennant simple lettre

missive (courriel) devant mentionner l'ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

Art. 12. L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l'association.

Art. 13. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre
des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l'assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par courrier simple /

par internet / affichage au siège etc.

Art. 15.  L'association  est  gérée  par  un  conseil  d'administration  élu  pour  une  durée  de  4  années  par  l'Assemblée

Générale. Le conseil d'administration se compose de 3 à 8 membres; d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire,
d'un trésorier, ainsi qu'éventuellement 4 autres membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à
l'assemblée générale. Le conseil d'administration nomme si besoin est un directeur exécutif et ou toute autre personne
experte dans les missions confiés par l'assemblée générale.

Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants: le président a pour compétence la bonne marche de l'association,

il ordonne les dépenses, il représente l'association dans tous les domaines et dans toutes les missions qui lui sont dévolues;
le vice-président assiste et remplace le président en cas de vacance de ce poste; le secrétaire est en charge du courrier
et de toutes missions et questions administratives concernant l'association, le trésorier gère les comptes et toutes dé-

67966

L

U X E M B O U R G

penses ou recettes diligentées par le président, les autres membres auront un rôle et pourront effectuer toute mission
votées en réunion,....

Art. 16. Le conseil d'administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer que

si 2/3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus, en cas
d'égalité la voix du président est prépondérante:

Art. 17. Le conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'association. Il exécute les directives à lui dévolues

par l'assemblée générale conformément à l'objet de l'association.

Art. 18. Il représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'association soit valablement engagée à

l'égard de ceux-ci, 1 signature de membres (le président ou le secrétaire) en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activités,

les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L'exercice budgétaire commence le 1 

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l'assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.

Afin d'examen, l'assemblée désigne un ou deux réviseurs de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui

d'administrateur en exercice.

Art. 20. En cas de liquidation les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont produites et

ce au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l'association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur.
- les revenus de ses activités

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

En dehors de ses fonctions, il sera possible d'engager un directeur exécutif ou d'autres personnes expertes, cela à

contrat à durée déterminée et ou indéterminée, pour la réalisation des projets et missions définis par l'assemblée générale.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.

Ainsi fait à Esch-Sur-Alzette le 19 avril 2013.

M. RAMDEDOVIC Munir / M. VILLEMIN Jean / M. SIJARIC Alija / M. LECLERC Bernard / M. THEOBALD Michel
<i>Les membres fondateurs

Référence de publication: 2013051763/117.
(130063269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

Pasta Point Pétange Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 29, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 145.465.

L'an deux mille treize.
le dix-sept avril.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- Madame Domenica GARGANO, cuisinière, demeurant à L-4437 Soleuvre, 11, rue de Differdange.
2.- Monsieur Antonio MAELLARO, cuisinier, demeurant à L-4437 Soleuvre, 11, rue de Differdange.
Lesquels comparants sont ici représentés par Monsieur Emmanuel KARP, juriste, demeurant professionnellement à

L-2311 Luxembourg, 5557, avenue Pasteur, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 11 avril
2013,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

67967

L

U X E M B O U R G

Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PASTA POINT PETANGE S.à r.l., avec siège social

à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 145.465 (NIN 2009 2407 390).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date

du 20 mars 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 811 du 15 avril 2009.

Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cent vingt-cinq

(125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100.-), attribuées aux associés comme suit:

1.- Madame Domenica GARGANO, prénommée, soixante-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

2.- Monsieur Antonio MAELLARO, prénommé, soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Ensuite les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Pétange et par conséquent de modifier

le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 4. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège de la société est établi à Pétange.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de fixer la nouvelle adresse de la société à L-4702 Pétange, 29, rue Robert Krieps.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: : E. KARP, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 18 avril 2013. Relation: ECH/2013/739. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 22 avril 2013.

Référence de publication: 2013051521/44.
(130063365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2013.

VCP Jet Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 50.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 171.480.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2013.

Référence de publication: 2013053688/11.
(130065862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2013.

Autumnleaf S. à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue John Fitzgerald Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.095.

Par résolutions prises en date du 28 mars 2013, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Wendy FRIEDMAN DULMAN, avec adresse professionnelle au 9, West 57 

th

 Street,

10019 New York, Etats-Unis, de son mandat de Gérant de classe A, avec effet immédiat;

- nomination de Shari Verschell-Silverman, avec adresse professionnelle au 9, West 57 

th

 Street, 48 

th

 Floor, 10019

New York, Etats-Unis, au mandat de Gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2013.

Référence de publication: 2013053774/15.
(130066194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

67968


Document Outline

Agriculture Tourism Investment S.A.

Agri-Food S.A.

Albatros Invest S.A.

Autonomy Real Estate Spain

Autumnleaf S. à r.l.

Batiselect S.A.

Blue Dolphin S.A.

Carina Silva S.à r.l.

Carina Silva S.à r.l.

Carrelages Lux S.à r.l.

Cetiri Holding S.A.

Cetrel Securities S.A.

Chinna S.A., SPF

Cita Sàrl

Clarins Ventures S.A.

Concertine S.A.

Congel International S.à r.l.

Coopération Luxembourg - Montenegro

Coriolan

Covent Garden Holdings S.à r.l.

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Eren Groupe S.A.

Floann S.A.

Freenom S.à r.l.

Glassvision S.à r.l.

Global-Waste-Energy S.A.

Halcyon S.à r.l.

Inmet Luxembourg

Mark IV USA S.à r.l.

Metal Group International S.à r.l.

Pasta Point Pétange Sàrl

Planalto S.A.

Recypatents S.àr.l.

Red Point Investments S.A. SPF

Royalux S.A.

SES Astra 2G S.à r.l.

SES Astra 5B S.à.r.l.

Société Internationale d'Investissements Financiers et Technologiques S.A.

Spirallux S.A.

Sweden Lux Incentive 2012 S.A.

Think 2 Consult S.A.

Una Mas

VCP Jet Luxco S.à r.l.