logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1287

31 mai 2013

SOMMAIRE

Ace Asset Management - SICAV SIF . . . . .

61766

Acsof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61745

Acsof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61748

Ader 3 C S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61770

Advent Tower (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .

61748

Aero Technical Support & Services Hol-

dings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61774

Aesa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61755

AIGGRE Sporta S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61770

Alis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61774

Aljo Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61775

Aljo Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61775

Alpha Advisory Company S.A.  . . . . . . . . . .

61766

Aluber S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61765

Amaggi Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

61765

AmTrust Captive Solutions Limited  . . . . .

61765

Apax Edison Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

61764

Architecture et Environnement S.A. . . . . .

61765

Arnau Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61764

Arnau Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61764

Athena Equity Trading S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

61763

Atlas Gracechurch S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

61763

Avenue Asia (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . .

61763

Avenue Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

61764

Aviva Investors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61766

Diador Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61766

Enerfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61744

Flystar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61767

Fondaco Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61767

Generali Multinational Pension Solutions

SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61775

G.O. II - Luxembourg Two S.à r.l.  . . . . . . .

61767

Grand City Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . .

61761

IMC Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

61770

Indesit Company Luxembourg S.A.  . . . . . .

61769

International Finance Group  . . . . . . . . . . . .

61776

IW Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61769

Java S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61768

Joie de Cannes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61769

Julius Baer Investment Services S.à r.l.  . . .

61770

Kinetic Partners (Luxembourg) Manage-

ment Company S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

61774

Kinetic Partners (Luxembourg) S.à r.l.  . . .

61774

Kronospan Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .

61768

Lancaster Properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61768

Leggett & Platt Canada Co., Luxembourg

Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61730

Leggett & Platt Canada Co., Luxembourg

Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61730

Marli Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61755

Meridian Group Investments S.à r.l.  . . . . .

61767

Meridian Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

61749

MMFLX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61776

MPR Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61775

Place Wallis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61760

Queristics Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61760

StatPro International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

61745

Telenet Finance Luxembourg II S.A.  . . . . .

61771

Titan Luxco 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61760

61729

L

U X E M B O U R G

Leggett & Platt Canada Co., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.320.

OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 1 mars 2013 de Leggett & Platt Canada Co./Société Leggett &

Platt Canada, une société (N.S. Unlimited Liability) constituée selon les lois de Nova Scotia, ayant son siège social au
900-1959 Upper Water Street, Halifax, B3J 3N2 Canada et enregistrée auprès du "Registry of Joint Stock Companies
(Nova Scotia)" sous le numéro 3268807 ( la "Société"), qu'une succursale de la Société sera établie au Luxembourg à la
date effective du 1 janvier 2013.

1) La succursale luxembourgeoise aura pour dénomination "Leggett & Platt Canada Co., Luxembourg Branch" (la

"Succursale").

2) L'adresse de la Succursale sera fixée au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3) La Succursale aura pour objet de détenir des actions dans les sociétés affiliées qui lui sont affectées de temps en

temps par la société, exercer ses droits d'actionnaire dans de telles sociétés affiliées, notamment la réception de dividendes
et transfert de fonds et, seulement après avoir reçu l'approbation du conseil d'administration de la société, aliéner de
telles actions. La succursale peut arranger et octroyer du financement à des sociétés affiliées mais ne peut toutefois pas
elle-même emprunter autrement qu'à d'autres sociétés du groupe.

4) La succursale sera gérée par un conseil de gérance et les individus suivants seront nommés avec effet au 1 mars

2013 et pour une durée indéterminée:

- Mr Johannes Laurens de Zwart, gérant de catégorie A, né le 19 juin 1967 à Gravenhage, Pays-Bas, avec adresse

professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Mr Jacob Mudde, gérant de catégorie A, né le 14 octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle

au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Mme Carol Thurnheer, gérant de catégorie B, né le 9 juillet 1972 à Berneck, Suisse, avec adresse professionnelle au

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

5) Le conseil de gérance de la Succursale ne sera en position de délibérer que si au moins un gérant de catégorie A et

un gérant de catégorie B sont présents lors de ladite réunion.

6) la Succursale sera validement engagée envers les tiers par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un

gérant de catégorie B.

7) la Société est validement représentée envers les tiers par les personnes suivantes.
- Mme Shonna Koch, Director, née le 27 mars 1973 à Carthage, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle

au 1, Legget Road, Carthage, Missouri, 64836, Etats-Unis d'Amérique.

- Mme Kirsten Beerly, Director, née le 17 novembre 1972 à Carthage, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse profes-

sionnelle 1, Legget Road, Carthage, Missouri, 64836, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2013.

Référence de publication: 2013043798/40.
(130053739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

Leggett & Platt Canada Co., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.320.

Schedule B

ARTICLES OF ASSOCIATION

Interpretation

1. In these Articles, unless there be something in the subject or context inconsistent therewith:
(1) "Act" means the Companies Act (Nova Scotia);
(2) "Articles" means these Articles of Association of the Company and all amendments hereto;
(3) "Company" means the company named above;
(4) "director" means a director of the Company;
(5) "Memorandum" means the Memorandum of Association of the Company and all amendments thereto;
(6) "month" means calendar month;
(7) "Office" means the registered office of the Company;

61730

L

U X E M B O U R G

(8) "person" includes a body corporate;
(9) "proxyholder" includes an alternate proxyholder;
(10) "Register" means the register of members kept pursuant to the Act, and where the context permits includes a

branch register of members;

(11) "Registrar" means the Registrar as defined in the Act;
(12) "Secretary" includes any person appointed to perform the duties of the Secretary temporarily;
(13) "shareholder" means member as that term is used in the Act in connection with an umimited company having

share capital and as that term is used in the Memorandum;

(14) "special resolution" has the meaning assigned by the Act;
(15) "in writing" and "written" includes printing, lithography and other modes of representing or reproducing words

in visible form;

(16) words importing number or gender include all numbers and genders unless the context otherwise requires.
2. The regulations in Table A in the First Schedule to the Act shall not apply to the Company.
3. The directors may, out of the funds of the Company, pay all expenses incurred for the amalgamation and organization

of the Company.

Shares

4. The Company is authorized to issue an unlimited number of common shares without nominal or par value with the

power to divide the shares in the capital for the time being into classes or series and to attach thereto respectively any
preferred, deferred or qualified rights, privileges or conditions, including restrictions on voting rights and including re-
demption, purchase and other acquisition of such shares, subject, however, to the provisions of the Act.

5. The directors shall control the shares and, subject to the provisions of these Articles, may allot or otherwise dispose

of them to such person at such times, on such terms and conditions and, if the shares have a par value, either at a premium
or at par, as they think fit

6.  The  directors  may  pay  on  behalf  of  the  Company  a  reasonable  commission  to  any  person  in  consideration  of

subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares in the Company, or procuring
or agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for any shares in the Company. Subject to the
Act, the commission may be paid or satisfied in shares of the Company.

7. On the issue of shares the Company may arrange among the holders thereof differences in the calls to be paid and

in the times for their payment.

8. If the whole or part of the allotment price of any shares is, by the conditions of their allotment, payable in instalments,

every such instalment shall, when due, be payable to the Company by the person who is at such time the registered holder
of the shares.

9. Shares may be registered in the names of joint holders not exceeding three in number.
10. Joint holders of a share shall be jointly and severally liable for the payment of all instalments and calls due in respect

of such share. On the death of one or more joint holders of shares the survivor or survivors of them shall alone be
recognized by the Company as the registered holder or holders of the shares.

11. Save as herein otherwise provided, the Company may treat the registered holder of any share as the absolute

owner thereof and accordingly shall not, except as ordered by a court of competent jurisdiction or required by statute,
be bound to recognize any equitable or other claim to or interest in such share on the part of any other person.

Private Issuer

12. No security issued by the Company, other than a non-convertible debt security, may be transferred, except
(i) with the consent of the directors of the Company expressed by a resolution of the directors or by a document in

writing signed by a majority of the directors; or

(ii) with the consent of the holders of the shares entitled to vote at an ordinary general meeting expressed by a

resolution of the holders of those shares or by a document in writing signed by the holders of the majority of those
shares.

The Company shall not register any other purported transfer of securities. In this Article the term "security" includes

any security within the meaning of such term in the Securities Act (Nova Scotia) or regulations or rules made pursuant
thereto, as the same may be amended from time to time.

Certificates

13. Certificates of title to shares shall comply with the Act and may otherwise be in such form as the directors may

from time to time determine. Unless the directors otherwise deterrmne, every certificate of title to shares shall be signed
manually by at least one of the Chairman, President, Secretary, Treasurer, a vice-president, an assistant secretary, any
other officer of the Company or any director of the Company or by or on behalf of a share registrar transfer agent or
branch transfer agent appointed by the Company or by any other person whom the directors may designate. When

61731

L

U X E M B O U R G

signatures of more than one person appear on a certificate all but one may be printed or otherwise mechanically repro-
duced. All such certificates when signed as provided in this Article shall be valid and binding upon the Company. If a
certificate contains a printed or mechanically reproduced signature of a person, the Company may issue the certificate,
notwithstanding that the person has ceased to be a director or an officer of the Company and the certificate is as valid
as if such person were a director or an officer at the date of its issue.

14. Except as the directors may determine, each shareholder's shares may be evidenced by any number of certificates

so long as the aggregate of the shares stipulated in such certificates equals the aggregate registered in the name of the
shareholder.

15. Where shares are registered in the names of two or more persons, the Company shall not be bound to issue more

than one certificate or set of certificates, and such certificate or set of certificates shall be delivered to the person first
named on the Register.

16. Any certificate that has become worn, damaged or defaced may, upon its surrender to the directors, be cancelled

and replaced by a new certificate. Any certificate that has become lost or destroyed may be replaced by a new certificate
upon proof of such loss or destruction to the satisfaction of the directors and the furnishing to the Company of such
undertakings of indemnity as the directors deem adequate.

17. The sum of one dollar or such other sum as the directors from time to time determine shall be paid to the Company

for every certificate other than the first certificate issued to any holder in respect of any share or shares.

18. The directors may cause one or more branch Registers of shareholders to be kept in any place or places, whether

inside or outside of Nova Scotia.

Calls

19. The directors may make such calls upon the shareholders in respect of all amounts unpaid on the shares held by

them respectively and not made payable at fixed times by the conditions on which such shares were allotted, and each
shareholder shall pay the amount of every call so made to the person and at the times and places appointed by the
directors. A call may be made payable by instalments.

20. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the directors authorizing such call

was passed.

21. At least 14 days' notice of any call shall be given, and such notice shall specify the time and place at which and the

person to whom such call shall be paid.

22. If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for the payment

thereof, the holder for the time being of the share in respect of which the call has been made or the instalment is due
shall pay interest on such call or instalment at the rate of 9% per year or such other rate of interest as the directors may
determine from the day appointed for the payment thereof up to the time of actual payment.

23. At the trial or hearing of any action for the recovery of any amount due for any call, it shall be sufficient to prove

that the name of the shareholder sued is entered on the Register as the holder or one of the holders of the share or
shares in respect of which such debt accrued, that the resolution making the call is duly recorded in the minute book and
that such notice of such call was duly given to the shareholder sued in pursuance of these Articles. It shall not be necessary
to prove the appointment of the directors who made such call or any other matters whatsoever and the proof of the
matters stipulated shall be conclusive evidence of the debt.

Forfeiture Of Shares

24. If any shareholder fails to pay any call or instalment on or before the day appointed for payment, the directors may

at any time thereafter while the call or instalment remains unpaid serve a notice on such shareholder requiring payment
thereof together with any interest that may have accrued and all expenses that may have been incurred by the Company
by reason of such non-payment.

25. The notice shall name a day (not being less than 14 days after the date of the notice) and a place or places on and

at which such call or instalment and such interest and expenses are to be paid. The notice shall also state that, in the
event of non-payment on or before the day and at the place or one of the places so named, the shares in respect of which
the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

26. If the requirements of any such notice are not complied with, any shares in respect of which such notice has been

given may at any time thereafter, before payment of all calls or instalments, interest and expenses due in respect thereof,
be forfeited by a resolution of the directors to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect
of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

27. When any share has been so forfeited, notice of the resolution shall be given to the shareholder in whose name

it stood immediately prior to the forfeiture and an entry of the forfeiture shall be made in the Register.

28. Any share so forfeited  shall  be  deemed  the  property of  the Company and  the directors  may sell,  re-allot or

otherwise dispose of it in such manner as they think fit.

29. The directors may at any time before any share so forfeited has been sold, re-allotted or otherwise disposed of,

annul the forfeiture thereof upon such conditions as they think fit.

61732

L

U X E M B O U R G

30. Any shareholder whose shares have been forfeited shall nevertheless be liable to pay and shall forthwith pay to

the Company all calls, instalments, interest and expenses owing upon or in respect of such shares at the time of the
forfeiture together with interest thereon at the rate of 9% per year or such other rate of interest as the directors may
determine from the time of forfeiture until payment. The directors may enforce such payment if they think fit, but are
under no obligation to do so.

31. A certificate signed by the Secretary stating that a share has been duly forfeited on a specified date in pursuance

of these Articles and the time when it was forfeited shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against any
person who would have been entitled to the share but for such forfeiture.

Lien On Shares

32. The Company shall have a first and paramount lien upon all shares (other than fully paid-up shares) registered in

the name of a shareholder (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds from the sale thereof for debts,
liabilities and other engagements of the shareholder, solely or jointly with any other person, to or with the Company,
whether or not the period for the payment, fulfilment or discharge thereof has actually arrived, and such lien shall extend
to all dividends declared in respect of such shares. Unless otherwise agreed, the registration of a transfer of shares shall
operate as a waiver of any lien of the Company on such shares.

33. For the purpose of enforcing such lien the directors may sell the shares subject to it in such manner as they think

fit, but no sale shall be made until the period for the payment, fulfilment or discharge of such debts, liabilities or other
engagements has arrived, and until notice in writing of the intention to sell has been given to such shareholder or the
shareholder's executors or administrators and default has been made by them in such payment, fulfilment or discharge
for seven days after such notice.

34. The net proceeds of any such sale after the payment of all costs shall be applied in or towards the satisfaction of

such debts, liabilities or engagements and the residue, if any, paid to such shareholder.

Validity Of Sales

35. Upon any sale after forfeiture or to enforce a lien in purported exercise of the powers given by these Articles the

directors may cause the purchaser's name to be entered in the Register in respect of the shares sold, and the purchaser
shall not be bound to see to the regularity of the proceedings or to the application of the purchase money, and after the
purchaser's name has been entered in the Register in respect of such shares the validity of the sale shall not be impeached
by any person and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company
exclusively.

Transfer Of Shares

36. The instrument of transfer of any share in the Company shall be signed by the transferor. The transferor shall be

deemed to remain the holder of such share until the name of the transferee is entered in the Register in respect thereof
and shall be entitled to receive any dividend declared thereon before the registration of the transfer.

37. The instrument of transfer of any share shall be in writing in the following form or to the following effect:
For value received, . . . hereby sell, assign, and transfer unto . . . shares in the capital of the Company represented by

the within certificate, and do hereby irrevocably constitute and appoint . . . attorney to transfer such shares on the books
of the Company with full power of substitution in the premises.

Dated the . . . day of . . . ,
Witness: . . .
38. The directors may, without assigning any reason therefor, decline to register any transfer of shares
(1) not fully paid-up or upon which the Company has a lien, or
(2) the transfer of which is restricted by any agreement to which the Company is a party.
39. Every instrument of transfer shall be left for registration at the Office of the Company, or at any office of its transfer

agent where a Register is maintained, together with the certificate of the shares to be transferred and such other evidence
as the Company may require to prove title to or the right to transfer the shares.

40. The directors may require that a fee determined by them be paid before or after registration of any transfer.
41. Every instrument of transfer shall, after its registration, remain in the custody of the Company. Any instrument of

transfer that the directors decline to register shall, except in case of fraud, be returned to the person who deposited it.

Transmission Of Shares

42. The executors or administrators of a deceased shareholder (not being one of several joint holders) shall be the

only persons recognized by the Company as having any title to the shares registered in the name of such shareholder.
When a share is registered in the names of two or more joint holders, the survivor or survivors or the executors or
aa^mnistrators of the deceased shareholder, shall be the only persons recognized by the Company as having any title to,
or interest in, such share.

43. Notwithstanding anything in these Articles, if the Company has only one shareholder (not being one of several

joint holders) and that shareholder dies, the executors or administrators of the deceased shareholder shall be entitled

61733

L

U X E M B O U R G

to register themselves in the Register as the holders of the shares registered in the name of the deceased shareholder
whereupon they shall have all the rights given by these Articles and by law to shareholders.

44. Any person entitled to shares upon the death or bankruptcy of any shareholder or in any way other than by

allotment or transfer, upon producing such evidence of entitlement as the directors require, may be registered as a
shareholder in respect of such shares, or may, without being registered, transfer such shares subject to the provisions of
these Articles respecting the transfer of shares. The directors shall have the same right to refuse registration as if the
transferee were named in an ordinary transfer presented for registration.

Surrender Of Shares

45. The directors may accept the surrender of any share by way of compromise of any question as to the holder being

properly registered in respect thereof. Any share so surrendered may be disposed of in the same manner as a forfeited
share.

Increase And Reduction Of Capital

46. Subject to the Act, the shareholders may by special resolution amend these Articles to increase or alter the share

capital of the Company as they think expedient. Without prejudice to any special rights previously conferred on the
holders of existing shares, any share may be issued with such preferred, deferred or other special rights, or with such
restrictions, whether in regard to dividends, voting, return of share capital or otherwise, as the shareholders may from
time to time determine by special resolution. Except as otherwise provided by the conditions of issue, or by these Articles,
any capital raised by the creation of new shares shall be considered part of the original capital and shall be subject to the
provisions herein contained with reference to payment of calls and instalments, transfer and transmission, forfeiture, lien
and otherwise.

47. Subject to the provisions of this section and the rights, if any, under the Act or other applicable law of the holders

of shares of any class or series of shares to vote separately as a class or series thereon, the Company may reduce all or
a portion of the paid-up capital on a class or series of shares, or certain shares of such class or series of shares, for any
purpose. Any such reduction must be authorized by resolution of the shareholders and, where such reduction of paid-
up capital is so authorized, the shareholders approving such reduction may in such authorizing resolution determine when
the paid-up capital shall be reduced on the shares of the particular class or series of shares, or certain shares of such class
or series of shares, the amount of paid-up capital to be reduced on each such share (where such does not necessarily
follow from the determination of the amount reduced on the class or series as a whole) and the manner in which and
purpose for which such reduction shall be effected. If the shareholders fail to determine any such matter in such resolution
they may subsequently determine such matter by resolution, failing which the directors, or such persons as may be
authorized by the shareholders or directors by resolution, may make any such determination or determinations not
inconsistent with a prior determination of the shareholders as may be necessary or desirable from time to time. The
manner in which or purpose for which the reduction shall be effected may include, without limitation, any of the following:

(a) redeeming in accordance with the terms thereof, or purchasing or acquiring by agreement with the holders thereof,

any shares of any class or series, or certain shares of such class or series of shares;

(b) reducing or extinguishing any liability of the holders of any shares of any class or series including, without limitation,

extinguishing or reducing the liability on any of such shares not paid-up;

(c) either with or without extinguishing or reducing liability on shares of any class or series, cancelling any paid-up

capital which is lost or unrepresented by available assets;

(d) paying cash or transferring other property;
(e) issuing debenture stock debentures, or promissory notes;
(f) increasing any contributed surplus or other surplus account; or
(g) providing a sinking fund on any terms thought fit for the redemption, purchase or acquisition of shares of any class

or series.

The amount of the reduction in the paid-up capital of the class or series of shares, or certain shares of such class or

series of shares, shall be recorded, or shall be deemed to have been recorded, in the accounts of the Company maintained
or deemed to be maintained for such class or series of shares.

Meetings And Voting By Class Or Series

48. Where the holders of shares of a class or series have, under the Act, the terms or conditions attaching to such

shares or otherwise, the right to vote separately as a class in respect of any matter then, except as provided in the Act,
these Articles or such terms or conditions, all the provisions in these Articles concerning general meetings (including,
without limitation, provisions respecting notice, quorum and procedure) shall, mutatis mutandis, apply to every meeting
of holders of such class or series of shares convened for the purpose of such vote.

49. Unless the rights, privileges, terms or conditions attached to a class or series of shares provide otherwise, such

class  or  series  of  shares  shall  not  have  the  right  to  vote  separately  as  a  class  or  series  upon  an  amendment  to  the
Memorandum or Articles to:

61734

L

U X E M B O U R G

(1) increase or decrease any maximum number of authorized shares of such class or series, or increase any maximum

number of authorized shares of a class or series having rights or privileges equal or superior to the shares of such class
or series;

(2) effect an exchange, reclassification or cancellation of all or part of the shares of such class or series; or
(3) create a new class or series of shares equal or superior to the shares of such class or series.

Borrowing Powers

50. The directors on behalf of the Company may:
(1) raise or borrow money for the purposes of the Company or any of them;
(2) secure the repayment of funds so raised or borrowed in such manner and upon such terms and conditions in all

respects as they think fit, and in particular by the execution and delivery of mortgages of the Company's real or personal
property, or by the issue of bonds, debentures or other securities of the Company secured by mortgage or other charge
upon all or any part of the property of the Company, both present and future including its uncalled capital for the time
being;

(3) sign or endorse bills, notes, acceptances, cheques, contracts, and other evidence of or securities for funds borrowed

or to be borrowed for the purposes aforesaid;

(4) pledge debentures as security for loans;
(5) guarantee obligations of any person.
51. Bonds, debentures and other securities may be made assignable, free from any equities between the Company and

the person to whom such securities were issued.

52. Any bonds, debentures and other securities may be issued at a discount, premium or otherwise and with special

privileges as to redemption, surrender, drawings, allotment of shares, attending and voting at general meetings of the
Company, appointment of directors and other matters.

General Meetings

53. Ordinary general meetings of the Company shall be held at least once in every calendar year at such time and place

as may be determined by the directors and not later than 15 months after the preceding ordinary general meeting. All
other meetings of the Company shall be called special general meetings. Ordinary or special general meetings may be
held either within or without the Province of Nova Scotia.

54.  The  President,  a  vice-president  or  the  directors  may  at  any  time  convene  a  special  general  meeting,  and  the

directors, upon the requisition of shareholders in accordance with the Act shall forthwith proceed to convene such
meeting or meetings to be held at such time and place or times and places as the directors determine.

55. The requisition shall state the objects of the meeting requested, be signed by the requisitionists and deposited at

the Office of the Company. It may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisi-
tionists.

56. At least seven clear days' notice, or such longer period of notice as may be required by the Act, of every general

meeting, specifying the place, day and hour of the meeting and, when special business is to be considered, the general
nature of such business, shall be given to the shareholders entitled to be present at such meeting by notice given as
permitted by these Articles. With the consent in writing of all the shareholders entitled to vote at such meeting, a meeting
may be convened by a shorter notice and in any manner they think fit, or notice of the time, place and purpose of the
meeting may be waived by all of the shareholders.

57. The accidental omission to give notice to a shareholder, or non-receipt of notice by a shareholder, shall not

invalidate any resolution passed at any general meeting.

Record Dates

58. The directors may fix in advance a date as the record date for the determination of shareholders
(a) entitled to receive payment of a dividend or entitled to receive any distribution;
(b) entitled to receive notice of a meeting; or
(c) for any other purpose.
If no record date is fixed, the record date for the determination of shareholders
(a) entitled to receive notice of a meeting shall be the day immediately preceding the day on which the notice is given,

or, if no notice is given, the day on which the meeting is held; and

(b) for any other purpose shall be the day on which the directors pass the resolution relating to the particular purpose.

Proceedings At General Meetings

59. The business of an ordinary general meeting shall be to receive and consider the financial statements of the Company

and the report of the directors and the report, if any, of the auditors, to elect directors in the place of those retiring and
to transact any other business which under these Articles ought to be transacted at an ordinary general meeting.

61735

L

U X E M B O U R G

60. No business shall be transacted at any general meeting unless the requisite quorum is present at the commencement

of the business. A corporate shareholder of the Company that has a duly authorized agent or representative present at
any such meeting shall for the purpose of this Article be deemed to be personally present at such meeting.

61. One person, being a shareholder, proxyholder or representative of a corporate shareholder, present and entitled

to vote shall constitute a quorum for a general meeting, and may hold a meeting.

62. The Chairman shall be entitled to take the chair at every general meeting or, if there be no Chairman, or if the

Chairman is not present within fifteen 15 minutes after the time appointed for holding the meeting, the President or,
failing the President, a vice-president shall be entitled to take the chair. If the Chairman, the President or a vice-president
is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting or if all such persons present decline
to take the chair, the shareholders present entitled to vote at the meeting shall choose another director as chairman and
if no director is present or if all the directors present decline to take the chair, then such shareholders shall choose one
of their number to be chairman.

63. If within half an hour from the time appointed for a general meeting a quorum is not present, the meeting, if it was

convened pursuant to a requisition of shareholders, shall be dissolved; if it was convened in any other way, it shall stand
adjourned to the same day, in the next week, at the same time and place. If at the adjourned meeting a quorum is not
present within half an hour from the time appointed for the meeting, the shareholders present shall be a quorum and
may hold the meeting.

64. Subject to the Act, at any general meeting a resolution put to the meeting shall be decided by a show of hands

unless, either before or on the declaration of the result of the show of hands, a poll is demanded by the chairman, a
shareholder or a proxyholder; and unless a poll is so demanded, a declaration by the chairman that the resolution has
been carried, carried by a particular majority, lost or not carried by a particular majority and an entry to that effect in
the Company's book of proceedings shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion
of the votes recorded in favour or against such resolution.

65. When a poll is demanded, it shall be taken in such manner and at such time and place as the chairman directs, and

either at once or after an interval or adjournment or otherwise. The result of the poll shall be the resolution of the
meeting at which the poll was demanded. The demand of a poll may be withdrawn. When any dispute occurs over the
admission or rejection of a vote, it shall be resolved by the chairman and such determination made in good faith shall be
final and conclusive.

66. The chairman shall not have a casting vote in addition to any vote or votes that the chairman has as a shareholder.
67. The chairman of a general meeting may with the consent of the meeting adjourn the meeting from time to time

and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished
at the meeting that was adjourned.

68. Any poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith without

adjournment.

69. The demand of a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than

the question on which a poll has been demanded.

Votes Of Shareholders

70. Subject to the Act and to any provisions attached to any class or series of shares concerning or restricting voting

rights:

(1) on a show of hands every shareholder entitled to vote present in person, every duly authorized representative of

a corporate shareholder, and, if not prevented from voting by the Act, every proxyholder, shall have one vote; and

(2) on a poll every shareholder present in person, every duly authorized representative of a corporate shareholder,

and every proxyholder, shall have one vote for every share held;

whether or not such representative or proxyholder is a shareholder.
71. Any person entitled to transfer shares upon the death or bankruptcy of any shareholder or in any way other than

by allotment or transfer may vote at any general meeting in respect thereof in the same manner as if such person were
the registered holder of such shares so long as the directors are satisfied at least 48 hours before the time of holding the
meeting of such person's right to transfer such shares.

72. Where there are joint registered holders of any share, any of such holders may vote such share at any meeting,

either personally or by proxy, as if solely entitled to it. If more than one joint holder is present at any meeting, personally
or by proxy, the one whose name stands first on the Register in respect of such share shall alone be entitled to vote it.
Several executors or administrators of a deceased shareholder in whose name any share stands shall for the purpose of
this Article be deemed joint holders thereof.

73. Votes may be cast either personally or by proxy or, in the case of a corporate shareholder by a representative

duly authorized under the Act.

74. A proxy shall be in writing and executed in the manner provided in the Act. A proxy or other authority of a

corporate shareholder does not require its seal.

61736

L

U X E M B O U R G

75. A shareholder of unsound mind in respect of whom an order has been made by any court of competent jurisdiction

may vote by guardian or other person in the nature of a guardian appointed by that court, and any such guardian or other
person may vote by proxy.

76. A proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy

of that power or authority shall be deposited at the Office of the Company or at such other place as the directors may
direct. The directors may, by resolution, fix a time not exceeding 48 hours excluding Saturdays and holidays preceding
any meeting or adjourned meeting before which time proxies to be used at that meeting must be deposited with the
Company at its Office or with an agent of the Company. Notice of the requirement for depositing proxies shall be given
in the notice calling the meeting. The chairman of the meeting shall determine all questions as to validity of proxies and
other instruments of authority.

77. A vote given in accordance with the terms of a proxy shall be valid notwithstanding the previous death of the

principal, the revocation of the proxy, or the transfer of the share in respect of which the vote is given, provided no
intimation in writing of the death, revocation or transfer is received at the Office of the Company before the meeting or
by the chairman of the meeting before the vote is given.

78. Every form of proxy shall comply with the Act and its regulations and subject thereto may be in the following form:
I, . . . of . . . being . . . a . . . shareholder . . . of . . . hereby appoint . . . of . . . (or failing him/her . . . of . . . ) as my

proxyholder to attend and to vote for me and on my behalf at the ordinary/special general meeting of the Company, to
be held on the . . . day of . . . and at any adjournment thereof, or at any meeting of the Company which may be held prior
to * [insert specified date or event].

[If the proxy is solicited by or behalf of the management of the Company, insert a statement to that effect.]
Dated this . . . day of . . . .

Shareholder

79. Subject to the Act, no shareholder shall be entitled to be present or to vote on any question, either personally or

by proxy, at any general meeting or be reckoned in a quorum while any call is due and payable to the Company in respect
of any of the shares of such shareholder.

80. Any resolution passed by the directors, notice of which has been given to the shareholders in the manner in which

notices are hereinafter directed to be given and which is, within one month after it has been passed, ratified and confirmed
in writing by shareholders entitled on a poll to three-fifths of the votes, shall be as valid and effectual as a resolution of a
general meeting. This Article shall not apply to a resolution for winding up the Company or to a resolution dealing with
any matter that by statute or these Articles ought to be dealt with by a special resolution or other method prescribed
by statute.

81. A resolution, including a special resolution, in writing and signed by every shareholder who would be entitled to

vote on the resolution at a meeting is as valid as if it were passed by such shareholders at a meeting and satisfies all of
the requirements of the Act respecting meetings of shareholders.

Directors

82. Unless otherwise determined by resolution of shareholders, the number of directors shall not be less than one or

more than ten.

83. Notwithstanding anything herein contained the persons named in the Amalgamation Agreement pursuant to which

the Company was formed shall be the first directors of the Company.

84. The directors may be paid out of the funds of the Company as remuneration for their service such sums, if any,

as the Company may by resolution of its shareholders determine, and such remuneration shall be divided among them
in such proportions and manner as the directors determine. The directors may also be paid their reasonable travelling,
hotel and other expenses incurred in attending meetings of directors and otherwise in the execution of their duties as
directors.

85. The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but if their number falls below the

minimum permitted, the directors shall not, except in emergencies or for the purpose of filling vacancies, act so long as
their number is below the minimum.

86. A director may, in conjunction with the office of director, and on such terms as to remuneration and otherwise

as the directors arrange or determine, hold any other office or place of profit under the Company or under any company
in which the Company is a shareholder or is otherwise interested.

87. The office of a director shall ipso facto be vacated, if the director:
(3) becomes bankrupt or makes an assignment for the benefit of creditors;
(4) is, or is found by a court of competent jurisdiction to be, of unsound mind;
(5) by notice in writing to the Company, resigns the office of director; or
(6) is removed in the manner provided by these Articles.
88. No director shall be disqualified by holding the office of director from contracting with the Company, either as

vendor, purchaser, or otherwise, nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into or proposed

61737

L

U X E M B O U R G

to be entered into by or on behalf of the Company in which any director is in any way interested, either directly or
indirectly, be avoided, nor shall any director so contracting or being so interested be liable to account to the Company
for any profit realized by any such contract or arrangement by reason only of such director holding that office or of the
fiduciary relations thereby established, provided the director makes a declaration or gives a general notice in accordance
with the Act. No director shall, as a director, vote in respect of any contract or arrangement in which the director is so
interested, and if the director does so vote, such vote shall not be counted. This prohibition may at any time or times be
suspended or relaxed to any extent by a resolution of the shareholders and shall not apply to any contract by or on behalf
of the Company to give to the directors or any of them any security for advances or by way of indemnity.

Election Of Directors

89. At the dissolution of every ordinary general meeting at which their successors are elected, all the directors shall

retire from office and be succeeded by the directors elected at such meeting. Retiring directors shall be eligible for re-
election.

90. If at any ordinary general meeting at which an election of directors ought to take place no such election takes place,

or if no ordinary general meeting is held in any year or period of years, the retiring directors shall continue in office until
their successors are elected.

91. The Company may by resolution of its shareholders elect any number of directors permitted by these Articles and

may determine or alter their qualification.

92. The Company may, by special resolution or in any other manner permitted by statute, remove any director before

the expiration of such director's period of office and may, if desired, appoint a replacement to hold office during such
time only as the director so removed would have held office.

93. The directors may appoint any other person as a director so long as the total number of directors does not at any

time exceed the maximum number permitted. No such appointment, except to fill a casual vacancy, shall be effective
unless two-thirds of the directors concur in it. Any casual vacancy occurring among the directors may be filled by the
directors, but any person so chosen shall retain office only so long as the vacating director would have retained it if the
vacating director had continued as director.

Managing Director

94. The directors may appoint one or more of their body to be managing directors of the Company, either for a fixed

term or otherwise, and may remove or dismiss them from office and appoint replacements.

95. Subject to the provisions of any contract between a managing director and the Company, a managing director shall

be subject to the same provisions as to resignation and removal as the other directors of the Company. A managing
director who for any reason ceases to hold the office of director shall ipso facto immediately cease to be a managing
director.

96. The remuneration of a managing director shall from time to time be fixed by the directors and may be by way of

any or all of salary, commission and participation in profits.

97. The directors may from time to time entrust to and confer upon a managing director such of the powers exercisable

under these Articles by the directors as they think fit, and may confer such powers for such time, and to be exercised
for such objects and purposes and upon such terms and conditions, and with such restrictions as they think expedient;
and they may confer such powers either collaterally with, or to the exclusion of, and in substitution for, all or any of the
powers of the directors in that behalf; and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such
powers.

Chairman Of The Board

98. The directors may elect one of their number to be Chairman and may determine the period during which the

Chairman is to hold office. The Chairman shall perform such duties and receive such special remuneration as the directors
may provide.

President And Vice-presidents

99. The directors shall elect the President of the Company, who need not be a director, and may determine the period

for which the President is to hold office. The President shall have general supervision of the business of the Company
and shall perform such duties as may be assigned from time to time by the directors.

100. The directors may also elect vice-presidents, who need not be directors, and may determine the periods for

which they are to hold office. A vice-president shall, at the request of the President or the directors and subject to the
directions of the directors, perform the duties of the President during the absence, illness or incapacity of the President,
and shall also perform such duties as may be assigned by the President or the directors.

Secretary And Treasurer

101. The directors shall appoint a Secretary of the Company to keep minutes of shareholders' and directors' meetings

and perform such other duties as may be assigned by the directors. The directors may also appoint a temporary substitute
for the Secretary who shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be the Secretary.

61738

L

U X E M B O U R G

102. The directors may appoint a treasurer of the Company to carry out such duties as the directors may assign.

Officers

103. The directors may elect or appoint such other officers of the Company, having such powers and duties, as they

tliink fit.

104. If the directors so decide the same person may hold more than one of the offices provided for in these Articles.

Proceedings Of Directors

105. The directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings and

proceedings, as they think fit, and may determine the quorum necessary for the transaction of business. Until otherwise
determined, one director shall constitute a quorum and may hold a meeting.

106. If all directors of the Company entitled to attend a meeting either generally or specifically consent, a director

may participate in a meeting of directors or of a committee of directors by means of such telephone or other commu-
nications facilities as permit all persons participating in the meeting to hear each other, and a director participating in such
a meeting by such means is deemed to be present at that meeting for purposes of these Articles.

107. Meetings of directors may be held either within or without the Province of Nova Scotia and the directors may

from time to time make arrangements relating to the time and place of holding directors' meetings, the notices to be
given for such meetings and what meetings may be held without notice. Unless otherwise provided by such arrangements:

(1) A meeting of directors may be held at the close of every ordinary general meeting of the Company without notice.
(2) Notice of every other directors' meeting may be given as permitted by these Articles to each director at least 48

hours before the time fixed for the meeting.

(3) A meeting of directors may be held without formal notice if all the directors are present or if those absent have

signified their assent to such meeting or their consent to the business transacted at such meeting.

108. The President or any director may at any time, and the Secretary, upon the request of the President or any

director, shall summon a meeting of the directors to be held at the Office of the Company. The President, the Chairman
or a majority of the directors may at any time, and the Secretary, upon the request of the President, the Chairman or a
majority of the directors, shall summon a meeting to be held elsewhere.

109. Questions arising at any meeting of directors shall be decided by a majority of votes. The chairman of the meeting

may vote as a director but shall not have a second or casting vote.

110. At any meeting of directors the chairman shall receive and count the vote of any director not present in person

at  such  meeting  on  any question or matter  arising  at  such  meeting  whenever such  absent  director  has  indicated by
telegram, letter or other writing lodged with the chairman of such meeting the manner in which the absent director
desires to vote on such question or matter and such question or matter has been specifically mentioned in the notice
calling the meeting as a question or matter to be discussed or decided thereat. In respect of any such question or matter
so mentioned in such notice any director may give to any other director a proxy authorizing such other director to vote
for such first named director at such meeting, and the chairman of such meeting, after such proxy has been so lodged,
shall receive and count any vote given in pursuance thereof notwithstanding the absence of the director giving such proxy.

111. If no Chairman is elected, or if at any meeting of directors the Chairman is not present within five minutes after

the time appointed for holding the meeting, or declines to take the chair, the President, if a director, shall preside. If the
President is not a director, is not present at such time or declines to take the chair, a vice-president who is also a director
shall preside. If no person described above is present at such time and willing to take the chair, the directors present shall
choose some one of their number to be chairman of the meeting.

112. A meeting of the directors at which a quorum is present shall be competent to exercise all or any of the authorities,

powers and discretions for the time being vested in or exercisable by the directors generally.

113. The directors may delegate any of their powers to committees consisting of such number of directors as they

think fit. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may
be imposed on them by the directors.

114. The meetings and proceedings of any committee of directors shall be governed by the provisions contained in

these Articles for regulating the meetings and proceedings of the directors insofar as they are applicable and are not
superseded by any regulations made by the directors.

115. All acts done at any meeting of the directors or of a committee of directors or by any person acting as a director

shall, notwithstanding that it is afterwards discovered that there was some defect in the appointment of the director or
person so acting, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed
and was qualified to be a director.

116. A resolution in writing and signed by every director who would be entitled to vote on the resolution at a meeting

is as valid as if it were passed by such directors at a meeting.

117. If any one or more of the directors is called upon to perform extra services or to make any special exertions in

going or residing abroad or otherwise for any of the purposes of the Company or the business thereof, the Company
may remunerate the director or directors so doing, either by a fixed sum or by a percentage of profits or otherwise.

61739

L

U X E M B O U R G

Such remuneration shall be determined by the directors and may be either in addition to or in substitution for remune-
ration otherwise authorized by these Articles.

Registers

118. The directors shall cause to be kept at the Company's Office in accordance with the provisions of the Act a

Register of the shareholders of the Company, a register of the holders of bonds, debentures and other securities of the
Company and a register of its directors. Branch registers of the shareholders and of the holders of bonds, debentures
and other securities may be kept elsewhere, either within or without the Province of Nova Scotia, in accordance with
the Act.

Minutes

119. The directors shall cause minutes to be entered in books designated for the purpose:
(1) of all appointments of officers;
(2) of the names of directors present at each meeting of directors and of any committees of directors;
(3) of all orders made by the directors and committees of directors; and
(4) of all resolutions and proceedings of meetings of shareholders and of directors.
Any such minutes of any meeting of directors or of any committee of directors or of shareholders, if purporting to

be signed by the chairman of such meeting or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be receivable as prima
facie evidence of the matters stated in such minutes.

Powers Of Directors

120. The management of the business of the Company is vested in the directors who, in addition to the powers and

authorities by these Articles or otherwise expressly conferred upon them, may exercise all such powers and do all such
acts and things as may be exercised or done by the Company and are not hereby or by statute expressly directed or
required to be exercised or done by the shareholders, but subject nevertheless to the provisions of any statute, the
Memorandum or these Articles. No modification of the Memorandum or these Articles shall invalidate any prior act of
the directors that would have been valid if such modification had not been made.

121. Without restricting the generality of the terms of any of these Articles and without prejudice to the powers

conferred thereby, the directors may:

(1) take such steps as they think fit to carry out any agreement or contract made by or on behalf of the Company;
(2) pay costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment, and regis-

tration of the Company;

(3) purchase or otherwise acquire for the Company any property, rights or privileges that the Company is authorized

to acquire, at such price and generally on such terms and conditions as they think fit;

(4) pay for any property, rights or privileges acquired by, or services rendered to the Company either wholly or partially

in cash or in shares (fully paid-up or otherwise), bonds, debentures or other securities of the Company;

(5) subject to the Act, secure the fulfilment of any contracts or engagements entered into by the Company by mort-

gaging or charging all or any of the property of the Company and its unpaid capital for the time being, or in such other
manner as they think fit;

(6) appoint, remove or suspend at their discretion such experts, managers, secretaries, treasurers, officers, clerks,

agents and servants for permanent, temporary or special services, as they from time to time think fit, and determine their
powers and duties and fix their salaries or emoluments and require security in such instances and to such amounts as
they think fit;

(7) accept a surrender of shares from any shareholder insofar as the law permits and on such terms and conditions as

may be agreed;

(8) appoint any person or persons to accept and hold in trust for the Company any property belonging to the Company,

or in which it is interested, execute and do all such deeds and things as may be required in relation to such trust, and
provide for the remuneration of such trustee or trustees;

(9) institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceedings by and against the Company, its directors

or its officers or otherwise concerning the affairs of the Company, and also compound and allow time for payment or
satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Company;

(10) refer any claims or demands by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards;
(11) make and give receipts, releases and other discharges for amounts payable to the Company and for claims and

demands of the Company;

(12) determine who may exercise the borrowing powers of the Company and sign on the Company's behalf bonds,

debentures or other securities, bills, notes, receipts, acceptances, assignments, transfers, hypothecations, pledges, en-
dorsements, cheques, drafts, releases, contracts, agreements and all other instruments and documents;

61740

L

U X E M B O U R G

(13) provide for the management of the affairs of the Company abroad in such manner as they think fit, and in particular

appoint any person to be the attorney or agent of the Company with such powers (including power to sub-delegate) and
upon such terms as may be thought fit;

(14) invest and deal with any funds of the Company in such securities and in such manner as they think fit; and vary

or realize such investments;

(15) subject to the Act, execute in the name and on behalf of the Company in favour of any director or other person

who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company such mortgages of the Company's
property, present and future, as they think fit;

(16) give any officer or employee of the Company a commission on the profits of any particular business or transaction

or a share in the general profits of the Company;

(17) set aside out of the profits of the Company before declaring any dividend such amounts as they think proper as

a reserve fund to meet contingencies or provide for dividends, depreciation, repairing, improving and maintaining any of
the property of the Company and such other purposes as the directors may in their absolute discretion think in the
interests of the Company; and invest such amounts in such investments as they think fit, and deal with and vary such
investments, and dispose of all or any part of them for the benefit of the Company, and divide the reserve fund into such
special funds as they think fit, with full power to employ the assets constituting the reserve fund in the business of the
Company without being bound to keep them separate from the other assets;

(18) make, vary and repeal rules respecting the business of the Company, its officers and employees, the shareholders

of the Company or any section or class of them;

(19) enter into all such negotiations and contracts, rescind and vary all such contracts, and execute and do all such

acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they consider expedient for or in relation to any of
the matters aforesaid or otherwise for the purposes of the Company;

(20) provide for the management of the affairs of the Company in such manner as they think fit.

Solicitors

122. The Company may employ or retain solicitors any of whom may, at the request or on the instruction of the

directors, the Chairman, the President or a managing director, attend meetings of the directors or shareholders, whether
or not the solicitor is a shareholder or a director of the Company. A solicitor who is also a director may nevertheless
charge for services rendered to the Company as a solicitor.

The Seal

123. The directors shall arrange for the safe custody of the common seal of the Company (the "Seal"). The Seal may

be affixed to any instrument in the presence of and contemporaneously with the attesting signature of (i) any director or
officer acting within such person's authority or (ii) any person under the authority of a resolution of the directors or a
committee thereof. For the purpose of certifying documents or proceedings the Seal may be affixed by any director or
the President, a vice-president, the Secretary, an assistant secretary or any other officer of the Company without the
authorization of a resolution of the directors.

124. The Company may have facsimiles of the Seal which may be used interchangeably with the Seal.
125. The Company may have for use at any place outside the Province of Nova Scotia, as to all matters to which the

corporate existence and capacity of the Company extends, an official seal that is a facsimile of the Seal of the Company
with the addition on its face of the name of the place where it is to be used; and the Company may by writing under its
Seal authorize any person to affix such official seal at such place to any document to which the Company is a party.

Dividends

126. The directors may from time to time declare such dividend as they deem proper upon shares of the Company

according to the rights and restrictions attached to any class or series of shares, and may determine the date upon which
such dividend will be payable and that it will be payable to the persons registered as the holders of the shares on which
it is declared at the close of business upon a record date. No transfer of such shares registered after the record date
shall pass any right to the dividend so declared.

127. Dividends may be paid as permitted by law and, without limitation, may be paid out of the profits, retained earnings

or contributed surplus of the Company. No interest shall be payable on any dividend except insofar as the rights attached
to any class or series of shares provide otherwise.

128. The declaration of the directors as to the amount of the profits, retained earnings or contributed surplus of the

Company shall be conclusive.

129. The directors may from time to time pay to the shareholders such interim dividends as in their judgment the

position of the Company justifies.

130. Subject to these Articles and the rights and restrictions attached to any class or series of shares, dividends may

be declared and paid to the shareholders in proportion to the amount of capital paid-up on the shares (not including any
capital paid-up bearing interest) held by them respectively.

61741

L

U X E M B O U R G

131. The directors may deduct from the dividends payable to any shareholder amounts due and payable by the sha-

reholder to the Company on account of calls, instalments or otherwise, and may apply the same in or towards satisfaction
of such amounts so due and payable.

132. The directors may retain any dividends on which the Company has a lien, and may apply the same in or towards

satisfaction of the debts, liabilities or engagements in respect of which the lien exists.

133. The directors may retain the dividends payable upon shares to which a person is entitled or entitled to transfer

upon the death or bankruptcy of a shareholder or in any way other than by allotment or transfer, until such person has
become registered as the holder of such shares or has duly transferred such shares.

134. When the directors declare a dividend on a class or series of shares and also make a call on such shares payable

on or before the date on which the dividend is payable, the directors may retain all or part of the dividend and set off
the amount retained against the call.

135. The directors may declare that a dividend be paid by the distribution of cash, paid-up shares (at par or at a

premium), debentures, bonds or other securities of the Company or of any other company or any other specific assets
held or to be acquired by the Company or in any one or more of such ways.

136. The directors may settle any difficulty that may arise in regard to the distribution of a dividend as they think

expedient, and in particular without restricting the generality of the foregoing may issue fractional certificates, may fix
the value for distribution of any specific assets, may determine that cash payments will be made to any shareholders upon
the footing of the value so fixed or that fractions may be disregarded in order to adjust the rights of all parties, and may
vest cash or specific assets in trustees upon such trusts for the persons entitled to the dividend as may seem expedient
to the directors.

137. Any person registered as a joint holder of any share may give effectual receipts for all dividends and payments on

account of dividends in respect of such share.

138. Unless otherwise determined by the directors, any dividend may be paid by a cheque or warrant delivered to or

sent through the post to the registered address of the shareholder entitled, or, when there are joint holders, to the
registered address of that one whose name stands first on the register for the shares jointly held. Every cheque or warrant
so delivered or sent shall be made payable to the order of the person to whom it is delivered or sent. The mailing or
other transmission to a shareholder at the shareholder's registered address (or, in the case of joint shareholders at the
address of the holder whose name stands first on the register) of a cheque payable to the order of the person to whom
it is addressed for the amount of any dividend payable in cash after the deduction of any tax which the Company has
properly withheld, shall discharge the Company's liability for the dividend unless the cheque is not paid on due presen-
tation.  If  any  cheque  for  a  dividend  payable  in  cash  is  not  received,  the  Company  shall  issue  to  the  shareholder  a
replacement cheque for the same amount on such terms as to indemnity and evidence of non-receipt as the directors
may impose. No shareholder may recover by action or other legal process against the Company any dividend represented
by a cheque that has not been duly presented to a banker of the Company for payment or that otherwise remains
unclaimed for 6 years from the date on which it was payable.

Accounts

139. The directors shall cause proper books of account to be kept of the amounts received and expended by the

Company, the matters in respect of which such receipts and expenditures take place, all sales and purchases of goods by
the Company, and the assets, credits and liabilities of the Company.

140. The books of account shall be kept at the head office of the Company or at such other place or places as the

directors may direct.

141. The directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and

under  what  conditions  the  accounts  and  books  of  the  Company  or  any  of  them  shall  be  open  to  inspection  of  the
shareholders, and no shareholder shall have any right to inspect any account or book or document of the Company
except as conferred by statute or authorized by the directors or a resolution of the shareholders.

142. At the ordinary general meeting in every year the directors shall lay before the Company such financial statements

and reports in connection therewith as may be required by the Act or other applicable statute or regulation thereunder
and shall distribute copies thereof at such times and to such persons as may be required by statute or regulation.

Auditors And Audit

143. Except in respect of a financial year for which the Company is exempt from audit requirements in the Act, the

Company shall at each ordinary general meeting appoint an auditor or auditors to hold office until the next ordinary
general meeting. If at any general meeting at which the appointment of an auditor or auditors is to take place and no such
appointment takes place, or if no ordinary general meeting is held in any year or period of years, the directors shall appoint
an auditor or auditors to hold office until the next ordinary general meeting.

144. The first auditors of the Company may be appointed by the directors at any time before the first ordinary general

meeting and the auditors so appointed shall hold office until such meeting unless previously removed by a resolution of
the shareholders, in which event the shareholders may appoint auditors.

61742

L

U X E M B O U R G

145. The directors may fill any casual vacancy in the office of the auditor but while any such vacancy continues the

surviving or continuing auditor or auditors, if any, may act.

146. The Company may appoint as auditor any person, including a shareholder, not disqualified by statute.
147. An auditor may be removed or replaced in the circumstances and in the manner specified in the Act.
148. The remuneration of the auditors shall be fixed by the shareholders, or by the directors pursuant to authorization

given by the shareholders, except that the remuneration of an auditor appointed to fill a casual vacancy may be fixed by
the directors.

149. The auditors shall conduct such audit as may be required by the Act and their report, if any, shall be dealt with

by the Company as required by the Act.

Notices

150. A notice (including any communication or document) shall be sufficiently given, delivered or served by the Com-

pany upon a shareholder, director, officer or auditor by personal delivery at such person's registered address (or, in the
case of a director, officer or auditor, last known address) or by prepaid mail, telegraph, telex, facsimile machine or other
electronic means of communication addressed to such person at such address.

151. Shareholders having no registered address shall not be entitled to receive notice.
152. All notices with respect to registered shares to which persons are jointly entitled may be sufficiently given to all

joint holders thereof by notice given to whichever of such persons is named first in the Register for such shares.

153. Any notice sent by mail shall be deemed to be given, delivered or served on the earlier of actual receipt and the

third business day following that upon which it is mailed, and in proving such service it shall be sufficient to prove that
the notice was properly addressed and mailed with the postage prepaid thereon. Any notice given by electronic means
of communication shall be deemed to be given when entered into the appropriate transmitting device for transmission.
A certificate in writing signed on behalf of the Company that the notice was so addressed and mailed or transmitted shall
be conclusive evidence thereof.

154. Every person who by operation of law, transfer or other means whatsoever becomes entitled to any share shall

be bound by every notice in respect of such share that prior to such person's name and address being entered on the
Register was duly served in the manner hereinbefore provided upon the person from whom such person derived title to
such share.

155. Any notice delivered, sent or transmitted to the registered address of any shareholder pursuant to these Articles,

shall, notwithstanding that such shareholder is then deceased and that the Company has notice thereof, be deemed to
have been served in respect of any registered shares, whether held by such deceased shareholder solely or jointly with
other persons, until some other person is registered as the holder or joint holder thereof, and such service shall for all
purposes of these Articles be deemed a sufficient service of such notice on the heirs, executors or administrators of the
deceased shareholder and all joint holders of such shares.

156. Any notice may bear the name or signature, manual or reproduced, of the person giving the notice written or

printed.

157. When a given number of days' notice or notice extending over any other period is required to be given, the day

of service and the day upon which such notice expires shall not, unless it is otherwise provided, be counted in such
number of days or other period.

Indemnity

158. Every director or officer, former director or officer, or person who acts or acted at the Company's request, as

a director or officer of the Company, a body corporate, partnership or other association of which the Company is or
was a shareholder, partner, member or creditor, and the heirs and legal representatives of such person, in the absence
of any dishonesty on the part of such person, shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of the
directors out of the funds of the Company to pay, all costs, losses and expenses, including an amount paid to settle an
action or claim or satisfy a judgment, that such director, officer or person may incur or become liable to pay in respect
of any claim made against such person or civil, criminal or administrative action or proceeding to which such person is
made a party by reason of being or having been a director or officer of the Company or such body corporate, partnership
or other association, whether the Company is a claimant or party to such action or proceeding or otherwise; and the
amount for which such indemnity is proved shall immediately attach as a lien on the property of the Company and have
priority as against the shareholders over all other claims.

159. No director or officer, former director or officer, or person who acts or acted at the Company's request, as a

director or officer of the Company, a body corporate, partnership or other association of which the Company is or was
a shareholder, partner, member or creditor, in the absence of any dishonesty on such person's part, shall be liable for
the acts, receipts, neglects or defaults of any other director, officer or such person, or for joining in any receipt or other
act for conformity, or for any loss, damage or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency
of title to any property acquired for or on behalf of the Company, or through the insufficiency or deficiency of any security
in or upon which any of the funds of the Company are invested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy,
insolvency  or  tortious  acts  of  any  person  with  whom  any  funds,  securities  or  effects  are  deposited,  or  for  any  loss

61743

L

U X E M B O U R G

occasioned by error of judgment or oversight on the part of such person, or for any other loss, damage or misfortune
whatsoever which happens in the execution of the duties of such person or in relation thereto.

Execution of Documents and Instruments

160. Deeds, transfers, assignments, contracts, obligations, certificates and other instruments and documents of any

description whatsoever shall be effectively authorized by and signed on behalf of the Company if signed by any director
or officer acting within such person's authority, whether under seal or otherwise as such signatories may see fit. In addition,
the board of directors or the shareholders may from time to time by resolution direct the manner in which and the
person or persons by whom any particular document or instrument or class of documents or instruments may or shall
be signed. Any articles, notice, resolution, requisition, statement or other document or instrument required or permitted
to be executed by more than one person may be executed in several documents or instruments of like form each of
which is executed by one or more of such persons, and such documents or instruments, when duly executed by all
persons required or permitted, as the case may be, to do so, shall be deemed to constitute one document for all relevant
purposes. The secretary or any other officer or any director may sign certificates and similar instruments on the Com-
pany's behalf with respect to any factual matters relating to the Company's business and affairs, including certificates
verifying copies of the constating documents, resolutions and minutes of meetings of the Company.

Reminders

161. The directors shall comply with the following provisions of the Act or the Corporations Registration Act (Nova

Scotia) where indicated:

(1) Keep a current register of shareholders (Section 42).
(2) Keep a current register of directors, officers and managers, send to the Registrar a copy thereof and notice of all

changes therein (Section 98).

(3) Keep a current register of holders of bonds, debentures and other securities (Section 111 and Third Schedule).
(4) Call a general meeting every year within the proper time (Section 83). Meetings must be held not later than 15

months after the preceding general meeting.

(5) Send to the Registrar copies of all special resolutions (Section 88).
(6) Send to the Registrar notice of the address of the Company's Office and of all changes in such address (Section

79).

(7) Keep proper minutes of all shareholders' meetings and directors' meetings in the Company's minute book kept at

the Company's Office (Sections 89 and 90).

(8) Obtain a certificate under the Corporations Registration Act (Nova Scotia) as soon as business is commenced.
(9) Send notice of recognized agent to the Registrar under the Corporations Registration Act (Nova Scotia).
Référence de publication: 2013043799/779.
(130053739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

Enerfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 45.952.

L'an deux mille treize, le vingt-et-unième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Frédéric PAGET, avocat, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg au 35, avenue Monterey.
agissant en sa qualité de mandataire des actionnaires détenant l'intégralité du capital social de la société anonyme de

droit luxembourgeois dénommée «ENERFIN S.A.», ci-après la «Société», ayant son siège social à L-1114 Luxembourg au
3, rue Nicolas Adames, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le
numéro 45.952, constituée suivant un acte reçu par Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Differdange, le 15 dé-
cembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 70 du 19 février 1994 et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois en date du 28 décembre 2012 suivant une assemblée générale extraordinaire tenue
par-devant le notaire instrumentant, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 559 en date
du 7 mars 2013.

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle est restée annexée, avec la liste de présence, au susdit

acte du 28 décembre 2012 reçu par le notaire soussigné.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné de documenter qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la susdite

assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 28 décembre 2012, acte enregistré à Luxembourg Actes Civils,
le 2 janvier 2013, Relation: LAC/2013/290, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés le 21 janvier 2013 sous la
référence L130012791.

61744

L

U X E M B O U R G

En effet, à la seconde résolution, le 1 

er

 et le 2 

eme

 alinéa de l'article 5 relatifs au capital et au capital autorisé a été

erronément indiqué comme suit:

« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent soixante-dix-neuf mille vingt-quatre euro et quatre-vingt centimes

(EUR 279.024,80) représenté par onze mille deux cent cinquante-et-une (11.251) actions d'une valeur nominale de vingt-
quatre euro et quatre-vingt centimes (EUR 24,80) chacune.»

Alors qu'il aurait fallu indiquer:

« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent soixante-dix-neuf mille vingt-quatre euro et quatre-vingt centimes

(EUR 279.024,80) représenté par onze mille deux cent cinquante-et-une (11.251) actions d'une valeur nominale de vingt-
quatre euro et quatre-vingt centimes (EUR 24,80) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-neuf-mille euros (EUR 2.479.000).»
Le comparant déclare que toutes les autres résolutions du dudit acte restent inchangées et prie le notaire de faire

mention de la présente rectification partout où besoin sera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture des présentes faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Paget, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 mars 2013. Relation: LAC/2013/13598. Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 3 avril 2013.

Référence de publication: 2013043678/45.
(130053197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2013.

Acsof, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 85.061.

Les comptes annuels de la société au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013048370/12.
(130059823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

StatPro International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 148-150, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 156.905.

In the year two thousand and thirteen, on the fourth of March.
Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

StatPro Ltd, a private limited company incorporated and existing under the laws of England and Wales, with registered

office at StatPro House, 81-87 Hartfield Road, Wimbledon, London SW19 3JT, England, registered with the Companies
House of England and Wales, under number 3691156,

duly represented by its manager Mr Justin WHEATLEY, C.E.O., born on May 5, 1964 in London, United Kingdom,

residing in 7, rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg.

This appearing party, represented as stated above, has declared and requested the officiating notary to state:
- That the private limited liability company "StatPro International S.à r.l.", (the "Company"), established and having its

registered office in L-2330 Luxembourg, 148-150, boulevard de la Pétrusse, inscribed in the Trade and Companies' Re-
gistry of Luxembourg, section B, under the number 156,905, has been incorporated by deed of M 

e

 Francis KESSELER,

notary residing in Esch/Alzette, on the 28 

th

 of October 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, number 2843 of the 28 

th

 of December 2010.

61745

L

U X E M B O U R G

- That the appearing party is the sole current partner (the "Sole Partner") of the Company and that it has taken, through

its representative, the following resolution:

<i>First resolution

The Sole Partner decides to suppress any references to the A and B categories of managers and to amend subsequently

article 7 of the by-laws of the Company, in order to give it the following wording:

Art. 7. Management.
7.1 Appointment and removal
The Company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties.
The manager(s) need(s) not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by

the shareholder(s) of the Company.

7.2 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and
provided the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by the joint signature of the technical manager and any

administrative managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate all or part of his/its powers

for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers
will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of their agency.

7.3 Powers
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.4 Procedures
The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of managers is present or represented at

the meeting of the board of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company."

<i>Second resolution

The Sole Partner decides to establish technical and administrative categories of Managers.

<i>Third resolution

The Sole Partner decides to appoint for an undetermined period two additionnal managers, i.e.:
- Mr Dario CINTIOLI, Directeur du Développement, born on May 16, 1967 in Messina, Italiy, residing in Via Andrea

Ponti, 15, I-20143 Milan, as administrative manager.

- Mr Justin WHEATLEY, C.E.O., born on May 5, 1964 in London, United Kingdom, residing in 7, rue de la Boucherie,

L-1247 Luxembourg, as administrative manager.

The Sole Partner decides to appoint Mr Michel LEMPICKI as technical manager of the Company.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the representative of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said appearing person has signed with Us the notary the present deed.

61746

L

U X E M B O U R G

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le quatre mars.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné.

A COMPARU:

StatPro Ltd, société à responsabilité limitée de droit anglais et gallois, ayant son siège social à StatPro House, 81-87

Hartfield Road, Wimbledon, Londres SW19 3JT, Angleterre, inscrite auprès de la Companies House d'Angleterre et du
Pays de Galles, sous le numéro 3691156,

dûment représentée par son gérant Monsieur Justin WHEATLEY, C.E.O., né le 5 mai 1964 à Londres, Royaume-Uni,

demeurant 7, rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
-  Que  la  société  à  responsabilité  limitée  "StatPro  International  S.à  r.l.",  établie  et  ayant  son  siège  social  à  L-2330

Luxembourg, 148-150 boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 156.905, a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette, en date du 28 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2843 du
28 décembre 2010.

- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'"Associée Unique") de la Société et qu'elle a pris, par son

représentant, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associée Unique décide de supprimer toute référence aux catégories de gérants A et B et de modifier en consé-

quence l'article 7 des statuts de la société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 7. Gérance.
7.1 Nomination et révocation
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d'être révoqués ad nutum

par le(s) associé(s) de la Société.

7.2 Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe du gérant technique et d'un administrateur admi-

nistratif.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représen-
tation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.3 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.4 Procédures
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
distincts.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

7.5 Responsabilité des gérants
Le(s) gérants ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.»

<i>Deuxième résolution

L'Associée Unique décide d'instaurer des catégories de gérant technique et de gérant administratif.

61747

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de nommer pour une durée indéterminés deux gérants supplémentaires, savoir:
- Monsieur Dario CINTIOLI, Directeur du Développement, né le 16 mai 1967 à Messina, Italie, demeurant à Via Andrea

Ponti, 15, I-20143 Milan, en tant que gérant administratif.

- Monsieur Justin WHEATLEY, C.E.O., né le 5 mai 1964 à Londres, Royaume-Uni, demeurant 7, rue de la Boucherie,

L-1247 Luxembourg, en tant que gérant administratif.

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Michel LEMPICKI comme gérant technique de la société.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au représentant de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. WHEATLEY, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 mars 2013. LAC/2013/11359. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 18 mars 2013.

Référence de publication: 2013045762/150.
(130055441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Advent Tower (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 157.821.

Il résulte du contrat de transfert de parts réalisé en date du 25 février 2011 que AI Global Investments S.à r.l., transfère

45,042 parts sociales qu’elle détient dans la Société à Highbridge Mezzanine Partners Tower Equity L.P., une société à
responsabilité limitée, enregistré au Registre de Commerce des Iles Caïmanes sous le numéro 46644 et ayant son siège
social au 1, south Church Street, Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Iles Caïmanes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

Référence de publication: 2013048373/13.
(130059668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Acsof, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 85.061.

Les comptes annuels de la société au 30 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013048371/12.
(130059856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

61748

L

U X E M B O U R G

Meridian Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 77.794.692,60.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 154.555.

In the year two thousand and thirteen, on the fourteenth day of March,
Before Maître Martine Schaeffer, notary public, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED

Apax NXP US VII, L.P., a limited partnership governed by the laws of the Caiman Islands, having its registered office

at Walker House, KY-George Town, Grand Cayman, registered with the Register of Commerce of the Caiman Islands
under number 18065, holding 1,037,196,936 shares in the share capital of the Company, here represented by Mr Gianpiero
SADDI, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which,
initialled "ne varietur' by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities,

Apax NXP VI A L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at

33  Jermyn  Street,  SW1Y  6DN,  London,  United  Kingdom,  registered  with  the  Register  of  Commerce  of  the  United
Kingdom under number LP11590, holding 7,770,047,407 shares in the share capital of the Company, here represented
by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which, initialled "ne varietur' by the
appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities,

Apax NXP VA L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at

33  Jermyn  Street,  SW1Y  6DN,  London,  United  Kingdom,  registered  with  the  Register  of  Commerce  of  the  United
Kingdom under number LP11592, holding 1,782,787,248 shares in the share capital of the Company, here represented
by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which, initialled "ne varietur' by the
appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities,

Apax NXP VI 1 L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at

33  Jermyn  Street,  SW1Y  6DN,  London,  United  Kingdom,  registered  with  the  Register  of  Commerce  of  the  United
Kingdom under number LP11589, holding 9,667,974 shares in the share capital of the Company, here represented by Mr
Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which, initialled "ne varietur' by the appearing
person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities, and

Apax NXP VB-2 L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office

at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United
Kingdom under number LP11591, holding 1,069,504,325 shares in the share capital of the Company, Mr Gianpiero SADDI,
prenamed, by virtue of a proxy given under private seal which, initialled "ne varietur' by the appearing person and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

being  all  the  shareholders  (the  "Shareholders")  of  Meridian  Holding  S.à  r.l.,  a  Luxembourg  private  limited  liability

company (société à responsabilité limitée), incorporated by a notarial deed drawn up on 21 July 2010 by Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, having its registered office at 1-3 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
154.155, whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the "Memorial") number 1837, page 88141, dated 8 September 2010 (the "Company") and whose Articles
have been lastly amended by a notarial deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 8
February 2013, not yet published in the Memorial.

The Shareholders declare that they have been informed in advance of the agenda of the meeting and waive all convening

requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda
of this meeting.

The meeting has been called for with the following agenda:

<i>Agenda

A. To approve the determination by resolution of the board of managers passed on 14 March 2013 of a Total Re-

demption Amount (as defined in the Articles) of one hundred and two million one hundred twenty-four thousand one
hundred and ninety Euros and ninety-two Euro cents (EUR 102,124,190.92).

B. To acknowledge and approve the repurchase by the Company pursuant to a resolution of the board of managers

passed on 14 March 2013 and based on interim accounts dated 14 March 2013 of (i) each of the 1,944,867,315 F Shares
in the Company with a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) each (the "F Repurchased Shares") at a rounded price of
EUR 0.0425 per share and (ii) each of the 1,944,867,315 E Shares in the Company with a par value of one Euro Cent

61749

L

U X E M B O U R G

(EUR 0.01) each (the "E Repurchased Shares" together with the F Repurchased Shares, referred to as the "Repurchased
Shares")  at  a  price  of  EUR  0.0100  per  share.  Out  of  the  Total  Redemption  Amount,  USD  50,679,921.17  (EUR
38,897,346.30)  represents  the  total  par  value  of  the  repurchased  F  Shares  and  repurchased  E  Shares  and  USD
82,379,180.23 (EUR 63,226,844.62) constitutes the total partial liquidation bonus (EUR amounts are calculated on the
basis of an agreed exchange rate of USD 1 = EUR 0.7675);

C. To complete the consequent reduction of the Company's corporate capital by an amount of EUR 38,897,346.30

to EUR 77,794,692.60 by the cancellation of the Repurchased Shares.

D. To amend the articles of incorporation of the Company to reflect the proposed resolutions.
E. Miscellaneous.
After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The meeting of Shareholders resolved that the determination by resolution of the board of managers passed on 14

March 2013 of a Total Redemption Amount (as defined in the Articles of the Company) of one hundred and two million
one hundred twenty-four thousand one hundred and ninety Euros and ninety-two Euro cents (EUR 102,124,190.92) is
approved.

<i>Second resolution

The meeting of Shareholders resolved to acknowledge and approve the repurchase by the Company pursuant to a

resolution of the board of managers on on 14 March 2013 and based on interim accounts dated 14 March 2013 of (i)
each of the 1,944,867,315 F Shares in the Company with a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) each (the "F Repurchased
Shares") at a rounded price of EUR 0.0425 per share and (ii) each of the 1,944,867,315 E Shares in the Company with a
par value of one Euro Cent (EUR 0.01) each (the "E Repurchased Shares" together with the F Repurchased Shares, referred
to  as  the  "Repurchased  Shares")  at  a  price  of  EUR  0.0100  per  share.  Out  of  the  Total  Redemption  Amount,  USD
50,679,921.17 (EUR 38,897,346.30) represents the total par value of the repurchased F Shares and repurchased E Shares
and USD 82,379,180.23 (EUR 63,226,844.62) constitutes the total partial liquidation bonus (EUR amounts are calculated
on the basis of an agreed exchange rate of USD 1 = EUR 0.7675);

<i>Third resolution

The meeting of Shareholders resolved to reduce the Company's corporate capital by an amount of EUR 38,897,346.30

to EUR 77,794,692.60 by the cancellation of the Repurchased Shares.

<i>Fourth resolution

The meeting of Shareholders resolved to amend article 6.1.1 of the Articles to reflect the decisions taken under the

preceding resolutions so that henceforth it shall read as follows:

6.1.1. The corporate capital is fixed at EUR 77,794,692.60 represented by:
- 1,944,867,315 class A ordinary shares (the "A Shares"),
- 1,944,867,315 class B ordinary shares (the "B Shares"),
- 1,944,867,315 class C ordinary shares (the "C Shares"), and
- 1,944,867,315 class D ordinary shares (the "D Shares").
each having a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) and the rights and obligations as set out in these Articles, (together

the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholder"."

The meeting of Shareholders further resolved to amend article 6.1.3 of the Articles to reflect the decisions taken under

the preceding resolutions so that henceforth it shall read as follows:

6.1.3. The share capital of the Company may be reduced exclusively through the repurchase and subsequent can-

cellation of all the issued shares of one or more classes of Shares (an "Share Redemption") in the following order:

- the D shares;
- the C shares;
- the B shares; and
- the A shares.
Upon an Share Redemption becoming effective, the holders of the Shares which are repurchased by the Company as

part of the Share Redemption (the "Redeemed Shares") will be paid the Redemption Price for each Redeemed Share.

In these Articles:
"Interim Accounts" are management accounts of the Company;
"Available Amount" means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the

extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be
by the amount of the share capital reduction, the legal reserve reduction and any share premium relating to the class of

61750

L

U X E M B O U R G

Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses), and (ii) any sums to be
placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim
Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

Available Amount = (W + X + Y) - Z where W, X, Y and Z are the following amounts taken from the Interim Accounts

without double counting:

"W" means the net profits of the Company including carried forward profits less any losses of the Company including

carried forward losses;

"X" means any freely distributable share premium and other freely distributable reserves of the Company other than

any premia included in Y and, for the avoidance of doubt, other than any share premium which only relates to shares
other than the Redeemed Shares;

"Y" means the amount of the share capital reduction, the legal reserve reduction and of any share premium relating

to the Redeemed Shares;

"Z" means any sums to be placed into or retained in a non-distributable reserve pursuant to the requirements of law

or these Articles;

"Total Redemption Amount" is such amount as is determined by resolution of the Board of Managers and approved

by general meeting of the Shareholders, not exceeding the Available Amount;

"Redemption Price" equals the Total Redemption Amount divided by the total number of Redeemed Shares."
The meeting of Shareholders finally resolved to amend article 13 of the Articles to reflect the decisions taken under

the preceding resolutions so that henceforth it shall read as follows:

Art. 13. Distribution of profits. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until

and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law

and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose, if they
think it is appropriate, that cash available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Share-

holders in accordance with the provisions of Article 9 paragraph 3 above and in accordance with the following provisions:

(a) First, the holders of A Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.25%

of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of B Shares shall be granted a right to receive,
pro rata, a preferred dividend representing 0.30% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders
of C Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.35% of the nominal value of
the Shares issued by the Company. The holders of D Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred
dividend representing 0.40% of the nominal value of the Shares issued by the Company.

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (a) are to be made on a pari passu basis between the

holders of the class of Shares.

(b) After the distribution set out under (a) above, all remaining income available for further distribution (the "Excess")

in the Company, if any, shall be paid to the holders of D Shares (if the D Shares have been cancelled and do not exist
anymore, to the holders of the C Shares; or if the C Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders
of the B Shares; or if the B Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holder of the A Shares).

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (b) are to be made on a pari passu basis between the

holders of the class of Shares.

Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers

may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement
of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be
distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond
to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s)."

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately EUR 3.000.-

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

61751

L

U X E M B O U R G

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le quatorzième jour de mars,
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, soussignée,

ONT COMPARU

Apax NXP US VII, L.P., un limited partnership, régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au Walker House,

KY - George Town, Grand Cayman, enregistré auprès du registre de commerce des Iles Cayman sous le numéro 18065,
détenant 1.037.196.936 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Mr Gianpiero SADDI, clerc
de notaire ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, laquelle, paraphée "ne varietuf par le mandataire du com-
parant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

Apax NXP VI A L.P., un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 33 Jermyn

Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce du Royaume-Uni sous le numéro
LP11590, détenant 7.770.047.407 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Mr Gianpiero SADDI,
prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée "ne varietuf par le mandataire du comparant
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

Apax NXP VA L.P., un limited partnership, régi par les lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 33 Jermyn Street,

SW1Y  6DN,  Londres,  Royaume-Uni,  enregistré  auprès  du  registre  de  commerce  du  Royaume-Uni  sous  le  numéro
LP11592, détenant 1.782.787.248 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Mr Gianpiero SADDI,
prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée "ne varietur" par le mandataire du comparant
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

Apax NXP VI 1 L.P., un limited partnership, régi par les lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 33 Jermyn

Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce du Royaume-Uni sous le numéro
LP11589, détenant 9.667.974 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Mr Gianpiero SADDI,
prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée "ne varietur" par le mandataire du comparant
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui, et

Apax NXP VB-2 L.P., un limited partnership, régi par les lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 33 Jermyn

Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du Registre de commerce du Royaume-Uni sous le numéro
LP11591, détenant 1.069.504.325 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Mr Gianpiero SADDI,
prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée "ne varietur" par le mandataire du comparant
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

étant tous les associés (les "Associés") de Meridian Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit lu-

xembourgeois, constituée par un acte notarié dressé le 21 juillet 2010 par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à
Luxembourg, ayant son siège social au 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.555 et dont les
statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1837,
page 88141, en date du 8 septembre 2010, (la "Société") et dont les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un
acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 8 Février 2013, et non encore publié
au Mémorial.

Les Associés déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour et ont renoncé aux formalités et exigences

de convocation. L'assemblée est donc valablement constituée et peut délibérer et décider valablement sur tous les points
figurant à l'ordre du jour de l'assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

(A) Approuver la détermination par résolution du conseil de gérance passée le 14 mars 2013 d'un Montant Total de

Rachat (tel que défini dans les Statuts) de cent deux millions cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-dix euros et quatre-
vingt-douze centimes d'euro (102.124.190,92 EUR).

(B) Reconnaître et approuver le rachat par la Société en vertu d'une résolution du conseil de gérance passée le 14

mars 2013 et basée sur les comptes intérimaires datés du 14 mars 2013 de (i) chacune des 1.944.867.315 parts sociales
F de la Société d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacune et rachetées au prix arrondi de 0,0425
EUR par part sociale (les "Parts Sociales Rachetées F") et (ii) chacune des 1.944.867.315 parts sociales E de la Société
d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacune (les "Parts Sociales Rachetées E" et ensemble avec les
Parts Sociales Rachetées H définies comme les "Parts Sociales Rachetées") et rachetées à un prix de 0,0100 EUR par part
sociale. Du Montant Total de Rachat, 50.679.921,17 USD (38.897.346,30 EUR) constitue la valeur nominale totale des
Parts Sociales Rachetées F et des Parts Sociales Rachetées E, et 82.379.180,23 USD (63.226.844,62 EUR) constitue le

61752

L

U X E M B O U R G

montant total de bonus de liquidation partielle (les montants en EUR sont calculés sur la base d'un taux de change agréé
de 1 USD = 0,7675 EUR).

(C)  Réaliser  la  réduction  conséquente  du  capital  social  de  la  Société  pour  un  montant  de  38.897.346,30  EUR  à

77.794.692,60 EUR par l'annulation des parts sociales rachetées.

(D) Modifier les Statuts afin de refléter les résolutions proposées.
(E) Divers.
Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée des Associés a décidé que la détermination faite par résolution du conseil de gérance passée le 14 Mars

2013 du Montant Total de Rachat (tel que défini dans les Statuts de la Société) de cent deux millions cent vingt-quatre
mille cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-douze centimes d'euro (102.124.190,92 EUR) est approuvée.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée des Associés a décidé de reconnaître et d'approuver le rachat par la Société en vertu d'une résolution du

conseil gérance passée le 14 mars 2013 et basée sur les comptes intérimaires datés du 14 mars 2013 de (i) chacune des
1.944.867.315 parts sociales F de la Société d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacune et rachetées
au prix arrondi de 0,0425 EUR par part sociale (les "Parts Sociales Rachetées F") et (ii) chacune des 1.944.867.315 parts
sociales E de la Société d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacune (les "Parts Sociales Rachetées E"
et ensemble avec les Parts Sociales Rachetées H définies comme les "Parts Sociales Rachetées") et rachetées à un prix
de 0,0100 EUR par part sociale. Du Montant Total de Rachat, 50.679.921,17 USD (38.897.346,30 EUR) constitue la valeur
nominale totale des Parts Sociales Rachetées F et des Parts Sociales Rachetées E, et 82.379.180,23 USD (63.226.844,62
EUR) constitue le montant total de bonus de liquidation partielle (les montants en EUR sont calculés sur la base d'un taux
de change agréé de 1 USD = 0,7675 EUR).

<i>Troisième résolution

L'assemblée des Associés a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 38.897.346,30 EUR à

77.794.692,60 EUR par l'annulation des Parts Sociales Rachetées.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée des Associés a décidé de modifier l'article 6.1.1 des Statuts afin de refléter les décisions prises en vertu

des résolutions précédentes afin qu'il soit lu comme suit:

6.1.1. Le capital social souscrit est fixé à 77.794.692,60 EUR représenté par:
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie A (les "Parts Sociales A");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie B (les "Parts Sociales B");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie C (les "Parts Sociales C"); et
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie D (les "Parts Sociales D");
ayant chacune une valeur nominale d'un Centime d'Euro (0,01 EUR) chacune et les droits et obligations tels que décrits

dans ces Statuts (ensemble les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés». "

L'assemblée des Associés a également décidé de modifier l'article 6.1.3 des Statuts afin de refléter les décisions prises

en vertu des résolutions précédentes afin qu'il soit lu comme suit:

6.1.3. Le capital social de la Société pourra être uniquement réduit par le rachat et l'annulation subséquente de toutes

les Parts Sociales émises d'une ou plusieurs catégories de Parts Sociales (un "Rachat de Parts Sociales") dans l'ordre
suivant:

- les Parts Sociales D;
- les Parts Sociales C;
- les Parts Sociales B; et
- les Parts Sociales A.
Au moment où un Rachat de Parts Sociales devient effectif, les détenteurs des Parts Sociales qui sont rachetées par la

Société dans le cadre du Rachat de Parts Sociales (les "Parts Sociales Rachetées") recevront en paiement le Prix de Rachat
pour chaque Part Sociale Rachetée.

Dans les présents Statuts:
"Comptes Intérimaires" sont les comptes de gestion de la Société;
"Montant Disponible" signifie le montant total des profits nets de la Société (y compris les profits reportés) dans la

mesure où les Associés auraient eu droit à des distributions de dividendes suivant les Statuts, augmentés de (i) toutes
réserve distribuables (y compris pour éviter tout doute la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant par tout
montant de la réduction de capital social, de la réduction de la réserve légale et de toute prime d'émission liés à la catégorie
de Parts Sociales devant être rachetées/annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées) et (ii)

61753

L

U X E M B O U R G

toutes sommes devant être mises en réserve(s) suivant les exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois tel qu'établi
dans les Comptes Intérimaires (pour éviter tout doute, sans double comptage), pour que:

Montant Disponible = (W+X+Y) ? Z et W, X, Y et Z sont les montants suivants pris des Comptes Intérimaires sans

double comptage:

"W" signifie les bénéfices nets de la Société y compris les bénéfices reportés soustraits toutes pertes de la Société y

compris les pertes reportées;

"X" signifie toute prime d'émission librement distribuable et toutes autres réserves librement distribuables de la Société

autre que tous premia inclus dans Y, et, pour éviter tout doute, autre que toute prime d'émission liée uniquement aux
parts sociales autres que les Parts Sociales Rachetées;

"Y" signifie le montant de la réduction du capital social, de la réduction de la réserve légale et de la prime d'émission

concernant les Parts Sociales Rachetées;

"Z" signifie toutes sommes qui doivent être placées dans ou retenues sur une réserve non-distribuable en vertu des

exigences légales ou des présents Statuts;

"Montant Total de Rachat" est le montant déterminé par les résolutions du Conseil de Gérance et approuvé par

l'assemblée générale des Associés, et n'excédant pas le Montant Disponible;

"Prix de Rachat" équivaut au Montant Total de Rachat divisé par le nombre de Parts Sociales Rachetées."
L'assemblée des Associés a enfin décidé de modifier l'article 13 des Statuts afin de refléter les décisions prises en vertu

des résolutions précédentes afin qu'il soit lu comme suit:

Art. 13. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi

longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent ( 10%) du capital social de la Société.

Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer, si il le considère
approprié, que les fonds disponibles soient distribués.

La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec les

dispositions de l'Article 9 paragraphe 3 ci-dessus et conformément aux dispositions suivantes:

(a) Premièrement, les détenteurs des Parts Sociales A auront le droit de recevoir, au pro rata, un dividende préférentiel

représentant 0,25% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales B
auront le droit de recevoir, au pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,30% de la valeur nominale des Parts
Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales C auront le droit de recevoir, au pro rata, un dividende
préférentiel représentant 0,35% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts
Sociales D auront le droit de recevoir, au pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,40% de la valeur nominale
des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales E auront le droit de recevoir, au pro rata, un
dividende préférentiel représentant 0,45% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs
des Parts Sociales F auront le droit de recevoir, au pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,50% de la valeur
nominale des Parts Sociales émises par la Société.

Pour éviter tout doute, les paiements à effectuer en vertu de (a) devront être effectués sur une base pari passu entre

les détenteurs des catégories de Parts Sociales.

(b) Suite à la distribution décrite au (a) ci-dessus, tous les revenus restants disponibles pour une distribution supplé-

mentaire (l'"Excès") dans la Société, s'il y en a, devront être payés aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F (ou
si les Parts Sociales de Catégorie F ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E;
ou si les Parts Sociales de Catégorie E ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie
D; ou si les Parts Sociales de Catégorie D ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie
C; ou si les Parts Sociales de Catégorie C ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie
B; ou si les Parts Sociales de Catégorie B ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie
A).

Pour éviter tout doute, les paiements effectués en vertu du (b) devront être effectués sur une base pari passu entre

les détenteurs des Catégories de Parts Sociales.

Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut

décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par les Associé(s)."

61754

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison du présent acte, est évalué à environ EUR 3.000.-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, dont le notaire connaît le nom de famille,

prénom, état civil et domicile, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2013. LAC/2013/13382. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2013.

Référence de publication: 2013048012/353.
(130058254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2013.

Aesa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 170.000.

Par résolutions signées en date du 8 avril 2013, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de Rajen Shah, avec adresse au Jumeirah Beach Road, bâtiment Sunset Residences,

Jumeirah, Dubai, Emirats Arabes Unis, de son mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat;

2. nomination de Graham Horn, avec adresse professionnelle au 5, Gate Village, Level 1, DIFC, 506699, Dubai, Emirats

Arabes Unis, au mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

Référence de publication: 2013048376/15.
(130059204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Marli Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 154.777.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THIRTEEN
ON THE TWENTY-EIGHTH DAY OF MARCH,
Before US Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Rédange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
Is held an extraordinary general shareholder meeting of "Marli Invest S.A.", a public limited liability company ("société

anonyme") (hereafter the "Company"), having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.777 and incorporated by a deed of Maître Jean-
Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on July 30, 2010, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 1992 on September 24, 2010.

The Company's articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph

WAGNER, aforementioned, on May 22, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1687 on July 4, 2012.

The meeting is opened by Mr. Damien MATTUCCI, professionally residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, being

in the chair (hereafter the "Chairman"),

who appoints as secretary Mrs. Marie-Line SCHUL, professionally residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
The meeting elects as scrutineer Ms. Anna HERMES, professionally residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are recorded in an attendance list. This attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the

61755

L

U X E M B O U R G

represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed
for registration purposes.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed

"ne varietur" by the proxy holder of the appearing persons and the undersigned notary.

II. As it appears from the said attendance list, all the issued shares, representing the whole share capital of the Company,

are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all agenda items.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1.  Increase  of  the  share  capital  of  the  Company  by  an  amount  of  two  million  six  hundred  thousand  Euros  (EUR

2,600,000) in order to raise it from its present amount of sixty thousand Euros (EUR 60,000) to two million six hundred
sixty thousand Euros (EUR 2,660,000) by the issue of twenty six thousand (26,000) new shares with a par value of one
hundred Euros (EUR 100) each and an aggregate par value of two million six hundred thousand Euros (EUR 2,600,000),
all vested with the same rights and obligations as the existing shares;

2. Subscription to twenty four thousand seven hundred (24,700) new shares by Roxbury Holdings Limited ("Roxbury"),

with registered office at La Motte Chambers, St. Helier, Jersey, Channel Islands with company registration number 65081
(the "Roxbury Shares");

3. Subscription to one thousand three hundred (1,300) new shares by Mr. Charles John Pinnell ("CJP"), chartered

accountant, residing at Edifici Nordic 4A, Avda El Traves, La Massana, Principat d'Andorra, holder of UK passport number
761083312 and Andorran residence permit 224115Y (the "CJP Shares");

4.  Full  payment  of  the  Roxbury  Shares  by  the  conversion  of  an  uncontested  and  immediately  payable  receivable

amounting in total to two million four hundred seventy thousand Euros (EUR 2,470,000) held by Roxbury against the
Company;

5. Full payment of the CJP Shares by the conversion of an uncontested and immediately payable receivable amounting

in total to one hundred thirty thousand Euros (EUR 130,000) held by CJP against the Company;

6. Consideration of the valuation method used for determining the value of the receivables and the report of the

independent auditor;

7. Cancellation of the nominal value of the shares of the Company;
8. Decrease of the share capital of the Company by an amount of one hundred sixty five thousand nine hundred ninety

eight Euros and sixty four Euro Cents (EUR 165,998.64) in order to reduce it from its present amount of two million six
hundred sixty thousand Euros (EUR 2,660,000) to two million four hundred ninety four thousand one Euros and thirty
six Euro Cents (EUR 2,494,001.36) in order to offset the accumulated losses of the Company.

9. Amendment of the first paragraph of article 5 of the Company's Articles of Association to give it the following

content: 2,494,001.36) represented by twenty six thousand six hundred

Art. 5. Capital - Shares - Shares Certificates. The share capital is set at two million four hundred ninety four thousand

one Euros and thirty six Euro Cents (EUR (26,600) shares without indication of nominal value."

10. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the shareholders, the general meeting unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of two million six hundred thou-

sand Euros (EUR 2,600,000) in order to raise it from its present amount of sixty thousand Euros (EUR 60,000) to two
million six hundred sixty thousand Euros (EUR 2,660,000) by the issue of twenty six thousand (26,000) new shares with
a par value of one hundred Euros (EUR 100) each and an aggregate par value of two million six hundred thousand Euros
(EUR 2,600,000), all vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to agree to the subscription of (i) twenty four thousand seven hundred (24,700) New

Shares by Roxbury Holdings Limited ("Roxbury"), a company with registered office at La Motte Chambers, St. Helier,
Jersey, Channel Islands with company registration number 65081 and (ii) of one thousand three hundred (1,300) New
Shares by Mr. Charles John Pinnell ("CJP") and expressly acknowledges that the current shareholders of the Company
waive, to the extent necessary, any preferred subscription rights for the New Shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon Roxbury declares to subscribe to twenty four thousand seven hundred (24,700) New Shares and have

them fully paid up by the conversion of an uncontested and immediately payable receivable amounting in total to two
million four hundred seventy thousand Euros (EUR 2,470,000) held by Roxbury against the Company.

Furthermore, CJP declares to subscribe to one thousand three hundred (1,300) New Shares and have them fully paid

up by the conversion of an uncontested and immediately payable receivable amounting in total to one hundred thirty
thousand Euros (EUR 130,000) held by CJP against the Company.

61756

L

U X E M B O U R G

The total value of the above mentioned receivables, which is declared to be of two million six hundred thousand Euros

(EUR 2,600,000) by the contributors and whose valuation is accepted by the Company, is subject to an independent
auditor's report, in accordance with article 32-1 (5) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August
1915 as amended, established by Fiduciaire Everard &amp; Klein S.à r.l., with registered office at 83, rue de la Libération, L-5969
Itzig, which report concludes as follows:

<i>Conclusion

"Based on the work performed and described above, we are of the opinion that the planned contribution is described

in a clear and precise way and that the retained methods of evaluation are adapted to the given circumstances and lead
to a value at least equal to the number of 26,600 shares without indication of nominal value representing the share capital
at the end of the operation of increase and decrease of the share capital. Fiduciaire Everard &amp; Klein S.àr.l."

Such report, being initialed «ne varietur» shall remain attached to the present deed, to be filed at the same time with

the registration authorities.

Proof of the ownership by the contributors of the above mentioned receivables has been given to the undersigned

notary.

The contributors acting through their duly appointed attorney in fact declared that the contributions are free of any

charges and pledges, and that there exists no further impediments to the free transferability of the Contributions without
any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or
other formalities necessary to perform a valid conversion.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to cancel the nominal value of the shares of the Company with immediate effect. The

share capital of the Company will be represented by twenty six thousand six hundred (26,600) shares without indication
of nominal value.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of one hundred sixty five

thousand nine hundred ninety eight Euros and sixty four Euro Cents (EUR 165,998.64) in order to reduce it from its
present amount, i.e. the amount after the above capital increase, of two million six hundred sixty thousand Euros (EUR
2,660,000) to two million four hundred ninety four thousand one Euros and thirty six Euro Cents (EUR 2,494,001.36) in
order to offset the accumulated losses of the Company.

Such decrease shall be completed by reducing the accounting value of the shares so that the total number of shares

issued by the Company remains unchanged.

Proof of the accumulated losses has been given to the undersigned notary by way of the balance sheet of the Company

dated on 31 December 2012.

<i>Fifth resolution

Pursuant to the above resolutions, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles

of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

Art. 5. Capital - Shares - Shares Certificates. The share capital is set at two million four hundred ninety four thousand

one Euros and thirty six Euro Cents (EUR 2,494,001.36) represented by twenty six thousand six hundred (26,600) shares
without indication of nominal value."

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 3,200.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Strassen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE TREIZE
LE VINGT-HUIT MARS
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "Marli Invest SA" (ci-après la «Société»),

avec siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lu-

61757

L

U X E M B O U R G

xembourg, sous le numéro B 154.777, et constituée suivant un acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de
résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1992, le 24 septembre 2010.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu du Maître Jean-Joseph WAGNER, sus-

mentionné, en date du 22 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1687 en date du
4 juillet 2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Damien MATTUCCI, demeurant professionnellement au 163,

rue du Kiem, L-8030 Strassen (ci-après le «Président»),

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Line SCHUL, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem,

L-8030 Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Anna HERMES demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem,

L-8030 Strassen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est réguliè-

rement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital de la Société à concurrence de deux millions six cent mille euros (EUR 2.600.000) afin de

le porter de son montant actuel de soixante mille euros (EUR 60.000) à deux millions six cent soixante mille euros (EUR
2.660.000) par l'émission de vingt-six mille (26.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune et d'une valeur nominale totale de deux millions six cent mille euros (EUR 2.600.000), disposant des mêmes
droits et obligations que les actions existantes (les «Actions Nouvelles»);

2. Souscription à vingt-quatre mille sept cents (24.700) Actions Nouvelles par Roxbury Holdings Limited («Roxbury»)

avec siège social à La Motte Chambers, St. Helier, Jersey, Channel Islands avec numéro d'enregistrement 65081 (les
«Actions Roxbury»);

3. Souscription à mille trois cents (1.300) Actions Nouvelles par Monsieur Charles John Pinnell («CJP»), expert-comp-

table, ayant son adresse privée à Edifici Nordic 4A, Avda El Traves, La Massana, Principauté d'Andorre, détenteur du
numéro  du  passeport  du  Royaume-Uni  761083312  et  permission  de  résidence  de  la  Principauté  d'Andorre  numéro
224115Y (les «Actions CJP»);

4. Libération intégrale des Actions Roxbury par conversion d'une créance certaine, liquide et exigible de deux millions

quatre cent soixante-dix mille euros (EUR 2.470.000) détenue par Roxbury envers la Société;

5. Libération intégrale des Actions CJP par conversion d'une créance certaine, liquide et exigible de cent trente mille

euros (EUR 130.000) détenue par CJP envers la Société;

6. Prise en compte de la méthode d'évaluation utilisée pour déterminer la valeur des créances et du rapport du réviseur

d'entreprises;

7. Suppression de la valeur nominale des actions de la Société;
8. Réduction du capital de la Société à concurrence de cent soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros

soixante-quatre centimes (EUR 165.998,64) afin de le porter de son montant actuel de deux millions six cent soixante
mille euros (EUR 2.660.000,00) à deux millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille un euros trente-six centimes (EUR
2.494.001,36) par compensation des pertes accumulées de la Société;

9. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de lui donner le contenu suivant:

« Art. 5. Capital - Actions - Certificats d'Actions. Le capital social est fixé à deux millions quatre cent quatre-vingt-

quatorze mille un euros trente-six centimes (EUR 2.494.001,36) représenté par vingt-six mille six cents (26.600) actions
sans désignation de valeur nominale.»

10. Divers.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions six cent mille

euros (EUR 2.600.000) afin de le porter de son montant actuel de soixante mille euros (EUR 60.000) à deux millions six
cent soixante mille euros (EUR 2.660.000) par l'émission de vingt-six mille (26.000) nouvelles actions d'une valeur no-

61758

L

U X E M B O U R G

minale de cent euros (EUR 100) chacune et d'une valeur nominale totale de deux millions six cent mille euros (EUR
2.600.000), disposant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver la souscription de (i) vingt-quatre mille sept cents (24.700) Actions Nouvelles

par Roxbury Holdings Limited («Roxbury») et (ii) de mille trois cents (1.300) Actions Nouvelles par Monsieur Charles
John Pinnell («CJP») et l'assemblée prend expressément connaissance que les actionnaires présents de la Société renon-
cent à tout droit de souscription préférentiel éventuel en ce qui concerne les Actions Nouvelles.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, Roxbury déclare souscrire aux vingt-quatre mille sept cents (24.700) Actions Nouvelles et les libérer inté-

gralement par conversion d'une créance certaine, liquide et exigible de deux millions quatre cent soixante-dix mille euros
(EUR 2.470.000) détenue par Roxbury contre la Société.

En plus, CJP déclare souscrire aux mille trois cents (1.300) Actions Nouvelles et les libérer intégralement par con-

version d'une créance certaine, liquide et exigible de cent trente mille euros (EUR 130.000) détenue par CJP envers la
Société.

La valeur totale des créances susmentionnées, a été évaluée par les souscripteurs à un montant de deux millions six

cent mille euros (EUR 2.600.000), et dont l'estimation est acceptée par la Société, est sujette également à un rapport
d'un réviseur d'entreprises indépendant conformément à l'article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10
août 1915 telle que modifiée, rapport établi par Fiduciaire Everard &amp; Klein S.à r.l., ayant son siège social au 83, rue de la
Libération, L-5969 Itzig et dont le rapport conclut comme suit:

<i>Conclusion

"Based on the work performed and described above, we are of the opinion that the planned contribution is described

in a clear and precise way and that the retained methods of evaluation are adapted to the given circumstances and lead
to a value at least equal to the number of 26,600 shares without indication of nominal value representing the share capital
at the end of the operation of increase and decrease of the share capital. Fiduciaire Everard &amp; Klein S.àr.l."

Ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

La preuve de la propriété des créances susmentionnées a été rapportée au notaire soussigné.
Les souscripteurs prénommés, agissant par le biais de leur mandataire, ont déclaré que les créances susmentionnées

sont libres de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de ces créances et que des
instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires
pour effectuer ces conversions.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions de la Société avec effet immédiat. Le capital

de la Société sera désormais représenté par vingt-six mille six cents (26.600) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital de la Société à concurrence de cent soixante-cinq mille neuf cent

quatre-vingt-dix-huit euros soixante-quatre centimes (EUR 165.998,64) afin de le porter de son montant actuel, c'est-à-
dire le montant obtenu après l'augmentation de capital décrite ci-dessus, de deux millions six cent soixante mille euros
(EUR  2.660.000,00)  à  deux  millions  quatre  cent  quatre-vingt-quatorze  mille  un  euros  trente-six  centimes  (EUR
2.494.001,36) par compensation des pertes accumulées de la Société.

Cette réduction sera réalisée par une réduction de la valeur nominale des actions afin que le nombre total d'actions

émis par la Société demeure inchangé.

Preuve des pertes cumulées de la Société a été rapportée au notaire soussigné au moyen d'un bilan de la société daté

du 31 décembre 2012.

<i>Cinquième résolution

Suite aux précédentes résolutions, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts

de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital - Actions - Certificats d'Actions. Le capital social est fixé à deux millions quatre cent quatre-vingt-

quatorze mille un euros trente-six centimes (EUR 2.494.001,36) représenté par vingt-six mille six cents (26.600) actions
sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

61759

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à environ EUR 3.200,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Strassen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. MATTUCCI, M.-L. SCHUL, A. HERMES, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 02 avril 2013. Relation: RED/2013/511. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 09 avril 2013.

e

 Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013045667/255.
(130055587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

Queristics Investment, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 101.460.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé unique en date du 9 avril 2013

- Monsieur Yassine Hamda Khechini, employé privé, né le 12 février 1978 à Huddinge (Suède), résidant profession-

nellement au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg, est nommé Gérant de catégorie C de la Société en remplacement
de Monsieur Alain Renard, avec effet immédiat et pour une période illimitée.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2013048118/13.
(130058230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2013.

Place Wallis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 143.641.

<i>Extrait de la résolution prise par la gérante de la société

La gérante décide de transférer le siège social de la Société du 7B rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg au 40, rue

de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 22 février 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013048107/13.
(130058820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2013.

Titan Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.213.641,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 154.478.

Il résulte lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 14 décembre 2011 la décision

suivante:

Le changement de dénomination de l’associé de la Société, Titan Luxco 1 S.à r.l., immatriculée au registre de commerce

et des sociétés au Luxembourg sous le numéro B154473 en TeamSystem Holdco S.à r.l.immatriculee au registre de
commerce et des sociétés au Luxembourg sous le numéro B 154473.

61760

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2013048224/15.
(130058556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2013.

Grand City Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 165.560.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of March.
Before M 

e

 Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

Mrs Elisabeth RELAVE-SVENDSEN, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as the representative of the

board of directors of the public limited company " Grand City Properties S.A.", with registered office in L-1430 Luxem-
bourg,  6,  boulevard  Pierre  Dupong,  registered  at  the  Companies  and  Trade  Register  of  Luxembourg  ("Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg), section B, number 165.560, pursuant to a power given by the board of
directors of the said company in their meetings of October 5 

th

 and 15 

th

 , 2012 and March 22 

nd

 , 2013.

The copies of the minutes of these meetings, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the

notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing person, acting as said before, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1. The company "Grand City Properties S.A." has been incorporated by deed of M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing

in Luxembourg, on the 16 

th

 of December 2011, published in the Mémorial C number 287 on the 2 

nd

 of February 2012.

2. The subscribed capital of the company is fixed at six million three hundred fifty two thousand five hundred Euro

(6,352,500.- EUR), represented by sixty three million five hundred twenty-five thousand (63,525,000) shares of a par value
of ten Cents (0.10 EUR) each.

3. Pursuant to article 5 of the articles of association, the authorized capital is set at twenty million euro (20.000.000.-

EUR).

The board of directors is authorized to increase in one or several times the subscribed capital in the limits of the

authorized capital at the terms and conditions which he will fix and to suppress or limit the preferential subscription right
of the existing shareholder.

4. In its meetings dated October 5 

th

 and 15 

th

 , 2012 and March 22 

nd

 , 2013., the board of directors of the said

company has decided to increase the capital by five thousand Euro (5,000.- EUR), so as to raise the capital from its present
amount of six million three hundred-fifty two thousand-five hundred Euro (6,352,500.- EUR) to six million three hundred
fifty seven thousand five hundred Euro (6,357,500.- EUR) by the creation and the issue of fifty thousand (50,000) new
shares with a par value of ten Cents (0.10 EUR) each.

5. That the subscription and full payment of the fifty thousand (50,000) new shares has been made as detailed in the

minutes of the Board of Directors, of which a copy shall remain attached hereto.

<i>Payment

The new shares have been fully paid up in kind by converting the convertible bonds issued on October 5 

th

 and 15

th

 2012, for a total amount of two hundred Euro (200,000.- EUR) is at the disposal of the company, of which five thousand

Euro (5,000.- EUR), are allotted to the corporate share capital and the balance of one hundred ninety five thousand euro
(195,000.-EUR) is allotted to the premium account for conversion of bonds into shares.

<i>Report of the auditor.

This contribution was, in application of article 26-1 of the law on commercial companies, controlled by a report of an

independant auditor, namely, KPMG Luxembourg S.à r.l., «cabinet de réviseur d'entreprises agréé», under the signature
of Alison Macleod, independant auditor, who concluded the following:

«Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the valued of the

Bonds does not correspond at least to the nominal value of the shares which would be issued if the Bonds were to be
converted into share at the date of issuance of the Bonds.»

6. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the articles of association is amended

and now reads as follows:

Art. 5. (first paragraph). The subscribed capital of the Company is fixed at six million three hundred fifty seven thousand

five hundred Euro (6,357,500.- EUR), represented by sixty three million five hundred seventy-five thousand (63,575,000)
shares of a par value of ten Cents (0.10 EUR) each."

61761

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at EUR 1,600.-.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that at the request of the

appearing person the present deed is worded in English, followed by an French version; at the request of the same
appearing person, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-huit mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Me Elisabeth RELAVE-SVENDSEN, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de

mandataire spécial au nom et pour compte du conseil d'administration de la société anonyme "Grand City Properties
S.A.", avec siège social à L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des  Sociétés  de  Luxembourg,  section  B  numéro  165.560,  en  vertu  d'un  pouvoir  qui  lui  a  été  conféré  par  le  conseil
d'administration de ladite société en ses réunion du 5 et du 15 octobre 2012 et du 22 mars 2013.

Copies des procès-verbaux de ces réunions, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire,

resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations

comme suit:

1. La société anonyme " Grand City Properties S.A." a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT,

notaire de résidence à Luxembourg en date du 16 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 287 du 2 février 2012.

2. le capital souscrit de la société est fixé à six millions trois cent cinquante-deux mille cinq cents euros (6.352.500,-

EUR), représenté par soixante-trois millions cinq cent vingt-cinq mille (63.525.000) actions d'une valeur nominale de dix
Cents (0,10EUR) chacune..

3. Conformément à l'article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à vingt millions d'euros (20.000.000,- EUR).
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites

du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription
des anciens actionnaires.

4. En ses réunions du 5 et du 15 octobre 2012 et du 22 mars 2013, le conseil d'administration de ladite société a décidé

d'augmenter le capital social à concurrence de cinq mille euros (5.000,- EUR), pour porter le capital social ainsi de son
montant actuel de six millions trois cent cinquante-deux mille cinq cents euros (6.352.500,- EUR) à six millions trois cent
cinquante-sept mille cinq cents euros (6.357.500,- EUR) par la création et l'émission de cinquante mille (50.000) actions
nouvelles d'une valeur nominale de dix Cents (0,10 EUR) chacune.

5. Que la souscription et la libération intégrale des cinquante mille (50.000) actions nouvelles s'est faite, tel que détaillé

dans les procès-verbaux du Conseil d'administration.

<i>Libération

Les actions nouvelles ont été entièrement libérées en nature par conversion d'obligations convertibles émises le 5 et

15 octobre 2012, pour un montant total de deux cent mille euros (200.000,- EUR), dont cinq mille euros (5.000,- EUR)
sont alloués au compte capital social et le solde de cent quatre-vingt-quinze mille euros (195.000,- EUR) sont alloués au
compte prime de conversion des obligations en actions.

<i>Rapport du réviseur

Cet apport a fait, en application de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales l'objet d'un rapport d'un réviseur

d'entreprises agréé, savoir KPMG Luxembourg S.à r.l., cabinet de réviseur d'entreprises agréé, sous la signature de Alison
Macleod, réviseur d'entreprises, lequel a conclu ce qui suit:

«Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the valued of the

Bonds does not correspond at least to the nominal value of the shares which would be issued if the Bonds were to be
converted into share at the date of issuance of the Bonds.»

6. En conséquence de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

61762

L

U X E M B O U R G

« Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à six millions trois cent cinquante-sept mille cinq

cents euros (6.357.500,- EUR), représenté par soixante-trois millions cinq cent soixante-quinze mille (63.575.000) actions
d'une valeur nominale de dix Cents (0,10EUR) chacune."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à 1.600,- EUR.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du com-

parant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Elisabeth RELAVE-SVENDSEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 09 avril 2013. Relation GRE/2013/1414. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013046118/121.
(130056737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2013.

Athena Equity Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 62.500,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 164.265.

Par résolutions signées en date du 8 avril 2013, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de Rajen Shah, avec adresse au Jumeirah Beach Road, bâtiment Sunset Residences, étage

Apartment S39, Jumeirah 3, Dubai, Emirats Arabes Unis, de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat;

2. nomination de Graham Horn, avec adresse professionnelle au 5, Gate Village, Level 1, DIFC, 506699 Dubai, Emirats

Arabes Unis, au mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

Référence de publication: 2013048398/15.
(130059206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Avenue Asia (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.225.

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 15 Avril 2013

L’associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de nommer Mr. Henry Anthony Saavedra, né le 17 Novembre 1978 à New York, demeurant professionnellement

au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 15 Avril 2013 et pour une
durée illimitée.

Luxembourg, le 16 Avril 2013.

Référence de publication: 2013048400/14.
(130059776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Atlas Gracechurch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.010.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

61763

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 Avril 2013.

Référence de publication: 2013048399/10.
(130059518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Apax Edison Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 625.525,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 127.981.

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 15 avril 2013 que:
- Monsieur Javier RIGAU démissionne de son poste de gérant de classe B de la société avec effet au 12 avril 2013;
- Monsieur Francisco MENJIBAR, né le 10 octobre 1980 à Zaragoza (Espagne) et ayant son adresse professionnelle au

33 Jermyn Street, SW1Y 6DN Londres, Royaume-Uni, est nommé en tant que gérant de classe B avec effet au 15 avril
2013 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2013.

Référence de publication: 2013048390/15.
(130059656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Arnau Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.716.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Administrateur

Référence de publication: 2013048394/13.
(130059242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Arnau Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.716.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Administrateur

Référence de publication: 2013048395/13.
(130059243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Avenue Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.133.

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 15 Avril 2013

L’associé unique de la Société a décidé comme suit:

61764

L

U X E M B O U R G

- de nommer Mr. Henry Anthony Saavedra, né le 17 Novembre 1978 à New York, demeurant professionnellement

au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 15 Avril 2013 et pour une
durée illimitée.

Luxembourg, le 16 Avril 2013.

Référence de publication: 2013048401/14.
(130059777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Amaggi Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 144.097.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 Avril 2013.

Amaggi Luxembourg S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager B

Référence de publication: 2013048386/14.
(130059457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

AmTrust Captive Solutions Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 31.679.

REMPLACE LE DEPOT N°L130056508 DU 10/04/2013
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AmTrust Captive Solutions Limited
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013048387/12.
(130059364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Aluber S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 101.215.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.04.2013.

<i>Pour: ALUBER S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Ana-Paula Duarte

Référence de publication: 2013048384/15.
(130059443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Architecture et Environnement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 42.538.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

61765

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013048392/10.
(130059205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Diador Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 141.006.

<i>I. Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon exceptionnelle à Strassen le 09 avril 2013

<i>5 

<i>ème

<i> Résolution:

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Christophe BLONDEAU, Pré-

sident du Conseil d’Administration, de Madame Brigitte DENIS et de Madame Cornelia METTLEN ainsi que celui du
Commissaire aux comptes H.R.T. Révision S.A avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra
en 2018.

<i>II. Changements d’adresse

La Société a été informée du changement d’adresse d’un administrateur et du commissaire aux comptes, Monsieur

Christophe BLONDEAU et H.R.T. Révision S.A. ayant désormais leur adresse au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

<i>Pour DIADOR FINANCE S.A.

Référence de publication: 2013048538/17.
(130059726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Alpha Advisory Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 116.375.

<i>Extrait de la décision du liquidateur datée 11 avril 2013:

Mr Paul de Quant, en sa qualité de liquidateur de la société Alpha Advisory Company S.A. (la «Société»), a décidé de

transférer le siège social de la Société avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2013 du 412 route d'Esch, L-1471 Luxembourg

au 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

<i>Pour Alpha Advisory Company S.A.
Signature
<i>Un Madataire

Référence de publication: 2013048383/16.
(130059547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Aviva Investors, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 32.640.

Le bilan au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 Avril 2013.

Référence de publication: 2013048402/10.
(130059788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Ace Asset Management - SICAV SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.430.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

61766

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2013.

Référence de publication: 2013048405/11.
(130059699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Fondaco Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 137.128.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale Ordinaire du 11 avril 2013

En date du 11 avril 2013, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Pierre Cimino, de Monsieur Franco Brovia et de Monsieur Danilo Vitali

en tant qu’administrateurs,

- de renouveler les mandats de Monsieur Fabio Libertini, Monsieur Henri Ninove et de Madame Sharon Hamlyn en

qualité d’Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014,

Luxembourg, le 12 avril 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Fondaco Lux SA
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2013048611/17.
(130059031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Flystar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 17, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 105.161.

Il résulte d’une décision des associés en date du 16.04.2013 que le siège social de la société est transféré de L-1321

Luxembourg, 119a, rue de Cessange à L-1741 Luxembourg, 17, rue de Hollerich avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G.T. Experts Comptables S.à r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2013048610/12.
(130059280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

G.O. II - Luxembourg Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 112.164.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

Référence de publication: 2013048615/10.
(130059650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Meridian Group Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.244,38.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 175.116.

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 21 Mars 2013

L’associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Mr Anthony Sheehan en tant que gérant A de la Société et ce avec effet au 21 Mars 2013

61767

L

U X E M B O U R G

- de nommer Mr. Johan Eriksson, né le 18 Septembre 1979 à Norberg, Suède, demeurant professionnellement au 22-23

Old Burlington Street, 1 

st

 Floor, London W1S2JJ, en tant que gérant A de la Société avec effet au 21 Mars 2013 et pour

une durée illimitée.

Luxembourg, le 11 Avril 2013.

Référence de publication: 2013047444/15.
(130057528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Java S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 122.057.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 10

<i>avril 2013

Monsieur HEITZ Jean- Marc est révoqué de ses fonctions d’administrateur.
Monsieur REGGIORI Robert, expert-comptable, né le 15.11.1966 à Metz (France), domicilié professionnellement au

17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2015.

Pour extrait sincère et conforme
JAVA S.A.
Jacopo ROSSI
<i>Administrateur

Référence de publication: 2013048715/17.
(130059608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Lancaster Properties, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 117.336.

<i>Extrait de succession des parts

Suite au décès de Thomas Finnegan et à la lettre des avocats G. Jones &amp; Co. datée 13 décembre 2011 relative à la

succession du patrimoine de Thomas Finnegan, décédé le 16 décembre 2010, les parts de la société ont été transférées
comme suit:

- 80 parts sociales transférées à James Finnegan né le 9 juillet 1940 à Monaghan (Irlande) et avec adresse personnelle

à The Grange, Newtown, Enfield, County Meath Ireland.

Luxembourg, le 16 Avril 2013.

Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013048735/16.
(130059815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Kronospan Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.

R.C.S. Luxembourg B 46.483.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 avril 2013

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la société BDO Audit ayant son siège social 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg aux fonctions de réviseur d'entreprises. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2013.

Extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013048734/13.
(130059462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

61768

L

U X E M B O U R G

Indesit Company Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 15.826.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire le 25 mars 2013

Les mandats des administrateurs et du Réviseur d'entreprise venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la

période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM Michele Piagnani, demeurant Via Pomelli 17, CH-6983 Magliaso (Suisse), président;
Dominique Audia, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Armand De Biase, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Salvatore Desiderio, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Daniele Antonio Spadarotto, demeurant au 37 Wharf Road, PE9 2EB, Stamford (Royaume Uni) administrateur;
Luca Oglialoro, demeurant Via Carino 13, I-24010 Ponteranica (Italie) administrateur;
Guido Picari, demeurant Via Pedemonte 2, CH-6928 Viganello (Suisse), administrateur.

<i>Réviseur d'entreprise

KPMG Audit, 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
INDESIT COMPANY LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2013048698/25.
(130059123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

IW Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 87.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2013.

Référence de publication: 2013048709/10.
(130059661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Joie de Cannes S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 113.844.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2013.

JOIE DE CANNES S.A.
Représentée par Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Director

Référence de publication: 2013048718/15.
(130059770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

61769

L

U X E M B O U R G

Julius Baer Investment Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.250.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 31.070.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 1 

<i>er

<i> avril 2013

L'associé unique décide de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Mr Stephan Leutenegger,

né le 3 juin 1970 à Wattwil, Suisse, demeurant professionnellement à c/o Bank Julius Baer &amp; Co. Ltd, Bahnhofstrasse 36,
8001 Zurich, Suisse en tant que gérant supplémentaire de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Julius Baer Investment Services S.à r.l.

Référence de publication: 2013048712/14.
(130059265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

IMC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.625,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 136.526.

EXTRAIT

En date du 12 avril 2013, l'associé unique a pris les résolutions suivantes;
- La démission de Monsieur Ivo Hemelraad, en tant que gérant B, est acceptée avec effet immédiat.
- Madame Barbara Neuerburg, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue

nouveau gérant B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 16 avril 2013.

Référence de publication: 2013048691/15.
(130059546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Ader 3 C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 134.682.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ADER 3 C S.A.

Référence de publication: 2013048407/10.
(130059239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

AIGGRE Sporta S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 130.675.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2013.

Bouchra Akhertous
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013048409/12.
(130059622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

61770

L

U X E M B O U R G

Telenet Finance Luxembourg II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 156.414.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty eighth day of March.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme") "Te-

lenet  Finance  Luxembourg  II  S.A.",  with  registered  office  at  L-1882  Luxembourg,  5,  rue  Guillaume  Kroll,  R.C.S.
Luxembourg B 156414, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy
of Luxembourg) on October 28, 2010, published in the Mémorial C number 2642 of December 2, 2010.

The meeting is presided by Mrs Christina SCHMIT-VALENT, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster,

3, route de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr. Massimo PERRONE, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster,

3, route de Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Alain THILL, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de

Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment of article 2.1 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

« Art. 2.1. The Company's registered office is established in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any
other location in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General
Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.».

2. Transfer of the registered office from L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll to L-2370 Howald, 2, rue Peter-

nelchen.

3. Resignation of Mrs. Sandra ROLLAND as director and discharge.
4. Resignation of Mr. Dominique ROBYNS as director and discharge.
5. Resignation of Mrs. Muriel BOURGEOIS as director and discharge.
6. Appointment of Mr. Jonathan LEPAGE, company director, born in Namur (Belgium), on August 27, 1975, residing

professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the statutory
general shareholders' meeting of 2018.

7. Appointment of Mr. Oliver WOLF, company director, born in Bendorf/Rhein (Germany), on April 1, 1974, residing

professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the statutory
general shareholders' meeting of 2018.

8. Appointment of Mr. Christophe Emmanuel SACRE, company director, born in Ottignies (Belgium), on January 22,

1985, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end
of the statutory general shareholders' meeting of 2018.

9. Sundry.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, checked and signed "ne varietur" by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept at
the latter's office.

The proxies of the represented shareholders signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.

III As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolutions:

<i>First resolution

Article 2.1 of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

« Art. 2.1. The Company's registered office is established in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any
other location in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General
Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.».

61771

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The registered office is transferred from L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll to L-2370 Howald, 2, rue Pe-

ternelchen.

<i>Third resolution

Discharge is given to the resigning director, Mrs. Sandra ROLLAND, for the performance of her mandate.

<i>Fourth resolution

Discharge is given to the resigning director, Mr. Dominique ROBYNS, for the performance of his mandate.

<i>Fifth resolution

Discharge is given to the resigning director, Mrs. Muriel BOURGEOIS, for the performance of his mandate.

<i>Sixth resolution

Mr. Jonathan LEPAGE, company director, born in Namur (Belgium), on August 27, 1975, residing professionally at

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as director until the end of the statutory
general shareholders' meeting of 2018.

<i>Seventh resolution

Mr. Oliver WOLF, company director, born in Bendorf/Rhein (Germany), on April 1, 1974, residing professionally at

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as director until the end of the statutory
general shareholders' meeting of 2018.

<i>Eighth resolution

Mr. Christophe Emmanuel SACRE, company director, born in Ottignies (Belgium), on January 22, 1985, residing pro-

fessionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as director until the end of
the statutory general shareholders' meeting of 2018.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

is estimated at about nine hundred Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the at-

torney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same attorney and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surname, Christian name,

civil status and residence, they have signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-huit mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Telenet Finance Luxembourg

II S.A.", ayant son siège à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg B156414, constituée suivant
acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 28
octobre 2010, publié au Mémorial C numéro 2642 du 2 décembre 2010.

L'assemblée  est  présidée  par  Madame  Christina  SCHMIT-VALENT,  employée,  demeurant  professionnellement  à

L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Massimo PERRONE, employé, demeurant professionnellement à

L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l'article 2.1 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

61772

L

U X E M B O U R G

« Art. 2.1. Le siège de la Société est établi à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale),
selon les modalités requises pour la modification des Statuts».

2) Transfert du siège social de L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.
3) Démission de Madame Sandra ROLLAND de son mandat d'administrateur et décharge.
4) Démission de Monsieur Dominique ROBYNS de son mandat d'administrateur et décharge.
5) Démission de Madame Muriel BOURGEOIS de son mandat d'administrateur et décharge.
6) Nomination de Monsieur Jonathan LEPAGE, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 27 août 1975,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administra-
teur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

7) Nomination de Monsieur Oliver WOLF, administrateur de sociétés, né à Bendorf/Rhein (Allemagne), le 1 

er

 avril

1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme admi-
nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

8) Nomination de Monsieur Christophe Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés, né à Ottignies (Belgique), le

22  janvier  1985,  demeurant  professionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,
comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

9) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

<i>Première résolution

L'article 2.1 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 2.1. Le siège de la Société est établi à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale),
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.».

<i>Deuxième résolution

Le siège social est transféré de L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.

<i>Troisième résolution

Décharge est donnée à l'administrateur démissionnaire, Madame Sandra ROLLAND, pour l'exercice de son mandat.

<i>Quatrième résolution

Décharge est donnée à l'administrateur démissionnaire, Monsieur Dominique ROBYNS, pour l'exercice de son mandat.

<i>Cinquième résolution

Décharge est donnée à l'administrateur démissionnaire, Madame Muriel BOURGEOIS, pour l'exercice de son mandat.

<i>Sixième résolution

Monsieur Jonathan LEPAGE, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 27 août 1975, demeurant profes-

sionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  est  nommé  comme  administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

<i>Septième résolution

Monsieur Oliver WOLF, administrateur de sociétés, né à Bendorf/Rhein (Allemagne), le 1 

er

 avril 1974, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé comme administra-
teur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

61773

L

U X E M B O U R G

<i>Huitième résolution

Monsieur Christophe Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés, né à Ottignies (Belgique), le 22 janvier 1985,

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé comme
administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

s'élève à environ neuf cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du man-

dataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête du même mandataire et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Christina SCHMIT-VALENT, Massimo PERRONE, Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 avril 2013. Relation GRE/2013/1436. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013048214/172.
(130058256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2013.

Aero Technical Support &amp; Services Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 128.997.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013048375/10.
(130059399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

KPLMC, Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. KPL, Kinetic Partners (Luxembourg) S.à r.l.).

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 65, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 112.519.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2013.

Référence de publication: 2013047386/12.
(130057486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

Alis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.284.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013048413/10.
(130059624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

61774

L

U X E M B O U R G

Aljo Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 149.084.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 12 avril 2013

Est nommé président du conseil d’administration, la durée de son mandat sera fonction de celle de son mandat d’ad-

ministrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit
le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles:

- Monsieur Frédéric Depireux, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013048414/13.
(130059309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Aljo Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 149.084.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 avril 2013

1. La démission de Madame Séverine Desnos avec effet au 11 avril 2013.
2. L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
- Monsieur Frédéric Depireux, demeurant professionnellement au 18 rue Robert Stümper L- 2557 Luxembourg, avec

effet au 12 avril 2013.

Le  nouvel  administrateur  terminera  le  mandat  de  son  prédécesseur,  mandat  qui  viendra  à  expiration  à  l’issue  de

l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 novembre 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013048415/15.
(130059309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Generali Multinational Pension Solutions SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 141.004.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 15 mars 2013:

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Monsieur Gian Luigi Costanzo a démissionné en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 28 février 2013.
- Monsieur Mauro Dugulin a été nommé Président du Conseil d’Administration de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

Pour extrait conforme
Alex SCHMITT
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013048617/16.
(130059642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

MPR Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 156.579.

<i>Extrait des résolutions prises à Luxembourg par l'associé unique de la société en date du 12 avril 2013

1. L'associé unique décide de révoquer Monsieur Cyril PALCANI demeurant professionnellement au 37, rue d'Anvers,

L-1130 Luxembourg de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 12 avril 2013.

61775

L

U X E M B O U R G

2. L'associé unique décide de nommer Monsieur Sébastien FRANÇOIS, employé privé, né le 4 décembre 1980 à

Libramont-Chevigny (Belgique), demeurant professionnellement au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, en qualité de
gérant de la Société avec effet au 12 avril 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013048046/15.

(130058987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2013.

MMFLX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 200.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 175.308.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 13 mars 2013

Il résulte des décisions écrites de l'associé unique de la Société (l' «Associé Unique») la décision suivante (traduction

libre):

- L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Lawrence Noe, gérant.

- L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Paul Reeve Stimson, né le 25 septembre 1949 dans l'Etat du Michigan,

aux Etats Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1, Curzon Street, à Londres W1J 5HA, au Royaume-
Uni, en qualité de gérant de la Société, pour une durée indéterminée, avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur
Lawrence Noe, gérant démissionnaire.

Luxembourg, le 25 mars 2013.

Pour extrait analytique conforme
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signature

NEW YORK, 2 

nd

 APRIL 2013.

Pour extrait analytique conforme
Paul Reeve Stimson

Référence de publication: 2013048040/23.

(130058106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2013.

IFG S.A., International Finance Group, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 57.491.

EXTRAIT

FIDUCIAIRE DE LA GARE SA (en abrégé FIDUGARE), ayant son siège social au 41, route de Longwy, L-8080 Bertrange,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B54075. Dénonce le siège social de la Société
Anonyme INTERNATIONAL FINANCE GROUP en abrégé IFG, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B57491 avec effet au premier jour de sa domiciliation à cette adresse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 15 avril 2013.

<i>Pour FIDUGARE S.A.
Jacques Van Rysselberghe
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2013048704/16.

(130059297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

61776


Document Outline

Ace Asset Management - SICAV SIF

Acsof

Acsof

Ader 3 C S.A.

Advent Tower (Luxembourg) S.à r.l.

Aero Technical Support &amp; Services Holdings

Aesa S.à r.l.

AIGGRE Sporta S.à r.l.

Alis S.A.

Aljo Property S.A.

Aljo Property S.A.

Alpha Advisory Company S.A.

Aluber S.A.

Amaggi Luxembourg S.à r.l.

AmTrust Captive Solutions Limited

Apax Edison Holdco S.à r.l.

Architecture et Environnement S.A.

Arnau Invest S.A.

Arnau Invest S.A.

Athena Equity Trading S.à r.l.

Atlas Gracechurch S.à r.l.

Avenue Asia (Luxembourg) S.à r.l.

Avenue Luxembourg S.à r.l.

Aviva Investors

Diador Finance S.A.

Enerfin S.A.

Flystar S.à r.l.

Fondaco Lux S.A.

Generali Multinational Pension Solutions SICAV

G.O. II - Luxembourg Two S.à r.l.

Grand City Properties S.A.

IMC Luxembourg S.à r.l.

Indesit Company Luxembourg S.A.

International Finance Group

IW Investments S.A.

Java S.A.

Joie de Cannes S.A.

Julius Baer Investment Services S.à r.l.

Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l.

Kinetic Partners (Luxembourg) S.à r.l.

Kronospan Luxembourg S.A.

Lancaster Properties

Leggett &amp; Platt Canada Co., Luxembourg Branch

Leggett &amp; Platt Canada Co., Luxembourg Branch

Marli Invest S.A.

Meridian Group Investments S.à r.l.

Meridian Holding S.à r.l.

MMFLX S.à r.l.

MPR Finance S.à r.l.

Place Wallis S.à r.l.

Queristics Investment

StatPro International S.à r.l.

Telenet Finance Luxembourg II S.A.

Titan Luxco 2 S.à r.l.