This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1192
22 mai 2013
SOMMAIRE
Allianz Global Investors Fund II . . . . . . . . . 57175
Allianz Global Investors Fund IX . . . . . . . . 57176
Almasa S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57180
Ana Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57171
AviaRent S.C.A. SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . 57196
BD - Family Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57182
beta3 dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57196
Bizvalue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57194
Bizvalue SICAV-SIF S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . 57200
Causerman Investissements S.A. . . . . . . . . 57173
CENTUM Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57182
Charlotte Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . 57174
Cobano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57173
Codecis International S.A. . . . . . . . . . . . . . . 57178
Commerzbank International Portfolio Ma-
nagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57180
Eurinvest S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57181
Eurox Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57176
Fincra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57170
Gelsomino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57181
Globus Equity SICAV SIF . . . . . . . . . . . . . . . 57201
H & A Global Macro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57200
I.B.M.S. - International Business and Mana-
gement Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57171
Interval S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57171
Investec Global Strategy Fund . . . . . . . . . . 57177
IPConcept (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . 57202
Jockey Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57170
Jordanus Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . 57175
Kerta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57216
LLIC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57213
Longview Partners Investments . . . . . . . . . 57178
LUXFER - Industriehallenbau S.A. . . . . . . . 57179
Malibaro, SA SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57172
Maraton International S.A. . . . . . . . . . . . . . . 57173
Mavica Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . 57170
Öhman Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57194
P. Corporate Investments S.A. . . . . . . . . . . 57202
P. Corporate Investments S.à r.l. . . . . . . . . 57202
Perseus Immobilien Gesellschaft 11 . . . . . 57182
Quadrum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57194
Quadrum SICAV-SIF S.C.A. . . . . . . . . . . . . 57200
Stratège S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57172
Sylvex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57174
Transair S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57172
Truc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57193
Vahina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57179
VCM Golding Mezzanine SICAV . . . . . . . . . 57194
VCM Golding Mezzanine SICAV . . . . . . . . . 57180
VCM Golding Mezzanine Sicav II . . . . . . . . 57196
VCM Golding Mezzanine Sicav II . . . . . . . . 57194
Vestigia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57177
WILLI S.A., société de gestion de patrimoi-
ne familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57174
YRI Global Liquidity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 57179
57169
Jockey Holding, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 68.793.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, le <i>5 juin 2013i> à 11 heures, pour
délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2012
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire
5. Renouvellement des mandats d'administrateurs
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013058419/18.
Mavica Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 66.476.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>07 juin 2013i> à 09:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2011 et 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013059206/696/18.
Fincra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 135.998.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>10 juin 2013i> à 14.00 heures, pour délibérer
sur l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Report de la date de l'Assemblée au 10 juin 2013,
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice
clos au 31 décembre 2012,
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2013062751/18.
57170
Ana Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 75.064.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2013i> à 10.00 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013065116/755/18.
I.B.M.S. - International Business and Management Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 100.719.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>11 juin 2013i> à 09.30 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2013065120/833/18.
Interval S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 39.661.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>11 juin 2013i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2013065121/833/18.
57171
Malibaro, SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 134.992.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au siège social en date du <i>7 juin 2013i> à 17 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2012.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2013065127/1004/18.
Stratège S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 43.308.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10.6.2013i> à 17H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2012
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- nominations statutaires
- divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013065126/560/17.
Transair S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 21.505.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>12 juin 2013i> à 10.30 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2013065123/833/19.
57172
Causerman Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 52.637.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 2013i> à 10.00 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société.
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013065117/755/19.
Maraton International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 104.318.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>12 juin 2013i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2013065122/833/19.
Cobano S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2bis, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 140.669.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>7 juin 2013i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2012
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013065125/788/16.
57173
Charlotte Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 111.517.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>30 mai 2013i> à 10:30 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2011 et 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013055874/696/16.
Sylvex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8149 Bridel, 38, Val des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 40.302.
Mesdames et Messieurs les actionnaires de SYLVEX S.A. sont invités à participer à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>31 mai 2013i> à 11.00 heures à l'adresse suivante: L-1445 Strassen, 7A, rue Thomas Edison, PKF Weber
& Bontemps.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration.
2. Rapport du réviseur du commissaire aux comptes.
3. Approbation des comptes 2012 de ELITA sàrl.
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012.
5. Affectation des résultats des comptes 2012.
6. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
7. Divers
Les documents qui seront soumis au vote de l'Assemblée générale extraordinaire peuvent être obtenus sur demande
auprès de Maître Jacques-Yves HENCKES, avocat, L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.
Référence de publication: 2013044748/20.
WILLI S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 131.202.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme WILLI S.A. Société de gestion de patrimoine familial sont priés
d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>30 mai 2013i> à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013061189/750/18.
57174
Jordanus Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 14.033.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>3 juin 2013i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013060479/755/18.
Allianz Global Investors Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 117.659.
Hiermit wird mitgeteilt, dass die
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Anteilinhaber der Allianz Global Investors Fund II (SICAV) am <i>11. Juni 2013i> um 11:15 Uhr Ortszeit Luxemburg
am Gesellschaftssitz 6A, route de Trèves in 2633 Senningerberg, Luxemburg, stattfinden wird, um die folgenden Tage-
sordnungspunkte zu erörtern und darüber abzustimmen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer sowie Verabschiedung des Jahresabs-
chlusses und der Verwendung der Erträge (ggf.) für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2012.
2. Entlastung des Verwaltungsrats von seiner Verantwortung für alle Maßnahmen, die im Rahmen seines Mandates
während des Geschäftsjahres bis 31. Dezember 2012 ergriffen wurden.
3. Wiederwahl von Herrn Mathias Müller als Verwaltungsratsmitglied.
4. Ko-Optierung der Herren Dr Kai Wallbaum und Markus Breidbach als Verwaltungsratsmitglieder.
5. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxemburg, zum Abschlussprüfer.
6. Beschluss über sonstige Angelegenheiten, die ordnungsgemäß auf der Versammlung vorgebracht werden.
<i>Abstimmung:i>
Die Beschlüsse auf der Tagesordnung können ohne Quorum mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst
werden. Das Quorum sowie die Mehrheitsverhältnisse im Verhältnis zu den ausstehenden Anteilen werden am 6. Juni
2013 per 24:00 Uhr Ortszeit Luxemburg ("Stichtag") bestimmt.
<i>Abstimmungsregelung:i>
Zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt sind die Anteilinhaber, die eine Bestätigung ihrer Depotbank oder ihres
Instituts vorlegen können, aus der die Anzahl der von ihnen am Stichtag gehaltenen Anteile hervorgeht und welche bis
11:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am 7. Juni 2013 bei der Transferstelle, der RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary
Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, eingegangen sein muss.
Alle Anteilinhaber, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung berechtigt sind, haben das Recht, einen
Vertreter zu bestimmen, der an ihrer Stelle abstimmen darf. Um gültig zu sein, muss die Stimmrechtsvoll-macht vollständig
ausgefüllt und handschriftlich durch den Auftragserteilenden oder dessen Anwalt oder, falls der Auftragserteilende eine
Gesellschaft ist, mit dem Firmensiegel oder handschriftlich durch einen Bevollmächtigten unterzeichnet werden und an
die Transferstelle, die RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette,
Luxemburg, geschickt werden, so dass sie bis 11:00 Uhr Ortszeit Luxemburg in Luxemburg am 7. Juni 2013 dort einge-
troffen ist.
Vollmachtsformulare erhalten registrierte Anteilinhaber bei der Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A., Do-
miciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg. Eine zum Stellvertreter ernannte Person muss
57175
kein Anteilinhaber der Gesellschaft sein. Durch die Ernennung eines Stellvertreters ist ein Anteilinhaber nicht von der
Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen.
Sollten Sie weitere Rückfragen haben, konsultieren Sie bitte Ihren Finanzberater, die Verwaltungsgesellschaft oder eine
der im Verkaufsprospekt vom 31. Oktober 2012 ausgewiesenen Informationsstellen.
Sollten Sie Ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, wenden Sie sich bitte an die Allianz Global
Investors Europe mbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60325 Frankfurt am Main, E-Mail: info@allianzgi.com als Infor-
mationsstelle für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.
Exemplare des zum 31. Oktober 2012 aktualisierten Verkaufsprospekts sind am Sitz der Gesellschaft, bei der Ver-
waltungsgesellschaft, den Vertriebsgesellschaften und den Informationsstellen der Gesellschaft in jedem Rechtsgebiet, in
dem die Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, während der üblichen Geschäftszeiten einsehbar bzw. auf
Anfrage kostenlos erhältlich.
Senningerberg, Mai 2013.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2013065113/755/50.
Eurox Europe S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 154.992.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme EUROX EUROPE S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>30 mai 2013i> à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013061175/750/17.
Allianz Global Investors Fund IX, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 48.370.
Hiermit wird mitgeteilt, dass die
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Anteilinhaber der Allianz Global Investors Fund IX (SICAV) am <i>11. Juni 2013i> um 10:45 Uhr Ortszeit Luxemburg
am Gesellschaftssitz 6A, route de Trèves in 2633 Senningerberg, Luxemburg, stattfinden wird, um die folgenden Tage-
sordnungspunkte zu erörtern und darüber abzustimmen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer sowie Verabschiedung des Jahresabs-
chlusses und der Verwendung der Erträge (ggf.) für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2012.
2. Entlastung des Verwaltungsrats von seiner Verantwortung für alle Maßnahmen, die im Rahmen seines Mandates
während des Geschäftsjahres bis 31. Dezember 2012 ergriffen wurden.
3. Wiederwahl von Herrn Mathias Müller als Verwaltungsratsmitglied.
4. Ko-Optierung der Herren Dr Kai Wallbaum sowie Herrn Markus Breidbach als Verwaltungsratsmitglieder.
5. Wiederwahl von KPMG Luxemburg S.à r.l. zum Abschlussprüfer.
6. Beschluss über sonstige Angelegenheiten, die ordnungsgemäß auf der Versammlung vorgebracht werden.
<i>Abstimmung:i>
Die Beschlüsse auf der Tagesordnung können ohne Quorum mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst
werden. Das Quorum sowie die Mehrheitsverhältnisse im Verhältnis zu den ausstehenden Anteilen werden am 6. Juni
2013 per 24:00 Uhr Ortszeit Luxemburg ("Stichtag") bestimmt.
<i>Abstimmungsregelung:i>
Zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt sind die Anteilinhaber, die eine Bestätigung ihrer Depotbank oder ihres
Instituts vorlegen können, aus der die Anzahl der von ihnen am Stichtag gehaltenen Anteile hervorgeht und welche bis
57176
11:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am 7. Juni 2013 bei der Transferstelle, der RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary
Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, eingegangen sein muss.
Alle Anteilinhaber, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung berechtigt sind, haben das Recht, einen
Vertreter zu bestimmen, der an ihrer Stelle abstimmen darf. Um gültig zu sein, muss die Stimmrechtsvoll-macht vollständig
ausgefüllt und handschriftlich durch den Auftragserteilenden oder dessen Anwalt oder, falls der Auftragserteilende eine
Gesellschaft ist, mit dem Firmensiegel oder handschriftlich durch einen Bevollmächtigten unterzeichnet werden und an
die Transferstelle, die RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette,
Luxemburg, geschickt werden, so dass sie bis 11:00 Uhr Ortszeit Luxemburg in Luxemburg am 7. Juni 2013 eingetroffen
ist.
Vollmachtsformulare erhalten registrierte Anteilinhaber bei der Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A., Do-
miciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg. Eine zum Stellvertreter ernannte Person muss
kein Anteilinhaber der Gesellschaft sein. Durch die Ernennung eines Stellvertreters ist ein Anteilinhaber nicht von der
Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen.
Sollten Sie weitere Rückfragen haben, konsultieren Sie bitte Ihren Finanzberater, die Verwaltungsgesellschaft oder eine
der im Verkaufsprospekt vom 21. Dezember 2012 ausgewiesenen Informationsstellen.
Sollten Sie Ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, wenden Sie sich bitte an die Allianz Global
Investors Europe mbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60325 Frankfurt am Main, E-Mail: info@allianzgi.com als Infor-
mationsstelle für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.
Exemplare des zum 21. Dezember 2012 aktualisierten Verkaufsprospekts sind am Sitz der Gesellschaft, bei der Ver-
waltungsgesellschaft, den Vertriebsgesellschaften und den Informationsstellen der Gesellschaft in jedem Rechtsgebiet, in
dem die Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, während der üblichen Geschäftszeiten einsehbar bzw. auf
Anfrage kostenlos erhältlich.
Senningerberg, Mai 2013.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2013065114/755/50.
Vestigia, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 104.507.
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
GENERAL MEETING
which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on <i>7 June 2013i> at 10.00 o'clock, with
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915;
The statutory general meeting held on 30 April 2013 approving annual accounts as per 31 December 2011 was not
able to deliberate on item 3, as the legally required quorum was not achieved. The general meeting, which is going to be
held extraordinarily on 7 June 2013 will deliberate whatever the proportion of the capital represented.
<i>The board of directors.i>
Référence de publication: 2013057644/534/16.
Investec Global Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 139.420.
Dear Shareholder,
The Board of Directors of the Company has the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the Company which will be held at 4pm at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on <i>13i>
<i>June 2013i> , with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the Report of the Board of Directors.
2. Presentation of the Report of the Auditor.
3. Approval of the audited financial statements for the year ended 31 December 2012.
4. Allocation of the net results for the year ended 31 December 2012.
5. Discharge of Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 31 December 2012.
57177
6. To re-elect as Directors for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2014:
- Mr. Hendrik Jacobus du Toit;
- Mr. Grant David Cameron;
- Mr. Gregory David Cremen;
- Mr. John Conrad Green;
- Ms. Kim Mary McFarland;
- Mr. Claude Niedner;
- Mr. Michael Edward Charles Ryder Richardson.
7. To re-elect KPMG Luxembourg S.à r.l as Auditor of the Company for a term ending at the next Annual General
Meeting to be held in 2014.
8. To vote upon payment of total combined remuneration of the Directors up to but not exceeding US$200,000 to
be apportioned between the re-elected Directors, with no single Director receiving more than US$35,000 for the
period from this Annual General Meeting to the next Annual General Meeting to be held in 2014.
9. Any other business.
Shareholders are informed that the Annual General Meeting may validly deliberate on the items of the agenda without
any quorum requirement and the resolution on each item of the agenda may validly be passed at the majority of the votes
validly cast at such Annual General Meeting. Each share is entitled to one vote. A Shareholder may act at the Annual
General Meeting by proxy.
Please be advised that only Shareholders on record by 4pm on 11 June 2013 may be entitled to vote at this Annual
General Meeting. Should you not be able to attend this Annual General Meeting, you are kindly requested to date, sign
and return the form of proxy
by fax or by mail by 4pm on 11 June 2013 to 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number (+352) 464
010 413.
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2013065118/755/41.
Codecis International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 124.925.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 juin 2013i> à 15:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L'Assemblée Générale du 07 mai 2013 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n'ayant pas été atteint.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013062076/696/15.
Longview Partners Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.878.
The Board of Directors convenes the Shareholders of the SICAV to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the company on <i>10 June 2013i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
- Allocation of Results
The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the
votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV.
The Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors (ifs.fds@bdl.lu) at least five
calendar days before the Meeting.
Référence de publication: 2013065119/755/15.
57178
Vahina, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 78.166.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>10 juin 2013i> à 13.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013065124/534/15.
LUXFER - Industriehallenbau S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 9.821.
The Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 31, 2013i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2012
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Modification of the Board of Director's composition
5. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2013060481/795/16.
YRI Global Liquidity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.404.
Par résolutions signées en date du 26 mars 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes;
1) Démission du Gérant A suivant à partir du 26 mars 2013:
Mr Martinus Cornelis Johannes Weijermans
2) Nomination du nouveau Gérant A suivant à partir du 26 mars 2013 pour une durée indéterminée:
Me Pamela Morag Valasuo, née le 26 mai 1975 à Borgà Ik, Finlande, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3) Nomination du nouveau Gérant B suivant à partir du 26 mars 2013 pour une durée indéterminée:
Mr Michael Gerard Mc Auliffe, né le 26 octobre 1971 à Dublin, Irlande, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2013.
<i>Pour la Société
i>Pamela Valasuo
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2013044746/22.
(130053931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2013.
57179
VCM Golding Mezzanine SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 102.202.
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 24. April 2013:i>
Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversamm-
lung des Jahres 2017 enden:
- Markus Gierke, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Ekkehart Kessel, Verwaltungsratsmitglied
- Silvan Trachsler, Verwaltungsratsmitglied
PricewaterhouseCoopers Société coopérative mit Sitz in 400, route d’Esch, L-1014 Luxemburg wurde als Abschluss-
prüfer der Gesellschaft bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2014 bestellt.
Munsbach, den 24. April 2013.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Référence de publication: 2013063523/17.
(130078065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Almasa S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 14.210.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>31 mai 2013i> à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013060478/795/15.
Commerzbank International Portfolio Management, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 41.022.
Hiermit wird mitgeteilt, dass die
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Anteilinhaber der Commerzbank International Portfolio Management (SICAV) am <i>11. Juni 2013i> um 11:00 Uhr
Ortszeit Luxemburg am Gesellschaftssitz 6A, route de Trèves in L-2633 Senningerberg, Luxemburg, stattfinden wird, um
die folgenden Tagesordnungspunkte zu erörtern und darüber abzustimmen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer sowie Verabschiedung des Jahresabs-
chlusses und der Verwendung der Erträge (ggf.) für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2012.
2. Entlastung des Verwaltungsrats von seiner Verantwortung für alle Maßnahmen, die im Rahmen seines Mandates
während des Geschäftsjahres bis 31. Dezember 2012 ergriffen wurden.
3. Wiederwahl der Herren Jean-Christoph Arntz, Falk Fischer sowie Oliver Pietsch als Verwaltungsratsmitglieder.
4. Wiederwahl von KPMG Luxemburg S.à r.l. zum Abschlussprüfer.
5. Beschluss über sonstige Angelegenheiten, die ordnungsgemäß auf der Versammlung vorgebracht werden.
<i>Abstimmung:i>
Die Beschlüsse auf der Tagesordnung können ohne Quorum mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst
werden. Das Quorum sowie die Mehrheitsverhältnisse im Verhältnis zu den ausstehenden Anteilen werden am 6. Juni
2013 per 24:00 Uhr Ortszeit Luxemburg ("Stichtag") bestimmt.
57180
<i>Abstimmungsregelung:i>
Zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt sind die Anteilinhaber, die eine Bestätigung ihrer Depotbank oder ihres
Instituts vorlegen können, aus der die Anzahl der von ihnen am Stichtag gehaltenen Anteile hervorgeht und welche bis
11:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am 7. Juni 2013 bei der Transferstelle, der RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary
Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, eingegangen sein muss.
Alle Anteilinhaber, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung berechtigt sind, haben das Recht, einen
Vertreter zu bestimmen, der an ihrer Stelle abstimmen darf. Um gültig zu sein, muss die Stimmrechtsvoll-macht vollständig
ausgefüllt und handschriftlich durch den Auftragserteilenden oder dessen Anwalt oder, falls der Auftragserteilende eine
Gesellschaft ist, mit dem Firmensiegel oder handschriftlich durch einen Bevollmächtigten unterzeichnet werden und an
die Transferstelle, die RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette,
Luxemburg, geschickt werden, so dass sie bis 11:00 Uhr Ortszeit Luxemburg in Luxemburg am 7. Juni 2013 eingetroffen
ist.
Vollmachtsformulare erhalten registrierte Anteilinhaber bei der Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A., Do-
miciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg. Eine zum Stellvertreter ernannte Person muss
kein Anteilinhaber der Gesellschaft sein. Durch die Ernennung eines Stellvertreters ist ein Anteilinhaber nicht von der
Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen.
Sollten Sie weitere Rückfragen haben, konsultieren Sie bitte Ihren Finanzberater, die Verwaltungsgesellschaft oder eine
der im Verkaufsprospekt vom 28. September 2012 ausgewiesenen Informationsstellen.
Sollten Sie Ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, wenden Sie sich bitte an die Allianz Global
Investors Europe mbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60325 Frankfurt am Main, E-Mail: info@allianzgi.com als Infor-
mationsstelle für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.
Exemplare des zum 28. September 2012 aktualisierten Verkaufsprospekts sind am Sitz der Gesellschaft, bei der Ver-
waltungsgesellschaft, den Vertriebsgesellschaften und den Informationsstellen der Gesellschaft in jedem Rechtsgebiet, in
dem die Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, während der üblichen Geschäftszeiten einsehbar bzw. auf
Anfrage kostenlos erhältlich.
Senningerberg, Mai 2013.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2013065115/755/49.
Eurinvest S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 6.025.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme EURINVEST S.A.-SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>30 mai 2013i> à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013061174/750/15.
Gelsomino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 107.861.
Les comptes au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GELSOMINO S.A.
Robert REGGIORI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013044988/12.
(130055169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.
57181
BD - Family Select, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Le règlement de gestion coordonné au 1. avril 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02. mai 2013.
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature
Référence de publication: 2013058024/11.
(130071089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
CENTUM Fund, Fonds Commun de Placement.
The liquidation of Centum Fund (the "Fund") has been closed with effect from 14 December 2009 by decision of the
Management Company acting as liquidator of the Fund.
The Management Company has approved the liquidation report in relation to the liquidation of the Fund.
All liquidation proceeds have been distributed to the unitholders of the Fund.
The corporate documents of the Fund will be retained for a period of five years at the registered office of the Mana-
gement Company.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013065128/6275/11.
Perseus Immobilien Gesellschaft 11, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 132.800.
DEMERGER PROPOSAL
The board of managers of the Transferring Company proposes a partial demerger of the Transferring Company (scis-
sion partielle) without dissolution of the Transferring Company ("De-Merger") as permitted by article 288 of the
Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended ("Law"), subject to (i) the terms and conditions
of the present proposal of de-merger ("De-Merger Proposal") (projet de scission) prepared in accordance with articles
307 and 289 of the Law, (ii) the approval of the general meeting of the shareholder(s) of the Transferring Company and
(iii) the compliance with other mandatory formalities in the Law and mentioned hereafter.
The De-Merger will consist in (i) the transfer of a part of the assets and liability of the Transferring Company to the
Recipient Company, a new Luxembourg limited liability company to be established by virtue of the De-Merger under the
name of Perseus Immobilien Gesellschaft 13 and (ii) the continuance of the Transferring Company with the assets and
liabilities not transferred. The assets subject to the transfer comprise the Transferring Company's real estates located in
Halle (Germany) consisting of buildings, open spaces and apartments further detailed under Article 2.1, for a total gross
amount of EUR 9,782,143.05 (nine million seven hundred eighty two thousand one hundred forty three Euros and five
cents).
The De-Merger Proposal will be published in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, at least one (1) month
prior to the general meeting of the shareholder(s) of the Transferring Company which shall deliberate on the De-Merger
Proposal.
1. Legal Form - Name - Corporate seat of the companies participating in the De-Merger.
1.1 Transferring Company
The Transferring Company exists under the form of a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg
law under the name "Perseus Immobilien Gesellschaft 11". The registered office of the Transferring Company is established
at 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and
companies register under number B 132.800.
1.2 Recipient Company
The Recipient Company (not yet incorporated) shall exist under the form of a société à responsabilité limitée (to be)
incorporated under Luxembourg law under the name "Perseus Immobilien Gesellschaft 13". The registered office of the
Recipient Company shall be established at 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. Transfer of assets and liabilities to the Recipient Company.
2.1 Transferred Assets
57182
In accordance with article 307 (1) in connection with article 289 (2) h) of the Law, the assets ("Transferred Assets")
of the Transferring Company to be transferred to the Recipient Company are exclusively the following:
Situation of the Building
Cadastral reference
1 Wörtlitzer Straße 1-5
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 2970 bis 3029
Flurst. 206
Phillip-von-Ladenberg-Straße 1-6
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 2911 bis 2969
Flurst. 6/95
2 Phillip-von-Ladenberg-Straße 11-18
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 3030 bis 3110
Flurst.6/ 87
3 3 Albert-Roth-Straße 8-14
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 3111 bis 3150
Flurst. 112
4 Alte Heerstraße 218-223
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 3151 bis 3211
Flurst. 205
5 Ludwig-Bethcke-Straße 1-10
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 3511 bis 3610
Flurst. 131,132
2.2 Transferred Liabilities
In accordance with article 307 (1) in connection with article 289 (2) h) of the Law, the liabilities ("Transferred Liabi-
lities") of the Transferring Company to be transferred to the Recipient Company are exclusively the following:
- Loan agreement (Darlehensvertrag) entered into on December 11, 2012 (as further amended on February 21, 2013),
among others, by the Transferring Company, as borrower and COREALCREDIT BANK AG, a public limited company,
having its registered office at D-60322 Frankfurt, Grüneburgweg, as lender for a principal amount of EUR 91,000,000.-
(ninety one million Euros) carrying an interest of 1 month EURIBOR + spread of 2.10% per year (the "Loan Agreement").
The part of the Loan Agreement allocated to the Transferring Company amounts to EUR 9,000,000.- (nine million
Euros).
- Intercompany loan agreement entered into on March 28, 2008 by the Transferring Company, as borrower and the
Transferring Company's sole member, PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l., a Luxembourg limited liability
company, having its registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 127 199 for a principal amount of EUR 5,293,506.- (five million two
hundred ninety three thousand five hundred six Euros) carrying an interest of 5,06% per annum (the "Intercompany
Loan").
The part of the Intercompany Loan to be transferred to the Recipient Company amounts to EUR 763,853.05 (seven
hundred sixty three thousand eight hundred fifty three Euros and five Cents).
2.3 Transferred Agreement(s)
Any agreement relating to the asset and property management as well as any property lease agreement (the "Trans-
ferred Agreement(s)") to be transferred with respect to any of the Transferred Assets will be transferred to the Recipient
Company.
2.4 Remaining Assets
Any other assets of the Transferring Company not defined above as Transferred Assets shall remain with the Trans-
ferring Company ("Remaining Assets").
2.5 Remaining Liabilities
Any other liabilities of the Transferring Company not defined above as Transferred Liabilities shall remain with the
Transferring Company ("Remaining Liabilities").
3. Valuation. The Transferred Assets, after having taken into account the Transferred Liabilities, have been valuated
based on the annual accounts of the Transferring Company as of 31 December 2012 at their book value at EUR 18,290
(eighteen thousand two hundred ninety Euros).
4. Exchange ratio of the shares. As consideration for the transfer by the Transferring Company at the Date of Effect
(as defined in section 7 below) of the Transferred Assets, the Recipient Company shall issue 59 (fifty nine) new shares
for a total accounting value of EUR 18,290 (eighteen thousand two hundred ninety Euros) to the shareholder(s) of the
Transferring Company.
In accordance with article 307 (1) in connection with article 289 (2) b) of the Law, the shares to be issued by the
Recipient Company will be allotted to the shareholder(s) of the Transferring Company proportionally to their share-
holding in the Transferring Company based on the following exchange ratio:
57183
Each one (1) share in the Transferring Company (which shall be exchanged) will entitle to one (1) new share with a
nominal value of EUR 310.- (three hundred ten Euros) each in the Recipient Company.
No cash payment will be made to the shareholder(s) of the Transferring Company.
5. Delivery formalities of the shares of the Recipient Company. Following the cancellation of the shares subject to
exchange (pursuant to section 4 above) in the shareholder register of the Transferring Company, the shareholder(s) of
the Transferring Company will be registered directly as shareholder(s) in the shareholder register of the Recipient Com-
pany. The Recipient Company will not issue share certificates nor allot or deliver fractional shares.
6. Profit entitlement. The newly issued shares to be allotted by the Recipient Company to the shareholder(s) of the
Transferring Company will entitle them to the results of the Recipient Company in particular to dividends, as of the Date
of Effect (as defined in section 7 below).
7. Date of Effect of the De-Merger - Effectiveness of the De-Merger for accounting purposes. In accordance with article
307 (1) in connection with article 301 of the Law, the De-Merger will become effective between the Transferring Company
and the Recipient Company and will entail ipso iure (by law) the universal transfer of the Transferred Assets and Liability
to the Recipient Company as of the day of its approval by the general meeting of the shareholder(s) of the Transferring
Company taken no earlier than one (1) month after the publication of the De-Merger Proposal in the Memorial C ("Date
of Effect").
In accordance with article 307 (1) in connection with article 302 of the Law, the De-Merger will take effect towards
third parties as of the day of publication in the Mémorial C of the resolutions of the general meeting of the shareholder
(s) of the Transferring Company approving the De-Merger.
For accounting purposes, the De-Merger shall be deemed effective as of the Date of Effect.
As from the Date of Effect, the Transferring Company and the Recipient Company are deemed to carry out business
in their own respective names and the operations of the Transferring Company and the Recipient Company in respect
of the Transferred Assets and Transferred Liabilities are deemed to be booked in the accounts of the Recipient Company.
8. Articles of incorporation - Managers of the Recipient Company. The proposed articles of incorporation of the
Recipient Company are as follows:
Art. 1. There exists a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the name of
PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 13", (hereafter the "Company"), which will be governed by these articles of
association (the "Articles") as well as by the relevant legal dispositions.
Art. 2. The purpose of the Company is the purchase and sale of immoveable properties as well as real estate mana-
gement.
It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of
any securities of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire
by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities, to
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities, to grant to the companies,
in which it has participating interests either directly or indirectly or to the companies which are controlled by the same
persons as the Company, any support, loans, advances or guarantees.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security
for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible
notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.
The Company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The duration of the Company is unlimited.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective decision of the
shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The corporate capital is fixed at eighteen thousand two hundred ninety Euros (18,290.- EUR), divided into fifty
nine (59) shares with a par value of three hundred and ten Euros (310.- EUR) each.
All the shares have been subscribed and fully paid up.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. The share capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing
commercial companies.
57184
Art. 7. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.
Art. 8. Shares shall be freely transferable between shareholders.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-shareholders with the unanimous approval of all the
shareholders.
Art. 9. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the shareholders are allowed to pursue the sealing of
property or documents of the Company.
Art. 11. The Company is managed by a board of managers (the "Board of Managers") appointed as a collegiate body
by the general meeting of the Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The general meeting of
Shareholders determines the powers and term of the mandates of the Managers. If no term is indicated the Managers are
appointed for an undetermined period. The Managers may be revoked by the general meeting of shareholders with or
without cause (ad nutum) at any time.
The Board of Managers shall always be composed of six (6) Managers, each of whom does not reside in Germany,
three of which shall be category A Managers (the "Category A Manager") and the other three shall be Category B Managers
(the "Category B Manager"), whether shareholders or not, who are appointed by the sole shareholder or, as the case
may be, by the general meeting of shareholders.
If the post of a manager elected by the general meeting becomes vacant the remaining managers thus elected, may
provisionally fill the vacancy by applying the same rules as the ones described above.
In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 12. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the Managers present at the meeting designated
to that effect by the board.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.
Meetings of the Board of Managers are collective and may only validly take resolutions if an equal numbers of Category
A Managers and Category B Managers are present or represented; proxies between managers being permitted, with the
restrictions that a manager can only represent one of his colleagues.
Each Manager shall have one vote on all matters brought before the Board of Managers. The chairman will not have
any casting vote.
Resolutions of the Board of Managers may only validly be taken through the affirmative vote of a majority of the
Managers present or represented at a duly constituted meeting at which a quorum is present provided that, such majority
must include the affirmative vote of at least one (I) Class A Manager and one (I) Class B Manager.
The Board of Managers shall meet not less frequently than quarterly, upon not less than fifteen (15) calendar days prior
written notice (unless such prior written notice requirement is otherwise waived in writing by at least one (1) Class A
Manager and one (1) Class B Manager duly given to all Managers (provided that actions not specifically referred to in any
agenda accompanying a notice may not be taken up at the relevant meeting).
At least one (1) meeting of the Board of Managers must be held during each quarter of each Fiscal Year at the Company's
offices in Luxembourg.
Meetings of the Board of Managers may be held at the Company's registered office in Luxembourg or by conference
call, video conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the Managers attending the meeting
can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of
the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Managers can properly deliberate. Participation in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the
resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.
The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or Email confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the Ma-
nagers' meetings.
No Manager shall be entitled to any compensations or consideration for services rendered in its capacity as a Manager.
Any action or decision required or permitted to be taken at any meeting of the Board of Managers may be taken
without meeting if (i) all of the Managers consent to such action or decision in writing, and (ii) the writing or writings are
filed with the records of the company.
Art. 13. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition
in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.
All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of august
10
th
, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the Board of Managers.
57185
Art. 14. The Company will be validly bound by the joint signature of any two Managers being one (1) Class A Manager
and one (1) Class B Manager.
Art. 15. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.
The Board of Managers may further appoint such officers and/or other Company representatives as the Board of
Managers shall deem necessary or advisable. Each officer shall hold office until his resignation or removal. The Board of
Managers may elect to remove any officer with or without cause at any time.
The Board of Managers shall have the power to set up one or more committees (including an executive committee)
to which the authority to make certain decisions may be delegated by the Board of Managers. No member of a committee
may be removed without approval of the Board of Managers.
Art. 16. In the execution of their mandate, the Managers are not held personally responsible. As agents of the Company,
they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 17. Every shareholder may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number
of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
Art. 18. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by a majority of the shareholders representing
seventy five percent of the capital.
In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the
Articles, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.
Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in
written form.
Contracts concluded between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder must also
be mentioned in a protocol or be established in written form.
This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.
Art. 19. The business year begins on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
Art. 20. Every year, the annual accounts are drawn up by the Managers.
Art. 21. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 22. Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.
The balance is at the disposal of the shareholders.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions: (i) interim accounts are drawn up
by the Board of Managers; (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal
reserve; (in) the decision to pay interim dividends is taken by the General Meeting of shareholders within two (2) months
from the date of the interim accounts; (iv) the rights of the creditors of the Company; and (v) where the interim dividends
paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the
Company.
Art. 23. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need
not to be shareholder and who are appointed by the shareholders who will specify their powers and remuneration.
Art. 24. For all points not regulated by these Articles, reference is made to the provisions of the Law and its modifying
acts, concerning trading companies.
The board of managers of the Recipient Company shall be composed, for an unlimited period of time, as follows:
- Mrs. Sophie BATARDY, born on 22 January 1963, in Lille (France), residing professionally at L-2311 Luxembourg,
55-57, avenue Pasteur, as Category A Manager,
- Mr. Nico HANSEN, born on 31st March 1969, in Differdange (Grand-Duchy of Luxembourg), residing professionally
at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, as Category A Manager,
- Mr. Simon KÖNIG, bora on 13 October 1974, in Bern (Switzerland), residing at CH-8700 Künsnacht / Zurich, 39,
Seestrasse, as Category A Manager,
- GS Lux Management Services S.à r.l., a Luxembourg limited liability company, having its registered office at L-1536
Luxembourg, 2, rue du Fosse, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88 045,
as Category B Manager;
57186
- W2007 Parallel Bear S.à r.l., a Luxembourg limited liability company, having its registered office at L-1536 Luxembourg,
2, rue du Fosse, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131 044, as Category
B Manager; and
- Whitehall Bear S.à r.l., a Luxembourg limited liability company, having its registered office at L-1536 Luxembourg, 2,
rue du Fosse, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137 548, as Category B
Manager.
8. Documents available to the shareholders. In accordance with article 307 (1) in connection with article 295 of the
Law, the shareholder(s) of the Transferring Company are entitled to inspect at the registered office of the Transferring
Company the following documents at least one (1) month prior to the date of the general meeting of the shareholder(s)
convened for the purpose of deliberating on the De-Merger Proposal:
a) the De-Merger Proposal;
b) the annual accounts and the management reports of the Transferring Company for the three (3) closed financial
years before this De-Merger;
c) a report of the board of managers of the Transferring Company established in accordance with article 307 (1) in
connection with article 293 of the Law; and
d) a report of an independent expert established in accordance with article 307 (1) in connection with article 294 of
the Law.
The documents mentioned under items c) and d) will not be required and / or made available at the registered office
of the Transferring Company if all the shareholders of the Transferring Company waive this requirement as permitted
by article 307 (1) in connection with article 296 of the Law.
9. Rights of Creditors. In accordance with article 307 (1) in connection with article 297 (1) of the Law, if the De-
Merger would affect the rights of creditors of the Transferring Company (or of the Recipient Company respectively)
whose claims existed prior to the publication of the resolutions of the general meeting of the shareholders of the Trans-
ferring Company approving the De-Merger, these creditors may request from court an injunction (référé) to the
Transferring Company (or to the Recipient Company respectively) to provide adequate security interests. Creditors must
request this injunction within a period of two (2) months following the publication of the resolutions of the general
meeting of the shareholder(s) of the Transferring Company approving the De-Merger.
10. Declarations. For the purpose of article 307 (1) in connection with article 289 (2) f) of the Law, the board of
managers of the Transferring Company hereby declares that the Transferring Company has neither issued shares with
special rights, nor securities with special rights other than shares.
For the purpose of article 307 (1) in connection with article 289 (2) g) of the Law, the board of managers of the
Transferring Company hereby declares that no special remuneration or benefit shall be granted to (i) the experts (if any)
referred to in article 294 of the Law, to the extent applicable, (ii) the board of managers of the Transferring Company,
and (iii) the statutory auditor (if any) of the Transferring Company.
Signed for approval in Luxembourg on 8 May 2013.
For the board of manages of the Transferring Company
Simon König
<i>A Manager
i>GS Lux Management Services S.à r.l.
<i>B Manager
i>Marielle STIJGER / Dominique LE GAL
<i>Manager / Manageri>
[Follows the German Translation of Above Text]
Perseus Immobilien Gesellschaft 11
Société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung
55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg
HRG Luxemburg B 132.800
(die „Übertragende Gesellschaft")
Perseus Immobilien Gesellschaft 13
Société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung
55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg
(noch nicht gegründet)
(die „Übernehmende Gesellschaft")
57187
ABSPALTUNGSVORSCHLAG
Der Verwaltungsrat der Übertragenden Gesellschaft schlägt eine teilweise Abspaltung der Übertragenden Gesellschaft
ohne Auflösung der Übertragenden Gesellschaft vor, („Abspaltung"), wie dies gemäß Artikel 288 des Luxemburger Ge-
setzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften („Gesetz") in seiner geänderten Fassung zulässig ist, und zwar
vorbehaltlich (i) der Bestimmungen und Bedingungen des vorliegenden Abspaltungsvorschlags („Abspaltungsvorschlag"),
der gemäß den Artikeln 307 und 289 des Gesetzes vorbereitet wurde, (ii) der Genehmigung der ordentlichen Haupt-
versammlung der Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft und (iii) der Einhaltung anderer obligatorischer Formalitäten
aus dem Gesetz, die nachstehend genannt sind.
Die Abspaltung wird aus Folgendem bestehen: (i) der Übertragung eines Teils der Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten der Übertragenden Gesellschaft an die Übernehmende Gesellschaft, einer neuen Luxemburger Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die durch die Abspaltung unter dem Namen Perseus Immobilien Gesellschaft 13 gegründet werden
soll, und (ii) der Fortführung der Übertragenden Gesellschaft mit den nicht übertragenen Vermögenswerten und Ver-
bindlichkeiten. Die zu übertragenden Vermögenswerte umfassen die Immobilien der Übertragenden Gesellschaft in Halle
(Deutschland), wobei es sich um Gebäude, Freiflächen und Wohnungen handelt, die eingehender unter Artikel 2.1 be-
schrieben sind und deren Gesamtbruttobetrag sich auf EUR 9.782.143,05 (neun Millionen siebenhundertzweiundachtzig-
tausendeinhundertdreiundvierzig Euro und fünf Cent) beläuft.
Der Abspaltungsvorschlag wird im Amtsblatt von Luxemburg, Memorial C, mindestens einen (1) Monat vor der or-
dentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft, die über den Spaltungsvorschlag beraten
wird, veröffentlicht.
1. Rechtsform - Name - Gesellschaftssitz der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften.
1.1 Übertragende Gesellschaft
Die Übertragende Gesellschaft besteht in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht
unter dem Namen „Perseus Immobilien Gesellschaft 11". Der eingetragene Geschäftssitz der Übertragenden Gesellschaft
ist 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxem-
burg unter der Nummer B 132.800.
1.2 Übernehmende Gesellschaft
Die Übernehmende Gesellschaft (noch nicht gegründet) wird in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
nach Luxemburger Recht unter dem Namen „Perseus Immobilien Gesellschaft 13" bestehen. Der eingetragene Sitz der
Empfangenden Gesellschaft wird 55-57, Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sein.
2. Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an die Übertragende Gesellschaft.
2.1 Übertragene Vermögenswerte
Gemäß Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 289 (2) h) des Gesetzes bestehen die von der Übertragenden Ge-
sellschaft an die Empfangende Gesellschaft zu übertragenden Vermögenswerte („Übertragene Vermögenswerte") aus-
schließlich aus Folgendem:
Lage des Gebäudes
Grundbucheintragung
1 Wörtlitzer Straße 1-5
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 2970 bis 3029
Flurst. 206
2 Phillip-von-Ladenberg-Straße 1-6
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 2911 bis 2969
Flurst. 6/95
3 Phillip-von-Ladenberg-Straße 11-18
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 3030 bis 3110
Flurst. 6/87
4 Albert-Roth-Straße 8-14
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 3111 bis 3150
Flurst. 112
5 Alte Heerstraße 218-223
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 3151 bis 3211
Flurst. 205
6 6 Ludwig-Bethcke-Straße 1-10
D-06132 Halle (Saale)
Wörmlitz
Blatt 3511 bis 3610
Flurst. 131, 132
2.2 Übertragene Verbindlichkeiten
Gemäß Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 289 (2) h) des Gesetzes bestehen die von der Übertragenden Ge-
sellschaft an die Übernehmende Gesellschaft zu übertragenden Verbindlichkeiten („Übertragene Verbindlichkeiten")
ausschließlich aus Folgendem:
57188
- Darlehensvertrag vom 11. Dezember 2012 (wie weiter geändert am 21. Februar 2013, abgeschlossen u. a. durch die
Übertragende Gesellschaft als Darlehensnehmer und COREALCREDIT BANK AG, einer Aktiengesellschaft mit einge-
tragenem Sitz unter der Anschrift D-60322 Frankfurt, Grüneburgweg, als Darlehensgeber über einen Gesamtbetrag von
EUR 91 000 000,- (einundneunzig Millionen Euro) mit einer Zinsrate von 1 Monat EURIBOR + Zins-Spread von 2,10%
pro Jahr („Darlehensvertrag").
Der Anteil der Darlehensvertrag, der der Übertragenden Gesellschaft zugewiesen ist, beläuft sich auf EUR 9 000 000,-
(neun Millionen Euro).
- Gesellschaftsinterne Darlehensvereinbarung, abgeschlossen am 28. März 2008 von der Übertragenden Gesellschaft
als Darlehensnehmer und dem alleinigen Mitglied der Übertragenden Gesellschaft, PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT
S.à r.l., einer Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz unter der Anschrift L-2311 Luxemburg, 55-57,
avenue Pasteur, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 127 199, über einen Gesamtbetrag
von EUR 5 293 506,-(fünf Millionen zweihundertdreiundneunzigtausendfünfhundertsechs Euro) zu einem Zinssatz von
5,06 % pro Jahr („Konzerninternes Darlehen"). Der Anteil des Konzerninternen Darlehens, der an die Übernehmende
Gesellschaft zu übertragen ist, beträgt EUR 763 853,05 (siebenhundertdreiundsechzigtausendachthundertdreiundfunfzig
Euro und 5 Cent).
2.3 Übertragene Vereinbarungen
Alle im Hinblick auf die Übertragenen Vermögenswerte zu übertragenden Vereinbarungen in Verbindung mit dem
Asset- und Property-Management sowie Immobilienmietverträge („Übertragene Vereinbarungen") werden an die Über-
nehmende Gesellschaft übertragen.
2.4 Verbleibende Vermögenswerte
Alle anderen Vermögenswerte der Übertragenden Gesellschaft, die oben nicht als Übertragene Vermögenswerte
definiert sind, bleiben bei der Übertragenden Gesellschaft („Verbleibende Vermögenswerte").
2.5 Verbleibende Verbindlichkeiten
Alle anderen Verbindlichkeiten der Übertragenden Gesellschaft, die oben nicht als Übertragene Verbindlichkeiten
definiert sind, bleiben bei der Übertragenden Gesellschaft („Verbleibende Verbindlichkeiten").
3. Bewertung. Die Übertragenen Vermögenswerte wurden nach Berücksichtigung der Übertragenen Verbindlichkeiten
auf der Grundlage des Jahresabschlusses der Übertragenden Gesellschaft zum 31. Dezember 2012 zu ihrem Buchwert
mit EUR 18.290 (achtzehntausendzweihundertneunzig Euro) bewertet.
4. Umtauschverhältnis der Aktien. Als Gegenleistung für die Übertragung der Übertragenen Vermögenswerte durch
die Übertragende Gesellschaft am Datum des Inkrafttretens (wie in Punkt 7 unten definiert) gibt die Übernehmende
Gesellschaft 59 (neunundfünfzig) neue Aktien zu einem Gesamtbuchwert von EUR 18.290 (achtzehntausendzweihun-
dertneunzig Euro) an die Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft aus.
Gemäß Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 289 (2) b) des Gesetzes werden die von der Übernehmenden Ge-
sellschaft auszugebenden Aktien den Aktionären der Übertragenden Gesellschaft proportional zu ihren Aktienanteilen
an der Übertragenden Gesellschaft auf Grundlage des folgenden Umtauschverhältnisses zugeteilt:
Jede einzelne (1) Aktie der Übertragenden Gesellschaft (die umgetauscht wird) verleiht Anspruch auf eine (1) neue
Aktie zu einem Nennwert von EUR 310,-(dreihundertzehn Euro) der Empfangenden Gesellschaft.
Die Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft erhalten keine Barzahlungen.
5. Ausgabeformalitäten für die Aktien der Übernehmenden Gesellschaft. Nach der Annullierung der Aktien, die (gemäß
Punkt 4 oben) getauscht werden, im Aktienregister der Übertragenden Gesellschaft werden die Aktionäre der Übertra-
genden Gesellschaft direkt als Aktionäre im Aktienregister der Übernehmenden Gesellschaft registriert. Die Überneh-
mende Gesellschaft gibt keine Aktienzertifikate aus, und sie tätigt auch keine Zuweisung oder Ausgabe von Teilaktien.
6. Gewinnberechtigung. Die neu ausgegebenen Aktien, die von der Übernehmenden Gesellschaft den Aktionären der
Übertragenden Gesellschaft zuzuteilen sind, verleihen diesen einen Anspruch an den Ergebnissen der Übernehmenden
Gesellschaft und insbesondere auf Dividenden (wie unter Punkt 7 unten definiert).
7. Datum des Inkrafttretens der Abspaltung - Wirksamkeit der Abspaltung für Rechnungslegungszwecke. Gemäß Ar-
tikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 301 des Gesetzes tritt die Abspaltung zwischen der Übertragenden Gesellschaft
und der Übernehmenden Gesellschaft mit Folge ipso jure (per Gesetz) der Übertragung im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge der Übertragenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an die Übernehmende Gesellschaft am Tag ihrer
Genehmigung durch die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft in Kraft, die erst
einen (1) Monat nach der Veröffentlichung des Abspaltungsvorschlags in Memorial C erteilt werden darf („Datum des
Inkrafttretens").
Gemäß Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 302 des Gesetzes wird die Abspaltung gegenüber Dritten an dem
Tag wirksam, an dem die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft
zur Genehmigung der Abspaltung im Memorial C veröffentlicht werden.
Für Rechnungslegungszwecke gilt die Abspaltung ab dem Datum des Inkrafttretens als wirksam.
57189
Ab dem Datum des Inkrafttretens werden die Übertragende Gesellschaft und die Übernehmende Gesellschaft als
Gesellschaften angesehen, die ihren Geschäften unter ihrem jeweiligen eigenen Namen nachgehen, und die Transaktionen
der Übertragenden Gesellschaft und der Übernehmenden Gesellschaft bezüglich der Übertragenen Vermögenswerte und
der Übertragenen Verbindlichkeiten gelten als in den Büchern der Übernehmenden Gesellschaft verbucht.
8. Statuten - Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft. Die vorgeschlagenen Statuten der Übernehmenden
Gesellschaft lauten wie folgt:
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PERSEUS IMMOBILIEN GE-
SELLSCHAFT 13" („die Gesellschaft"), welche der vorliegenden Satzung sowie den relevanten Gesetzesbestimmungen
unterliegt.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien.
Die Gesellschaft kann ihre Gelder zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jegli-
chen Sicherheiten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum
Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten, deren
Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen,
Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist oder an Unter-
nehmen, die von denselben Personen kontrolliert werden wie die Gesellschaft, verwenden.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente, sowie nicht verzinsliche PEC,
CPEC, Wertpapiere, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheine und andere Wertpapiere ausgeben.
Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, und jede Art finanzieller Operationen, die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg). Er kann auf Grund eines Beschlusses
der Gesellschafter, welcher nach den Bestimmungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden
anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats
verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch
im Ausland haben.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt achtzehntausend zwei hundert neunzig Euro (18.290,- EUR), eingeteilt in neun-
undfünfzig (59) Anteile mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR).
Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt.
Jedes verfügbare Agio wird ausgeschüttet.
Art. 6. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesetzes
vom 10. August 1915 festgelegt ist.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen
sowie am Gewinn.
Art. 8. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter,
bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.
Art. 9. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit
eines Gesellschafters.
Art. 10. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in keinem Falle erlaubt, solche Gesellschaftsgüter und
Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft ein-
schränken könnten.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat („der Verwaltungsrat") geleitet, welcher als Kollegialgre-
mium durch die Gesellschafterhauptversammlung gemäß den weiter unten beschriebenen Bestimmungen ernannt wird.
Die Gesellschafterhauptversammlung bestimmt die Befugnisse, sowie die Mandatsdauer der Geschäftsführer. Wird keine
Dauer angegeben, werden die Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt. Die Geschäftsführer können jeder-
zeit durch die Hauptversammlung der Aktionäre mit oder ohne Angabe von Gründen (ad nutum) entlassen werden.
Der Verwaltungsrat besteht immer aus sechs (6) Geschäftsführern, wovon keiner in Deutschland wohnt, drei sind
Geschäftsführer der Kategorie A (die „Kategorie A Geschäftsführer"), die drei anderen Geschäftsführer der Kategorie B
57190
(„die Kategorie B Geschäftsführer") Diese müssen keine Gesellschafter sein und können entweder vom einzigen Gesell-
schafter oder von der Allgemeinen Gesellschafterversammlung ernannt werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Geschäftsführers frei, können die verbleibenden Ver-
waltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen, jedoch unter Berücksichtigung der oben aufgeführten
Regeln. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.
Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die gleiche Anzahl von Kategorie A Geschäftsführern, sowie Kategorie
B Geschäftsführern anwesend, oder vertreten ist; Vollmachten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein
Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Jeder Geschäftsführer hat eine Stimme für sämtliche Angelegenheiten, welche dem Verwaltungsrat vorgelegt werden.
Die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden entscheidet bei Stimmengleichheit.
Entscheidungen des Verwaltungsrats können nur per Mehrheitsentscheid getroffen werden. Dazu muss die Mehrheit
seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Vollmachten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein
Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Eine solche Mehrheitsentscheidung muss die Stimme
mindestens eines Kategorie A Geschäftsführers, sowie eines Kategorie B Geschäftsführers enthalten.
Der Verwaltungsrat kommt mindestens einmal pro Quartal zusammen, mit einer schriftlichen Mitteilungsfrist, welche
mindestens fünfzehn (15) Tage beträgt (es sei denn, dass eine solche Benachrichtigungsfrist entfällt, durch schriftlichen
Mitteilung mindestens einem (1) Kategorie B Geschäftsführer und mindestens einem (1) Kategorie B Geschäftsführer,
vorausgesetzt, dass Aktionen, welche der Mitteilung explizit als Agenda beigefügt sind, nicht von der entsprechenden
Verwaltungsratssitzung diskutiert werden dürfen. Mindestens eine (1) Verwaltungsratsitzung muss in jedem Quartal eines
jeden Steuerjahrs in den Räumlichkeiten der Gesellschaft in Luxemburg stattfinden.
Verwaltungsratsitzungen können in den Räumlichkeiten der Gesellschaft in Luxemburg per Telefon- oder Videokon-
ferenz, oder ähnlichen Kommunikationsmitteln stattfinden, wobei (i) die, an der Konferenz teilnehmenden Geschäftsfüh-
rer identifizierbar sind, (ii) sämtliche, an der Konferenz teilnehmenden Personen in der Lage sind, sich gegenseitig zu
hören und miteinander zu sprechen, (iii) die Übertragung der Sitzung darf nicht unterbrochen werden (ongoing basis),
sowie (iv) sämtliche Teilnehmer in angemessener Weise verhandeln können.
Teilnahme an einer solchen Konferenz gilt als persönliche Anwesenheit an einer solchen Sitzung. Wird ein Beschluss
während einer solchen Konferenz getroffen, gilt dieser Beschluss als in Luxemburg getroffen, falls die Konferenz von
Luxemburg ausgegangen ist.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder E-Mail abgeben, welche
schriftlich bestätigt werden müssen.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Kein Verwaltungsratsmitglied ist ermächtigt, Entschädigungen oder andere Entgelte für, in seiner Funktion als Ge-
schäftsführer geleistete Dienste zu erhalten.
Jeder Beschluss oder Aktion, welche während einer Vorstandsitzung gefällt werden darf oder muss, kann ohne Zu-
sammentreten der Verwaltungsrats getroffen werden, wenn (i) sämtliche Geschäftsführer ihr Einverständnis hierzu
schriftlich mitteilen, und (ii) diese schriftlichen Einverständniserklärungen in den Archiven der Gesellschaft aufbewahrt
werden.
Art. 13. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, sämtliche Ange-
legenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915 („das Gesetz"), sowie durch die späteren Ände-
rungen, oder durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeits-
bereich des Verwaltungsrates.
Art. 14. Die Gesellschaft ist durch die Kollektivunterschrift zweier (2) Geschäftsführer, wovon einer (1) der Kategorie
A, sowie einer (1) der Kategorie B zugehören muss, gebunden.
Art. 15. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Gesellschafter zu sein brau-
chen, die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.
Der Verwaltungsrat ist des Weiteren ermächtigt, Führungskräfte und/oder andere Vertreter der Gesellschaft zu be-
stellen, falls der Verwaltungsrat dies als notwendig oder ratsam betrachtet. Jede so ernannte Kraft bekleidet ihr Amt bis
sie kündigt oder abgerufen wird. Der Verwaltungsrat kann jederzeit, ohne Angabe von Gründen. Eine solche Kraft er-
nennen oder beurlauben.
Der Verwaltungsrat ist befugt, einen oder mehrere Ausschüsse (einschließlich eines geschäftsführenden Ausschusses)
einzusetzen, sowie diesen zu befugen, gewisse Entscheidungen zu treffen. Kein Mitglied eines solchen Ausschusses darf
ohne die Zustimmung des Verwaltungsrats abberufen werden.
57191
Art. 16. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner
Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Art. 18. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Gesellschafter angenommen wurden.
Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung betreffen, werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche
mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.
Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.
Beschlüsse, welche, aufgrund dieser Befugnisse durch den einzigen Gesellschafter getroffen werden, müssen in einem
Protokoll verzeichnet oder in schriftlicher Form festgehalten werden.
Desgleichen müssen Verträge, welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft geschlossen wur-
den, in einem Protokoll verzeichnet oder in schriftlicher Form festgehalten werden.
Diese Bestimmung ist nicht für, unter normalen Bedingungen ausgeführte laufende Geschäfte anwendbar.
Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 20. Jedes Jahr wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.
Art. 21. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 22. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage
zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Zwischendividenden (Interim dividends) können jederzeit unter Berücksichtigung folgender Vorschriften ausgeschüttet
werden: (i) eine Zwischenbilanz (interim account) wird vom Verwaltungsrat aufgesetzt; (ii) die Zwischenbilanz zeigt, dass
genügend Profit und andere Reserven (inklusive Aktienprämien) zur Ausschüttung vorhanden sind; allerdings sollte der
auszuzahlende Betrag, den Profit, welcher seit Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres, von welchem die Bilanz von
der Gesellschafterhauptversammlung angenommen wurde nicht übertreffen, erhöht durch, vom letzten Geschäftsjahr
übernommene Gewinne, sowie ausschüttbare Reserven, abzüglich Verlustvorträge (carried forward losses) und Summen,
welche in legale Reserven einzutragen sind; (iii) die Entscheidung, solche Zwischendividenden auszuschütten, wird von
der Gesellschafterhauptversammlung innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum der Einrichtung der Zwischenkonten
getroffen; (iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind nicht beeinträchtigt, wenn die Vermögenswerte der Ge-
sellschaft in Betracht gezogen werden; sowie (v) im Falle
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein
Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung
festlegen.
Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften, verwiesen.
Der Verwaltungsrat der Übernehmenden Gesellschaft wird sich auf unbestimmte Zeit wie folgt zusammensetzen:
- Frau Sophie BATARDY, geb. am 22. January 1963 in Lille (Frankreich) mit professioneller Adresse unter der Anschrift
L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, als Kategorie A Geschäftsführer,
- Herr Nico HANSEN, geb. am 31. März 1969 in Differdange (Großherzogtum Luxemburg) mit professioneller Ad-
resseunter der Anschrift L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, als Kategorie A Geschäftsführer,
- Herr Simon KÖNIG, geb. am 13. October 1974 in Bern (Switzerland) mit [professioneller] Adresse unter der An-
schrift CH-8700 Küsnacht/Zürich, Seestrasse 39, als Kategorie A Geschäftsführer,
- GS Lux Management Services S.à r.l., eine Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem
Sitz unter der Anschrift L-1536 Luxemburg, 2, rue du Fossé, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der
Nummer B 88 045, als Kategorie B Geschäftsführer,
- W2007 Parallel Bear S.à r.l., eine Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz unter
der Anschrift L-1536 Luxemburg, 2, rue du Fossé, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B
131 044, als Kategorie B Geschäftsführer, und
- Whitehall Bear S.à r.l., eine Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz unter der
Anschrift L-1536 Luxemburg, 2, rue du Fossé, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 137
548, als Kategorie B Geschäftsführer.
8. Den Aktionären zur Verfügung stehende Dokumente. Gemäß Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 295 des
Gesetzes sind die Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft berechtigt, die nachstehend genannten Dokumente am
eingetragenen Sitz der Übertragenden Gesellschaft mindestens einen (1) Monat vor dem Datum der ordentlichen Haupt-
versammlung der Aktionäre, die zwecks der Beratung über den Abspaltungsvorschlag einberufen wurde, zu prüfen:
57192
a) Abspaltungsvorschlag,
b) Jahresabschlüsse und Managementberichte der Übertragenden Gesellschaft für die drei (3) abgeschlossenen Ge-
schäftsjahre vor dieser Spaltung,
c) einen Bericht des Vorstands der Übertragenden Gesellschaft, der gemäß Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel
293 des Gesetzes erstellt wurde, und
d) einen Bericht eines unabhängigen Sachverständigen, der gemäß Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 294 des
Gesetzes erstellt wurde.
Die unter c) und d) genannten Dokumente sind nicht erforderlich und/oder werden nicht am eingetragenen Sitz der
Übertragenden Gesellschaft zur Verfügung gestellt, wenn alle Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft auf diese An-
forderung verzichten, wie dies gemäß Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 296 des Gesetzes zulässig ist.
9. Rechte der Gläubiger. Gemäß Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 297 (1) des Gesetzes gilt Folgendes: Sollte
sich die Abspaltung auf Rechte von Gläubigern der Übertragenden Gesellschaft (oder der Übernehmenden Gesellschaft)
auswirken, deren Ansprüche bereits vor der Veröffentlichung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der
Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft zur Genehmigung der Abspaltung bestanden, können diese Gläubiger bei
Gericht eine Anordnung beantragen, nach welcher die Übertragende Gesellschaft (oder die Übernehmende Gesellschaft)
angemessene Sicherheiten bieten muss. Gläubiger müssen diese Anordnung innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Mo-
naten nach der Veröffentlichung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Übertragenden
Gesellschaft zur Genehmigung der Abspaltung beantragen.
10. Erklärungen. Im Sinne von Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 289 (2) f) des Gesetzes erklärt der Vorstand
der Übertragenden Gesellschaft hiermit, dass die Übertragende Gesellschaft neben Aktien weder Aktien mit Sonder-
rechten noch Wertpapiere mit Sonderechten ausgegeben hat.
Im Sinne von Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 289 (2) g) des Gesetzes erklärt der Vorstand der Übertragenden
Gesellschaft hiermit, dass (i) in Artikel 294 des Gesetzes genannten Sachverständigen (gegebenenfalls), sofern anwendbar,
(ii) dem Vorstand der Übertragenden Gesellschaft und (iii) dem Abschlussprüfer (gegebenenfalls) der Übertragenden
Gesellschaft keine besonderen Vergütungen oder Vorteile gewährt werden.
Zur Genehmigung unterzeichnet in Luxemburg am 8 Mai 2013.
<i>Für den Vorstand der Übertragenden Gesellschaft
i>Simon König
<i>A Manager
i>GS Lux Management Services S.à r.l.
<i>B Manager
i>Marielle STIJGER / Dominique LE GAL
<i>Manager / Manageri>
[Follows the German Translation of Above Text/Nachstehend die deutsche Übersetzung des obigen Textes]
Référence de publication: 2013064068/622.
(130078761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2013.
Truc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 103.601.
EXTRAIT
Il résulte du Conseil d'administration de la société TRUC S.A. qui s'est tenue extraordinairement en date du 20 mars
2013 au siège social que:
Monsieur Gary Dennis avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal; L-2449 Luxembourg a été nommé admi-
nistrateur de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016 en remplacement de
Monsieur Sven HEUERTZ démissionnaire avec effet au 31 décembre 2012.
Monsieur Anton Baturin avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal; L-2449 Luxembourg a été nommé ad-
ministrateur de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016 en remplacement de
Mademoiselle Cindy Reiners démissionnaire avec effet au 20 mars 2013.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Référence de publication: 2013045317/19.
(130054784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.
57193
Öhman Fund, Fonds Commun de Placement.
The liquidation of Öhman Fund (the "Fund") has been closed with effect from 3 June 2010 by decision of the Mana-
gement Company acting as liquidator of the Fund.
The Management Company has approved the liquidation report in relation to the liquidation of the Fund.
All liquidation proceeds have been distributed to the unitholders of the Fund.
The corporate documents of the Fund will be retained for a period of five years at the registered office of the Mana-
gement Company.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013065129/6275/11.
VCM Golding Mezzanine SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 102.202.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 16. Mai 2013.
Référence de publication: 2013063524/10.
(130078067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
VCM Golding Mezzanine Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 110.495.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 16. Mai 2013.
Référence de publication: 2013063526/10.
(130078068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Quadrum S.A., Société Anonyme,
(anc. Bizvalue S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 152.827.
L'an deux mille treize, le vingt-six avril;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxem-
bourg "BIZVALUE S.A.", établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 152827 (la "Société"), constituée suivant acte
reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1020 du 15 mai 2011,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Martine SCHAEFFER:
- en date du 23 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 83 du 15 janvier
2011; et
- en date du 8 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1366 du 22 juin 2011.
L'assemblée est présidée par Madame Alexia UHL, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling.
La Présidente désigne Madame Anne-Laure ADAM, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling, comme secrétaire.
L'assemblée choisit Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling, comme scrutateur.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
57194
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de la dénomination sociale en "QUADRUM S.A." et modification afférente de la première phrase de
l'article 1
er
des statuts;
2. Modification de l'objet social afin de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:
« Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".
La Société peut tenir des actions et des intérêts dans une société en commandite par actions luxembourgeoise qui
sera constituée sous la dénomination de QUADRUM SICAV FIS S.C.A. et peut agir comme actionnaire commandité de
cette société.
La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter,
ainsi que procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immo-
biliers, terrains à bâtir y compris."
3. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en "QUADRUM S.A." et de modifier subséquemment la pre-
mière phrase de l'article 1
er
des statuts comme suit:
" Art. 1
er
. (premier alinéa). Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "QUADRUM S.A."."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 2 des statuts la teneur comme
ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 2).
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la Présidente ajourne l'assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. UHL, A-L. ADAM, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2013. LAC/2013/19865. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 13 mai 2013.
Référence de publication: 2013062857/76.
(130077548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
57195
VCM Golding Mezzanine Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 110.495.
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 24. April 2013:i>
Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversamm-
lung des Jahres 2017 enden:
- Markus Gierke, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Ekkehart Kessel, Verwaltungsratsmitglied
- Silvan Trachsler, Verwaltungsratsmitglied
PricewaterhouseCoopers Société coopérative mit Sitz in 400, route d’Esch, L-1014 Luxemburg wurde als Abschluss-
prüfer der Gesellschaft bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2014 bestellt.
Munsbach, den 24. April 2013.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Référence de publication: 2013063525/17.
(130078066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
beta3 dynamic, Fonds Commun de Placement.
AUFLÖSUNG
Gemäß Beschluss des Vorstandes der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. wurde das Sondervermögen
am 8. Mai 2013 aufgelöst. Das Liquidationsverfahren wurde vollständig abgeschlossen. Alle Gelder konnten ausgezahlt
werden. Eine Hinterlegung bei der Caisse de Consignation war daher nicht notwendig.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Receuil des Sociétés et associations.
Luxemburg, im Mai 2013.
<i>Für den Vorstand der Verwaltungsgesellschafti> .
Référence de publication: 2013065130/1346/10.
AviaRent S.C.A. SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 148.416.
Im Jahre zweitausendunddreizehn, am neunzehnten Tag des Monats April.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxembourg,
fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Avia Rent S.C.A., SICAV-FIS (die "Gesellschaft") statt, einer In-
vestmentgesellschaft mit variablem Kapital, mit Gesellschaftssitz in 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg, gegründet
gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Decker, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, am 18. Sep-
tember 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), Nummer 1259 vom
1. Juli 2009.
Die außerordentliche Hauptversammlung wurde eröffnet durch die Vorsitzende, Frau Christina Breit, Angestellte,
beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende wählt Frau Stefanie Faber, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg, zur Schriftführerin und
Stimmzählerin.
Da das Büro der außerordentlichen Hauptversammlung nun vollständig zusammengestellt ist, erklärt und bittet die
Vorsitzende den Notar folgendes zu beurkunden:
I.- Da alle Aktien Namensaktien sind, wurde gegenwärtige Versammlung einberufen durch Einladungen welche an alle
Aktionäre am 4. April 2013 per Einschreiben versandt wurden.
II. Die Agenda der außerordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt:
<i>Agenda:i>
1. Änderung von Artikel 3 der Satzung
2. Änderung von Artikel 10 der Satzung
3. Änderung des ersten Absatzes von Artikel 12 der Satzung
4. Änderung des zweiten Absatzes von Artikel 12 der Satzung
5. Ergänzung von Artikel 21 am Ende des Artikels
57196
6. Änderung von Artikel 26 der Satzung
7. Änderung der Überschrift von Artikel 27 der Satzung
8. Änderung von Artikel 27 der Satzung
III. Die anwesenden oder vertretenen Anteilseigner und die Anzahl der von jedem von ihnen gehaltenen Anteile sind
in der Anwesenheitsliste aufgeführt, die (i) von den anwesenden Anteilseignern, (ii) von den Bevollmächtigten der ver-
tretenen Anteilseigner und (iii) den Mitgliedern des Büros unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste sowie die Voll-
machten, die von den Mitgliedern des Büros als „ne varieteur" gekennzeichnet wurden, werden diesem Dokument
beigefügt, um mit ihm einregistriert zu werden.
IV. In Anlehnung an das Gesetz vom 10. August 1915 werden die Beschlüsse im Rahmen dieser außerordentlichen
Hauptversammlung gültig getroffen, sofern ein Anwesenheitsquorum von fünfzig Prozent des Kapitals erreicht ist und
eine Zustimmungsmehrheit von mindestens Zwei-Dritteln der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gegeben ist.
V. Gemäß der Anwesenheitsliste sind 98.531,000 Aktien von den insgesamt 118.311,000 Aktien anwesend oder ver-
treten.
Es werden die folgenden Beschlüsse gefasst, wobei 98.281,000 Aktien zustimmen und 250,00 Aktien sich enthalten:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, Artikel 3 der Satzung wie folgt abzuändern:
„Die Gesellschaft beginnt mit der notariellen Beurkundung dieser Satzung und ist für unbestimmte Zeit errichtet. Die
Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Kon-
kurs oder einem vergleichbaren Ereignis hinsichtlich eines oder mehrerer Aktionäre, aufgelöst."
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, Artikel 10 der Satzung wie folgt abzuändern:
„Aktien der Gesellschaft sind sachkundigen Anlegern im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2007 vorbehalten, also
institutionellen oder professionellen Anlegern sowie - vorbehaltlich des nachfolgenden Satzes - sonstigen Anlegern, die
jeweils schriftlich ihren Status als sachkundige Anleger erklären und (i) eine Mindestanlage in Höhe von EUR 125.000,-
tätigen oder (ii) über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, einer Investment-
gesellschaft im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG
verfügen, die ihnen bescheinigt, den Sachverstand, die Erfahrung und Kenntnisse zu besitzen, um auf angemessene Weise
eine Anlage in der Gesellschaft bzw. dem betreffenden Compartment der Gesellschaft einschätzen zu können. Dabei sind
nur nicht-natürliche Personen, deren Zahl auf nicht mehr als 100 (einhundert) begrenzt ist, als Anleger zugelassen. Des
weiteren kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz ihrer Aktien durch bestimmte Anleger einschränken
oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solche Besitz:
zu Lasten der Interessen der übrigen Aktieninhaber oder der Gesellschaft geht; oder
einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird;
oder
den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.
Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:
die Ausgabe der Aktien verweigern, wenn es offenkundig ist, dass diese Ausgabe zur Folge haben würde, den Aktien-
besitz auf eine andere Person zu übertragen, die nicht berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen,
den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer Person, der es nicht erlaubt ist, Aktien
der Gesellschaft zu besitzen (wie etwa Personen, welche keine sachkundigen Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007
darstellen), entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,
den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer oder mehreren Personen zu einem
solchen Anteil gehalten werden, der die Anwendbarkeit der Steuergesetze oder sonstige Gesetze anderer Länder als
Luxemburg zur Folge hat,
bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimmrecht
aberkennen.
In den Fällen b) und c) wird folgendes Verfahren angewandt:
Die Gesellschaft wird dem Aktionär, der die Aktien besitzt, eine Benachrichtigung (im Folgenden "Rückkaufsbena-
chrichtigung" genannt) zusenden.
Die Rückkaufsbenachrichtigung gibt die zurückzukaufenden Aktien, den zu bezahlenden Rückkaufpreis und den Ort,
wo dieser Preis zu bezahlen ist, an. Die Rückkaufbenachrichtigung kann dem Aktionär als Einschreibebrief an seine be-
nannte Versandadresse oder an die im Aktienregister eingetragene Adresse zugesandt werden. Der betroffene Aktionär
ist verpflichtet, der Gesellschaft ohne Verzögerung das oder die Zertifikate zurückzugeben, die die in der Rückkaufsbe-
nachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern. Mit Büroschluss des in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Tages
57197
ist der Aktionär nicht mehr Besitzer der in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien. Die Aktienzertifikate, die
die entsprechenden Aktien verkörpern, werden annulliert.
Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden (im folgenden
"Rückkaufspreis" genannt), entspricht dem Nettovermögenswert der ausgegebenen Aktien, so wie dieser am Tag der
Rückkaufsbenachrichtigung gemäß Artikel 13 der vorliegenden Satzung festgesetzt wird.
Der Rückkaufpreis wird dem Besitzer dieser Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo
ansässigen Bank, welche in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Rückkauf-
preis den betroffenen Aktionär gegen Rückgabe der eventuell ausgegeben Aktienzertifikate, die die in der Rückkaufsbe-
nachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern, auszahlen. Nach Hinterlegung des Rückkaufpreises gemäß diesen
Bedingungen, können Personen, die an den in der Rückkaufsbenachrichtigung Aktien interessiert sind, keine Ansprüche
auf diese Aktien geltend machen oder rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft unternehmen. Hiervon ausgenommen
ist das Recht des sich als rechtmäßiger Besitzer der Aktien ausweisenden Aktionärs, den hinterlegten Rückkaufpreis gegen
Rückgabe des oder der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, wie zuvor erläutert, ausgezahlt zu bekommen.
Unter der Bedingung, dass die Gesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestandenen
Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Besitz sich die Aktien befinden."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, den ersten Absatz von Artikel 12 der Satzung wie folgt abzuändern:
"Jeder Aktionär hat das Recht, innerhalb von sechs Monaten ab Zugang einer entsprechenden Erklärung beim Kom-
plementär die Rücknahme von Aktien und die Auszahlung des jeweiligen Nettovermögenswerts der betreffenden Aktien
am Tag der Rücknahme zu verlangen. Klarstellend wird festgelegt, dass der Regelungsgehalt wie in § 80c Abs. 2 bis 4 des
Investmentgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (das „InvG") enthalten nicht, auch nicht entsprechend, gilt. Die
Gesellschaft hält Liquidität von mindestens EUR 500.000,- bis maximal EUR 5.000.000,- vor. Im Falle von Rücknahmen
von Aktien kann dieser Betrag zweckentsprechend erhöht werden. Liquide Mittel der Compartments werden nur in
Vermögensgegenstände im Sinne von § 80 Abs.1 S.1 Nr. 1-5 InvG investiert. Der Gesamtbetrag darf - unter entspre-
chender Berücksichtigung des Regelungsgehalts von § 80 Abs. 2 InvG - höchstens 49% des Nettovermögenswertes eines
Compartments betragen."
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, den zweiten Absatz von Artikel 12 der Satzung wie folgt abzuändern:
„Der Komplementär kann ausnahmsweise eine zwangsweise Rücknahme der Aktien eines Aktionärs beschließen, wenn
er der Ansicht ist, dass (i) der Besitz von Aktien des betreffenden Aktionär zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionär
oder der Gesellschaft geht oder (ii) einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich
ziehen kann (wie z.B., dass es sich bei dem betreffenden Aktionär nicht um einen sachkundigen Anleger handelt) oder (Iii)
bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird
oder (iv) den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet."
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, Artikel 21 der Satzung am Ende des Artikels um die folgende Formulierung zu ergänzen:
"Der Komplementär kann jederzeit eine Generalversammlung eines oder mehrerer spezifischer Compartments ein-
berufen, um über ein bestimmtes Thema zu entscheiden, welches ausschließlich im Zusammenhang mit diesem/diesen
Compartment/s steht.
Die gesetzlichen Bestimmungen und die Regelungen dieser Satzung, die für Generalversammlungen der Gesellschaft
gelten, sind, soweit möglich, mutatis mutandis auf die Generalversammlungen der Aktionäre eines oder mehrerer bes-
timmten/er Compartment/s anwendbar."
<i>Sechster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, Artikel 26 der Satzung wie folgt abzuändern:
"Die Gesellschaft kann gemäß den Bestimmungen der Satzung zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung
und vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse, wie sie für Satzungsänderungen gemäß dem Gesetz von
1915 gelten, aufgelöst werden. Der Fonds wird auch bei Auflösung des letzten existierenden Teilfonds aufgelöst.
Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des in Artikel 7 aufgeführten Mindestkapitals fällt, wird die Frage
der Auflösung der Gesellschaft durch den Komplementär der Generalversammlung vorgetragen. Die Generalversamm-
lung entscheidet ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der bei dieser Versammlung vertretenen
Aktionäre.
Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird der Generalversammlung durch den Komplementär auch dann unter-
breitet, wenn das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestkapitals gemäß Artikel 7 fällt. In diesem Falle wird
die Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum beschliessen, und die Auflösung kann durch die Aktionäre ent-
schieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktionäre halten.
57198
Die Versammlung muss innerhalb einer Frist von 40 Tagen nach Feststellung, dass das Mindestgesellschaftskapital
unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Mindestkapitals gefallen ist, einberufen werden.
Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen
sein können und die ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Generalversammlung ernannt
werden müssen. Letztere beschließt auch über die Befugnisse und eventuelle Vergütung der Liquidatoren.
Der Netto-Liquidationserlös der Gesellschaft wird von den Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem
Aktienbesitz an der Gesellschaft verteilt."
<i>Siebter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, die Überschrift von Artikel 27 der Satzung wie folgt abzuändern:
„ Art. 27. Laufzeit, Auflösung und Verschmelzung von Compartments".
<i>Achter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, Artikel 27 der Satzung wie folgt abzuändern:
„Compartments können auf unbestimmte Zeit oder für einen festgelegten Zeitraum aufgelegt werden. Dieses wird im
Verkaufsprospekt, insbesondere unter den spezifischen Aspekten für das jeweilige Compartment, festgelegt.
Sollte für ein Compartment eine Laufzeit (festgelegter Zeitraum) bestimmt sein, so wird dieses nach Beendigung der
Laufzeit automatisch aufgelöst, es sei denn, dass die Generalversammlung der Aktionäre dieses Compartments zuvor,
unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Nettovermögenswertes des betreffenden
Compartments und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, die Laufzeit dieses Com-
partments verlängert hat. Die Laufzeit eines Compartments kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Falls
das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Generalversammlung des betreffenden Compartments nicht er-
reicht werden sollte, kann im Rahmen einer zweiten Generalversammlung des betreffenden Compartments ohne
Einhaltung eines Anwesenheitsquorums über die Verlängerung der Laufzeit dieses Compartments entschieden werden.
Nach Beendigung der Laufzeitverlängerung wird das betreffende Compartment automatisch aufgelöst.
Der Komplementär kann beschliessen, ein oder mehrere Compartments zusammenzulegen, oder einen oder mehrere
Compartments aufzulösen, indem die betroffenen Aktien entwertet werden und den betroffenen Aktionären der Net-
tovermögenswert der Aktien dieses oder dieser Compartments zurückerstattet wird. Der Komplementär kann ebenfalls
beschliessen, einen oder mehrere Compartments mit einem anderen luxemburgischen spezialisierten Investmentfonds
oder Organismus für gemeinsame Anlagen zu verschmelzen.
Der Komplementär ist befugt, einen der vorgenannten Beschlüsse zu fassen
- im Falle einer wesentlichen Änderung der sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Lage in den Ländern, in denen
Anlagen für das jeweilige Compartment getätigt werden oder in denen die Aktien dieses Compartments vertrieben
werden, oder
- sofern der Wert der Vermögenswerte des jeweiligen Compartments derart fällt, dass eine wirtschaftlich effiziente
Verwaltung dieses Compartments nicht mehr gewährleistet werden kann, oder
- im Rahmen einer Rationalisierung.
Der Liquidationserlös, der von einem Aktionär nach Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurde, verbleibt für
einen Zeitraum von sechs Monaten bei der Depotbank und wird anschliessend bei der Caisse des Consignations in
Luxemburg hinterlegt; nach 30 Jahren verfällt der Liquidationserlös. Jedes Compartment kann separat und ohne Beein-
trächtigung eines anderen Compartments aufgelöst werden. Die Auflösung des letzten bzw. einzigen Compartments führt
ipso iure zur Liquidation der Gesellschaft.
Der Beschluss des Komplementärs, die Verschmelzung eines oder mehrerer Compartments mit einem oder mehreren
anderen Compartments der Gesellschaft oder mit einem anderen luxemburgischen spezialisierten Investmentfonds oder
Organismus für gemeinsame Anlagen vorzunehmen, wird den betroffenen Aktionären mitgeteilt.
Im Falle der Verschmelzung mit einem luxemburgischen "fonds commun de placement" ist der Beschluss nur für die
dieser Verschmelzung zustimmenden Aktionäre bindend."
Vorerwähnte Satzungsänderungen fanden mit der Zustimmung des Komplementärs statt.
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte auf der Agenda stehen, ist die Hauptversammlung beendet.
Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: C. BREIT, S. FABER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 février 2013. Relation: LAC/2013/19283. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - zum Zwecke der Hinterlegung beim Gesellschafts- und Handelsregister
und der Veröffentlichung im Memorial erteilt.
57199
Luxemburg, den 6. Mai 2013.
Référence de publication: 2013057700/196.
(130071143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.
H & A Global Macro, Fonds Commun de Placement.
AUFLÖSUNG
Gemäß Beschluss des Vorstandes der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. wurde das Sondervermögen
am 8. Mai 2013 aufgelöst. Das Liquidationsverfahren wurde vollständig abgeschlossen. Alle Gelder konnten ausgezahlt
werden. Eine Hinterlegung bei der Caisse de Consignation war daher nicht notwendig.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Receuil des Sociétés et associations.
Luxemburg, im Mai 2013.
<i>Für den Vorstand der Verwaltungsgesellschafti> .
Référence de publication: 2013065131/1346/10.
Quadrum SICAV-SIF S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé,
(anc. Bizvalue SICAV-SIF S.C.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 160.406.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-sixth day of April;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "BIZVALUE SICAV-SIF S.C.A.", a
corporate partnership limited by shares ("société en commandite par actions'") in the form of an investment company
with variable capital ("société d'investissement à capital variable") qualifying as a specialised investment fund ("fond d'in-
vestissement spécialisé"), established and having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,
registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 160406, (the "Fund"),
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the April 18, 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 902 of May 5, 2011.
The Meeting is presided by Mrs. Alexia UHL, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling.
The Chairman appoints Mrs. Anne-Laure ADAM, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue
Jean Engling, as secretary.
The Meeting elects Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, as scrutineer.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Change of Fund's name into "QUADRUM SICAV-SIF S.C.A." and subsequent amendment of the first paragraph of
article 1 of the by-laws;
2. Amendment of the first paragraph of article 6 of the by-laws;
3. Amendment of article 15 of the by-laws; and
4. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
57200
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to change the Fund's name into "QUADRUM SICAV-SIF S.C.A." and to subsequently amend the
first paragraph of article 1 of the by-laws in order to give it the following wording:
« Art. 1. Corporate name - Form. There is hereby established a corporation in the form of a Luxembourg corporate
partnership limited by shares ('société en commandite par actions") under the corporate name "QUADRUM SICAV-SIF
S.C.A." (hereafter referred to as the "Fund"), qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investis-
sement spécialisé, subject to the provisions of the Luxembourg law relating to special investment funds dated February
13
th
, 2007 (the "Law") and related laws and regulations."
<i>Second resolutioni>
The Meeting acknowledges that the corporate name of the Fund's General Partner has been changed from "BIZVALUE
S.A." into "QUADRUM S.A.".
In order to reflect such action in the Fund's by-laws, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 6 as
well as article 15 in order to give them the following wordings:
« Art. 6. General Partner. The General Partner (associé gérant commandité) of the Fund will be "QUADRUM S.A.",
a public limited company ("société anonyme") incorporated on 28
th
April 2010, under the law of the Grand Duchy of
Luxembourg, established and having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, registered with
the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 152827."
« Art. 15. Management. The Fund will be managed by the General Partner "QUADRUM S.A."."
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to
speak, the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand two
hundred Euros.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Signé: A. UHL, A-L. ADAM, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2013. LAC/2013/19866. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 13 mai 2013.
Référence de publication: 2013062858/77.
(130077787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Globus Equity SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 158.639.
Par résolution circulaire du 22 mars 2013, Monsieur Dag RINGDAL, 25 Cite am Wenkel, L-8086 BERTRANGE, a été
coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Peer Kierstein NIELSEN, démissionnaire, avec effet
au 1
er
avril 2013.
Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les
comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 08 avril 2013.
<i>Pour: GLOBUS EQUITY SICAV SIF
i>Société d'investissement à capital variable
Experta Luxembourg
Société anonyme
Marie-Laurence Thill / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2013044993/19.
(130054931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.
57201
IPConcept (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 82.183.
Le règlement de gestion de BPM coordonné au 03 mai 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature
Référence de publication: 2013055542/13.
(130068536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2013.
P. Corporate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. P. Corporate Investments S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 75.613.
L'an deux mille treize, le quinze mars.
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en
remplacement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme P. CORPORATE INVEST-
MENTS S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 75613,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 13 avril
2000, publié au Mémorial C numéro 614 du 29 août 2000, et dont les statuts ont été modifiés:
suivant actes reçus par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch:
- en date du 13 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 383 du 8 avril 2004;
- en date du 6 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 829 du 9 mai 2007;
et suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 23 octobre 2008, publié au Mémorial
C numéro 2894 du 4 décembre 2008,
ayant un capital social de soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (64.990,- EUR), représenté par six
mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (6.499) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à L-6130
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé,
demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1.- Transformation de la forme juridique de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée.
2.- Refonte des statuts.
3.- Nomination des gérants.
4.- Transfert du siège social de L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, à I-31100 Treviso (TV), Via Caccianiga 4 (Italie).
5.- Décision corrélative d'adoption de la nationalité italienne.
6.- Confirmation que tous les actifs et passifs de la société luxembourgeoise, sans limitation resteront la propriété de
la société en Italie.
7.- Refonte des statuts en langue italienne.
57202
8.- Donner mandats pour procéder à toutes les démarches nécessaires tant en Italie qu'au Grand-Duché de Luxem-
bourg en relation avec le transfert de siège.
9.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transformer conformément à la faculté prévue à l'article 3 de la loi sur les sociétés commerciales
la Société en société à responsabilité limitée sans changement de la personnalité juridique de la Société.
Les six mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (6.499) actions sont échangées contre six mille quatre cent quatre-vingt-
dix-neuf (6.499) parts sociales toutes détenues comme suit:
- La société à responsabilité limitée de droit italien AZIENDA AGRICOLA BIASUZZI S.R.L., ayant son siège social à
I-31021 Mogliano Veneto, Treviso, Via Angeli (Italie), numéro d'immatriculation TV 001864402771, mille neuf cent vingt
huit parts sociales; 1.928
- Dr. Ing. Monsieur Maurizio BIASUZZI, né à Treviso (Italie), le 3 décembre 1950, demeurant à I-31100 Treviso, Vicolo
Spineda 6 (Italie), quatre mille cinq cent soixante et onze parts sociales; 4.571
La dénomination de la société est modifiée en P. CORPORATE INVESTMENTS S.à r.l..
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide la refonte des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
"Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il existe société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise
de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant
sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au
contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances
ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.
Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.
En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,
industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de P. CORPORATE INVESTMENTS S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (64.990,- EUR),
représenté par six mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (6.499) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (10,-
EUR) chacune.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les
trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
57203
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales."
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de lui accorder
décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour et de nommer comme gérants les actuels membres du conseil
d'administration à savoir:
- Monsieur Niccolò LUCCHINI, né à Lugano (Suisse), le 1
er
août 1942, demeurant à CH-6901 Lugano, Via Pretorio
7 (Suisse);
- Monsieur Jacopo ROSSI, né à San Dona' di Piave (Italie), le 20 avril 1972, demeurant professionnellement à L-2449
Luxembourg, 10, boulevard Royal;
- Monsieur Régis DONATI, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnellement à L-1219
Luxembourg, 17, rue Beaumont;
et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.
Leur mandat prendra fin lors de l'inscription de la société en Italie.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide que le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2012 déjà approuvés par l'assemblée
des actionnaires, sont à considérés comme compte sociaux de clôture au Luxembourg et en même temps comme comptes
sociaux d'ouverture en Italie et de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la
date de ce jour de L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, à I-31100 Treviso (TV), Via Caccianiga 4 (Italie), et de faire
adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège
donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle et le tout sous la condition
résolutoire de la non-homologation de ce transfert par les autorités italiennes compétentes pour quelque motif que ce
soit.
L'assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité de l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur
les sociétés commerciales.
57204
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée confirme que tous les actifs et passifs sans limitation resteront la propriété de la société dont le siège est
transféré en Italie.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique en Italie:
Dr. Ing. Maurizio BIASUZZI, de nationalité italienne, né à Treviso (Italie), le 3 décembre 1950, demeurant à I-31100
Treviso, Vicolo Spineda 6 (Italie), code fiscal BSZ MRZ 50T03 L407B,
L'administrateur unique aura tous les pouvoirs de signature individuelle soit pour la gestion ordinaire soit pour la
gestion extraordinaire de la société.
<i>Septième résolutioni>
Consécutivement à l'adoption de la cinquième résolution, il a été unanimement décidé de continuer l'activité en Italie
sous la dénomination de P. Corporate Investments SRL, de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2040, de
modifier l'objet social comme il est repris dans l'article 2 des nouveaux statuts en langue italienne, et de modifier comme
suit les statuts de la société afin de les mettre en conformité avec la loi italienne:
"STATUTO DELLA SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ' LIMITATA
"P. Corporate Investments SRL"
Titolo I°. Denominazione, Oggetto, Sede, Durata.
Art. 1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "P. Corporate Investments SRL".
Art. 2. La società ha per oggetto sociale le seguenti attività da esercitarsi tassativamente non nei confronti del pubblico:
- l'assunzione, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, di partecipazioni in altre società ed
enti, italiani ed esteri, industriali, commerciali, agricoli, immobiliari, di servizi in genere anche finanziari;
- il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa;
- la compravendita di titoli azionari ed obbligazionari, di quote di società solo ed esclusivamente nei confronti di società
controllate o collegate a'sensi dell'art. 2359 C.C..
La società potrà inoltre svolgere attività immobiliari con l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la permuta
di beni immobili in genere sia in Italia che all'estero.
La società potrà inoltre svolgere attività nel settore dell'allevamento equino, della gestione di scuderie di cavalli da
corsa, dell'ippica in genere nonché nel settore agricolo in genere e di attività connesse.
La società potrà inoltre svolgere attività nel settore alberghiero, case di cura e per anziani, ricettivo in genere, della
ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e attività turistica in genere.
Potrà anche svolgere attività di commercio in genere sia al dettaglio che all'ingrosso di qualunque bene o prodotto
anche alimentare.
La società in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, potrà compiere altresì tutte le operazioni
commerciali, industriali, finanziarie, compresa l'acquisizione di fondi comuni d'investimento di qualsiasi tipologia e genere,
mobiliari ed immobiliari, prestare garanzie e fidejussioni bancarie o diverse, operazioni tutte ritenute necessarie od utili
al conseguimento dell'oggetto sociale.
La società potrà infine assumere l'esercizio, anche in locazione, la gestione e la liquidazione di aziende aventi gli stessi
scopi o scopi affini a quelli sociali, il tutto con le operazioni che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie
od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Art. 3. La società ha sede legale nel Comune di Treviso (TV).
all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111 -ter delle
disposizioni del codice civile.
Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, agenzie, succursali e filiali.
Art. 4. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata
o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci, a termini di legge.
Titolo II°. Capitale sociale, Partecipazioni e Loro trasferimento
Art. 5. Il capitale sociale è fissato in Euro 64.990 (sessantaquattromila novecento novanta Euro) diviso in quote a sensi
di legge.
Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura), a titolo gratuito
(mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le
maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti
non sono stati integralmente eseguiti.
57205
Nel caso di aumento del capitale sociale, mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo, in
proporzione alle partecipazioni da essi possedute. In caso di mancato esercizio, parziale o totale, del diritto di opzione,
le quote non optate devono essere collocate prima presso i soci che hanno esercitato il diritto di opzione, in proporzione
alle loro partecipazioni sociali, ed in second'ordine presso terzi non soci al valore indicato dall'assemblea che ha deliberato
l'aumento.
La delibera di aumento di capitale può prevedere, salvo per il caso dell'art. 2482 ter C.C., che l'aumento di capitale
possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, in tal caso spetterà ai soci che non hanno
consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.
Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valu-
tazione economica, nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile.
I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere
fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di
risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 C.C.
La società può emettere titoli di debito con decisione dell'assemblea dei soci che delibererà con le maggioranze previste
dell'art. 13 del presente statuto.
La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale
e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza
della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.
La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere
iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della
maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.
Art. 6. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Art. 7. II trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli
articoli 2284 e 2289 del codice civile.
La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:
- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto,
- in caso di liquidazione gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al
patrimonio sociale, esso a tal fine è determinato a sensi del successivo articolo 26.
Le decisioni circa la continuazione e la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci con
il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% del capitale sociale, senza tener conto, ai fini del calcolo della
maggioranza, della partecipazione del socio defunto.
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tuttavia agli altri soci, spetta il diritto di prelazione per
l'acquisto. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i
negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i
contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.
Il socio che intende, in tutto od in parte, alienare la propria partecipazione è tenuto ad offrirla per iscritto in prelazione
agli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione nella società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno indicante il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e nome dell'acquirente.
I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera
raccomandata da inviarsi, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.
Trascorso tale termine la prelazione si intenderà rifiutata.
Qualora uno o più soci rinunci ad esercitare in tutto o in parte il diritto di prelazione i rimanenti avranno la facoltà di
acquistare le partecipazioni in vendita per le quali la prelazione non è stata esercitata, sempre in parti pro¬porzionali alle
rispettive partecipazioni nella società, e con l'osservanza della procedura indicata nei commi precedenti.
Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione e, nel caso in cui il numero delle partecipazioni
per le quali è stata esercitata la prelazione rimanga comunque inferiore all'offerta, la prelazione si intende rinunciata per
la totalità e l'alienante potrà vendere al soggetto indicato nella lettera di cui sopra, la partecipazione stessa ad un prezzo
che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci.
Qualora la cessione per atto tra vivi avvenga per atto di donazione o con un corrispettivo diverso dal denaro, il prezzo
della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il
prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui
ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto
della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali normalmente
tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a
un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.
57206
Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.
Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.
Il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto nel Registro
delle imprese.
Titolo III. Decisione dei soci - Assemblea
Art. 8. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili,
b) la nomina dell'organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di Controllo o del revisore;
d) le modificazioni del presente statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-
vante modificazione dei diritti dei soci;
f) emissione di titoli di debito;
g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Non possono partecipare alle decisioni, in qualsiasi forma venganoadottate, i soci morosi ed i soci titolari di parteci-
pazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.
Art. 9. Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, sono adottate mediante
consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo
amministrativo.
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale
dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione,
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti,
- l'indicazione dei soci consenzienti,
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o
astensione,
- la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti che astenuti che contrari,
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto
dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione,
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno tras-
mettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno
esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della
loro contrarietà o astensione, la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che
consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale
alla sua partecipazione.
Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale
sociale.
Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo ai punti d) e) f) e g), in tutti gli altri casi espressamente
previsti dalla legge o dal presente statuto sociale, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero
di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante
deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
Art. 10. L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo.
Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma possono aver luogo anche in altra sede, entro il territorio
nazionale.
Art. 11. La convocazione dell'assemblea è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'ordine del
giorno, l'ora, il giorno e il luogo dell'adunanza,da inviarsi ai soci, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese a norma
dell'art. 2479 bis C.C., agli amministratori ed all'Organo di Controllo se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza
stessa.
57207
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella
adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.
L'avviso di convocazione può essere inviato a soci ed amministratori, ed all'Organo di Controllo se nominato, anche
mediante posta elettronica o telefax nel luogo e presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax dagli stessi com-
unicato alla società e riportato nel Registro delle Imprese, fermo restando che i soci che non intendono indicare una
utenza fax o un indirizzo e-mail, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza hanno diritto di ricevere la comunica-
zione a mezzo lettera raccomandata.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa accertare l'identità e la legittimazione
dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il
presidente ha la facoltà di formulare proposte di delibera e di trattazione dell'ordine del giorno.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle
seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione
e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-
zione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio video collegati
a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
L'assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato
l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo se nominato, o gli amministratori e l'Organo di
Controllo siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
Se gli amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società
nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi ad essi.
Art. 12. L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico
o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore anagraficamente più anziano ed in caso di pari
anzianità da quello che risulterà da sorteggio.
In loro mancanza fungerà da presidente persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.
Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scelto anche tra non soci.
Art. 13. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.
Il diritto di intervento in assemblea è regolato dalla legge.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà
essere conservata dalla società.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo
da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.
La delega non può essere conferita ad un amministratore della società nè all'Organo di Controllo, se nominato, nè a
dipendenti della società.
Le assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con i quorum previsti
dall'art. 2479 bis del c.c.
Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse
specifiche maggioranze.
Art. 14. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal
notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato
da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identi-
ficazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da
un notaio.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio nel libro delle
decisioni dei soci.
57208
Titolo IV. Amministrazione
Art. 15. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della
nomina:
- da un Amministratore Unico,
- da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo
di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno
determinati dai soci in occasione della nomina.
Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se
nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.
Art. 16. Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà
stabilito dai soci all'atto della loro nomina.
In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità
di motivazione, ovvero di giusta causa.
E' amessa la rieleggibilità.
Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei
Consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più amministratori, con
poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli
altri amministratori.
Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Con-
siglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amminis-
trativo è stato ricostituito.
Art. 17. Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un
Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che
sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.
Art. 18. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto
previsto al successivo art. 19 sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per
iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale
dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro
contrarietà o astensione
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto
dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione.
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno
trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno
esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della
loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto
contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che
consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi i fax e la posta elettronica.
Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori
in carica.
Le decisioni degli amministratori, adottate a'sensi del presente articolo dovranno essere trascritte nel libro delle
decisioni degli amministratori.
Con le suddette maggioranze, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o
su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale.
57209
Art. 19. Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 quinto comma C.C. ovvero nel caso di cui al precedente
articolo 18 ultimo comma, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio
di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
A tal fine il consiglio di amministrazione:
- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo
idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con
telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, luogo e l'ora della riunione, nonchè
l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè nell'ambito del territorio nazionale, o in altro stato appartenente
all'Unione Europea.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono
tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo se nominato.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle
seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione
e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-
lizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei
suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario, detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto,
nel libro delle decisioni degli amministratori.
Art. 20. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti
di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri
componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di
amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione
della nomina, potranno essere attribuiti sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione
potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina
in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori
in via congiunta.
Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore
all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.
L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori speciali per il compimento di determinati atti
o categorie di atti, determinandone i poteri.
Art. 21. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del
consiglio di amministrazione, in via disgiunta tra di loro.
Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via
congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in
via congiunta ovvero in via disgiunta.
La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed i procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati
dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.
Art. 22. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere
assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci,
in occasione della nomina o con apposita decisione.
Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la rimunerazione degli amministratori investiti
di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di Controllo nominato.
57210
All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante polizza assi-
curativa.
Titolo V. Bilancio e Utili
Art. 23. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.
Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro
centottanta giorni quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze
della stessa lo richiedano a norma del combinato disposto degli art.li 2364 e 2478 bis C.C.: in quest'ultimo caso peraltro
gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma
abbreviata) le ragioni della dilazione.
Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da
destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato,
fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura proporzionale.
Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.
Titolo VI. Organo di controllo - Revisore legale dei conti
Art. 24. La società può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti,
un organo di controllo o un revisore legale dei conti.
L'organo di controllo può essere costituito anche da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo
stabilito per le società per azioni.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo
cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale
previste per le società per azioni.
Nel caso in cui l'organo di controllo svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, tale organo dovrà essere
necessariamente composto da soggetti che, oltre ad essere dotati dei medesimi requisiti professionali previsti dall'art.
2397, co. 2, c.c. per i sindaci di S.p.a., dovranno essere scelti fra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, in
applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-bis c.c.
Il revisore legale o la società di revisione, se nominati, potranno esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta
a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili,
nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.
Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le
disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.
Titolo VII. Scioglimento e Liquidazione
Art. 25. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
per il decorso del termine;
per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea,
all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter Codice Civile;
nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 Codice Civile;
per deliberazione dell'assemblea;
per le altre cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla
legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
57211
- il numero di liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del
consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
Titolo VIII. Recesso
Art. 26. Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera
che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro
Imprese esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato
il diritto di recesso non possono essere cedute.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia quando la società revoca la delibera che lo
legittima ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al
patrimonio sociale determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore
dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione
che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni
societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto
nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi di legge su istanza della parte più diligente.
Il rimborso deve essere eseguito con le modalità previste dalla legge entro 180 giorni dalla comunicazione della volontà
di recedere.
Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni
oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire
a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo
da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente
riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applicherà l'articolo 2482 c.c.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della
partecipazione del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo
legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di
provvedere, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad
importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.
Titolo IX. Clausola compromissoria e Norma di rinvio
Art. 27. Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori,
liquidatori ed Organo di Controllo, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità
al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla
Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.
Art. 28. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di
legge."
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Dr. Ing. Monsieur Maurizio BIASUZZI, de
nationalité italienne, né à Treviso (Italie), le 3 décembre 1950, demeurant à I-31100 Treviso, Vicolo Spineda 6 (Italie),
avec tous pouvoirs de substitution et de délégation, à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires
à l'inscription de la société à Trévise, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches,
réquisitions, déclarations et délégations y relatives.
<i>Neuvième résolutioni>
Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société par les autorités ita-
liennes compétentes.
Tous pouvoirs sont conférés à Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Lu-
xembourg, 17, rue Beaumont, pour faire constater pardevant notaire la réalisation de la condition suspensive.
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée décide que tous les documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés
pendant un période de cinq ans à l'ancien siège de la société.
57212
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille trois cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal. Passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Bob PLEIN, Alain THILL, Joseph ELVINGER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mars 2013. Relation GRE/2013/1257. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013040201/598.
(130049485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.
LLIC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 51.052.308,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 164.014.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of December.
Before Me Francis KESSSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Liberty UK and Europe Holdings Limited, a private company limited by shares and existing under the laws of England
and Wales, with registered office at Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, Manchester, M1 5ES, United Kingdom,
registered with the Registrar for Companies of England and Wales with Company Number 700621712 here represented
by Nathalie HOULLE, attorney-at-law, having her professional address in Howald, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue
of a proxy given under private seal on 19 December 2012.
The said proxy after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed company is the sole member (the “Member”) of LLIC S.à r.l., a company incorporated and existing
under the laws of Luxembourg, with registered office at, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B164.014, incorporated on 14 September
2011 by a deed of the undersigned notary published in the Memorial C, number 2958 dated 2 December 2011 (the
“Company”).
That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Acknowledgment of the resignation of Mr. James Francis KELLEHER from his position as A manager of the Company
with effect as at the end of the present meeting and granting to him full discharge (quitus) with respect to his mandate
as manager of the Company.
2. Appointment of Mr. Edmund Campion KENEALY, born on 17 October 1962 in New York (United States of Ame-
rica), residing at 12 Ruddock Road, Sudbury, Massachussetts 01776 (United States of America) as new A manager of the
Company with effect as at the end of the present meeting for an unlimited period of time.
3. Increase of the capital of the Company by an amount of fifty one million, twenty two thousand three hundred eight
United States Dollars (USD 51,022,308.-) so as to raise it from its present amount of thirty thousand United States Dollars
(USD 30,000.-) to fifty one million, fifty two thousand three hundred eight United States Dollars (USD 51,052,308.-) by
the issue of fifty one million, twenty two thousand, three hundred eight (51,022,308) new shares, having a nominal value
of one United States Dollar (USD 1.-) each, for a total subscription price of fifty one million, twenty two thousand three
hundred eight United States Dollars (USD 51,022,308.).
4. Subscription for the fifty one million, twenty two thousand, three hundred eight (51,022,308) new shares by the
Company’s sole member Liberty UK and Europe Holdings Limited and payment up in full by contribution in kind of a
claim held by Liberty UK and Europe Holdings Limited against the Company for an amount of fifty one million, twenty
two thousand three hundred eight United States Dollars (USD 51,022,308.-).
Subsequent cancellation of the contributed claim pursuant to article 1300 (2) of the Luxembourg Civil Code (‘confu-
sion’).
5. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company so as to reflect the increase of capital.
After this had been set forth, the following resolutions were taken in conformity with the agenda of the meeting:
57213
<i>First resolutioni>
The Member resolved to acknowledge the resignation of Mr. James Francis KELLEHER from his position as A manager
of the Company with effect as at the end of the present meeting and granting to him full discharge (quitus) with respect
to his mandate as manager of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Member resolved to appoint Mr. Edmund Campion KENEALY, born on 17 October 1962 in New York (United
States of America), residing at 12 Ruddock Road, Sudbury, Massachussetts 01776 (United States of America) as new A
manager of the Company with effect as at the end of the present meeting for an unlimited period of time.
<i>Third resolutioni>
The Member resolved to increase the capital of the Company by an amount of fifty one million, twenty two thousand
three hundred eight United States Dollars (USD 51,022,308.- ) so as to raise it from its present amount of thirty thousand
United States Dollars (USD 30,000.-) to fifty one million, fifty two thousand three hundred eight United States Dollars
(USD 51,052,308.-) by the issue of fifty one million, twenty two thousand, three hundred eight (51,022,308) new shares,
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, for a total subscription price of fifty one million, twenty
two thousand three hundred eight United States Dollars (USD 51,022,308.-).
<i>Subscription and paymenti>
The Member decided to approve the subscription of Liberty UK and Europe Holdings Limited, represented as stated
above, for the the fifty one million, twenty two thousand, three hundred eight (51,022,308) new shares and payment in
full by contribution in kind of a claim held by Liberty UK and Europe Holdings Limited against the Company and surren-
dered to the Company for an amount of fifty one million, twenty two thousand three hundred eight United States Dollars
(USD 51,022,308.-).
The claim having been surrendered to the Company, it shall be cancelled and no longer outstanding in accordance
with article 1300 (2) of the Luxembourg Civil Code (‘confusion’).
Evidence of the value of the contributed claim has been provided through (i) a contribution certificate issued by an
authorized representative of Liberty UK and Europe Holdings Limited on 19 December 2012 and (ii) a valuation certificate
issued by the management of the Company on 19 December 2012.
<i>Fourth resolutioni>
The Member resolved to amend article 5.1 of the articles of association of the Company so as to reflect the increase
of capital as follows:
“ 5.1. The Company’s issued share capital is set at fifty one million, fifty two thousand three hundred eight United
States Dollars (USD 51,052,308.-), represented by fifty one million, fifty two thousand three hundred eight (51,052,308)
shares having a nominal value of one United States Dollars (USD1.-) per share”
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the foregoing increase of capital are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by name, Christian name,
civil status and residence, the said appearing person signed with the notary the present deed.
Follows the french version:
L’an deux mille douze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Liberty UK and Europe Holdings Limited, une société constituée selon le droit de l'Angleterre et du pays de Galles,
ayant son siège social au Eversheds House, 70, Great Bridgewater Street, Manchester, MI 5ES, Royaume Uni, immatriculée
auprès du Registre de Commerce de l'Angleterre et du pays de Galles sous le numéro 700621712, représentée par Maître
Nathalie HOULLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée en Luxembourg le
19 décembre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire représentant la partie comparante et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins d’enregistrement.
57214
La société préqualifée est l’associé unique (l’«Associé») de LLIC S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée
selon le droit luxembourgeois, avec siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B164.014, constituée
selon acte daté du 14 septembre 2011 u notaire soussigné, publié au Mémorial C en date du 2 décembre 2011, numéro
2958 (la «Société»).
L’ordre du jour est le suivant:
<i>Agendai>
1. Constatation, de la démission de M. James Francis KELLEHER de sa fonction de gérant de classe A de la Société
avec effet à la fin de cette assemblée et octroi d’une décharge pleine et entière audit gérant (quitus) en rapport avec son
mandat de gérant de la Société;
2. Nomination de M. Edmund Campion KENEALY, né le 17 octobre 1962 à New York (Etats-Unis d’Amérique),
résidant au 12 Ruddock Road, Sudbury, Massachussetts, 01776 (Etats-Unis d’Amérique) en tant que nouveau gérant de
classe A de la Société avec effet à la fin de cette assemblée et ce pour une durée illimitée.
3. Augmentation du capital de la Société pour un montant de cinquante et un millions vingt-deux mille trois cent huit
Dollars Américains (USD 51.022.308,-) pour le porter de son montant actuel de trente mille Dollars Américains (USD
30.000,-) à un montant de cinquante et un millions cinquante-deux mille trois cent huit Dollars Américains (USD
51.052.308,-) par l’émission de cinquante et un millions vingt-deux mille trois cent huit (51.022.308) nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1,-), pour une valeur totale de souscription de cinquante et
un millions vingt-deux mille trois cent huit dollars américains (USD 51.022.308,-)
4. Souscription des cinquante et un millions vingt-deux mille trois cent huit (51.022.308) nouvelles parts sociales par
l’associé unique de la Société Liberty UK and Europe Holdings Limited et paiement de la totalité par apport en nature,
par l’apport d’un droit à recevoir détenu par Liberty UK and Europe Holdings Limited envers la Société pour un montant
de cinquante et un millions vingt-deux mille trois cent huit Dollars Américains (USD 51.022.308,-).
Annulation subséquente de ce droit à recevoir apporté en vertu de l’article 1300 (2) du Code Civil luxembourgeois
(«confusion»).
5. Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter la prédite augmentation de capital.
Ces faits exposés, les résolutions suivantes ont été prises conformément à l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
L’Associé décide d’accepter la démission de M. James Francis KELLEHER de sa fonction de gérant de classe A de la
Société avec effet à la fin de cette assemblée et de lui octroyer décharge pleine et entière (quitus) en rapport avec son
mandat de gérant de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé décide de nommer M. Edmund Campion KENEALY, né le 17 octobre 1962 é New York, (Etats-Unis d’Amé-
rique), résidant au 12 Ruddock Road, Sudbury, Massachussetts, 01776 (Etats-Unis d’Amérique) en tant que nouveau gérant
de classe A de la Société avec effet à la fin de cette assemblée et ce pour une durée illimitée.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé décide d’augmenter le capital de la Société pour un montant de cinquante et un millions vingt-deux mille
trois cent huit Dollars Américains (USD 51.022.308,-) pour le porter de son montant actuel de trente mille Dollars
Américains (USD 30.000,-) à un montant de cinquante et un millions cinquante-deux mille trois cent huit Dollars Amé-
ricains (USD 51.052.308,-) par l’émission de cinquante et un millions vingt-deux mille trois cent huit (51.022.308) nouvelles
parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1,-), pour une valeur totale de souscription de cinquante
et un millions vingt-deux mille trois cent huit dollars américains (USD 51.022.308,-)
<i>Souscription et libérationi>
L’Associé décide d’accepter la souscription par Liberty UK and Europe Holdings Limited, représenté tel qu’indiqué ci-
avant, des cinquante et un millions vingt-deux mille trois cent huit (51.022.308) nouvelles parts sociales et paiement de
la totalité par apport en nature, par l’apport d’un droit à recevoir détenu par Liberty UK and Europe Holdings Limited
envers la Société pour un montant de cinquante et un millions vingt-deux mille trois cent huit dollars américains (USD
51.022.308,-).
Ce droit à recevoir étant remis à la Société, il sera de fait annulé et cessera d’être en circulation conformément à
l’article 1300 (2) du Code Civil luxembourgeois («confusion»).
La preuve de la valeur de ce droit à recevoir a été fournie par (i) un certificat d’apport émis par le représentant légal
de Liberty UK and Europe Holdings Limited en date du 19 décembre 2012 et par (ii) un certificat d’évaluation émis par
les gérants de la Société en date du 19 décembre 2012.
57215
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé décide de modifier la première phrase de l’article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter la prédite
augmentation de capital comme suit:
« Art. 5.1. Capital social. Le capital social est fixé à cinquante et un millions cinquante-deux mille trois cent huit Dollars
Américains (USD 51.052.308,-) représenté par cinquante et un millions cinquante-deux mille trois cent huit (51.052.308)
nouvelles parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1,-) chacune.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
s’élève à approximativement sept mille euros (EUR 7.000,-).
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénoms
usuels, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Houlle, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2012. Relation: EAC/2012/17895. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013040621/170.
(130049916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.
Kerta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 169.561.
Il se dégage d’un accord de cessions de parts sociales signé sous seing privée en date du 4 janvier 2013 que:
- La société Emerald Tamborine LLC, avec siège social à Two North Riverside Plaza, 60606 Chicagi, USA a cédé ses
444.879 parts sociales qu’elle détient dans la société Kerta S.à r.l., avec siège social au 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, à la société Terranum Corporate Properties S.à r.l., avec siège social à 40, avenue Monterey, L-2163 Lu-
xembourg.
- La société Terranum Business Investments S.A., avec siège social à 50, Street, étage 16
th
, 01098 Panama, a cédé
toutes ses 746.647 parts sociales qu’elle détient dans la société Kerta S.à r.l., avec siège social au 40, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, à la société Terranum Corporate Properties S.à r.l., avec siège social à 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg.
- La société CREL Investments Limited, avec siège social à 196, Road Town, VG1110 Tortola, BVI, a cédé toutes ses
28914 parts sociales qu’elle détient dans la société Kerta S.à r.l., avec siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Lu-
xembourg, à la société Terranum Corporate Properties S.à r.l., avec siège social à 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg.
- La société Colombian Development Investments Limited, avec siège social à 1, Harbour Centre, étage 3
rd
, KY1-1102
Grand Cayman, a cédé toutes ses 79560 parts sociales qu’elle détient dans la société Kerta S.à r.l., avec siège social au
40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, à la société Terranum Corporate Properties S.à r.l., avec siège social à 40,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Il en résulte donc que la société Terranum Corporate Properties S.à r.l., avec siège social à 40, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 174.009,
détient la totalité des 1.300.000 parts sociales et est en conséquence l’associé unique de la société Kerta S.à r.l., avec
siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés B 169.561.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 2013.
Référence de publication: 2013045619/30.
(130055528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
57216
Allianz Global Investors Fund II
Allianz Global Investors Fund IX
Almasa S.A., SPF
Ana Holding S.A., SPF
AviaRent S.C.A. SICAV-FIS
BD - Family Select
beta3 dynamic
Bizvalue S.A.
Bizvalue SICAV-SIF S.C.A.
Causerman Investissements S.A.
CENTUM Fund
Charlotte Investment S.A.
Cobano S.A.
Codecis International S.A.
Commerzbank International Portfolio Management
Eurinvest S.A. - SPF
Eurox Europe S.A.
Fincra S.A.
Gelsomino S.A.
Globus Equity SICAV SIF
H & A Global Macro
I.B.M.S. - International Business and Management Services S.A.
Interval S.A. - SPF
Investec Global Strategy Fund
IPConcept (Luxembourg) S.A.
Jockey Holding
Jordanus Holding S.A., SPF
Kerta S.à r.l.
LLIC S.à r.l.
Longview Partners Investments
LUXFER - Industriehallenbau S.A.
Malibaro, SA SPF
Maraton International S.A.
Mavica Investments S.A.
Öhman Fund
P. Corporate Investments S.A.
P. Corporate Investments S.à r.l.
Perseus Immobilien Gesellschaft 11
Quadrum S.A.
Quadrum SICAV-SIF S.C.A.
Stratège S.A.
Sylvex S.A.
Transair S.A. - SPF
Truc S.A.
Vahina
VCM Golding Mezzanine SICAV
VCM Golding Mezzanine SICAV
VCM Golding Mezzanine Sicav II
VCM Golding Mezzanine Sicav II
Vestigia
WILLI S.A., société de gestion de patrimoine familial
YRI Global Liquidity S.à r.l.