This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1096
8 mai 2013
SOMMAIRE
1 2 3 Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52562
ACP II2 S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52562
Actelion Finance SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52604
ADEPA Asset Management S.A. . . . . . . . .
52562
AI Northern Star (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52581
Algen Technologie Luxembourg S.A. . . . .
52576
Atlant Europe RE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
52579
Comco MCS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52565
DCL Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52608
Eneris Polska S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52603
Etablissements Locanord S.A. . . . . . . . . . . .
52607
Immaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52564
ISP Luxembourg Canada . . . . . . . . . . . . . . .
52567
IVG Logistics Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
52569
Jackson, Jones & Cie S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . .
52564
Jacmar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52564
Jakadi S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52568
Keystone Management S.A. . . . . . . . . . . . . .
52569
La Chanterelle Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
52570
LF Hotels Acquico I SCS . . . . . . . . . . . . . . . .
52590
Life Point Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52569
Luigi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52563
Lunala Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
52568
Morisco International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
52568
PAA Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52570
Pegas Nonwovens SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52570
Plains Midstream Luxembourg . . . . . . . . . .
52567
Profi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52567
Project Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52563
Quinn Group Luxembourg Hotels S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52562
Randstad Recruitment & Selection S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52571
RM Properties 2 S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52563
Secapital S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52601
SHIP Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52565
SHIP Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52566
SHIP Luxco Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52565
Sipicione International S.A. . . . . . . . . . . . . .
52564
Sparinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52566
Star Consult s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52566
TechnoMarine S.A, Succursale de Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52566
Transition Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52603
Utu Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
52573
Web Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52573
XX ZW Investment Group S.A. . . . . . . . . .
52563
52561
L
U X E M B O U R G
ADEPA Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 114.721.
<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 mars 2013i>
(…)
Approbation de la nomination d’un administrateur:
a. Mr. Philippe Beckers, né à Liège (Belgique), le 6 septembre 1960, demeurant à CH-1028, Preverenges (Suisse), 7,
Chemin des Tuileries est approuvé administrateur de la société ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. jusqu’à l’assemblée
qui se tiendra en 2014.
(…)
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013040890/15.
(130050639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
ACP II2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 94.960.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 décembre 2012 que:
1. La liquidation de la société ACP II 2 S.C.A. est cloturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 412F, route d'Esch, L-1417 Luxembourg, et y seront
conservés pendant cinq ans au moins.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013040888/14.
(130050908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Quinn Group Luxembourg Hotels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 103.794.
Veuillez noter que l'associée unique, Quinn Group Luxembourg Property S.à r.l., a désormais son siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte avec effet au 13 décembre 2012.
Luxembourg, le 27 mars 2013.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Quinn Group Luxembourg Hotels S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013041388/13.
(130050396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
1 2 3 Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 55.215.
EXTRAIT
L’adresse de Madame Carine HUON, administrateur-délégué de la Société, est B-3000 Leuven, Jan Cobbaertplein
2/201.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2013041543/12.
(130050515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
52562
L
U X E M B O U R G
XX ZW Investment Group S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 171.838.
Par résolutions signées en date du 15 mars 2013, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, de son mandat d’administrateur de Catégorie B, avec effet immédiat;
- nomination de Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
d’administratrice de Catégorie B, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2013.
Référence de publication: 2013041535/15.
(130051146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
RM Properties 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.216.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 décembre 2012 que:
1. La liquidation de la société RM PROPERTIES 2 S.C.A. est cloturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 412F, route d'Esch, L-1417 Luxembourg, et y seront
conservés pendant cinq ans au moins.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013041400/14.
(130050910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Luigi S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 53.014.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 mars 2013i>
Est nommé administrateur de catégorie B, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2015, Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant pro-
fessionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Thierry FLEMING,
administrateur de catégorie B démissionnaire en date de ce jour.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013041276/13.
(130050968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Project Service S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 147.851.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 28 Mars 2013i>
A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- Le siège social de la société est transféré au 18 Rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Référence de publication: 2013041381/12.
(130051082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
52563
L
U X E M B O U R G
Jacmar S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 82.894.
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2013: -
- Est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2013 la démission de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant
que Commissaire aux Comptes.
- Est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2013 la nomination de FIDUCIAIRE SEVE S.A. ayant son siège social 12D
Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 82421 en tant que Commissaire aux Comptes en rem-
placement de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2018.
Luxembourg, le 27 février 2013.
<i>Pour JACMAR S.A.i>
Référence de publication: 2013041222/16.
(130050707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Jackson, Jones & Cie S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 118.374.
RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg que le nouveau siège social de
PAI Syndication General Partner Limited est désormais situé 1, Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernesey GY1
2HL.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2013.
Référence de publication: 2013041220/13.
(130050292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Immaco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7526 Mersch, 9, allée John W. Leonard.
R.C.S. Luxembourg B 105.151.
<i>Extrait de l’Assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 janvier 2013i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la nomination de Monsieur Pierre Hoffmann, demeurant à L-7343 Steinsel, 16, rue des Templiers,
comme nouveau commissaire aux comptes.
Référence de publication: 2013041199/11.
(130050870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Sipicione International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 153.003.
Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg, en abrégé Experta Luxembourg, société anonyme, en sa
qualité d'agent domiciliataire, a dénoncé le siège social de la société anonyme SIPICIONE INTERNATIONAL S.A., 42,
rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, RCS Luxembourg B-153003, avec effet au 28 mars 2013 et résilié la convention de
domiciliation.
Luxembourg, le 28 mars 2013.
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Roselyne Candido-Michel
Référence de publication: 2013041440/14.
(130050550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
52564
L
U X E M B O U R G
SHIP Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 154.678.
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’associé unique de la Société en date du 27 mars 2013:
D’accepter la démission de Monsieur Phil LOUGHLIN avec effet immédiat;
et
De nommer en tant que gérant de Catégorie B de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée,
Monsieur Robin MARSHALL, né le 05 juin 1970 à Paisley, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 1, Mayfair Place,
Devonshire House, WIJ 8AJ Londres, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2013.
Référence de publication: 2013041435/16.
(130051188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
SHIP Luxco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 156.893.
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’associé unique de la Société en date du 27 mars 2013:
D’accepter la démission de Monsieur Phil LOUGHLIN avec effet immédiat;
et
De nommer en tant que gérant de Catégorie A 2 de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée,
Monsieur Robin MARSHALL, né le 05 juin 1970 à Paisley, Royaume-Uni, résidant professionnellement au Mayfair Place,
Devonshire House, WIJ 8AJ Londres, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2013.
Référence de publication: 2013041434/16.
(130050899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Comco MCS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 40, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 41.488.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 13 mars 2013i>
Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur Stefan König a
été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014. Les mandats d'administrateur de Madame Marie-Hélène
Godart et Monsieur Joachim Krotten ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014. Le mandat
de réviseur d'entreprise de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en 2014.
Suite aux décisions de l'assemblée générale ordinaire du 13 mars 2013, le conseil d'administration se compose de la
façon suivante:
a) Monsieur Stefan König, administrateur et administrateur délégué, adresse professionnelle 40, rue des Bruyères,
L-1274 Howald,
b) Madame Marie-Hélène Godart, administrateur, adresse professionnelle 40, rue des Bruyères, L-1274 Howald,
c) Monsieur Joachim Krotten, administrateur, adresse professionnelle 40, rue des Bruyères, L-1274 Howald.
Le réviseur d'entreprise est PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013041552/22.
(130049946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2013.
52565
L
U X E M B O U R G
Sparinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 83.976.
RECTIFICATIF
Notification rectificative d'une notification enregistrée et déposée le 19/03/2013 sous le numéro L130045475.
Veuillez prendre note de la correction suivante:
- Per NOESGAARD, Directeur Général, Sparinvest Holding A/S, 28 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
<i>Pour SPARINVEST SICAV
i>RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2013041452/14.
(130050318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
SHIP Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 154.706.
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’associé unique de la Société en date du 27 mars 2013:
D’accepter la démission de Monsieur Phil LOUGHLIN avec effet immédiat;
et
De nommer en tant que gérant de Catégorie B de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée,
Monsieur Robin MARSHALL, né le 05 juin 1970 à Paisley, Royaume-Uni, résidant professionnellement au Mayfair Place,
Devonshire House, WIJ 8AJ Londres, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2013.
Référence de publication: 2013041436/16.
(130050900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Star Consult s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2166 Luxembourg, 3, rue Mozart.
R.C.S. Luxembourg B 164.973.
<i>Extrait des résolutions circulaires prises par les gérants de la Société en date du 27 mars 2013i>
Il résulte des résolutions prises par le Conseil de gérance de la Société en date du 27 mars 2013 que le siège social de
la Société a été transféré du 6 rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg au 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 27 mars 2013.
Thierry Drinka
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013041413/14.
(130050263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
TechnoMarine S.A, Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 133.021.
Il est pris acte que l'adresse de Monsieur Jean-Marc CREPIN et de Monsieur Jacques-Philippe AURIOL, Gérants est la
suivante: 2, rue de la Rôtisserie, CH-1204 Genève.
Luxembourg, le 15 février 2013.
Signatures.
Référence de publication: 2013041472/10.
(130050922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
52566
L
U X E M B O U R G
Profi S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 29.749.
Par la présente, la Fiduciaire ROMAIN ZIMMER dénonce avec effet au 3 janvier 2011 la domiciliation de fait du siège
social 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg, de la Société Anonyme PROFI S.A., inscrite au R.C.S. Luxembourg
sous le numéro B29749.
Luxembourg, le 27 mars 2013.
Romain ZIMMER.
Référence de publication: 2013041380/10.
(130050402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Plains Midstream Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 157.025.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 mars 2013i>
1. Le mandat de gérant A de M. Al SWANSON a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de
2014.
2. Le mandat de gérant A de M. David RABINOWITZ a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2014.
3. Le mandat de gérant B de M. Hugo FROMENT a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de
2014.
4. Le mandat de gérant B de M. Andrew O'SHEA a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de
2014.
Luxembourg, le 27.3.2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Plains Midstream Luxembourg
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013041358/20.
(130050254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
ISP Luxembourg Canada, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 133.821.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 19 mars 2013i>
1. M. Sébastien ANDRE a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. M. Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
3. M. Gérard BIRCHEN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
4. Mme Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 12 novembre 1979, demeurant
professionnellement à L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur, a été nommée comme gérante de catégorie B
pour une durée indéterminée.
5. M. Tobias STEMMLER, administrateur de sociétés, né à Neunkirchen, Saar (Allemagne), le 18 juillet 1983, demeurant
professionnellement à L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur, a été nommé comme gérant de catégorie B
pour une durée indéterminée.
6. M. Vincent REGNAULT, administrateur de sociétés, né à Anderlecht (Belgique), 4 septembre 1982, demeurant
professionnellement à L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur, a été nommé comme gérant de catégorie B
pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 28 mars 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ISP Luxembourg Canada
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013041217/24.
(130051138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
52567
L
U X E M B O U R G
Morisco International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 86.606.
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2013: -
- Est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2013 la démission de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. en tant
que Commissaire aux Comptes.
- Est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2013 la nomination de FIDUCIAIRE SEVE S.A. ayant son siège social 12D
Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 82421 en tant que Commissaire aux Comptes en rem-
placement de FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2018.
Luxembourg, le 27 février 2013.
<i>Pour MORISCO INTERNATIONAL S.A.i>
Référence de publication: 2013041324/16.
(130050708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Lunala Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 113.716.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 mars 2013i>
Nomination de Monsieur Ioannis ZAIMIS, né le 01/03/1969 à Thessaloniki (Grèce) et demeurant au 2, Rankestrasse,
D-10789 Berlin, Allemagne, au poste d'Administrateur B de la société. Son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée
Générale Annuelle de 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
LUNALA INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013041277/16.
(130050665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Jakadi S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 172.366.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 6 mars 2013 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- LEEWARD FUND MANAGEMENT LTD, Administrateur, Main Street Charlestown, Nevis, Saint-Kitts-et-Nevis,
représenté par son représentant permanent, Monsieur Peter VANDERBRUGGEN, 37 Thurloe Court, Fulham Road, SW3
6SB Londres, Royaume Uni et immatriculé au Registre de Nevis sous le numéro C5939;
- Monsieur Florian BERTHIER, Administrateur, employé privé, 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Peter VANDERBRUGGEN, Administrateur-Président, directeur d'entreprise, 37 Thurloe Court, Fulham
Road, SW3 6SB Londres, Royaume Uni.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.
L'assemblée générale du 6 mars 2013 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- LEEWARD VENTURES PARTNERS, 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B140373.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.
Luxembourg, le 6 mars 2013.
<i>Pour JAKADI S.A.-SPF
i>Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2013041223/22.
(130050623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
52568
L
U X E M B O U R G
IVG Logistics Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 105.222.
<i>Auszug der von der Generalversammlung der Aktionäre am 20. Februar 2013 getroffeneni>
<i>Beschlüssei>
1) Das Mandat des Verwaltungsratsmitglieds Herrn. Oliver KOLLE, ist beendet und wird nicht erneuert.
2) Berufung in den Verwaltungsrat bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2014 des Herr
Philipp Alexander SCHAPER, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 17. Februar 1975 in Itzehoe (Deutschland),
beruflich wohnhaft in D-60549 Frankfurt am Main (Deutschland), The Squaire 18 Am Flughafen.
Luxemburg, den 28. März 2013.
Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für IVG LOGISTICS HOLDING S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013041218/17.
(130051177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Keystone Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 157.691.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 mars 2013i>
L'Assemblée Générale prend connaissance et accepte la démission de Messieurs Ronald Weber, Romain Bontemps et
Ralph Bourgnon de leur mandat respectif d'administrateurs de la société.
L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs sortants:
- M. Cyril Garreau, demeurant au boulevard Brand Whitlock 3/b12; В-1150 Bruxelles, Belgique.
- M. Jean-Pierre Agarra, demeurant au 34, rue du Cornet B-1040 Bruxelles, Belgique.
Leurs mandats expireront lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2013.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013041229/17.
(130050285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Life Point Service, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9662 Kaundorf, 14, Am Ieweschtduerf.
R.C.S. Luxembourg B 133.162.
EXTRAIT
Il résulte d’un procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Life Point Service Sàrl qui s’est tenue
au siège social de la société le 26 mars 2013 que:
1. La société révoque Monsieur Jean-Claude Mardaga de son poste de Gérant avec effet immédiat.
2. Est nommé en tant que gérant, Madame Audrey Sersté, né le 1
er
décembre 1980 à Etterbeek (Belgique), demeurant
professionnellement à 8 ARELERSTROOSS, L-8363-GREISCH, pour une durée indéterminée.
Et suite aux cessions de parts du 27 mars 2013 le capital social est ainsi réparti:
- Madame Audrey SERSTE.: 100 parts sociales,
- Total des parts: 100 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2013.
<i>Pour Life Point Service Sàrl
i>LPL Expert-Comptable Sàrl
Référence de publication: 2013041272/20.
(130050876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
52569
L
U X E M B O U R G
PAA Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 157.008.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique le 20 mars 2013i>
1. Le mandat de gérant A de M. Al SWANSON a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de
2014.
2. Le mandat de gérant A de M. David RABINOWITZ a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2014.
3. Le mandat de gérant B de M. Hugo FROMENT a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de
2014.
4. Le mandat de gérant B de M. Andrew O'SHEA a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de
2014.
Luxembourg, le 27.3.2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PAA Luxembourg
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013041367/20.
(130050298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Pegas Nonwovens SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 112.044.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société le 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2013i>
Le conseil d'administration de la Société tenu en date du 1
er
mars 2013 a décidé, conformément à l'article 8.4 des
statuts de la Société, de réélire en tant qu'administrateur de la société Mr. Marian Rasik, né le 15 mai 1971, demeurant
professionnellement à 3623/86 Primetická, CZ-669 04 Znojmo, République Tchèque. Ce mandat est valable avec effet au
1
er
mars 2013 pour une période de trois années se terminant le 29 février 2016. Cette nomination fera l'objet d'une
confirmation lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 27 mars 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013041370/17.
(130050220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
La Chanterelle Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5533 Remich, 1, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 172.493.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la cession de parts socialesi>
En vertu d'une convention de cession de parts sociales passée sous seing privé en date du 27 mars 2013, à 14 heures,
Madame Isabelle BOLLET, née le 13 mars 1958 à Amnéville (France), demeurant à 15, Rue de la Treille - F-57 480
Contz-les-Bains (France),
a cédé 75 (soixante-quinze) parts sociales de la Société à Monsieur Franck PERIQUET, né le 07 août 1967 à Thionville
(France), 15, Rue de la Treille - F-57 480 Contz-les-Bains (France),
Remich, le 27 mars 2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013041259/17.
(130050430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
52570
L
U X E M B O U R G
Randstad Recruitment & Selection S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 82.565.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Maître François BROUXEL, lawyer, residing in Luxembourg,
acting as duly authorized and empowered representative of RANDSTAD RECRUITMENT & SELECTION S.A., a public
limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at
41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 82565, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg enacted on 23 May
2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1201 of 20 December 2001, which
articles of association have been amended for the last time by a deed received by the undersigned notary on 15 November
2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2843 of 23 November 2012, hereafter
referred to as the "Absorbing Company",
ROWLANDS INTERNATIONAL S.A., a public limited liability company (société anonyme), having its registered office
at 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 103168, incorporated pursuant to a deed of Maître Léon Thomas Metzler, notary residing in Luxembourg enacted on
24 September 2004 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1220 of 29 November
2004, which articles of association have been amended for the last time by a deed received by Maître Léon Thomas
Metzler on 3 February 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 528 of 2 June
2005, and
TEMPO-TEAM HR SERVICES, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 133535, incorporated under the name "VEDIOR HR SERVICES" pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, enacted on 5 November 2007 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2868 of 11 December 2007, which articles of association have been amended for the last time by
a deed received by Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg on 7 October 2008, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 2658 dated 30 October 2008, hereafter collectively with ROWLANDS
INTERNATIONAL S.A., the "Absorbed Companies" and collectively with ROWLANDS INTERNATIONAL S.A. and
TEMPO-TEAM HR SERVICES referred to as the "Merging Companies",
by virtue of a power granted to him pursuant to the resolutions of the respective board of directors or managers of
each of the Merging Companies taken on 12 November 2012.
A copy of these resolutions shall remain appended to the present deed to be filed with it with the registration autho-
rities.
Such appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to record the fol-
lowing:
1. That pursuant to the deed of the undersigned notary dated 15 November 2012, the boards of directors or managers
of each of the Merging Companies have adopted a common merger project, in order to proceed with the merger by
absorption of the Absorbed Companies into the Absorbing Company, with effect as at 31 December 2012 between the
Merging Companies and from an accounting perspective.
2. That Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the share capital of the Absorbed Companies and
the merger will be carried out pursuant to the simplified merger procedure set forth by Articles 278 et seq. of the Law.
3. That the boards of directors and managers of the Absorbing Company and the Absorbed Companies have drawn
the draft common terms of merger in accordance with articles 261 and 278 of the Law.
4. That the common terms of merger have been enacted by notarial deed on 15 November 2012 and published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 2843 dated 23 November 212, i.e. at last one month
before the merger takes effect between the Merging Companies.
5. That the sole shareholder of the Merging Companies was entitled at least one month before the mergers have
become effective, to inspect at the registered office of these companies, the documents and information referred to in
Article 267 (1) a., b. and c. of the Companies Law.
6. That no shareholder of the Absorbing Company has required that an extraordinary general meeting of shareholder
of the Absorbing Company be convened pursuant to article 279 (c) of the Law.
7. That the approval of the merger, either by the general meeting of the Absorbing Company, or by the general meeting
of the Absorbed Companies, is not necessary, the requirements of article 279 of the Law being fulfilled and
8. That the merger between the acquiring company and the acquired companies becomes effective as from 31 De-
cember 2012, and thus the Acquired Companies definitely cease to exist as of such date.
52571
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surnames, Christian
names, civil status and residences, he signed together with Us, notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt sept décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de
RANDSTAD RECRUITMENT & SELECTION S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège
social sis au 41, avenue de la gare, L-1611 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le matricule B 82565, constituée en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire établi à
Luxembourg, du 23 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1201 du 20 décembre
2001, lesquels statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte reçu par le notaire soussigné,
le 15 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2843 du 23 novembre 2012,
ci-après dénommée la «Société Absorbante»,
ROWLANDS INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 5,
place de la Gare, L-1616 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
matricule B 103.168, constituée en vertu d'un acte de Maître Léon Thomas Metzler, notaire de résidence à Luxembourg,
du 24 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1220 du 29 novembre 2004,
lesquels statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte reçu de Maître Léon Thomas
Metzler, le 3 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 528 du 2 juin 2005, et
TEMPO-TEAM HR SERVICES, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis
au 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 133.535, constituée sous la dénomination «VEDIOR HR SERVICES» en vertu d'un acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, entré en vigueur le 5 novembre 2007 et publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 2868 du 11 décembre 2007, lesquels statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour la dernière fois par un acte de Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg le 26 septembre 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2658 du 30 octobre 2008, dénommée ci-après
collectivement avec ROWLANDS INTERNATIONAL S.A. les «Sociétés Absorbées» et collectivement avec ROW-
LANDS INTERNATIONAL S.A. et TEMPO-TEAM HR SERVICES ci-après dénommées les «Sociétés Fusionnantes»,
en vertu d'un pouvoir lui conféré par les résolutions des conseils d'administration des Sociétés Fusionnantes prises en
date du 12 novembre 2012.
Une copie de ces résolutions restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enre-
gistrement.
Lequel comparant, agissant ès-qualités, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1. Que par acte reçu du notaire instrumentant en date du 15 novembre 2012, les conseils d'administration et de
gérance des Sociétés Fusionnantes ont établi un projet de fusion aux termes duquel les conseils d'administration et de
gérance de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées ont décidé de procéder à la fusion par absorption des
Sociétés Absorbées par la Société Absorbante, et ce avec effet au 31 décembre 2012 à l'égard des Sociétés Fusionnantes
et d'un point de vue comptable.
2. Que la Société Absorbante détient l'intégralité du capital social des Sociétés Absorbées et que la fusion sera ac-
complie conformément à la procédure de fusion simplifiée telle que prévue par les articles 278 et suivants de la Loi.
3. Que les conseils d'administration et de gérance des Sociétés Fusionnantes ont arrêté un projet commun de fusion
conformément aux articles 261 et 278 de la Loi.
4. Que ledit projet commun de fusion a été adopté par acte notarié du 15 novembre 2012, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2843 du 23 novembre 2012, soit un mois au moins avant que la fusion ne
devienne effective entre les Sociétés Fusionnantes.
5. Que l'actionnaire unique des Sociétés Fusionnantes a été en mesure, durant une période d'au moins un mois avant
que la fusion ne devienne effective, de prendre connaissance au siège social de ces sociétés de tous les documents et
informations énumérés à l'article 267 paragraphe (1) a., b. et c. de la Loi.
6. Qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a exigé qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la Société Absorbante ne soit convoquée conformément à l'article 279 (c) de la Loi.
52572
L
U X E M B O U R G
7. Que l'approbation de la fusion, que ce soit par l'assemblée générale de la Société Absorbante ou par l'assemblée
générale des Société Absorbées, n'est pas nécessaire, les conditions de l'article 279 de la Loi étant remplies, et
8. Que la fusion entre la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées devient effective à partir du 31 décembre 2012
et les Sociétés Absorbées cesseront donc définitivement d'exister à cette date.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses noms, prénoms, états et
demeures, il a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: François BROUXEL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2013. Relation GRE/2013/94. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Junglinster, le 6 mars 2013.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2013033367/133.
(130040243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2013.
Utu Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.422.800,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 127.987.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 25 mars 2013i>
Les associés de la Société ont décidé en date du 25 mars 2013:
- d’accepter la démission de Monsieur Jean-Robert Bartolini en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013041503/12.
(130050607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Web Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 175.697.
STATUTS
L'an deux mille treize, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Raphaël AUWERKERKEN, né à Knokke-Heist - Belgique, le 12 mars 1990 et résident au 14 rue des Prunelles,
L-5639 Mondorf-les-Bains.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a
arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, les prestations de conception,
de développement, de mise en œuvre et de maintenance de sites Web, ainsi que toutes prestations de services dans le
domaine de la communication, de la publicité, de l'informatique, de la télématique, du commerce électronique et de
solutions d'e-commerce.
Elle fournira et assurera tous services administratifs et de secrétariat à toutes entreprises, organisations et sociétés.
La société a par ailleurs pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
52573
L
U X E M B O U R G
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".
La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter,
ainsi que procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immo-
biliers, terrains à bâtir y compris.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: "WEB CONSULTING S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Windhof.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts
sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de
l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont révocables ad nutum.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Les gérants peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si
les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les gérants qui y
ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les gérants auront les mêmes effets que les réso-
lutions adoptées lors des réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut également prendre ses décisions
par voie circulaire.
Dans les rapports avec les tiers, les gérants auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et
approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.
Le gérant, ou en cas de pluralité des gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité des gérants, le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération
(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
52574
L
U X E M B O U R G
La Société sera engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de plusieurs gérants, par la signature conjointe
de deux membres du conseil de gérance.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, avec effet au 31 décembre, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
dresse l'inventaire, le bilan et le compte de pertes et profits conformément à la Loi.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire, du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de
la Société.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le
capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à
sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Art. 19. Toutes les matières non régies par les présents Statuts seront soumises aux dispositions de la Loi, telle qu'elle
a été ou sera modifiée en temps opportun.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces,
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été
prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associé a pris les résolutions suivantes:
1) Monsieur Raphaël AUWERKERKEN, né le 12 mars 1990 à Knokke-Heist, Belgique et domicilié au 14, rue des
Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains, est nommé gérant de la société.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale des associés qui se tiendra en l'an 2018.
2) Le siège social de la Société est fixé au 20, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof.
3) La première année sociale commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2013.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
52575
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. AUWERKERKEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 1
er
mars 2013. Relation: LAC/2013/9560. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2013033272/137.
(130040111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2013.
Algen Technologie Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten.
R.C.S. Luxembourg B 175.798.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend dreizehn, den sechsten März.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- Frau Ina REHORST, Kauffrau, wohnhaft in D-48493 Wettringen, Frankostrasse, 16.
2.- Herr Johannes HULLEGIE, Techniker/Industriemeister, wohnhaft in D-59510 Lippetal, Roggenkamp 24.
3.- Die Aktiengesellschaft Delta Realestate S.A. mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 10, an den Längten, eingetragen beim
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 142.277 (NIN 2008 2228 609),
hier rechtsgültig vertreten durch den Delegierten des Verwaltungsrates Herrn Marc ROHLFS, Kaufmann, wohnhaft
in D-18273 Güstrow, Pferdemarkt 19.
Welche Komparenten, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt, den handelnden Notar ersuchten die Satzungen
einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:
I. - Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital
Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Algen Technologie Luxembourg S.A.“.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck:
- die Vermarktung, Planung, Koordinierung und Bau von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien zur Produktion
der daraus resultierenden Rohstoffe für die weiterverarbeitende Industrie.
- die Forschung, Entwicklung und Optimierung von Algenproduktionsanlagen in geschlossenen Systemen.
- das Betreiben von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien und Vermarktung der daraus resultierenden Pro-
duktion.
- die Durchführung sämtlicher industrieller, wirtschaftlicher Geschäfte und deren finanzieller Planung, welche direkt
oder indirekt mit der Gründung, der Verwaltung und der Finanzierungsplanung dieser Geschäfte zusammenhängen.
- die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet erscheinen. Sie
kann insbesondere Unternehmen, deren Unternehmensgegenstände ihrem eigenen gleich oder ähnlich sind, gründen, sie
erwerben, pachten, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten; weiter ganz oder
teilweise ihren Betrieb verpachten oder die Betriebsführung Dritten überlassen.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt und beginnt am Tage der Gründung.
Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzli-
chen Bestimmungen durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre erfolgen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000,-) und ist aufgeteilt in drei
hundert zehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je EIN HUNDERT EURO (€ 100,-).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden
Aktien.
Art. 6. Das Grundkapital kann durch Beschluss einer außergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre erhöht
oder herabgesetzt werden.
52576
L
U X E M B O U R G
Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen gesetzlichen Formen und Voraussetzungen ge-
nügen.
II. - Verwaltung und Aufsicht
Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern. Auch Nicht-
Gesellschafter können dem Verwaltungsrat angehören.
Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsrats-
mitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächstfol-
gende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.
Die Amtsdauer des Verwaltungsrates beträgt höchstens sechs (6) Jahre.
Art. 8. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vor-
sitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen.
Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-
tungsratsmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.
In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch telegrafisch zur Tagesordnung
abzustimmen.
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auss-
chlaggebend.
Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet. Abs-
chriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden von dem
Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfüllung
des Gesellschaftszweckes notwendig erscheinenden Verfügungen und Verwaltungsmaßnahmen.
Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz und laut den gegenwärtigen
Statuten vorbehaltene Beschlüsse.
Art. 11. Die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäfts-
führung, kann Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten, ob Aktionäre oder nicht,
vom Verwaltungsrate übertragen werden, welcher deren Befugnisse festlegt. Erfolgt die Übertragung an ein Verwal-
tungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Es steht dem Verwaltungsrat zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu denen er selbst befugt ist.
Dritten gegenüber ist die Gesellschaft in allen Fällen verpflichtet durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei
Verwaltungsratsmitgliedern, wobei die Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes obligatorisch ist.
Zusätzlich wird die Gesellschaft verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes,
handelnd im Rahmen der täglichen Geschäftsführung.
Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied
rechtsgültig vertreten.
Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsi-
denten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Zahl durch die Generalver-
sammlung, die ihre Ernennung vornimmt, festgelegt wird.
Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höchs-
tens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden.
Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.
III. - Generalversammlung
Art. 13. Jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Ak-
tionäre; dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte
zu tätigen und gutzuheißen.
Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am zweiten Freitag des Monats Juni um 10:00 Uhr statt
am Sitz der Gesellschaft oder der an dem in der Einberufung angegebenen Ort.
Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.
Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen Bevoll-
mächtigten vertreten lassen.
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen.
52577
L
U X E M B O U R G
Der Verwaltungsrat kann alle anderen, durch die Aktionäre zu vollbringenden Bedingungen, um an der Generalver-
sammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.
Art. 15. Falls sämtliche Gesellschafter das Gesamtkapital vertreten, können Generalversammlungen auch ohne vorhe-
rige Einberufungen stattfinden.
IV. - Geschäftsjahr und Gewinnverteilung
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember desselben
Jahres.
Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-
schaftskapitals erreicht hat.
Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.
Die etwa auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten
zur Auszahlung. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen Währung
als derjenigen, in der die Bilanz erstellt wird, zu zahlen und dabei den Umrechnungskurs zu bestimmen.
V. - Auflösung, Liquidation, Beglaubigung und Kosten
Art. 18. Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschließen. Bei Auflösung
der Gesellschaft werden Liquidatoren ernannt; zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaf-
ten ernannt werden.
Deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung.
Art. 19. Im Übrigen, besonders hinsichtlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen,
unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen.
Art. 20. Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich, dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August
eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endigt am 31. Dezember 2013.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2014 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die drei hundert zehn (310) Aktien wie folgt zu
zeichnen:
1.- Frau Ina REHORST, Kauffrau, wohnhaft in D-48493 Wettringen, Frankostrasse, 16,
fünfundsiebzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
2.- Herr Johannes HULLEGIE, Techniker / Industriemeister, wohnhaft in D-59510 Lippetal, Roggenkamp 24,
fünfundsiebzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
3.- Die Aktiengesellschaft Delta Realestate S.A. mit Sitz in Grevenmacher, 10, an den Längten,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 142.277,
ein hundert sechzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Total: drei hundert zehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Sämtliche Aktien wurden bis zum Belaufe von fünfundzwanzig Prozent (25%) in bar eingezahlt; machend den Betrag
von SIEBEN TAUSEND SIEBEN HUNDERT FÜNFZIG EURO (€ 7.750,-), wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.
Die Aktien verbleiben Namensaktien bis zu ihrer gänzlichen Einzahlung.
<i>Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft obliegenden Gründungskosten irgendwelcher Art werden abgeschätzt auf ein tausend drei hun-
dert Euro (€ 1.300,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens berufen bekennen und fassten, nachdem sie die
ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die Zahl der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:
52578
L
U X E M B O U R G
a) Herr Marc ROHLFS, Kaufmann, geboren in Bremen (Deutschland), am 9. Januar 1981, wohnhaft in D-18273 Güs-
trow, Pferdemarkt 19.
b) Herr Karl Gerhard HEUTMANN, Kaufmann, geboren in Gronau (Deutschland), am 17. Juli 1948, wohnhaft in
D-48493 Wettingen, Frankostrasse, 16.
c) Herr Hans-Holger HAGENS, Kaufmann, geboren in Bremen (Deutschland), am 20. Januar 1960, wohnhaft in
D-17214 Nossentiner Hütte, Dorfstrasse 6a.
3.- Zum Kommissar wird bestellt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SALCON S.à r.l. mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 10, an den Längten,
eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 107.576.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen General-
versammlung des Jahres 2014.
5.- Die Generalversammlung beschliesst Herrn Marc ROHLFS, vorgenannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates zu
ernennen, sein Mandat endet bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2014, mit der Befugnis die
Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung zu verpflichten und die Gesellschaft gegenüber Dritten im
Rahmen dieser tagtäglichen Geschäftsführung durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig zu vertreten.
6.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6776 Grevenmacher, 10, an den Längten.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Echternach, in der Amtsstube, des amtierenden Notars, am Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unters-
chrieben.
Gezeichnet: I. REHORST, J. HULLEGIE, M. ROHLFS, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 8 mars 2013. Relation: ECH/2013/436. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): J. M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 8. März 2013.
Référence de publication: 2013034491/179.
(130042419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2013.
Atlant Europe RE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 172.755.
In the year two thousand and thirteen, on the eighth day of February.
Before Us Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, acting on behalf of Maître
Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original
of the present deed (hereinafter referred to as the "Notary").
THERE APPEARED:
Atlant Real Estate S.A., a company incorporated on 18
th
March 2011 under the laws of British Virgin Islands, having
its registered office at OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands and being registered
under BVI Business Companies Act 2004 with the number 1638475,
here represented by Mr. Alain Thill, notary clerk, professionally residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg
by virtue of the power of attorney given on 5
th
February 2013 (hereinafter referred to as the "Attorney").
The said power of attorney, initialled ne varietur by the Attorney of the Appearing Party (as such term is defined
below) and the Notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
(hereinafter referred to as the "Appearing Party").
Such Appearing Party is the sole shareholder of Atlant Europe RE S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company
("société à responsabilité limitée"), duly incorporated before Notary Jean Seckler on 14
th
November 2012 and existing
under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 172755, and whose articles of association (hereinafter referred to as the "Articles") have
been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 3016, page 144726, on 13
th
December 2012 and have not been amended since that time (hereinafter referred to as the "Company").
The Appearing Party representing the whole corporate capital requires the Notary to act the following resolutions:
52579
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Appearing Party, on its quality of the sole shareholder of the Company, resolves to increase the issued share
capital of the Company by an amount of eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 87,500.-) in order to raise it from
its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-)
by issuing eighty-seven thousand five hundred (87,500) new shares (hereinafter referred to as the "New Shares"), having
a nominal value of one Euro (EUR 1.-).
The New Shares are issued fully paid up by way of contribution in cash, subscribed and issued as follows:
<i>Subscription and paymenti>
The Appearing Party declares to subscribe to eighty-seven thousand five hundred (87,500) New Shares, each share
having a par value of one Euro (EUR 1.-). Such New Shares are paid up by a contribution (hereinafter referred to as the
"Contribution") in cash for a total amount of eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 87,500.-) fully allocated to
the Company's share capital.
The proof of the existence and of the value of the above Contribution has been produced to the undersigned Notary.
<i>Second resolutioni>
The Appearing Party consequently decides to amend the first paragraph of article 5 of the Company's Articles, which
shall henceforth read as follows:
« Art. 5. Share Capital.
(5.1.) The share capital of the Company is set at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) divided into one hundred
thousand (100,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each."
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at one thousand nine hundred and twenty-five Euro.
Whereof, the present deed is drawn up in Echternach, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned Notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the Appearing Party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the Attorney of the Appearing Party known to the Notary by her name, first name,
civil status and residence, the Attorney of the Appearing Party signed together with the Notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le huit février.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rempla-
cement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte (ci-après le "Notaire").
A COMPARU:
Atlant Real Estate S.A., une société constituée le 18 mars 2011 selon les lois des Îles Vierges Britanniques, ayant son
siège social au OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Îles Vierges Britanniques, et étant enregistrée
en vertu de BVI Business Companies Act 2004 sous le numéro 1638475,
ici représentée par Monsieur Alain Thill, clerc de notaire, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu du mandate octroyé le 5 février 2013 (ci-après le "Mandataire").
La procuration, signée ne varietur par le Mandataire de la Personne Comparante (tel que ce terme est défini ci-dessous)
et par le Notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
(ci-après la "Personne Comparante").
Telle Personne Comparante est l'associé unique d'Atlant Europe RE S.à r.l., une société à responsabilité limitée lu-
xembourgeoise, dûment constituée par devant le Notaire Jean Seckler le 14 novembre 2012 et existante selon les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 172755, et dont les statuts (ci après les "Statuts") ont été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations le 13 décembre 2012, sous le numéro 3016, page 144726, et n'ont pas été modifiés depuis cette date (ci-
après la "Société").
La Personne Comparante représentant la totalité du capital social demande le Notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La Personne Comparante, en sa qualité de l'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social de la
Société d'un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-) afin de le porter de son montant actuel
52580
L
U X E M B O U R G
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-) par l'émission de quatre-vingt sept
mille cinq cents (87.500) nouvelles actions (ci-après les "Nouvelles Actions"), chaque action ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1.-).
Les Nouvelles Actions devant être intégralement libérées par une contribution en numéraire, et devant être souscrites
et émises comme suit:
<i>Souscription et Paiementi>
La Personne Comparante déclare souscrire à quatre-vingt sept mille cinq cents (87.500) Nouvelles Actions, chacune
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-). Ces Nouvelles Actions sont payées par un apport (ci-après l'"Apport")
en numéraire pour un montant total de quatre-vingt sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-), entièrement alloué au
capital social de la Société.
Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'Apport ont été présentés au Notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
La Personne Comparante décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la Société, qui sera
désormais rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital social.
(5.1.) Le capital social de la Société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) divisé en cent mille (100.000) parts
sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune."
<i>Coûts et fraisi>
Les coûts, frais, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement mille neuf cent vingt-cinq euros.
Sur quoi, le présent acte a été établi à Echternach, à la date mentionnée au début du présent acte.
Le Notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que le présent acte est dressé en langue anglaise
suivi d'une traduction française; à la demande de la Personne Comparante et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Après que lecture de l'acte a été faite au mandataire de la Personne Comparante, connu du Notaire par son nom,
prénom, statut civil et lieu de résidence, ledit mandataire de la Personne Comparante a signé ensemble avec le Notaire
le présent acte.
Signé: Alain THILL, Henri Beck.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 février 2013. Relation GRE/2013/717. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Calire PIERRET.
Référence de publication: 2013034003/112.
(130042140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.
AI Northern Star (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 175.793.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the sixth of March.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
"AI Global Investments S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.619,
here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, with professional address in Howald, Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Luxembourg, on 5 March 2013.
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:
1. Corporate form and Name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of "AI Northern
Star (Luxembourg) S.à r.l." (the "Company"), a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated
52581
L
U X E M B O U R G
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as
amended from time to time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including
Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds
and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as invest-
ments, and to sell, exchange and dispose of the same;
3.2 to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease,
mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and
rights of the Company;
3.3 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
3.4 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers
(as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
3.5 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) think fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other
securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the
Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those
securities;
3.6 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for
the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;
3.7 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee
and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital,
principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on
shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect
interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company
or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration
or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part
of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the
purposes of this Article 3.7 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the
payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and
purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of,
or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;
3.8 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;
52582
L
U X E M B O U R G
3.9 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favor of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000.00) represented by fifty thousand (50,000)
shares of one euro (EUR 1.00) each having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles,
"Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other se-
curities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to
the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the
avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.
5.4 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that
representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend
and other payment rights.
7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Share-
holders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;
7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged
by article 189 of the 1915 Law;
7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.
8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil
de gérance (the "Board of Managers").
8.4 A Manager may be removed at any time for any legitimate reason by a Shareholders' Resolution passed in accord-
ance with Luxembourg Law and these Articles.
9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action, which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to rep-
resent and/or bind the Company:
10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, any two Managers;
10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.
11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, any manager may
delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers
52583
L
U X E M B O U R G
and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant con-
ditions of its agency.
12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers
shall appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.
12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's
Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person
or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference telephone, video conference or similar form of communications equipment (initiated from Luxembourg)
provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting.
A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum
and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes
of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than
the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same
place.
12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)
shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned. For the
avoidance of doubt, written resolution shall be avoided in case the Company has to decide any important or strategic
decisions.
12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Manager present at the Meeting.
13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultations, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the
resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders rep-
resenting three quarters of the Shares.
13.5 A resolution to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be
passed by at least half of the Shareholders representing three quarters of the Shares.
13.6 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening
requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities
either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.
13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
13.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed
by written vote of Shareholders rather than at a meeting of Shareholders provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.
14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on 1
st
January each year and ends on the 31
st
of December the same year.
15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
52584
L
U X E M B O U R G
15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these
Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered
from the relevant Shareholder(s).
16. Dissolution and Liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in
accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.
17. Interpretation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative
body (whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifi-
cations) thereof.
17.1.2 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The fifteen thousand (15,000) shares have been subscribed by "AI Global Investments S.à r.l.", prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifty thousand Euro (EUR 50,000.00), is as
of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2013.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.
<i>Resolutions of the sole partneri>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Michael J. RISTAINO, company vice president, born on October 8, 1961 in Massachusetts, United States of
America; residing at 75, State Street, 29
th
Floor, Boston, MA 02109, United States of America;
- Mrs. Myriam DELTENRE, accountant, born on February 16, 1963 in Arlon, Belgium, residing at 48, Le Pas de Loup,
B-6791 Guerlange, Belgium;
- Mr. Fergal O'HANNRACHAIN, accountant, born on 27 November 1964 in Dublin, residing at 7 rue Tubis, L-2629
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mrs. Linda HARROCH, lawyer, born on May 10, 1973 in Casablanca, Marocco, residing at 2, rue de Peternelchen,
L-2370 Howald, Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
52585
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le six mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
«AI Global Investments S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises
ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.619,
ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg le 5 mars 2013.
La procuration, signée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
1. Forme et Nom. Ce document constitue les statuts (les "Statuts") de "AI Northern Star (Luxembourg) S.à r.l." (la
"Société"), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg notamment la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi de 1915").
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) L'associé Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si la Société est administrée par un Associé Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si la Société administrée par un Conseil de Gérance; ou
2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par résolution
des associés de la Société (une "Résolution des Associés") prise en conformité avec ces Statuts - notamment l'article 13.4
- et les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").
2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera
de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par l'Associé Unique ou
le Conseil de gérance, le cas échéant.
2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
3. Objet. L'objet de la Société est:
3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la
Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou
autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute
personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;
3.2 de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger,
louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la
Société;
3.3 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une
partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;
3.4 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Gérant Unique ou le
Conseil de Gérance (tel qu'approprié) estime adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne
avec ou sans garantie;
3.5 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que l'Administrateur Unique
ou le Conseil de Gérance estime adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obli-
gations et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité
ou une partie des biens de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter,
convertir et rembourser ces titres;
3.6 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits,
l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant
tout employé de la Société;
52586
L
U X E M B O U R G
3.7 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et
octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal,
les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre
titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute
personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute
activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par
engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des
actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent
Article 3.9 "garantie" inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement
ou la satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat d'actifs ou
de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de payement, ou d'être respon-
sable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;
3.8 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que
commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou
autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);
3.9 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec
ou en faveur de toute personne) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) considère comme
incitant ou propice à l'accomplissement de tout ou partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie
des pouvoirs de celle-ci;
SOUS RESERVE que la Société n'entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du
secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation
requise par celle-ci.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est de cinquante mille euros (EUR 50.000,00), représenté par cinquante mille (50.000)
parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,00) chacune (les "Parts Sociales"); ayant les droits et obligations tel que
prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales
et "Associé" devra être interprété conformément.
5.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent
être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.
5.3 La Société peut, sans restriction, accepter de l'equity ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou
d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions
relatives à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et
aux présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions au contributeur.
5.4 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.
5.5 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses Parts Sociales conformément à la Loi de 1915.
6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plusieurs personnes sous réserve que tous les détenteurs d'une
Part Sociale notifient par écrit à la Société lequel d'entre eux devra être considéré comme leur représentant; la Société
s'adressera à ce représentant comme s'il était l'unique associé au regard de cette Part Sociale notamment eu égard à
l'exercice du droit de vote, aux dividendes ainsi qu'à tous autres droits à paiement.
7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où la Société ne comprend qu'un seul Associé, les Parts Sociales seront librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où la Société comprend plusieurs Associés:
7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas transmissibles autrement qu'à cause de mort à d'autres personnes que les Associés
à moins que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales aient accepté le transfert en assemblée
générale;
7.2.2 Les Parts Sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à d'autres personnes que les Associés à moins
que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales détenues par les ayants droit aient accepté le
transfert ou dans les circonstances prévues par l'article 189 de la Loi de 1915;
7.2.3 Le transfert de Parts Sociales est soumis aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants ("Gérants") nommés par une Résolution des Associés prise
en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.
52587
L
U X E M B O U R G
8.2 Dans le cas où la Société est administrée par un seul gérant, il est défini ci-après comme le "Gérant Unique".
8.3 En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
8.4 Un gérant pourra être révoqué à tout moment, pour toute cause légitime, par Résolution des Associés prise en
conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.
9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, lorsque la Société n'a qu'un seul gérant, ou dans tous les autres cas, le
Conseil de Gérance, peut prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société,
à l'exception de celles requérant une décision des Associés conformément à la Loi Luxembourgeoise ou aux présents
Statuts.
10. Représentation de la société. Sous réserve des dispositions prévues par la Loi Luxembourgeoise et les présents
Statuts, les personnes suivantes son autorisées à représenter et/ou engager la Société:
10.1 Dans le cas où la Société n'a qu'un Gérant Unique, le Gérant Unique;
10.2 En cas de pluralité de gérants, deux des Gérants;
10.3 Toute personne à qui le pouvoir aura été délégué en conformité avec l'Article 11.
11. Agent des gérants. Le Gérant Unique, ou en cas de pluralité de Gérants, tout gérant, peut déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées et détermine les pouvoirs, responsabilités et la ré-
munération (le cas échéant) de tout mandataire, la durée de représentation de la Société ainsi que toutes autres conditions
de leur mandat.
12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil de Gérance") sont convoquées par tout Gérant.
Le Conseil de Gérance nommera un président.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil de
Gérance sans convocation préalable si tous les gérants ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors
de la dite Réunion du Conseil de Gérance en personne ou par un représentant autorisé.
12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une Réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant
(à l'exclusion de toute autre personne), pour assister, délibérer, voter et exécuter ses fonctions en son nom lors de cette
Réunion du Conseil de Gérance. Un Gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs autres Gérants lors d'une
Réunion du Conseil de Gérance sous réserve que (et tant que les conditions de quorum sont satisfaites) au moins deux
Gérants soient physiquement présents à la Réunion du Conseil de Gérance tenue en personne ou participent à la Réunion
du Conseil de Gérance tenue conformément à l'Article 12.5.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
12.5 Tout Gérant ou son représentant peut valablement participer à une Réunion du Conseil de Gérance par confé-
rence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire (initiée depuis le Luxembourg)
sous réserve que chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les autres participants tout au
long de la réunion. Ledit participant sera réputé présent à la réunion, sera comptabilisé dans le quorum et habilité à
prendre part au vote. Conformément à la Loi Luxembourgeoise, toute affaire conclue de telle manière par les Gérants
sera, pour les besoins de ces Statuts, réputée valablement et effectivement conclu par le Conseil de Gérance, nonobstant
le fait que le nombre de Gérants (ou leur représentant) physiquement présents au même endroit est inférieur au nombre
requis.
12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou pour tout Gérant, son représentant), est valide et effective
comme si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue et peut être
documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu, signés par ou au nom d'un
ou plusieurs des Gérants. Les résolutions écrites devront être évitées en cas de prise de décisions importantes et stra-
tégiques.
12.7 Les procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance sont signés et les extraits de ces procès-verbaux certifiés
par tous les Gérants présents aux réunions.
13. Résolutions des associés.
13.1 Tout Associé dispose d'un vote pour chaque action qu'il détient.
13.2 Comme prévu aux Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valablement prises seulement si
les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent, toutefois si le quorum n'est pas atteint lors de la
première réunion ou première consultation écrite, les Associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois,
par lettre recommandée avec accusé de réception et la résolution pourra être prise à la majorité des votes enregistrés,
sans tenir compte du nombre de Parts Sociales représentées.
13.3 Le changement de nationalité de la Société ainsi que l'accroissement des participations des Associés dans la Société
requièrent l'unanimité.
13.4 Tel qu'il est prévu à l'Article 13.3, toute résolution modifiant les Statuts (y compris un changement de Siège Social)
ne peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.
52588
L
U X E M B O U R G
13.5 Une résolution visant à déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou à nommer les liquidateurs ne
peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.
13.6 Une assemblée des Associés peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si
tous les Associés ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite assemblée en personne ou
par représentant autorisé.
13.7 Un Associé pourra être représenté à une assemblée des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail
ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
13.8 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, les Résolutions des Associés pourront être prises par écrit et non en
assemblée, sous réserve que chaque Associé reçoive le texte exact des résolutions et des décisions à adopter et donne
son vote part écrit.
14. Exercice social.
14.1 L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier chaque année et se termine le 31 décembre de la même
année.
15. Distribution des parts.
15.1 Du bénéfice net, déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent seront prélevés et alloués
à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint
dix pour cent du capital nominal de la Société.
15.2 Dans le respect de la Loi luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société peut distribuer des dividendes
conformément aux droits respectifs des Associés.
15.3 Le Gérant unique ou le Conseil de Gérance, le cas échéant, peut décider de payer des dividendes intérimaires au
(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon les présents Statuts
et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées
par l'associé(s).
16. Dissolution et Liquidation. La dissolution de la Société sera décidée par l'assemblée des Associés en conformité
avec la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13. Si à tout moment il n'y a qu'un seul Associé, celui-ci peut à sa propre discrétion,
décider de liquider la Société en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et dettes, connus ou inconnus, de la
Société.
17. Interprétation et Loi Luxembourgeoise.
17.1 Dans les présents Statuts:
17.1.1 Une référence à:
(a) un genre inclut tous les genres;
(b) (à moins que le contexte ne requiert autrement) l'utilisation du singulier inclut le pluriel et inversement;
(c) une "personne" inclut la référence à tout particulier, entreprise, corporation et autre entité sociétaire, gouverne-
ment, état ou organisme d'état ou toute société commune, association ou partenariat, ou tout corps syndical (qu'il ait ou
non une personnalité juridique propre);
(d) une disposition légale ou loi inclut toutes modifications et toutes refontes de celle-ci (avec ou sans modification).
17.1.2 Les titres contenus dans les présents Statuts n'affectent pas leur interprétation.
17.2 En sus des présents Statuts, la Société est aussi soumise à toutes dispositions applicables de la Loi Luxembour-
geoise.
<i>Souscription et Libérationi>
«AI Global Investments S.à r.l.», prénommée, a souscrit l'ensemble des cinquante mille (50.000) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille euros
(EUR 50.000,00) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2013.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents euros.
52589
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Michael J. RISTAINO, vice-président de société, né le 8 octobre 1961 à Massachusetts, Etats-Unis d'Amé-
rique, demeurant au 75 State Street, 29
th
Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis d'Amérique;
- Madame Myriam DELTENRE, comptable, née le 16 février 1963 à Arlon, Belgique, demeurant au 48, Le Pas de Loup,
B-6791 Guerlange, Belgique;
- Monsieur Fergal O'HANNRACHAIN, comptable, né le 27 Novembre 1964 à Dublin, demeurant au 7 rue Tubis,
L-2629 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Madame Linda HARROCH, avocat, née le 10 mai 1973 à Casablanca, Maroc, résidant au 2, rue Peternelchen, L-2370
Howald-Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 mars 2013. Relation: EAC/2013/3286. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2013034503/482.
(130042378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2013.
LF Hotels Acquico I SCS, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 175.791.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of February.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. "LF Hotels Acquico I (GP) S.à.r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913 Grand
Duchy of Luxembourg, being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxem-
bourg) (RCS) under B 155838 and having a share capital of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-), and has been
incorporated on September 9
th
, 2010 pursuant to a deed of Maître Joelle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on November 11
th
, 2010
(hereinafter the "General Partner"), and
2. "Leopard Germany Holding Hotels S.à.r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 12, Rue Léandre Lacroix,
L-1913 Grand Duchy of Luxembourg, being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(R.C.S. Luxembourg) (RCS) under B 155841 and having a share capital of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-), and has
been incorporated on September 9
th
, 2010 pursuant to a deed of Maitre Joelle Baden, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on November 11
th
,
2010, (hereinafter, the "Initial Limited Partner")
3. "Fattal Hotels Ltd (Israel)", a limited liability company, duly formed and registered on March 29
th
1974 with the
Israeli registrar of Companies, under the Israeli Companies Law, and registered with the Israeli Registrar of Companies
under the number 51-067881-6 (hereinafter, the "Second Limited Partner"),
and all those who may become limited members in the future are collectively herein referred to as the limited partners
(the "Limited Partners"),
Both represented by Bakary Sylla, with professional address at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, by virtue
of two proxies given under private seal on 14 February 2013,
52590
L
U X E M B O U R G
Said proxies, after signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, represented as here above, have requested the notary to document the limited partnership
(société en commandite simple) created between them and its articles of association (the "Articles of Association") as
follows:
Art. 1. Form - Name. There is hereby formed by the undersigned among the subscribers and all those who may become
holders of interests hereafter issued, a Luxembourg limited partnership (société en commandite simple) which will be
governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Companies Law"), and by these
Articles of Association, under the name of "LF Hotels Acquico I (GP) SCS" (the "Partnership").
Art. 2. Registered office. The principal place of business of the Partnership shall be located at 12, rue Léandre Lacroix,
L-1913 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the
general meeting of the Limited Partners.
Art. 3. Duration. The Partnership has been established for an unlimited period.
Art. 4. Object and Investment objectives.
(1) The purpose of the Partnership is the direct or indirect holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign real estate companies and any other form of real estate investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer of securities of any kind by sale, exchange or otherwise and
the administration, control and development of its real estate portfolio located in Germany.
(2) The purpose of the Partnership is also to invest in real estate property, either by means of purchase, exchange or
such other manners as well as the disposal, the administration, the development and the management of real estate
property, and to carry out any operation relating directly or indirectly thereto or which it may deem useful in the
accomplishment and development of this purpose.
(3) The Partnership may further guarantee, borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures by
way of private placement or grant loans in any other form or otherwise assist the companies in which it holds a direct
or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Partnership.
(4) The Partnership may further act as a member with limited liability for all debts and obligations of memberships or
similar corporate structures.
(5) The Partnership may carry out any transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly
connected with its corporate object, at the exclusion of any regulated activity, and engage in any lawful act or activity and
exercise any powers permitted under the Companies Law, that, in either case, are incidental to and necessary or con-
venient for the accomplishment of the above mentioned purposes; provided that same are not contrary to the foregoing
purposes and are not otherwise prohibited by any agreements to which the Partnership may then be a party.
(6) The above enumeration is indicative and not limitative, provided that any aforementioned purpose is subject to
applicable Luxembourg laws, in particular the provisions of the Companies Law.
Art. 5. Liabilities.
(1) The Limited Partners shall have no personal obligation for the debts or liabilities of the Partnership except as
provided in the Articles of Association and in the Companies Law and shall only be liable to make capital contributions
to the Partnership to the extent of their respective commitments to the Partnership.
(2) The General Partner, which is acting as the manager of the Partnership shall be fully liable for the Partnership's
debts, liabilities and obligations exceeding the Partnership's assets.
Art. 6. Capital. The Partnership's initial capital is set at twenty thousand and one Euro (EUR 20,001.-), divided into one
(1) General Partner's interest of one Euro (EUR 1.-) and twenty-thousand (20,000) Limited Partners' interests of one
Euro (EUR 1.-) each.
The Limited Partners' interests may be issued in one or more classes.
The total cash contributions of the General Partner and the Initial Limited Partner have been fully paid in.
The General Partner may agree to increase the capital of the Partnership at any time by a decision of the general
meeting of the Limited Partners with approval of the majority of the Limited Partners representing three quarters of the
Partnership interests and the corresponding number of additional interests without par value shall be issued by the
Partnership.
Art. 7. Form of Interests.
(1) The Partnership shall issue interests in registered form only.
(2) All issued interests shall be registered in the register of partners kept by the General
Partner, and such register shall contain the name of each owner of interests, his residence or elected domicile as
indicated to the Partnership and the number of interests held by him and the amount paid up for the subscription of such
interests. The inscription of the Partner's name in the register evidences his right of ownership on such interests.
52591
L
U X E M B O U R G
(3) Limited Partners shall provide the Partnership with an address to which all notices and announcements may be
sent. Such address will also be entered into the register of partners. A Limited Partner may, at any time, change his address
as entered into the register by means of a written notification to the Partnership at its registered office, or at such other
address as may be set by the General Partner from time to time.
(4) The Partnership recognises only one single owner per interest. If one or more interests are jointly owned or if the
ownership of such Interests is disputed, all persons claiming a right to such interests have to appoint one single attorney
to represent such interests towards the Partnership. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights
attached to such interests.
Art. 8. Restrictions on the ownership of Interests. The General Partner may restrict or prevent the ownership of
interests by any person, for any reason whatsoever. In particular, without any limitation, the General Partner may restrict
or prevent the ownership of interests, if in the opinion of the General Partner such holding may be detrimental to the
Partnership, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourgish or foreign; or if as a result
thereof the Partnership may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have
otherwise incurred.
Art. 9. Conversion and Transfer of Interests.
(1) The General Partner may only sell, assign, transfer, pledge or encumber (together "transfer") all or any portion of
its General Partner's Interest, if such sale, assignment, transfer, pledge or encumbrance (together "transfer") is approved
by a resolution of the general meeting adopted in the manner required to amend the Articles of Association.
(2) A Limited Partner may not transfer his interests except with the prior written consent of the General Partner,
which shall not be unreasonably withheld. Any transfer is subject to the purchaser, assignee, transferee, pledgee or
beneficiary of the encumbrance thereof (together "transferee") fully and completely assuming in writing, prior to the
transfer, all outstanding obligations of the Limited Partner selling, assigning, transferring, pledging or encumbering the
Interests (together "transferor").
(3) Transfers of interests must be made by a notarial or a private deed. They are not valid vis-à-vis the Partnership
and the third parties until they have been notified to the Partnership or accepted by the Partnership through a notarial
deed.
Art. 10. Management. The Partnership shall be managed by the General Partner or its successor as the case may be,
in its capacity as a sole general partner (associé gérant commandité) of the Partnership.
Any change in the management or replacement of the General Partner will have to be agreed upon by the general
meeting of the Limited Partners.
Art. 11. Powers of the General Partner.
(1) The General Partner shall have the broadest powers to administer and manage the Partnership, to act in the name
of the Partnership in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate
object of the Partnership.
(2) The General Partner has all powers and capacity to represent the Partnership vis-à-vis third parties.
(3) All powers not expressly reserved by law or these Articles of Association to the general meeting shall be within
the competence of the General Partner.
Art. 12. Restrictions on the Limited Partners. The Limited Partners shall take no part in the operation of the Partnership
or the management or control of its business and affairs, and shall have no right or authority to act for the Partnership
or to take any part in or in any way to interfere in the conduct or management of the Partnership or to vote on matters
relating to the Partnership other than as provided in the Companies Law or as set forth in the Articles of Association.
Art. 13. General meeting of the Limited Partners. The general meeting of Limited Partners shall represent the entire
body of Limited Partners of the Partnership. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Partnership, provided that, unless otherwise provided herein, no resolution shall be validly passed
unless approved by the General Partner.
The general meeting of Limited Partners shall meet upon call by the General Partner.
An annual general meeting of Partners shall be held on the third Friday of the month of July at 10.00 a.m. for the
purpose of approving the annual accounts and the report of the General Partner. The General Partner shall have sole
responsibility for preparing the annual accounts and the report and shall submit the relevant documents for approval of
the Limited Partners at the above mentioned meeting.
Other meetings of Limited Partners may be held at such places and times as may be specified in the respective notices
of meeting.
General meetings of Limited Partners shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least
eight days prior to the meeting to each Limited Partner at the Limited Partner's registered address. The giving of such
notice to Partners needs not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared by the General Partner.
As all interests of the Partnership are in registered form, notices to Limited Partners may be mailed by registered mail
only.
52592
L
U X E M B O U R G
If all Limited Partners are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of
the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by the Limited Partners in order to
attend any meeting of Limited Partners.
All general meetings shall be presided over by the General Partner or its designee.
The business transacted at any meeting of the Limited Partners shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
The General Partner may fix in advance a date, not exceeding fifty days, preceding the date of any meeting of Limited
Partners as a record date for the determination of the Limited Partners entitled to notice of, and to vote at, any such
meeting and in such case such Limited Partners and only such Limited Partners as shall be Limited Partners of record on
the date so fixed shall be entitled to such notice of, and to vote at, such meeting, notwithstanding any transfer of any
interests of the Partnership on the register of Limited Partners after any such record date fixed as aforesaid.
Each interest of the Partnership is entitled to one vote at all general meetings of Limited Partners, in compliance with
Luxembourg law and the Articles of Association. A Limited Partner may act at any meeting of Limited Partners by giving
a written proxy to another person, who need not be a Limited Partner.
The presence, in person or represented by proxy, of Limited Partners whose aggregate voting rights constitute a
majority of all voting rights shall constitute a quorum. If a meeting of the Limited Partners cannot be organised because
a quorum shall not be present or represented, the Limited Partners entitled to vote at such meeting, present in person
or represented by proxy, shall have the power to adjourn the meeting from time to time until a quorum shall be present
or represented. When a meeting is adjourned to another time or place, notice need not be given of the adjourned meeting
if the time and place thereof are announced at the meeting at which the adjournment is taken. At the adjourned meeting
at which a quorum shall be present or represented, the Limited Partners may transact any business which might have
been transacted at the original meeting.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting, including in particular approval of the
annual accounts and changes in interest capital are passed, subject to the approval by the General Partner, by a simple
majority vote of the Limited Partners present or represented.
Art. 14. Statutory auditor. The operations of the Partnership shall be supervised by a statutory auditor, who needs
not be Limited Partner. The statutory auditor shall be appointed by the annual general meeting of the Limited Partners
for a period beginning at the end of the annual general meeting of the Limited Partners meeting and ending at the date
of the next annual general meeting of the Limited Partners.
Art. 15. Accounting year. The Partnership's accounting period starts on the 1
st
April and ends on the 31
st
March of
the following year.
Art. 16. Allocation of profits and losses between Limited Partners.
All profits and losses of the Partnership shall be allocated between the Limited Partners in proportion to the number
of Partnership interests held by each of them in the Partnership.
Art. 17. Distribution of income proceeds and Capital proceeds between Limited Partners. All proceeds of the Part-
nership shall be distributed by the general meeting of the Limited Partners, upon proposal of the General Partner.
Art. 18. Conflicts of interest. No contract or other transaction between the Partnership and any other company or
firm shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner or any one or more of the officers of the General
Partner is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any officer of the
General Partner who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Part-
nership shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or
firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any officer of the General Partner may have in any transaction of the Partnership an interest opposite
to the interests of the Partnership, such officer shall make known to the General Partner such opposite interest and shall
not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such officer's interest therein shall be reported
to the next succeeding general meeting of the Limited Partners.
The term "opposite interest", as used in the preceding paragraph, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be
determined by the General Partner on its discretion.
Art. 19. Indemnification and Liability.
(1) The Partnership agrees to indemnify and hold harmless out of the Partnership's assets any of the General Partner
or any associate thereof (the "Indemnified Persons") against any and all liabilities, actions, proceedings, claims, costs,
demands, damages and expenses (including legal fees) incurred or threatened arising out of or in connection with or
relating to or resulting from the Indemnified Person being or having acted as a general partner or manager in respect of
the Partnership or arising in respect of or in connection with any matter or other circumstance relating to or resulting
from the exercise of its powers as a general partner or manager or from the provision of services to or in respect of the
52593
L
U X E M B O U R G
Partnership or under or pursuant to any management agreement or other agreement relating to the Partnership or in
respect of services as a nominated director or which otherwise arise in relation to the operation, business or activities
of the Partnership provided however that any Indemnified Person shall not be so indemnified with respect to any matter
resulting from their fraud, wilful misconduct, bad faith or reckless disregard for their obligations and duties in relation to
the Partnership or, save in the case of Indemnified Persons who are individuals (i.e. any officer, director, limited partner,
agent, member, adviser, consultant, partner or employee of the General Partner, the services providers or any associate
thereof), their negligence (provided that such negligence has had a material adverse economic effect on the partners or
the Partnership), or, in the case of the General Partner, any matter resulting from a breach of any duty it may have, or
any liability it may incur, to the Partnership or any Limited Partner under the Companies Law.
(2) The indemnities under this Article 18 shall continue in effect notwithstanding that the Indemnified Person shall
have ceased to act as General Partner or otherwise to provide services to or in respect of the Partnership or to act in
any of the capacities described in this Article 18.
(3) The General Partner shall not be liable to any Limited Partner or to the Partnership for the negligence, dishonesty
or bad faith of any agent acting for the General Partner or for the Partnership provided that such agent was selected,
engaged and retained by the General Partner, applying reasonable care.
Art. 20. Dissolution and Liquidation. The Partnership may at any time be dissolved by a resolution of the general
meeting subject to the quorum and majority requirements of the general meeting of Limited Partners.
Liquidation shall be carried out by the General Partner, unless the general meeting of the Limited Partners appoints
one or more other liquidators who need not be Limited Partners. The general meeting shall in each case determine the
powers and compensation of any liquidator(s). The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to
the Limited Partners in proportion to their Interest in the Partnership.
Art. 21. Amendments of the Articles of Association. The Articles of Association may only be amended (whether in
whole or in part) by the written consent of the General Partner and of the Limited Partners holding more than two thirds
of the aggregate number of all classes of interests of the Partnership issued, provided however that no such variation shall
be made which:
- shall impose upon any Limited Partner any obligation to make any further payment to the Partnership beyond the
amount of its original subscription;
- increases the liabilities of or obligations of, or diminishes the rights of or protections of, a particular Limited Partner
or a particular group of Limited Partners differently than the other Limited Partners under the Articles of Association;
or
- otherwise modifies the limited liability of any Limited Partner, without the affirmative consent of all Limited Partners
adversely affected thereby and provided further that no variation may be made to this Article 25 without the unanimous
consent of all Limited Partners.
Art. 22. Governing law. The Articles of Association and the rights, obligations and relationships of the parties hereto
shall be governed by and construed in accordance with the laws of Luxembourg and in particular by the Companies Law
and all the parties irrevocably agree that the courts of Luxembourg shall have exclusive jurisdiction to settle any disputes
which may arise out of or in connection with the Articles of Association and that accordingly any suit, action or procee-
dings arising out of or in connection with these Articles of Association shall be brought in such courts.
Art. 23. General provision. For everything that is not provided for in the Articles of Association, the parties refer to
the legal provisions on the matter.
<i>Transitional dispositions:i>
<i>First accounting yeari>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Partnership and shall terminate on 31
st
March
2013.
<i>First annual meetingi>
The first annual general meeting of the Limited Partners shall take place in the year 2013.
<i>Subscription and Liberation:i>
The General Partner, LF Hotels Acquico I (GP) S.à.r.l., prenamed, makes a contribution in the amount of one Euro
(EUR 1.-) totally paid-up as certified by a banking certificate delivered to the notary, for which it is granted the single
General Partner's Interest.
The Initial Limited Partner, Leopard Germany Holding Hotels S.a.r.l., prenamed, makes a contribution in the amount
of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) totally paid-up as certified by a banking certificate delivered to the notary, for
which it is granted one hundred limited partners' interests.
52594
L
U X E M B O U R G
The Second Limited Partner Fattal Hotels Ltd (Israel), makes a contribution in the amount of five thousand Euro (EUR
5,000.-) totally paid-up as certified by a banking certificate delivered to the notary, for which it is granted one hundred
limited partners' interests
<i>Costsi>
The amount of costs, expenditures, remunerations and charges, of any kind whatsoever, which lies on the Partnership
due to the presents, are estimated at an amount of EUR 1,579.-.
<i>Extraordinary Limited Partners meetingi>
The aforementioned appearing parties, representing the whole of the capital subscribed and considering themselves
as duly convened, have afterwards formed an extraordinary Limited Partners' meeting.
After having noted that the present meeting is properly formed, they unanimously took the following resolutions:
1. The registered office of the Partnership is fixed at 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded
in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text, the
English version will prevail and be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day written at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney in fact of the persons appearing, he signed together with the notary
the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahr zweitausenddreizehn, am 18. Februar.
Vor Maître Paul Decker, niedergelassener Notar in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Es waren erschienen:
1. „LF Hotels Acquico I (GP) S.à.r.l.", einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
nach im Großherzogtum Luxemburg geltendem Recht, mit eingetragenem Sitz in der Rue Léandre Lacroix Nr. 12, L-1913
Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg statt. Leopard Germany Holding Hotels S.à.r.l. verfügt über ein Grundkapital
von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) und wurde am 09. September 2010 durch einen Rechtsakt von Maître Joëlle
Baden, niedergelassener Notar in Luxemburg, Großherzogtum Luxembourg gegründet, am 11. November 2010 im Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wordne (im Folgenden „Komplementär"), und
2. „Leopard Germany Holding Hotels S.à.r.l.", einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) nach im Großherzogtum Luxemburg geltendem Recht, mit eingetragenem Sitz in der Rue Léandre Lacroix Nr.
12, L-1913 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg statt. Leopard Germany Holding Hotels S.à.r.l. verfügt über ein
Grundkapital von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) und wurde am 09. September 2010 durch einen Rechtsakt von
Maître Joëlle Baden, niedergelassener Notar in Luxemburg, Großherzogtum Luxembourg gegründet, am 11. November
2010 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht worden (im Folgenden „anfänglicher Komman-
ditist"),
3. „Fattal Hotels Ltd (Israel)", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die am 29. März 1974 ordnungsgemäß nach
israelischem Gesellschaftsrecht gegründet wurde und beim israelischen Registergericht unter der Nummer 51-067881-6
eingetragen ist (im Folgenden „zweite Kommanditist"),
und alle, die in Zukunft Kommanditist werden können, werden hier zusammen Kommanditisten („Kommanditisten")
genannt.
Beide werden von Bakary Sylla, mit der Geschäftsanschrift 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxemburg auf der Grund-
lage von zwei privatschriftlichen Vollmachten vom 14. Februar 2013 vertreten.
Die Vollmachten, die den Vermerk „ne varietur" der erschienenen Partei und des Notars tragen, verbleiben für die
Zwecke der Eintragung im Anhang zu der vorliegenden Urkunde.
Die erschienenen Parteien, die wie vorstehend angegeben vertreten sind, bitten den Notar um die Dokumentierung
der von ihnen gegründeten Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) sowie der zugehörigen Satzung („Sat-
zung") wie folgt:
Art. 1. Form - Name. Hiermit wird von den Unterzeichneten unter den Zeichnern [sic] und allen, die u. U. Inhaber
von in Folge ausgestellten Anteilen werden, eine Kommanditgesellschaft nach luxemburgischem Recht (société en com-
mandite simple) gegründet, die den Vorschriften des Gesetzes zu Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der
geltenden Fassung („Gesellschaftsgesetz") und dieser Satzung unterliegt und den Namen LF Hotels Acquico I (GP) SCS
(„Kommanditgesellschaft") trägt.
Art. 2. Eingetragener Geschäftssitz. Der Hauptgeschäftssitz der Kommanditgesellschaft ist in der 12, rue Léandre
Lacroix, L-1913 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
52595
L
U X E M B O U R G
Der Sitz kann auf der Grundlage eines Beschlusses der Hauptversammlung der Kommanditisten an jeden anderen Ort
innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 3. Laufzeit. Die Kommanditgesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Gegenstand und Anlageziele.
(1) Der Gegenstand der Kommanditgesellschaft ist die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung in beliebiger Form an
luxemburgischen und ausländischen Immobiliengesellschaften und an sonstigen Formen von Immobilienanlagen, die Ak-
quisition durch Kauf, Zeichnung oder auf sonstige Weise, die Übertragung von Wertpapieren jeglicher Art durch Verkauf,
Eintausch oder sonstige Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung des in Deutschland gelegenen Immo-
bilienportfolios.
(2) Der Gegenstand der Kommanditgesellschaft besteht auch in der Anlage in Immobilienobjekte, entweder auf der
Grundlage von Kauf, Eintausch oder auf sonstige Weise, sowie der Veräußerung, Verwaltung, Entwicklung und Leitung
von Immobilienobjekten und Ausführung aller Handlungen, die unmittelbar oder mittelbar damit in Verbindung stehen
oder die beim Erreichen und bei der Entwicklung dieses Gegenstands für nützlich erachtet werden.
(3) Die Kommanditgesellschaft kann darüber hinaus Garantien abgeben, Darlehen jeglicher Art aufnehmen und Schuld-
verschreibungen und Anleihen im Zuge einer Privatplatzierung ausgeben oder Darlehen in anderer Form gewähren oder
die Unternehmen, an denen die Kommanditgesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder die zur gleichen
Unternehmensgruppe wie die Kommanditgesellschaft gehören, auf sonstige Weise unterstützen.
(4) Die Kommanditgesellschaft kann darüber hinaus als Mitglied mit beschränkter Haftung in Bezug auf alle Schulden
und Pflichten der Mitgliedschaft oder ähnliche Gesellschaftsstrukturen handeln.
(5) Die Kommanditgesellschaft darf jede gewerbliche oder finanzielle Transaktion ausführen, die unmittelbar oder
mittelbar mit dem Unternehmensziel verbunden ist, wobei jedoch genehmigungspflichtige Handlungen ausgenommen sind,
und jede rechtmäßige Handlung oder Aktivität und alle Befugnisse ausüben, die gemäß dem Gesellschaftsgesetz gestattet
sind und die jeweils mit dem Erreichen des vorstehend genannten Gegenstands einhergehen oder dafür notwendig oder
zweckdienlich sind, wobei diese jedoch dem vorstehend genannten Gegenstand nicht entgegenstehen und auch sonst
nicht gegen Verträge verstoßen dürfen, bei denen die Kommanditgesellschaft u. U. als Partei auftritt.
(6) Obige Aufzählung ist beispielhaft und nicht begrenzend, wobei jedoch jeder vorstehend genannte Gegenstand den
geltenden luxemburgischen Gesetzen unterliegt, insbesondere den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes.
Art. 5. Verbindlichkeiten.
(1) Soweit in der Satzung und im Gesellschaftsgesetz keine anderslautenden Angaben gemacht sind, sind die Kom-
manditisten nicht persönlich für die Schulden oder Verbindlichkeiten der Kommanditgesellschaft haftbar und lediglich
verpflichtet, ihre Kapitaleinlage im Umfang ihrer jeweiligen Zusage der Kommanditgesellschaft gegenüber zu leisten.
(2) Der Komplementär, der als Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft auftritt, ist gesamtschuldnerisch und un-
beschränkt für die Schulden, Verbindlichkeiten und Pflichten der Kommanditgesellschaft haftbar, die über das Vermögen
der Kommanditgesellschaft hinausgehen.
Art. 6. Kapital. Das Anfangskapital der Kommanditgesellschaft wird auf zwanzigtausendundeinen Euro (EUR 20.001.-)
festgelegt und in einen (1) Anteil des Komplementärs in Höhe von einem Euro (EUR 1.-) und in zwanzigtausend (20.000)
Anteile der Kommanditisten in Höhe von je einem Euro (EUR 1.-) aufgeteilt.
Die Anteile der Kommanditisten können in einer oder mehreren Klassen ausgegeben werden.
Die gesamten Bareinlagen des Komplementärs und der anfänglichen Kommanditisten sind vollständig eingezahlt.
Der Komplementär kann sich jederzeit mit einer Kapitalerhöhung der Kommanditgesellschaft auf der Grundlage einer
Entscheidung der Hauptversammlung der Kommanditisten mit Genehmigung der Mehrheit der Kommanditisten, die drei
Viertel der Anteile an der Kommanditgesellschaft darstellen, einverstanden erklären und die Kommanditgesellschaft gibt
dann die entsprechende Anzahl von zusätzlichen Anteilen ohne Nennwert aus.
Art. 7. Art der Anteile.
(1) Die Kommanditgesellschaft gibt nur eingetragene Anteile aus.
(2) Alle ausgegebenen Anteile werden vom Komplementär im Gesellschaftsregister geführt. Das Register beinhaltet
den Namen jedes Inhabers von Anteilen, seinen Wohnort oder sein Zustellungsdomizil, der bzw. das der Kommandit-
gesellschaft mitgeteilt wird, sowie die Anzahl der vom Inhaber gehaltenen Anteile und den Preis, den er für die Zeichnung
der Anteile gezahlt hat. Der Eintrag des Namens des Gesellschafters ist Nachweis seines Eigentumsrechtes an den je-
weiligen Anteilen.
(3) Die Kommanditisten teilen der Kommanditgesellschaft eine Anschrift mit, an die alle Mitteilungen und Bekannt-
machungen gesendet werden. Diese Anschriften werden auch in das Gesellschaftsregister eingetragen. Ein Kommanditist
kann seine im Register eingetragene Anschrift jederzeit ändern und lässt der Kommanditgesellschaft dazu eine schriftliche
Mitteilung an den eingetragenen Sitz oder an eine andere Anschrift zukommen, die gelegentlich vom Komplementär
mitgeteilt werden kann.
(4) Die Kommanditgesellschaft erkennt pro Anteil nur einen einzigen Inhaber an. Befindet sich ein oder mehrere Anteile
im gemeinsamen Eigentum oder wird das Eigentum an solchen Anteilen streitig gemacht, dann müssen alle Personen, die
52596
L
U X E M B O U R G
ein solches Recht an den Anteilen geltend machen, einen einzigen Anwalt bestellen, der diese Anteile dann der Kom-
manditgesellschaft gegenüber vertritt. Eine Nichtbestellung eines solchen Anwalts bedeutet die Aussetzung aller mit den
Anteilen verbundenen Rechte.
Art. 8. Einschränkungen am Eigentum an den Anteilen. Der Komplementär kann das Eigentum einer Person an Anteilen
aus beliebigen Gründen einschränken oder verhindern. Insbesondere kann der Komplementär uneingeschränkt das Ei-
gentum an Anteilen einschränken oder verhindern, wenn eine solche Inhaberschaft nach Ansicht des Komplementärs
nachteilig für die Kommanditgesellschaft ist, zu einer Verletzung von luxemburgischen oder ausländischen Gesetzen oder
Vorschriften führen kann oder die Kommanditgesellschaft als Folge davon steuerliche Nachteile oder sonstige finanzielle
Nachteile erleidet, die sie ansonsten nicht erlitten hätte.
Art. 9. Umwandlung und Übertragung von Anteilen.
(1) Dem Komplementär ist der Verkauf, die Abtretung, Übertragung, Verpfändung oder dingliche Belastung (zusammen
„Übertragung") aller oder eines Teils der Anteile des Komplementärs nur dann gestattet, wenn der Verkauf, die Abtretung,
Übertragung, Verpfändung oder dingliche Belastung (zusammen „Übertragung") durch einen Beschluss der Hauptver-
sammlung in Übereinstimmung mit der Satzung in Bezug auf Ergänzungen [sic] gestattet wird.
(2) Ein Kommanditist darf seine Anteile nur mit der vorherigen, schriftlichen Zustimmung des Komplementärs, die
nicht unsachgemäß vorenthalten werden darf, übertragen. Jede Übertragung unterliegt der Voraussetzung, dass der Käu-
fer, Abtretungsempfänger, Übertragungsempfänger, Pfandnehmer oder Begünstigte der dinglichen Belastung (zusammen
„Übertragungsempfänger") alle ausstehenden Pflichten des Kommanditisten, der die Anteile verkauft, abtritt, überträgt,
verpfändet oder dinglich belastet (zusammen „Übertragender"), ganz und vollumfänglich schriftlich übernimmt.
(3) Die Übertragung von Anteilen erfolgt im Zuge einer notariell beglaubigten Urkunde oder Privaturkunde. Sie ist der
Kommanditgesellschaft und Dritten gegenüber erst nach Mitteilung an die Kommanditgesellschaft oder Annahme durch
die Kommanditgesellschaft im Zuge einer notariell beglaubigten Urkunde wirksam.
Art. 10. Geschäftsführung. Die Kommanditgesellschaft wird vom Komplementär bzw. seinem Nachfolger in seiner
Kapazität als alleiniger Komplementär (associé gérant commandité) der Kommanditgesellschaft geführt.
Änderungen an der Geschäftsführung oder in Bezug auf den Wechsel des Komplementärs bedürfen der Zustimmung
der Hauptversammlung der Kommanditisten.
Art. 11. Befugnisse des Komplementärs.
(1) Der Komplementär hat die umfassendsten Befugnisse für die Verwaltung und Leitung der Kommanditgesellschaft,
für die Handlung im Namen der Kommanditgesellschaft unter allen Umständen sowie die Ausübung und Genehmigung
aller Handlungen und Maßnahmen, die mit dem Unternehmensziel der Kommanditgesellschaft im Einklang stehen.
(2) Der Komplementär verfügt über alle Befugnisse und die Berechtigung, die Kommanditgesellschaft Dritten gegen-
über zu vertreten.
(3) Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich kraft Gesetz oder aufgrund der Satzung der Hauptversammlung vorbehalten
sind, fallen unter die Zuständigkeit des Komplementärs.
Art. 12. Einschränkungen der Kommanditisten. Die Kommanditisten sind nicht am Betrieb der Kommanditgesellschaft
oder der Geschäftsführung oder Kontrolle in Bezug auf die Geschäfte und Angelegenheiten beteiligt und haben keine
Rechte und keine Befugnis, im Namen der Kommanditgesellschaft zu handeln oder sich in irgendeiner Weise an der
Leitung oder Führung der Kommanditgesellschaft zu beteiligen oder sich darin einzumischen oder in Bezug auf die Kom-
manditgesellschaft betreffende Angelegenheiten abzustimmen, soweit im Gesellschaftsgesetz oder in der Satzung keine
anderslautenden Angaben gemacht sind.
Art. 13. Hauptversammlung der Kommanditisten. Die Hauptversammlung der Kommanditisten stellt das gesamte Or-
gan der Kommanditisten der Kommanditgesellschaft dar. Sie hat die umfassendsten Befugnisse für die Anweisung,
Durchführung oder Ratifizierung von Handlungen in Bezug auf den Betrieb der Kommanditgesellschaft, wobei, soweit hier
keine anderslautenden Angaben gemacht sind, ein Beschluss erst dann als wirksam verabschiedet gilt, wenn er vom Kom-
plementär genehmigt wird.
Die Gesellschafterversammlung der Kommanditisten wird vom unbeschränkt haftenden Gesellschafter einberufen.
Eine Jahreshauptversammlung der Gesellschafter wird am dritten Freitag des Monats Juli um 10.00 Uhr stattfinden, um
die Jahresabschlüsse und den Bericht des unbeschränkt haftenden Gesellschafters zu genehmigen. Der unbeschränkt
haftende Gesellschafter trägt die alleinige Verantwortung für die Erstellung der Jahresabschlüsse und des Berichts und
muss die betreffenden Dokumente bei der oben erwähnten Versammlung zur Genehmigung durch die Kommanditisten
vorlegen.
Andere Versammlungen der Kommanditisten können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden wie
in den jeweiligen Ankündigungen zur Versammlung angegeben.
Gesellschafterversammlungen der Kommanditisten werden gemäß einer die Tagesordnung enthaltende Ankündigung
einberufen, die jedem Kommanditisten mindestens acht Tage vor der Versammlung an die registrierte Anschrift des
Kommanditisten zugeschickt wird. Eine solche Ankündigung an die Gesellschafter muss der Versammlung gegenüber nicht
begründet werden. Die Tagesordnung ist vom unbeschränkt haftenden Gesellschafter vorzubereiten.
52597
L
U X E M B O U R G
Da es sich bei allen Anteilen der Gesellschaft um Namensanteile handelt, dürfen Ankündigungen an Kommanditisten
nur per Einschreiben geschickt werden.
Wenn alle Kommanditisten anwesend oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen und über die Ta-
gesordnung informiert ansehen, kann die Gesellschafterversammlung ohne Ankündigung stattfinden.
Der unbeschränkt haftende Gesellschafter kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Kommanditisten
zu erfüllen sind, um an einer Versammlung der Kommanditisten teilzunehmen.
Bei allen Gesellschafterversammlungen führt der unbeschränkt haftende Gesellschafter oder die von diesem benannte
Person den Vorsitz.
Die Verhandlungsgegenstände einer Gesellschafterversammlung der Kommanditisten sind auf die in der Tagesordnung
(die alle gesetzlich erforderlichen Angelegenheiten enthalten muss) enthaltenen Angelegenheiten und mit solchen Ange-
legenheiten verbundene Gegenstände beschränkt.
Der unbeschränkt haftende Gesellschafter kann im Voraus einen Tag, nicht mehr als fünfzig Tage vor dem Datum einer
Gesellschafterversammlung der Kommanditisten, als Stichtag für die Bestimmung der Kommanditisten, die Anspruch auf
eine Ankündigung für und auf Abstimmung bei einer solchen Versammlung haben, festlegen, und in diesem Fall haben die
betreffenden Kommanditisten - und nur diese Kommanditisten - die an dem so bestimmten Datum eingetragene Kom-
manditisten sind, Anspruch auf eine solche Ankündigung für und auf Abstimmung bei der betreffenden Versammlung,
ungeachtet einer Übertragung von Gesellschaftsanteilen im Verzeichnis der Kommanditisten nach einem solchen wie oben
erwähnt festgelegten Stichtag.
Gemäß Luxemburger Recht und dem Gesellschaftsvertrag berechtigt jeder Gesellschaftsanteil zur Abgabe einer Stim-
me bei allen Gesellschafterversammlungen der Kommanditisten. Ein Kommanditist kann bei einer Gesellschafterver-
sammlung der Kommanditisten handeln, indem er einer anderen Person, bei der es sich nicht um einen Kommanditisten
handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilt.
Durch die Anwesenheit, persönlich oder durch Vollmacht vertreten, von Kommanditisten, deren Stimmrechte zu-
sammen die Mehrheit aller Stimmrechte darstellen, ist die Versammlung beschlussfähig. Wenn eine Versammlung der
Kommanditisten nicht organisiert werden kann, weil keine beschlussfähige Mehrheit anwesend oder vertreten ist, sind
die bei einer solchen Versammlung persönlich anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen stimmberechtigten Kom-
manditisten dazu berechtigt, die Versammlung jeweils zu vertagen, bis eine beschlussfähige Mehrheit anwesend oder
vertreten sein kann. Bei Verlegung einer Versammlung auf einen anderen Termin oder an einen anderen Ort muss keine
Benachrichtigung über die vertagte Versammlung erfolgen, wenn deren Ort und Zeit bei der Versammlung, bei der die
Vertagung beschlossen wird, bekanntgegeben werden. Bei der vertagten Versammlung, bei der eine beschlussfähige
Mehrheit anwesend oder vertreten sein muss, können die Kommanditisten alle Verhandlungsgegenstände behandeln, die
ggf. bei der ursprünglichen Versammlung verhandelt worden wären.
Soweit nicht gesetzlich oder in diesem Dokument anderweitig vorgesehen, werden Beschlüsse der Gesellschafterver-
sammlung, einschließlich insbesondere der Genehmigung der Jahresabschlüsse und von Veränderungen des Anteilskapitals,
vorbehaltlich der Zustimmung des unbeschränkt haftenden Gesellschafters mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden
oder vertretenen Kommanditisten gefasst.
Art. 14. Abschlussprüfer. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist von einem Abschlussprüfer zu überwachen, bei
dem es sich nicht um einen Kommanditisten handeln muss. Der Abschlussprüfer wird von der Jahreshauptversammlung
der Kommanditisten für einen Zeitraum, der am Ende der Jahreshauptversammlung der Kommanditisten beginnt und am
Datum der nächsten Jahreshauptversammlung der Kommanditisten endet, bestellt.
Art. 15. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. April und endet am 31. März des folgenden
Jahres.
Art. 16. Aufteilung der Gewinne und Verluste unter den Kommanditisten. Alle Gewinne und Verluste der Gesellschaft
sind gemäß der Anzahl der Gesellschaftsanteile, die von jedem von ihnen an der Gesellschaft gehalten werden, unter den
Kommanditisten aufzuteilen.
Art. 17. Aufteilung des Einkommens- und Kapitalertrags unter den Kommanditisten. Alle Erträge der Gesellschaft sind
von der Gesellschafterversammlung der Kommanditisten auf Vorschlag des unbeschränkt haftenden Gesellschafters aus-
zuschütten.
Art. 18. Interessenkonflikte. Verträge oder andere Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einem anderen Unter-
nehmen oder einer anderen Firma werden nicht durch den Umstand beeinflusst oder aufgrund des Umstandes ungültig,
dass der unbeschränkt haftende Gesellschafter oder einer oder mehrere der leitenden Angestellten (Officers) des un-
beschränkt haftenden Gesellschafters an einem solchen anderen Unternehmen oder einer solchen anderen Firma beteiligt
ist oder ein Direktor, Partner, leitender Angestellter (Officer) oder Mitarbeiter des betreffenden anderen Unternehmens
oder der betreffenden anderen Firma ist. Ein leitender Angestellter (Officer) des unbeschränkt haftenden Gesellschafters,
der als Direktor, Partner, leitender Angestellter oder Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Firma tätig ist, mit der
die Gesellschaft einen Vertrag schließen oder auf andere Weise Geschäfte tätigen soll, darf nicht aufgrund einer solchen
Verbindung mit dem betreffenden anderen Unternehmen oder der betreffenden anderen Firma daran gehindert werden,
52598
L
U X E M B O U R G
Angelegenheiten in Bezug auf einen solchen Vertrag oder ein solches anderes Geschäft in Betracht zu ziehen, diesbezüglich
seine Stimme abzugeben oder entsprechende Handlungen vorzunehmen.
Falls ein leitender Angestellter (Officer) des unbeschränkt haftenden Gesellschafters ein Interesse an einer Transaktion
der Gesellschaft hat, das den Interessen der Gesellschaft entgegensteht, so hat der betreffende leitende Angestellte dem
unbeschränkt haftenden Gesellschafter das betreffende entgegenstehende Interesse bekanntzugeben und darf eine solche
Transaktion nicht in Betracht ziehen oder dazu abstimmen, und über die betreffende Transaktion und das Interesse des
betreffenden leitenden Angestellten daran ist der nächsten Gesellschafterversammlung der Kommanditisten zu berichten.
Der Begriff „entgegenstehendes Interesse", wie im vorstehenden Absatz verwendet, schließt keine Beziehungen mit
oder ohne Interesse an einer Angelegenheit, Position oder Transaktion ein, die eine Person, ein Unternehmen oder eine
Rechtskörperschaft betrifft, welche jeweils vom unbeschränkt haftenden Gesellschafter in seinem eigenen Ermessen fest-
gelegt werden können.
Art. 19. Entschädigung und Haftung.
(1) Die Gesellschaft verpflichtet sich dazu, alle [sic] des unbeschränkt haftenden Gesellschafters oder eines Partners
des unbeschränkt haftenden Gesellschafters (die „freigestellten Personen") aus dem Vermögen der Gesellschaft zu ent-
schädigen und schadlos zu halten in Bezug auf und gegen alle Verbindlichkeiten, Klagen, Verfahren, Ansprüche, Kosten,
Forderungen, Schadensersatz und Aufwendungen (einschließlich von Rechtskosten), die entstanden sind oder angedroht
wurden, welche sich ergeben aus oder im Zusammenhang mit dem Umstand oder mit diesem in Verbindung stehen oder
daraus resultieren, dass die freigestellte Person unbeschränkt haftender Gesellschafter oder Geschäftsführer in Bezug auf
die Gesellschaft ist oder als solcher fungiert hat, oder die entstehen in Bezug auf oder im Zusammenhang mit Angele-
genheiten oder anderen Umständen bezüglich der oder als Ergebnis der Ausübung seiner Befugnisse als unbeschränkt
haftender Gesellschafter oder Geschäftsführer oder als Ergebnis der Erbringung von Dienstleistungen für oder in Bezug
auf die Gesellschaft oder im Rahmen von oder gemäß einem Geschäftsführungsvertrag oder anderen Vertrag bezüglich
der Gesellschaft oder in Bezug auf Dienstleistungen als ernannter Direktor oder die sich anderweitig ergeben in Bezug
auf die Geschäftstätigkeit, das Geschäft oder Aktivitäten der Gesellschaft, allerdings mit der Maßgabe, dass eine freige-
stellte Person nicht auf diese Weise entschädigt werden soll in Bezug auf Angelegenheiten, die aus ihrem Betrug,
vorsätzlichen Fehlverhalten, ihrer Bösgläubigkeit oder grob fahrlässigen Missachtung ihrer Verpflichtungen und Pflichten
bezüglich der Gesellschaft resultieren, oder, außer im Falle von freigestellten Personen, die Einzelpersonen sind (d. h.
leitende Angestellte (Officers), Direktoren, Kommanditisten, Vertreter, Mitglieder, Ratgeber, Berater, Gesellschafter
oder Mitarbeiter des unbeschränkt haftenden Gesellschafters, der Dienstleistungsanbieter oder ihrer Partner), aus ihrer
Fahrlässigkeit (vorausgesetzt, dass eine solche Fahrlässigkeit eine wesentliche negative wirtschaftliche Auswirkung auf die
Gesellschafter oder die Gesellschaft gehabt hat) oder, im Falle des unbeschränkt haftenden Gesellschafters, in Bezug auf
Angelegenheiten, die aus der Verletzung einer Pflicht resultieren, die er ggf. nach dem Gesellschaftsrecht gegenüber der
Gesellschaft oder einem Kommanditisten hat, oder eine Verbindlichkeit, die ihm ggf. nach dem Gesellschaftsrecht ge-
genüber der Gesellschaft oder einem Kommanditisten entsteht.
(2) Die Entschädigungen gemäß diesem Artikel 18 bestehen ungeachtet des Umstands, dass die freigestellte Person
nicht mehr als unbeschränkt haftender Gesellschafter fungiert oder auf andere Weise keine Dienstleistungen mehr für
oder in Bezug auf die Gesellschaft erbringt oder nicht mehr in einer der in diesem Artikel 18 beschriebenen Funktionen
handelt, fort.
(3) Der unbeschränkt haftende Gesellschafter haftet gegenüber den Kommanditisten oder der Gesellschaft nicht für
die Fahrlässigkeit, Unredlichkeit oder Bösgläubigkeit eines für den unbeschränkt haftenden Gesellschafter oder für die
Gesellschaft handelnden Vertreters, soweit dieser Vertreter vom unbeschränkt haftenden Gesellschafter unter Beachtung
der angemessenen Sorgfalt ausgewählt, beauftragt und eingestellt wurde.
Art. 20. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung vor-
behaltlich der Anforderungen hinsichtlich der beschlussfähigen Mehrheit und der Mehrheit der Gesellschafterversamm-
lung der Kommanditisten jederzeit aufgelöst werden.
Die Liquidation wird vom unbeschränkt haftenden Gesellschafter vorgenommen, soweit nicht die Gesellschafterver-
sammlung der Kommanditisten einen oder mehrere andere Liquidatoren bestellt, bei denen es sich nicht um Komman-
ditisten handeln muss. Die Gesellschafterversammlung wird in jedem Fall die Befugnisse und die Vergütung der
Liquidatoren bestimmen. Der Nettoerlös der Liquidation ist vom Liquidator/den Liquidatoren gemäß ihrem Anteil an der
Gesellschaft an die Kommanditisten auszuschütten.
Art. 21. Änderungen des Gesellschaftsvertrags. Der Gesellschaftsvertrag darf nur durch die schriftliche Zustimmung
des unbeschränkt haftenden Gesellschafters und der Kommanditisten, die mehr als zwei Drittel der Anzahl sämtlicher
ausgegebenen Gesellschaftsanteile aller Klassen halten, (ganz oder teilweise) geändert werden, allerdings mit der Maßgabe,
dass keine Veränderungen vorgenommen werden dürfen, die
- einem Kommanditisten eine Verpflichtung auferlegen, eine Zahlung an die Gesellschaft zu leisten, die über seine
ursprüngliche Zeichnungssumme hinausgeht;
- die Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen eines bestimmten Kommanditisten oder einer bestimmten Gruppe von
Kommanditisten in anderer Weise als die anderer Kommanditisten gemäß dem Gesellschaftsvertrag erhöhen oder die
52599
L
U X E M B O U R G
Rechte oder den Schutz eines bestimmten Kommanditisten oder einer bestimmten Gruppe von Kommanditisten in an-
derer Weise als die anderer Kommanditisten gemäß dem Gesellschaftsvertrag verringern; oder
- in anderer Weise ohne die ausdrückliche Zustimmung aller Kommanditisten, die hiervon negativ betroffen sind, die
beschränkte Haftung eines Kommanditisten verändern, und weiterhin mit der Maßgabe, dass dieser Artikel 25 ohne die
einstimmige Zustimmung aller Kommanditisten nicht geändert werden darf.
Art. 22. Geltendes Recht. Der Gesellschaftsvertrag und die Rechte, Verpflichtungen und Beziehungen der Parteien
unterliegen Luxemburger Recht, und insbesondere dem Gesellschaftsrecht Luxemburgs, und sind nach diesem auszulegen,
und alle Parteien erklären sich unwiderruflich damit einverstanden, dass ausschließlich die Gerichte von Luxemburg dafür
zuständig sind, Streitigkeiten beizulegen, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Gesellschaftsvertrag ergeben, und
dass demgemäß alle Prozesse, Klagen oder Verfahren, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Gesellschaftsvertrag
ergeben, in den betreffenden Gerichten anzustrengen sind.
Art. 23. Allgemeines. Für alle Angelegenheiten, die nicht im Gesellschaftsvertrag vorgesehen sind, verweisen die Par-
teien auf die gesetzlichen Bestimmungen zu den betreffenden Angelegenheiten.
<i>Übergangsbestimmungen:i>
<i>Erstes Rechnungsjahri>
Das erste Rechnungsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. März 2013.
<i>Erste Jahresversammlungi>
Die erste Jahreshauptversammlung der Kommanditisten wird im Jahr 2014 stattfinden.
<i>Zeichnungi>
Der unbeschränkt haftende Gesellschafter, LF Hotels Acquico I (GP) S.à.r.l., leistet eine Einlage in Höhe von einem
Euro (EUR 1,-), die vollständig eingezahlt ist, wie durch eine dem Notar übergebene Bankbescheinigung belegt, für den
ihm der einzige Anteil des unbeschränkt haftenden Gesellschafters gewährt wird.
Der anfängliche Kommanditist, Leopard Germany Holding Hotels S.à.r.l., leistet eine Einlage in Höhe von fünfzehn-
tausend Euro (EUR 15.000,-), die vollständig eingezahlt ist, wie durch eine dem Notar übergebene Bankbescheinigung
belegt, für den ihm einhundert Kommanditanteile gewährt werden.
Der zweite Kommanditist, Fattal Hotels Ltd (Israel), leistet eine Einlage in Höhe von fünftausend Euro (EUR 5.000,-),
die vollständig eingezahlt ist, wie durch eine dem Notar übergebene Bankbescheinigung belegt, für den ihm einhundert
Kommanditanteile gewährt werden
<i>Kostenschätzungi>
Der Betrag der Kosten, Aufwendungen, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art, der aufgrund dieses Dokuments auf
der Gesellschaft liegt, wird auf einen Betrag von EUR 1.579,- geschätzt.
<i>Außerordentliche Versammlung der Kommanditisteni>
Die vorstehend erwähnten erschienenen Parteien, die das gesamte gezeichnete Kapital repräsentieren und sich als
ordnungsgemäß einberufen ansehen, haben anschließend eine außerordentliche Versammlung der Kommanditisten ge-
bildet.
Nachdem sie festgestellt hatten, dass diese Versammlung ordnungsgemäß zusammengesetzt ist, haben sie einstimmig
die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft wird bestimmt als 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913, Großherzogtum Lu-
xemburg.
WORÜBER URKUNDE, Erstellt wurde zu Luxemburg, mit Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde
in Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der eng-
lischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns,
dem unterzeichnenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Signé: B. SYLLA, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20/02/2013. Relation: LAC/2013/7799. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 7 mars 2013.
Référence de publication: 2013034724/588.
(130042340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2013.
52600
L
U X E M B O U R G
Secapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 108.305.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-second day of February;
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
There appeared:
KRUK S.A., a joint stock company, with registered office in Ul. Legnicka 56, 54-204 Wroclaw, Poland,
duly represented by Mr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, with professional address at 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal which after having been signed "ne varietur" by the appearing proxyholder
and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,
acting as sole member of SECAPITAL S.à.r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée de titrisation, with
registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register at section B under number 108305, incorporated on 17 May 2005 pursuant to a deed drawn up by Maître
Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations"
number 1045 of 15 October 2005.
The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time on 1
st
February 2013 pursuant
to a deed drawn up by the undersigned notary, not yet published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations".
The sole member, represented as above stated, requests the undersigned notary to document the following:
<i>First resolutioni>
The sole member resolves to reduce the Company's corporate capital by an amount of PLN 9,727,000 (nine million
seven hundred twenty-seven thousand Polish zloty) in order to reduce it from PLN 544,734,000 (five hundred forty-four
million seven hundred thirty-four thousand Polish zloty) to PLN 535,007,000 (five hundred thirty-five million seven thou-
sand Polish zloty) by reimbursement to the sole member and simultaneous cancellation of 9,727 (nine thousand seven
hundred twenty-seven) Class A corporate units with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand Polish zloty) each.
The sole member also resolves to reduce the legal reserve related to Compartment A by an amount of PLN 972,700
(nine hundred seventy-two thousand seven hundred Polish zloty) to bring it from PLN 23,193,400 (twenty-three million
one hundred ninety-three thousand four hundred Polish zloty) to PLN 22,220,700 (twenty-two million two hundred
twenty thousand seven hundred Polish zloty) and to reimburse this amount to the sole member.
Power is given to the managers of the Company to organise the payment in accordance with Luxembourg law provi-
sions applicable in case of reduction of share capital.
<i>Second resolutioni>
The sole member resolves to amend article five (5) of the Company's Articles of Incorporation, which henceforth will
be read as follows:
"The corporate capital of the company is fixed at PLN 535,007J0000 (five hundred thirty-five million seven thousand
Polish zloty) divided into 338,460 (three hundred thirty-eight thousand four hundred sixty) Class A corporate units,
50,378 (fifty thousand three hundred seventy-eight) Class B corporate units, 14,576 (fourteen thousand five hundred
seventy-six) Class C corporate units, 24,385 (twenty-four thousand three hundred eighty-five) Class D corporate units
and 107,208 (one hundred seven thousand two hundred eight) Class E corporate units with a nominal value of PLN 1,000
(one thousand Polish zloty) each, which have the same rights in all respects."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of this
deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing party, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-deux février;
52601
L
U X E M B O U R G
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A comparu:
KRUK S.A., société anonyme, ayant son siège social à Ul. Legnicka 56, 54-204 Wroclaw, Pologne,
ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé laquelle, signée «ne varietur» par le man-
dataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera
soumise à la formalité de l'enregistrement,
agissant en sa qualité d'associée unique de SECAPITAL S.à.r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de
titrisation, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 108305, constituée en date du 17 mai 2005 suivant un
acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1045 du 15 octobre 2005.
Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu en date du 1
er
février 2013 suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de PLN 9.727.000 (neuf
millions sept cent vingt-sept mille zloty polonais) afin de le porter de son montant actuel de PLN 544.734.000 (cinq cent
quarante-quatre millions sept cent trente-quatre mille zloty polonais) à PLN 535.007.000 (cinq cent trente-cinq millions
sept mille zloty polonais) par remboursement à l'associée unique et annulation de 9.727 (neuf mille sept cent vingt-sept)
parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune.
L'associée unique décide également de réduire la réserve légale relative au Compartiment A à concurrence d'un
montant de PLN 972.700 (neuf cent soixante-douze mille sept cents zloty polonais) afin de la porter de son montant
actuel de PLN 23.193.400 (vingt-trois millions cent quatre-vingt-treize mille quatre cents zloty polonais) à PLN 22.220.700
(vingt-deux millions deux cent vingt mille sept cents zloty polonais) et de rembourser ce montant à l'associée unique.
Pouvoir est donné aux gérants de la Société pour organiser le paiement en conformité avec la législation luxembour-
geoise applicable en matière de réduction de capital.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à PLN 535.007.000 (cinq cent trente-cinq millions sept mille zloty polonais) représenté par
338.460 (trois cent trente-huit mille quatre cent soixante) parts sociales de catégorie A, 50.378 (cinquante mille trois
cent soixante-dix-huit) parts sociales de catégorie B, 14.576 (quatorze mille cinq cent soixante-seize) parts sociales de
catégorie C, 24.385 (vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq) parts sociales de catégorie D et 107.208 (cent sept
mille deux cent huit) parts sociales de catégorie E d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune et
qui ouvrent les mêmes droits à tous égards.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, payables par la Société en raison du présent acte, sont
évalués approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. PONSARD, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 février 2013. LAC/2013/8709. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 1
er
mars 2013.
Référence de publication: 2013034844/107.
(130042336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2013.
52602
L
U X E M B O U R G
Eneris Polska S.A., Société Anonyme,
(anc. Transition Capital S.A.).
Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 75.118.
L'an deux mille treize, le vingt-six février.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «TRANSITION CAPITAL SA», établie et ayant
son siège à L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny, constituée suivant acte du notaire Paul DECKER de Luxembourg-Eich en
date du 16 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 520 du 20 juillet 2000,
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Joseph Elvinger de Luxembourg en date du
13 juin 2007, publié au dit Mémorial C, Numéro 1712 du 13 août 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 75.118.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Roland CIMOLINO, expert comptable, demeurant professionnellement
à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
qui désigne comme secrétaire Patricia HENRY, comptable, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 59,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
L'assemblée choisit comme scrutateur Roland CIMOLINO, expert comptable, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société;
2. Modification afférente de l'article 1
er
des statuts de la Société;
3. Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article 3 des statuts de la société.
4. Modification de l'article 8 des statuts de la société;
5. Démission d'un administrateur;
6. Nomination d'un nouvel administrateur.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,
resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.
Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de «TRANSITION CAPITAL S.A.» en «Eneris
Polska S.A.».
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée choisit de modifier en conséquence l'article 1
er
des statuts de la Société
pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
« Art. 1
er
. La société prend la dénomination de «Eneris Polska S.A.».»
<i>Troisième résolutioni>
L'article 3 des statuts de la Société est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 3. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et en particulier en Pologne (ou tout
autre forme d'investissement), en particulier dans le domaine d'infrastructures liées à l'environnement, l'énergie, l'eau et
les déchets ainsi que les concessions, délégations ou partenariats de services publics (notamment la distribution et le
traitement de l'eau, assainissement, traitement des déchets et leur transformation en énergie, les réseaux de chaleur,
etc..), l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option,
d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets, licences ou actifs immobiliers,
52603
L
U X E M B O U R G
leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances
ou garanties, enfin toute activité de développement et toutes opérations généralement quelconques se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet.
La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement
de son objet.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée de modifier le troisième paragraphe de l'article 8 des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
« Art. 8. Le conseil d'Administration peut désigner parmi ses membres un président.
Le Conseil d'Administration est convoqué par l'administrateur-délégué, s'il en est un, ou par au moins deux de ses
membres et il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, téléfax ou autres moyens de communication électronique étant
admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou autres moyens
de communication électronique.
Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité absolue des votants, en cas de partage, la voix de l'administrateur-
délégué, s'il en est un, est prépondérante.
Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, aura la même valeur juridique qu'une résolution prise lors
d'une réunion du conseil d'administration régulièrement convoquée et tenue. Pareille résolution pourra résulter de plu-
sieurs écrits ayant la même forme et signées chacun par un ou plusieurs administrateurs.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée accepte la démission de DMD S.A. aux fonctions d'administrateur avec décharge.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Jean-Marc JANAILHAC, administrateur de
société, demeurant à F-75006 Paris (France), 68, rue de Grenelles.
Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice 2016, en même temps que les autres administrateurs.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels,
état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: CIMOLINO, HENRY, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 1
er
mars 2013. Relation: LAC/2013/9591. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 14 mars 2013.
Référence de publication: 2013035503/98.
(130043560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2013.
Actelion Finance SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 96.016.
In the year two thousand and thirteen, on the eleventh day of the month of March.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ACTELION FINANCE SCA, a "société en com-
mandite par actions" established in Luxembourg with registered office at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and
entered in the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under section B number 96.016 and incorporated
52604
L
U X E M B O U R G
following a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on September 26, 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1089 of October 21, 2003, (the "Company"). The articles of
incorporation have been amended pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on 13
May 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 755, on 22 July 2004 and on 26.
November 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 149, on 17. February 2005.
The extraordinary general is presided by Mrs Nathalie GUTENSTEIN, private employee, residing professionally at
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, Switzerland.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Irena COLAMONICO, private employee, residing professio-
nally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
The meeting elects as scrutineer M. Raymond THILL, maître en droit,, residing professionally at the same address.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
(i) The shareholders, all present or represented, declare having been duly convened and having previous knowledge
of the agenda.
(ii) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1 To move the registered office of the Company within the Grand Duchy of Luxembourg from 25c, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg to 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
2 To amend article 2, paragraph 1 and 2 of the articles of incorporation of the Company to reflect that the registered
office of the Company is in the municipality of Strassen and may be transferred within the same municipality by resolution
of the Manager.
3 Miscellaneous.
(iii) The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders, and the number of
their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxyholders
and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
(iv) The proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned
notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(v) It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital of sixty-two thousand Swiss
francs (CHF 62,000.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly resolve
on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company from 25c, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg to 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 2, paragraph 1 and 2 of the articles of incorporation of the Company
as follows:
Art. 2. Paragraph 1 and 2. "The Company will have its registered office in the municipality of Strassen."
The registered office may be transferred within the same municipality by resolution of the Manager."
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le onze mars.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ACTELION FINANCE SCA, une société en com-
mandite par actions ayant son siège social à 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 96.016 et constituée suivant acte reçu par Me Gérard Lecuit,
notaire résident à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26 septembre 2003, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1089 du 21 octobre 2003 («la Société»). Les statuts ont été modifies par
52605
L
U X E M B O U R G
acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résident à Luxembourg, le 13 maiy 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 755, le 22 juillet 2004 et le 26 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 149, le 17 février 2005.
L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte sous la présidence de Madame Nathalie GUTENSTEIN, employée
privée, demeurant professionnellement à Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, Suisse.
Le président désigne comme secrétaire Madame Irena COLAMONICO, employée privée, demeurant professionnel-
lement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à
la même adresse.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
(i) Les actionnaires, tous présents ou représentés, déclarent avoir été dument convié et ont eu connaissance de l'ordre
du jour de l'assemblée.
(ii) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Transfert du siège social de la Société au sein du Grand-Duché de Luxembourg de 25c, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg au 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
2 Modification de l'article 2, paragraphe 1 and 2 des statuts de la Société pour refléter que le siège social de la Société
est établi dans la commune de Strassen et peut être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du Gérant.
3 Divers.
(iii) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-
tions que chacun d'entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise si-
multanément à l'enregistrement.
(iv) Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire ins-
trumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement.
(v) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de soixante-
deux mille francs suisse (CHF 62,000.-), sont représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment
informés avant cette assemblée.
Ensuite, après délibération, l'assemblée générale a pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de 25c, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
à 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 2, paragraphe 1 et 2 des statuts de la Société comme suit:
Art. 2. Paragraphe 1 et 2. "Le siège social est établi dans la commune de Strassen.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit à l'intérieur de la même commune par décision du Gérant."
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des même comparants, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: N. Gutenstein, I. Colamonico, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 mars 2013. LAC/2013/11456. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2013.
Référence de publication: 2013035634/116.
(130044281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.
52606
L
U X E M B O U R G
Etablissements Locanord S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9560 Wiltz, 58, rue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 129.798.
L'an deux mille treize, le quatre mars.
Pardevant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ETABLISSEMENTS LOCA-
NORD S.A. (2007 2220 464) avec siège social à L-9560 Wiltz, 58, rue du X Septembre;
constituée suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, alors notaire de résidence à Wiltz, en date du 15 juin 2007,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C N0 1833 du 29 août 2007, page 87961, RCS B129798
La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Claude STREICHER, administrateur,demeurant
à L-9510 Wiltz, 3, rue des Prés.
Le président choisit comme secrétaire Monsieur Wilhelm THEODOR, salarié-chauffeur, demeurant à L-9533 Wiltz,
rue de l'industrie, 12;
et comme scrutateur, Monsieur Olivier GASPARD, comptable, demeurant à B-6600 Bastogne, 61, route d'Assenois.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarant se
référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
L'intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:
<i>Ordre du jour:i>
i.- Extension de l'objet social et modification subséquente d l'article 3 des statuts.
2.- Nomination d'un délégué à la gestion journalière.
3.- Renouvellement des mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes.
4.- Modification du pouvoir de signature et modification subséquente de l'article 12 des statuts;
5.- Divers
Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'étendre l'objet social pour donner la teneur suivante à l'article 3 des statuts:
« Art. 3. La société a pour objet la location de moyens de transports automoteurs sans chauffeur, la location d'instal-
lations pour chantiers ainsi que la location de matériel pour fêtes.
La société a également pour objet la location et le commerce de véhicules automoteurs, de camions, de machines et
de véhicules de génie civil, de grues, de containeurs, le commerce de produits accessoires pour véhicules automoteurs,
de pneumatiques, de produits pétroliers, de carburants et lubrifiants, bicyclettes, cycles à moteur auxiliaire, motos, ainsi
que l'exploitation d'une station d'essence.
D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet ou de son but».
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer un délégué à la gestion journalière.
Dans le cadre des activités visées dans l'extension de l'objet social, il y a lieu de nommer Monsieur Wilhelm THEODOR,
salarié chauffeur, demeurant à L-9533 Wiltz, 12, rue de l'industrie, comme délégué à la gestion journalière pour une durée
de six ans.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de renouveler les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes pour une
durée de 6 ans, c.à d.:
- Monsieur Claude STREICHER, demeurant à L-9510 Wiltz, 3, rue des Prés, en tant qu'administrateur unique,
52607
L
U X E M B O U R G
- La Société International Business Councelors S.à r.l., ayant son siège à L-9570 Wiltz, 9, rue des Tondeurs, en tant
que commissaire aux comptes.
<i>Quatrième et Dernière résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le pouvoir de signature de sorte que l'article 12 de la société aura la teneur suivante:
« Art. 12. Si la société comporte un conseil d'administration composé de plusieurs administrateurs la société sera
engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'ad-
ministrateur délégué.
Pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de location, de moyens de transports automoteurs sans
chauffeur, de location d'installations pour chantier et de matérielles pour fêtes, la société devra toujours être engagée
par la signature individuelle de l'administrateur unique.
Pour toutes les opérations entrant dans le cadre du commerce de véhicules automoteurs, de camions, de machines
et de véhicules de génie civil, de grues, de containeurs, le commerce de produits accessoires pour véhicules automoteurs,
de pneumatiques de produits pétroliers, de carburants et lubrifiants, bicyclettes, cycles à moteur auxiliaire, motos, ainsi
que l'exploitation d'une station d'essence la signature conjointe de l'administrateur unique et du délégué à la gestion
journalière sont requises.
Si tel n'est pas le cas, la société devra toujours être engagée par la signature de l'administrateur unique nécessairement
conjointe à celle de la personne au nom de laquelle l'autorisation préalable du Ministère des Classes Moyennes a été
délivrée.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 16:45 heures.
DONT ACTE, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Streicher, Theodor, Gaspard, Martine Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 6 mars 2013. Relation: CLE/2013/36. Reçu soixante-quinze euros = 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Rodenbour C.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre aux Firmes.
Clervaux, le 11 mars 2013.
Martine WEINANDY.
Référence de publication: 2013036120/83.
(130044170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2013.
DCL Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 127.647.
<i>I. Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon exceptionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen,i>
<i>le 25 février 2013i>
<i>5 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
Le mandat d'Administrateur-délégué et le mandat de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Yvan DE
THOMAZ DE BOSSIERRE, le mandat d'Administrateur de Monsieur Christophe BLONDE AU, le mandat d'Administra-
teur-délégué de Madame Martine KOCH, ainsi que celui de Commissaire de la société, H.R.T. Révision S.A., sont arrivés
à échéance. L'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet au 21 juin 2012 le mandat d'Administrateur-délégué
de Monsieur Yvan DE THOMAZ DE BOSSIERRE (Président du Conseil) et de Madame Martine KOCH, le mandat d'ad-
ministrateur de Monsieur Christophe BLONDEAU et le mandat du Commissaire aux Comptes, la société H.R.T. Révision
S.A., pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en
2018.
<i>II. Changements d'adressei>
La Société a été informée du changement d'adresse d'un administrateur et du commissaire aux comptes, Monsieur
Christophe BLONDEAU et H.R.T. Révision S.A. ayant désormais leur adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DCL INVEST S.A.i>
Référence de publication: 2013041076/24.
(130050643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
52608
1 2 3 Luxembourg S.A.
ACP II2 S.C.A.
Actelion Finance SCA
ADEPA Asset Management S.A.
AI Northern Star (Luxembourg) S.à r.l.
Algen Technologie Luxembourg S.A.
Atlant Europe RE S.à r.l.
Comco MCS S.A.
DCL Invest S.A.
Eneris Polska S.A.
Etablissements Locanord S.A.
Immaco S.A.
ISP Luxembourg Canada
IVG Logistics Holding S.A.
Jackson, Jones & Cie S.e.n.c.
Jacmar S.A.
Jakadi S.A., SPF
Keystone Management S.A.
La Chanterelle Lux S.à r.l.
LF Hotels Acquico I SCS
Life Point Service
Luigi S.A.
Lunala Investments S.A.
Morisco International S.A.
PAA Luxembourg
Pegas Nonwovens SA
Plains Midstream Luxembourg
Profi S.A.
Project Service S.A.
Quinn Group Luxembourg Hotels S.à r.l.
Randstad Recruitment & Selection S.A.
RM Properties 2 S.C.A.
Secapital S.à.r.l.
SHIP Luxco 1 S.à r.l.
SHIP Luxco 2 S.à r.l.
SHIP Luxco Holding S.à r.l.
Sipicione International S.A.
Sparinvest
Star Consult s.à r.l.
TechnoMarine S.A, Succursale de Luxembourg
Transition Capital S.A.
Utu Luxembourg 1 S.à r.l.
Web Consulting S.à r.l.
XX ZW Investment Group S.A.