This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 359
14 février 2013
SOMMAIRE
ATG Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17216
AW Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17214
Axis Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17232
Bluegreen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17187
BRE/Europe 6-A Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
17211
BRSG S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17191
Cabinet vétérinaire de l'Iris Sàrl . . . . . . . . .
17229
Cera-Net S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17231
Charade S.A.H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17212
Chessboard S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17210
China Cargo Airlines Corporation Limited
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17212
China Logistics S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17206
Dengold Overseas S.A., SPF . . . . . . . . . . . .
17187
DEXIA World Alternative . . . . . . . . . . . . . .
17188
Dynamic Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17189
Elikonos JEREMIE GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17207
European CleanTech I SE . . . . . . . . . . . . . . .
17211
Européenne de Diversification - Eurodiv
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17186
Falbala S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17190
FERBLA S.A., société de gestion de patri-
moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17211
Financière Blandine Spf S.A. . . . . . . . . . . . .
17187
Financieringsmaatschappij voor Toerisme
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17208
First Baltic Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
17186
German Bond Opportunities UI . . . . . . . . .
17191
Japan Logistics Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
17206
La Concorde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17209
Locationlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17188
LogAxes Austria III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
17210
LRI Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17193
LuxRis Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17191
Marit Invest S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17188
MBC Group LTD, Luxembourg Branch . .
17209
McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17208
McKey Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17209
Meuse Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17212
MosliB Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17208
Murasec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17213
Mutual Competence Company S.A. . . . . .
17213
Nabors Lux Finance 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17213
National Air Cargo (Luxembourg) Sàrl . .
17213
Nimacar S.à r.l. Unipersonnelle . . . . . . . . .
17213
Phoenix III Mixed O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17207
Phoenix II Mixed N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17207
Racine Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .
17186
Sopura Sustainable Development Compa-
ny S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17189
TFB Fenster-Beteiligungs GmbH . . . . . . . .
17224
Tollamen SPF, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17190
Tooris Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17190
Transtrend Equity Strategies . . . . . . . . . . . .
17193
Union Investment Luxembourg S.A. . . . . .
17193
Viggo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17189
Whirlpool Luxembourg Ventures S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17210
17185
L
U X E M B O U R G
Européenne de Diversification - Eurodiv S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 90.756.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>4 mars 2013i> à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013022650/534/16.
Racine Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 108.298.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>4 mars 2013i> à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013022654/795/18.
First Baltic Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 109.076.
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le jeudi <i>7 mars 2013i> à 10h00 au siège de la société: 7, Val Ste-Croix, Luxembourg et qui aura pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors for the financial year ended December 31, 2011,
2. Approval of the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended December 31, 2011;
3. Allocation of the results for the financial year ended December 31, 2011;
4. Deliberation in accordance with article 100 of law of 10 august 1915 (as amended);
5. Discharge to the members of the Board of Directors and to the Statutory Auditor in respect of the execution of
their mandates to December 31, 2011;
6. Miscellaneous.
Pour pouvoir assister à cette Assemblée Générale, Messieurs les Actionnaires doivent préalablement présenter leurs
titres devant le bureau de l'Assemblée. Ils ont également la possibilité de déposer leurs titres avant l'Assemblée auprès
d'une banque et d'obtenir un certificat de blocage.
<i>Le Conseil d'Administrationi> .
Référence de publication: 2013020985/536/20.
17186
L
U X E M B O U R G
Bluegreen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 64.425.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>4 mars 2013i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation des résultats,
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article
100 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013022648/755/20.
Financière Blandine Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 65.114.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>4 mars 2013i> à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013022651/795/15.
Dengold Overseas S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 76.796.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui se tiendra le <i>4 mars 2013i> à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour la période du 1er janvier 2012 au 27 novembre 2012
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013022649/795/19.
17187
L
U X E M B O U R G
Locationlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 151.209.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>6 mars 2013i> à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013022652/795/15.
Marit Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 169.104.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mars 2013i> à 17:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013022653/795/15.
DEXIA World Alternative, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 82.737.
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires («l'Assemblée») de DEXIA WORLD ALTERNATIVE aura lieu au siège social de la société, 69, route
d'Esch, L-1470 Luxembourg le <i>22 février 2013i> à 10 heures 30
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 30 septembre
2012
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 30 septembre
2012
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2012
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les
décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de
s'inscrire avant le 20 février 2013 auprès de DEXIA WORLD ALTERNATIVE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à
l'attention de Fund Corporate Services (Fax N° +352 / 2460-3331).
Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
calendaires avant l'Assemblée aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L - 1470 Luxem-
bourg.
17188
L
U X E M B O U R G
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social
de la société ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.
<i>CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2013019060/755/29.
Viggo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 111.185.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>22 février 2013i> à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2012.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2013019059/1023/16.
SSDC S.A., Sopura Sustainable Development Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.688.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mars 2013i> à 17:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013022656/795/15.
Dynamic Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 81.617.
Die Anteilinhaber der SICAV Dynamic Funds werden hiermit zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am Freitag, <i>01. März 2013i> um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Beschlussfassung über die Liquidation der Gesellschaft
2. Ernennung eines Liquidators sowie Festlegung von dessen Befugnissen
3. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Anteilinhaber berechtigt, die bis spätestens 22. Februar 2013 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesell-
schaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten
werden. Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
17189
L
U X E M B O U R G
Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Bes-
chlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.
Luxemburg, im Januar / Februar 2013.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2013014077/755/20.
Tollamen SPF, SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 16.551.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mars 2013i> à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013022657/795/15.
Tooris Estates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 122.628.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>22 février 2013i> à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2012.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2013019062/1023/16.
Falbala S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 47.528.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>22 février 2013i> à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
novembre 2012.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2013019061/1023/17.
17190
L
U X E M B O U R G
BRSG S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 50.594.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>22 février 2013i> à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
novembre 2012.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2013019063/1023/17.
German Bond Opportunities UI, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds German Bond Opportunities UI (FCP) welcher von der Universal-
Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 30.11.2012.
<i>Für den German Bond Opportunities UI (FCP)
i>Universal-Investment-Luxembourg S. A.
Holger Emmel / Saskia Sander
Référence de publication: 2013019023/12.
(130022226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.
LuxRis Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 175.000.
STATUTS
L'an deux mille treize, le trente-et-un janvier.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire résidant à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Christophe CAVAILLES, né à Paris (France), le 16 août 1969, demeurant à F-06430 Peymeinade, 43, Chemin
des Pins.
Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant de documenter comme
suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires
de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
17191
L
U X E M B O U R G
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «LuxRis Holding S.à r.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 12 500 Euros (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 Euros (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les
trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes ces parts ont été souscrites par Monsieur Christophe CAVAILLES, prénommé.
Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de 12 500 Euros
(douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée
au notaire soussigné, qui le constate expressément.
17192
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.200.-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8080 Bertrange, 2, Rue Pletzer,
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Madame Catherine-Marie Monique BOUVY, née à Sainte-Cécile (Belgique), le 15 avril 1972, demeurant à L-2358
Luxembourg, 16, Rue Paul Palgen.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Vis-à-vis de la société, tout engagement de dépense ou d'investissement supérieur à un montant de cinquante mille Euros
(EUR 50.000,-) ou équivalent dans une autre devise doit nécessiter l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Cette
autorisation doit réunir les voix de la majorité des associés représentant le trois quarts (3/4) du capital social.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. CAVAILLES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 février 2013. Relation: LAC/2013/5257. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 8 février 2013.
Référence de publication: 2013020677/98.
(130024727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
LRI Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 28.101.
Durch Beschluss der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. mit Zustimmung der Depotbank M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A. wurde das Sondervermögen Real Assets Secondaries FCP-FIS per 21. Januar 2013 aufgelöst. Der Fonds
verfügt zum Zeitpunkt der Auflösung über keine ausstehenden Anteile. Mithin ist mangels Investitionen und Zuflüsse im
Fonds eine Übertragung eines Liquidationserlöses an die Caisse de Consignation nicht erforderlich.
Munsbach, im Februar 2012.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti> .
Référence de publication: 2013022655/2501/11.
Union Investment Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 28.679.
Der Fonds UniInstitutional Flexible Commodities (WKN: A1JDAE / ISIN: LU0651917410) wurde gemäß Artikel 12
des Verwaltungsreglements zum 10. Januar 2013 liquidiert.
Die Verwaltungsgesellschaft erklärt die Liquidation für abgeschlossen.
Der Liquidationsbericht kann bei der Verwaltungsgesellschaft, Union Investment Luxembourg S.A., 308, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg, angefordert werden.
Luxemburg, im Februar 2013.
Union Investment Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2013022658/12.
Transtrend Equity Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 132.012.
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth of November.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, was held an extraordinary general meeting of the sha-
reholders of "Transtrend Equity Strategies" (hereinafter referred as "the Company"), with registered office at 5, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Henri HELLINCKX, then notary residing in Mersch, on
17193
L
U X E M B O U R G
September 20
th
2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2467 dated October
31
st
, 2007,
registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 132012.
The meeting is opened at 9:00 a.m., and Mrs Marie BERNOT, private employee, residing professionally in Luxembourg
is elected chairman of the meeting.
Mrs Alexandra SCHMITT, private employee, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Laetitia BOEUF, private employee, residing professionally in Lu-
xembourg, is appointed to assume the role of secretary.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II- The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the
attendance list signed by the shareholders present, by the proxies of the shareholders represented and by the members
of the bureau. The said list and proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau will be annexed to this
document, to be registered with this deed and proxies of shareholders represented.
III.- It appears from the attendance list that out of 26,739.0330 shares in issue, 14,698.8433 shares are duly represented
at this meeting. In consideration of the agenda and of the provisions of Article 67 and 67-1 of the law on commercial
companies, the meeting is validly constituted and therefore entitled to decide on the items of the agenda.
IV.- The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman requested the notary to state that:
<i>Agendai>
1. Appointment of Mr Thomas Nummer as Director, as approved by the CSSF until the Annual General Meeting in
2013.
2. Amendment and restatement of the Articles of Incorporation in the form filed with and approved by the Commission
de Surveillance du Secteur Financier, in the form attached hereto.
<i>First resolutioni>
The meeting decides to appoint Mr Thomas NUMMER, born on 24 April 1969 in Trier, residing professionally in
Luxembourg as Director until the Annual General Meeting in 2013.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend and restates the Articles of Incorporation of Transtrend Equity Strategies which will
be read in the form attached hereto:
"Heading I. Denomination - Registered office - Period - Object
Art. 1. Denomination. There exists among the shareholders ("Shareholders"), a company in the form of a "société
anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of Transtrend Equity Strategies (the
"Company").
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy
of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board
of directors (the "Board" or "Board of Directors", and each director, a "Director").
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, military, economic or social deve-
lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg company.
Art. 3. Period. The Company is established for an indefinite period. The Company may be dissolved by a resolution
of the General Meeting of the Company adopted at any time in the manner required for amendment of these articles of
incorporation (the "Articles").
Art. 4. Object. The object of the Company is to invest the funds available to it in securities and derivative financial
instruments related to the equity markets, such as individual stocks, stock certificates, depository receipts, warrants,
stock baskets, stock indices, exchange-traded funds, futures, forwards, options and swaps (collectively, "Equity Interests"),
all the foregoing with the purpose of achieving long-term capital appreciation while attempting to control risks, thus
affording its Shareholders the results of the management of its portfolio. The Company may also invest in transferable
securities and financial instruments of any kind, in any other instruments representing rights of ownership, claims or
transferable securities and in cash.
17194
L
U X E M B O U R G
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by part II of the Luxembourg law of 17 December 2010
regarding Undertakings for Collective Investment (the "Law of 2010").
Heading II. Capital - Shares - Net Asset Value
Art. 5. Capital - Sub-Funds, Shares and Classes. The capital of the Company shall be represented by shares of no par
value fully paid up (the "Shares") and shall at any time be equal to the total value of the net assets of the Company as
defined in Article 11 hereof.
The minimum capital of the Company may not be less than one million two hundred fifty thousand euro (EUR
1,250,000).
The Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes (each a "Class") in a number of sub-
funds of the Company (each a "Sub-Fund"). The Company shall establish segregated opposable accounts each constituting
a Sub-Fund within the meaning of article 181 of the Law of 2010 and the proceeds of the issue of the relating Class or
Classes shall be invested, pursuant to Article 4 hereof, in such assets and instruments as the Board of Directors shall
from time to time determine in respect of the relating Sub-Fund and in respect of the specific assets and liabilities com-
plement of each Class, as described in the selling documents. The Board of Directors may create at any moment additional
Classes and Sub-Funds.
The Board of Directors may decide to apply for listing of the Shares of a Class or Sub-Fund on any stock exchange.
The Board of Directors shall establish each Sub-Fund or Class for an unlimited or limited duration. For limited duration
Sub-Funds or Classes, the Board of Directors shall extend the duration for one or more periods, if the general meeting
of Shareholders (the "General Meeting") of the Sub-Fund or Class concerned decides accordingly at the quorum and the
majority of votes required for a modification of these Articles. On the expiring date of a Sub-Fund or a Class with limited
duration, the Company shall redeem all outstanding Shares of such Sub-Fund or Class in accordance with Article 8 hereof.
Shareholders shall be informed in writing. Selling documents of each Sub-Fund or Class shall indicate the duration of such
Sub-Fund or Class and their extension, if any.
The annual accounts of the Company, including all Sub-Funds' accounts, shall be expressed in EUR, which is the refe-
rence currency (the "Reference Currency") of the Company.
When Sub-Funds' accounts are not expressed in EUR, such accounts are translated into EUR and added together with
the accounts of the Sub-Funds expressed in EUR for the purposes of establishing the annual accounts of the Company.
Art. 6. Form of Shares. With respect to each Class, the Company shall issue Shares in registered form. The Board
shall determine whether Shareholders can elect to obtain Share certificates; else, Shareholders will receive instead a
confirmation of their shareholding. If a Shareholder desires that more than one Share certificate be issued for his Shares,
if so allowed, the cost of such additional certificates may be charged to such Shareholder.
Each Share can be available as institutional Share ("Institutional Share") or as ordinary Share ("Ordinary Share"), as
determined by the Board and specified in the selling documents. Institutional Shares may be only owned by institutional
investors ("Institutional Investors") who qualify as such according to the guidelines and recommendations issued by the
Luxembourg supervisory authorities. Ordinary Shares may be owned by all types of investors.
Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and after receipt of the subscription monies. The
subscriber will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the subscription monies by the
Company, receive title to the Shares purchased by him and upon application obtain delivery of definitive Share certificates
or a confirmation of his shareholding.
Payments of dividends will be made to Shareholders to a bank account in their own name or, only if not in breach with
any law, rule, regulation, order or directive applicable to the Company's business, in the name of designated third parties.
All issued Shares shall be written down in the register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one
or more persons designated for that purpose by the Company. Such register shall contain for each Shareholder, in case
of an individual, at least his name, his nationality, his residence or elected domicile and the number of Shares held by him,
and in case of an entity, at least its statutory name, its jurisdiction of incorporation, its principal or registered address
and the number of Shares held by it. Every transfer of a Share shall be entered in the register of Shareholders.
Transfer of Shares shall be effected (a) if Share certificates have been issued, upon delivering the certificate(s) repre-
senting such Shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company, and (b), if no
Share certificates have been issued, by written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shareholders,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.
The Company may also recognise any other evidence of transfer satisfactory to it.
Every Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the
Company may be sent. Such address will be entered in the register of Shareholders and may be changed by the Shareholder
at any time by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may
be set by the Company from time to time.
Provided the Company issues Share fractions of the Class concerned, if payment made by any subscriber results in the
issue of a Share fraction, the person entitled to such fraction shall not be entitled to vote on that fraction but shall, to
17195
L
U X E M B O U R G
the extent the Company shall determine as to the calculation of fractions, be entitled to dividends and to all other actions
on a pro rata basis.
If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid or destroyed,
then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond
delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may determine. At the issuance of
the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in place of which
the new one has been issued shall become void.
Mutilated Share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated certificates shall
be delivered to the Company and shall be annulled immediately.
The Company may, at its election, charge the Shareholder for the costs of a duplicate or of a new Share certificate
and all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in
connection with the annulment of the old Share certificate.
Art. 7. Issue of Shares. Within each Class, the Board of Directors is authorised without limitation to issue further
Shares to be fully paid at any time, generally without reserving to the existing Shareholders a preferential right to sub-
scription of the Shares to be issued.
When the Company issues Shares for subscription, the price per Share at which such Shares are offered and sold,
unless otherwise indicated in the selling documents, shall be based on the net asset value ("Net Asset Value") as hereinafter
defined for the relevant Class, taking the investor's performance fee deficit or credit related to his investment in such
Class resulting from equalisation (the "Equalisation Adjustment") into account, if applicable, and net of such sales fee as
the selling documents may provide. The price so determined shall be payable within a period as determined by the Board
of Directors, which shall normally not exceed six (6) Luxembourg business days ("Business Days") from the relevant date
of valuation of the net assets of the Class (the "Valuation Day").
The Board of Directors may also accept subscriptions whereby the payment of subscription monies is made by means
of the transfer of an existing portfolio, as provided for in the Luxembourg law of 10 August 1915 (the "Law of 1915") as
amended, subject that all investments of this portfolio comply with the investment objectives and restrictions of the
relevant Sub-Fund. Such a portfolio must be easy to evaluate. A valuation report, the cost of which is to be borne by the
relevant investor, will be drawn up by the auditor, appointed pursuant to Article 22, according to article 26-1 (2) of the
Law of 1915 and will be filed at the registered office of the Company.
The Board of Directors may lay down restrictions on the frequency of issuance of Shares of a Class. In particular, the
Board of Directors may decide to issue Shares of a Class during one or more subscription periods or according to another
periodicity as provided for in the selling documents. Shares shall be issued only upon acceptance of the application and
after subscription monies have been received by the Company. The Board of Directors may subject subscriptions to any
further restrictions it considers fit and suitable.
The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company or to any other duly
authorised person, the duty of accepting subscriptions, receiving subscription monies and issuing new Shares relating
thereto.
Art. 8. Redemptions. The Board of Directors has the authority at any time, for efficient management purposes, to have
the Company redeem Shares of a Class closed to Shareholders' redemption requests, at a price determined hereafter.
As regards a limited duration Class, the Board of Directors will in principle have the Company redeem the Shares of
that Class on the last Valuation Day of the period determined in the selling documents, at a price based on the Net Asset
Value determined on that day, taking the Shareholder's Equalisation Adjustment into account, if applicable, and in principle
without redemption fee, as specified in the selling documents. The redemption proceeds shall normally be paid no later
than ten (10) Business Days after such Valuation Day. The Class will then be dissolved, unless the Board of Directors, on
the occasion of an extraordinary general meeting of Shareholders of the Class to be held in principle one (1) month
before the last Valuation Day of the period, makes an offer to the General Meeting of the Class concerned for the
continuation and/or the restructuring of the Class, possibly under slightly different terms and conditions, and the General
Meeting of the Class approves such an offer with the quorum and the majority of votes as is required for a modification
of the Articles. In any case, the right of the Shareholders to obtain redemption of their Shares on the Valuation Day in
principle without redemption fee shall remain fully preserved, whatever the resolution taken at such extraordinary general
meeting of Shareholders of the Class concerned.
Shareholders may not request the Company to redeem their Shares, unless the Board of Directors resolves to grant
such right to such Class Shareholders, according to such terms and conditions, as specified in the selling documents.
When Shareholders have redemption rights the following provisions apply.
The redemption proceeds shall normally be paid not later than fifteen (15) Business Days after the redemption day
("Redemption Day") concerned. The redemption price shall be based on the Net Asset Value of the relevant Shares, as
determined at the Redemption Day concerned and in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less a charge
at the rate provided by the selling documents and also taking the Shareholder's Equalisation Adjustment into account, if
applicable. The relevant redemption price may be rounded upward or downward as the Board of Directors may decide.
Any redemption request must be filed by such Shareholder in written form at the registered office of the Company or
17196
L
U X E M B O U R G
at any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of Shares and shall be accompanied
by the certificate(s) for such Shares in proper form (if issued) and by proper evidence of transfer or assignment (if
applicable).
In the event of suspension of the determination of the Net Asset Value pursuant to Article 12 hereof, if a redemption
request has not been revoked following the suspension, redemption will occur as of the first Redemption Day following
the lifting of the suspension. Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
No redemption by a single Shareholder may, unless otherwise decided by the Board of Directors, be for an amount of
less than that of the minimum redemption amount for the relevant Class as determined from time to time by the Board
of Directors and as specified in the selling documents.
If a redemption of Shares would reduce the value of the holdings of a single Shareholder of Shares of one Class below
the minimum holding as the Board of Directors shall determine for such Class from time to time and as specified in the
selling documents, then such Shareholder shall be deemed to have requested the redemption, as the case may be, of all
his Shares of such Class, unless the Board agrees on the contrary.
Further, if on any Valuation Day conversion requests pursuant to Article 9 and redemption requests pursuant to this
Article on aggregate exceed a determined ceiling of the number of Shares in issue of a specific Class or Sub-Fund, the
Board of Directors may decide that part or all of such requests for redemption and conversion will be deferred for a
period and in a manner that the Board of Directors considers to be in the best interests of the Company, such a period
in principle not exceeding three (3) Redemption Days. On the applicable Redemption Day following that period, these
redemption and conversion requests will be dealt with in a manner that the Board of Directors considers to be in the
best interest of the Company and its Shareholders. Any redemption and conversion request may again be subject to the
ceiling, if the Board of Directors considers that the implementation of all redemption and conversion requests on such
Redemption Day would adversely affect or prejudice the interests of the Company.
Under special circumstances affecting the interests of the Company, the Board of Directors may in turn delay a
proportionate part of the payment to Shareholders requesting redemption of Shares. The right to obtain redemption is
contingent upon the corresponding Sub-Fund having sufficient liquid assets to honour redemptions requests. The Com-
pany may also defer payment of the redemption of a Class if raising funds to pay such redemption would, in the opinion
of the Board of Directors, be unduly burdensome to the corresponding Sub-Fund. The payment may be deferred until
the special circumstances have ceased; the redemption price will be based on the then prevailing Net Asset Value, taking
the Shareholder's Equalisation Adjustment into account, if applicable, and taking into account any redemption fee provided
in the selling documents, if applicable.
The Board of Directors may proceed to a compulsory redemption of all outstanding Shares of a specific Class or Sub-
Fund, if so authorised by a simple majority of the Shares present or represented and voting at a general meeting of
Shareholders of such Class or Sub-Fund, in any event that the Board of Directors thinks it necessary for the best interest
of the Shareholders and the Company. The Board of Directors may also proceed to such compulsory redemption, without
authorisation, in case the net assets of a specific Class or Sub-Fund fall below the amount determined for the relevant
Class or Sub-Fund in the selling documents, upon thirty (30) days notice to the Shareholders concerned, or in other cases
as provided for in the selling documents.
The Board of Directors may subject redemptions to any restrictions it considers fit and suitable; in particular, the
Board of Directors may decide that Shares are not redeemable during a determined period, as specified in the selling
documents.
Art. 9. Conversion of Shares. Shareholders are not authorised to convert Shares of one Class into Shares of another
Class, unless the Board of Directors resolves to grant such right to Shareholders of such Class(es), under the terms and
conditions provided for in the selling documents.
When Shareholders have conversion right, the following provisions apply taking into account the terms and conditions
provided for in the selling documents. The conversion price shall be derived from the respective Net Asset Value of both
Classes concerned, determined on the same or subsequent Valuation Day, taking the Shareholder's Equalisation Adjust-
ment(s) on both sides into account, if applicable, as defined in Article 11 hereafter, and, if necessary, taking into account
the applicable exchange rate between the currencies of quotation (the "Dealing Currencies") of the Classes concerned.
If a conversion of Shares would reduce the value of the holdings of a single Shareholder of Shares of one Class below the
minimum holding applicable to such Class as the Board of Directors shall determine from time to time, then such Sha-
reholder could be requested to convert all his Shares of the Class concerned. The Shares of the Class switched out of
shall be cancelled. The provisions applicable to redemptions pursuant to Article 8 apply mutatis mutandis to conversions.
Art. 10. Restrictions on acquisition, Holding and Ownership of Shares. The Board of Directors may restrict or prevent
the acquisition, holding or ownership of Shares by any person, firm, corporate body or other entity, alone or in conjunction
with anyone else, (a) if in the judgement of the Board of Directors such acquisition, holding or ownership may be detri-
mental to the Company, any of its agents or the majority of its Shareholders or any Sub-Fund or Class, or (b) if it may
result in a breach of any law, rule, regulation or other requirement, whether Luxembourgish or foreign, or (c) if as a
result thereof it may have adverse regulatory, tax or legal consequences for the Company or any of its agents and/or its
service providers, in particular if as a result thereof the Company or any of its agents and/or service providers would
become subject to laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg (including but without limitation tax laws).
17197
L
U X E M B O U R G
Such person, firm, corporate body or other entity who is prevented or restricted to acquire, hold or own Shares due to
restrictions imposed by the Board of Directors is hereinafter being referred to as a "Prohibited Person".
For such purposes the Board of Directors may:
(i) decline to issue any Shares and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such issuance
or registry of transfer would or might result in the acquisition, holding or ownership of such Shares by a Prohibited
Person; and
(ii) at any time, whenever it thinks necessary, require a Shareholder, or anyone seeking to register the transfer of
Shares in the register of Shareholders, to furnish it with any information, supported by an affidavit, which it may consider
necessary for the purpose of determining whether or not the acquisition, holding or ownership of such Shareholder's
Shares rests or will rest in a Prohibited Person; and
(iii) decline to accept the vote by or on behalf of any Prohibited Person, holding or owning Shares, at any general
meeting of Shareholders; and
(iv) where it appears to the Board of Directors that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any
other person is a holder or an owner of Shares, direct such Prohibited Person, and if required such other person acting
in conjunction with such Prohibited Person in this respect, to validly transfer the holding or ownership of the relevant
Shares, whatever is the case, to a person not being a Prohibited Person and to provide to the Board of Directors evidence
of such transfer within a period determined by the Board. If the Board has decided to not give such a direction, or such
Prohibited Person and/or such other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect fail(s) to
comply with the direction, the Board may compulsorily redeem or cause to be redeemed all Shares held or owned by
such Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person in the following manner:
(1) The Board shall serve a notice (the "Compulsory Redemption Notice") upon the Prohibited Person and if required
any other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect holding such Shares or appearing in
the register of Shareholders as the owner(s) of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to be redeemed as
aforesaid, the date of redemption, the manner in which the price to be paid for such Shares will be calculated, and the
place at which the redemption proceeds in respect of such Shares are payable. Any such notice may be served upon such
Prohibited Person and if required any other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect by
posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such Prohibited Person and if required any other person
acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect at his/their last address known to or appearing in the
register of Shareholders. The said Prohibited Person and if required any other person acting in conjunction with such
Prohibited Person in this respect shall thereupon forthwith be obliged to deliver promptly to the Company the Share
certificate(s) representing the Shares specified in the Compulsory Redemption Notice. Immediately as of the close of
business on the date specified in the Compulsory Redemption Notice, such Prohibited Person and if required any other
person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect shall cease to be the holder(s) or owner(s) of
the Shares specified in such notice, and his/their name(s) shall be removed from the register of Shareholders.
(2) The price at which the Shares specified in a Compulsory Redemption Notice will be redeemed (the "Compulsory
Redemption Price") shall be the redemption price as defined in Article 8 hereof, less any redemption fee provided for in
the selling documents and less any extraordinary expenses incurred by the Company in relation to the compulsory
redemption.
(3) Payment of the Compulsory Redemption Price will be made available to the former Shareholder of such Shares
normally in the Dealing Currency of the Class concerned and will be deposited for payment to such former Shareholder
by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere as specified in the Compulsory Redemption Notice, upon final
determination of the Compulsory Redemption Price, following, if applicable, surrender of the Share certificate(s) specified
in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the Compulsory Redemption Notice
as aforesaid such former Shareholder shall have no further interest in such Shares or any of them, nor any claim against
the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the Compulsory Redemption Price (without
interest) from such bank following, if applicable, effective surrender of the Share certificate(s) as aforesaid. Any funds
receivable by a former Shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five (5) years from the date
specified in the Compulsory Redemption Notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the Sub-Fund that
comprises the relevant Class or Classes. The Board of Directors shall have the power from time to time to take all steps
necessary to perfect such reversion and to authorise such action on behalf of the Company.
(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Compulsory Redemption Notice, provided
that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.
U.S. Persons (as hereinafter defined) constitute a specific category of Prohibited Persons. The Sub-Funds are not open
to investment by U.S. Persons. Where it appears to the Board that any Shareholder is a U.S. Person, who either alone
or in conjunction with any other person is a holder or an owner of Shares, the Board may compulsorily redeem or cause
to be redeemed all Shares held or owned by such Prohibited Person, and if applicable by such other person acting in
conjunction with such Prohibited Person in this respect, without delay.
17198
L
U X E M B O U R G
For the purpose of these Articles, the term "U.S." or "United States" means the United States of America, its states,
districts, territories or possessions or an enclave of the United States government, its agencies or instrumentalities. The
term "U.S. Person" means a citizen or resident of the U.S., a corporation, partnership or other entity created or organised
in the U.S. or under U.S. laws, or any person falling within the definition of the term U.S. Person under Regulation S
promulgated under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or under Rule 4.7 under the U.S. Commodity Exchange
Act, as amended.
Art. 11. Net Asset Value calculation.
1. Valuation
For the purpose of determining the issue, conversion, and redemption price thereof, the Net Asset Value of Shares
in each Sub-Fund shall be determined by the Company or its delegate from time to time, but in principle not less than
once a month, as the Board of Directors may decide.
The Net Asset Value of each Sub-Fund will be expressed in the Reference Currency of the Sub-Fund concerned, and
will be determined on each Valuation Day by deducting total liabilities attributable to a Sub-Fund from total assets attri-
butable to such Sub-Fund.
When the Sub-Fund is comprised of one Class, the Net Asset Value per Share of the Class will be expressed in the
Reference Currency of the Sub-Fund and will be determined on each Valuation Day by dividing the net assets attributable
to the Sub-Fund by the number of Shares of the Class then outstanding and by rounding the resulting sum per Share to
the nearest lowest (current) sub-division of the currency concerned.
When the Sub-Fund is comprised of different Classes, the Net Asset Value of each Class will be valued in the Reference
Currency of the Sub-Fund and determined according to the provisions mentioned hereon, taking into account the specific
assets and liabilities attributable to each Class. If the Dealing Currency of a Class is different from the Reference Currency
of the corresponding Sub-Fund, the net assets of the Sub-Fund attributable to that Class valued in the Reference Currency
of the Sub-Fund will be converted into and expressed in the Dealing Currency of the Class concerned.
The Net Asset Value per Share of a Class in a Sub-Fund with multiple Classes will be expressed in the Dealing Currency
of the Class concerned and will be determined on each Valuation Day by dividing the total Net Asset Value of that Class
on that Valuation Day by the total number of Shares of that Class then outstanding and by rounding the resulting sum
per Share to the nearest lowest (current) sub-division of the currency concerned.
On each occasion when a dividend is declared payable, the Net Asset Value of the Shares which are entitled to such
dividend shall be reduced in line with the amount of the dividend.
If since the close of business of the relevant Valuation Day there has been a material change in the quotations on the
markets on which a substantial portion of the investments of the Sub-Fund is dealt or quoted, the Company may in order
to safeguard the interest of Shareholders and the Sub-Fund, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
All subscription, conversion and redemption applications without any exception will be processed at the price of this
second valuation.
The assets attributable to a Sub-Fund shall be deemed to include: (1) all cash in hand or on deposit, including accrued
interest; (2) all accounts receivable on demand and any amounts due to the Sub-Fund (including any cash dividends to be
received and outstanding settlements of Equity Interests positions which have been liquidated, but have not yet settled);
(3) all Equity Interests positions and any other investments (including stock dividends (to be) received and any rights
derived from corporate actions like conversions); (4) all accrued interest on any interest bearing accounts held by the
Company on behalf of the Sub-Fund except to the extent that such interest is comprised in the principal thereof; (5) the
prepaid expenses as far as these have not been written off or reimbursed; and (6) all other assets of any kind and nature
attributable to the Sub-Fund.
The valuation of the assets will be made as follows:
a. the value of any cash on hand or on deposit and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends declared but
not yet received and accrued interest shall be deemed to be the full amount thereof, unless the same is unlikely to be
paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the Company
may consider appropriate in such case to reflect the fair value of the asset;
b. the value of securities which are quoted or dealt in on any exchange shall normally be based, except as defined in
(e) below, on the last available price on the exchange on which the trade in such assets occurred or on that which is
normally the principal market for such assets;
c. securities dealt in on another organised market are valued in a manner as near as is reasonably possible to that
described in the preceding paragraph;
d. the liquidating value of derivative financial instruments not traded on exchanges shall mean their liquidating value,
determined, pursuant to policies established by the Board, on a basis consistently applied for each different variety of
contracts. The liquidating value of derivative financial instruments traded on exchanges shall normally be based upon the
settlement prices established on the exchanges on which the particular contracts are traded by the Sub-Fund; provided
that if a contract could not have been liquidated on the Valuation Day, the basis for determining the liquidating value of
such contract shall be such value as the Board may deem fair and reasonable; and
17199
L
U X E M B O U R G
e. in the event that any of the assets on the Valuation Day are not quoted or dealt in on any exchange or other organised
market or if, with respect to any asset quoted or dealt in on any exchange or dealt in on another organised market, the
price as determined pursuant to the preceding paragraphs is not, in the opinion of the Board of Directors, representative
of the fair market value of the relevant asset, the value of such asset will be determined prudently and in good faith on
the basis of the estimated settlement or sales price, in line with logical and customary points of reference in other markets.
The valuation of the assets shall be based on information (including without limitation, position reports, confirmation
statements, recap ledgers, etc.) which is available at the time of such valuation with respect to all positions in portfolio
and accrued interest income, accrued management, performance and service fees, and accrued brokerage commissions
and other trading costs.
The Board of Directors may rely upon confirmation from the prime brokers ("Prime Brokers"), the Custodian (as
defined in Article 28), the banks of the Company and their affiliates in determining the value of assets held for the Sub-
Funds. The Sub-Funds' income and expenses (including fees but excluding organisational expenses not yet charged) will
normally be determined on an accrual basis.
The liabilities attributable to a Sub-Fund shall be deemed to include: (1) all loans and accounts payable, including
outstanding settlements of Equity Interests positions which have been entered into, but have not yet settled; (2) all accrued
interest on loans of the Sub-Fund; (3) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations
for payments of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company with respect
to the Sub-Fund concerned; (4) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation
Day and any other provisions or reserves authorised and approved by the Board of Directors; and (5) all other liabilities
of whatsoever kind and nature comprising, without limitation, formation expenses, fees payable to its brokers or Invest-
ment Manager, as defined in Article 19, accountants, custodians, domiciliary, registrar, transfer and paying agents and
permanent representatives in places of registration, any other agent, officer or delegate employed by the Company, fees
for legal and auditing services, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising
or preparing and printing of the selling documents of the Company, explanatory memoranda or registration statements,
the cost of translating such documents in such languages as deemed appropriate, reasonable marketing expenses in
connection with the offering of Shares, the cost of obtaining and maintaining a listing on a stock exchange, all taxes or
governmental charges, all other operating expenses including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges
and brokerage, insurance, postage, telephone, telefax and telex, and all extraordinary expenses not incurred in the or-
dinary course of business including litigation and indemnification expenses, taking reimbursements by third parties into
account. The Company may calculate in respect of each Sub-Fund, administrative and other expenses of a regular or
recurring nature on an estimated figure of yearly or other periods in advance and may accrue the same in suitable
proportions over any such period.
The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if they consider that
such valuation better reflects the fair value of any asset or liability.
As far as possible, all investments and disinvestments decided upon until the Valuation Day will be included in the Net
Asset Value calculations.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, any Net Asset Value determined by the Company shall
be final and binding on the Sub-Funds, third parties and present, past and future Shareholders. The valuation will not be
audited or adjusted without good reason.
2. Allocation of assets and liabilities and of income and expenses
The Board shall establish a separate pool of assets and liabilities, income and expenses for each Sub-Fund. Such pool
shall be attributed only to the Sub-Fund concerned.
Pools of assets and liabilities, income and expenses of Sub-Funds are kept in segregated accounts, unless otherwise
specifically disclosed in the selling documents, and shall be established in the following manner:
a. the proceeds from the issue of Shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Company to the pool
of assets established for that Sub-Fund, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall
be applied to such Sub-Fund subject to the provisions of this chapter;
b. where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same Sub-Fund as the assets from which it is derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;
c. where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated
to the relevant Sub-Fund, and the creditors' recourse with respect of such a liability or of such an action, notwithstanding
anything to the contrary contained herein or in any other agreement or instrument with respect to such liability or such
an action, shall be limited solely to the assets of the relevant Sub-Fund which constitute, form and are the assets of the
relevant Sub-Fund and the creditor shall have no recourse for the satisfaction of such a liability or of such an action against
any attorney-in-fact acting on behalf of the Company, any other Sub-Fund, or any Shareholder, Director, officer, employee,
agent, service provider, representative or affiliate of the Company. Pursuant to article 181 of the Law of 2010, the
Company constitutes a single legal entity. However, each Sub-Fund corresponds to a distinct part of the assets and
liabilities of the Company;
17200
L
U X E M B O U R G
d. in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated between the relevant Sub-Funds on an equitable basis pro rata to their
number or to their respective net assets; and
e. in addition, upon the record date of assets and/or liabilities attributed to a specific Class according to its specific
management complement, the Net Asset Value of such Class shall be adapted accordingly by taking into account such
attributed assets and/or liabilities.
Assets allocated to an account at the Prime Brokers, Custodian, banks or other financial intermediary may comprise
assets of different Sub-Funds, only if and to the extent specifically provided in the selling documents. In such event each
Sub-Fund will have a pro rata entitlement to the assets comprised in such account.
The pro rata entitlements will be calculated at each Valuation Day and will vary with allocations and withdrawals made
on behalf of each Sub-Fund, and with changes in the exchange rates of the Reference Currency of each Sub-Fund involved
relative to the Reference Currencies of other Sub-Funds involved.
All income and realised gains or losses and changes in valuation of open positions attributable to each Sub-Fund shall
accrue to such Sub-Fund and all expenses and liabilities related to a particular Sub-Fund and any redemption of the Shares
related thereto shall be charged to and paid from the assets attributable to the relevant Sub-Fund. Thus, the Shareholders
of any Sub-Fund will not have any interest in any assets of the Company other than the assets attributable to the Sub-
Fund in which they are invested.
Pursuant to article 181 of the Law of 2010, the Company constitutes a single legal entity. Each Sub-Fund corresponds
to a distinct part of the assets and liabilities of the Company. The rights of Shareholders and creditors concerning a Sub-
Fund or which have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of a Sub-Fund are limited to the assets
of that Sub-Fund. The assets of a Sub-Fund are exclusively available to satisfy the rights of Shareholders in relation to that
Sub-Fund and the rights of those creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or
liquidation of that Sub-Fund. For the purpose of the relation between Shareholders, each Sub-Fund will be deemed to be
a separate entity. Therefore, the Net Asset Value of its Shares fluctuates according to the net assets to which they relate.
For the purposes of this Article:
a. Shares in respect of which application of subscription has been accepted but payment of the subscription monies
has not yet been received, shall be deemed to be existing as of the close of business on the Valuation Day on which they
have been allotted and the price therefore, until received by the Sub-Fund, shall be deemed an asset of the respective
Sub-Fund;
b. Shares of the Sub-Fund to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately as of the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from such time and until
paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the respective Sub-Fund;
c. all investments, cash balances and other assets of the Sub-Fund not expressed in the currency in which the Net
Asset Value of any Class of such Sub-Fund is denominated, shall be converted in that currency after taking into account
the market rate or rates of exchange prevailing at the relevant Valuation Day; and
d. effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Sub-Fund on
such Valuation Day, to the extent practicable.
Art. 12. Suspension of the Net Asset Value determination. The Board of Directors may suspend the determination of
the Net Asset Value and the issue, redemption and conversion of Shares of a Sub-Fund if caused by any of the items under
(a) through (e) below:
a. any period when any of the principal exchanges or other markets on which a substantial portion of the assets of the
Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary
holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended;
b. the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or a valuation of
assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund cannot be made normally or without seriously prejudicing
the interests of the Shareholders;
c. any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price or value
of any of the assets attributable to such Sub-Fund or the current price or values on any exchange in respect of the assets
attributable to such Sub-Fund;
d. any period when the Company is unable to repatriate funds for the purposes of making payments on the redemption
of the Shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of invest-
ments or payments due on redemption of Shares cannot in the opinion of the Board of Directors be effected at normal
rates of exchange; or
e. upon the publication of a notice convening a general meeting of Shareholders for the purpose of resolving dissolution
of the Company, a liquidation of a Sub-Fund, or a compulsory redemption of all outstanding Shares of a Sub-Fund or, in
cases where any such action does not require approval of the General Meeting of the Company or of the respective Sub-
Fund, upon the publication of a notice to the Shareholders for the purpose of notifying them of such action.
Any such suspension shall be notified to investors requesting issue, redemption or conversion of Shares by the Com-
pany at the time of application, or, if the resolution to suspend occurs after application but before an issue, redemption
17201
L
U X E M B O U R G
or conversion of Shares has been effectuated, upon the resolution to suspend. In the event of a suspension the Board of
Directors may determine another Valuation Day which will be announced in the same publication. The publication will
also be sent to the Shareholders.
Heading III. Management and Audit
Art. 13. The Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than
three members; members of the Board of Directors need not be Shareholders.
The Directors shall be elected by the General Meeting of the Company at the annual general meeting of Shareholders
for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a
Director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by means of a resolution adopted by the
General Meeting of the Company at a general meeting of Shareholders.
The Directors, whose names are specified on the meeting agenda for the annual general meeting of Shareholders for
the purposes of being proposed as Directors, are elected by the General Meeting of the Company at the majority of the
Shares present or represented and voting. The Directors, whose names are not proposed in the agenda, are elected by
the General Meeting of the Company at the majority votes of the outstanding Shares.
In the event of a vacancy in the office of director, the remaining Directors may elect, by a three-fifth (3/5) majority of
the Directors present or represented and voting at such meeting of the Board of Directors, a Director to fill for the time
being such vacancy until the next annual general meeting of Shareholders.
Art. 14. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors may choose from among its members a chairman
(the "Chairman", which will also refer to his duly appointed proxy), and may choose from among its members one or
more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who does not need to be a Director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.
The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors. If the Chairman is not present, the Board of
Directors may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented and
voting at any such meeting. The Board of Directors from time to time may appoint officers of the Company, including a
general manager, and any assistant general managers, assistant secretaries, advisory committees or other officers consi-
dered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time
by the Board of Directors. Officers need not be Directors or Shareholders. The officers appointed, unless otherwise
stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them by the Board of Directors.
The Board of Directors shall meet upon written notice by the Chairman, or by two Directors, to all Directors at least
five (5) days in advance of the hour set for such meeting. Such notice shall also set forth the place for the meeting. The
notice requirements may be waived by the consent in writing or by e-mail or fax of each Director. Separate notice shall
not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors. In circumstances of emergency, any Director may convene a meeting of the Board of Directors
without delay by notice by any means, specifying the emergency circumstances.
Any Director may have himself represented at a meeting of the Board of Directors by appointing in writing, duly signed,
another Director as his proxy. A Director duly appointed as proxy, may represent only one other Director at a meeting.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company
by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if more than three-fifth (3/5) of the Directors is present or
represented and voting at a meeting of the Board of Directors. Resolutions shall be taken by a majority of the Directors
present or represented and voting at such meeting.
In the event that in any meeting of the Board of Directors the number of votes for and against a resolution are equal,
the Chairman will have a casting vote.
Circular resolutions may also be passed by the Board of Directors, provided all Directors, by affixing their signature
to the wording of the written resolution on one or several similar documents, have hereby consented to the passing of
such circular resolution.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its
powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more Directors or officers of
the Company or to other contracting parties, as set forth in Article 17 hereafter.
Art. 15. Board of Directors' powers. The Board of Directors has the widest powers to carry out all acts of management
or of disposition that shall interest the Company, subject to the investment policy provided for in Article 18 hereafter.
All powers not expressly reserved for the General Meeting by law or by these Articles are intra vires the Board of
Directors.
Art. 16. Joint signature. The Company will be bound by the joint signature of at least two Directors or by the joint or
individual signature of any person(s) to whom signatory authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 17. Delegation of powers. In compliance with article 60 of the Law of 1915 the Board of Directors may delegate
its powers of the daily management of the Company, as well as the representation of the Company with respect to
17202
L
U X E M B O U R G
management, either to one or more Directors (whereby the Chairman may always replace one Director in such Director's
absence), or to one or more individuals, which may not necessarily be Directors, or legal entity or entities, and which
may, upon approval of the Board, sub-delegate his/their duties. The Board of Directors may give also special powers of
attorney under private or authentic form.
The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the affairs of the Sub-Funds and specific tasks to
committees consisting of persons involved in the management of the Sub-Funds other than Directors. Any committee so
formed shall, according to the powers so delegated, manage the Sub-Fund concerned, implement the investment policy
of the Sub-Fund concerned, be responsible for monitoring the compliance of the investments with these Articles and the
selling documents and be responsible for monitoring the marketing policy of the Sub-Fund concerned. Any committee
so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulation which may from time to time be
imposed by the Board of Directors.
Art. 18. Investment policy. The Board of Directors shall have power to determine, based upon the principle of risk
control, the investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, the
Sub-Funds and their relating Classes, as well as any restrictions which shall from time to time be applicable to the in-
vestments of the Sub-Funds and their related Classes, in compliance with applicable laws.
Art. 19. Investment Manager. The Board of Directors has appointed by means of an investment management agreement
Transtrend B.V., a Dutch limited liability company, as the core investment manager (the "Investment Manager") to the
Company. The Investment Manager shall supply the Company with recommendation and advice with respect to the
Company's investment policy pursuant to Article 18 hereof. In the event of termination of said agreement in any manner
whatsoever, the Company shall change its name and the name(s) of its Sub-Fund(s) forthwith upon the request of the
Investment Manager to a name not resembling the one specified in Article 1 hereof.
Art. 20. Directors' opposing interest. No contract or other transaction between the Company and any other corpo-
ration or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company
is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any Director or officer
of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any corporation or firm with which the
Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation
or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other
business.
In the event that any Director or officer of the Company may have an opposing interest in a transaction of the Company,
such Director or officer shall make known to the Board of Directors such opposing interest and shall not consider or
vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or officer's interest therein shall be reported to
the General Meeting of the Company at the next succeeding general meeting of Shareholders.
The term "opposing interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving the Investment Manager, the central administration agent, the Custodian,
the Prime Brokers or a bank of the Company, any subsidiary or affiliate thereof or such other company or entity as may
from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion.
Art. 21. Indemnification. The Company shall indemnify, protect and hold harmless any Director or officer of the
Company (each, an "Indemnitee") against losses, claims, damages, liabilities, costs and expenses (including, without limi-
tation, attorneys' and accountants' fees and disbursements), reasonably incurred by the Indemnitee in connection with
any action, suit or proceeding to which the Indemnitee may be a party,by reason of the Indemnitee being or having been
a Director or officer of the Company or, at the Company's request, of any other corporation of which the Company is
a shareholder or creditor and from which the Indemnitee is not entitled to similar indemnification (each, a "Proceeding").
Indemnification by the Company shall not apply if in a Proceeding the relevant judge(s) or arbitrator(s) shall have finally
ruled against the Indemnitee, or in relation to matters as to which the Indemnitee shall be finally adjudged in such Pro-
ceeding to be liable for gross negligence, willful misconduct, fraud or any other wrongful act. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Com-
pany is advised by counsel that the Indemnitee did not commit gross negligence, willful misconduct, fraud or any other
wrongful act. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the Indemnitee may be entitled.
Any indemnification obtained by the Indemnitee other than from the Company shall reduce to such extent the indem-
nification of the Company under this Article 21.
Art. 22. Audit of the Company. The Company shall appoint an authorised auditor who shall carry out the duties
prescribed by the Law of 2010.
Heading IV. General Meeting - Accounting year - Dividends
Art. 23. Representation. The General Meeting of the Company shall represent the entire body of Shareholders. Its
resolutions shall be binding upon all the Shareholders regardless of the Class held by them. It shall have the broadest
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
17203
L
U X E M B O U R G
However, if the resolutions only concern the particular rights or duties of the Shareholders of one Class or if the
possibility exists of a conflict of interest between different Classes, such resolutions are to be taken by the General
Meeting of such Class(es).
Art. 24. General Meetings. The Board of Directors has the authority to call any general meeting of Shareholders. The
Board of Directors must call the general meeting upon written request, specifying the agenda, emanating from Sharehol-
ders representing at least one- fifth (1/5) of the capital.
The annual general meeting of Shareholders is held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office of
the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Thursday
of May at 12.00 a.m. If such day is not a Business Day, the annual general meeting of Shareholders shall be held on the
next following Business Day.
Other general meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
The Chairman shall preside at all general meetings of Shareholders. If the Chairman is not present, the General Meeting
of the Company, the Sub-Fund or the Class, as the case may be, may appoint another Director or any other person as
chairman pro tempore by vote of the majority present or represented and voting at any such meeting. The Chairman,
or, in his absence, the chairman pro tempore, may choose a secretary who shall be responsible for keeping the minutes
of the general meeting.
Notices of all general meetings of Shareholders shall be sent by registered mail at least eight (8) days prior to the
meeting to each Shareholder at the Shareholder's address in the register of Shareholders. Such notices include the agenda
and specify the time and place of the meeting, the conditions for admission and refer to the requirements of applicable
Luxembourg law with regard to the necessary quorum and majorities required for the meeting. The convening notice for
the annual general meeting will be accompanied by a copy of the Company's audited annual report, or this notice will
indicate the place where and how such report may be obtained by Shareholders free of charge.
The Board of Directors may determine all conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to attend and
vote in any meeting of Shareholders.
If all Shareholders in a general meeting are present or represented and consider themselves duly convened and infor-
med of the agenda set forth for that meeting, such a meeting may take place without notice.
The General Meeting of the Company, Sub-Fund or Class may duly resolve only on the points set forth in the agenda
and on business incidental to such points. When the agenda provides for a director's election, the director's name,
proposed to be elected, shall be specified in the agenda. Resolutions passed by the General Meeting of the Company are
binding for all Shareholders, irrespective of the Sub-Fund or Class to which their Shares belong. Matters of interest to
one Sub-Fund or Class will require the vote of the holders of the Shares of the Sub-Fund or Class concerned, subject to
the provisions of Article 31 hereof.
Each amendment to the Articles entailing a variation of rights of the Shareholders of a Sub-Fund or Class must be
approved by a resolution of the General Meeting of the Company and by a resolution of the General Meeting of the Sub-
Fund or Class concerned.
Art. 25. Quorum and Majority conditions. The quorum required by law shall govern the conduct of the General Meeting
of the Company, Sub-Fund or Class, as the case may be, unless otherwise provided herein.
Each Share of whatever Sub-Fund and regardless of the Net Asset Value per Share within its Class, is entitled to one
vote, subject to the restrictions contained in these Articles. A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders
by giving a written proxy to another person, who does not need to be a Shareholder but can not be a Prohibited Person.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a general meeting of Shareholders
duly convened will be passed by simple majority of Shares present or represented and voting.
Art. 26. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
of January of each year and shall
end on the 31
st
of December of the same year.
Art. 27. Dividends. With respect to each Class, the General Meeting of each Class shall, upon the proposal of the
Board of Directors in respect of such Class, determine how the annual results of such Class shall be disposed of.
Any resolution as to the dividend payable on Shares of a Class shall be subject only to the vote of the General Meeting
of that Class; in this case, each Class is entitled to distribute the maximum dividend authorised by Luxembourg law.
With respect to each Class, the Board of Directors may decide to pay interim dividends in accordance with the law.
Payments of dividends will be made to Shareholders to a bank account in their own name or, only if not in breach with
any law, rule, regulation, order or directive applicable to the Company's business, in the name of designated third parties.
The Board of Directors may pay the dividends in such currency and at such time and place that it shall determine from
time to time.
Heading V. Final provisions
Art. 28. Custodian. To the extent provided for by the Law of 2010, the Company shall enter into a custodian agreement
with a bank (the "Custodian") which shall satisfy the requirements of the Law of 2010. All Equity Interests, cash, instru-
17204
L
U X E M B O U R G
ments and other assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian, who shall assume towards
the Company and its Shareholders the responsibilities provided by law.
In the event of the Custodian desiring to terminate the custodian agreement, the Board of Directors shall use its best
endeavours to find a successor custodian within two (2) months. The Board of Directors may terminate the appointment
of the Custodian, but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian has been appointed to act
in the place thereof.
Art. 29. Dissolution - Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting of the
Company adopted at any time in the manner required for an amendment in the Articles.
If the net assets of the Company fall below two-third (2/3) of the minimum capital, the Board of Directors is required
by law to submit the question of dissolution of the Company to the General Meeting for which no quorum shall be
prescribed and which shall decide by a simple majority of Shares present or represented and voting at the general meeting.
If the net assets of the Company fall below one-fourth (¼) of the minimum capital, the Board of Directors must submit
the question of the dissolution of the Company to the General Meeting for which no quorum shall be prescribed; disso-
lution may be resolved by Shareholders holding one-fourth (¼) of the Shares at the general meeting.
The general meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days as from the ascertainment
that the net assets have fallen below two-third (2/3) or one-fourth (¼) of the minimum capital, as the case may be.
The liquidation procedure provided for in Article 30 shall apply.
A Sub-Fund or Class may be liquidated by a resolution of its Shareholders adopted at any time in the manner required
for an amendment in the Articles.
The Board of Directors may also proceed, without authorisation, to the liquidation of a Sub-Fund or Class, if the
existence of such Sub-Fund or Class or the holding or owning of its Shares by certain investors would, in the opinion of
the Board of Directors, place the Company or any of its agents and/or service providers in breach of an applicable law,
a regulation or requirement of any jurisdiction, otherwise adversely affect or prejudice the tax status, residence or good
standing of the Company or any of its agents and/or service providers or otherwise cause the Company or any of its
agents to suffer material financial, legal or any other disadvantage.
In accordance with Article 8, the Board of Directors may, under certain circumstances, proceed to a compulsory
redemption of all Shares of a specific Sub-Fund or Class outstanding, which will in principle result in the Sub-Fund or Class
being liquidated, unless otherwise decided by the Board.
Each Sub-Fund or Class may be liquidated separately, i.e. the liquidation of one Sub-Fund or Class shall not by itself
mean that other Sub-Funds or Classes will have to be liquidated as well. Only the liquidation of the last remaining Sub-
Fund shall lead to dissolution of the Company within the meaning of article 145 of the Law of 2010.
At the discretion of the Board, the General Meeting of two or more Sub-Funds or Classes may at any time and upon
notice of the Board of Directors decide, without quorum and at the majority of the Shares present or represented and
voting for each Sub-Fund or Class concerned, to merge one or more Sub-Funds or Classes (the "Absorbed Sub-Fund(s)
or Class(es)") into another Sub-Fund or Class. In any case shall the Shareholders of the Absorbed Sub-Fund(s) or Class
(es) be offered the opportunity to redeem their Shares free of charge during a thirty (30) days period starting as from
the date on which the Company has notified them of the resolution to merge, it being understood that, at the expiration
of the same period, the resolution to merge will bind all the Shareholders who have not made use of this prerogative.
Further to the closing of any merger procedure, the auditor of the Company will report upon the way the entire procedure
has been conducted and shall certify the exchange parity of the Shares.
All Shareholders concerned by the resolution to liquidate a Sub-Fund or Class or to merge different Sub-Funds or
Classes will be notified. The Company may not merge one of its Sub-Funds with a third party, Luxembourgish or not.
In accordance with Article 12, the Board of Directors may suspend the determination of the Net Asset Value of Sub-
Funds and the issue, redemption and conversion of the Shares of such Sub-Funds upon the publication of a notice convening
a general meeting of Shareholders for the purpose of resolving dissolution of the Company, a liquidation of a Sub-Fund,
or a compulsory redemption of all outstanding Shares of a Sub-Fund or, in cases where any such action does not require
approval of the General Meeting of the Company or of the respective Sub-Fund, upon the publication of a notice to the
Shareholders for the purpose of notifying them of such action.
Art. 30. Liquidation procedure. In the event of the dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one
or several liquidators (who may be natural persons or legal entities), named by the General Meeting of the Company
deciding such dissolution and determining the liquidator's powers and remuneration.
The net proceeds of liquidation corresponding to each Class shall be distributed by the liquidator to the Shareholders
of each Class in proportion of their holding of Shares in such Class.
Art. 31. Articles amendment. These Articles may be amended from time to time by the General Meeting of the
Company, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment affecting
the rights of the Shareholders of any Class shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in
respect of each such relevant Class.
17205
L
U X E M B O U R G
Art. 32. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of
2010 and the Law of 1915."
Nothing else being on the agenda the meeting was closed at 9:30 a.m.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
this document are estimated at approximately one thousand three hundred thirty euros (EUR 1,330.-).
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English only in accordance with article 26 (2) of the Law of 2010.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Signé: M. BERNOT, A. SHMITT, L. BOEUF, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 novembre 2012. Relation: LAC/2012/54947. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, Délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
Luxembourg, le 31 janvier 2013.
Référence de publication: 2013018980/721.
(130021921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.
Japan Logistics Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 2.100.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 164.887.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution du conseil de gérance de la Société en date du 27 décembre 2012, que le siège social de la
Société a été transféré au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg avec effet au 27 décembre 2012.
Il en résulte également que le gérant unique de la Société, BRE/Management Asia S.A., a son siège social au 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg avec effet au 27 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013005874/17.
(130005519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2013.
China Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 161.162.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution du conseil de gérance de la Société en date du 27 décembre 2012, que le siège social de la
Société a été transféré au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg avec effet au 27 décembre 2012.
Il en résulte également que le gérant unique de la Société, BRE/Management Asia S.A., a son siège social au 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg avec effet au 27 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013005862/17.
(130005518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2013.
17206
L
U X E M B O U R G
Phoenix III Mixed O, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 108.723.
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société avec effet du 3 janvier 2013i>
En vertu de l'acte de transfert de parts, avec effet du 3 janvier 2013,
- la société Phoenix Holdco I S.à r.l. a transféré ses 462 parts sociales de la Société à Taliesin III GmbH & Co. KG,
ayant son siège social à Jägerstr. 58, 10117 Berlin, Allemagne, et
- la société Phoenix Holdco 2 GmbH & Co. KG a transféré ses 38 parts sociales de la Société à Taliesin Jersey Limited,
ayant son siège social à Elisabeth House, 9 Castle Street, St Helier, JE2 3RT, Jersey, Iles Anglo Normandes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2013.
Habiba Boughaba
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013004822/18.
(130004428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2013.
Phoenix II Mixed N, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 110.516.
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société avec effet du 3 janvier 2013i>
En vertu de l'acte de transfert de parts, avec effet du 3 janvier 2013,
- la société Phoenix Holdco I S.à r.l. a transféré ses 462 parts sociales de la Société à Taliesin III GmbH & Co. KG,
ayant son siège social à Jägerstr. 58, 10117 Berlin, Allemagne, et
- la société Phoenix Holdco 2 GmbH & Co. KG a transféré ses 38 parts sociales de la Société à Taliesin Jersey Limited,
ayant son siège social à Elisabeth House, 9 Castle Street, St Helier, JE2 3RT, Jersey, Iles Anglo Normandes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2013.
Habiba Boughaba
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013004819/18.
(130004344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2013.
Elikonos JEREMIE GP, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 170.705.
<i>Extrait des décisions des associés prises à Luxembourg en date de 20 Novembre 2012i>
A) Rosetran Holdings Limited a transféré 4,166 parts sociales à Slopepoint Limited, une société de droit chypriote,
ayant son siège social à Kostaki Pantelidi, 1, Bâtiment Kolokasides, 3
ème
étage, 1010, Nicosia, Chypre, enregistrée au
Registre des Sociétés de la République de Chypre sous le numéro HE 182440.
B) Rosetran Holdings Limited a transféré 4,167 parts sociales à Slopepoint Holdings Limited, une société de droit
chypriote, ayant son siège social à Kostaki Pantelidi, 1, Bâtiment Kolokasides, 3
ème
étage, 1010, Nicosia, Chypre, enre-
gistrée au Registre des Sociétés de la République de Chypre sous le numéro HE 180821.
<i>Pour Elikonos JEREMIE GP. S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013006080/18.
(130006414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
17207
L
U X E M B O U R G
McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.550,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 157.844.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 31 décembre 2012i>
- La démission de Monsieur John J. Coggins en tant que gérant de classe A de la Société a été acceptée avec effet au
31 décembre 2012.
- Monsieur José Eduardo de Oliveira Miron, né le 14 mars 1963 à Sao Paulo, Brésil, avec adresse professionnelle à c/
o Keystone Foods LLC, Five Tower Bridge, 300 Barr Harbor Drive, Suite 600, West Conshohocken, PA 19428, Etats-
Unis d'Amérique, a été nommé en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet au 31 décembre 2012 et
pour une durée indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013006259/18.
(130006143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
MosliB Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: CHF 17.000,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 158.592.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions de clôture de liquidation prises le 21 Décembre 2012 par l'assemblée générale extraordinaire des associési>
<i>de la société (en liquidation)i>
Par résolutions prises le 21 décembre 2012, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société a décidé:
- de clôturer la liquidation de la Société avec effet au 21 décembre 2012;
- que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au 64 rue Principale, L-5367 Schuttrange, Lu-
xembourg, pendant une période de cinq années à partir de la publication du présent extrait; et
- que toutes les dettes de la Société ont été payées et toutes distributions ou provisions nécessaires ont été faites.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013006267/17.
(130006407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
Financieringsmaatschappij voor Toerisme S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 98.859.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 4 octobre 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme FINANCIE-
RINGSMAATSCHAPPIJ VOOR TOERISME S.A., dont le siège social à L-1331 Luxembourg, 65, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, a été dénoncé en date du 3 septembre 2008.
Ce même jugement a ordonné la publication du dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à charge
du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Esch/Alzette, le 12 décembre 2012.
Pour extrait conforme
Maître Karim ZEDIRA
<i>Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2013006116/19.
(130006619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
17208
L
U X E M B O U R G
MBC Group LTD, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 142.799.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions du conseil d'administration de MBC Group Holding Hungary Limited Liability Company datées
du 03 janvier 2013 que:
1. La démission de Monsieur Serge Sehouenou en tant gérant de la Succursale a été acceptée avec effet au 31 décembre
2012;
2. Madame Sophie Jaffré, né le 27 juillet 1984 à Bar-le-Duc, France résidant professionnellement au 16 avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg a été nommé gérant de la Succursale avec effet 1
er
janvier 2013 et ce pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 11 janvier 2013.
Référence de publication: 2013006277/17.
(130006611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
McKey Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 787.575,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 101.381.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 31 décembre 2012i>
- La démission de Monsieur John J. Coggins en tant que gérant de catégorie A de la Société a été acceptée avec effet
au 31 décembre 2012.
- Monsieur José Eduardo de Oliveira Miron, né le 14 mars 1963 à Sao Paulo, Brésil, avec adresse professionnelle à c/
o Keystone Foods LLC, Five Tower Bridge, 300 Barr Harbor Drive, Suite 600, West Conshohocken, PA 19428, Etats-
Unis d'Amérique, a été nommé en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet au 31 décembre 2012
et pour une durée indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour McKey Luxembourg S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013006260/18.
(130006123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
La Concorde, Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 54.078.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la Société tenu en date du 29 octobre 2012 que Monsieur
Olivier LIEGEOIS a été nommé Président du Conseil d'Administration.
De plus, il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue extraordinairement en
date du 29 novembre 2012 que le mandat des personnes suivantes a été renouvelé avec effet immédiat et ce jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de la Société approuvant les comptes clos au 30 juin 2017:
- Monsieur Patrick MOINET, Administrateur,
- Monsieur Olivier LIEGEOIS, Administrateur,
- Monsieur Luc GERONDAL, Administrateur, et
- REVICONSULT S.à r.l., Commissaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2013.
Référence de publication: 2013008710/19.
(130009776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.
17209
L
U X E M B O U R G
LogAxes Austria III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.336.250,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 135.928.
EXTRAIT
La personne physique mentionnée ci-dessous a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 28
décembre 2012.
- M. John-Paul McKEON, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
Le conseil de gérance se compose donc comme suit au 28 décembre 2012:
- Alix VAN ORMELINGEN, Gérante
- Mark PHILLIPS, Gérant
Pour extrait conforme,
A Luxembourg, le 16 janvier 2013.
Référence de publication: 2013008704/18.
(130009692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.
Chessboard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 11.670,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 155.582.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique de la Société en date du 30 Novembre 2012i>
L'associé unique de la Société a décidé des modifications suivantes avec effet immédiat:
- D'accepter la démission de Joannes C. L. Van de Sanden en tant que gérant A de la Société;
- De nommer Miroslav Stoev, né le 4 Janvier 1976 à Sofia, Bulgarie, demeurant professionnellement au 20, rue de la
Poste, L-2346, Luxembourg, en tant que gérant A de la Société pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 30 Novembre 2012.
Jan Willem Overheul
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013006014/16.
(130006139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
Whirlpool Luxembourg Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 800.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 149.177.
En date du 21 décembre 2012, l'associé unique de la Société, Whirlpool Financial Corporation International, une société
à responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social sis à Corporate Service Company, 2711 Centerville Rd., Suite
400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware
sous le numéro 09233364, a transféré 800.000 (huit cent mille) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de
1 EUR (un Euro) chacune, à Whirlpool International Manufacturing S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social sis au 50, rue Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 139.331 ("WIM").
Il en résulte que WIM est devenu l'associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2013.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013006534/20.
(130006641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
17210
L
U X E M B O U R G
FERBLA S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 152.262.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15.01.2013.
<i>Pour: FERBLA S.A., société de gestion de patrimoine familial
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Cindy Szabo
Référence de publication: 2013007752/16.
(130008998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.
BRE/Europe 6-A Q S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.853.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution du conseil de gérance de la Société en date du 27 décembre 2012, que le siège social de la
Société a été transféré au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg avec effet au 27 décembre 2012.
Il en résulte également que le gérant unique de la Société, BRE/Management 6 S.A., a son siège social au 2-4, rue Eugène
Ruppert, L-2453, Luxembourg avec effet au 2 janvier 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013006516/17.
(130006696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
European CleanTech I SE, Société Européenne.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 155.076.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 20 décembre 2012i>
En date du 20 décembre 2012, le conseil d'administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de nommer Mercodi BVBA, représentée par Monsieur Jo CORNU en tant que président du conseil d'administration
de la Société;
- de nommer LDS NV, une Naamloze Vennotschap, constituée et régie selon les lois de Belgique, ayant son siège social
à l'adresse suivante: Notenbosdreef 2, 8210 Zedelgem, Belgique, et immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises (RLE Brugge, afdeling Oostende) sous le numéro 0885.592.380, ayant comme représentant permanent Mon-
sieur Luc DESENDER, né le 22 mai 1964 à Soest, Allemagne, résidant à l'adresse suivante: Notenbosdreef 2, 8210
Zedelgem, Belgique, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec pouvoir individuel de signature et avec
effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2013.
Electrawinds SE
Signature
Référence de publication: 2013006078/21.
(130006237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
17211
L
U X E M B O U R G
Charade S.A.H, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 38.830.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le juge-commissaire Thierry SCHILTZ en son rapport oral, le liqui-
dateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de
la société anonyme CHARADE S.A.H dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 25B boulevard Royal a été dénoncé le
1
er
décembre 2010.
Le prédit jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Me Anne DEVIN-KESSLER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013006029/16.
(130006582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
China Cargo Airlines Corporation Limited Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center.
R.C.S. Luxembourg B 104.871.
DISSOLUTION
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire 20.12.2012 à 10.00 heuresi>
L'assemblée décide que la succursale de Luxembourg "CHINA CARGO AIRLINES CORPORATION LIMITED LU-
XEMBOURG ", ayant son siège social à Cargo Center L-1360 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg section B, numéro 104871, est dissoute avec effet au 31.12.2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10.01.2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013006030/16.
(130006289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.
Meuse Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 103.711.
Il résulte d'un courrier adressé aux associés de la Société en date du 31 décembre 2012 que M. Oliver MAY a démis-
sionné de ses fonctions de gérant avec effet au 31 décembre 2012 à 18h00.
Il résulte par ailleurs d'un courrier adressé aux associés de la Société en date du 9 janvier 2013 que M. Dirk RUPPERT
a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet immédiat au 9 janvier 2013.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société:
- a été composé comme suit du 31 décembre 2012 au 9 janvier 2013:
* M. Rachid OUAÏCH, gérant;
* M. Paul DEVONSHIRE, gérant; et
* M. Dirk RUPPERT, gérant.
- sera composé comme suit à compter du 9 janvier 2013:
* M. Rachid OUAÏCH, gérant; et
* M. Paul DEVONSHIRE, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2013.
Référence de publication: 2013008734/22.
(130010028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.
17212
L
U X E M B O U R G
Nimacar S.à r.l. Unipersonnelle, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8530 Ell, 36, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 100.214.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013008768/10.
(130010133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.
Nabors Lux Finance 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.450,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 153.636.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2013.
Référence de publication: 2013008763/10.
(130009609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.
Mutual Competence Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3333 Hellange, 30, route de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 87.078.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013008761/10.
(130009339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.
Murasec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8262 Mamer, 5, rue de la Résistance.
R.C.S. Luxembourg B 123.947.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013008760/10.
(130009463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.
National Air Cargo (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 116.397.
Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 27 décembre 2012 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012;
- L'adresse professionnelle de Monsieur Geoffrey Henry et Monsieur Alberto Morandini a été transférée du 41, Bou-
levard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2013.
Référence de publication: 2013008764/14.
(130010051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2013.
17213
L
U X E M B O U R G
AW Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 9, rue Nicolas Brosius.
R.C.S. Luxembourg B 173.986.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-huitième jour de décembre.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu,
1. Monsieur Arthur Welter, né le 29 mars 1939 à Luxembourg, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4, Rue Nicolas
Gredt,
ici représenté par Madame Stéphanie Paché, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer 53
Route d'Arlon, en vertu d'un pouvoir sous seing privé; et
2. Madame Marie-José Ihry, épouse Welter, née le 15 novembre 1938, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4, Rue Nicolas
Gredt,
ici représentée par Madame Stéphanie Paché, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer 53
Route d'Arlon, En vertu d'un pouvoir sous seing privé.
Lesquels pouvoirs, après avoir été signés ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, resteront annexés aux
présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels parties comparantes, représentées comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentaire de documenter
les statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la société n'a qu'un associé unique, la société
peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la société.
La société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la
banqueroute de l'associé unique.
Art. 2. La société prend la dénomination de AW Invest S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social dans la commune de Leudelange.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toutes autres
manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours.
Art. 4. Le capital social de la société est fixé à UN MILLION D'EUROS (1.000.000,-EUR) représenté par dix mille
(10.000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune.
Art. 5. Les actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l'article trente neuf de la loi sur les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.
Art. 6. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura
le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme
propriétaire à l'égard de la société.
Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles entre actionnaires.
Cependant si un actionnaire désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, il doit les offrir préférentiellement
aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société.
En cas de désaccord sur le prix de cession, celui-ci sera fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent
céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés
ne s'entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxem-
bourg.
Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus
seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.
17214
L
U X E M B O U R G
Administration - Surveillance
Art. 8. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être
administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un repré-
sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 5 Ibis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 9. La Société est engagée en toute circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société,
par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou, le cas échéant, par la
signature individuelle de l'administrateur unique, ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un
tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.
Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra procéder à des ver-
sements d'acomptes sur dividendes.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action représentative du capital social donne droit
à une voix.
Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué
dans l'avis de convocation le dernier lundi de d'avril à 14 heures, et pour la première fois en l'an deux mille treize. Si ce
jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2
et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.
Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout ou il n'y est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. Arthur Welter, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.000 actions
2. Marie-José Irhy, épouse Welter, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 actions
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérés de sorte que la somme de UN MILLION D'EUROS
(1.000.000,-EUROS) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille treize.
La première assemblée générale se tiendra en deux mille quatorze.
17215
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 modifié de la loi
sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille deux cents
Euros (EUR 2.200).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les actionnaires représentant l'intégralité du capital social se sont constitués en assemblée et ont pris à
l'unanimité les décisions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
(i). - Arthur Welter, prénommé, né le 29 mars 1939 à Luxembourg, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4, Rue Nicolas
Gredt.
(ii). Marie-José Ihry, épouse Welter, née le 15 novembre 1938, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4, Rue Nicolas Gredt,
(iii). Viviane Welter, née le 15 avril 1965 à Luxembourg, demeurant à l-1934 Luxembourg, rue de Leudelange, 10.
(iv). Marianne Welter, née le 15 mars 1968 à Luxembourg, demeurant à L-1934 Luxembourg, rue de Leudelange, 12.
3 Est nommé administrateur-délégué: Arthur Welter, prénommé.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion.
4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Fiduciaire et Expertises (Luxembourg) SA, situé à 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, RCS Luxembourg B numéro 70909.
5. Le siège social est fixé à 9 rue Nicolas Brosius L-3372 Leudelange
<i>Pouvoirsi>
La personne comparante, agissant dans un intérêt commun, donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé
de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de
frappe(s)) au présent acte.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,
il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Stéphanie Paché, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 décembre 2012. LAC / 2012 / 61432. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
- Pour copie conforme - Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 janvier 2013.
Référence de publication: 2013003630/144.
(130004079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.
ATG Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 173.980.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eighteenth day of December,
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary, residing professionally in Junglinster, Grand-Duchy of Luxem-
bourg,
There appeared:
- ATG International, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 20,000, having its registered
address at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and in the process of registration with the Registre de Commerce
et des Sociétés, Luxembourg;
here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by
virtue of powers of attorney.
17216
L
U X E M B O U R G
The said powers of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:
Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by
Luxembourg law as well as by the present Articles (the "Company").
Art. 2. Name. The Company's name is ATG Holdings.
Art. 3. Purpose. The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form what-
soever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents, licenses, copyright, designs, secret pro-
cesses or formulas, trademarks or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop,
encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.
The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity
which form part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance,
loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as
borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.
Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its
purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand-
Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality by means of a resolution of the
sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles
or to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case
of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.
The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.
Title II - Capital - Shares
Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand US Dollars) divided into 20,000
(twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, fully paid-up.
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case
of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.
Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-
mensurate to such shareholder's ownership of shares.
Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only
one owner per share
Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the
Company has a sole shareholder.
Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.
Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning com-
mercial companies, as amended from time to time (the "Law").
Art. 10. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient
distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.
Title III - Management
Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where
more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different
types of managers, namely type A managers and type B managers.
No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole
shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent
17217
L
U X E M B O U R G
(50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.
A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or
in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the
share capital of the Company, as the case may be.
Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole
shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the sole manager or the board of managers, as the case may be.
The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint
signature of at least one type A manager and one type B manager.
The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one
or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.
Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among
its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and
who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.
The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,
the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.
Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another
manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication
means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear
each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.
A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present
in person or by proxyholder at least one type A manager and at least one type B manager.
Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers
of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented, including the favorable
vote of at least one type A manager and at least one type B manager. Deliberations of the board of managers shall be
recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the
chairman or two managers.
Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly
made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of
the Company.
Title IV - Shareholder meetings
Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in
accordance with the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing
Art. 16 General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of
managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least
24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed
on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as
such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.
Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-
holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at
a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.
Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share
capital represented. However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote
of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.
17218
L
U X E M B O U R G
The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed
twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote
and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.
When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-
Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice,
on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.
Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit
Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1
st
and ends on December 31
st
.
Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as
the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder,
or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.
Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.
Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This
allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.
The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution
of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute
it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.
Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the
case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement
of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.
Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be
entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several
statutory auditors.
No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.
Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%)
of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of
shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of
shareholders.
Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register
as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.
Title VI - Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality
of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.
Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the
sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the
shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets
of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders
proportionally to the shares they hold.
<i>Temporary provisioni>
Notwithstanding the provisions of article 17, the first financial year of the Company starts today and will end on
December 31, 2013.
17219
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription - Paymenti>
All the 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) representing the entire share
capital of the Company, have been entirely subscribed as follows:
- 20,000 (twenty thousand) shares representing all of the share capital of the Company subscribed by ATG International
S.a r.l., named above, subject to the payment of a share premium attached thereto amounting to USD 75,000 (seventy-
five thousand US Dollars), the whole being fully paid up by a contribution in cash of an amount of USD 95,000 (ninety-
five thousand US Dollars);
Therefore, the amount of USD 95,000 (ninety-five thousand US Dollars) is as now at the disposal of the Company,
proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,.450.-.
The contribution of 95.000,- USD is valued at EUR 72,156.10-.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders representing the entirety of the subscribed
share capital passed the following resolutions:
1) - Stewart Kam CHEONG, born on July 22, 1962 in Port Louis, Mauritius, and residing professionally at 6C, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg; and
- Hermann G. SCHOMMARZ, born on November 20, 1970 in Amersfoort, Netherlands, and residing professionally
at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg;
are appointed as type A managers of the Company for an undetermined duration;
- Maria FRIEDMAN, born on February 14, 1965 in Lake Worth, Florida, USA, residing professionally at 6205 Peachtree
Dunwoody Road, CP-12, Atlanta, GA 30328, USA;
is appointed as type B manager of the Company for an undetermined duration.
2) The registered office of the Company shall be established at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Junglinster, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the
present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-huit décembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
- ATG International, une société à responsabilité limitée (private limited liability company) et existant valablement en
vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 20.000 USD, ayant son adresse au 6C, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxembourg;
toutes deux ici représentées par Max Mayer demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations
données sous seing privé.
Les dites procurations paraphées ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.
La dite parties comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts»)
d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
Titre I
er
. - Forme- Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois
ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est ATG Holdings.
17220
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des
participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, licences, droit
d'auteurs, brevets, dessins et modèles, procédés ou secrets de fabrication, marques, et droits assimilés, ou tout autre
titre de propriété que la Société jugera opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre
ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées.
La Société pourra également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou com-
merciales, accorder à toute société ou entité associée d'une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un
intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu'em-
prunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.
Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants,
par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par
résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant
plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Titre II. - Capital - Parts sociales
Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille dollars américains), divisé en 20.000 (vingt mille)
parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune et sont chacune entièrement libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par
résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.
Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote
proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.
Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire
par part sociale.
Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés de la Société ou lorsque la Société a un
associé unique.
Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins
soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.
Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).
Art. 10. Rachat des parts. La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves
distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.
Titre III. - Gérance
Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où
plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories
différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.
Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en
cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.
Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé
unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.
Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique,
ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du
conseil de gérance, le cas échéant.
La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe
d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.
Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques
à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
17221
L
U X E M B O U R G
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.
Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses
membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour,
l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est
renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen
de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou
par tout autre moyen de communication approprié, s'ils sont initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant
à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation
est réputée équivalente à une participation physique.
Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type A
et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.
Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par
un vote de la majorité des gérants présents ou représentés, y inclus le vote favorable d'au moins un gérant de type A et
au moins un gérant de type B.
Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.
Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-
lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés con-
formément à la Loi.
Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la
Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.
Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,
le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut,
elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.
Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins
24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit
un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.
Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant
plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représentée. Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement
par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social
de la Société.
La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-
cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par
tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalable-
ment à son vote écrit.
Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au
Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant
si ce jour est férié.
Titre V. - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit
Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
17222
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas
échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité
d'associés à l'assemblé générale des associés.
Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,
charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des
associés, représente le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être
obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à
entière reconstitution.
Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés re-
présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés
proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.
Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,
peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.
Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un
commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.
Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.
Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur
mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.
Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes
à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée
générale des associés peut cependant nommé un réviseur d'entreprise à tout moment.
Titre VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par
l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la sus-
pension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.
Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé
unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui dé-
terminera leurs pouvoirs et rémunérations.
Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité
d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.
<i>Disposition temporairei>
Nonobstant les dispositions de l'article 17, le premier exercice de la société débute ce jour et s'achèvera le 31 dé-
cembre 2013.
<i>Souscription - Paiementi>
L'intégralité des 20.000 (vingt mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (une dollar américain) chacune
représentant la totalité du capital social de la Société a été entièrement souscrite comme suit:
- 20.000 (vingt mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société, souscrites par ATG Inter-
national S.à r.l. prénommée, moyennant le paiement d'une prime d'émission y attachée d'un montant de 75.000 (soixante-
quinze mille dollars américains), la totalité étant entièrement libérée par un apport en numéraire d'un montant de 95.000
USD (quatre-vingt-quinze mille dollars américains);
et
Par conséquent, le montant de 95.000 (quatre-vingt-quinze mille dollars américains) est donc à la disposition de la
Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
17223
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 1.450,- EUR
L'apport de 95.000,- USD est évalué à 72.156,10- EUR.
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant la totalité du capital social souscrit, ont
pris les résolutions suivantes:
1) - Stewart Kam CHEONG, né le 22 juillet 1962, à Port Louis, Ile Maurice, demeurant professionnellement au 6C,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg;
- Hermann G. SCHOMMARZ, né le 20 novembre 1970, à Amersfoort, Pays-Bas, demeurant professionnellement au
6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg;
sont nommés gérants de type A de la Société pour une période indéterminée;
- Maria FRIEDMAN, née le 14 février 1965, à Lake Worth, Floride, USA, demeurant professionnellement au 6205
Peachtree Dunwoody Road, CP-12, Atlanta, GA 30328, USA;
est nommée gérante de type B de la Société pour une période indéterminée.
2) Le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2012. Relation GRE/2012/4987. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 7 janvier 2013.
Référence de publication: 2013003623/424.
(130004046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.
TFB Fenster-Beteiligungs GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 173.915.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, am zehnten Dezember,
vor dem unterzeichnenden Notar Maître Marc Loesch, mit Amtssitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
Fenster Holding GmbH, eine société à responsabilité limité luxemburgischen Rechts, mit Verwaltungssitz in 26-28 rue
Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg mit einem Gesellschaftskapital von zwei Millionen
vierundzwanzigtausendachthundert Euro (EUR 2.024.800,-), im Registrierungsprozess beim Luxemburger Handels- und
Firmenregister;
hier vertreten durch Herrn Manfred Müller, Rechtsanwalt, mit Anschrift in Luxemburg,
kraft einer privatschriftlichen Vollmacht vom 6. Dezember 2012;
Die erschienene Partei ist die Alleingesellschafterin der Gesellschaft und wird im folgenden als „Gesellschafterin"
bezeichnet.
Die vorgenannte Vollmachte, welche durch die Vertreter der erschienenen Partei und den unterzeichnenden Notar
gegengezeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung dauerhaft beigefügt.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den amtierenden Notar gebeten folgendes zu beurkunden:
I. Die Gesellschafterin hält alle Gesellschaftsanteile der TFB Fenster-Beteiligungs GmbH, eine nach deutschem Recht
gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Zumhofer Strasse 25, D-73635 Rudersberg, Bundesrepublik
Deutschland eingetragen im Stuttgarter Handelsregister unter der Nummer HRB 282004 (die „Gesellschaft").
17224
L
U X E M B O U R G
II. Die Gesellschafterin, vertreten wie oben dargestellt, erklärte ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der
folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:
<i>Tagesordnungi>
1 Kenntnisnahme des Protokolls der Gesellschafterversammlung vom 6. Dezember 2012 welche in der Bundesrepublik
Deutschland stattfand bezüglich der Verlegung des Verwaltungssitzes (jedoch nicht des satzungsmäßigen Gesellschaftssi-
tzes) und des steuerlichen Sitzes der Gesellschaft, ohne Auflösung der Gesellschaft, von Rudersberg, Bundesrepublik
Deutschland nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2 Verlegung des Verwaltungssitzes (jedoch nicht des satzungsmäßigen Gesellschaftssitzes) und des steuerlichen Sitzes
der Gesellschaft, ohne Auflösung der Gesellschaft, von Rudersberg, Bundesrepublik Deutschland nach Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, mit Wirkung zum Datum dieser Gesellschafterversammlung.
3 Annahme der luxemburgischen Nationalität, Betreiben der Gesellschaft nach luxemburgischem und deutschem Recht
und Annahme der Gesellschaftsform einer „société à responsabilité limitée".
4 Zurkenntnisnahme eines Zwischenabschlusses der Gesellschaft vom 31. Oktober 2012 und eines Zertifikates der
Gesellschaftsführer bezüglich dieses Zwischenabschlusses.
5 Kenntnisnahme darüber dass das Nettovermögen der Gesellschaft mindestens dem ausgegebenen Stammkapital von
fünfzehn Millionen fünfhundertzweiundvierzigtausend Euro (EUR 15.542.000,-) entspricht und anschließend dass die Ge-
sellschaft die luxemburgischen gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen bezüglich der Mindestkapitalanforderungen für eine
société à responsabilité limitée folglich einhält.
6 Komplette Neuformulierung der Gesellschaftssatzung um diese in Einklang mit dem Gesellschaftsrecht des Großher-
zogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland zu bringen.
7 Bestimmung des Verwaltungssitzes der Gesellschaft: 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg.
8 Festsetzung der Anzahl der Gesellschaftsführer auf zwei (2) und Bestellung der folgenden Personen als Geschäfts-
führer auf unbegrenzte Zeit:
- Herr Michiel Kramer, geboren am 25. Januar 1961 in Hilversum (Niederlanden), Gesellschaftsführer, geschäftsansässig
in 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg); und
- Herr Heiko Dimmerling, geboren am 13. Januar 1970 in Fulda (Deutschland), Gesellschaftsführer, geschäftsansässig
in 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
III. Die Gesellschafterin, vertreten wie oben dargestellt, forderte daraufhin den amtierenden Notar auf folgende Bes-
chlüsse festzuhalten:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterin hat beschlossen, das Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 6. Dezember 2012 welche in
der Bundesrepublik Deutschland stattfand, bezüglich der Verlegung des Verwaltungssitzes (jedoch nicht des
satzungsmäßigen Gesellschaftssitzes) und des steuerlichen Sitzes der Gesellschaft, ohne Auflösung der Gesellschaft, von
Rudersberg, Bundesrepublik Deutschland nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zur Kenntnis zu nehmen.
Das erwähnte Protokoll der Gesellschafterversammlung, welches durch die Vertreter der erschienenen Partei und
den unterzeichnenden Notar ne varietur gegengezeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde beigefügt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterin hat beschlossen, den Verwaltungssitz (jedoch nicht den satzungsmäßigen Gesellschaftssitz) und
den steuerlichen Sitz der Gesellschaft, ohne Auflösung der Gesellschaft, von Rudersberg, Bundesrepublik Deutschland
nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zu verlegen, mit Wirkung zum Datum dieser Gesellschafterversammlung.
Die Gesellschafterin hat zur Kenntnis genommen, dass als Folge der oben genannten Verlegung, die Gesellschaft aus
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg verwaltet wird.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterin hat beschlossen, dass als Folge der oben genannten Verlegung, die Gesellschaft die luxemburgische
Nationalität annimmt, dass die Gesellschaft nach luxemburgischen und deutschem Recht betrieben wird und sie die Ge-
sellschaftsform einer „société à responsabilité limitée" annimmt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterin hat die Annahme eines Zwischenabschlusses der Gesellschaft vom 31. Oktober 2012 und eines
Zertifikates der Gesellschaftsführer bezüglich dieses Zwischenabschlusses, beschlossen.
Der besagte Zwischenabschluss und das Zertifikat, welche durch die Vertreter der erschienenen Partei und den un-
terzeichnenden Notar ne varietur gegengezeichnet wurden, bleiben dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung
dauerhaft beigefügt.
17225
L
U X E M B O U R G
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterin hat zur Kenntnis genommen, dass das Nettovermögen der Gesellschaft mindestens dem ausge-
gebenen Stammkapital von fünfzehn Millionen fünfhundertzweiundvierzigtausend Euro (EUR 15.542.000,-) entspricht, und
dass die Gesellschaft die luxemburgischen gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen bezüglich der Mindestkapitalanforder-
ungen für eine société à responsabilité limitée einhält.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterin hat die komplette Neuformulierung der Gesellschaftssatzung beschlossen um diese in Einklang
mit dem Gesellschaftsrecht des Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland zu bringen. Die Ge-
sellschafterin hat weiterhin beschlossen dass die Gesellschaftssatzung künftig wie folgt lautet:
„ § 1. Firma, Sitz.
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet TFB Fenster-Beteiligungs GmbH.
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Rudersberg.
(3) Der Sitz der Geschäftsführung und Verwaltung der Gesellschaft ist Luxemburg Stadt (Großherzogtum Luxemburg).
Dieser kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg
verlegt werden.
§ 2. Gegenstand des Unternehmens.
(1) Der Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere solchen aus der Fenster-Industrie.
(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen, die dem vorgenannten Zweck zu dienen geeignet sind.
§ 3. Stammkapital.
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 15.542.000,- (in Worten: fünfzehn Millionen fünfhundertzweiund-
vierzigtausend Euro) und ist derzeit in einen Geschäftsanteil mit einem Nennwert von EUR 15.542.000,- (in Worten:
fünfzehn Millionen fünfhundertzweiundvierzigtausend Euro) aufgeteilt. Der Geschäftsanteil ist vollständig eingezahlt.
(2) Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Geschäftsanteile mit denselben
Rechten und Pflichten ausgestattet.
(3) Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
(4) Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig
getroffenen Beschlüsse mit sich.
§ 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft einzeln. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemein-
sam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen oder allen Geschäftsführern
kann auch Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des Verbots, im Namen des Vertretenen
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft vorzunehmen (Verbot von Insichgeschäf-
ten), erteilt werden.
(2) Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und, mit oder ohne Angabe von Gründen,
abberufen. Diese schließt, ändert oder beendet auch die Dienstverträge mit den Geschäftsführern.
(3) Die Geschäftsführer üben ihr Amt in Übereinstimmung mit dem Gesetz, diesem Gesellschaftsvertrag, einer von
der Gesellschafterversammlung, beziehungsweise dem Gesellschafterausschuss zu beschließenden Geschäftsordnung und
den Beschlüssen und Weisungen der Gesellschafterversammlung beziehungsweise des Gesellschafterausschusses aus.
§ 5. Gesellschafterausschuss.
(1) Die Gesellschafterversammlung kann einen Gesellschafterausschuss wählen, der aus mindestens fünf (5) Mitgliedern
besteht. Die Gesellschafterversammlung kann eine höhere Zahl festlegen. Die Gesellschafterversammlung kann dem Ge-
sellschafterausschuss eine Geschäftsordnung geben.
(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Gesellschafterausschusses beträgt 4 Jahre, gerechnet ab ihrer Wahl. Die Wieder-
wahl ist zulässig. Mitglieder des Gesellschafterausschusses können ohne Angabe von Gründen vor Ablauf ihrer Amtszeit
durch Gesellschafterbeschluss abberufen werden. Jedes Mitglied kann ohne Angabe von Gründen vor Ablauf seiner
Amtszeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft sein Amt niederlegen.
(3) Der Gesellschafterausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, der den Gesellschafterausschuss zwischen
den Sitzungen und gegenüber Dritten im Rechtsverkehr vertritt und die Beschlüsse des Gesellschafterausschusses durch-
führt. Der Gesellschafterausschuss kann auch einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen, dem die Rechte des Vorsi-
tzenden im Falle dessen Verhinderung zustehen. Eine Abwahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters ist jederzeit ohne
Gründe zulässig.
17226
L
U X E M B O U R G
§ 6. Aufgaben des Gesellschafterausschusses.
(1) Der Gesellschafterausschuss ist das Vertrauensorgan der Gesellschafter. Er hat dem Wohl der Gesellschaft zu
dienen und die Interessen der Gesellschafter zu beachten. Er berät die Geschäftsleitung.
(2) Er ist berechtigt, soweit gesetzlich zulässig, eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung zu erlassen und einzelne
oder bestimmte Arten von Geschäften von seiner Zustimmung abhängig zu machen.
(3) Zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben ist der Gesellschafterausschuss regelmäßig von den Geschäfts-
führern über die Angelegenheiten der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen zu unterrichten. Der
Gesellschafterausschuss kann von der Geschäftsführung jederzeit die Erteilung von Auskünften sowie die Vorlage von
Berichten und Unterlagen verlangen. Er kann jederzeit die Geschäftsbücher, Unterlagen und die Kasse einsehen und
überprüfen. Der Gesellschafterausschuss kann die Wahrnehmung dieser Aufgaben auf einzelne Mitglieder delegieren.
(4) Wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist, kann der Gesellschafterausschuss eine Gesellschafterver-
sammlung einberufen.
(5) Der Gesellschafterausschuss ist kein Aufsichtsrat oder Geschäftsführungsrat.
§ 7. Sitzungen und Beschlussfassung des Gesellschafterausschusses.
(1) Der Gesellschafterausschuss kommt mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr zu einer Sitzung zusammen. An der
Sitzung des Gesellschafterausschusses können neben seinen Mitgliedern weitere Personen teilnehmen, die durch Bes-
chluss des Ausschusses im Einzelfall oder generell zu allen Sitzungen beigeladen werden.
(2) Beschlüsse des Gesellschafterausschusses werden in Sitzungen gefasst. Sofern kein Mitglied des Gesellschafteraus-
schusses widerspricht, können nach dem Ermessen des Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung seines Stellver-
treters, Beschlüsse auch durch Einholen schriftlicher, fernkopierter, fernmündlicher Erklärungen oder durch Erklärungen
per E-Mail oder Intranet gefasst werden. In diesem Falle ist eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung
von seinem Stellvertreter zu bestimmende Frist für den Eingang der Stimmen festzulegen.
(3) Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden vom Vorsitzenden einberufen. Die Einberufung hat schriftlich oder
per Telefax, EMail oder Intranet unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen. Der Vorsitzende - im Verhinderungsfalle
sein Stellvertreter - bestimmt den Sitzungsort und leitet die Sitzung.
(4) Der Gesellschafterausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung ordnungsgemäß geladen sind
und mindestens drei seiner Mitglieder - darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter - an der Abstimmung teilneh-
men. Abwesende Mitglieder des Gesellschafterausschusses können an der Beschlussfassung des Gesellschafterausschusses
dadurch teilnehmen, dass sie sich durch ein anderes Mitglied vertreten oder ihre schriftlichen Stimmabgaben überreichen
lassen.
(5) Der Gesellschafterausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden und im Falle seiner Verhinderung die seines Stellvertreters.
(6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Gesellschafterausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom
Vorsitzenden, im Verhinderungsfall seinem Stellvertreter, zu unterzeichnen ist; bei einer schriftlichen oder fernmündlichen
Beschlussfassung ist deren Ergebnis schriftlich niederzulegen, die Niederschrift vom Vorsitzenden des Gesellschafteraus-
schusses oder bei seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter zu unterzeichnen und den anderen Mitgliedern des
Gesellschafterausschusses unverzüglich zu überlassen.
(7) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses erhalten neben dem Ersatz der ihnen bei der Ausübung ihrer Amts-
tätigkeit erwachsenden Auslagen keine Vergütung, Zu dem Auslagenersatz werden anfallende Umsatzsteuern (Mehr-
wertsteuern) erstattet.
§ 8. Gesellschafterversammlungen.
(1) Gesellschafterversammlungen werden von den Geschäftsführern, dem Gesellschafterausschuss oder von Gesell-
schaftern, die zusammen mehr als zehn Prozent der Geschäftsanteile halten, einberufen. Jeder Geschäftsführer und der
Vorsitzende des Gesellschafterausschusses ist allein berechtigt, eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Gesell-
schafterversammlungen finden am Sitz der Geschäftsführung und Verwaltung der Gesellschaft beziehungsweise an dem
im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt. Die Einberufung erfolgt durch eingeschriebenen Brief unter Angabe der
Tagesordnungspunkte. Bei einer ordentlichen Gesellschafterversammlung ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen, bei
einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung eine Ladungsfrist von einer Woche einzuhalten, wobei der Tag der
Absendung und der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen sind. Der Verzicht auf Einberufungsformalitäten erfordert
einen einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter.
(2) Jährlich findet unverzüglich, spätestens einen Monat nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses der Gesell-
schaft durch den Gesellschafterausschuss die ordentliche Gesellschafterversammlung statt. Sie beschließt über die
Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Geschäftsführer, der Mitglieder
des Gesellschafterausschusses sowie die Wahl des Abschlussprüfers.
(3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses, wenn die
Gesellschafter nicht in der Versammlung mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen anderen Vorsitzenden bestellen.
(4) Sofern eine notarielle Niederschrift der Gesellschafterversammlung nicht aufgenommen worden ist, ist über den
Verlauf der Versammlung eine Niederschrift anzufertigen, die Ort und Datum der Versammlung, die Anwesenden, die
17227
L
U X E M B O U R G
Tagesordnungspunkte, den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen und die gefassten Beschlüsse festhält. Die Niederschrift
ist von dem Protokollführer und dem Vorsitzenden der Versammlung zu unterzeichnen; die Unterzeichnung ist jedoch
keine Wirksamkeitsvoraussetzung für die gefassten Beschlüsse.
§ 9. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht einberufen wurde zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von
Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, werden
Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Stammkapitals repräsentieren.
(2) Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen
Beschlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
(3) Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke
der Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen wird, entsprechen die Mehrheitsverhältnisse der Mehrheit der Anzahl
der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren.
(4) Gesellschafterbeschlüsse werden regelmäßig in Gesellschafterversammlungen getroffen. Außerhalb von Gesell-
schafterversammlungen können Beschlüsse schriftlich, fernschriftlich, fernmündlich, telegrafisch oder per Telefax gefasst
werden, sofern alle Gesellschafter sich daran beteiligen und gesetzlich keine strengere Form vorgeschrieben ist.
(5) Jeder Gesellschafter kann sich bei der Beschlussfassung aufgrund schriftlicher Vollmacht durch einen Bevollmäch-
tigten vertreten lassen und sich des Beistands eines Rechtsanwalts oder Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters bedienen.
(6) Fehlerhafte Beschlüsse, die nicht nichtig sind, können nur innerhalb einer Frist von einem Monat ab Beschlussfassung
angefochten werden.
(7) Soweit rechtlich zulässig, ist ein Gesellschafter zur Stimmabgabe auch bei einer Beschlussfassung über seine Ent-
lastung, über seine Befreiung von einer Verbindlichkeit oder über die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Erledigung
eines Rechtsstreits gegenüber der Gesellschaft berechtigt.
§ 10. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 11. Jahresabschluss, Gewinnverwendung.
(1) Der Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) mit Anhang und Lagebericht ist von den Geschäfts-
führern aufzustellen, von dem gewählten Abschlussprüfer zu prüfen und dem Gesellschafterausschuss innerhalb von drei
Monaten ab dem Ende eines Geschäftsjahrs mit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers und dem Gewinnverwen-
dungsvorschlag der Geschäftsführung vorzulegen.
(2) Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) einer Rücklage zugewiesen
(die „Rücklage").
Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Stammkapitals
erreicht.
(3) Nach der Zuweisung zur Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt
werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen
oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttfähigen Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Gesellschafter
ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.
(4) Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vors-
tehenden Bestimmungen, können die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Gesellschafter auszahlen. Die
Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.
§ 12. Verfügung über Geschäftsanteile.
(1) Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
(2) Der Alleingesellschafter kann seine Geschäftsanteile frei übertragen.
(3) Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Geschäftsanteile unter ihnen frei übertragbar
und die Geschäftsanteile können nur dann an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer
Mehrheit, die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.
§ 13. Dauer, Bekanntmachungen.
(1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
(2) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger und durch entsprechende
Publikationsmittel in Luxemburg.
§ 14. Salvatorische Klausel. Sollten Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder
ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Das gleiche
gilt für Lücken in dieser Satzung. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine ange-
messene Regelung gelten, die im Rahmen des rechtlich möglichen dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter
vereinbart hätten, hätten sie die Frage bei Gründung der Gesellschaft oder bei einer späteren Satzungsänderung bedacht.
17228
L
U X E M B O U R G
Dies gilt auch, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in der Satzung vorgeschriebenen Maß der Leistung
oder Zeit (Frist oder Termin) beruht. In diesem Fall soll ein dem Gewollten möglichst nahekommendes rechtlich zulässiges
Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) gelten. Die Gesellschafter werden die entsprechend notwendigen Sa-
tzungsänderungen in der gesetzlich vorgeschriebenen Form vornehmen."
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterin hat beschlossen, den Verwaltungssitz und den steuerlichen Sitz der Gesellschaft nach 26-28, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zu verlegen.
<i>Achter Beschlussi>
Die Gesellschafter haben beschlossen die Anzahl der Gesellschaftsführer auf zwei (2) festzulegen und folgende Per-
sonen als Geschäftsführer auf unbegrenzte Zeit zu bestellen:
- Herr Michiel Kramer, geboren am 25. Januar 1961 in Hilversum (Niederlanden), Gesellschaftsführer, geschäftsansässig
in 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg); und
- Herr Heiko Dimmerling, geboren am 13. Januar 1970 in Fulda (Deutschland), Gesellschaftsführer, geschäftsansässig
in 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg).
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund
dieser Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr fünftausendachthundert Euro (EUR 5.800,-) geschätzt.
Worüber Urkunde, die vorliegende Urkunde wurde aufgenommen in Luxemburg durch den unterzeichnenden Notar
zum eingangs erwähnten Datum.
Nachdem das Dokument dem Vollmachtnehmer der oben erschienenen Partei, welcher dem unterzeichnenden Notar
bekannt ist durch seinen Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz, vorgelesen wurde, hat dieser die vorliegende
originale Urkunde zusammen mit dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.
Signé: M. Müller, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 18 décembre 2012, REM/2012/1629. Reçu soixate-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 28 décembre 2012.
Référence de publication: 2013003479/272.
(130002711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2013.
Cabinet vétérinaire de l'Iris Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 51, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 173.964.
STATUTS
L'an deux mil douze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Madame Aurore CAUCHOIS, vétérinaire, né le 16 septembre 1977 à Villerupt (France), demeurant à F-54260
Longuyon, 6 Place Thibaut.
2) Monsieur Julian SCALONI, vétérinaire, né le 7 janvier 1976 à Messancy (Belgique), demeurant à B-6780 Turpange,
rue des Tisserands 85,
ici représentés par Madame Marie-Denise GUIOT-WILLEMET, expert-comptable, demeurant professionnellement au
Windhof, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles après avoir été signées «ne varietur»
par le mandataire comparant et le notaire instrumentant et resteront annexées au présent acte pour être formalisées
avec lui.
Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un Cabinet de Médecin-Vétérinaire ainsi que la vente des articles de la
branche.
17229
L
U X E M B O U R G
En général, la société pourra faire toutes opérations ou transactions de nature à promouvoir et faciliter la réalisation
ou l'extension de son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de «Cabinet vétérinaire de l'Iris Sàrl», société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune d'Esch-sur-Alzette.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- €) chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l'assemblée des associés.
L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil treize.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Madame Aurore CAUCHOIS, vétérinaire, né le 16 septembre 1977 à Villerupt (France),
demeurant à F-54260 Longuyon, 6 Place Thibaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
2) Monsieur Julian SCALONI, vétérinaire, né le 7 janvier 1976 à Messancy (Belgique),
demeurant à B-6780 Turpange, rue des Tisserands 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
17230
L
U X E M B O U R G
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500,- €) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
expressément.
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille trois cent cinquante euros (1.350,-
euros). A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au
paiement des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du
capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et,
après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à deux:
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Madame Aurore CAUCHOIS, vétérinaire, né le 16 septembre 1977 à Villerupt (France), demeurant à F-54260 Lon-
guyon, 6 Place Thibaut.
- Monsieur Julian SCALONI, vétérinaire, né le 7 janvier 1976 à Messancy (Belgique), demeurant à B-6780 Turpange,
rue des Tisserands 85.
La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature conjointe des
deux gérants.
3. L'adresse de la société est fixée à L-4323 Esch-sur-Alzette, 51, rue C.M. Spoo.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale
peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société pré-
sentement constituée.
Après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.-D. GUIOT-WILLEMET, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 3 janvier 2013. Relation: EAC/2013/73. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Pétange, le 8 janvier 2013.
Référence de publication: 2013003694/117.
(130003566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.
Cera-Net S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 44, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 57.578.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013009206/9.
(130010838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2013.
17231
L
U X E M B O U R G
Axis Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 105.159.
L'an deux mille douze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AXIS EUROPE S.A., avec siège
social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 105.159 (NIN 2004 2226 832),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 décembre 2004, publié au Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations numéro 335 du 14 avril 2005,
au capital social de trente et un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur
nominale de dix Euros (€ 10.-) chacune, entièrement libérées.
L'assemblée est présidée par Monsieur H.H.J. (Rob) KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à
L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Djilali KEHAL, employé privé, demeurant professionnel-
lement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Valérie ALBANTI, employée privée, demeurant professionnellement
à L-1610 Luxembourg, 42¬44, avenue de la Gare.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un liquidateur.
3.- Détermination de ses pouvoirs.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée "ne varietur" par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide la mise en liquidation de la société AXIS EUROPE S.A. avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée Luxglobal Services S.à r.l., avec siège social à L-1610
Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 160.089, comme liquidateur de la société.
<i>Troisième résolutioni>
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus par les articles
144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: H.H.J. KEMMERLING, D. KEHAL, V. ALBANTI, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 2 janvier 2013. Relation: ECH/2013/26. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Echternach, le 8 janvier 2013.
Référence de publication: 2013004494/53.
(130004837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
17232
ATG Holdings
AW Invest S.A.
Axis Europe S.A.
Bluegreen S.A.
BRE/Europe 6-A Q S.à r.l.
BRSG S.A., SPF
Cabinet vétérinaire de l'Iris Sàrl
Cera-Net S.à r.l.
Charade S.A.H
Chessboard S.à r.l.
China Cargo Airlines Corporation Limited Luxembourg
China Logistics S.à r.l.
Dengold Overseas S.A., SPF
DEXIA World Alternative
Dynamic Funds
Elikonos JEREMIE GP
European CleanTech I SE
Européenne de Diversification - Eurodiv S.A.
Falbala S.A., SPF
FERBLA S.A., société de gestion de patrimoine familial
Financière Blandine Spf S.A.
Financieringsmaatschappij voor Toerisme S.A.
First Baltic Property S.A.
German Bond Opportunities UI
Japan Logistics Topco S.à r.l.
La Concorde
Locationlux S.A.
LogAxes Austria III S.à r.l.
LRI Invest S.A.
LuxRis Holding S.à r.l.
Marit Invest S.A., SPF
MBC Group LTD, Luxembourg Branch
McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l.
McKey Luxembourg S.à r.l.
Meuse Invest S.à r.l.
MosliB Holdings Sàrl
Murasec S.à r.l.
Mutual Competence Company S.A.
Nabors Lux Finance 1
National Air Cargo (Luxembourg) Sàrl
Nimacar S.à r.l. Unipersonnelle
Phoenix III Mixed O
Phoenix II Mixed N
Racine Investissement S.A.
Sopura Sustainable Development Company S.A.
TFB Fenster-Beteiligungs GmbH
Tollamen SPF, SA
Tooris Estates S.A.
Transtrend Equity Strategies
Union Investment Luxembourg S.A.
Viggo S.A.
Whirlpool Luxembourg Ventures S.à r.l.