logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 164

23 janvier 2013

SOMMAIRE

AB (Holdings) 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

7831

Aki-Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7833

Al Badr B. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7833

Aldebaran Sociaty S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

7832

Alex Arendt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7872

Alison Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

7832

Am Weinebierg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

7831

Anathocys S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7832

Anjos Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7835

An.so.fi HOLDING S.A. (AMBOISE SO-

CIETE FINANCIERE)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

7831

AP.Diner S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7868

Aptical Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7833

Archimédial S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7832

Arjo International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

7832

Arkhia Architecture S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

7833

Arnould & Silberreiss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7833

Ascain Immobilière S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

7834

Asens S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7834

A.S. Hotels S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7830

Assolux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7830

Auberge de la Gaichel S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

7834

Automobiles Origer S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

7834

Axes GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7836

Axilis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7831

Bacur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7836

Beauty Secret sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7836

B.E.E.P. (Business Economy Engineering

Projects) Luxembourg, S.àr.l.  . . . . . . . . . .

7872

B. Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7835

Brinkdoor Limited T/A Euro London Ap-

pointments Luxembourg (succursale)  . .

7835

Brussco Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7868

B & S EF STEIG Immobilien AG . . . . . . . . .

7836

B & S Immobilien AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7835

b-to-v S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7828

Caesar Raseac S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7869

Dipta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7871

D'Owstellgleis S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7828

GC Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7871

GEORGES FABER Opticien S.à r.l.  . . . . . .

7870

Greenfield South Holdings S.à r.l. . . . . . . . .

7850

Groupe BÂTI.Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7871

iHouse Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7829

International Cores Luxembourg (I.C.L.)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7826

Interni Casa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7826

JFL IT Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

7830

JNG & Associés S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7828

KKR Actor Investor S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

7872

La Case Créole S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

7827

L.C. Buro'tic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7827

L'Oenophile Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7827

Logis-Concept S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7829

Lufra Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

7826

Lux Décor Peinture S.A. en abrégé LDP

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7827

Luxoil PJS GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7826

Meridiam Infrastructure A2 West S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7871

Miland Holding s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7826

Office Metro Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7830

PEC Anton S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7854

P.I.C. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7829

Steinfeld Investitionen S.A.  . . . . . . . . . . . . .

7837

Wellspring Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . .

7827

Xylem Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7846

Zentraleuropäische Immobilien Anlagege-

sellschaft A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7828

ZTA 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7829

7825

L

U X E M B O U R G

Luxoil PJS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 61, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 90.380.

Lés comptés annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012166985/10.
(120220594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Miland Holding s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 101.980.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012167003/10.
(120220272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

International Cores Luxembourg (I.C.L.) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 92.221.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012166875/10.
(120219977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Interni Casa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.351.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour INTERNI CASA S.à r.l.
Fideco Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012166877/12.
(120219790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Lufra Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 30.867.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2012.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2012166975/12.
(120219947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

7826

L

U X E M B O U R G

L.C. Buro'tic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 313, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.218.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2012166938/10.
(120220761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

L'Oenophile Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 4, rue de Kahler.

R.C.S. Luxembourg B 128.049.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012166942/10.
(120220215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

La Case Créole S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 131.924.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Gérant

Référence de publication: 2012166943/10.
(120220152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Lux Décor Peinture S.A. en abrégé LDP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 393, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 87.327.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2012166976/10.
(120220937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Wellspring Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 161.279.

EXTRAIT

Les comptes annuels de la Société du 22 avril 2011 au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012167356/14.
(120220174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

7827

L

U X E M B O U R G

ZIAG A.G., Zentraleuropäische Immobilien Anlagegesellschaft A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 161.233.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 11 décembre

2012 que le commissaire aux comptes VERIDICE S.à r.l., société à responsabilité limitée, R.S.C. Luxembourg B154843,
ayant son siège social au 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg a été remplacé par CONCI-
LIUM S.à r.l., société à responsabilité limitée, R.S.C. Luxembourg B161634, ayant son siège social au 34A, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, avec effet à partir du 3 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2012.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012167384/15.
(120219953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

JNG &amp; Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 107.045.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

En date du 15 novembre 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a déclaré closes pour absence d'actif

les opérations de liquidation de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Signature
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2012167413/14.
(120221112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

b-to-v S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 122.075.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgelaufene

Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21.12.2012.

<i>Für b-to-v S.à r.l.
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2012167440/13.
(120222501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

D'Owstellgleis S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6985 Hostert, 9, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 40.643.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/12/2012.

G.T. Experts comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2012167441/12.
(120222334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

7828

L

U X E M B O U R G

iHouse Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 151.056.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20/12/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2012167442/12.
(120221856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Logis-Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1530 Luxembourg, 53, rue Anatole France.

R.C.S. Luxembourg B 140.540.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 23 novembre 2012

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée d'un an, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012:

- AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012167420/13.
(120220686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

P.I.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 23.075.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

En date du 15 novembre 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a déclaré closes pour absence d'actif

les opérations de liquidation de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Signature
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2012167433/14.
(120221113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

ZTA 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R.C.S. Luxembourg B 161.834.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 novembre 2012, les décisions suivantes ont été prises:
Remplace le document déposé antérieurement: RCS B 161 834 L120218745
Enregistré et déposé le 19.12.2012
1. Est nommé Commissaire en remplacement TOP AUDIT SA. (anciennement de PKF ABAX AUDIT SA.) jusqu'à

l'Assemblée Générale statuant sur les Comptes Annuels clôturant au 31 décembre 2016:

EURAUDIT SA R.L., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, RCS Luxembourg B 42 889.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2012167386/15.
(120220832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

7829

L

U X E M B O U R G

A.S. Hotels S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 91.936.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal dʼArrondissement de et à Luxembourg, VI 

e

 section, siégeant en

matière commerciale, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société AS HOTELS SA, ayant
eu son siège social à L-1258 LUXEMBOURG, 1 Rue Jean-Pierre Brasseur

Les frais ont été mis à charge de la masse.

Pour extrait conforme
Me Joëlle NICLOU
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2012167444/15.
(120221661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Office Metro Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.454.

EXTRAIT

Il résulte de la décision intervenue qu'il y a lieu de rayer les gérants ci-après:
- Monsieur Mark Leslie James DIXON, né le 2 novembre 1959 à Hornchurch, Royaume-Uni, et
- Monsieur Douglas SUTHERLAND, né le 7 juin 1956 à Eugene, Oregon, Etats-Unis d'Amérique.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le curateur

Référence de publication: 2012167431/14.
(120220442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

JFL IT Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1268 Luxembourg, 27, rue Jean-Pierre Biermann.

R.C.S. Luxembourg B 166.806.

Par le présent avis, je soussigné Jean-Baptiste SAVARY, gérant et administrateur de la société JFL IT Consulting S.à.r.l,

vous informe de sa décision de transférer, à la date du 1 

er

 Janvier 2013, le siège social de la société de l'adresse suivante:

21, Rue Jean-Pierre Biermann L-1268 LUXEMBOURG
A la nouvelle adresse suivante:
27, Rue Jean-Pierre Biermann L-1268 LUXEMBOURG

Jean-Baptiste SAVARY.

Référence de publication: 2012167412/13.
(120220669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Assolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 68.527.

Le bilan de la société au 31 mars 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012167462/12.
(120221884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

7830

L

U X E M B O U R G

AB (Holdings) 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 140.455.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2012.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2012167467/12.
(120221896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

An.so.fi HOLDING S.A. (AMBOISE SOCIETE FINANCIERE), Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 100.994.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour An.so.fi HOLDING S.A. (AMBOISE SOCIETE FINANCIERE)
Société anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012167455/14.
(120222664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Axilis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 129.589.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2012

- Monsieur KESSEL Aubry cède à Monsieur PIRLET Alain 100 parts de la société AXILIS S.à r.l.

Extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012167523/11.
(120222310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Am Weinebierg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9519 Wiltz, 48, route d'Ettelbrück.

R.C.S. Luxembourg B 100.459.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 21/12/2012.

<i>Pour la société
C.F.N GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P. 80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012167453/17.
(120222294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

7831

L

U X E M B O U R G

Anathocys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 125.803.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

ANATHOCYS S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2012167456/14.
(120222121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Archimédial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 76.833.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAHAUX Claude
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012167458/11.
(120222012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Arjo International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 75.106.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2012167459/11.
(120221715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Aldebaran Sociaty S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 107.384.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012167488/9.
(120222462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Alison Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 33, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 76.756.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012167489/9.
(120222018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

7832

L

U X E M B O U R G

Aki-Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 115.411.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012167486/10.
(120222021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Al Badr B. S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 40.505.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 14 décembre

<i>2012 à Luxembourg.

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société AL BADR B. S. A., qui cessera d'exister.
L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 50, Route d'Esch

à L-1450 Luxembourg.

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Directors / Administrateurs

Référence de publication: 2012167487/16.
(120223133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Arkhia Architecture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4430 Belvaux, 28, rue G.-D. Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 120.671.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012167506/10.
(120222024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Arnould &amp; Silberreiss, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 38, rue des Martyrs.

R.C.S. Luxembourg B 105.609.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012167507/9.
(120221332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Aptical Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 83.934.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012167502/9.
(120222436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

7833

L

U X E M B O U R G

Automobiles Origer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3813 Schifflange, 55-57, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 65.923.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2012167518/13.
(120221756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Auberge de la Gaichel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8469 Gaichel, Maison 7.

R.C.S. Luxembourg B 111.005.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arlon, le 20/12/2012.

AUBERGE DE LA GAICHEL S.à.r.l.
SUD FIDUCIAIRE SPRL

Référence de publication: 2012167515/12.
(120222483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Asens S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 29.665.

Le bilan et le compte de perte et profits au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/12/2012.

BEMO EUROPE - BANQUE PRIVEE
18, bd Royal, L2449 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2012167512/14.
(120222260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Ascain Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 102.627.

EXTRAIT

Le 1 

er

 décembre 2012, les associés de la société ont décidé, conformément à l'article 4 des statuts de la société, de

transférer:

- le siège social de la société de L-1255 Luxembourg, 1.2, rue de Bragance, à L-1221 Luxembourg. 207 rue de Beggen;
- les adresses professionnelles des associés actuels de la société et de son gérant de L-1255 Luxembourg, 12, rue de

Bragance, à L-1221 Luxembourg, 207 rue de Beggen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012167511/15.
(120221323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

7834

L

U X E M B O U R G

Brinkdoor Limited T/A Euro London Appointments Luxembourg (succursale), Succursale d'une société

de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 124.262.

EXTRAIT

En date du 06 Décembre 2012, la maison mère de la Succursale a pris la résolution suivante:
- Notification du changement d’adresse de la Succursale du 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au

15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, avec effet rétroactif au 30 avril 2012.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 21 Décembre 2012.

Référence de publication: 2012167543/14.
(120222590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

B. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Luxembourg, 8, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 51.070.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

a déclaré closes pour absence d'actif, les opérations de liquidation de la société:

B.LUX S.A., ayant eu son siège social à L-1274 HOWALD, 8, rue des Bruyères, inscrite au registre de commerce de

Luxembourg sous le n° RC B 51 070;

Pour extrait conforme
Me Céline HENRY-CITTON
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2012167533/15.
(120222226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

B &amp; S Immobilien AG, Société Anonyme.

Siège social: L-5440 Remerschen, 124, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 142.098.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20/12/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2012167531/12.
(120221496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Anjos Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 89.101.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait de la résolution de l'actionnaire unique en date du 18 décembre 2012

Il résulte de la résolution de l'associé unique que la liquidation de la société Anjos Holding S.A. a été clôturée. Les

livres et documents comptables seront conservés pendant une période de 5 ans au siège social de la société.

Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012167497/13.
(120221995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

7835

L

U X E M B O U R G

Bacur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 90.230.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2012

Les actionnaires renouvellent le mandat de commissaire de Monsieur Armand Fohl, employé privé, demeurant à 2,

rue du Kiem L-5337 Moutfort.

Le mandat prendra fin lors de l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2012167546/13.
(120221461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

B &amp; S EF STEIG Immobilien AG, Société Anonyme.

Siège social: L-5440 Remerschen, 124, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 142.024.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20/12/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2012167530/12.
(120221470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Axes GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5434 Niederdonven, 16, rue de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 89.096.

<i>Auszug des Beschlusses der Generalversammlung vom 17. Dezember 2012

Die Generalversammlung beschliesst:
- den Rücktritt von Herrn Bernd May vom Amt des Geschäftsführers mit Wirkung zum 17.12.2012 anzunehmen;
- zum neuen Geschäftsführer wird Herr Olaf Lexen, geb. am 05.10.1970 in D- Trier, wohnhaft in 16, rue de la Moselle,

L - 5434 Niederdonven mit Wirkung zum 17.12.2012 ernannt.

Luxemburg, den 17.12.2012.

<i>Für die Gesellschaft

Référence de publication: 2012167522/14.
(120221983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

Beauty Secret sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5380 Uebersyren, 22, rue de Mensdorf.

R.C.S. Luxembourg B 164.675.

RECTIFICATIF

Les  comptes  rectificatifs  au  31  décembre  2011  (rectificatif  des  comptes  au  31.12.2011  déposés  le  16.08.2012  no

L120144419) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BEAUTY SECRET SARL
G&amp;G Associates Sàrl
Gioacchino GALIONE
<i>Gérant

Référence de publication: 2012167552/15.
(120221760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.

7836

L

U X E M B O U R G

Steinfeld Investitionen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 173.328.

STATUTS

L'an deux mille douze, le trente novembre;
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

A COMPARU

SGG S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à

L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 65906,

ici représentée par Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, employé, résidant professionnellement à L-2086 Luxembourg,

412F, route d'Esch, (le Mandataire), en vertu d'une procuration donnée sous seing privée le 26 novembre 2012.

Laquelle  procuration,  après  avoir  été  signée  «ne  varietur»  par  le  Mandataire  et  le  notaire  instrumentant,  restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.

1.1 II est formé une société anonyme (la Société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,

notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (la Loi), et par les présents
statuts (les Statuts).

1.2 La Société existe sous la dénomination de «STEINFELD INVESTITIONEN S.A.».
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra

pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.

Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-

tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique)
par une décision de l'Administrateur Unique.

2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

4.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

4.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

4.4 La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.

4.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

7837

L

U X E M B O U R G

4.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) représenté par cinq mille (5.000) actions

ordinaires d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

5.2 Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de quarante millions (EUR

40.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) à quarante-cinq millions
d'euros (EUR 45.000.000,-), le cas échéant par l'émission de quarante mille (40.000) actions de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

5.3 En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non
spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nou-
velles,  la  libération  et  les  augmentations  effectives  du  capital  et  enfin,  à  mettre  les  statuts  en  concordance  avec  les
modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

5.4 De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

5.5 Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rem-

boursement et toutes autres conditions y ayant trait.

5.6 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
5.7 Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le Conseil d'Administration

est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

5.8 Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors

d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit pourront
être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-
tière de modifications des statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de

l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la
Loi.

6.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.

6.3 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.

Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une réfé-
rence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assem-

blée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de

la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le dernier lundi de juin à 17.00
heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.

7.4 L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des

circonstances exceptionnelles le requièrent.

7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

7838

L

U X E M B O U R G

7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-

rence  ou  tout  autre  moyen  de  communication  similaire  grâce  auquel  (i)  les  actionnaires  participant  à  la  réunion  de
l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de

l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

8.2 Chaque action donne droit à une voix.
8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée

Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 9. Administration de la Société.
9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration

composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Associé
Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a (ont) pas besoin d'être
actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'ad-
ministrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).

9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée

Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un
administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.
10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et

peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au

lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis
par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit
jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un

autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont

présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après
l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire,
s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.

Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.

10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence

téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

7839

L

U X E M B O U R G

10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise

par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du

Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière.

12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution

de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou
l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Adminis-
tration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature

conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent
ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des
affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi,

par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant pas six ans et
il est rééligible.

15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

la même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des
Statuts.

17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer

des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société.

17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et

doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

7840

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à
la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et
qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera
également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi.

Art. 20. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2014.
Exceptionnellement et dans le respect de l'article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la première

assemblée générale annuelle se tiendra le 30 mai 2014.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, l'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus,

déclare souscrire les cinq mille (5.000) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions sont libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en nu-

méraire, de sorte que le montant de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et en constate

expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de
la Loi.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de EUR 3.400,-.

<i>Résolutions de l'associé unique

L'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social sou-

scrit, prend les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un);
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
(i) Monsieur Serge KRANCENBLUM, M.B.A., né à Metz (France), le 8 octobre 1961, demeurant professionnellement

au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

(ii) Monsieur Jean-Hugues DOUBET, Maître en droit privé, né à Strasbourg (France), le 7 mai 1974, demeurant pro-

fessionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

(iii) Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, employé, né à Carpentras (France), le 10 août 1977, demeurant profession-

nellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

3. FIN-CONTROLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 42230 est nommée commissaire de la Société;

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de l'année 2017; et

5. l' adresse du siège social de la Société est établie à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français et l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth of November;

7841

L

U X E M B O U R G

Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED

SGG S.A., a public limited company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having

its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, registered with the Trade and Companies Registry Lux-
embourg under number B 65906,

here represented by Mr. Pierre-Siffrein GUILLET, employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route

d'Esch, by virtue of a proxy given under private seal dated November 26, 2012 (the Proxyholder).

The said proxy, after having been signed «ne varietur» by the Proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, requested the notary to state as follows the articles of incorporation

of a public limited liability company ('société anonyme") which is hereby incorporated:

Art. 1. Form and Name.
1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (the Company) which will be

governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the Law), and by the present articles of incorporation (the Articles).

1.2 The Company will exist under the name of "STEINFELD INVESTITIONEN S.A.".
1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of

directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole
Director.

2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or

are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted

in the manner required for amendments of the Articles.

Art. 4. Corporate objects.
4.1 The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests

in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as
well as the administration, management, control and development of such participations.

4.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real

estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

4.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a

portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

4.4 The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of

companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.

4.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
4.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and that
aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital is set at five million Euros (EUR 5,000,000.-) consisting of five thousand (5,000) ordinary

shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.

7842

L

U X E M B O U R G

5.2 The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by forty millions Euros (40,000,000.-)

in order to raise it up from five million Euros (EUR 5,000,000.-) to forty-five million Euros (45,000,000.-) as the case may
be by the issue of forty thousand (40,000) shares of a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each, having the
same rights as the existing shares.

5.3 The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to
determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix
all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution,
to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of
capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized
and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10 

th

 , 1915 and especially under the

condition that the authorization has to be renewed every five years.

5.4 Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer

form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the
limits of the authorized capital.

5.5 The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reim-

bursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

5.6 A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
5.7 The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase

of capital within the limits of the authorized capital.

5.8 The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general

meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 6. Shares.
6.1 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form,

at the opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the Shareholders, subject
to the restrictions foreseen by Law.

6.2 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title

of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint
one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct
holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.3 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

Art. 7. Meetings of the shareholders of the Company.
7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In

these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or
powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.

7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company

(the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers
to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of

the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on the last Monday of June at 17.00. If such day is not a business day for banks in
Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional

circumstances so require.

7.5 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

7.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partic-
ipating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.

Art. 8. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.
8.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General

Meetings, unless otherwise provided herein.

8.2 Each share is entitled to one vote.

7843

L

U X E M B O U R G

8.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in

original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

8.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves

as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 9. Management.
9.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors

composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole
Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s)
of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors
(A Directors and B Directors).

9.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General

Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall
be eligible for reappointment.

9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors

elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of
shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board.
10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and

may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who
need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well
as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person

delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the
meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors
shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circum-
stances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax
or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,

or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented

at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event

that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or

similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent

in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 11. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed

all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 12. Delegation of powers.
12.1 The Board of Directors may appoint one delegate to the day to day management of the Company, who need not

to be neither a shareholder neither a Directors, who will have the full power to act in the name of the Company concerning
the day to day management.

12.2 The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

7844

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Binding signatures.
13.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two

members of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to
whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

13.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A

Director together with any B Director.

Art. 14. Conflict of interests.
14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

14.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of

the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning
transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

Art. 15. Statutory Auditor(s).
15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or,

where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be
elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

15.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their

remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1 

st

 of January of each year and shall

terminate on the 31 

st

 of December of the same year.

Art. 17. Allocation of profits.
17.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

17.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may

alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

17.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such

places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Law.

Art. 18. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General

Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company,
the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed
by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remu-
neration of the liquidator(s).

Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,

subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.

Art. 20. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitory provisions

The first business year begins on this day and ends on the 31 

st

 of December 2013.

The first annual General Meeting will be held in 2014.
Exceptionally and in the respect of article 70 of the law of August 10, 1915 on Commercial Companies, the first annual

general meeting will be held on May 30, 2014.

7845

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and Payment

The Articles of the Company having thus been established, the Sole Shareholder, pre-named, represented as stated

above, hereby declares to subscribe to the five thousand (5,000) shares representing the total share capital of the Com-
pany.

All these shares are paid up by the Sole Shareholder to an extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash,

so that the amount of five million Euros (EUR 5,000,000.-) paid by the Sole Shareholder is from now on at the free disposal
of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law have been fulfilled and

expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply
with the provisions of article 27 of the Law.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 3,400.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The Sole Shareholder, pre-named, represented as stated above, representing the entire of the subscribed capital,

passed the following resolutions:

1. the number of directors is set at 3 (three) and the number of auditors at 1 (one);
2. the following persons are appointed as directors:
(i) Mr. Serge KRANCENBLUM, M.B.A., born in Metz (France), on October 8, 1961, residing professionally at 412F,

route d'Esch, L-2086 Luxembourg:

(ii) Mr. Jean-Hugues DOUBET, Maître en droit privé, born in Strasbourg (France), on May 7, 1974, residing profes-

sionally at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg; and

(iii) Mr. Pierre-Siffrein GUILLET, employee, born in Carpentras (France), on August 10, 1977, residing professionally

at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

3. FIN-CONTROLE S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated and existing under Luxembourg

law, having its registered office in L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, registered with the Trade and Companies'
Registry of Luxembourg under the number B 42230, has been appointed as statutory auditor (commissaire) of the Com-
pany;

4. the mandates of the directors and the statutory auditor will expire at the annual general meeting in the year 2017;

and

5. the address of the registered office of the Company is established in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks French and English, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the French and the English text, the French version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said Proxyholder has signed with Us the notary the present deed.

Signé: P-S. GUILLET, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2012. LAC/2012/57420. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Référence de publication: 2012162009/545.
(120213059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Xylem Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 172.763.

In the year two thousand and twelve, on the fourth day of December, at noon.
Before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared

7846

L

U X E M B O U R G

Xylem Delaware, Inc., an incorporation organized and existing under the laws of the state of Delaware (U.S.A), having

its registered office at 1105, North Market Street, Wilmington DE19801, U.S.A. tax ID number 06-1077415 (the Sole
Shareholder),

hereby represented by Ms Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing in Luxembourg, pursuant to a power-of-attorney

under private seal given in New York on December 4, 2012,

which power-of-attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing

party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be submitted with such deed to the
registration authorities,

for the extraordinary general meeting of shareholders (the Meeting) of Xylem Global S.à r.l., a private limited company

(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at 9, rue Gabriel
Lippmann,  L-5365  Munsbach,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies'  Register  under  the  number  B
172.763 (the Company), the Sole Shareholder acting in lieu of the Meeting.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that
I.  It is the sole  shareholder  of  the  Company  and holds  all 10,238,007.- (ten million  two  hundred and  thirty-eight

thousand and seven) ordinary shares having a par value of EUR 1.- (one euro) per share representing the entire subscribed
share capital of the Company amounting to EUR 10,238,007.- (ten million two hundred and thirty-eight thousand and
seven euro).

II. The Sole Shareholder recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

<i>Agenda

1. Capital increase of the Company by an amount of EUR 69,439.-(sixty-nine thousand four hundred and thirty-nine

euro) so as to raise it from its present amount of EUR 10,238,007.- (ten million two hundred and thirty eight thousand
and seven euro) to an amount of EUR 10,307,446 (ten million three hundred and seven thousand four hundred forty-six
euro) and issue of 69,439 (sixty-nine thousand four hundred and thirty-nine) ordinary shares having a par value of EUR
1.- (one euro) each (the Shares) having the same rights and privileges as the existing shares.

2. Subscription to and payment of the Shares specified under 1) above and payment of a share premium to be allocated

to the premium reserve of the Company by the contribution of all the shares in Xylem Hong Kong Limited by Portacel
Inc. and payment in full of the capital increase and each of the Shares (nominal value and share premium).

3. Amendment of article 4, first paragraph, of the Company's articles of incorporation so as to reflect the resolutions

to be adopted under items 1) and 2) of the Agenda.

III. The Sole Shareholder has passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 69,439.- (sixty-nine

thousand four hundred and thirty-nine euro) so as to bring it from its present amount of EUR 10,238,007.- (ten million
two hundred and thirty-eight thousand and seven euro) represented by 10,238,007.- (ten million two hundred and thirty-
eight thousand and seven) Shares having a par value of EUR 1.- (one euro) each to an amount of EUR 10,307,446 (ten
million three hundred and seven thousand four hundred forty-six euro) and to create and issue 69,439.- (sixty-nine
thousand four hundred and thirty-nine) new Shares, having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each and having the
same rights and privileges as the existing shares and to approve the new shareholder as new shareholder of the Company.

<i>Second resolution

<i>Subscription and Allotment

A. Portacel Inc., a company incorporated and existing under the laws of Pennsylvania, having its registered office at

309 Briar Rock Road, The Woodlands, Texas, 77380, federal ID # 25-1737074, r

represented by Ms Danielle Kolbach, prenamed,
by virtue of a power of attorney under private seal dated December 4, 2012,
declares to subscribe to the 69,439.- (sixty-nine thousand four hundred and thirty-nine) new Shares and to pay up

such new Shares and the share premium thereon by a contribution in kind of 1,000,000 (one million) shares with a par
value of USD 1 (one US Dollar) representing 100% of the issued shares of Xylem (Hong Kong) Limited, a private limited
company incorporated and existing under the laws of Hong Kong, having its registered address at Room 817, 8/F., Tower
B, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong, together with all rights and
duties, in particular the right to receive profits including those of the current business year and all profits not yet distributed
as of today, having an aggregate value of EUR 694,390.86 (six hundred ninety-four thousand three hundred and ninety
euro and eighty-six cents).

B. The contribution made to the Company is to be recorded at fair market value which amounts to EUR 694,390.86.-

(six hundred ninety-four thousand three hundred and ninety euro and eighty-six cents) as it results from the valuation
certificate as of December 4, 2012 (the Certificate) attached hereto) and to be allocated as follows:

7847

L

U X E M B O U R G

1) EUR 69,439.- (sixty-nine thousand four hundred and thirty-nine euro) to the nominal share capital of the Company;

and

2) the balance, i.e. EUR 624,951.86.- (six hundred twenty-four thousand nine hundred fifty-one euro and eighty-six

cents), is to be allocated to the premium reserve of the Company; it being noted that the contribution shall be accounted
for at fair market value and it being further noted that any value adaptation, for any accounting or tax reasons generally
whatsoever in Luxembourg or abroad, of the fair market value of the contribution shall be effectuated by way of increase
or decrease (as the case may be) of the issue premium in which case a corresponding premium adaptation of the premium
reserve shall be made.

The Certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

As a result of the above, the shareholding in the Company is as of now as follows:

Xylem Delaware Inc., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,238,007 shares
Portacel Inc., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69,439 shares

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 4 of the

articles of association of the Company, which shall have the following wording:

"The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 10,307,446 (ten million three hundred and seven thousand

four hundred forty-six euro), represented by 10,307,446 (ten million three hundred and seven thousand four hundred
forty-six) ordinary shares with a par value of one euro (EUR 1.-) per share."

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at EUR 2,200 (two thousand two hundred euro).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version; at the request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences
between the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzwölf, am vierten Dezember um Mittag,
vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg),

ist erschienen

Xylem Delaware, Inc., eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht des Staates Delaware (U.S.A.) mit

Gesellschaftssitz 1105, North Market Street, Wilmington DE19801, U.S.A. mit Steuernummer 06-1077415 (der Alleinige
Gesellschafter),

hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in New York, am 4. Dezember 2012,
welche Vollmacht, nach der Unterzeichnung ne varietur durch den Vollmachtsnehmer und den unterzeichnenden

Notar, dieser Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden,

zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die Versammlung) der Gesellschaft Xylem Global S.à r.l., eine Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 9,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, eingetragen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter der
Nummer B 172.763 (die Gesellschaft), wobei der Alleinige Gesellschafter anstelle der Versammlung handelt.

Der Alleinige Gesellschafter ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
I. Der Alleinige Gesellschafter hält alle 10.238.007.- (zehn Millionen zweihundertachtunddreißigtausend und sieben)

Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 1.- (einem Euro), welche ein Gesamtkapital von EUR 10.238.007.-
(zehn Millionen zweihundertachtunddreißigtausend und sieben Euro) darstellen.

II. Der Alleinige Gesellschafter erklärt, ausführlich über die auf der Grundlage der folgenden Tagesordnung zu fassenden

Beschlüsse informiert zu sein:

<i>Tagesordnung

1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals um EUR 69.439.-(neunundsechzigtausend vierhundertneununddreißig Euro),

um das bestehende Kapital in Höhe von EUR 10.238.007.- (zehn Millionen zweihundertachtunddreißigtausend und sieben
Euro)  auf  EUR  10.307.446.-(zehn  Millionen  dreihundertsiebentausend  vierhundertsechsundvierzig  Euro)  zu  erhöhen,

7848

L

U X E M B O U R G

durch Ausgabe von 69.439.- (neunundsechzigtausend vierhundertneununddreißig) neuen Gesellschaftsanteilen mit einem
Nennwert von jeweils EUR 1.- (einem Euro) (die Anteile) mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bestehenden
Gesellschaftsanteile.

2. Zeichnung und Zahlung der unter Tagesordnungspunkt 1) erwähnten Anteile, zusammen mit einem an die Agio-

rücklage der Gesellschaft zuzuweisenden Agio, durch Portacel Inc., und Zahlung der Agiorücklage durch eine Sacheinlage
von allen Anteilen der Xylem Hong Kong Limited.

3. Abänderung von Artikel 4, erster Absatz der Satzung, entsprechend den gemäß den Tagesordnungspunkten 1) bis

2) zu fassenden Beschlüssen.

III. Der Alleinige Gesellschafter fasst folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um EUR 69.439.- (neunundsechzigtausendvierhundert

neununddreißig Euro) von EUR 10.238.007.- (zehn Millionen zweihundertachtunddreißigtausend und sieben Euro), ein-
geteilt  in  10.238.007.-  (zehn  Millionen  zweihundertachtunddreißigtausend  und  sieben)  Gesellschaftsanteile  mit  einem
Nennwert von jeweils EUR 1.- (einem Euro), auf EUR 10.307.446 (zehn Millionen dreihundertsiebentausendvierhundert-
sechsundvierzig Euro) aufzu¬stocken, durch Schaffung und Ausgabe von 69.439.- (neunundsechzigtausend vierhundert-
neununddreißig) neuen Anteilen mit einem Nennwert von jeweils EUR 1.- (einem Euro) und mit den gleichen Rechten
und Privilegien wie die bestehenden Gesellschaftsanteile und der Alleinige Anteilsinhaber erklärt sich einverstanden mit
der Zeichnung durch den neuen Anteilsinhaber.

<i>Zweiter Beschluss

<i>Zeichnung und Zuteilung

A. Daraufhin ist die Portacel Inc., , eine Gesellschaft geründet unter den Gesetzen des Staates Pennsylvania, mit Ge-

schäftssitz in 309 Briar Rock Road, The Woodlands, Texas, 77380, Federal ID # 25-1737074,

vertreten durch Frau Danielle Kolbach, vorgenannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 4. Dezember 2012,
erklärt die 69.439.- (neunundsechzigtausend vierhundertneununddreißig) neuen Anteilen zu zeichnen und den Nenn-

wert der Anteile sowie das Agio einzuzahlen durch eine Sacheinlage bestehend aus einer Million (1.000.000) Anteilen mit
einem Nennwert von USD 1 (einem Dollar) welche 100% der ausgegebenen Anteile der Xylem (Hong Kong) Limited
darstellen, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter den Gesetzen Hong Kongs, mit Geschäftssitz
Room 817, 8/F., Tower B, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong,
gemeinsam mit den Gewinnrechten, welche zu diesem Tage noch nicht ausgeschüttet worden sind, mit einem Gesamtwert
von EUR 694.390,86.-(sechshundertvierundneunzigtausenddreihundertneunzig Euro und sechsundachtzig Cents).

B. Die Einlage in die Gesellschaft wird zu ihrem fairen Marktwert bewertet, welcher EUR 694.390,86.- (sechshundert-

vierundneunzigtausend-dreihundertneunzig Euro und sechsundachtzig Cents). beträgt, so wie es aus dem Bewertungs-
zertifikat vom 4. Dezember 2012 (das Zertifikat), welcher beigebogen, hervorgeht) und welcher wie folgt zugeteilt wird:

1) ein Betrag von EUR 69.439.- (neunundsechzigtausend vierhundertneununddreißig Euro) wird dem nominalen Ge-

sellschaftskapital zufließen;

2) der Restbetrag, d.h. EUR 624.951,86 (sechshundertvierundzwan-zigtausendneunhunderteinundfünfzig Euro), wird

der Agiorücklage der Gesellschaft zugewiesen; wobei zu beachten ist, dass die Einlage in den Büchern der Gesellschaft
zum fairen Marktwert auszuweisen ist; und wobei ferner zu beachten ist, dass jede Wertanpassung des Marktpreises der
Einlage aus Rechnungslegungs- oder Steuergründen in Luxemburg oder anderswo durch Erhöhung oder Herabsetzung
(je nachdem was zutrifft) des Ausgabeagios unter Vornahme der entsprechenden Agioangleichung der Agiorücklage er-
folgen muss.

Ein Kopie jeweils der obengenannten Zertifikats bleibt nach der ne varietur Unterzeichnung des Bevollmächtigten der

erschienenen Parteien und des unterzeichnenden Notars der gegenwärtigen Urkunde beigebogen um mit dieser einre-
gistriert zu werden.

Als Folge obiger Beschlüsse, bestätigt die Versammlung dass sich die Anteile an der Gesellschaft wie folgt verteilen:

Xylem Delaware Inc., vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.238.007 Anteile
Portacel Inc., vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.439 Anteile

<i>Dritter Beschluss

Infolge der obengenannten Beschlüsse beschließt der Alleinige Gesellschafter, den ersten Absatz von Artikel 4 der

Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

"Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 10.307.446 (zehn Millionen dreihundertsiebentausend vierhundert-

sechsundvierzig Euro) und ist eingeteilt in 10.307.446 (zehn Millionen dreihundertsiebentausend vierhundertsechsund-
vierzig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1.-(einem Euro)."

7849

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich auf

EUR 2.200 (zweitausendzweihundert Euro).

Der Unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der Vollmachtnehmerin der erschienenen Parteien in englischer Sprache, gefolgt von einer deut-
schen Übersetzung, verfasst worden ist, und dass auf Verlangen derselben Vollmachtnehmerin bei Abweichungen zwischen
dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Nach Verlesung der Urkunde hat die Vollmachtnehmerin der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, die

vorstehende Originalurkunde unterzeichnet.

Signé: D. Kolbach, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 6 décembre 2012, REM/2012/1568. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 12 décembre 2012.

Référence de publication: 2012162081/190.
(120213818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Greenfield South Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 30.000,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 162.037.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of November, before Maître Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Greenfield South Holdings S.à r.l., a

Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2, boulevard
Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 162.037 (the Company). The Company was incorporated on 3 May 2011 pursuant to a deed of Mr Francis
Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations - N° 2181 of 16 September 2011. The articles of association of the Company have never been
amended.

There appeared:

(1) TCW Energy Fund XIV L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the state of Delaware, United

States of America, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904 USA, registered
with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4817072, registered with the Dela-
ware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4242939;

(2) TCW Energy Fund XIV-A L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the state of Delaware, United

States of America, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904 USA, registered
with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4817072, registered with the Dela-
ware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4242928;

(3) TCW Energy Fund XIV-B L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the state of Delaware, United

States of America, having its registered office at 1700, Pennsylvania Avenue, Washington DC, 20006, USA, registered
with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4474534;

(4) TCW Energy Fund XIV (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Cayman Islands, having

its registered office at 4 

th

 Floor, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, Cayman Islands, regis-

tered with the Registrar of Limited Partnerships Cayman Islands under filing number CT-18508;

(5) Energy Fund XV, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the state of Delaware, United States

of America, having its registered office at 1700, Pennsylvania Avenue, Washington DC, 20006, USA, registered with the
Delaware Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4778596;

(6) Energy Fund XV-A, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the state of Delaware, United States

of America, having its registered office at 1700, Pennsylvania Avenue, Washington DC, 20006, USA, registered with the
Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4817072;

7850

L

U X E M B O U R G

(7) Energy Fund XV-B, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the state of Delaware, United States

of America, having its registered office at 1700, Pennsylvania Avenue, Washington DC, 20006, USA, registered with the
Secretary of State, Division of Corporations under filing number 4817070;

(8) Energy Fund XV (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Cayman Islands, having its

registered office at 4 

th

 Floor, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, Cayman Islands, registered

with the Registrar of Limited Partnerships Cayman Islands under filing number CT-41264;

(each a Shareholder, together the Shareholders).
All the Shareholders are here represented by Heike Kubica, banker, professionally residing in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies, given under private seal;

Said proxies, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the Shareholders and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The appearing parties have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the 30,000 (thirty thousand) shares having a nominal value of CAD 1 (one Canadian dollar) each, representing

the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at the Meeting;

II. that the agenda of the Meeting (the Agenda) is worded as follows:
1. Approval of the interim accounts of the Company (the Interim Accounts) for the period from 1 January 2012 to

the date of the Liquidation (as defined hereafter) (up to and excluding the Liquidation (as defined hereafter));

2. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire) (the

Liquidation);

3. Appointment of EIG Management Company, LLC as liquidator (liquidateur) in relation to the Liquidation (the Li-

quidator);

4. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the procedure of the liquidation of the Com-

pany; and

5. Discharge (quitus) of the managers of the Company for the performance of their respective mandates for the period

from 1 January 2012 to the date of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company resolving on
the Liquidation;

6. Miscellaneous.
III. The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Shareholders waive the

convening notices, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

The Meeting is consequently duly constituted and may deliberate upon the items of the Agenda.
After deliberation, the Meeting takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to approve the Interim Accounts which, after having been initialled ne varietur by the proxyholder

of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to dissolve with immediate effect the Company and to put the Company into voluntary liquidation

(liquidation volontaire).

<i>Third resolution

The Meeting resolves to appoint EIG Management Company, LLC, a limited liability company, formed under the laws

of the State of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
United States of America and registered with the Delaware Secretary of State under file number 4832196, as Liquidator
of the Company.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxem-

bourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Law).

The Meeting also resolves to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances,

to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in

the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the
Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons
or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

7851

L

U X E M B O U R G

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to

execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of
the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance pay-

ments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders, in accordance with article
148 of the Law.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to grant full discharge to the managers of the Company for the performance of their respective

mandates from 1 January 2012 to the date hereof.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above pro-

xyholder of the Shareholders, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the
same appearing parties, in the case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the Shareholders, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-neuf novembre, par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg,

Grand Duché du Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Greenfield South Holdings S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 162.037 (la Société).
La Société a été constituée le 3 mai 2011 en vertu d'un acte de Maître Francis Kesseler, notaire résidant à Esch-sur-
Alzette (Grand Duché de Luxembourg) publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2181 du 16
septembre 2011. Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés.

ONT COMPARU:

1. TCW Energy Fund XIV L.P., une société de droit de l'état du Delaware, ayant son siège social au 160, Greentree

Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904 aux Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Delaware Secretary of
State, Division of Corporations sous le numéro d'immatriculation 4242939;

2. TCW Energy Fund XIV-A L.P., une société de droit de l'état du Delaware, ayant son siège social au 160, Greentree

Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904 aux États-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Delaware Secretary of
State, Division of Corporations sous le numéro d'immatriculation 4242928;

3. TCW Energy Fund XIV-B L.P., une société de droit de l'état du Delaware, ayant son siège social au 1700, Pennsylvania

Avenue, Washington DC, 20006, aux États-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Delaware Secretary of State, Di-
vision of Corporations sous le numéro d'immatriculation 4474534;

4. TCW Energy Fund XIV (Cayman) L.P., une société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social au 4 

th

 Floor,

Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, Iles Cayman, immatriculée auprès du Registrar of Limited
Partnerships Cayman Islands sous le numéro d'immatriculation CT-18508;

5. Energy Fund XV, L.P., une société de droit de l'état du Delaware, ayant son siège social au 1700, Pennsylvania Avenue,

Washington DC, 20006, aux États-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Delaware Secretary of State, Division of
Corporations sous le numéro d'enregistrement 4778596;

6. Energy Fund XV-A, L.P., une société de droit de l'état du Delaware, ayant son siège social au 1700, Pennsylvania

Avenue, Washington DC, 20006, aux États-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Delaware Secretary of State, Di-
vision of Corporations sous le numéro d'enregistrement 4817072;

7. Energy Fund XV-B, L.P., une société de droit de l'état du Delaware, ayant son siège social au 1700, Pennsylvania

Avenue, Washington DC, 20006, aux États-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Delaware Secretary of State, Di-
vision of Corporations sous le numéro d'enregistrement 4817070;

8. Energy Fund XV (Cayman), L.P., une société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social au 4 

th

 Floor, Century

Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, Iles Cayman, immatriculée auprès du Registrar of Limited Part-
nerships Cayman Islands sous le numéro d'immatriculation CT-41264,

(chacune étant désignée individuellement comme un Associé, et ensemble comme les Associés).

7852

L

U X E M B O U R G

Les Associés sont représentés par Heike Kubica, banquière, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand Duché

du Luxembourg, en vertu de procurations accordées sous seing privé.

Lesdites procurations, après paraphe ne varietur par le mandataire des Associés et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants ont requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:
I. que les 30.000 (trente mille) parts sociales d'une valeur nominale de CAD 1 (un Dollar Canadien) chacune, repré-

sentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée (l'Ordre du jour) est libellé comme suit:
1. Approbation des comptes intérimaires de la Société (les Comptes Intérimaires) pour une période qui s'étend du 1

er

 janvier 2012 à la date de la Liquidation (telle que définie plus loin) (jusqu'à et à l'exclusion de la Liquidation (telle que

définie plus loin));

2. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire (la Liquidation);
3. Désignation de EIG Management Company, LLC en tant que liquidateur en vue de procéder à la Liquidation (le

Liquidateur);

4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société; et
5. Décharge (quitus) aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs pour la période allant du 1

janvier 2012 à la date de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société décidant de la Liquidation;

6. Divers.
III. L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, les Associés décident de

renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et ayant une parfaite connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

L'Assemblée est par conséquent dûment constituée et apte à délibérer des points de l'Ordre du jour.
Après délibération, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver les Comptes Intérimaires qui, après avoir été paraphés ne varietur par le mandataire

des parties comparantes et par le notaire instrumentaire, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec ce
dernier aux formalités de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation volontaire.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer en tant que Liquidateur de la Société EIG Management Company, LLC, une société

de droit de l'état du Delaware, avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, aux
Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du Delaware Secretary of State sous le numéro 4832196.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus décrits aux articles 144 et seq. de la loi

luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé
Unique. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs
personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-

dation,  afin  qu'il  exécute,  délivre,  et  effectue  toutes  obligations  relatifs  à  tout  contrat  ou  document  requis  pour  la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous

versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux Associés de la Société, conformément à
l'article 148 de la Loi.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée  décide  d'accorder  décharge  aux  gérants  de  la  Société  pour  l'exercice  de  leurs  mandats  respectifs  à

compter du 1 

er

 janvier 2012 et jusqu'à la date des présentes.

7853

L

U X E M B O U R G

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 1.500.-

Le notaire instrumentaire, qui comprend et qui parle l'anglais, déclare qu'à la demande du mandataire des Associés, le

présent acte soit rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de
divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des Associés, le mandataire des parties comparantes a signé avec nous, le notaire,

l'original du présent acte.

Signé: H. KUBICA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57798. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Référence de publication: 2012161685/210.
(120213937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

PEC Anton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 173.349.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of November.
Before the undersigned Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PEC Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, and
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 152.572 and

duly represented by Mr Diederik Wintershoven, lawyer, having his professional address at 35, avenue John F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on 27 November 2012, which will remain attached to the present deed.
The appearing party, represented as stated above, has requested the notary to document the deed of incorporation

of a société à responsabilité limitée, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as
follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owner(s) of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "PEC Anton S.à r.l." (hereinafter
the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's purpose is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxem-

bourg or abroad, as well as all operations relating to real estate properties, including but not limited to (i) financing the
acquisition of real estate properties by contracting loans, issuing bonds or implementing any other form of financing as
well as granting any related security (such as pledges or mortgages) as the Company may deem necessary or appropriate
in relation thereto or (ii) the direct or indirect holding of participations in companies in the Grand Duchy of Luxembourg
or abroad, including but not limited to listed companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties, either directly or indirectly through the holding of
participations in companies in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad having a corporate purpose similar to the
Company's  purpose  as  set  out  in  this  article  3  (hereinafter  "Real  Estate  Companies",  and  individually  a  "Real  Estate
Company").

3.2 An additional purpose of the Company is the creation, development and realisation of a portfolio, consisting of

interests, securities and rights of any kind and of any form of investment in Real Estate Companies, whether such entities
exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of interests,

7854

L

U X E M B O U R G

securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well
as the administration and control of such portfolio.

3.3 The Company may further:
(i) grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any Real Estate Company

in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other
manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or
agent of the Company or of any Real Estate Company in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind
or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the
Company;

(ii) lend funds or otherwise assist, including but not limited to the implementation and management of financial ins-

truments and/or contractual arrangements for the centralisation of liquidities of any Real Estate Company in which it
holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or
which forms part of the same group of entities as the Company;

(iii) raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

(iv) participate in the incorporation, development and/or control of any Real Estate Company; and
(v) act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Real Estate

Company.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.
5.1  The  Company's  share  capital  is  set  at  twenty  five  thousand  euro  (EUR  25,000.-),  represented  by  twenty  five

thousand (25,000) shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each. The shares are collectively referred to as the
"Shares" and individually a "Share".

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into Shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders, whereby the number of shareholders is limited to forty (40),

unless otherwise provided for by law.

6.3 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder or

any other shareholder, as the case may be, shall not cause the Company's dissolution.

6.4 The Company may, to the extent permitted by law, redeem its own shares at any time.
6.5 The Company's Shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of Shares held by such shareholder, any transfers of Shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such Share transfers pursuant to these articles of association as
well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter of his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of Shares.
8.1 Proof of ownership of Shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

7855

L

U X E M B O U R G

8.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered the sole owner of that Share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3 The Company's Shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided for by law,
the Shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of Shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or

in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant to which any
member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" or the "shareholders" used in these
articles of association shall be read as a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4 If the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders,

the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent
applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings of shareholders shall apply with
respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor or by the board of statutory auditors, if any, or by shareholders representing in the aggregate
more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such
date as specified in the notice of such meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the

municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution(s) in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum and vote
11.3.1 Each Share entitles to one (1) vote.
11.3.2 Unless otherwise provided for by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are

validly adopted when approved by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share
capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted

7856

L

U X E M B O U R G

for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless
of the portion of capital represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.7 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to

take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board
of managers" used in these articles of association shall be read as a reference to the "sole manager".

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone

or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

Art. 16. Election and removal of managers and term of office.
16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of office.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager to be revoked, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/
her/its own revocation.

16.3 Any manager may be re-elected for successive terms.

7857

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meetings of the board of managers. In his/her/its absence,

the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at

a meeting of the board of managers.

18.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting

of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of

the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the sole

signature of any member of the board of managers or by the signature of the sole manager or by the joint signatures or
by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or
by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the
power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly in accordance with and
subject to the limits of such delegation.

7858

L

U X E M B O U R G

E. Supervision

Art. 21 Statutory auditor(s) - Approved auditor(s).
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general
meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law of19 December 2002 regarding the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several approved auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed
by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on January first of each year and shall terminate on

December thirty-first of the same year.

Art. 23. Profits.
23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided for by law, the general meeting of shareholders will determine how

the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law, these articles of association
and any shareholders' agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the Company.

Art. 24. Interim dividends.
24.1 The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends

in accordance with any shareholders' agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the
Company, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available
and (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which
the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for
this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law
or of these articles of association.

24.2 The share premium may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of

the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve and
in accordance with any shareholders' agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the
Company.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration, in accordance with any share-
holders' agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the Company.

7859

L

U X E M B O U R G

H. Governing law

Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitional provision

The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31 De-

cember, 2013.

<i>Subscription and payment

The Shares to be issued have been subscribed and paid-in in cash by PEC Holdings S.a r.l., aforementioned, which has

paid-in twenty five thousand euro (EUR 25,000.-) and subscribed the twenty five thousand (25,000) Shares.

All the Shares have been entirely paid-in in cash, so that the twenty five thousand Euro (EUR 25,000.-) is as of now

available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand three hundred euro (EUR
1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

PEC Holdings S.à r.l., aforementioned, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened,

has immediately passed the following resolutions:

1. The number of members of the board of managers is fixed at five (5).
2. The following persons are appointed managers of the Company with immediate effect and for an unlimited period

of time:

a. Mr Claude Niedner, born on 15 October 1966 in Karlsruhe, Germany, professional address 14, rue Erasme, L-2082

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

b. Mr Richard Everett, born on 20 July 1965 in Clevedon, United Kingdom, professional address One New Change,

London EC4M 9AF, United Kingdom;

c. Mr Alistair Mc Donnell, born on 27 January 1978 in Antrim, Ireland, professional address One New Change, London

EC4M 9AF, United Kingdom;

d. Mr Sansal Özdemir, born on 31 March 1973 in Cankaya, Turkey, professional address 26-28, rue Edward Steichen,

2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

e. Mr Daniel Laurencin, born on 8 October 1969 in Bastogne, Belgium, professional address 26-28, rue Edward Steichen,

2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The following entity is appointed as approved auditor of the Company with immediate effect and for an unlimited

period of time, but may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders:

PriceWaterhouseCoopers, a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, registered with the

Luxembourg trade and companies register under number B 65 477, having its registered address at 400, route d'Esch,

L-1014 Luxembourg.

4. The address of the Company's registered office is set at 26-28, rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the proxyholder of

the appearing party, this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same pro-
xyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the appearing party signed together with

the notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Texts:

Im Jahre zweitausend und zwölf, am dreißigsten Tag im November.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Loesch, Notar mit Amtssitz im Mondorf, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

7860

L

U X E M B O U R G

PEC Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilitié limitée) nach luxemburgi-

schem Recht, mit Sitz in 2628, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, eingetragen im luxemburgischem Handelsre-
gister unter der Nummer B 152.572,

und vertreten durch Diederik Wintershoven, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

vertreten durch Herrn Diederik Wintershoven, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 35, avenue John F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 27. November 2012, welche zwecks Einregistrierung ge-

genwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die erschienene Partei, vertreten wir vorgenannt, hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzunehmen, welche gegründet werden soll und deren Satzung
wie folgt lautet:

A. Name - Dauer - Zweck - Sitz

Art. 1. Name. Nunmehr besteht zwischen dem(n) jetzigen Eigentümer(n) der Geschäftsanteile und/oder jedem zu-

künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter dem Namen
"PEC Anton S.à r.l." (die "Gesellschaft").

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch

einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter aufgelöst werden, welcher in gleicher Weise gefasst wird, wie
für eine Änderung dieser Satzung erforderlich.

Art. 3. Zweck.
3.1 Der Gesellschaftzweck ist der Erwerb und Verkauf von Immobilien sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch

im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Immobilien, einschließlich aber nicht beschränkt auf (i) Finan-
zierung des Erwerbs von Immobilien durch Vergabe von Darlehen, emittieren von Anleihen oder Durchführung jeder
anderen Art der Finanzierung sowie die Bewilligung jeder damit verbundenen Sicherheit (z.B. Pfandrechte oder Hypo-
theken) wie die Gesellschaft in solch einem Zusammenhang für notwendig oder angemessen hält, oder (ii) das direkte
oder indirekte Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf börsennotierte Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Immobilien zu erwerben, zu entwi-
ckeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten, welche direkt oder indirekt durch das Halten von
Beteiligungen an Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit einem Gesellschaftszweck ähnlich
dem Gesellschaftszweck der Gesellschaft, wie in diesem Artikel 3 (im Folgenden "Immobiliengesellschaften" und einzeln
als "Immobiliengesellschaft").

3.2 Ein weiterer Gesellschaftzweck der Gesellschaft ist die Schaffung, Entwicklung und Realisation eines Portfolios,

bestehend aus Beteiligungen, Wertpapieren und Rechten jeglicher Art und jeder Form von

Investitionen in Immobiliengesellschaften, obschon solche Rechtsträger bestehen oder erst geschaffen werden, insbe-

sondere durch Zeichnung, Erwerb durch Kauf, Verkauf oder Tausch von Beteiligungen, Wertpapieren oder Rechten
jeglicher Art, ebenso wie alle Eigenkapitalinstrumente, Schuldtitel (Schuldverschreibungen), Patente und Lizenzen sowie
die Verwaltung und Aufsicht eines solchen Portfolios.

3.3 Die Gesellschaft kann darüber hinaus:
(i) jede Art von Sicherheiten für die Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft oder einer Immobiliengesellschaft,

an der die Gesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in die die Gesellschaft
auf irgendeine andere Weise investiert oder welche Teil der gleichen Gruppe der Gesellschaft ist, gewähren oder ein
Geschäftsführer oder ein anderer Bevollmächtigter oder Beauftragter des Unternehmens oder jeder beliebigen Immo-
biliengesellschaft, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in denen die
Gesellschaft in anderer Weise investiert ist oder die Teil der gleichen Gruppe angehört wie die Gesellschaft bildet;

(ii) Gelder verleihen oder auf andere Weise, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Durchführung und Verwaltung

von Finanzinstrumenten und / oder vertragliche Vereinbarungen für die Zusammenlegung von Barvermögen einer Im-
mobiliengesellschaft, an der die Gesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder
in denen die Gesellschaft auf irgendeine andere Weise investiert ist oder die Teil der gleichen Gruppe der Gesellschaft
ist, unterstützen;

(iii) Finanzielle Mittel mittels Kreditaufnahme jeglicher Art oder durch die Emission von Wertpapieren oder Schuldti-

teln, einschließlich Anleihen, durch die Annahme einer anderen Form von Investition oder durch die Gewährung von
Rechten jeglicher Art;

(iv) Teilnahme an der Gründung, Entwicklung und/oder Aufsicht einer Immobiliengesellschaft, und
(v) als Partner/Gesellschaftsinhaber mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für die Schulden und Verpflich-

tungen jeglicher Immobiliengesellschaft.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

7861

L

U X E M B O U R G

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss der Geschäftsführer verlegt wer-

den.

4.3 Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter in jede andere Gemeinde des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird, wie für eine Änderung dieser Satzung erforderlich.

4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch

Beschluss der Geschäftsführer errichtet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25,000.-) bestehend aus fünf-

undzwanzigtausend (25,000) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1.-) pro Gesellschaftsanteil.
Die Geschäftsanteile werden insgesamt mit „Geschäftsanteilen" und einzeln als „Gesellschaftsanteil" bezeichnet.

5.2 Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann, gemäß der gesetzlichen Regelungen, durch einen Be-

schluss der Hauptversammlung der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden, welcher in der Weise gefasst wird,
wie für eine Änderung dieser Satzung erforderlich.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) Gesellschafter

nicht überschreiten darf, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt

6.3 Die Gesellschaft wird weder durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Auflösung, Konkurs, Insolvenz oder ein anderes

ähnliches einen oder mehrere Gesellschafter betreffendes Ereignis aufgelöst.

6.4 Die Gesellschaft kann, soweit gesetzlich zulässig, ihre eigenen Geschäftsanteile zu jeder Zeit zurückkaufen.
6.5 Die Anteile der Gesellschaft sind in Namensanteile.

Art. 7. Anteilsregister der Gesellschafter.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister der Gesellschafter aufbewahrt, wo es durch jeden Gesellschafter

eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister der Gesellschafter enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, den Wohnsitz oder Sitz oder Hauptsitz der Gesellschaft, die Anzahl der Geschäftsanteile welche durch den jeweiligen
Gesellschafter gehalten werden, alle Übertragungen von Geschäftsanteilen, den Zeitpunkt der Bekanntgabe oder Annah-
me dieser Übertragungen von Geschäftsanteilen durch die Gesellschaft gemäß dieser Satzung sowie jegliche Sicherheiten
welche auf Geschäftsanteile gewährt wurden.

7.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft per Einschreiben seine/ihre Adresse und jede Änderung derselben mit-

teilen. Die Gesellschaft kann sich auf die letzte angegebene Adresse des Gesellschafters verlassen.

Art. 8. Eigentum und Übertragung von Anteilen.
8.1 Der Nachweis des Eigentums an Anteilen kann durch die Aufnahme eines Gesellschafters in das Anteilsregister

der Gesellschafter geschaffen werden. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters können Zertifikate
über die genannte Eintragung in dem Anteilsregister der Gesellschafter herausgeben und von dem leitenden Geschäfts-
führer,  von  zwei  Geschäftsführern  oder  dem  Einzelgeschäftsführer,  den  Umständen  entsprechend,  unterschrieben
werden.

8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sobald ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft als alleinigen Inhaber vertritt.
Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem von mehreren Personen gehalt-
enen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

8.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Anteile dürfen inter vivos neuen Gesellschaftern

nur mit Zustimmung der Gesellschafter, einschließlich des Übertragenden, die mit einer Mehrheit von mindestens fünf-
undsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals zu beschließen hat, übertragen werden. Sei denn es wird gesetzlich
anderweitig bestimmt, dürfen die Anteile nicht von Todes wegen an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, außer mit
der Genehmigung der Gesellschafter, welche eine Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesell-
schaftskapitals (der Stimmrechte) der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4 Jede Übertragung von Anteilen muss durch einen Übertragungsvertrag dokumentiert werden durch schriftliche

Beurkundung oder bedarf notarieller Form, je nach Sachlage, und eine solche Übertragung wird gegenüber der Gesellschaft
und Dritten wirksam durch Mitteilung der Übertragung an oder mit der Genehmigung der Übertragung durch die Ge-
sellschaft,  gemäß  der  jedes  Mitglied  der  Geschäftsführung  die  Übertragung  in  das  Anteilsregister  der  Gesellschafter
aufzeichnen kann.

8.5 Die Gesellschaft kann, durch jeden ihrer Geschäftsführer, auch jede Übertragung, welche aus Schriftverkehr oder

einem anderen Dokument die Zustimmung des Veräußerers und des Erwerbers ersichtlich werden lässt, akzeptieren und
in das Anteilsregister der Gesellschafter eintragen.

7862

L

U X E M B O U R G

C. Hauptversammlung der Gesellschafter

Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter.
9.1 Die Gesellschafter üben ihre gemeinschaftlichen Rechte in der Hauptversammlung der Gesellschafter aus, welche

ein Organ der Gesellschaft darstellt.

9.2 Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesell-

schafter aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Gesellschafter" nicht ausdrücklich in
dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf die "Hauptversammlung der Gesellschafter"
als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.

9.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die ihr durch Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verlie-

henen Befugnisse.

9.4 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, anstatt eine Hauptver-

sammlung der Gesellschafter abzuhalten, können die Gesellschafter auch per schriftlichen Beschluss abstimmen, vorbe-
haltlich  der  Bestimmungen  des  Gesetzes.  Soweit  anwendbar,  gelten  die  Bestimmungen  dieser  Satzung  über
Hauptversammlungen der Gesellschafter hinsichtlich eines solchen Beschlusses in schriftlicher Form.

Art. 10. Ladung der Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1 Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann jederzeit durch die Geschäftsführer oder den/die satzungsmäßi-

gen Buchprüfer oder die satzungsmäßige Buchprüferversammlung, falls vorhanden, oder durch die Gesellschafter die
zusammen insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals halten, soweit zutreffend, einberufen
werden. Die Ladung zu der Hauptversammlung der Gesellschafter muss den Ort und das Datum enthalten.

10.2 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Hauptver-

sammlung in Luxembourg am eingetragenem Sitz der Gesellschaft, oder an jedem anderen in der Ladung bezeichneten
Ort stattfinden. Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter muss innerhalb von sechs (6) Monaten, nach dem
die Konten der Gesellschaft geschlossen wurden, einberufen werden.

10.3 Die Ladung zu jeder Hauptversammlung der Gesellschafter muss die Tagesordnung der Versammlung, den Ort

und das Datum und die Uhrzeit der Versammlung enthalten und diese Ladung muss per Einschreiben mindestens acht (8)
Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum an jeden Gesellschafter versendet werden.

10.4 Wenn in einer Hauptversammlung der Gesellschafter alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und er-

klären,  dass  sie  über  die  Tagesordnung  der  Versammlung  informiert  worden  sind,  kann  die  Hauptversammlung  der
Gesellschafter ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Durchführung von Hauptversammlungen der Gesellschafter - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1In jeder Hauptversammlung der Gesellschafter soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem

Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Stimmzähler, die durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt
werden und welche weder Gesellschafter noch

Mitglieder  der  Geschäftsführung  sein  müssen.  Der  Rat  der  Versammlung  soll  insbesondere  sicherstellen,  dass  die

Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln betreffend die Ladung, Mehrheits-
erfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2In jeder Hauptversammlung der Gesellschafter muss eine Anwesenheitsliste geführt werden. 11.3Quorum und

Abstimmung

11.3.1 Jeder Anteil berechtigt zu einer (1) Stimme.
11.3.2 Sofern nicht anders durch das Gesetz oder diese Satzung bestimmt ist, werden die Beschlüsse der Gesellschafter

rechtmäßig erlassen, wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals der
Gesellschaft halten nach erster Abstimmung genehmigt. Wenn diese Mehrheit nicht mit der ersten Abstimmung erreicht
wird, werden die Gesellschafter für eine zweite Abstimmung vertagt oder befragt. Bei der zweiten Abstimmung werden
die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig von dem vertretenen Anteil
am Gesellschaftskapital.

11.4 Ein Gesellschafter kann an jeder Hauptversammlung der Gesellschafter teilnehmen, indem sie/er eine andere

Person, Gesellschafter oder Nicht-Gesellschafter, als ihren/seinen Vertreter schriftlich durch ein unterzeichnetes Doku-
ment, das per Post, Telefax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, bevollmächtigt.
Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5 Gesellschafter, die an einer Hauptversammlung der Gesellschafter per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder

durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und effektiv an der Versammlung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Bestimmung des Quorums und der
Mehrheit.

11.6 Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Gesellschafter durch ein unterzeichnetes

Stimmformular, welches per Post, E-Mail, Faxschreiben, oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der
Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur solche
Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum
und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden Vor-

7863

L

U X E M B O U R G

schlag  drei  Kästchen  enthalten,  die  es  dem  Gesellschafter  ermöglichen,  seine  Stimme  zugunsten  oder  gegen  den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben, indem das entsprechenden Kästchen ankreuzt wird. Die Gesellschaft wird nur
solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Hauptversammlung der Gesellschafter, auf die sie sich beziehen,
erhalten hat.

11.7 Die Geschäftsführung kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden müs-

sen, um an einer Hauptversammlung der Gesellschafter teilnehmen zu können.

Art. 12. Änderung der Satzung. Vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen und Bestimmungen, kann diese Satzung mit

einem Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter geändert werden, soweit (i) eine Mehrheit der Gesellschafter
vorhanden ist (ii) welche mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten.

Art. 13. Protokoll von Hauptversammlungen der Gesellschafter.
13.1 Die Hauptversammlung der Gesellschafter muss ein Protokoll der Versammlung anfertigen, welches von den

Mitgliedern des Rates der Versammlung, sowie von jedem Gesellschafter, der dies ersucht, unterzeichnet wird.

13.2 Der alleinige Gesellschafter, soweit zutreffend, wird auch ein Protokoll seiner Beschlüsse anfertigen und diese

unterzeichnen.

13.3 Kopien oder Abschriften solcher Originalprotokolle, welche in gerichtlichen Verfahren verwendet werden sollen

oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder durch
den leitenden Geschäftsführer oder durch zwei beliebige Geschäftsführer oder den Einzelgeschäftsführer unterzeichnet
werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerversammlung.
14.1 Die Gesellschaft soll durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten werden, welche nicht Gesellschafter

der Gesellschaft sein müssen. Sollten mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden diese Geschäftsführer eine Ge-
schäftsführerversammlung, welche die juristische Einheit bildet, die für die Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-
schaft zuständig ist. Die Gesellschaft kann mehrere Arten von Geschäftsführern haben. In einem solchen Fall, soweit
anwendbar und wo der Begriff "Einzelgeschäftsführer" nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in dieser
Satzung genannter Verweis auf die "Geschäftsführerversammlung" als Verweis auf den „Einzelgeschäftsführer" gelesen
werden.

14.2 Die Geschäftsführerversammlung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu

handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit
Ausnahme der von Gesetzes wegen oder durch diese Satzung den Gesellschaftern vorbehaltenen Handlungen.

14.3 Die tägliche Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser täglichen Geschäfts-

führung/Verwaltung kann auf einen oder mehrere Geschäftsführer oder an eine andere Person, Gesellschafter oder Nicht-
Gesellschafter,  allein  oder  gemeinsam  als  Vertreter  der  Gesellschaft  handelnd,  delegiert  werden.  Ihre  Ernennung,
Abberufung und Befugnisse werden durch Beschluss der Geschäftsführerversammlung festgelegt.

14.4 Die Gesellschaft kann auch besondere Rechte durch notarielle Bevollmächtigung oder privatschriftliche Urkunde

allen Personen, allein oder gemeinsam als Vertreter der Gesellschaft handelnd, gewähren.

Art. 15. Zusammensetzung der Geschäftsführerversammlung.  Die  Geschäftsführerversammlung  wählt  unter  ihren

Mitgliedern einen leitenden Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung aus. Die Geschäftsführerversammlung kann
auch einen Schriftführer ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied der Geschäftsführerversammlung sein muss.

Art. 16. Wahl und Abberufung von Geschäftsführern und Amtszeit.
16.1 Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gewählt, welche ihre Bezüge und Amts-

zeit festlegt.

16.2  Jeder  Geschäftsführer  kann  jederzeit,  ohne  Einhaltung  einer  Frist  und  ohne  Angabe  von  Gründen  durch  die

Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden. Ein Geschäftsführer der abberufen werden soll, der gleichzeitig
Gesellschafter der Gesellschaft ist, darf nicht von der Abstimmung über die eigene Abberufung ausgeschlossen werden.

16.3 Jeder Geschäftsführer kann in aufeinander folgenden Zeiträumen wiedergewählt werden.

Art. 17. Einberufung der Geschäftsführerversammlung.
17.1 Die Geschäftsführerversammlung versammelt sich auf Einberufung durch ihren leitenden Geschäftsführer oder

durch zwei Geschäftsführer an dem in der Ladung zu der Versammlung angegebenen Ort, wie in dem folgenden Absatz
beschrieben wird.

17.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerversammlung per Post, Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren
Kommunikationsmittels schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Ladung
zu bezeichnen sind. Eine solche Ladung ist nicht notwendig, falls alle Geschäftsführer per Post, Faxschreiben, E-Mail oder

7864

L

U X E M B O U R G

mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels, ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie des unter-
zeichneten schriftlichen Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist.

Eine solche Bekanntmachung/Einberufung/Ladung ist nicht notwendig, falls alle Geschäftsführer, ihre Zustimmung ab-

gegeben haben, wobei eine Kopie des unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist.
Auch ist eine Bekanntmachung/Einberufung/Ladung zu einer Geschäftsführerversammlung dann nicht erforderlich, wenn
Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss der Geschäftsführerversammlung bestimmt worden sind. Des Weiteren
ist eine Bekanntmachung/Einberufung/Ladung nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer bei der Geschäftsführerver-
sammlung anwesend oder vertreten sind oder im Falle von schriftlichen Beschlüssen gemäß dieser Satzung.

Art. 18. Durchführung von Geschäftsführerversammlung.
18.1 Der leitende Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung führt den Vorsitz aller Geschäftsführerversamm-

lungen. In dessen Abwesenheit kann die Geschäftsführerversammlung jedoch einen anderen Geschäftsführer als leitenden
Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung pro tempore ernennen.

18.2 Quorum
Die Geschäftsführerversammlung kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte ihrer

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

18.3 Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an einer Geschäftsführerversammlung teilnehm-

enden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der leitende Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung hat im
Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme.

18.4 Ein Geschäftsführer kann an einer Geschäftsführerversammlung teilnehmen, indem er einen anderen Geschäfts-

führer durch ein unterzeichnetes Dokument, welches per Faxschreiben, E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kom-
munikationsmittel  übermittelt  wird,  schriftlich  bevollmächtigt,  wobei  eine  Kopie  der  Bevollmächtigung  hinreichender
Beweis dafür ist. Jeder Geschäftsführer kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5 Jeder Geschäftsführer, der an einer Geschäftsführerversammlung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder

durch ein anderes Kommunikationsmittel, welches das Identifizieren eines solchen Geschäftsführers ermöglicht, teilnimmt
und es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und effektiv an der Versammlung teilzunehmen, gilt
als anwesend für die Bestimmung des Quorums und der Mehrheit. Eine solche Geschäftsführerversammlung, die mittels
solcher Kommunikationsmittel durchgeführt wurde, wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.

18.6  Der  Geschäftsführerversammlung  kann  einstimmig  schriftliche  Beschlüsse  fassen,  die  wirkungsgleich  mit  Be-

schlüssen sind, welche an ordnungsgemäß abgehaltenen Geschäftsführerversammlungen verabschiedet wurden. Solche
schriftlichen Beschlüsse werden verabschiedet, wenn sie von allen Geschäftsführern auf einem einzigen Dokument oder
auf mehreren Duplikaten datiert und unterzeichnet wurden, eine Kopie der Unterschrift per Post, Fax, E-Mail oder mittels
anderer Kommunikation ist hinreichender Beweis dafür. Das einzige Dokument, das alle Unterschriften oder die Ge-
samtheit aller Duplikate, den Umständen entsprechend, bildet den Beschluss, der als Nachweis der Verabschiedung des
Beschlusses gilt und das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der letzten Unterschrift.

18.7 Jedes Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die der Geschäftsführerversammlung zur Entscheidung vorliegt,

direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches dem Interesse der Gesellschaft entgegen steht, die
Geschäftsführerversammlung  über  diesen  Interessenkonflikt  informieren,  und  seine  Erklärung  muss  im  Protokoll  der
betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in
Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen Einzelgeschäftsführer hat
und dieser Einzelgeschäftsführer direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse an einer Transaktion hat, die
zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft eingegangen wurde, welche dem Interesse der Gesellschaft
entgegensteht, muss solch ein entgegenstehendes Interesse im Protokoll der betreffenden Transaktion aufgenommen
werden.

Art. 19. Protokoll der Geschäftsführerversammlung.
19.1 Der Schriftführer oder falls kein Schriftführer ernannt wurde, fertigt der leitende Geschäftsführer ein Protokoll

jeder Geschäftsführerversammlung an, welches vom Schriftführer oder dem leitenden Geschäftsführer unterzeichnet
werden soll.

19.2 Der Einzelgeschäftsführer soll ebenfalls Protokolle seiner Beschlüsse anfertigen und diese unterzeichnen.
19.3 Jede Kopie oder Ausfertigung eines jeden Originalprotokolls das im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens an-

gefertigt wird oder für die Weitergabe an Dritte bestimmt ist, soll vom leitenden Geschäftsführer, von zwei Geschäfts-
führern oder vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden, sofern zutreffend.

Art. 20. Beziehungen zu Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift

eines jeden Geschäftsführers, des Einzelgeschäftsführers oder die gemeinsamen Unterschriften oder alleinige Unterschrift
jeder Person/Personen verpflichtet, die von den Geschäftsführern oder dem Einzelgeschäftsführer dazu bevollmächtigt
worden  ist.  Die  Gesellschaft  wird  gegenüber  Dritten  verpflichtet  mit  der  Unterschrift  eines  jeden  Bevollmächtigten/
mehrerer Bevollmächtigter dem/denen die tägliche Geschäftsführung übertragen worden ist, alleine oder gemeinschaftlich
handelnd; dies im Einklang mit und im Rahmen der Beschränkungen einer solchen Übertragung.

7865

L

U X E M B O U R G

E. Supervision

Art. 21. Satzungsmäßige Buchprüfer - Unabhängige Wirtschaftsprüfer.
21.1. Im Falle dass die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, soll sie von einem oder mehreren

satzungsmäßigen Buchprüfern beaufsichtigt werden, die Gesellschafter sein dürfen, aber keine Gesellschafter sein müssen.

21.2 Die Hauptversammlung der Gesellschafter soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer festlegen, sie ernennen,

ihre Bezahlung und die Dauer ihres Mandats festlegen.

21.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen von

der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

21.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben unbeschränkte Rechte in Bezug auf die permanente Aufsicht und Kontrolle

aller Tätigkeiten der Gesellschaft.

21.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer dürfen sich bezüglich der Überprüfung der Konten und Bücher der Gesellschaft

eines Experten bedienen. Ein solcher Experte muss von der Gesellschaft anerkannt werden.

21.6 Im Falle mehrerer satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese die satzungsmäßige Buchprüferversammlung, die unter

ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen muss. Die satzungsmäßige Buchprüferversammlung kann auch einen
Schriftführer bestimmen, der weder ein Gesellschafter, noch ein satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die
Einberufung und Abhaltung der Sitzungen der satzungsmäßigen Buchprüferversammlung, werden die Regeln angewendet,
die gemäß dieser Satzung auch auf die Einberufung und Abhaltung der Geschäftsführerversammlung Anwendung finden.

21.7 Für den Fall dass die Gesellschaft zwei der drei im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen für die Zeitspanne,
die in Artikel 36 desselben Gesetzes genannt ist, überschreitet, werden die satzungsmäßigen Buchprüfer durch einen oder
mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer ersetzt, ausgewählt aus den Mitgliedern des Instituts der unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer („Institut des réviseurs d'entreprises"), die von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden,
die die Dauer ihres Mandats festlegt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Gewinne.
23.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme
der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können mit Zustimmung dieses Gesell-

schafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

23.3 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann im Verhältnis dazu die gesetzliche Rücklage der Ge-

sellschaft herabgesetzt werden, so dass sie stets zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

23.4 Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften wird die Hauptversammlung der Gesellschafter darüber bestimmen,

wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinnes der Gesellschaft verwendet werden soll; dies im Einklang mit
dem Gesetz, dieser Satzung und sämtlicher Gesellschaftervereinbarungen, die von Zeit zu Zeit zwischen den Gesell-
schaftern der Gesellschaft eingegangen werden können

Art. 24. Zwischendividenden - Ausgabeagio.
24.1 Die Geschäftsführer oder die Hauptversammlung der Gesellschafter können im Einklang mit sämtlichen Gesell-

schaftervereinbarungen, die von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft eingegangen werden können,
Zwischendividenden zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenabschlüsse erstellt wurden, welche belegen, dass
ausreichende Mittel für eine Zwischendividende zur Verfügung stehen und (ii) der ausgegebene Betrag die seit Ende des
vergangenen Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss genehmigt wurde, angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht
durch vorgetragene Gewinne und Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Beiträge,
welche nach den Regelungen dieser Satzung und des Gesetzes einer Rücklage zugeführt werden müssen, nicht übersteigt

24.2 Das Ausgabeagio kann frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden durch einen Gesellschafterbeschluss oder

Geschäftsführerbeschluss, gemäß den gesetzlichen Regelungen betreffend die Unveräußerlichkeit des Gesellschaftskapi-
tales und die gesetzlichen Rücklagen der Gesellschaft und im Einklang mit sämtlichen Gesellschaftervereinbarungen, die
von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft eingegangen werden können.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

toren, natürliche Personen oder juristische Personen ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter
ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren be-
stimmt; dies im Einklang mit sämtlichen Gesellschaftervereinbarungen, die von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern
der Gesellschaft eingegangen werden können.

7866

L

U X E M B O U R G

H. Anwendbares Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Diese Satzung soll ausgelegt und interpretiert, sowie von den Regelungen des luxem-

burgischen Rechtes bestimmt werden. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen
des Gesetzes von 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils aktuellen Fassung.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember,

2013.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die auszugebenden Anteile wurden gezeichnet und bar eingezahlt von der PEC Holdings S.ä.r.l., die vorgenannt wurde,

die fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25,000.-) eingezahlt und die die fünfundzwanzigtausend (25,000) Anteile gezeichnet
hat.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von fünfundzwanzigtausend

Euro (EUR 25,000.-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-) geschätzt.

<i>Hauptversammlung der Gesellschafter

Die PEC Holdings S.ä r.l., die vorgenannt wurde, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und die sich als ord-

nungsgemäß geladen erachtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anzahl der Geschäftsführer wird mit fünf (5) festgelegt.
2. Die folgenden natürlichen Personen werden mit sofortiger Wirkung und für unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern

der Gesellschaft ernannt:

a. Herr Claude Niedner, geboren am 15. Oktober 1966 in Karlsruhe, Deutschland, Geschäftsadresse 14, rue Erasme,

L-2082 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

b. Herr Richard Everett, geboren am 20. Juli 1965 in Clevedon, Vereinigtes Königreich, Geschäftsadresse One New

Change, London EC4M 9AF, Vereinigtes Königreich;

c. Herr Alistair Mc Donnell, geboren am 27. Januar 1978 in Antrim, Irland, Geschäftsadresse One New Change, London

EC4M 9AF, Vereinigtes Königreich;

d. Herr Sansal Özdemir, geboren am 31. März 1973 in Cankaya, Türkei, Geschäftsadresse 26-28, rue Edward Steichen,

2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

e. Herr Daniel Laurencin, geboren am 8. Oktober 1969 in Bastogen, Belgien, Geschäftsadresse 26-28, rue Edward

Steichen, 2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Die folgende juristische Person wird zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung

und für eine unbestimmte Zeit ernannt, die aber jederzeit ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen
von der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden kann:

PricewaterhouseCoopers, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet unter den Gesetzen des Großher-

zogtums Luxemburg, registriert im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-65 477,
mit Gesellschaftssitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg.

4. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 26-28, rue Edward Steichen, 2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Ersuchen

des Vollmachtnehmers der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen desselben Vollmachtnehmers und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen
Text soll die englische Fassung vorrangig sein.

Worüber Urkunde, diese notarielle Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem Tag, der zu

Beginn dieser Urkunde genannt wurde, aufgesetzt.

Nachdem das Dokument dem Vollmachtnehmer der erschienenen Partei verlesen wurde, unterzeichnete dieser Voll-

machtnehmer diese Originalurkunde zusammen mit dem Notar.

Signé: D. Wintershoven, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 6 décembre 2012, REM/2012/1554. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

7867

L

U X E M B O U R G

Mondorf-les-Bains, le 10 décembre 2012.

Référence de publication: 2012161928/757.
(120213604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Brussco Sàrl, Société à responsabilité limitée,

(anc. AP.Diner S.à r.l.).

Siège social: L-7232 Bereldange, 1, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 154.074.

L'an deux mille douze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

A comparu:

Monsieur Christophe BRUSSELMANS, gérant de société, né le 25 novembre 1977 à Arlon (Belgique) (matr: 1977 11

25 134) et demeurant à L-7232 Bereldange, 1, rue des Jardins,

ici représenté par Monsieur Daniel REDING, expert-comptable, demeurant professionnellement à Ettelbruck,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 22 novembre 2012, laquelle procuration, après avoir été signée

“ne varietur” par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec
lui,

en qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée "AP.DINER S.A R.L." avec siège social à L-7232 Be-

reldange, 1, rue des Jardins,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg, en date du 24 juin 2010, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1634 du 12 août 2010,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 154.074;
Le comparant prénommé, représentant l'intégralité du capital social de la susdite société, s'est réunie en assemblée

générale extraordinaire et a pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'associé décide de modifier la raison sociale de la société et en conséquence de modifier l'article 1 des statuts qui

aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de “BRUSSCO Sàrl”

<i>Deuxième résolution:

L'associé décide à d'étendre l'objet social de la société et en conséquence de modifier l'article 3 des statuts en sa

première phrase qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger:
L'exploitation d'une petite restauration avec snack, consommation sur place ou à emporter et avec vente de boissons

alcooliques et non-alcooliques;

L'exploitation d'une agence immobilière (achat, vente, location, toutes transactions immobilières), gérance d'immeu-

bles (syndic), administration de biens, promotions immobilières ainsi qu'une agence d'affaires.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, industrielle, commerciale et financière se rattachant directement ou indirectement aux
objets précités et à tous similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation, l'extension ou le développement."

Plus rien n'étant à l'ordre de jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Frais.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 700,00 €.

<i>Déclaration

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les

bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge du comparant représenté ès-qualités.

7868

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Daniel REDING, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 28 novembre 2012. Relation: DIE/2012/14234. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur (signé): pd. Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 12 décembre 2012

Référence de publication: 2012161466/60.
(120213574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Caesar Raseac S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 107.610.

DISSOLUTION

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh of November.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

CAESAR HOLDING LIMITED, a company incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at Le

Truchot, National Westminster House, BGU - GY1 3RA St Peter Port, here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao
Conde, private employee, with professional address in L-4030 Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard by virtue of a proxy
given under private seal.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
- That the company Caesar Raseac S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 47, avenue John

F. Kennedy L-1855 Luxembourg (the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of Maître Paul FRIEDERS,
notary residing in Luxembourg on 4 April 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 14
September 2005 2012, number 895, amended pursuant to a deed of Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg
on 25 April 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 24 September 2005 2012, number
939.

- That the share capital of the Company is fixed at four hundred forty-seven thousand Euro (EUR 447,000.-), repre-

sented by seventeen thousand eight hundred eighty (17,880) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,
fully paid-up;

- That the Sole Shareholder has acquired the totality of shares of the Company;
- That Company's activities having ceased, the Sole Shareholder decides to proceed with the dissolution of the Com-

pany and to put it into liquidation;

- That the Sole Shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting in this capacity requests the

notary to act its declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in relation of the
close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore the liquidator declares that with respect to possible
liabilities of the Company presently unknown, it irrevocably assumes to pay all such liabilities; that as a consequence of
the above, all the liabilities of the company are paid;

- That the remaining net assets have been paid to the Sole Shareholder;
- That full discharge is granted to the Company's managers for the exercise of their mandates.
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the company's

former registered office.

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and regis-

tration.

Whereof, drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date named at the beginning of the presents.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read in the language of the attorney in fact of the person appearing, acting in her hereabove

capacity, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, the said person signed together
with the notary the present deed.

7869

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.
Par devant Nous, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

CAESAR HOLDING LIMITED, une société constituée sous les lois de Guernesey, ayant son siège social à Le Truchot,

National Westminster House, BGU - GY1 3RA St Peter Port, ici représentée par Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde,
employée privée, avec adresse professionnelle à L-4030 Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procu-
ration délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante, restera annexée au présent acte

avec lequel elle sera soumise aux formalités d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
Que la société Caesar Raseac S.à r.l., ayant son siège social au 47, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, (la

"Société"), a été constituée suivant acte notarié de Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg en
date du 4 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 septembre 2005, numéro 895,
modifié en date du 25 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 24 septembre 2005,
numéro 939.

Que le capital social de la Société est fixé à quatre cent quarante sept mille Euros (EUR 447.000,-) représenté par dix-

sept mille huit cents quatre-vingt (17,880) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune,
entièrement libérées.

Que l'Associé Unique est porteur de la totalité des parts de la Société;
Que les activités de la Société ayant cessé, l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société et sa mise

en liquidation.

Que l'Associé Unique, se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, il requiert le notaire instru-

mentant d'acter sa déclaration que toutes les dettes de la Société sont réglées et que le passif relatif à clôture de la
liquidation est dûment approvisionné. Par ailleurs, il déclare que s'il existe des dettes de la Société encore inconnues à
ce jour, il assume l'obligation irrévocable de payer de telles dettes; par conséquent toutes les dettes de la dite Société
sont réglées;

Que l'actif net restant a été payé à l'Associé Unique;
Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société pour la durée de leurs mandats.
Que tous les livres de compte et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de

la Société.

Tous les pouvoirs nécessaires sont donnés au porteur d'une expédition des présentes afin d'accomplir toutes les

formalités de publication et d'enregistrement.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la partie comparante, le

présent acte  de  société  est rédigé  en  langue  anglaise, suivi  d'une version française.  Sur demande  de la même  partie
comparante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Lecture faite dans la langue du mandataire de la partie comparante, agissant comme décrit ci-dessus, connu du notaire

instrumentant par son nom, prénom, état civil et résidence, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15918. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012161523/92.
(120213726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2012.

GEORGES FABER Opticien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 9, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 34.984.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2012166802/10.
(120220135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

7870

L

U X E M B O U R G

GC Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 47.047.

Les comptes consolidés au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Référence de publication: 2012166796/10.
(120221018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Dipta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 73.012.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2012

L'assemblée a prononcé la clôture de liquidation de la société.
L'assemblée a en outre décidé que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au siège social de BDO Tax &amp; Accounting, 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg, et en outre que les sommes
et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation
seront déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2012.

Référence de publication: 2012166658/16.
(120220257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Meridiam Infrastructure A2 West S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.600.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 146.420.

<i>Extrait des résolutions écrites des associés de la Société

1. Les associés de la Société ont pris acte et ont accepté la démission de Monsieur Stéphane NOIRIE en sa qualité de

membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 5 décembre 2012; et

2. Les associés de la Société ont décidé de nommer Monsieur Peter HAYKWOSKI, né le 4 juillet 1972 à Varsovie, en

Pologne, de résidence professionnelle au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg en qualité de membre du conseil de gérance
de la Société avec effet au 5 décembre 2012.

En conséquence, (i) le conseil de gérance de la Société se compose de la manière suivante:
- Mr. Martijn VERWOEST;
- Mr. Hendrik HUIZING; et
- Mr. Peter HAYKWOSKI.
(ii) Thierry DEAU conserve son mandat de gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MERIDIAM Infrastructure A2 West S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012162668/22.
(120214756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Groupe BÂTI.Lux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 111.799.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

7871

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Référence de publication: 2012164952/10.
(120218093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Alex Arendt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 38.

R.C.S. Luxembourg B 164.609.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012164677/10.
(120217507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

B.E.E.P. (Business Economy Engineering Projects) Luxembourg, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 121.251.

Les comptes annuels pour la période allant du 1 

er

 janvier 2009 au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012164700/10.
(120217668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

KKR Actor Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 3.458.000,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 152.109.

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 25 septembre 2012 l'associé unique de la Société a:
- accepté la démission de Michael Frost avec effet au 26 septembre 2012 en tant que membre du Conseil de Gérance

de la Société (Gérant);

- nommé Monsieur Martin Preuß en tant que membre du Conseil de Gérance de la Société (Gérant) à partir du 27

septembre 2012 pour une durée indéterminée;

de sorte que le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Martin Preuß, né le 26 octobre 1980 à Troisdorf, Allemagne, avec adresse professionnelle au Stirling
Square, 7 Carlton Gardens, SW1Y 5AD Londres, Royaume-Uni

Gérant

William J. Janetschek, né le 28 août 1961 à New York, USA, avec adresse professionnelle au 9 West
57 Street, Suite 4200, NY 10019, New York, USA.

Gérant

Stefan Lambert, né le 8 janvier 1964 à Trèves, Allemagne, avec adresse professionnelle au 63, rue
de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Gérant

Dr. Jan Könighaus, né le 14 novembre 1972 à Pinneberg, Allemagne, avec adresse professionnelle
au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Gérant

Dr. Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1972 à Constance, en Allemagne, avec adresse
professionnelle au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Gérant

<i>Pour la Société
Dr. Jan Könighaus
<i>Gérant

Référence de publication: 2012165090/28.
(120217565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

7872


Document Outline

AB (Holdings) 2 S.à r.l.

Aki-Immo S.A.

Al Badr B. S.A.

Aldebaran Sociaty S.A.

Alex Arendt S.A.

Alison Investments S.A.

Am Weinebierg S.à r.l.

Anathocys S.à r.l.

Anjos Holding S.A.

An.so.fi HOLDING S.A. (AMBOISE SOCIETE FINANCIERE)

AP.Diner S.à r.l.

Aptical Europe S.A.

Archimédial S.A.

Arjo International S.à r.l.

Arkhia Architecture S.A.

Arnould &amp; Silberreiss

Ascain Immobilière S.à r.l.

Asens S.A.

A.S. Hotels S.A.

Assolux S.à r.l.

Auberge de la Gaichel S.à r.l.

Automobiles Origer S.à r.l.

Axes GmbH

Axilis S.à r.l.

Bacur S.A.

Beauty Secret sàrl

B.E.E.P. (Business Economy Engineering Projects) Luxembourg, S.àr.l.

B. Lux S.A.

Brinkdoor Limited T/A Euro London Appointments Luxembourg (succursale)

Brussco Sàrl

B &amp; S EF STEIG Immobilien AG

B &amp; S Immobilien AG

b-to-v S.à r.l.

Caesar Raseac S.à r.l.

Dipta S.A.

D'Owstellgleis S.à.r.l.

GC Europe

GEORGES FABER Opticien S.à r.l.

Greenfield South Holdings S.à r.l.

Groupe BÂTI.Lux S.A.

iHouse Sàrl

International Cores Luxembourg (I.C.L.) S.à r.l.

Interni Casa S.à r.l.

JFL IT Consulting S.à r.l.

JNG &amp; Associés S.A.

KKR Actor Investor S.à r.l.

La Case Créole S. à r.l.

L.C. Buro'tic S.A.

L'Oenophile Sàrl

Logis-Concept S.A.

Lufra Immobilière S.A.

Lux Décor Peinture S.A. en abrégé LDP S.A.

Luxoil PJS GmbH

Meridiam Infrastructure A2 West S.à r.l.

Miland Holding s.à r.l.

Office Metro Limited

PEC Anton S.à r.l.

P.I.C. S.A.

Steinfeld Investitionen S.A.

Wellspring Investments S.à r.l.

Xylem Global S.à r.l.

Zentraleuropäische Immobilien Anlagegesellschaft A.G.

ZTA 1 S.A.