This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3074
21 décembre 2012
SOMMAIRE
Abax Investment Services . . . . . . . . . . . . . .
147507
Acta Priv S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147506
Aquarius Capital Development S.A. . . . . .
147512
Bailey Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
147508
be2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147507
Besix Global Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147507
Bigpoint GMTP Lux JV S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
147508
B-Iond S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147544
Bluestone Capital Partners S.A. . . . . . . . . .
147532
Brandstyles.com Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147512
BRS International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147509
BT Broadband Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
147509
C2P S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147511
Calatrava Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147506
Cashcloud AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147513
C.A.S. Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147511
C.D.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147510
C.E.A.O. Bénard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147510
Charlotte and Charles S.à r.l. . . . . . . . . . . .
147510
Circuit 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147510
Compagnie Immobilière des Ardennes
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147506
Confidensia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147511
CVI Luxembourg Fifteen S.à r.l. . . . . . . . . .
147517
D-Cars S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147511
Distrielec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147512
Entrust-Invest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147540
FundTap Luxembourg Funds . . . . . . . . . . . .
147552
G.O. II - Luxembourg Three S.à r.l. . . . . . .
147552
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. . . . . .
147514
Iceo Parallel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147513
IMP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147513
Indosuez Management II S.A. . . . . . . . . . . .
147514
Insight International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
147514
Interdate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147514
Kona Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147530
Neoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147551
Parana Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
147545
Passy Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
147515
Perimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147512
Petit Bois Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
147549
Pradera Central Istanbul S.à r.l. . . . . . . . . .
147547
RIL II Whitelands S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
147542
Schortgen Reliures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
147513
Soft S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147506
Soft S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147506
Spido Oil s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147507
Tajura S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147508
Web Leasure Investment . . . . . . . . . . . . . . .
147509
Woodlander Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
147509
Woodlander Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
147508
147505
L
U X E M B O U R G
Soft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 98.239.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012151268/10.
(120199208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Soft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 98.239.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012151269/10.
(120199209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Compagnie Immobilière des Ardennes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 85.292.
EXTRAIT
Il est pris acte de la nouvelle adresse de la société à responsabilité limitée «ADVISORY & CONSULTING», immatri-
culée au RCS Luxembourg sous le numéro B 160.540, domiciliée dorénavant au 11A Boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012151376/13.
(120199142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Calatrava Re, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 148.233.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 65287 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012152889/10.
(120201517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Acta Priv S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 59.923.
<i>Extrait de la résolution unique prise lors de la réunion du conseil d'administration du 12 novembre 2012i>
Le siège social de la société sera transféré du numéro 12 au numéro 14, rue de la Gare, L-7535 Mersch avec effet au
15 novembre 2012.
Mersch, le 12 novembre 2012.
Nico AREND.
Référence de publication: 2012156801/11.
(120207764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
147506
L
U X E M B O U R G
be2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 123.206.
Die Gesellschafter haben beschlossen,
1. Der Rücktritt von Nicole Gerdau-Klimsa vom Amt des Geschäftsführers mit Wirkung zum 30.11.2012 wird ange-
nommen.
2. Frau Laetitia Pateau, geboren am 14.02.1973 in Paris (Frankreich), mit beruflicher Anschrift in L-1150 Luxemburg,
291, route d'Arlon, wird ab dem 01.12.2012 zur neuen Geschäftsführerin auf unbestimmte Zeit ernannt.
Référence de publication: 2012156780/12.
(120207377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Spido Oil s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 67.206.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Steinfort, le 29 novembre 2012.
<i>Pour SPIDO OIL s.à r.l.
i>World Hopper s.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012156675/13.
(120206409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.
Abax Investment Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 147.837.
<i>Extrait du conseil d'administration du 23 octobre 2012i>
Le conseil d'administration décide de nommer PriceWaterhouseCoopers, ayant son siège social établi au 400, Route
d'Esch, L-1471 Luxembourg, (R.C.S Luxembourg B 65.477) comme réviseur de la société en remplacement de Deloitte
S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (RCS Luxembourg B.67.895)
Le mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012156783/14.
(120207100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Besix Global Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 77.870.
<i>Extraits du Procès verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2012i>
- L'Assemblée reconduit les mandats d'administrateur de M. Paul MOUTON, M. Frédéric DE SCHREVEL, M. Thierry
MIGEOTTE, M. Yannick ZIGMANN jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2013 statuant sur les
comptes 2012.
- L'Assemblée reconduit le mandat du Réviseur d'entreprises MAZARS jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordi-
naire de juin 2013 statuant sur les comptes 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2012156829/15.
(120207488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
147507
L
U X E M B O U R G
Bigpoint GMTP Lux JV S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 139.155.
DISSOLUTION
Il résulte des délibérations de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 30 novembre 2012 que la clôture
de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux
pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.
Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Bigpoint GMTP Lux JV S.àr.l., en liquidation volontaire
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012156834/15.
(120207820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Bailey Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 172.253.
Il résulte des transferts de parts sociales en date du 16 November 2012 que:
- Pallister Holdings Limited, 9 Colombus Center, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Îles Vierges Britanniques, a
transféré le 16 November 2012 cinq cent parts sociales (500) à CV4 Ltd, Woodbourne Hall PO Box 3162 Road Town
Tortola, Îles Vierges Britanniques
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012156825/14.
(120207766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Woodlander Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 62.226.
<i>Rectificatif du bilan au 31 décembre 2010 enregistré à Luxembourg le 23/10/2012. référence L120182721 qui a été déposé aui>
<i>registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 23/10/2012.i>
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Companies & Trusts Promotion S.A.
Référence de publication: 2012156724/13.
(120206623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.
Tajura S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 75.295.
Les comptes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TAJURA S.A.
ROSSI Jacopo / HEITZ Jean-Marc
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012156690/12.
(120206353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.
147508
L
U X E M B O U R G
Web Leasure Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 43, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 145.906.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2012.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2012156726/12.
(120206542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.
Woodlander Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 62.226.
<i>Rectificatif du bilan au 31 décembre 2011 enregistré à Luxembourg le 23/10/2012. référence L120182723 qui a été déposé aui>
<i>registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 23/10/2012 était incorrect.i>
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Companies & Trusts Promotion S.A.
Référence de publication: 2012156723/13.
(120206622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.
BRS International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 140.077.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 27 juin 2012i>
L'assemblée générale a décidé de remplacer le réviseur d'entreprises actuel par la société Mazars Luxembourg, société
anonyme, ayant son siège social à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159962, pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale
annuelle en relation avec les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Référence de publication: 2012156859/14.
(120207772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
BT Broadband Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 4.025.906.884,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 71.594.
<i>Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la société en date du 30 octobre 2012i>
1. L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Leslie Charles WINNISTER, demeurant professionnelle-
ment au 81, Newgate Street, GB-EC1A 7AJ Londres, de son mandat de gérant B de la Société, avec effet au 11 octobre
2012.
2. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1
er
décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012156860/15.
(120207353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
147509
L
U X E M B O U R G
Charlotte and Charles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 172.763.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a cédé en date du 3 décembre 2012 toutes ses parts dans la Société à Xylem Delaware,
Inc., étabie et ayant son siège social à 1105, North Market Street, Wilmington DE19801, Etats-Unis d'Amérique.
La Société prend acte de la démission de Monsieur François Georges avec effet au 3 décembre 2012.
Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Pour extrait conforme
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012156892/15.
(120207603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
C.E.A.O. Bénard, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.
R.C.S. Luxembourg B 97.417.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2012i>
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société C.E.A.O. Bénard, tenue en date du 3 septembre 2012:
- Acceptation du changement du siège social au 44 rue de wiltz L-2734 Luxembourg, avec effet au 3 septembre 2012
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012156865/14.
(120207287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Circuit 3, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 170.221.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de la Société prises avec effet au 27 août 2012i>
Le Conseil d’Administration a décidé de nommer Monsieur Christian COUTURIER, administrateur de la Société, à la
fonction de Président du Conseil d’Administration pour la durée de son mandat d’administrateur de la Société.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Circuit 3
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012156877/13.
(120207111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
C.D.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 85.253.
<i>Extrait de la résolution unique prise lors de la réunion du conseil d'administration du 21 novembre 2012i>
Le siège social de la société a été transféré du numéro 12 au numéro 14, rue de la Gare, L-7535 Mersch.
Mersch, le 21 novembre 2012.
Nico AREND / Jean-Marie MATHGEN
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012156864/12.
(120207754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
147510
L
U X E M B O U R G
C.A.S. Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 68.168.
Une liste des fondés de pouvoirs de la Société CAS Services S.A. en fonction au 15 novembre 2012 a été déposée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CAS Services S.A.
Signature
Référence de publication: 2012156862/12.
(120207436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
C2P S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 140.851.
La nouvelle adresse de Monsieur Pascal Canaud, Associé et Gérant de la société C2P S.A R.L. est la suivante: 1 Ter,
rue Maurice Bouchor F-10000 Troyes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2012.
C2P S.À R.L.
Référence de publication: 2012156906/13.
(120207610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
D-Cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3414 Dudelange, 39, rue Bannent.
R.C.S. Luxembourg B 147.729.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinairei>
Le 15 novembre 2012 à 18h00 heures, l'associé de la société D Cars SàRL s'est réuni en assemblée générale au siège
social de la société à L-3429 Dudelange, 218, Route de Burange
La décision suivante est adoptée:
- Transfert du siège de la Société à L-3414 Dudelange, 39 rue Bannent avec effet au 15 novembre 2012.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 heures.
Carlos Alberto MARQUES PINTO.
Référence de publication: 2012156907/14.
(120207773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Confidensia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5427 Greiveldange, 4A, Bechelsbierg.
R.C.S. Luxembourg B 154.874.
<i>Auszug aus dem Protokoll der aussergewöhnlichen Generalversammlung der Confidensia S.A. abgehalten in L-5427 Greiveldingen,i>
<i>am 15. September 2012:i>
1. Abberufung des Verwalters Herrn Nicolas RUFFINI, Rentner, wohnhaft in L-5427 Greiveldingen, Bechelsbierg 4a.
2. Zum alleinigen Verwalter wird bestellt: Herr Thomas KALETA, Kaufmann, wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 66-70,
Grand-Rue.
Luxemburg, den 15. September 2012.
N. SCHARPFF.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, den 28. November 2012.
Référence de publication: 2012156896/15.
(120207297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
147511
L
U X E M B O U R G
Distrielec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 154.799.
EXTRAIT
Monsieur Georges MERGEN est révoqué du mandat d'administrateur.
Monsieur Christophe LAMBERT, administrateur, déclare par la présente, que son adresse est la suivante:
31 rue de Florival, B-1390 Archennes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2012.
<i>Pour DISTRIELEC SA
i>Signature
Référence de publication: 2012156919/15.
(120207414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Perimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 144.009.
Par la présente, la société «ADVISORY & CONSULTING» représentée par son gérant unique Monsieur Guillaume
BERNARD, informe qu'elle démissionne de sa fonction de Commissaire aux comptes de la Société référencée ci-dessus,
et ceci avec effet immédiat.
Strassen, le 03 mai 2012.
ADVISORY & CONSULTING
Guillaume BERNARD
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012151390/14.
(120199211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Aquarius Capital Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 137.866.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012156812/13.
(120207025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Brandstyles.com Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 103.514.
<i>Rectificatif du L110211725 déposé le 29/12/2011i>
Die verkürzte Bilanz zum 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2012156838/12.
(120207563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
147512
L
U X E M B O U R G
IMP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 159.669.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg de manière extraordinaire en date du 21 novembrei>
<i>2012i>
L'assemblée décide de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg S.à r.l. ayant son siège social au 9, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé.
Le mandat du réviseur d'entreprises agréé ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle
approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2012.
Pour extrait conforme
IMP S.à r.l.
Référence de publication: 2012157076/15.
(120207476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Iceo Parallel, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue J.-P. Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 147.586.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012153024/14.
(120201622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Schortgen Reliures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 121, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 94.350.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012156656/13.
(120206788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.
Cashcloud AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 155.416.
Die Aktionäre haben in einer ordentlichen Hauptversammlung vom 08.11.2012 beschlossen:
1. Der Rücktritt von Frau Christina Kaufmann als Rechnungsprüfer wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Gesellschaft EUROPEAN AUDIT, Société à Responsabilité Limitée, mit Sitz in 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette,
R.C.S. Luxembourg B 50956, wird mit sofortiger Wirkung zum neuen Rechnungsprüfer ernannt. EUROPEAN AUDIT
wird für das Geschäftsjahr 2012 ernannt.
Référence de publication: 2012156875/12.
(120207132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
147513
L
U X E M B O U R G
Insight International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 153.220.
EXTRAIT
- Dénonciation du siège social:
Le siège social de la société INSIGHT INTERNATIONAL SARL, inscrite au Registre de Commerce et des Société
numéro B 153220 dont siège social fixé au L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois est dénoncé par le domiciliataire avec
effet au 1
er
décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE SARL
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012157081/15.
(120207483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 55.855.
<i>Auszug aus den Beschlüssen der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 26. November 2012i>
Die Hauptversammlung beschließt:
- die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Herr Claude Niedner, Herr Rainer Lemm und Herr Ralf Funk bis zur
nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2013 zu verlängern;
- Ernst & Young, société anonyme, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg und einges-
chrieben beim Luxemburger Gesellschaftsund Handelsregister unter der Nummer B47771, zum Wirtschaftsprüfer der
Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2013 zu ernennen.
Référence de publication: 2012157031/14.
(120207479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Interdate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 158.155.
Die Hauptversammlung hat beschlossen,
1. Der Rücktritt von Nicole Gerdau-Klimsa vom Amt des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds mit Wirkung zum
30.11.2012 wird angenommen.
2. Frau Laetitia Pateau, geboren am 14.02.1973 in Paris (Frankreich), mit beruflicher Anschrift in L-1150 Luxemburg,
291, route d'Arlon, ab dem 01.12.2012 zum neuen alleinigen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen. Das Mandat von Frau
Pateau endet mit der ordentlichen Hauptversammlung, die im Jahre 2018 stattfinden wird.
Référence de publication: 2012157082/13.
(120207411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Indosuez Management II S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 46.093.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 avril 2012i>
Le mandat de la société ERNST & YOUNG SA., siège social au 7 parc d'activités Syrdall à L-5365 Munsbach, est
renouvelé comme Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an.
<i>Pour la société
i>INDOSUEZ MANAGEMENT II S.A.
Référence de publication: 2012157080/12.
(120207385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
147514
L
U X E M B O U R G
Passy Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 98.829.
L'an deux mille douze, le quinzième jour de novembre.
Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ESTATES S.A., ayant son siège social au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.770,
en sa qualité d'actionnaire unique de PASSY DEVELOPMENT S.A., une société anonyme constituée et régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 98.829, constituée suivant acte de Maître
Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Luxembourg, du 15 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du 20 mars 2004, n° 322 et dont les statuts ont été modifié en dernier lieu le 29 novembre 2007 suivant
acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 29 janvier 2008, n° 226 (la «Société»),
ici représentée par Monsieur Patrick de Froidmont, juriste, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper,
L 2557 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 novembre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Actionnaire Unique a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Agendai>
1 Modifier l'année sociale de la Société;
2 Sous réserve de la modification ci-dessus, (i) clôturer l'année sociale en cours au 30 novembre 2012, (ii) décider
qu'une année sociale intermédiaire commencera le 1
er
décembre 2012 et se terminera le 31 décembre 2012, et qu'en
conséquence (iii) une nouvelle année sociale commencera le 1
er
janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2013; et
3 Modifier en conséquence l'article 14 des statuts de la Société pour changer l'année sociale;
4 Divers.
L'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'année sociale de la Société afin qu'elle débute le premier jour de janvier
et se termine le dernier jour de décembre de chaque année.
<i>Seconde résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé (i) de clôturer l'année sociale en cours au 30 novembre 2012, (ii) qu'une année sociale
intérimaire commencera le 1
er
décembre 2012 et se terminera le 31 décembre 2012, et qu'en conséquence (iii) une
nouvelle année sociale commencera le 1
er
janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2013.
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de modifier en conséquence l'article 14 des statuts de la Société, qui sera dorénavant
rédigé comme suit:
« Art. 14. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.»
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés
approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue française, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie
comparante, le présent acte a été rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise; à la demande de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte français primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg par le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
soussigné par ses noms, prénoms usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Follows the English version of the preceding text:
In the year two thousand twelve, on the fifteenth day of November.
147515
L
U X E M B O U R G
Before us, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
ESTATES S.A., with registered office at 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg
register of commerce and companies under number B 106.770,
in its capacity as Sole Shareholder of PASSY DEVELOPMENT S.A., a société anonyme incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper,
registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 98.829, incorporated pursuant to
a deed of Maître Gérard LECUIT, then notary residing in Luxembourg, dated January 15, 2004, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations of March 20, 2004, n° 322, and whose articles of incorporation have been amended
on November 29, 2007 pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of January 29, 2008, n° 226 (the "Company"),
duly represented by Mr Patrick de Froidmont, juriste, with professional address at 18, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, by virtue of a proxy dated November 15, 2012.
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agendai>
1 To change the financial year of the Company;
2 Subject to the above change, (i) to end the current financial year of the Company on 30 November 2012, (ii) to
resolve that an interim financial year will begin on 1
st
December 2012 and end on 31 December 2012, and that accordingly
(iii) a new financial year will begin on 1
st
January 2013 and end on 31 December 2013;
3 To amend subsequently the article 14 of the articles of association of the Company in order to change the fiscal
year;
4 Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the financial year of the Company so that it shall forthwith begin on the first
day of January and ends on the last day of December of each year.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved (i) to end the current financial year of the Company on 30 November 2012, (ii) that
an interim financial year will begin on 1
st
December 2012 and end on 31 December 2012, and that accordingly (iii) a new
financial year will begin on 1
st
January 2012 and end on 31 December 2012.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 14 of the articles of association of the Company in order to change
the fiscal year, which shall from now on read as follows:
" Art. 14. The business year begins on January 1
st
of each year and ends on December 31
st
the same year."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).
The undersigned notary who knows French, states herewith that on request of the above appearing party, the present
deed is worded in French followed by a English version; on request of the same party and in case of divergences between
the English and the French text, the French text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Signé: P. DE FROIDMONT, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2012. Relation: DIE/2012/13736. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveur p.d.i> (signé): RECKEN.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
147516
L
U X E M B O U R G
Diekirch, le 23 novembre 2012.
Référence de publication: 2012153199/105.
(120201893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
CVI Luxembourg Fifteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 132.063.
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of November.
Before Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
CVI EUROPE LLC, a limited liability corporation incorporated and existing under the laws of Delaware, United States
of America, with its principal office at 15407 McGinty Road West, Minnetonka, Minnesota 55391 USA, registered in
Delaware under company number 5003374,
here represented by Mr. Philipp Metzschke, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of CVI Luxembourg Fifteen S.à r.l. (the "Company"), a société à respon-
sabilité limitée having its registered office at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132063, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary, on 23 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2440,
dated 27 October 2007.
The articles of association have been amended pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary, on 22 July 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2233, dated 21 November 2011 and no
amendments have been made since.
The appearing party representing all the share corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to convert the twenty thousand (20,000) shares, having a par value of
one pound sterling (GBP 1) each, into two million (2,000,000) shares, having a par value of one pence (GBP 0.01) each.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to create a share class A and a share class B in the share capital of the
Company, setting out the rights attached to each share class in the fifth resolution.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company decides to convert one million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred
(1,999,900) ordinary shares, having a par value of one pence (GBP 0.01) each, into one million nine hundred ninety-nine
thousand nine hundred (1,999,900) class A shares and one hundred (100) ordinary shares, having a par value of one pence
(GBP 0.01) each, into one hundred (100) class B shares with a subsequent allocation of one million nine hundred ninety-
nine thousand nine hundred (1,999,900) class A shares and one hundred (100) class B shares to the sole shareholder of
the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company decides to amend the financial year of the Company so that it will from now
on, start on 1 January and end on 31 December of each year. Therefore the current financial year which started on 1
June 2012 will end on 31 December 2012.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions and in view of the transfer of one hundred (100) class B shares to a third
party, the sole shareholder of the Company decides to fully restate the articles of association of the Company, which
shall henceforth read as follows:
"A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owners of the Shares and all those who may become Share-
holders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by the 1915
Law regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
147517
L
U X E M B O U R G
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.
The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited
liability for all debts and obligations of such entities.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of CVI Luxembourg Fifteen S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its Shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twenty thousand pounds sterling (GBP 20,000) represented by one million
nine hundred ninety-nine thousand nine hundred (1,999,900) A Shares having a par value of one pence (GBP 0.01) each
and one hundred (100) B Shares having a par value of one pence (GBP 0.01) each.
Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of Shareholders representing three
quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. Share issues and transfers.
9.1. Save as provided in the remainder of this article 9 below (and pursuant to article 10 (Events of Default)) and subject
to the provisions of the 1915 Law (and more specifically article 189 of the 1915 Law), there is no restriction on the
transfer of all or any A Share(s) by the A Shareholder and the B Shareholder may only transfer all or any B Share(s) with
the prior written consent of the A Shareholder, such consent not to be unreasonably withheld or delayed in the case of
a transfer of all or any B Share(s) to an Affiliate of the B Shareholder.
9.2. Any transferee of A Shares (the "A Transferee") shall not be entered into the Register unless:
(i) the transfer complies with the Shareholders Agreement (if any), these articles of association and the 1915 Law; and
(ii) (without prejudice to article 9.5 (i)) all costs and expenses in relation to such transfer are borne by the A Shareholder
(and the A Transferee, the B Shareholder and the Company are indemnified accordingly).
9.3. Any transferee of B Shares (the "B Transferee") shall not be entered into the Register unless:
(i) the transfer complies with the Shareholders Agreement (if any), these articles of association and the 1915 Law;
(ii) where the transfer is to an Affiliate of the B Shareholder (an "Affiliate Transferee"), the B Shareholder provides
such evidence as the A Shareholder may require to demonstrate to the satisfaction of the A Shareholder that the Affiliate
Transferee is an Affiliate of the B Shareholder; and
(iii) all costs and expenses in relation to such transfer are borne by the B Shareholder (and the B Transferee, the A
Shareholder and the Company are indemnified accordingly).
9.4. In the event that at any time following the completion of a transfer or disposal by the B Shareholder (a "Transferring
B Shareholder") of all or any B Share(s) to an Affiliate of the Transferring B Shareholder pursuant to article 9.3, such
Affiliate Transferee ceases to be an Affiliate of the Transferring B Shareholder, the Transferring B Shareholder shall
procure that the Affiliate Transferee shall immediately transfer the B Share(s) to the Transferring B Shareholder or to an
Affiliate of the Transferring B Shareholder in accordance with article 9.3.
9.5. On or prior to a sale or other disposal of the entire A Shares or the entire issued shares in the A Shareholder
(or any holding company of the A Shareholder) (an "A Shareholder Realisation") to a third party purchaser (which shall
not, for the avoidance of doubt, include any Affiliate of the A Shareholder) (such third party purchaser being the "Pur-
chaser") the A Shareholder undertakes that it shall:
(i) inform the B Shareholder promptly in writing that the A Shareholder Realisation has or is to take place, including
details of the relevant transaction and the proceeds received or proposed to be received (net of all costs and expenses
of such sale or disposal including without limitation marketing and valuation costs, agents' and professional fees and taxes)
("Net Proceeds") of the A Shareholder Realisation (including details of the amount of any deferred or contingent proceeds)
(an "A Shareholder Realisation Notice"); and
147518
L
U X E M B O U R G
(ii) procure, upon completion of an A Shareholder Realisation, that the Purchaser acquires all the B Share(s) from the
B Shareholder in consideration for the payment by the Purchaser to the B Shareholder of such amount as may be agreed
among the Shareholders from time to time (including under the Shareholders Agreement (if any)) (the "Agreed Amount").
(a "B Share Offer")
9.6. The board of managers undertakes to convene general meetings of the Shareholders of the Company from time
to time as necessary in order for the Shareholders to approve (and vote in favour of):
(i) the payment of the Agreed Amount by way of an Interim Redemption; and
(ii) that payment of the Agreed Amount shall be made as soon as practicable thereafter.
9.7. If, following:
(i) either:
a) a sale to a third party (which, for the avoidance of doubt, shall not be any party that is not an Affiliate of the A
Shareholder) of: (i) all of the issued share capital and/or equivalent interests in Propco held by the Company from time
to time; or (ii) the Property; or
b) a grant of a long lease of the Property by Propco to a third party which results in a nominal value being attributable
to Propco's reversionary interest in the Property,
(in each case, the "Sale"); and
(ii) the receipt by the Company of all consideration monies due to it under the relevant sale agreement in relation to
the Sale,
and an Agreed Amount has become payable in accordance with the Shareholders Agreement (if any), the board of
managers undertakes to convene a general meeting of the Shareholders of the Company in order for the Shareholders
to approve (and vote in favour of):
(i) the payment of the Agreed Amount;
(ii) the redemption of all of the B Shares (the "Final Redemption"); and
(iii) that payment of the Agreed Amount shall be made as soon as practicable thereafter.
9.8. On or following an A Shareholder Realisation and the issue of an A Shareholder Realisation Notice the A Share-
holder shall have the right (the "Drag Along Right") to require the B Shareholder to accept the B Share Offer in full from
the Purchaser provided that the A Shareholder shall procure the compliance of the Purchaser in respect of the Agreed
Amount in accordance with article 9.5 (ii) above.
9.9. The Drag Along Right may be exercised by the A Shareholder by service of a notice ("Drag Along Notice") to that
effect on the B Shareholder within five (5) Business Days following the date of an A Shareholder Realisation Notice.
Subject to article 9.8, on the exercise of the Drag Along Right, the B Shareholder will be bound to accept the B Share
Offer and to comply with the obligations assumed by virtue of such acceptance.
9.10. Following any payments in accordance with article 9.5, article 9.7 or article 9.9 as the case may be, the B Share-
holder shall have no further entitlement to payment of any Agreed Amount.
Art. 10. Events of Default.
10.1. The B Shareholder commits an event of default (an "Event of Default", and the B Shareholder then being a
"Defaulting Shareholder") if:
(i) an order is made by a court of competent jurisdiction, or a resolution is passed, for the liquidation or administration
of the B Shareholder or a notice of appointment of an administrator of the B Shareholder is filed with a court of competent
jurisdiction (otherwise than in the course of a reorganisation or restructuring previously approved in writing by the A
Shareholder);
(ii) any step is taken (otherwise than in the course of a reorganisation or restructuring previously approved in writing
by the A Shareholder) to appoint a manager, receiver, administrative receiver, administrator, trustee or other similar
officer of the B Shareholder or in respect of the B Shareholder or any of its assets which include either (i) the Shares
held by the B Shareholder or (ii) shares or other securities in the B Shareholder;
(iii) it convenes a meeting of its creditors or makes or proposes any arrangement or composition with, or any assign-
ment for the benefit of, its creditors;
(iv) it commits a material breach of the Shareholder Agreement (if any) and (if capable of remedy) fails to remedy the
same (or establish plans to remedy the same in a manner satisfactory to the A Shareholder), acting reasonably within
twenty (20) Business Days of notice to do so being given by the A Shareholder (and in which the A Shareholder expresses
its intention to exercise its rights under this article);
(v) it stops payment generally or is unable to pay its debts as they fall due or enters into any dealings with its creditors
with a view to avoiding, or in the expectation of, insolvency; or
(vi) any event or proceedings in any jurisdiction which have an effect analogous to any of the events or proceedings
specified in this article 10.1 (i) to 10.1(v) (inclusive) in respect of the B Shareholder.
10.2. Further, the B Shareholder commits an Event of Default if:
(i) it ceases to be under the direct or indirect control of the Specified Individuals;
147519
L
U X E M B O U R G
(ii) any of the events defined as "Events of Default" (as defined in the Servicing Agreement (if any)) apply in relation to
the Operator;
(iii) the Operator is in material breach under the Servicing Agreement (if any) in circumstances which entitles Propco
to terminate the Servicing Agreement (if any) in accordance with its terms or Propco is entitled to terminate the Servicing
Agreement (if any) as a result of the wilful misconduct or gross negligence of the Operator;
(iv) the Operator ceases to be under the direct or indirect Control of the Specified Individuals.
10.3. Consequences of an Event of Default.
(i) The B Shareholder shall notify the A Shareholder in writing as soon as reasonably practicable in the event that it
becomes a Defaulting Shareholder or if it becomes aware of the occurrence of an Event of Default.
(ii) Where an Event of Default occurs the A Shareholder may elect to serve an irrevocable written notice on the
Defaulting Shareholder (a "Default Purchase Notice") requiring the purchase by the A Shareholder of all the B Shares at
the nominal value of the B Shares.
(iii) No further amount in respect of the any Agreed Amount shall become due and payable following an Event of
Default.
10.4. Completion of the sale and purchase of the B Shares pursuant to article 10.3(ii) shall:
(i) take place within thirty (30) Business Days of the Default Purchase Notice at a time, date and place determined by
the managers of the Company (acting reasonably);
(ii) be on terms that the B Shares are sold with full title guarantee free from Encumbrances and with all rights attaching
to it with effect from the relevant transfer date; and
(iii) require the B Shareholder to execute the Register for the B Shares, against which the A Shareholder shall pay to
the B Shareholder the nominal value for the B Share(s) and any Agreed Amount which (subject to the terms of the
Shareholders Agreement (if any)) became due and payable prior to the Event of Default.
10.5. If a Shareholder fails to sell or purchase any B Share in accordance with this article 10, the provisions of article
13 shall apply.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the Shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 12. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
Art. 13. Power of Attorney.
13.1. As security for the performance of its obligations under articles 9.7 to 9.10 and article 10, each Shareholder shall
be deemed to have appointed the Company (such appointment being revocable only upon a Shareholder ceasing to hold
any Shares), acting by any manager, to be its attorney for the following purposes:
(i) to approve, execute (as a deed or otherwise) and deliver all such documents as its attorney shall in its absolute and
unfettered discretion deem necessary for the purpose of giving effect to any transfer of Shares pursuant to article 9.9 or,
as the case may be, article 10 (or in case of the B Shareholder, an Interim Redemption or the Final Redemption); and
(ii) to cause the relevant transferee's name to be entered into the Register as the holder of the relevant Shares.
C. Management
Art. 14. The Company shall be managed by at least one manager, who does not need to be a Shareholder.
In dealings with third parties, the managers have the most extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The managers are appointed by the general meeting of Shareholders of the Company, upon a list of candidates provided
by the A Shareholder only, who may fix the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time solely
by the A Shareholder without there having to exist any legitimate reason (cause légitime).
The board of managers shall deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or repre-
sented and all decisions are validly taken by the majority of the managers present or represented.
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Art. 15. In the case of several managers, the Company is managed by the board of managers which shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary,
who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon being called by any one manager at the place indicated in the notice of meeting.
All board of managers' meetings shall be held at the registered office of the Company or any other place in Luxembourg
as indicated in the notice. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a
chairman, the board of managers may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such
meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to all of the managers at least twenty-four
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in the case of emergency, in which case the nature and the
147520
L
U X E M B O U R G
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. The notice may be omitted in the case of assent of each
manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special con-
vocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 16. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 17. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 18. A manager does not assume, by reason of its position, any personal liability in relation to commitments regularly
made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for
the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or willful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Art. 19. A manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry¬forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder
Art. 20. Each Shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of Shares which he
owns. Each Shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents Shares.
Art. 21. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by Shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of association requires the approval of a majority of Shareholders representing at least
three quarters of the share capital of the Company.
Art. 22. Where there is a sole shareholder of the Company, such sole shareholder shall exercise the powers granted
to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the 1915 Law concerning commercial
companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 23. The Company's financial year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of
each year.
Art. 24. Each year on the thirty-first of December the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each Shareholder may inspect the above
inventory and balance sheet at the Company's registered office.
147521
L
U X E M B O U R G
Art. 25. Five per cent (5%) of the net profit shall, at all times, be set aside for the establishment of a statutory reserve,
until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the Shareholder
(s). Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law or, if there is
a Shareholders Agreement, in accordance with the terms of such Shareholders Agreement.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 26. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be Shareholders, and which are appointed by the general meeting of Shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
Shareholders proportionally to the Shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be
or, if there is a Shareholders Agreement, in accordance with the terms of such Shareholders Agreement.
Art. 27. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the 1915
Law on commercial companies and amendments thereto. The English version of these articles of association shall be
binding.
G. Definitions
Art. 28.
"1915 Law" means the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time to
time;
"A Shareholder Realisation" has the meaning set out in article 9.5;
"A Shareholder Resolution Notice" has the meaning set out in article 9.5(i);
"A Shareholder" means the holder(s) of the A Shares from time to time;
"A Shares" means the issued class A shares in the share capital of the Company from time to time with a par value of
one pence (GBP 0.01) each;
"A Transferee" has the meaning set out in article 9.2;
"Affiliate" means:
(i) any direct or indirect subsidiary undertaking or direct or indirect parent undertaking of that Person and any sub-
sidiary undertaking of any such parent undertaking, in each case from time to time, provided that, to be an Affiliate of the
B Shareholder, such parent undertaking or subsidiary undertaking must also be under the direct or indirect Control of
the Specified Individuals jointly; and
(ii) in relation to the A Shareholder only, also means:
(a) any undertaking (including without limitation any partnership or unit trust) where the A Shareholder or any entity
referred to in (i) above alone or together holds 50% or more of the economic interest in such undertaking; and/or
(b) any undertaking (including without limitation any partnership or unit trust) where the A Shareholder or any entity
referred to in (i) above alone or together with any other entity referred to in (ii)(a) above Controls such undertaking.
"Affiliate Transferee" has the meaning set out in article 9.3;
"Agreed Amount" has the meaning set out in article 9.5;
"B Share Offer" has the meaning set out in article 9.5;
"B Shares" means the issued class B shares in the share capital of the Company from time to time with a par value of
one pence (GBP 0.01) each;
"B Shareholder" means the holder of the B Shares from time to time;
"B Transferee" has the meaning set out in article 9.3;
"Business Day" means any day that is not a Saturday, Sunday or a day on which banks are required or permitted to be
closed in London or Luxembourg;
"Control" means the possession, directly or indirectly, of the power to direct the management and the policies of a
person or entity whether through the ownership of voting securities, by contract, or otherwise (including for the avoi-
dance of doubt, in the case of the A Shareholder only, through fund management or advisory services); and "Controls"
and "Controlled by" shall be interpreted accordingly;
"Default Purchase Notice" has the meaning set out in article 10.3(ii);
"Defaulting Shareholder" has the meaning set out in article 10.1;
"Drag Along Notice" has the meaning set out in article 9.9;
"Drag Along Right" has the meaning set out in article 9.8;
"Encumbrance" means any claim, option, mortgage, pledge, lien, charge, assignment, hypothecation, right to acquire,
right of pre-emption, right of first refusal, title retention, or any other third party right or security interest, or other
agreement or arrangement which has the same or a similar effect to the granting of security;
147522
L
U X E M B O U R G
"Event of Default" has the meaning set out in article 10.1;
"Final Redemption" means the redemption of all of the B Shares pursuant to article 9.7;
"Interim Redemption" means the redemption of a B Share which is not the Final Redemption;
"Net Proceeds" has the meaning set out in article 9.5;
"Operator" means Canmoor Asset Management Limited or such Operator Affiliate of Canmoor Asset Management
Limited;
"Operator Affiliate" means any Person that, directly or indirectly, Controls or is Controlled by or is under common
Control with such Person (and, in the case of Prospect First Limited and its shareholders, any other Person managed or
advised by CarVal Investors LLC or any of its Affiliates);
"Person" means any individual, corporation, partnership, joint venture, association, joint stock company, trust, entity,
unincorporated organisation or government or any agency or political subdivision thereof;
"Propco" has the meaning set out in the Shareholders Agreement (if any);
"Property" has the meaning set out in the Shareholders Agreement (if any);
"Purchaser" has the meaning set out in article 9.5;
"Register" means the register of the Shareholders of the Company;
"Sale" has the meaning set out in article 9.7;
"Servicing Agreement" means any servicing agreement (if any) dated on or around the date of the Shareholders Agree-
ment (if any) between Propco and the Operator, as amended from time to time;
"Shareholder" means, as the context shall require, either or both of the A Shareholder and the B Shareholder and
"Shareholders" means both of them;
"Shareholders Agreement" means any shareholders' agreement (if any) entered into by the Company's Shareholders
in relation to the Company, as amended from time to time;
"Shares" means, as the context shall require, any or all of the A Shares and/or the B Shares;
"Specified Individuals" has the meaning set out in the Shareholders Agreement (if any);
"Transferring B Shareholder" has the meaning set out in article 9.4."
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder of the party appearing
signed together with the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendzwölf, den vierzehnten November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri BECK, mit Amtssitz in Echternach, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN
CVI EUROPE LLC, eine limited liability corporation gegründet und bestehend unter den Rechten des Staates Delaware,
Vereinigte Staaten von Amerika, mit Gesellschaftssitz in 15407 McGinty Road West, Minnetonka, Minnesota, 55391
Vereinigte Staaten von Amerika und eingetragen in Delaware unter der Nummer 5003374,
vertreten durch Herrn Philipp Metzschke, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen
Vollmacht.
Die Vollmacht wird nach Paraphierung „ne varietur' durch den Notar und den Bevollmächtigten der vorliegenden
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg eingereicht zu
werden.
Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter von CVI Luxembourg Fifteen S.à r.l. (hier folgend die "Gesell-
schaft"), eine société à responsabilité limitée mit Sitz in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, eingetragen
beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 132063, welche durch notarielle Urkunde
des Notars Maître Joseph Elvinger vom 23.August 2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
unter Nummer 2440 am 27. Oktober 2007.
Die Satzung wurde zuletzt am 22. Juli 2011 durch notarielle Urkune des Notars Maître Martine Schaeffer abgeändert,
veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 2233 am 21. November 2011.
Die erschienene Partei, welche das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertritt, ersucht den Notar folgende
Beschlüsse zu Beurkunden:
147523
L
U X E M B O U R G
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt die bestehenden zwanzigtausend (20.000) Anteile mit einem Nominalwert von
jeweils einem Pfund Sterling (GBP 1) in zwei Millionen (2.000.000) Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Penny (GBP 0,01) umzuwandeln.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt eine Anteilsklasse A und eine Anteilsklasse B im Gesellschaftskapital der Ge-
sellschaft zu schaffen und die mit den Anteilsklassen verbundenen Rechte im fünften Beschluss festzulegen.
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt eine Million neunhundertneunundneunzigtausend neunhundert (1.999.900) An-
teile mit einem Nominalwert von jeweils einem Penny (GBP 0,01) in eine Million neunhundertneunundneunzigtausend
neunhundert (1.999.900) Anteile der Klasse A, sowie einhundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem
Penny (GBP 0,01) in einhundert (100) Anteile der Klasse B umzuwandeln und darauffolgend eine Million neunhundert-
neunundneunzigtausend neunhundert (1.999.900) Anteile der Klasse A und einhundert (100) Anteile der Klasse B dem
alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft zuzuordnen.
<i>Vierter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, sodass dieses fortan am 1. Januar
beginnt und am 31. Dezember jeden Jahres endet.
Demzufolge endet das laufende Geschäftsjahr, welches am 1. Juni 2012 begann, am 31. Dezember 2012.
<i>Fünfter Beschlussi>
Als Konsequenz der voranstehenden Beschlüsse und in Hinsicht auf die Übertragung von einhundert (100) Anteilen
der Klasse B an eine drritte Person, beschließt der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft die Satzung der Gesellschaft
abzuändern und neuzuformulieren welche fortan wie folgt lautet:
"A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes von 1915, sowie durch nachstehende Satzung geregelt
wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-
chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CVI Luxembourg Fifteen S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Be-
schluss der Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch
einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere
Filialen können entweder in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend Pound Sterling (GBP 20.000,-), aufgeteilt in eine Million neun-
hundertneunundneunzigtausend neunhundert (1.999.900) A Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem penny
(GBP 0,01) und einhundert (100) B Anteile mit einem Nominalwert von je einem penny (GBP 0,01).
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese
Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.
147524
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Anteilsvergaben und Übertragungen.
9.1. Sofern nicht im restlichen Artikel 9 (und gemäß Artikels 10 (Verzugfälle)), sowie vorbehaltlich der Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 (insbesondere des Artikels 189 des Gesetzes von 1915), anders festgelegt, gelten keine Ein-
schränkungen in Bezug auf die Übertragung von allen, beziehungsweise einzelnen A Anteilen durch den A Gesellschafter
und der B Gesellschafter kann nur im Falle einer ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis des A Gesellschafters alle,
beziehungsweise einzelne B Anteile übertragen. Diese Einverständnis sollte nicht ohne angemessenen Grund verzögert
werden sollte die Übertragung der B Anteile durch den B Gesellschafter an einen Partner des B Gesellschafters erfolgen.
9.2. Jeglicher Erwerber von A Anteilen (der "A Erwerber") soll nicht in das Anteilsregister einzutragen werden es sei
denn:
(i) die Übertragung geschieht in Übereinstimmung mit dem Gesellschafterabkommen (soweit vorhanden), dieser Sat-
zung und dem Gesetz von 1915; und
(ii) (ohne gegen Artikel 9.5 (i) zu verstoßen) alle Kosten in Zusammenhang mit einer solchen Übertragung werden
vom A Gesellschafter getragen (und der A Erwerber, B Gesellschafter und die Gesellschaft werden entsprechend ent-
schädigt).
9.3. Jeglicher Erwerber des B Anteils (der "B Erwerber") soll nicht in das Anteilsregister einzutragen werden es sei
denn:
(i) die Übertragung geschieht in Übereinstimmung mit dem Gesellschafterabkommen (soweit vorhanden), dieser Sat-
zung und dem Gesetz von 1915;
(ii) im Falle einer Übertragung an einen Partner des B Gesellschafters (ein "Partnererwerber"), liefert der B Gesell-
schafter jeden vom A Gesellschafter geforderten Beleg, um zur Zufriedenheit des A Gesellschafters nachzuweisen, dass
der Partnererwerber ein Partner des B Gesellschafters ist; und
(iii) alle Kosten in Zusammenhang mit einer solchen Übertragung werden vom B Gesellschafter getragen (und der B
Erwerber, A Gesellschafter und die Gesellschaft werden entsprechend entschädigt)
9.4. Sollte zu einem Zeitpunkt nach Abschluss einer Übertragung oder Veräußerung gemäß Artikel 9.3 des/der B Anteil
(s/e) durch den B Gesellschafter (der "Übertragende B Gesellschafter") an einen Partner des B Gesellschafters, dieser
Partner kein Partner des B Gesellschafters mehr sein, so ist der B Gesellschafter dazu verpflichtet zu veranlassen, dass
der Partnererwerber den/die B Anteil(e) unmittelbar an den B Gesellschafter oder einen Partner des B Gesellschafters
in Übereinstimmung mit Artikel 9.3 überträgt.
9.5. Beim, beziehungsweise vor dem Verkauf oder einer anderen Veräußerung der A Anteile oder Anteile im A Ge-
sellschafter (oder jeglicher Holdinggesellschaft des A Gesellschafters) (eine "A Gesellschafter Veräußerung") an einen
dritten Käufer (welcher, zur Vermeidung jedes Zweifels, kein Partner des A Gesellschafters ist) (ein solcher dritter Käufer,
der "Käufer"), verpflichtet sich der A Gesellschafter zu Folgendem:
(i) den B Gesellschafter umgehend schriftlich zu informieren, dass die A Gesellschafter Veräußerung stattgefunden hat
oder stattfinden wird, einschließlich aller Angaben zur entsprechenden Transaktion und der Erträge, die bei der A Ge-
sellschafter Veräußerung erhalten wurden oder vorgeschlagen sind (abzüglich aller Kosten eines solchen Verkaufs oder
einer solchen Veräußerung einschließlich, ohne Einschränkung, Marketing- und Wertschätzungskosten, Vermittler- und
Expertenhonorare und Steuern) (die "Nettoerträge") (einschließlich aller Angaben des Betrags aller aufgeschobenen oder
bedingten Erträge) (ein "A Gesellschafter Veräußerungsbescheid"); und
(ii) bei Abschluss einer A Gesellschafter Veräußerung, herbeizuführen, dass der Käufer alle B Anteile vom B Gesell-
schafter gegen Zahlung durch den Käufer eines Betrags an den B Gesellschafter, wie jener von den Gesellschaftern
zeitweilig vereinbart werden kann (einschließlich unter dem Gesellschafterabkommen (soweit vorhanden)) (der "Ver-
einbarte Betrag").
(ein "B Anteil Angebot")
9.6. Der Geschäftsführerrat verpflichtet sich Hauptversammlungen der Gesellschafter der Gesellschaft von Zeit zu
Zeit, und sofern notwendig, einzuberufen, damit die Gesellschafter Folgendem zustimmen (sowie zugunsten Folgendem
abstimmen):
(i) der Zahlung des Vereinbarten Betrages durch eine Zwischeneinziehung; und
(ii) dass die die Zahlung des Vereinbarten Betrages so bald wie möglich danach erfolgen soll.
9.7. Sollte nach:
(i) entweder:
a) einem Verkauf an eine dritte Partei (welche, zur Vermeidung jedes Zweifels, keine Partei sein darf, die nicht Partner
des A Gesellschafters ist) von: (i) dem gesamten von der Gesellschaft zeitweilig gehaltenen und von Propco ausgegebenen
Gesellschaftskapital und/oder gleichwertigen Beteiligungen in Propco; oder (ii) der Immobilie; oder
b) dem Gewähren einer Dauervermietung der Immobilie durch Propco an eine dritte Partei, welche es ermöglicht,
Propco's Beteiligungsansprüchen in der Immobilie einen nominalen Wert zuzurechnen,
(in jedem Fall, der "Verkauf"); und
147525
L
U X E M B O U R G
(ii) dem Erhalt, durch die Gesellschaft, von allen Geldern, die ihr gemäß der entsprechenden Verkaufsverträge, in
Zusammenhang mit dem Verkauf, zustehen,
sowie ein Vereinbarter Betrag in Übereinstimmung mit dem Gesellschafterabkommen (sofern vorhanden) fällig ge-
worden ist, verpflichtet sich der Geschäftsführerrat Hauptversammlungen der Gesellschafter der Gesellschaft einzube-
rufen damit die Gesellschafter Folgendem zustimmen (und zugunsten Folgendem abstimmen):
(i) der Zahlung des Vereinbarten Betrags;
(ii) dem Einziehen aller B Anteile (die "Endeinziehung"); und
(iii) dass die die Zahlung des Vereinbarten Betrages so bald wie möglich danach erfolgen soll.
9.8. Bei oder nach einer A Gesellschafter Veräußerung sowie des Versands eines A Gesellschafter Veräußerungsbe-
scheids, soll der A Gesellschafter das Recht haben (das "Drag Along Recht") dem B Gesellschafter abzuverlangen das B
Anteil Angebot vollständig vom Käufer zu akzeptieren, vorausgesetzt, dass der A Gesellschafter die Einhaltung des Käufers
aller Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Vereinbarten Betrag gemäß Artikel 9.5(ii) herbeiführt.
9.9. Das Drag Along Recht kann vom A Gesellschafter anhand einer Mitteilung (der "Drag Along Mitteilung") an den
B Gesellschafter zu diesem Zweck innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Datum eines A Gesellschafter Veräußerungs-
bescheids ausgeübt werden. Vorbehaltlich Artikel 9.8, ist der B Gesellschafter bei Ausübung des Drag Along Rechts dazu
verpflichtet, das B Anteil Angebot zu akzeptieren und die aus dieser Akzeptanz entstandenen Verpflichtungen zu befolgen.
9.10. Nach allen Zahlungen die gegebenenfalls gemäß Artikel 9.5, Artikel 9.7 oder Artikel 9.9, erfolgt sind, soll der B
Gesellschafter kein weiteres Recht auf Zahlung eines Vereinbarten Betrags haben.
Art. 10. Verzugsfälle.
10.1. Der B Gesellschafter befindet sich im Falle eines Verzugs (ein "Verzugsfall") und gilt demzufolge als ("Säumiger
Gesellschafter") wenn:
(i) die gerichtliche Anordnung eines zuständigen Gerichts ausgestellt oder der Beschluss über eine Liquidation oder
Verwaltung des B Gesellschafters gefasst wurde oder die Ernennung eine Verwalters des B Gesellschafters beim zustän-
digen Gericht eingelegt wurde (ausgenommen während einer vom A Gesellschafter schriftlich gebilligten Reorganisation
oder Umstrukturierung);
(ii) eine Maßnahme ergriffen wird (außer während einer vom A Gesellschafter im Voraus schriftlich gebilligten Reor-
ganisation oder Umstrukturierung), um einen Geschäftsführer, Konkursverwalter, gerichtlich bestellten Konkursverwal-
ter, gesetzlichen Verwalter, Kurator oder ähnlichen Beauftragen des B Gesellschafters, in Zusammenhang mit dem B
Gesellschafter oder seiner Aktiva, welche einerseits (i) die vom B Gesellschafter gehaltenen Anteile, sowie (ii) Anteile
oder andere Wertpapiere im B Gesellschafter umfassen, zu ernennen.
(iii) er eine Versammlung der Gläubiger einberuft oder eine Vereinbarung oder Aufschiebung einer Zahlungspflicht mit
seinen, oder Abtretung zugunsten dieser, Gläubigern tätigt oder vorschlägt,
(iv) er das Gesellschafterabkommen (soweit vorhanden) erheblich verletzt und (soweit möglich) diese Verletzung nicht
innerhalb von zwanzig (20) Werktagen nach Erhalt eines Aufforderungsschreibens des A Gesellschafters (in welchem der
A Gesellschafter seine Absicht, die ihm unter dem vorliegenden Artikel entstandenen Rechte auszuüben, mitteilt) beseitigt
(oder Maßnahmen vorstellt um diese in einer vom A Gesellschafter befriedigend empfundenen Art und Weise zu besei-
tigen),
(v) er allgemein Zahlungen einstellt oder nicht in der Lage zur Tilgung seiner fälligen Schulden ist oder jeglichen Handel
mit Gläubigern eingeht in Hinsicht auf Insolvenz um diese zu vermeiden, oder
(vi) jede Maßnahme oder jedes Gerichtsverfahren in einem beliebigen Gerichtsstand, der bezüglich des B Gesellschaf-
ters vergleichbare Auswirkungen hat wie Fälle, die unter Artikel 10.1 (i) bis (einschließlich) 10.1 (v) aufgeführt sind.
10.2. Desweiteren, befindet sich der B Gesellschafter im Verzugsfall wenn:
(i) er nicht mehr unter direkter oder indirekter Kontrolle der Bezeichneten Personen steht;
(ii) jegliche Fälle, die als Verzugsfälle im Dienstleistungsabkommen (soweit vorhanden) aufgeführt sind und auf den
Betreiber zutreffen;
(iii) so bald der Betreiber das Dienstleistungsabkommen (soweit vorhanden) verletzt und somit Propco dazu befugt
das Dienstleistungsabkommen (soweit vorhanden) gemäß dessen Modalitäten zu kundigen oder Propco durch absichtli-
ches schuldhaftes Verhalten oder grobe Fahrlässigkeit des Betreibers dazu befugt wird das Dienstleistungsabkommen
(soweit vorhanden) zu kündigen;
(iv) der Betreiber nicht mehr unter direkter oder indirekter Kontrolle der Bezeichneten Personen steht.
10.3. Auswirkungen eines Verzugsfalls.
(i) Der B Gesellschafter hat den A Gesellschafter so schnell wie möglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, sollte er
Säumiger Gesellschafter werden oder Kenntnis vom Eintreten eines Verzugsfalls haben.
(ii) Beim Eintreten eines Verzugsfalls kann der A Gesellschafter den Säumigen Gesellschafter durch eine unwiderrufliche
schriftliche Benachrichtigung (eine "Säumnisbenachrichtigung"), die den Kauf der B Anteile durch den A Gesellschafter
zum Nominalwert zur Folge hat, abmahnen.
147526
L
U X E M B O U R G
(iii) Nach Eintreten eines Verzugsfalls wird kein weiterer Betrag in Zusammenhang mit dem Vereinbarten Betrag fällig
oder zahlbar.
10.4. Der Abschluss des Verkaufs und Kaufs der B Anteile gemäß Artikel 10.3(ii) soll:
(i) innerhalb von dreißig (30) Werktagen folglich der Säumnisbenachrichtigung, an von den (angemessen handelnden)
Geschäftsführern der Gesellschaft festgelegten Zeit, Datum und Ort stattfinden;
(ii) dadurch bedingt sein, dass die B Anteile mit uneingeschränktem Eigentumsrecht, lastenfrei und mit allen ange-
schlossenen Rechten, mit Wirkung zum entsprechenden Übertragungsdatum, verkauft werden; und (iii) den B Gesell-
schafter dazu verpflichten, das Anteilsregister für die B Anteile zu unterzeichnen, wohingegen der A Gesellschafter dem
B Gesellschafter den nominalen Wert der B Anteile, sowie jegliche bis zum Eintreten des Verzugsfalls angefallenen Ver-
einbarten Beträge auszahlt.
10.5. Sollte ein Gesellschafter den Verkauf oder Kauf eines B Anteils gemäß dieses Artikel 10 versäumen, tritt Artikel
13 in Kraft.
Art. 11. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Art. 12. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-
genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
Art. 13. Vollmacht.
13.1. Als Sicherheit für das Nachkommen der ihm aus Artikeln 9.7 bis 9.10 und Artikel 10 entstandenen Verpflichtungen,
soll gelten, dass jeder Gesellschafter der Gesellschaft, welche durch jeden Geschäftsführer vertreten wird, Vollmacht für
folgende Zwecke erteilt (eine solche Vollmacht kann nur erlöschen wenn der Gesellschafter keine mehr Anteile hält):
(i) Die Bewilligung, Unterschrift (in Form einer notariellen Urkunde oder jeglicher anderer Form) und Verkündung,
jeglicher Dokumente die der Bevollmächtigte seinem absolutem und uneingeschränkten Ermessen für nötig hält um eine
Übertragung von Anteilen gemäß Artikel 9.9 oder, gegebenenfalls, Artikel 10 (oder im Falle des B Gesellschafters, einer
Zwischeneinziehung oder Endeinziehung), und
(ii) die ordnungsgemäße Einschreibung des jeweiligen Erwerbers in das Anteilsregister als Inhaber der jeweiligen An-
teile.
C. Geschäftsführung
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung, von einer ausschließlich vom A Gesellschafter bereitgestell-
ten Kandidatenliste, ernannt, welcher auch die Dauer ihres Mandats bestimmen kann. Die Geschäftsführer können
jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund («cause légitime») hierzu bestehen muss, ausschließlich vom A Gesellschafter
entlassen werden.
Der Geschäftsführerrat kann nur dann rechtsgültig beraten und handeln wenn mindestens die Mehrheit der Ge-
schäftsführer anwesend oder vertreten ist und alle Beschlüsse werden rechtsgültig von der Mehrheit der anwesenden
oder vertretenen Geschäftsführern getroffen.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 15. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.
Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort
einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Ge-
schäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden
ernennen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
147527
L
U X E M B O U R G
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 16. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.
Art. 17. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst.
Art. 18. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.
Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied sowie deren Erben, Nach-
lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die nach vernünftigem Ermessen in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit,
einer Klage oder einem Verfahren, bei dem der Geschäftsführer oder das Geschäftsführerratsmitglied auf Grund seiner
Funktion als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäftsführer oder Geschäftsführerratsmitglied der Gesellschaft oder, auf
Anfrage der Gesellschaft, jeder anderen Körperschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist und
von der er nicht berechtigt ist, Entschädigung zu erhalten, Partei geworden ist, entstanden sind. Dies gilt für Angelegen-
heiten bei denen letztendlich eine schwere Pflichtverletzung (faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute
intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten
gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber
informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf
Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte, zu der die Person berechtigt ist, ausschließen.
Art. 19. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschließen, Zwischendividenden auszu-
schütten, und zwar auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsfüh-
rerrat vorbereitet wird und aufzeigt, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag
nicht die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen
Gewinne und der zur Verteilung zur Verfügung stehenden Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verluste und
der Beträge, die einer gesetzlich oder durch die Satzung vorgeschriebenen Kapitalrücklage zugeführt werden.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 20. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 21. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 22. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 23. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 24. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Ge-
schäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt
sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
147528
L
U X E M B O U R G
Art. 25. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Zwischendividenden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 26. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung, oder
gegebenenfalls der alleinige Gesellschafter, legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Insofern nicht
anderes vorgesehen ist, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 27. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweist die Erschienene auf die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung. Die englische Fassung dieser Satzung soll maßgeblich
sein.
G. Definitionen
Art. 28.
"Gesetz von 1915" heißt das Luxemburger Gesetz bezüglich Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der jeweils
gültigen Fassung;
"A Gesellschafter Veräußerung" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.5 angegeben ist;
"A Gesellschafter Veräußerungbescheid" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.5 (ii) angegeben ist;
"A Gesellschafter" heißt der zeitweilige Halter der A Anteile;
"A Anteile" heißen die zeitweilig ausgegebenen Anteile der Anteilsklasse A im Gesellschaftskapital der Gesellschaft mit
einem Nominalwert von jeweils einem penny (GBP 0,01);
"A Erwerber" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.2 angegeben ist;
"Partner" heißt:
(i) jedes direkte oder indirekte Tochterunternehmen oder direkte oder indirekte Mutterunternehmen dieser Person
und jedes Tochterunternehmen einer jeden solchen Mutterunternehmens, in jedem Fall von Zeit zu Zeit, unter Bedingung,
dass im Falle eines Partners des B Gesellschafters, ein solches Mutterunternehmen oder Tochterunternehmen ebenfalls
unter gemeinsamer direkter oder indirekter Kontrolle der Bezeichneten Personen steht; und
(ii) in Zusammenhang mit ausschließlich dem A Gesellschafter, heißt ebenfalls:
(a) alle Unternehmen (einschließlich, ohne Beschränkung, aller offenen Handelsgesellschaften oder Investmentgesell-
schaften) bei dem der A Gesellschafter oder jedes, auf in (i) Bezug genommene, Unternehmen einzeln oder gemeinsam
50% oder mehr der wirtschaftlichen Beteiligung in einem solchen Unternehmen halten; und/oder
(b) alle Unternehmen (einschließlich, ohne Beschränkung, aller offenen Handelsgesellschaften oder Investmentgesell-
schaften) bei dem der A Gesellschafter oder jedes, auf in (i) Bezug genommene, Unternehmen einzeln oder gemeinsam
mit jeder anderen auf in (ii) a Bezug genommenen Gesellschaft ein solches Unternehmen kontrolliert.
"Partnererwerber " hat die Bedeutung, die in Artikel 9.3 angegeben ist;
"Vereinbarter Betrag" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.5 angegeben ist;
"B Anteil Angebot" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.5 angegeben ist;
"B Anteile" heißen die zeitweilig ausgegebenen Anteile der Anteilsklasse B im Gesellschaftskapital der Gesellschaft mit
einem Nominalwert von jeweils einem penny (GBP 0,01);
"B Gesellschafer" heißt der zeitweilige Halter der B Anteile;
"B Erwerber" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.3 angegeben ist;
"Werktag" heißt jeder Tag, der kein Samstag, Sonntag oder ein Tag, an dem Banken in London oder Luxemburg
schliessen können oder müssen, ist;
"Kontrolle" heißt die direkte oder indirekte Befugnis über die Geschäftsführung und Politik einer Person oder Gesell-
schaft zu leiten, entweder durch den Besitz von Titeln mit Wahlrecht, vertraglich begründet, oder anderwärtig (ein-
schließlich, zur Vermeidung jedes Zweifels, im Falle ausschließlich des A Gesellschafters, durch Fond management oder
Beratungsdienstleistungen); darüber hinaus sollen "kontrolliert" und "kontrolliert von" enstprechend interpretiert wer-
den;
"Säumnisbenachrichtigung" hat die Bedeutung, die in Artikel 10.3 (ii) angegeben ist;
"Säumiger Gesellschafter" hat die Bedeutung, die in Artikel 10.1 angegeben ist;
"Drag Along Mitteilung" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.9 angegeben ist;
"Drag Along Recht" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.8 angegeben ist;
147529
L
U X E M B O U R G
"Belastung" heißt jede(r/s) Forderung, Option, Hypothek, Pfand, dingliches Sicherungsrecht, Kosten, Übertragung,
Verpfändung, Kaufrecht, Vorzugsrecht, Vorkaufsrecht, Titeleinbehalt, oder jedes dritte Recht oder Sicherungsrecht, oder
anderes Abkommen oder andere Vereinbarung welche ähnliche Auswirkungen wie die Gewährung einer Sicherheit dar-
stellt;
"Verzugsfall" hat die Bedeutung, die in Artikel 10.1 angegeben ist;
"Endeinziehung" heißt die Einziehung aller B Anteile gemäß Artikel 9.7;
"Zwischeneinziehung" heißt die Einziehung eines B Anteils die keine Endeinziehung ist;
"Nettoerträge" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.5 angegeben ist;
"Betreiber" heißt Canmoor Asset Management Limited oder jeder Betreiberpartner von Canmoor Asset Management
Limited;
"Betreiberpartner" heißt jede Person, die eine solche Person direkt oder indirekt kontrolliert oder von ihr kontrolliert
wird oder die unter gemeinsamer Kontrolle mit einer solchen Person steht (und im Falle von Prospect First Limited und
dessen Gesellschaftern, jede andere Person, die von CarVal Investors LLC oder deren Partnern geleitet oder beraten
wird);
"Person" heißt jede(r/s) Individuum, Gesellschaft, Unternehmen, offene Handelsgesellschaft, Gemeinschaftsunterneh-
men, Verband,
Aktiengesellschaft, Investmentgesellschaft, juristische Person, uneingetragene Organisation, Regierung oder jede Be-
hörde und deren politische Unterabteilung;
"Propco" hat die Bedeutung, die im Gesellschafterabkommen (sofern vorhanden) angegeben ist;
"Immobilie" hat die Bedeutung, die im Gesellschafterabkommen (sofern vorhanden) angegeben ist;
"Erwerber" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.5 angegeben ist;
"Anteilsregister" heißt das Register der Gesellschafter;
"Verkauf" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.7 angegeben ist;
"Dienstleistungsabkommen" heißt jedes Dienstleistungsabkommen (sofern vorhanden) am oder um das gleiche Datum
wie das Gesellschafterabkommen (sofern vorhanden) zwischen Propco und dem Betreiber abgeschlossen, in der jeweils
gültigen Fassung;
"Gesellschafter" heißt, abhängig vom Zusammenhang, entweder der A Gesellschafter oder der B Gesellschafter und
"Gesellschafter" heißt beide;
"Gesellschafterabkommen" heißt jedes Gesellschafterabkommen (sofern vorhanden), welches zwischen den Gesell-
schaftern in Zusammenhang mit der Gesellschaft abgeschlossen ist, in der jeweils gültigen Fassung;
"Anteile" heißt, abhängig vom Zusammenhang, einzelne oder alle A Anteile und/oder B Anteile;
"Bezeichnete Individuen" hat die Bedeutung, die im Gesellschafterabkommen (sofern vorhanden) angegeben ist;
"Übertragender B Gesellschafter" hat die Bedeutung, die in Artikel 9.4 angegeben ist."
Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde
erwähnt wird.
Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der
erschienenen Partei, dass die vorliegende Urkunde auf Deutsch abgefasst ist nebst einer englischen Fassung; auf Anfrage
der erschienenen Partei und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und deutschen Fassung, soll die englische
Fassung maßgeblich sein.
Das Dokument wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen, der besagte Bevollmächtigte der
erschienenen Partei unterzeichnet zusammen mit dem Notar die vorliegende Originalurkunde.
Gezeichnet: P. METZSCHKE, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 16 novembre 2012. Relation: ECH/2012/1914. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Echternach, den 22. November 2012.
Référence de publication: 2012152249/758.
(120201443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
Kona Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 88.922.
L'an deux mille douze, le sept novembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
147530
L
U X E M B O U R G
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, société de gestion de patri-
moine familial, en abrégé «SPF» "KONA HOLDING S.A." (numéro d'identité 2002 40 03 346), avec siège social à L-8041
Strassen, 80, rue des Romains, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 88.922, constituée sous la forme d'une société
anonyme holding suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 août 2002, publié au Mémorial C numéro
1540 du 25 octobre 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
5 mai 2008, publié au Mémorial C, numéro 1438 du 11 juin 2008, ledit acte contenant notamment adoption par la société
du statut de société de gestion de patrimoine familial, en abrégé «SPF».
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-
gique)
Le Président désigne comme secrétaire Madame Miranda JANIN, employée privée, demeurant à Belvaux.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que l'ordre du jour est conçu comme suit:
1) Acceptation des démissions avec effet au 31 octobre 2012 des administrateurs et du commissaire aux comptes
actuellement en fonction et décharge pleine et entière.
2) Mise en liquidation de la société.
3) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
II. - Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence,
laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau,
restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
III. - Que la société a un capital social d'un million d'euros (€ 1.000.000.-), représenté par mille (1.000) actions sans
désignation de valeur nominale.
IV. - Qu'il résulte de ladite liste de présence que les mille (1.000) actions de la société sont présentes ou représentées
et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points
portés à l'ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter les démissions des sociétés «A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité
limitée» et «TAXIOMA s.à r.l.» et de Madame Ingrid HOOLANTS comme administrateurs et de Monsieur Paul JANSSENS
comme commissaire aux comptes de la société, avec effet au 31 octobre 2012 et de leur donner décharge pleine et
entière pour l'exercice de leurs mandats.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Madame Joan KLEBAN-RAUPAH, retraitée, née à Los Angeles
(Etats-Unis d'Amérique) le 26 décembre 1951, demeurant à 55069 Oak Hill, La Quinta, CA92253, Californie (USA).
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux
articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.
Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires,
pour des opérations spéciales et déterminées.
Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer Monsieur Alfred RAUPAH, retraité, né à Gladbeck (Allemagne) le 11 décembre 1924,
demeurant à 55069 Oak Hill, La Quinta, CA92253, Californie (USA) comme commissaire-vérificateur.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximative¬ment à mille cent euros (€ 1.100.-), sont à charge
de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
147531
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signé: J.M. WEBER, JANIN, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 12 novembre 2012. Relation: CAP/2012/4312. Reçu douze euros (12,-).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bascharage, le 20 novembre 2012.
A. Weber.
Référence de publication: 2012153466/69.
(120201809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Bluestone Capital Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 173.028.
STATUTES
In the year two thousand and twelve,
on the twenty-second day of November.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
"LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.", in short "INTERCONSULT", a "société anonyme' gover-
ned by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
represented by:
a) Mr François MANTI, employee, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Mr Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, lawyer, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371
Luxembourg,
both acting as authorized signatories of said company with joined signing power.
Such appearing party, acting in his here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a public limited company (société anonyme) which he declares organize and the articles of incorporation
of which shall be as follows:
I. Name, Duration, Object, Registered Office
Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of "Bluestone Capital Partners S.A." (hereinafter
the "Company").
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The Company's main purpose is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprises in any form whatsoever, as well as to the administration, management, control and
development of those participations.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have
occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
147532
L
U X E M B O U R G
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a
Luxembourg company.
II. Corporate Capital, Shares
Art. 5. The corporate share capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) consisting of three
hundred and ten (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) per share.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these articles of incorporation. The Company may, to the extent and under terms
permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered
shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed
by two directors or, if the Company as only one director, by this director.
The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided
for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.
The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signature may be
affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A
certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
must be filed in accordance with §§1 and two of the Law.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Company.
III. General meetings of Shareholders
Decision of the sole shareholder
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.
The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders
representing at least one tenth of the Company's share capital.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company,
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the thirtieth day of the month of
June of each year at 11.00 a.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following
business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.
Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.
Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board
(bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.
All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
147533
L
U X E M B O U R G
IV. Board of Directors
Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not
be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholders in the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,
remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
directors.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of visioconference or by any other similar
means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical cha-
racteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterrup-
tedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting
held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at
a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,
the chairman of the board of directors shall have a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one
director only, the sole director shall sign these documents.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company
in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
147534
L
U X E M B O U R G
Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed
of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
V. Supervision of the Company
Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.
VI. Accounting year, Balance
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on first day of January of each year and shall terminate on
thirty-first day of December of the same year.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by
Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.
VII. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
VIII. Amendment of the articles of incorporation
Art. 18. These articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.
IX. Final clause - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31
December 2012.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in June 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
All three hundred and ten (310) shares have been subscribed by "LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING
S.A.", in short "INTERCONSULT", above-mentioned, in its capacity as sole shareholder.
All the shares have been entirely paid-in cash so that the amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the Law and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately thousand euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions.
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed directors:
a) Mr Alexis KAMAROWSKY, Company Director, born in Bad Rothenfelde (Germany), on 10 April 1947, residing
professionally at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Mr Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Lawyer, born in La Spezia (Italy), on 12 September 1964, residing
professionally at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
147535
L
U X E M B O U R G
c) Mr Jean-Marc DEBATY, Company Director, born in Rocourt (Belgium), on 11 March 1966, with professional address
at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
3. The following company is appointed statutory auditor:
«LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», in short «INTERCONSULT», a société anonyme gover-
ned by the laws of Luxembourg, established and having its registered office at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B number 40312).
4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve
the accounts of the accounting year 2017.
5. The address of the Company is set at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze,
le vingt-deux novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
«LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme
régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
ici représentée par:
a) Monsieur François MANTI, employé privé, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg;
agissant les deux en leurs qualités de signataires autorisés de la Société avec pouvoir de signature conjointe.
Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser
acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
I. Nom, Durée, Objet, Siège Social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de «Bluestone Capital Partners S.A.» (ci-après la «Société»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. L'objet principal de la Société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
147536
L
U X E M B O U R G
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) consistant en trois cent dix (310)
actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des Actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trentième jour du mois de juin de chaque année
à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'Administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
147537
L
U X E M B O U R G
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
147538
L
U X E M B O U R G
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
V. Surveillance de la Société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en juin 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par la société «LUXEMBOURG INTERNATIONAL CON-
SULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», pré-qualifiée, en sa qualité d'actionnaire unique.
Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE
EUROS (31.000,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare
expressément qu'elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille euros.
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) Monsieur Alexis KAMAROWSKY, Directeur de Sociétés, né à Bad Rothenfelde (Allemagne), le 10 avril 1947,
demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Juriste, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964 de-
meurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
c) Monsieur Jean-Marc DEBATY, Administrateur de Sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 11 mars 1966, avec adresse
professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
147539
L
U X E M B O U R G
3. La société suivante a été nommée commissaire aux comptes:
«LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme
régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 40312).
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer
sur les comptes de l'année 2017.
5. L'adresse de la Société est établie au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
DONT ACTE, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donné aux personnes comparantes connues du notaire instrumentant par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, celles-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. MANTI, F. CANNIZZARO di BELMONTINO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15590. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012155671/437.
(120205805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2012.
Entrust-Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 172.870.
STATUTS
L'an deux mille douze, le huit novembre.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) Monsieur Geert Gaston Celina JANSSEN, IT manager, demeurant à B-2570 Duffel, Mechelsebaan 262,
2) Monsieur Wim BORREMANS, IT manager, demeurant à B-3071 Kortenberg, Haaggatstraat, 75,
3) Monsieur Yves CROONENBORGHS, IT manager, demeurant à B-2260 Westerlo, de Merodedreef, 155,
4) Monsieur Matthieu van der SCHUEREN DEVÈZE, business consultant, demeurant à B-1180 Ukkel, Boetendaellaan,
89.
Messieurs Geert Gaston Celina JANSSEN, Wim BORREMANS, Yves CROONENBORGHS et Matthieu van der
SCHUEREN DEVEZE, sont ici représentés par Monsieur Fernand SASSEL, expert comptable, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg, sur base de quatre procurations, lesquelles, après avoir été signées par le mandataire prénommé
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité
limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois
y relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.
147540
L
U X E M B O U R G
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «ENTRUST-INVEST Sàrl».
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être déplacé dans la même commune par
simple décision de la gérance de la société.
Il peut être transféré en dehors de cette commune en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu
d'une décision de l'assemblée générale des associés.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixe a quatorze mille euros (14.000,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent quarante euros (140,- EUR) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de son objet social.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par celui-ci. Les dispositions des articles 200-1 et 200-2 de la loi sur les sociétés commerciales sont
alors applicables.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Du bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve
légal jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée
générale des associés.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Geert Gaston Celina JANSSEN, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
147541
L
U X E M B O U R G
2) Wim Borremans, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
3) Yves Croonenborghs, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
4) Matthieu van der Schueren Devèze, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de
quatorze mille euros (14.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2013.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille euros (1.000.- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des vois les résolutions suivantes:
1. - Le siège social de la société est établi à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
2. - Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Geert Gaston Celina JANSSEN, prénommé,
2) Monsieur Wim BORREMANS, prénommé,
3) Monsieur Yves CROONENBORGHS, prénommé,
4) Monsieur Matthieu van der SCHUEREN DEVÈZE, prénommé.
Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante, connue du notaire
par nom, prénom, état et demeure, a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. SASSEL, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 14 novembre 2012. Relation: REM/2012/1433. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): L. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Remich, le 21 novembre 2012.
P. SERRES.
Référence de publication: 2012153463/118.
(120201749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
RIL II Whitelands S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Capital social: GBP 8.995,98.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 131.209.
In the year two thousand and twelve, on the twenty ninth day of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Residential Initiatives II S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), incorporated
under Luxembourg law, with registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register section B, under number 130.142;
here represented by Flora Gibert, employee, with professional address at 15 Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, by
virtue of a power of attorney established on 23 October 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")
existing in Luxembourg under the name of "RIL II Whitelands S.à r.l.", having its registered office at 2 Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under num-
147542
L
U X E M B O U R G
ber 131.209, incorporated by a deed of the undersigned notary of 21 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2227 of 16 October 2007, and which bylaws have been last amended by a deed of
the undersigned notary of 20 December 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
413 of 18 February 2008.
II. The Company's share capital is fixed at eight thousand nine hundred ninety-five Pounds Sterling ninety-eight pence
(GBP 8,995.98.-) represented by eight hundred ninety-nine thousand five hundred and ninety-eight (899,598) shares with
a nominal value of one pence (EUR 0.01) each.
III. The sole shareholder resolves to dissolve the Company anticipatively and to put it into liquidation.
IV. The sole shareholder resolves to appoint Mr. Christophe Mathieu, Belgian Citizen, born on 18 January 1978 in
Verviers (Belgium), having his professional address at 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as liquidator of
the Company.
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148 bis of the Luxembourg companies
law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required
by law.
All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operations being a matter of liquidation
purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the sole
shareholder, in kind or in cash.
The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all
either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative
payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions,
and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.
V. The sole shareholder resolves to give full discharge to the members of the Board of Managers of the Company for
the accomplishment of their mandate unless the liquidation reveals faults in the execution of their duty.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the present sole shareholder's meeting are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Residential Initiatives II S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée et existant sous
les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, enregistrée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.142;
ici représentée par Flora Gibert, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Lu-
xembourg, en vertu d’une procuration donnée le 23 Octobre 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
"RIL II Whitelands S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 131.209, con-
stituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 21 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2227 du 16 octobre 2007, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du
147543
L
U X E M B O U R G
notaire soussigné reçu en date du 20décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
413 du 18 février 2008.
II. Le capital social est fixé à huit mille neuf cent quatre-vingt quinze Livres Sterling quatre-vingt dix-huit pence (GBP
8,995.98) représenté par huit cent quatre-vingt dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt dix-huit (899,598) parts sociales d'une
valeur nominale de un pence (GBP 0.01) chacune.
III. L’associé unique décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.
IV. L’associé unique décide de nommer M. Christophe Mathieu, de nationalité belge, né le 18 janvier 1978 à Verviers
(Belgique), ayant son adresse professionnelle au 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme liquidateur de
la Société.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales.
Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle
est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou
en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles
qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques
et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur
des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous
rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre
toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de
recours ou à des prescriptions acquises.
V. L’associé unique décide de donner décharge aux membres du Conseil de Gérance de la Société, sauf si la liquidation
fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant représenté
par son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, il a signé avec nous notaire, le présent acte.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2012. Relation: LAC/2012/51279. Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, 19 novembre 2012.
Référence de publication: 2012153235/119.
(120201772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
B-Iond S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 88.763.
<i>Extrait du procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale tenue au siège social le 16 mai 2012i>
L'Assemblée décide d'acter la démission de Messieurs Henri MIGNON et Oscar REICHLING ainsi que Madame
Myriam MIGNON de leur poste d'administrateur avec effet immédiat.
Elle décide de nommer Monsieur Michel HAAG, domicilié Duerfstrooss 96 à L-9647 Doncols, au poste d'administra-
teur pour une durée de 6 ans.
En outre, elle décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Pascal REICHLING et de Madame Ma-
deleine MEIS, domiciliée Duerfstrooss 96 à L-9647 Doncols pour une durée de 6 ans.
147544
L
U X E M B O U R G
Le Conseil d'Administration, à l'instant réuni, décide de remplacer Madame Madeleine MEIS au poste d'administrateur-
délégué par Monsieur Michel HAAG. Et il décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué et de Président du
Conseil d'Administration de Monsieur Pascal REICHLING pour 6 ans.
En outre, il décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Henri MIGNON.
L'Assemblée décide également de remplacer au poste de Commissaire aux comptes, et ce, à partir de l'exercice clôturé
au 31 décembre 2012, la société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA par la Fiduciaire Fernand SASSEL & Cie SA, re-
présentée par son administrateur-délégué Monsieur Fernand SASSEL, ayant son siège social Route d'Esch 7 à L-1470
Luxembourg et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B34.239.
Les mandats des administrateurs et du Commissaire prendront fin lors de l'Assemblée Générale de 2018.
A compter de cette Assemblée, le Conseil d'Administration sera composé comme suit:
- Pascal REICHLING, Président du Conseil d'Administration et administrateur-délégué
- Michel HAAG, administrateur-délégué
- Madeleine MEIS, administrateur
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012156824/28.
(120207555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Parana Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 111.203.
In the year two thousand and twelve, on the twelfth of November.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, (Grand-Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED
The company Bellford Properties Limited, having its registered office at 57/63, Line Wall Road, Gibraltar, registered
with the "Registrar of Companies Gibraltar" under the number 94015,
hereby represented by:
- Mrs. Catherine Peuteman, private employee, residing professionally at 19 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
and
- Mr. Patrice Yande, private employee, residing professionally at 19 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on October 29, 2012,
which proxy signed "ne varietur" by the proxyholders of the entity appearing and the undersigned notary, shall remain
annexed to this document to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to act:
- That the private limited liability company PARANA CORPORATION S.à r.l., having its registered office at L-2453
Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number
B 111.203 (NIN 2005 2428 697) has been incorporated by deed of the notary Henri HELLINCKX, then residing in Mersch,
on the 3rd of October 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 186 of January
26, 2006.
That the corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (€ 12.500.-), divided into one hundred twenty-
five (125) shares of one hundred Euro (€ 100.-) each, all attributed to the company Bellford Properties Limited.
The appearing party, represented as said before, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder, being aware of the financial situation of the company, decides to dissolve the company PARANA
CORPORATION S.à r.l. and to put it into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint the company PIKELANE CORPORATE LIMITED, a British Virgin Islands
company, having its registered office at c/o Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, P.O. Box 3175, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands, registered at the "Registrar of Corporate Affairs" under the number 1515831, as
liquidator of the company.
The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by
article 144 and following of the law of August 10, 1915, concerning commercial companies.
147545
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, represented as said before, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request
of the same appearing party, represented as said before, and in case of divergence between the English and the French
text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, acting as said before, known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with us, the notary, the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douze novembre.
Par-devant Maître Henri BECK notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU
La société Bellford Properties Limited, ayant son siège à 57/63, Line Wall Road, Gibraltar, inscrite au "Registrar of
Companies Gibraltar" sous le numéro 94015,
ici représentée par:
- Madame Catherine Peuteman, employée privée, résidant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, et
- Monsieur Patrice Yande, employé privé, résidant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, délivrée en date du 29 octobre 2012,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les mandataires de la comparante et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée PARANA CORPORATION S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,
19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 111.203 (NIN
2005 2428 697) a été constituée suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, alors de résidence à Mersch, en
date du 3 octobre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 186 du 26 janvier 2006.
- Que le capital social de la société s'élève au montant de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par
cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent Euros (€ 100.-) chacune, toutes attribuées à la société Bellford Properties
Limited.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique, déclarant avoir connaissance de la situation financière de la société, décide de dissoudre la société
PARANA CORPORATION S.à r.l. et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide de nommer la société PIKELANE CORPORATE LIMITED, une société constituée sous les
lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social aux bureaux d'Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI)
Limited, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au «Registrar of Corporate Affairs» sous le
numéro 1515831, comme liquidateur de la société.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,
représentée comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la
partie comparante, représentée comme dit ci-avant, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version
anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire par
noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. PEUTEMAN, P. YANDE, Henri BECK.
147546
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Echternach, le 16 novembre 2012. Relation: ECH/2012/1899. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 22 novembre 2012.
Référence de publication: 2012153197/94.
(120201507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Pradera Central Istanbul S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 121.204.
In the year two thousand and twelve, on the seventh day of November
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
Pradera Central Holdco S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 33, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (RCS Luxembourg B
111 721),
represented by Mrs Gwendoline LALOUX, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney signed on 30 October 2012.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of the registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of Pradera Central Istanbul S.à r.l. (the “Company”), société à responsabilité
limitée with its registered office at 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incor-
porated in Luxembourg under the name of PRADERA CENTRAL MILITARI, S.à r.I. by a deed of the undersigned notary
on 19 October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2364 on 19 December
2006, last time amended by a deed of the undersigned notary on 21 December 2007, published in the Mémorial C n° 472
of 23 February 2008, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under n° B 121.204;
- that he has been fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the subscribed capital by an amount of 100.- EUR to bring it from its present amount of 12,500.- EUR
to 12,600.- EUR by the issuance of 1 new share with a par value of 100.- EUR.
2. Contribution of the said increase of capital in kind of a part of a certain, liquid and immediately payable claim held
by the sole shareholder against Pradera Central Istanbul S.à r.l. of an amount of 702.000. - EUR, the surplus between the
nominal value of the share issued and the total value of the contribution being transferred to a share premium account
of the corporation.
3. To amend accordingly article 6 of the articles of incorporation of the Company.
4. Miscellaneous.
- that he has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder, represented as stated here above, resolves to increase the Company's subscribed capital by an
amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro
(EUR 12.500.-) to twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-) divided into one hundred and twenty-six (126) shares,
each share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), by creation of one (1) new share.
<i>Subscription - Paymenti>
The sole shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe to the one (1) new share and to have
it fully paid up by contribution in kind of a part of a certain, liquid and immediately payable claim held by it against the
company Pradera Central Istanbul S.à r.l. of an amount of seven hundred and two thousand euro (702,000.- EUR).
The existence and the value of the said claim has been certified to the undersigned notary.
The surplus between the nominal value of the share issued and the total value of the contribution in kind, being the
amount of seven hundred and one thousand and nine hundred euro (701,900. - EUR) shall be transferred to a share
premium account of the corporation.
147547
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder, represented as stated here above, decides to amend article 6 of the articles of incorporation,
which will henceforth have the following wording:
“ Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) represented by one hundred
twenty-six (126) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share.”
There being no further item on the agenda, the meeting is closed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately two thousand two hundred euro (2,200.- EUR).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mil douze, le sept novembre.
Par devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Pradera Central Holdco S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg (RCS Luxembourg B 111 721),
représentée aux fins des présentes par Madame Gwendoline LALOUX, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 30 octobre 2012.
Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- qu’elle est la seule et unique associée de Pradera Central Istanbul S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son
siège social au 33, avenue de la liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée
sous la dénomination de PRADERA CENTRAL MILITARI, S.à r.I., suivant acte du notaire soussigné du 19 octobre 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2364 le 19 décembre 2006, modifié la dernière fois suivant
acte du notaire soussigné du 21 décembre 2007, publié au Mémorial C, le 23 février 2008, N°472, société inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro B-121.204.
- qu’elle reconnaît être parfaitement informée des décisions à intervenir sur la base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du Jouri>
1. Augmenter le capital social d’un montant de 100,- EUR pour le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR à
12.600,- EUR par l’émission de 1 nouvelle part sociale d’une valeur nominale de 100,- EUR.
2. Apport en nature d’une partie d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par le seul associé à l’encontre de
Pradera Central Istanbul S.à r.l. d’un montant de 702.000,- EUR, la différence entre la valeur nominale de la part sociale
émise et la valeur totale de l’apport étant transférée à un compte prime d’émission de la société.
3. Modification concordante de l’article 6 des statuts.
4. Divers.
- qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de cent euros (100,- EUR) de manière
à porter le capital de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), à douze mille six cents euros
(12.600,- EUR) divisé en cent vingt six (126) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR),
le tout par émission d’une (1) part sociale nouvelle.
<i>Souscription - Paiementi>
L'associé unique, représenté comme dit est, déclare souscrire à la nouvelle part sociale et la libérer moyennant apport
en nature d’une partie d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par lui-même contre Pradera Central Istanbul
S.à r.l. d’un montant de sept cent deux mille euros (702.000.- EUR). L’existence et la valeur de la dite créance a été
certifiée au notaire instrumentant. La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la
participation apportée, étant de sept cent un mille neuf cents euros (701.900 EUR) sera transférée à un compte de prime
d’émission de la société.
147548
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique, représenté comme dite est, décide de modifier en conséquence l’article 6 de statuts de la société
pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Capital social. Le capital est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) représenté par cent vingt-six
(126) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent
acte sont évalués à approximativement deux mille deux cents euros (2.200,- EUR).
Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant précité,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce
dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. LALOUX, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52864. Reçu soixante-quinze (EUR
75,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Référence de publication: 2012156047/122.
(120205989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2012.
Petit Bois Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 154.748.
L'an deux mille douze, le quinzième jour de novembre.
Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ESTATES S.A., ayant son siège social au 18, rue Robert Stùmper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.770,
en sa qualité d'actionnaire unique de PETIT BOIS PROPERTY S.A., une société anonyme constituée et régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stùmper, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 154.748, constituée suivant acte de Maître
Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, du 28 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 23 septembre 2010, n° 1985 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (la
«Société»),
ici représentée par Monsieur Patrick de Froidmont, juriste, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stùmper,
L 2557 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 novembre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Actionnaire Unique a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Agendai>
1 Modifier l'année sociale de la Société;
2 Sous réserve de la modification ci-dessus, (i) clôturer l'année sociale en cours au 30 novembre 2012, (ii) décider
qu'une année sociale intermédiaire commencera le 1
er
décembre 2012 et se terminera le 31 décembre 2012, et qu'en
conséquence (iii) une nouvelle année sociale commencera le 1
er
janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2013; et
3 Modifier en conséquence l'article 18 des statuts de la Société pour changer l'année sociale;
4 Divers.
L'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
147549
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'année sociale de la Société afin qu'elle débute le premier jour de janvier
et se termine le dernier jour de décembre de chaque année.
<i>Seconde résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé (i) de clôturer l'année sociale en cours au 30 novembre 2012, (ii) qu'une année sociale
intérimaire commencera le 1
er
décembre 2012 et se terminera le 31 décembre 2012, et qu'en conséquence (iii) une
nouvelle année sociale commencera le 1
er
janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2013.
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de modifier en conséquence l'article 18 des statuts de la Société, qui sera dorénavant
rédigé comme suit:
« Art. 18. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.»
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés
approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue française, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie
comparante, le présent acte a été rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise; à la demande de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte français primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg par le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
soussigné par ses noms, prénoms usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Follows the english version of the preceding text:
In the year two thousand twelve, on the fifteenth day of November.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
ESTATES S.A., with registered office at 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg
register of commerce and companies under number B 106.770,
in its capacity as Sole Shareholder of PETIT BOIS PROPERTY S.A., a société anonyme incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper,
registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154.748, incorporated pursuant
to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated July 28, 2010, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations of September 23, 2010, n° 1985, and whose articles of incorporation have not yet
been amended (the "Company"),
duly represented by Mr Patrick de Froidmont, juriste, with professional address at 18, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, by virtue of a proxy dated November 15, 2012.
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agendai>
1 To change the financial year of the Company;
2 Subject to the above change, (i) to end the current financial year of the Company on 30 November 2012, (ii) to
resolve that an interim financial year will begin on 1
st
December 2012 and end on 31 December 2012, and that accordingly
(iii) a new financial year will begin on 1
st
January 2013 and end on 31 December 2013;
3 To amend subsequently the article 18 of the articles of association of the Company in order to change the fiscal
year;
4 Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the financial year of the Company so that it shall forthwith begin on the first
day of January and ends on the last day of December of each year.
147550
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved (i) to end the current financial year of the Company on 30 November 2012, (ii) that
an interim financial year will begin on 1
st
December 2012 and end on 31 December 2012, and that accordingly (iii) a new
financial year will begin on 1
st
January 2012 and end on 31 December 2012.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 18 of the articles of association of the Company in order to change
the fiscal year, which shall from now on read as follows:
" Art. 18. The business year begins on January 1
st
of each year and ends on December 31
st
the same year."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).
The undersigned notary who knows French, states herewith that on request of the above appearing party, the present
deed is worded in French followed by a English version; on request of the same party and in case of divergences between
the English and the French text, the French text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Signé: P. DE FROIDMONT, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2012. Relation: DIE/2012/13737. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveur p.d.i> (signé): RECKEN.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 novembre 2012.
Référence de publication: 2012153204/103.
(120201738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Neoval, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 112.451.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le neuf novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A comparu:
«BY INTERNET SA», une société anonyme, ayant son siège social à L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins, con-
stituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 31 décembre 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 478 du 25 septembre 1996,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B numéro 62559.
Représentée par Monsieur Renaud VERCOUTER, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg,
ci-après nommée "l'associée unique",
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:
- La société à responsabilité limitée NEOVAL S.à. r.l., ayant son siège social à L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B, numéro 112.451.
ci-après dénommée "la Société",
a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, alors notaire de résidence à Remich, en date du 17
novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 53 du 9 janvier 2006.
- Le capital social de la Société est de deux cent mille euros (200.000.- EUR) représenté par huit milles (8.000) parts
sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
- La comparante est l'unique propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société;
- La comparante agissant comme associée unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
- La comparante, se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et
délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre
en exécution les dispositions du présent acte.
147551
L
U X E M B O U R G
- La comparante déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la société dissoute.
- La comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de la Société
comme indiqué ci-avant.
- Décharge pleine et entière est donnée au gérant de la Société.
Les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins;
- Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à l'associée
unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (par analogie de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-
ciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée
n'aura exigé la constitution de sûretés.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
à raison de cet acte, est dès lors évalué à 1.123,31 EUR.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu
des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française au comparant, ès-qualité qu'il agit, lequel a signé
avec le notaire le présent acte.
Signé: R. VERCOUTER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53692. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Référence de publication: 2012153162/53.
(120201856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
G.O. II - Luxembourg Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 117.284.
En date du 9 octobre 2012 et avec effet au 31 octobre 2012, Davide Madini, avec adresse au 8, Via Melchiorre Gioia,
20124 Milan, Italie, a démissionné de son mandat de gérant de la société G.O. II - Luxembourg Three S.à r.l., avec siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 117284.
Alter Domus Luxembourg S.à r.l., mandaté par le démissionnaire
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2012.
Référence de publication: 2012156997/14.
(120207279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
FundTap Luxembourg Funds, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 148.543.
Il résulte d’une décision prise par le conseil de gérance en date du 12 juillet 2012 que le siège social du fonds a été
transféré du 11, boulevard de la Foire au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le fonds
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012156967/14.
(120207197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
147552
Abax Investment Services
Acta Priv S.A.
Aquarius Capital Development S.A.
Bailey Investments S.à r.l.
be2
Besix Global Re S.A.
Bigpoint GMTP Lux JV S.àr.l.
B-Iond S.A.
Bluestone Capital Partners S.A.
Brandstyles.com Sàrl
BRS International S.A.
BT Broadband Luxembourg S.à r.l.
C2P S.à r.l.
Calatrava Re
Cashcloud AG
C.A.S. Services S.A.
C.D.P. S.A.
C.E.A.O. Bénard
Charlotte and Charles S.à r.l.
Circuit 3
Compagnie Immobilière des Ardennes S.A.
Confidensia S.A.
CVI Luxembourg Fifteen S.à r.l.
D-Cars S.à r.l.
Distrielec S.A.
Entrust-Invest Sàrl
FundTap Luxembourg Funds
G.O. II - Luxembourg Three S.à r.l.
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Iceo Parallel
IMP S.à r.l.
Indosuez Management II S.A.
Insight International S.à r.l.
Interdate S.A.
Kona Holding S.A.
Neoval
Parana Corporation S.à r.l.
Passy Development S.A.
Perimmo S.A.
Petit Bois Property S.A.
Pradera Central Istanbul S.à r.l.
RIL II Whitelands S.à r.l.
Schortgen Reliures S.à r.l.
Soft S.A.
Soft S.A.
Spido Oil s.à r.l.
Tajura S.A.
Web Leasure Investment
Woodlander Project S.A.
Woodlander Project S.A.