logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3035

15 décembre 2012

SOMMAIRE

1492i Investments & Co S.C.A.  . . . . . . . . . .

145649

3i GC Holdings Lab 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

145675

Aero Marketing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145653

Aero Marketing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145649

Blue Sky SPV 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145658

Captain Luxco 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145636

Càput International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

145660

CEPF Bavaria Intermediate 2 & Cy S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145641

Dekan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145660

Ecolab lux 7 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145641

EPGF (Luxembourg), Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

145646

ESCO Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

145653

Eurolux Invest Group SC  . . . . . . . . . . . . . . .

145639

Foncière Esterel SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145658

FREIF Wind Holdings II S.à r.l.  . . . . . . . . . .

145656

FREIF Wind Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

145654

Galaxy S.à r.l. SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145649

Global Fund House Management S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145654

Joran S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145634

L.C.A. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145656

LGS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145656

Link Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145635

LSF5 Roundup Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

145676

LX Alpha Phi S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145676

Mako Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145661

NameBox Cy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145656

Pecunia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145659

Scheffer Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

145675

S.C.I. Kenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145658

Security Capital (EU) Management Hol-

dings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145657

Skarman & Skarman S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

145675

SKOK Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145657

Société de la Bourse de Luxembourg  . . . .

145660

Soluwatt s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145676

Spencer Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145679

Staff Consulting & Interim S.àr.l.  . . . . . . . .

145679

Star-One  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145660

Steffen Salaisons S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145679

St. Georges Investment S.A. - SPF . . . . . . .

145679

Tacotec Packaging S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

145636

Takeoff Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

145639

Take Up Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

145636

Thalie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145639

The Private Equity Company SA  . . . . . . . .

145661

Top Sun s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145639

Traction S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145641

TTG Cayuga Bavaria Intermediate 2 & Cy

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145641

Val des Lauriers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145679

Vap Restaurants S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145641

Whale International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

145645

Wind Acquisition Finance S.A.  . . . . . . . . . .

145645

Yoaké Lounge Spa Luxembourg  . . . . . . . . .

145675

Yuma Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145649

145633

L

U X E M B O U R G

Joran S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 131.867.

L’an deux mille douze,
le dix-sept octobre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

la société «AUTAN S.à r.l. SPF», une société à responsabilité limitée de gestion de patrimoine familial de droit luxem-

bourgeois, établie et ayant son siège social au 13 avenue du Bois, L-1351 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire
soussigné, reçu en date de ce jour, numéro précédent de son répertoire,

ici représentée par:
Monsieur Yvon HELL, expert-comptable, demeurant professionnellement au 13 avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le15 octobre 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée par son mandataire prénommé, et agissant en sa qualité de seul et unique

associé de la société «JORAN S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social actuel au 13
avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, (la «Société»),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 131 867 et constituée

suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 19 septembre 2007, lequel acte de constitution fut publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 22 octobre 2007, sous le numéro 2377 et page 114 091,

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique de la Société DECIDE de modifier l'année sociale de la Société afin qu’à l’avenir l'année sociale com-

mence le premier janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année.

L'associé  unique  constate  en  même  temps,  que  l’année  sociale  qui  a  débuté  le  1 

er

  octobre  2011  s’est  terminée

exceptionnellement le 31 décembre 2011, soit neuf mois plus tôt que prévu par les statuts et l’exercice social qui a débuté
le 1 

er

 janvier 2012 se terminera donc le 31 décembre 2012.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique DECIDE de modifier l’article SEIZE (16) des statuts de la Société, afin de refléter le changement de

l’année sociale.

L'associé unique DECIDE que cet article SEIZE (16) des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 16. «L’année sociale de la société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même

année.»

<i>Troisième résolution

L'associé unique CONSTATE encore que depuis toute la période 2007 à 2011, les comptes annuels de la Société ont

été approuvés par l’assemblée générale des associés et régulièrement déposés au Registre de Commerce et des Sociétés
(RCS) pour des exercices sociaux erronément clôturés au 31 décembre de chacune de ces années, alors que ces mêmes
exercices sociaux auraient dû se terminer le 30 septembre de chaque année, selon les dispositions visées par l’article
SEIZE (16) des statuts, avant qu’il soit modifié.

Dont acte, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,

lequel mandataire a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Y. HELL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 octobre 2012. Relation: EAC/2012/13719. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012150359/51.
(120198620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

145634

L

U X E M B O U R G

Link Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 99.276.

DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le cinq novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de Monsieur Marc SIMONIS, administrateur de sociétés, demeurant au 1, Clos du

Grand Sart à B-4607 Dalhem (Belgique), en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 16 octobre 2012,
laquelle procuration, après avoir été paraphée “ne varietur” par la mandataire du comparant et par le notaire instru-
mentant, restera annexé aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a exposé et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
La société anonyme “Link Engineering S.A.”, ayant son siège social au 45-47, route d’Arlon L-1140 Luxembourg, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B, numéro 99276, ("la Société"), a été constituée
suivant acte reçu par le notaire Maître Edmond SCHROEDER, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du 14 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 412 le 24 août 1996.

Le capital social de la Société est de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (30.986,09

EUR) représenté par 1250 actions sans valeur nominale.

Le comparant, représenté comme ci-avant, est le propriétaire de la totalité des actions représentant l’intégralité du

capital de la Société.

L’actionnaire unique, représenté comme ci-avant, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation

financière de la Société.

L’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, qu'en sa qualité d’actionnaire unique représentant l’intégralité du capital
social il se trouve investie de tout l'actif et s'engage expressément à prendre à leur charge tout passif pouvant éventuel-
lement exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout payement à sa personne; partant la
dissolution et la liquidation de la Société sont à considérer comme faites et clôturées.

Décharge pleine et entière est accordée par l’actionnaire unique aux administrateurs et au commissaire aux comptes

de la Société.

L’actionnaire unique s’engage à procéder à l'annulation des actions de la Société.
Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société.
Toutefois aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de l’actionnaire unique ou rem-

boursement aux actionnaires ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés
commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et
liquidée n’aura exigé la constitution de sûretés.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à huit cents euros (800,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire par son nom, prénoms

usuels, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52127. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150402/51.
(120198487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

145635

L

U X E M B O U R G

Tacotec Packaging S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3719 Rumelange, 20, A Wiendelen.

R.C.S. Luxembourg B 148.054.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012150601/10.
(120198141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Take Up Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 125.880.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012150612/9.
(120198149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Captain Luxco 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.911.

In the year two thousand twelve, on the eighth of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,
acting as the representative of the board of directors (the Board) of Captain Luxco 1 S.A. (the Company), a public

company (société anonyme), incorporated and organised under the laws of Luxembourg, with registered office at 44,
Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 160911.

pursuant to resolutions taken by the Board on October 1, 2012 (the Resolutions).
A copy of the Resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, representing the Board pursuant to the Resolutions, requested the notary to record the fol-

lowing statements:

I.- The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

dated May 13, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1730 of July 29, 2011
(the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant
to a deed of the undersigned notary, dated June 5, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1723 of July 9, 2012.

II.- The Company has an issued share capital of thirty-one thousand eight hundred eighty-six Euro and four hundred

twenty-six thousandth Euro (EUR 31,886.426), represented by one million two hundred sixteen thousand eight hundred
thirty seven (1,216,837) Class A Shares, three thousand one hundred eighty-eight (3,188) Class B Shares, three thousand
one hundred eighty-eight (3,188) Class C Shares and three thousand one hundred eighty-eight (3,188) Class D Shares, in
registered form, having a par value of twenty six thousandth of one Euro (EUR 0.026).

III.- Article 5.3 of the Articles provides as follows:
“The Board is authorized, for a period of five (5) years from the date of the publication of the deed of incorporation,

to:

(i) increase the current share capital once or more up to an amount of five million two hundred thousand Euro (EUR

5,200,000), represented by up to one hundred ninety million and one (190,000,001) class A Shares, up to three million
three hundred thousand three hundred thirty three (3,333,333) class B Shares, up to three million three hundred thousand
three hundred thirty three (3,333,333) class C Shares and up to three million three hundred thousand three hundred
thirty three (3,333,333) class D Shares, by the issue of new Shares, regardless of the classes of Shares to which they
belong, but within the aforementioned limits, having the same rights as the existing Shares belonging to such classes of
Shares;

145636

L

U X E M B O U R G

(ii) limit or withdraw the shareholders’ preferential subscription rights to the new Shares and determine the persons

who are authorized to subscribe to the new Shares; and

(iii) record each share capital increase by way of a notarial deed and amend the register of Shares accordingly.”
IV.- The Board pursuant to the Resolutions resolved to inter alia:
(i) increase the share capital of the Company from its current amount of thirty-one thousand eight hundred eighty-six

Euro and four hundred twenty-six thousandth Euro (EUR 31,886.426), represented by one million two hundred sixteen
thousand eight hundred thirty seven (1,216,837) Class A Shares, three thousand one hundred eighty-eight (3,188) Class
B Shares, three thousand one hundred eighty-eight (3,188) Class C Shares and three thousand one hundred eighty-eight
(3,188) Class D Shares, in registered form, having a par value of twenty six thousandth of one Euro (EUR 0.026) each to
thirty-two thousand one hundred and two Euro and two hundred and twenty-six thousandth Euro (EUR 32,102.226) by
way of the creation and issue of five thousand (5,000) class A shares, one thousand one hundred (1,100) class B shares,
one thousand one hundred (1,100) class C shares and one thousand one hundred (1,100) class D shares, all with a par
value of twenty six thousandth of one Euro (EUR 0.026) each (the New Shares), and

(ii) appoint any employee of Notary Hellinckx office, acting under his sole signature, to execute and sign on behalf of

the Company any acts, deeds, declarations, certificates, notices, documents or statements as may be necessary to formalise
the share capital increase in front of a notary public in Luxembourg. This delegation of signatory powers shall cover but
shall not be limited to any corporate action necessary to amend and restate the articles of association, certify any excerpt
or extract of the Resolutions or part thereof and pay any taxes and duties which may become payable as a result of the
present share capital increase.

The New Shares have been fully subscribed and fully paid up by a contribution in cash of six thousand one hundred

and two Euro (EUR 6,102) fully allocated to the share capital account of the Company, as approved by the Resolutions,
evidence of which has been given to the undersigned notary.

V.- As a result of the above, the Board has resolved to amend article 5 of the Articles which should now be read as

follows:

“ 5.1. The issued share capital is set at thirty-two thousand one hundred and two Euro and two hundred and twenty-

six thousandth Euro (EUR 32,102.226), represented by one million two hundred and twenty-one thousand eight hundred
and thirty-seven (1,221,837) Class A Shares, four thousand two hundred and eighty-eight (4,288) Class B Shares, four
thousand two hundred and eighty-eight (4,288) Class C Shares and four thousand two hundred and eighty-eight (4,288)
Class D Shares, in registered form, having a par value of twenty six thousandth of one Euro (EUR 0.026) each, all subscribed
and fully paid-up.”

<i>Estimate of costs

The appearing party declares that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid

by the Company as a result of this deed amount approximately to EUR 1,500.-The undersigned notary, who understands
and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English,
followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le huitième jour du mois de novembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Annick Braquet, ayant son adresse professionnelle au 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg,
agissant en qualité de représentant du conseil d’administration (le Conseil) de Captain Luxco 1 S.A. (la Société), une

société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 44,
Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 160911

conformément aux décisions prises par le Conseil le 1 

er

 octobre 2012 (les Décisions).

Une copie des Décisions, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentant le Conseil conformément aux Décisions, a prié le notaire instrumentant d'acter

ce qui suit:

I. La Société a été constituée le 13 mai 2011 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-

bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1730 du 29 juillet 2011 (la Société). Les statuts

145637

L

U X E M B O U R G

de la Société (les Statuts) ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte du notaire soussigné, daté du 5 juin 2012, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1723 du 9 juillet 2012.

II. La Société a un capital social souscrit de trente-et-un mille huit cent quatre-vingt-six euros et quatre cent vingt-six

millièmes d’euros (31.886,426 EUR) représenté par un million deux cent seize mille huit cent trente-sept (1.216.837)
Actions de classe A, trois mille cent quatre-vingt-huit (3.188) Actions de classe B, trois mille cent quatre-vingt-huit (3.188)
Actions de classe C et trois mille cent quatre-vingt-huit (3.188) Actions de classe D, sous forme nominative, d'une valeur
nominale de vingt-six millièmes d'Euro (EUR 0,026) chacune.

III. L'article 5.3 des Statuts prévoit ce qui suit:
“Le Conseil est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l’acte constitutif,

à:

(i) augmenter le capital social existant en une ou plusieurs fois, à hauteur de cinq millions deux cent mille Euros (EUR

5.200.000), représenté par cent quatre-vingt-dix millions et une (190.000.001) Actions de classe A, trois millions trois
cent trente-trois mille trois cent trente-trois (3.333.333) Actions de classe B, trois millions trois cent trente-trois mille
trois cent trente-trois (3.333.333) Actions de classe C et trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois
(3.333.333) Actions de classe D, par l'émission de nouvelles Actions, sans tenir compte de la classe d'Actions à laquelle
elles appartiennent, ayant les mêmes droits que les Actions existantes appartenant à ces classes d'Actions;

(ii) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions et déterminer

les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et

(iii) faire constater chaque augmentation de capital social par acte notarié et modifier le registre des actions en con-

séquence.”

IV. Le Conseil, conformément aux Décisions, a décidé inter alia:
(i) d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un mille huit cent quatre-vingt-six

euros et quatre cent vingt-six millièmes d’euros (31.886,426 EUR) à trente-deux mille cent deux euros et deux cent vingt-
six millièmes d’euros (EUR 32.102,226) par la création et l'émission de cinq mille (5.000) parts sociales de classe A, mille
cent (1.100) parts sociales de classe B, mille cent (1.100) parts sociales de classe C et mille cent (1.100) parts sociales de
classe D, toutes ayant une valeur nominale de vingt-six millièmes d'euros (EUR 0,026) chacune (les Nouvelles Actions),
et

(ii) de nommer tout employé du Notaire Hellinckx, agissant sous sa seule signature, pour exécuter et signer pour le

compte de la Société tous les documents, actes, déclarations, certificats, mentions, documents ou déclarations jugés
nécessaires afin de formaliser la présente augmentation de capital social en présence d'un notaire de Luxembourg. Cette
délégation de pouvoir de signature couvre, mais n'est pas limitée à, toute action de la Société nécessaire à la modification
des statuts, la certification de tout extrait des Décisions ou partie de ces dernières et le paiement de toutes les taxes et
droits exigibles consécutifs à la présente augmentation de capital.

Les Nouvelles Actions ont été entièrement souscrites et entièrement libérées par un apport en numéraire de 6.102

(six mille cent deux) Euros entièrement affecté au compte de capital social de la Société tel qu’approuvé lors des Décisions,
dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

V. En conséquence de ce qui précède, le Conseil a décidé de modifier l’article 5 des Statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

“ 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille cent deux Euros et deux cent vingt-six millièmes d’euros (32.102,226

EUR) représenté par un million deux cent vingt-et-un mille huit cent trente-sept (1.221.837) actions de classe A, quatre
mille deux cent quatre-vingt-huit (4.288) actions de classe B, quatre mille deux cent quatre-vingt-huit (4.288) actions de
classe C, quatre mille deux cent quatre-vingt-huit (4,188) actions de classe D, ayant une valeur nominale vingt-six millièmes
d'Euro (0,026 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.”

<i>Estimation des coûts

La partie comparante déclare que les dépenses, coûts et frais ou charges de toute nature qui seront à régler par la

Société puisque découlant de cet acte, atteindront le montant approximatif de EUR 1.500.-

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare, par la présente, qu’à la demande de la personne

comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même personne
comparante, en cas de divergences entre le texte en anglais et celui en français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite à la partie comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53422. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

145638

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150121/152.
(120198387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Takeoff Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 85.601.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012150613/9.
(120198148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Thalie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 69.459.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2012150616/12.
(120198202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Top Sun s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4950 Bascharage, 56, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 47.764.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures

Référence de publication: 2012150622/10.
(120198061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Eurolux Invest Group SC, Société Civile.

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 4.938.

STATUTS

1. Monsieur HAYET Christophe, né le 21 janvier 1973 à Nivelles (Belgique), demeurant professionnellement au 46,

Rue Daumerie B-1471 Genappe (Belgique);

2. Monsieur LIBERT Christophe, né le 04 novembre 1973 à Watermael-Boitsfort (Belgique), demeurant au 6, Rue Cala

B-1473 Genappe (Belgique);

Lesquels comparants ont décidé d’acter les statuts d’une Société Civile qu’ils déclarent constituer entre eux comme

suit le 16/11/2012:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.

Art. 2. La Société a pour objet la détention, l’utilisation et la mise à disposition de biens mobiliers à des fins privées.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La dénomination est Eurolux Invest Group SC.

Art. 4. Le siège social est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue, il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l’assemblée générale.

145639

L

U X E M B O U R G

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à 100,00 EUR, répartis en 100 parts de 1,00 EUR chacune et constitué par l’apport en

numéraire sur un compte ouvert pour la société.

Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 50 parts à Monsieur HAYET Christophe, et 50 parts à Monsieur LIBERT

Christophe, les comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord
représentant au moins 50% des parts. L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des

tiers non-associés sans l’accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l’un des associés de ses
parts sociales, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et
agréé d’année en année lors de l’assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de
préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation
d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le
capital restant.

Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants

n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l’associé
décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régularisation,
désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la Société.

Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l’unanimité de tous les associés.

Art. 11. Le gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour

compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle de son
gérant.

Art. 12. Le bilan est soumis à l’approbation des associés, qui décident de l’emploi des bénéfices. Les bénéfices sont

répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 13. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du

Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la Société.

Art. 14. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du

gérant ou sur convocation d’un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le troisième vendredi
de juin de chaque année à 15 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur des
parts conformément à l’article 6. L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions
sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.

Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que

l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution à 100 EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

A l’instant, les parties comparantes représentant l’intégralité du capital social se sont réunies en assemblée générale

extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions
suivantes:

1. La société EDISYS SA, 65, Route d’Esch L-3340 Huncherange, RCS Luxembourg B 139924, est nommée co-gérant,
2. Monsieur HAYET Christophe, précité est nommé Gérant,
3. Le siège de la Société est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.
Lu, accepté et signé par les parties intervenantes.
Référence de publication: 2012150208/70.
(120198420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

145640

L

U X E M B O U R G

Traction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 82.284.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2012150624/12.
(120198203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

TTG Cayuga Bavaria Intermediate 2 &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. CEPF Bavaria Intermediate 2 &amp; Cy S.C.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 172.270.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150631/11.
(120198079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Vap Restaurants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 148.301.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de Vap Restaurants S.A., tenue extraordinairement le 12 novembre

<i>2012

Il a été décidé ce qui suit:
de remplacer Monsieur Mickaël Antolinos-Chanteperdrix, Administrateur de catégorie «B» par
- Monsieur Grégory Antolinos-Chanteperdrix, Administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1970 à Rillieux-la-Pape

(France), demeurant 14, rue du Châtelard, CH-1268 Begnins (Suisse).

Le mandat du nouvel Administrateur de catégorie «B» arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle

qui se tiendra en 2014.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- Messieurs Gregor Gerlach et Mario C. Bauer, Administrateurs de catégorie «A»;
- Messieurs Grégory Antolinos-Chanteperdrix et Michel Antolinos, Administrateurs de catégorie «B».

Pour extrait certifié conforme
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012150647/21.
(120198178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Ecolab lux 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la liberté.

R.C.S. Luxembourg B 171.512.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of October.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ecolab CH 1 GmbH, a limited liability company (gesellschaft mit beschrânkter Haftung) formed and existing under the

laws of Switzerland, with registered office at 44 Zentralstrasse, 6003 Lucerne, Switzerland, registered with the Lucerne
Commercial Register under number CH-100.4.788.188-3,

145641

L

U X E M B O U R G

hereby represented by Mr. Raymond Thill, maître en droit, having his professional address at 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on 24
October 2012.

The said power of attorney, initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of a limited liability company (société à res-

ponsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "Ecolab
Lux 7 S.à r.l." (the "Company"), with registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 171512, incorporated
by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 14 September
2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 2559 of 15 October 2012, and whose
articles of association have last been amended by a deed of the undersigned notary of 23 October 2012, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one (1)

Ordinary Share and twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) Class A Preferred Shares, all having a par value
of one euro (EUR 1.-) each, fully paid-up.

III. The appearing party then took the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of thirty-seven thousand five

hundred euro (EUR 37,500.-) to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
to  the  amount  of  fifty  thousand  euro  (EUR  50,000.-)  by  the  issuance  of  thirty-seven  thousand  five  hundred  Class  B
Preferred Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to be subscribed by Ecolab NL3 B.V., a company
formed and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at 7 Iepenhoeve, 3438 MR
Nieuwegein, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under KVK number 30231919.

<i>Subscription

Ecolab NL3 B.V., pre-named, declared to subscribe to the thirty-seven thousand five hundred (37,500) Class B Pre-

ferred Shares issued and allotted to it for a total aggregate amount of thirty-seven thousand five hundred euro (EUR
37,500.-),  increased  by  a  share  premium  in  the  amount  of  sixty-six  million  three  hundred  sixty-nine  thousand  three
hundred eighty-five euro (EUR 66,369,385.-), by a contribution in kind described below.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder approved and accepted the contribution in kind of the following assets, having a total aggregate

amount of sixty-six million four hundred six thousand eight hundred eighty-five euro (EUR 66,406,885.-), to the equity
basis of the Company by Ecolab NL3 B.V., aforesaid:

(i) all the issued shares representing the entire share capital of Ecolab NL10 B.V., a limited liability company formed

and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at 7 Iepenhoeve, 3438 MR Nieuwegein,
the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under the KVK number 56036094;

(ii) all the membership interests of Ecolab Holdings (Europe) LLC, a company formed and validly existing under the

laws of the state of Delaware, United-States of America, having its registered office at Corporations Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, United-States of America, registered with the Delaware Se-
cretary of State, Corporations Division, under number 2247865;

(iii) all the issued shares representing the entire share capital of Ecolab CH 3 GmbH, a limited liability company formed

and validly existing under the laws of Switzerland, having its registered office at 44 Zentralstrasse, 6003 Lucerne, Swi-
tzerland, registered with the Lucerne Commercial Register under number CH-100.4.793.900-5; and

(iv) 4,111 class A shares and 1,894 class B shares, representing 48.45 % of the share capital of Ecolab SA, a company

formed and validly existing under the laws of Venezuela, having its registered office at Avenida Francisco de Miranda,
Torre Edicampo, Piso 1, Urbanizacion Campo Alegre, Chacao. Caracas, Venezuela, registered with the Second Com-
mercial Registry of the Judicial Circumscription and State of Miranda under number 37, Volume 8-A Seg. Registry file
340930.

The contributions in kind by Ecolab NL3 B.V., aforesaid, to the Company are made in exchange for the issue and

allotment by the Company of thirty-seven thousand five hundred (37,500) Class B Preferred Shares with a par value of
one euro (EUR 1.-) each, in a total value of thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 37,500.-), which are all sub-
scribed and fully paid up by Ecolab NL3 B.V., aforesaid, and (ii) the allocation of an amount of sixty-six million three
hundred sixty-nine thousand three hundred eighty-five euro (EUR 66,369,385.-) to the share premium account relating
to Class B Preferred Shares.

145642

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

Ecolab NL3 B.V., aforesaid, declared that it is the unrestricted owner of the shares that are contributed and that these

contributions are free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free
transferability of the contributions to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have
been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform the valid transfer of the
contributions to the Company.

Ecolab NL3 B.V. also declared that it possesses the power to dispose of the assets that are contributed.
Evidence of the existence of the companies whose shares are contributed has been given to the undersigned notary.
As a consequence of the above mentioned increase of share capital, the new shareholder of the Company entered the

meeting and participated in the vote relating to the following resolution:

<i>Third resolution

Further to the above resolutions, the shareholders resolve to amend Article 6 of the Company's articles of association

which shall henceforth read as follows:

Art. 6. Share capital. The share capital is set at fifty thousand euros (EUR 50,000) represented by one (1) Ordinary

Share, twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) Class A Preferred Shares and thirty-seven thousand five hun-
dred (37,500) Class B Preferred Shares, all having a par value of one euro (EUR 1) each, fully paid-up.

In addition to the issued share capital, for each category of shares, a premium account may be set up into which any

premium paid in relation to the relevant category of shares, in excess of the capital contribution, may be transferred. The
amount in the premium account may be used to fund the repayment of any shares of the relevant category that the
Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the share-
holder(s) of the relevant category in the form of a dividend or otherwise or to allocate funds to the legal reserve."

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this general meeting are estimated at seven thousand euro (EUR 7,000.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-cinquième jour d'octobre.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Ecolab CH 1 GmbH, une société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), ayant son siège social

Zentralstrasse  44,  6003  Lucerne,  Suisse,  enregistrée  au  Registre  de  Commerce  de  Lucerne  sous  le  numéro
CH-100.4.788.188-3,

ici représentée par Mr. Raymond Thill, maître en droit, ayant son adresse professionnelle au 74 avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 octobre 2012.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire de constater ce qui suit:
I. La partie comparante est l'associé unique ( "l'Associé Unique") de la société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois dénommée Ecolab Lux 7 S.à r.l. (la "Société"), dont le siège social est établi au 13-15 avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 171512, constituée par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, du 14 septembre 2012 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, par un
acte du notaire instrumentant du 23 octobre 2012.

II. Le capital de la Société s'élève à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par une (1) Part Ordinaire

et douze mille quatre cent nonante-neuf (12.499) Parts Préférentielles de Catégorie A, toutes d'une valeur nominale d'un
euro (1 EUR) chacune, entièrement libérées.

III. La partie comparante adopte, ensuite, les résolutions suivantes:

145643

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de trente-sept mille cinq

cents euros (37.500,- EUR) afin de le porter d'un montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à un
montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR), par l'émission de trente-sept mille cinq cents (37.500) Parts Préféren-
tielles de Catégorie B, d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune, souscrite par Ecolab NL3 B.V., une société de
droit néerlandais, ayant son siège social au 7 Iepenhoeve, 3438 MR Nieuwegein, Pays-Bas, enregistrée au Registre du
Commerce des Pays-Bas sous le numéro KVK 30231919.

<i>Souscription

Ecolab  NL3  B.V.,  pré-qualifiée,  déclare  souscrire  les  trente-sept  mille  cinq  cents  (37.500)  Parts  Préférentielles  de

Catégorie B émises et qui lui sont allouées, pour un montant total de trente-sept mille cinq cents euros (37.500 EUR),
augmenté d'une prime d'émission d'un montant de soixante-six millions trois cent soixante-neuf mille trois cent quatre-
vingt-cinq euros (66.369.385,- EUR), par un apport en nature dont question ci-dessous.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver et d'accepter l'apport en nature, d'une valeur totale de soixante-six millions

quatre cent six mille huit cent quatre-vingt-cinq euros (66.406.885,- EUR), au capital augmenté des primes d'émission et
des primes assimilées de la Société, effectué par Ecolab NL3 B.V., pré-qualifiée, des actifs suivants:

(i) toutes les actions émises et représentant la totalité du capital social d'Ecolab NL10 B.V., une société à responsabilité

limitée  de  droit  néerlandais,  ayant son  siège  social  au  7  Iepenhoeve, 3438  MR Nieuwegein, Pays-Bas, enregistrée au
Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro KVK 56036094;

(ii) toutes les parts d'intérêts d'Ecolab Holdings (Europe) LLC, une société de droit de l'état de Delaware, Etats-Unis

d'Amérique, ayant son siège social au Corporations Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Dela-
ware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Delaware Secretary of State, Corporations Division, sous le
numéro 2247865;

(iii) toutes les actions émises et représentant la totalité du capital social d'Ecolab CH 3 GmbH, une société à respon-

sabilité limitée de droit suisse, ayant son siège social au 44 Zenstralstrasse, 6003 Lucerne, Suisse, enregistrée au Registre
du Commerce du canton de Lucerne sous le numéro CH-100.4.793.900-5; et

(iv) quatre mille cent onze (4,111) actions de catégorie A et mille huit cent nonante-quatre (1,894) actions de catégorie

B, représentant 48,45 % du capital social d'Ecolab SA, une société de droit vénézuélien, ayant son siège social au Avenida
Francisco de Miranda, Torre Edicampo, Piso 1, Urbanizacion Campo Alegre, Chacao. Caracas, Venezuela, enregistrée au
deuxième Registre du Commerce de l'état de Miranda sous le numéro 37, Volume 8-A, 340930.

Ces apports en nature par Ecolab NL3 B.V., pré-qualifiée, à la Société sont rémunérés par (i) l'émission par la Société

de trente-sept mille cinq cents (37.500) Parts Préférentielles de Catégorie B d'une valeur nominale de un (1) euro chacune,
représentant une valeur totale de trente-sept mille cinq cents euros (37.500 EUR), qui sont toutes souscrites et entiè-
rement libérées par Ecolab NL3 B.V., pré-qualifiée, et (ii) l'allocation d'un montant de soixante-six million trois cent
soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (66,369,385 EUR) au compte de prime d'émission relatif aux Parts
Préférentielles de Catégorie B.

<i>Déclaration

Ecolab NL3 B.V., pré-qualifiée, déclare qu'elle est pleine propriétaire des actions qui sont contribuées et que les apports

sont libres de tout gage, droit de rétention ou charge, et qu'il ne subsiste aucune entrave au libre transfert des apports
à la Société, sans restrictions ou limitations et que des instructions valides ont été données pour entreprendre toutes les
notifications, inscriptions, ou toute autres formalités nécessaires à la réalisation du transfert des apports à la Société.

Ecolab NL3 B.V., pré-qualifiée, déclare également qu'elle a la capacité de disposer des biens qui sont contribués.
Preuve de l'existence des sociétés dont les actions sont contribuées a été rapportée au notaire instrumentant.
En conséquence de cette augmentation de capital social, le nouvel associé de la Société a rejoint l'assemblée générale

et a participé au vote relatif aux résolutions suivantes:

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions adoptées ci-dessus, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui se

lit désormais comme suit:

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par une (1) Part

Ordinaire, douze mille quatre cent nonante-neuf (12.499) Parts Préférentielles de Catégorie A et trente-sept mille cinq
cent (37.500) Parts Préférentielles de Catégorie B, toutes d'une valeur nominale d'un euro ( 1 EUR) chacune, entièrement
libérées.

Outre le capital social souscrit, pour chaque catégorie de parts sociales, un compte de primes d'émission peut être

établi sur lequel toute prime d'émission payée concernant cette catégorie de parts sociales, en excès du capital social
souscrit, peut être transférée. Les primes d'émission peuvent être utilisées pour financer le remboursement de toute

145644

L

U X E M B O U R G

part sociale de la catégorie concernée que la Société peut racheter auprès de ces associés, afin de compenser toute perte
nette, de distribuer ces primes aux associés titulaires de parts sociales de la catégorie concernée sous la forme d'un
dividende ou autrement ou de les affecter à la réserve légale."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente assemblée générale s'élève à environ sept mille euros (7.000,- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 octobre 2012. Relation: LAC/2012/50615. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150201/196.
(120198624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Whale International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 153.498.

L'adresse professionnelle des gérants, Monsieur Thomas PELTIER, Monsieur Vladimir TCHIJEVSKI et Monsieur Petr

KOROTKEVICH est dorénavant la suivante:

270, route d'Arlon, L-8010 Strassen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150670/13.
(120198193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Wind Acquisition Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.

R.C.S. Luxembourg B 109.825.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 28 mars 2012

1. M. David CATALA a été renouvelé dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

2.  M.  Hugo  FROMENT  a  été  renouvelé  dans  son  mandat  d'administrateur  jusqu'à  l'issue  de  l'assemblée  générale

statutaire de 2013.

3.  M.  Pierre  CLAUDEL  a  été  renouvelé  dans  son  mandat  d'administrateur  jusqu'à  l'issue  de  l'assemblée  générale

statutaire de 2013.

4. M. Riccardo CALIENDO a été renouvelé dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2013.

5. M. Riccardo MARSILI a été renouvelé dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2013.

6. La société anonyme ERNST &amp; YOUNG a été renouvelée dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'as-

semblée générale statutaire de 2013.

145645

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Wind Acquisition Finance S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012150665/24.
(120198194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

EPGF (Luxembourg), Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.550.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 83.466.

In the year two thousand and twelve, on the eighth of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary of residence in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) EPGF FINANCE (Luxembourg), SARL, a Luxembourg société à responsabilité limitée incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, Rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number
B 83.465, here represented by Maya Van Belleghem, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal in Luxembourg on November 7 

th

 , 2012; and

2) Standard Life Investments European Property Growth Fund L.P., an investment fund, incorporated and existing

under the laws of England and Wales, with registered office at 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP and registered in
England and Wales under number LP007862 duly represented by its general partner Standard Life Investments (General
Partner EPGF) Limited, a private limited company incorporated and existing under the laws of Scotland and having its
registered office at 1 George St, Edinburgh EH2 2LL, registered in Scotland under number SC193443, here represented
by Maya Van Belleghem, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in
Edinburgh (Scotland) on November 7 

th

 , 2012.

The said proxies shall be initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned

notary and will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons acting in their capacity as shareholders (the "Shareholders") of EPGF (LUXEMBOURG), SARL,

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 83.466 and having a share
capital of six million five hundred thousand euro (EUR 6,500,000) (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of
Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated July 24 

th

 , 2001 and

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 140 of January 25 

th

 , 2002. The articles of incor-

poration of the Company have been amended for the last time on July 30 

th

 , 2009 pursuant to a deed of Maître Jean-

Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 339 of February 19 

th

 , 2011.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken and representing the entire share capital of the Company have requested the undersigned notary to state
their resolutions regarding the below agenda as follows:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of four million and fifty thousand euro (EUR 4,050,000)

so as to raise it from its current amount of six million five hundred thousand euro (EUR 6,500,000) to ten million five
hundred and fifty thousand euro (EUR 10,550,000) by the creation and the issue of one hundred and sixty-two thousand
(162,000) new shares, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each and having the same rights and obligations
as the existing shares.

2. Subscription for all the one hundred and sixty-two thousand (162,000) new shares by the existing shareholder of

the Company, Standard Life Investments European Property Growth Fund LP duly represented by its general partner
Standard Life Investments (General Partner EPGF) Limited by a contribution in cash in an amount of four million and fifty
thousand euro (EUR 4,050,000).

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company.
Further to the review of the different items composing the Agenda, the Shareholders, representing the entire share

capital of the Company, requested the notary to act the following resolution:

145646

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Shareholders resolved to increase the share capital of the Company by four million and fifty thousand euro (EUR

4,050,000), from six million five hundred thousand euro (EUR 6,500,000) up to ten million five hundred and fifty thousand
euro (EUR 10,550,000), by the issue of one hundred and sixty-two thousand (162,000) new shares with a nominal value
of twenty-five euro (EUR 25) each.

The one hundred and sixty-two thousand (162,000) new shares have been entirely subscribed and fully paid-up by

Standard Life Investments European Property Growth Fund LP duly represented by its general partner Standard Life
Investments (General Partner EPGF) Limited by a contribution in cash, so that the total amount of four million and fifty
thousand euro (EUR 4,050,000) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the Shareholders resolved to modify article 6 of the articles of incorporation

of the Company, which shall henceforth read as follows:

Art. 6. The unit capital is fixed at ten million five hundred and fifty thousand euro (EUR 10,550,000) represented by

four hundred and twenty-two thousand (422,000) units of twenty-five euro (EUR 25) each".

The rest of the articles of incorporation of the Company shall remain unchanged.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company

or are charged to the Company as a result of these resolutions is estimated at approximately three thousand six hundred
euro (EUR 3,600).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version, on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, known to the notary by her name, first

name, and residence, the proxyholder of the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le huit novembre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) EPGF FINANCE (Luxembourg), SARL, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.465,
ici représentée par Maya Van Belleghem, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration sous seing privé à Luxembourg le 7 novembre 2012; et

2) Standard Life Investments European Property Growth Fund LP, un fonds d'investissement, constitué et régie selon

les lois d'Angleterre et Wales ayant son siège social au 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP, immatriculé en Angleterre
et Wales sous le numéro LP007862, dûment représentée par son gérant unique et associé commandité Standard Life
Investments (General Partner EPGF) Limited, une private limited company, constituée et régie selon les lois d'Angleterre
et Wales ayant son siège social au 1 George St, Edinburgh EH2 2LL, Ecosse, immatriculée en Ecosse sous le numéro
SC193443, ici représentée par Maya Van Belleghem, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé à Edinburgh (Ecosse) le 7 novembre 2012.

Lesdites procurations seront signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et par le notaire sous-

signé et restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes agissant en leur qualité d'associés (les «Associés») de EPGF (LUXEMBOURG), SARL, une

société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 9, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.466 et ayant un capital social de six millions cinq cent mille
euros (6.500.000.- EUR) (la «Société»), constituée suivant un acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 juillet 2001 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 140 du 25 janvier 2002. La dernière modification des statuts de la Société a été faite en date du 30
juillet 2009 par acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 339 du 19 février 2011.

Les Associés, ainsi représentés, ont reconnu être dûment et pleinement informés des résolutions à prendre et re-

présentant l'intégralité du capital social de la Société, ont requis le notaire soussigné de constater leur décisions concernant
l'ordre du jour qui suit:

145647

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre millions cinquante mille euros (4.050.000.- EUR)

de sorte que le capital social de la Société dont le montant actuel est six millions cinq cent mille euros (6.500.000.- EUR)
s'élève désormais à un montant de dix millions cinq cent cinquante mille euros (10.550.000.- EUR) suite à l'émission de
cent soixante-deux mille (162.000) parts sociales ayant une valeur nominale unitaire de vingt-cinq euros (25.- EUR).

2. Accepter la souscription de cent soixante-deux mille (162.000) parts sociales par Standard Life Investments European

Property Growth Fund LP dûment représenté par son gérant unique et associé commandité Standard Life Investments
(General Partner EPGF) Limited au moyen d'un apport en espèces de quatre millions cinquante mille euros (4.050.000.-
EUR).

3. modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter cette augmentation de capital.

Après considération des différents points à l'Ordre du Jour, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social

de la Société, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société de quatre millions cinquante mille euros (4.050.000.-

EUR), pour le porter de son montant actuel de six millions cinq cent mille euros (6.500.000.- EUR), à dix millions cinq
cent  cinquante  mille  euros  (10.550.000.-  EUR),  par  l'émission  de  cent  soixante-deux  mille  (162.000)  nouvelles  parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune.

Les cent soixante-deux mille (162.000) nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées et souscrites par Standard

Life Investments European Property Growth Fund LP dûment représenté par son gérant unique et associé commandité
Standard Life Investments (General Partner EPGF) Limited, par un apport en numéraire, de sorte que la somme de quatre
millions cinquante mille euro (4.050.000.-EUR), se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu'il en à été justifié au notaire
soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés ont décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à dix millions cinq cent cinquante mille euros (10.550.000.- EUR) représenté par

quatre cent vingt-deux mille (422.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune.».

Le reste des statuts de la Société demeure inchangé.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de ces résolutions est estimé à environ trois mille six cents euros (3.600.- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumen-

tant par son nom, prénom usuel, et demeure, le mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: M. Van Belleghem et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52884. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150217/151.

(120198651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

145648

L

U X E M B O U R G

Yuma Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 125.051.

<i>Extract of the Extraordinary general meeting of the shareholders hold on September 21 

<i>st

<i> 2012 at the registered office of the

<i>company

The meeting has deliberated and has taken the following resolutions by unanimous vote:
1. The meeting decides to appoint as new director and new chairman of the board of directors until the ordinary

general meeting to be held in 2018, with sole signing authority, Mr. Larrea Fernandes Marcondes, born 16 

th

 October

1948 in Santana Do Livramento, RS, Brazil, residing Av. Lucio Costa 5740 Ap. 702, Rio de Janeiro, Brazil.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’assemblée a décidé et a pris a l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur et président du conseil d’administration jusqu’à l’assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2018, avec pouvoir de signature individuelle, M. Larrea Fernandes Marcondes, né 16
octobre 1948 à Santana Do Livramento, RS, Brésil, demeurant Av. Lucio Costa 5740 Ap. 702, Rio de Janeiro, Brésil.

Luxembourg, le 21 septembre 2012.

Yuma Europe S.A.

Référence de publication: 2012150683/20.
(120198070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

1492i Investments &amp; Co S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 164.398.

La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l, R.C.S. Luxembourg B 58545, avec siège social à L-1331 Lu-

xembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a démissionné de son mandat de membre du conseil de surveil-
lance.

Luxembourg, le 16 novembre 2012.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour 1492i Investments &amp; Co S.C.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012150688/14.
(120198097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Aero Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 154.881.

Par la présente, en ma qualité d'administrateur de la société AERO MARKETING SA, je vous informe démissionner

avec effet immédiat au jour de la présente, des fonctions d'administrateur de la société anonyme de droit luxembourgeois,
AERO MARKETING SA, établie et ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener, constituée en date du
26 Juillet 2010 par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame, et im-
matriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.154881.

Luxembourg, le 1 

er

 Novembre 2012.

Maître Edouard BUBENICEK.

Référence de publication: 2012150698/13.
(120198144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Galaxy S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en

Capital à Risque.

Capital social: EUR 40.327.300,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 73.667.

In the year two thousand and twelve, on the eighth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

145649

L

U X E M B O U R G

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Galaxy S.à r.l. SICAR, a Luxembourg

investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque) in the form of a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with regis-
tered office at 2, Place de Metz, L-1930 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 73667 and having a share capital of EUR 63,727,300 (the
Company). The Company was incorporated on 29 December 1999 pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notary, then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, C - number 233 of 28 March 2000. The articles of association of the Company (the Articles)
have been amended several times and for the last time on 17 September 2009 pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, C - number 2048 of 19 October 2009.

The  Meeting  was  opened  at  10.00  a.m.  and  was  chaired  by  Gabriel  de  la  Bourdonnaye,  residing  professionally  in

Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appointed as secretary, Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer, Adrien Pastorelli, residing professionally in Luxembourg.
The bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. That the shareholders of the Company (the Shareholders) represented at the Meeting and the number of shares

they hold are indicated on an attendance list, attached hereto as Schedule 1, which will remain attached to the present
minutes after having been signed by their representatives.

The proxies from the Shareholders after having been signed ne varietur by the proxyholders, acting on behalf of the

Shareholders and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the
registration authorities.

II.- that a convening notice has been sent on October 30, 2012 to each shareholder in accordance with article 16 of

the Articles;

III.- that from the attendance list, it appears that 2,549,090 (two million five hundred forty-nine thousand and ninety)

shares out of 2,549,092 (two million five hundred forty-nine thousand and ninety-two) existing shares, all with a nominal
value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, together representing more than three-quarters of the issued share capital of
the Company and held by a majority in number of the shareholders of the Company, are duly represented at the Meeting,
which is thus duly constituted in accordance with article 16, paragraph 3 of the Articles and may validly deliberate and
decide upon all the items of the agenda;

IV.- that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Approval of the reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 23,400,000 (twenty-three

million four hundred thousand Euros), in order to bring it from its present amount of EUR 63,727,300 (sixty-three million
seven hundred and twenty-seven thousand and three hundred Euros) to an amount of EUR 40,327,300 (forty million
three hundred and twenty-seven thousand and three hundred Euros) by way of the repayment and subsequent cancellation
of 936,000 (nine hundred and thirty-six thousands) class A and B ordinary shares in the Company, each with a par value
of EUR 25 (twenty-five Euros);

2. Approval of the subsequent amendment of article 6 of the Articles in order to reflect the reduction of the share

capital specified under item 2. above;

3. Empowerment and authorisation given to any manager of the Company or any attorney or employee of Allen &amp;

Overy Luxembourg, each acting individually, in the name and on behalf of the Company, to arrange and carry out any
necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the above agenda items and generally to
perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto; and

4. miscellaneous.
V.- that the Shareholders take the following resolutions, the shareholder Corinne Namblard abstaining:

<i>First resolution

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company (the Capital Reduction) by EUR 23,400,000 (twenty-

three millions four hundred thousand Euros), to bring it from its present amount of EUR 63,727,300 (sixty-three million
seven hundred and twenty-seven thousand and three hundred Euros) to an amount of EUR 40,327,300 (forty million
three hundred and twenty-seven thousand and three hundred Euros) by way of the repayment and subsequent cancellation
of 936,000 (nine hundred and thirty-six thousands) class A and B ordinary shares in the Company, each with a par value
of EUR 25 (twenty-five Euros), having an aggregate value of EUR 23,400,000 (twenty-three millions four hundred thousand
Euros) (the Cancellation Amount).

The Meeting acknowledges that the Cancellation Amount will be paid in cash to the respective holders of class A and

B ordinary shares (the Cash Payment).

The Meeting resolves to acknowledge and approve that the Company's board of managers (conseil de gérance) shall

proceed to the Cash Payment in accordance with article 19 (b) (vi) of the Articles.

145650

L

U X E M B O U R G

The Meeting resolves to record that the shareholding of the Company is, further to the above share capital reduction,

as follows:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645,232 class B ordinary shares;
KfW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322,616 class B ordinary shares;
Caisse des Dépôts et Consignations: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645,232 class A ordinary shares;
Corinne NAMBLARD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 class C ordinary shares;

Patrick DAGUET: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 class C ordinary shares;

and Sylvie FERLET: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 class C ordinary shares.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend and hereby amend article 6 of the Articles in order to reflect the resolution above,

so that they shall henceforth read as follows:

Art. 6. Capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 40,327,300 (forty million three hundred and

twenty-seven thousand and three hundred Euro) represented by 1,613,092 (one million six hundred and thirteen thousand
and ninety-two) shares, all having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) per share each divided into 645,232 (six
hundred and forty five thousand two hundred and thirty-two) Class A Ordinary Shares, 967,848 (nine hundred and sixty-
seven thousand eight hundred and forty-eight) Class B Ordinary Shares and 12 (twelve) Class C Ordinary Shares. Up to
a maximum number of 12, additional C Ordinary Shares will eventually be allocated to the Key Managers and certain MC
Managers, pursuant to the terms of the Protocol for the Managers.

The capital reaches EUR 1,000,000 (one million euro) as provided under the SICAR Law, and thereafter may not be

less than this amount.

Any holder of Share(s) must qualify as a well-informed investor within the meaning of Article 2 of the SICAR Law (a

Well Informed Investor). For the avoidance of doubt, the managers and the other persons involved in the management
of the Company are regarded as Well-Informed Investors for the purpose of Article 2 of the SICAR Law".

<i>Third resolution

The Meeting further resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above cancellation

of shares and hereby empowers and authorizes any manager of the Company or any attorney or employee of Allen &amp;
Overy Luxembourg to, each acting individually under his/her signature, proceed in the name and on behalf of the Company,
to the registration of the above cancellation of shares in the share register of the Company (including for the avoidance
of doubt, the filing and publication of documents with the relevant Luxembourg authorities) and to see to any formalities
in connection with the above resolutions.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 2,500.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Grand Duchy of Luxembourg on the day named at the beginning of

this document.

The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille douze, le huit novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Galaxy S.à r.l. SICAR une société

SICAR d'investissement en capital à risque de droit luxembourgeois ayant la forme d'une société à responsabilité limitée,
ayant son siège social au 2, Place de Metz L-1930 Luxembourg, étant immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73667 et ayant un capital social de 63.727.300 EUR (la Société). La Société a
été constituée sous la loi Luxembourgeoise le 29 décembre 1999 en vertu d’un acte de Me André-Jean-Joseph Schwacht-
gen,  notaire,  résidant  à  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  publié  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, C - numéro 233 du 28 mars 2000. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois, et
pour la dernière fois le 17 septembre 2009 en vertu d’un acte de Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – numéro 2048 du 19 octobre
2009,

L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures et présidée par Gabriel de la Bourdonnaye, de résidence professionnelle à

Luxembourg (le Président).

145651

L

U X E M B O U R G

Le Président désigne comme secrétaire Arlette Siebenaler, de résidence professionnelle à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Adrien Pastorelli, de résidence professionnelle à Luxembourg.
Le bureau constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. que les associés de la Société (les Associés) représentés à l'Assemblée et le nombre de parts qu'ils détiennent sont

mentionnés sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par le mandataire des
Associés.

Les procurations des Associés représentés à l’Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et

le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte afin d’être enregistrées avec ledit acte auprès des autorités
compétentes.

II.- qu'une convocation a bien été envoyée le 30 octobre 2012 à chaque associé conformément aux dispositions de

l'article 16 des Statuts;

III.- que d'après la liste de présence, il apparaît que 2.549.090 (deux millions cinq cent quarante-neuf mille quatre-vingt-

dix) parts sur les 2.549.092 (deux millions cinq cent quarante-neuf mille quatre-vingt-douze) parts sociales existantes,
toutes d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, représentant ensemble plus de trois quarts du capital
social libéré de la Société et détenu par une majorité en nombre des associés de la Société, sont dûment représentées à
l'Assemblée, qui est par conséquent dûment constituée en conformité avec les dispositions de l'article 16, paragraphe 3
des Statuts et qui peut en conséquence valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour;

IV.- que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Approuver la réduction du capital social de la Société d'un montant de 23.400.000 EUR (vingt-trois millions quatre

cent mille Euros), afin de le porter de son montant actuel de 63.727.300 EUR (soixante-trois millions sept cent vingt-sept
mille trois cents Euros) à un montant de 40.327.300 EUR (quarante millions trois cent vingt sept mille trois cents Euros)
par le remboursement et l'annulation subséquente de 936.000 (neuf cent trente-six mille) parts sociales ordinaires de
catégories A et B de la Société ayant chacune une valeur nominale de 25 EUR (vingt cinq Euros);

2. Approuver la modification consécutive de l'article 6 des Statuts en vue de refléter la réduction de capital social

mentionnée au point 2. ci-dessus;

3. pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou avocat ou employé d'Allen &amp; Overy Luxembourg chacun

agissant individuellement, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités Lu-
xembourgeoises  relativement  aux  points  de  cet  ordre  du  jour  et  de  manière  générale  accomplir  toutes  les  actions
nécessaires ou utiles en relation avec les présentes; et

4. Divers.
V.- L'Assemblée prend les résolutions suivantes, l’actionnaire Corinne Namblard s’abstenant:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société (la Réduction du Capital) d'un montant de 23.400.000

EUR (vingt-trois millions quatre cent mille Euros), afin de le porter de son montant actuel de 63.727.300 EUR (soixante-
trois millions sept cent vingt-sept mille trois cents Euros) à un montant de 40.327.300 EUR (quarante million trois cent
vingt-sept mille trois cents Euros) par voie de remboursement et d'annulation subséquente de 936.000 (neuf cent trente-
six mille) parts sociales ordinaires de catégories A et B de la Société ayant chacune une valeur nominale de 25 EUR (vingt
cinq Euros) et ayant une valeur totale de 23.400.000 EUR (vingt-trois millions quatre cent mille Euros) (le Montant de
l'Annulation).

L'Assemblée est informée que le Montant de l'Annulation sera payé en espèces (le Paiement en Espèces) aux détenteurs

des parts sociales ordinaires A et B.

L'Assemblée est également informée et autorise le conseil de gérance à déterminer, conformément à l'article 19 (b)

(vi) des Statuts, les modalités du Paiement en Espèces aux détenteurs des parts sociales ordinaires A et B.

L'Assemblée décide de prendre acte que suite à la Réduction du Capital ci-dessus, l'actionnariat de la Société est le

suivant:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645.232 parts sociales ordinaires B;
KfW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.616 parts sociales ordinaires B;
Caisse des Dépôts et Consignations: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645.232 parts sociales ordinaires A;
Corinne NAMBLARD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 parts sociales ordinaires C;

Patrick DAGUET: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 parts sociales ordinaires C; et

Sylvie FERLET: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 parts sociales ordinaires C.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts en vue de refléter la résolution ci-dessous, de sorte qu’il aura

la teneur suivante:

Art. 6. Capital. Le capital social souscrit de la Société est de EUR 40.327.300 (quarante millions trois cent vingt sept

mille trois cents Euros) représenté par 1.613.092 (un million six cent treize mille quatre-vingt-douze) Parts Sociales d'une

145652

L

U X E M B O U R G

valeur de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune, divisées en 645.232 (six cent quarante cinq mille deux cent trente-deux)
Parts Sociales Ordinaires A, 967.848 (neuf cent soixante-sept mille huit cent quarante-huit) Parts Sociales Ordinaires B
et 12 (douze) Parts Sociales Ordinaires C. Un maximum de 12 (douze) Parts Sociales Ordinaires C additionnelles pourra
éventuellement  être  alloué aux Dirigeants-clé et  à  certains  Cadres SG conformément  aux termes du Protocole  des
Gestionnaires.

Le capital social atteint EUR 1.000.000 (un million d'euros), tel que prévu dans la Loi SICAR sur la liste officielle des

SICARs luxembourgeoises, et ne peut ultérieurement être inférieur à ce montant.

Tout détenteur de Part(s) Sociale(s) doit se qualifier en tant qu'investisseur averti dans le sens de l'Article 2 de la Loi

SICAR (un Investisseur Averti). Afin d'éviter tout doute, les gérants et autres personnes impliquées dans la gestion de la
Société sont considérés comme des Investisseurs Avertis pour les besoins de l'Article 2 de la Loi SICAR."

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société de façon à y refléter l'annulation des parts

sociales susmentionnée et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, ou avocat ou employé d'Allen &amp; Overy
Luxembourg, agissant individuellement au nom de la Société de procéder à l'enregistrement de l'annulation des parts
sociales de la Société (en ce compris, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités compétentes) et
d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès des autorités Luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre
du jour.

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.500.-. Le notaire soussigné qui comprend et parle
anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version
française; à la requête de cette même partie, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: G. DE LA BOURDONNAY, A. BRAQUET, A. PASTORELLI, Y. MURSCHEL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53419. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150258/211.
(120198374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Aero Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 154.881.

Par la présente, en ma qualité d'administrateur de la société AERO MARKETING SA, je vous informe démissionner

avec effet immédiat au jour de la présente, des fonctions d'administrateur de la société anonyme de droit luxembourgeois,
AERO MARKETING SA, établie et ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener, constituée en date du
26 Juillet 2010 par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame, et im-
matriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.154881.

Luxembourg, le 1 

er

 Novembre 2012.

Maître Alain LORANG.

Référence de publication: 2012150699/13.
(120198147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

ESCO Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.340.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 19 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

145653

L

U X E M B O U R G

Esch/Alzette, le 19 octobre 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012150708/13.
(120198111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

FREIF Wind Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 164.025.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 19 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 19 octobre 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012150712/13.
(120198103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Global Fund House Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 141.046.

In the year two thousand twelve, on the twelfth of November.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Glenmore &amp; Waldorf B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of Netherlands, having its

registered office at 48a, Prins Hendrikkade, NL-1012 AC Amsterdam, The Netherlands, registered with the Chambre de
Commerce under number 32128438, here represented by Mrs Esther RAUDSZUS, employee, residing at L-1246 Lu-
xembourg, 2a, rue Albert Borschette, by virtue of a proxy given in Hilversum (NL) on 12 

th

 November, 2012.

Which proxy, after being signed “ne varietur” by the mandatory and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have requested the notary to enact the following:
- That " GLOBAL FUND HOUSE MANAGEMENT SÀRL”, a private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, has been incorporated pursuant
to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg on August 8 

th

 , 2008 and published at the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2268 dated September 17 

th

 , 2008;

- That the articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the same notary dated

February 11 

th

 , 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 623 dated April

nd

 , 2011.

- That the share capital of the Company amounts to one hundred twenty-five thousand Euro (125.000.- EUR), repre-

sented by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one thousand Euro (1.000.-EUR) each;

- That the appearing party is the current partner of the Company;
- That the appearing party fixed the agenda as follows:

<i>Agenda

1. Change of the registered office of the Company to 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
2. Subsequent amendment of article 5, first paragraph of the Articles of Association of the Company;
3. Miscellaneous.

<i>First resolution

The Partner decided to transfer the registered office of the Company from L-1246 Luxembourg, 2a, rue Albert Bor-

schette to L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

<i>Second resolution

The partner decides furthermore to subsequently amend article 5, first paragraph of the Articles of Association of the

Company as follows:

145654

L

U X E M B O U R G

“ Art. 5. First paragraph. The Company has its registered office in the municipality of Niederanven.”
There being nothing else on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille douze, le douze novembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Glenmore &amp; Waldorf B.V., une private limited liability company constituée sous le droit des Pays-Bas, établie et ayant

son siège social à 48a, Prins Hendrikkade, NL-1012 AC Amsterdam, Pays-Bas, inscrite à la Chambre de Commerce sous
le numéro 32128438, ici représenté par Madame Esther RAUDSZUS, employée, demeurant professionnellement à L-1246
Luxembourg, 2a, rue Albert Borschette, en vertu d’une procuration délivrée à Hilversum le 12 novembre 2012.

Ladite procuration, après signature “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que GLOBAL FUND HOUSE MANAGEMENT SÀRL, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2a,

rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de
résidence à Luxembourg en date du 8 août 2008 et publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le
numéro 2268 du 17 septembre 2008;

- Que les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du même notaire, en date du 11

février 2011, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 623 du 2 avril 2011.

- Que le capital social de la Société s’élève à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR), représenté par cent vingt-

cinq (125) actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune;

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de la Société.
- Que la comparante a fixé l’ordre du jour comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la Société au 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg;
2. Modification subséquente de l’article 5, alinéa 1 

er

 des statuts de la Société;

3. Divers.

<i>Première résolution

L’associé décide de transférer le siège social de la société de L-1246 Luxembourg, 2a, rue Albert Borschette à L-2633

Senningerberg, 6, route de Trèves.

<i>Deuxième résolution

L’associé décide également de modifier en conséquent l’article 5, alinéa 1 

er

 des statuts de la Société pour leur donner

la teneur suivante:

“  Art. 5. Alinéa 1 

er

 .  Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.”

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance a été levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparant le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

145655

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: E. Raudszus et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53384. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150280/97.
(120198386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

FREIF Wind Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 164.717.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 19 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 19 octobre 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012150713/13.
(120198107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

L.C.A. S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7653 Heffingen, 3, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 165.829.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 18 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 18 octobre 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012150718/13.
(120198100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

NameBox Cy, Société Anonyme,

(anc. LGS).

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 150.124.

L'an deux mille douze, le huit novembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LGS, ayant son siège social à L-1212

Luxembourg, 3, rue des Bains, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 150.124,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 139 du 22 janvier 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathanaëlle Gwendoline Doriane Gersende CLEENEWERCK

de CRAYENCOUR, attachée commerciale, domiciliée Rue Mattot, 67 à 1410 Waterloo (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Madame Donatienne Eliane Rolande Marie Ghislaine de FRAIPONT, sans profession,

domiciliée Rue La Falise 32, à 1470 Genappe (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bernard Xavier Marie Ghislain CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,

gérant de sociétés, domicilié Rue La Falise 32, à 1470 Genappe (Belgique).

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

145656

L

U X E M B O U R G

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination sociale en NameBox Cy.
2. Modification afférente de l'article 1 

er

 des statuts.

3. Divers.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en NameBox Cy de sorte que l'article 1 

er

 des statuts aura

désormais la teneur suivante:

“Il existe une société anonyme sous la dénomination de NameBox Cy.”
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. G. D. G. CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, D. E. R. M. G. DE FRAIPONT, B. X. M. G. CLEENEWERCK

DE CRAYENCOUR et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53421. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150400/54.
(120198381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Security Capital (EU) Management Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 51.782.

Statuts coordonnés, suite à une augmentation du capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à

Esch/Alzette, en date du 12 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 12 octobre 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012150729/13.
(120198099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

SKOK Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 133.842.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 19 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

145657

L

U X E M B O U R G

Esch/Alzette, le 19 octobre 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012150730/13.
(120198109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Blue Sky SPV 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 146.571.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jan Willem OVERHEUL
<i>Gérant

Référence de publication: 2012150791/11.
(120199610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

Foncière Esterel SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 146.054.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FONCIERE ESTEREL SA
Société Anonyme

Référence de publication: 2012150944/11.
(120199615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

S.C.I. Kenza, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8289 Kehlen, 24, Am Duerf.

R.C.S. Luxembourg E 4.727.

DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le six novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Christiane HANSENNE, née le 2 juillet 1954 à Verviers (Belgique), demeurant à L-8289 Kelhen, 24, Am Duerf,

agissant en tant que mandataire de:

1.- Madame Suzanne Louise FANDEL, retraitée, née à Fécamp (Belgique) le 4 février 1919, demeurant à L-8289 Kelhen,

24, Am Duerf, propriétaire de quatre-vingt-dix-huit (98) parts d’intérêts, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé en date du 6 novembre 2012;

2.- Monsieur Thierry Joseph Roland SAUGERON, étudiant, né à Luxembourg le 6 août 1992, demeurant à L-8289

Kelhen, 24, Am Duerf, propriétaire de une (1) part d’intérêt, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date
du 6 novembre 2012;

3.- Monsieur Nicolas Michel Jocelyn SAUGERON, étudiant, né à Luxembourg le 24 juin 1987, demeurant à L-8289

Kelhen, 24, Am Duerf, propriétaire de une (1) part d’intérêt, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date
du 16 juillet 2012;

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées “ne varietur” par la mandataire des comparants et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont exposé et requis au notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société civile immobilière “S.C.I. KENZA”, ayant son siège social au 24,

Am Duerf L-8289 Kelhen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section E, numéro
4727, ("la Société"), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 février 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1065 le 26 avril 2012.

Les associés décident de dissoudre avec effet immédiat la Société qui n’a jamais connu d’activité et ne possède aucun

immeuble.

145658

L

U X E M B O U R G

Décharge pleine et entière est accordée par les comparants à la gérante de la Société pour l’exercice de son mandat

à ce jour.

Il sera procédé à la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg suite à

la radiation de la Société.

Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au 24, Am Duerf K-8289 Kelhen.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à mille euros (1.000,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connu du notaire par son nom, prénoms

usuels, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. HANSENNE, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52138. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150541/47.
(120198475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Pecunia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 65.260.

L'an deux mille douze, le neuf novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de "PECUNIA S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 65260, constituée par acte de Maître Georges d’HUART,
alors notaire de résidence à Pétange, en date du 24 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 689 du 25 septembre 1998.

Les statuts ont été modifiés par acte de Maître Joseph ELVINGER en date du 11 novembre 2002, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1818 du 27 décembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au

18, rue de l’Eau, L–1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKE, employée privée, domiciliée profession-

nellement au 74, avenue Victor Hugo, L–1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L–1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante

(1.250) actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de neuf cent soixante mille neuf cent
quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 960.986,69) sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l'ordre  du  jour,  ci-après  reproduits,  tous  les  actionnaires  représentés  ayant  accepté  de  se  réunir  sans  convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

145659

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L.,

ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L–1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la
liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Zianveni, M. Krecké, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 novembre 2012. LAC/2012/53107. Reçu douze euros EUR 12,-

<i>Le Receveur

 (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150496/52.
(120198409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Société de la Bourse de Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 6.222.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Maurice Bauer.

Référence de publication: 2012150582/10.
(120198151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Dekan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 109.200.

Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DEKANS.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2012151626/11.
(120200004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Càput International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 67.642.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012151541/9.
(120199928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Star-One, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 98.455.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012152035/9.
(120199734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

145660

L

U X E M B O U R G

The Private Equity Company SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 84.556.

Les comptes annuels au 30 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012152053/9.
(120199738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Mako Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8023 Strassen, 20, rue du Genêt.

R.C.S. Luxembourg B 172.760.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twelfth of November.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr. Thomas Baumgartner, citizen of Switzerland, born May 26th 1965 in Thalwil, Switzerland, residing at 20, rue du

Genêt, L-8023 Strassen, duly represented by Mr. Erwin VANDE CRUYS, employee, having his professional address in
L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 6 November 2012.

The said proxies, signed "ne varietur" by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité

limitée, which they wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of Mako Capital S.à r.l. (the
"Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more  generally  any  securities  and/or  financial  instruments  issued  by  any  public  or  private  entity  whatsoever.  It  may
participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make
direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debtor equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the
financial sector.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate

to its object.

145661

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Registered office.
4.1. The Company's registered office is established in the municipality of Strassen.
4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1.  The  Company's  share  capital  is  set  at  twelve  thousand  five  hundred  euro  (EUR  12,500)  consisting  of  twelve

thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

5.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder. In case of plurality

of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in
the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such preferential
subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a
registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting
of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential
subscription right of the existing shareholder. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment
of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1. The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

6.3. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company's share capital.

6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed

shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6. The Company's shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.
7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of shares.
8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3. The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be trans-

ferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor,
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law,
the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

145662

L

U X E M B O U R G

8.4. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or

in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead

of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in

the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice
of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.

10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Quorum and vote
11.3.1. Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly

passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.

11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

145663

L

U X E M B O U R G

11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them

to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board
of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting

alone or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.
16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his own revocation.

16.3. Any manager shall hold office until his successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive

terms.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members

145664

L

U X E M B O U R G

of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his absence, the

board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2. Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least a majority of its members (ii) including one class

A and one class B managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

18.3. Vote
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, including at

least one class A manager and one class B manager. The chairman shall not have a casting vote.

18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his colleagues.

18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7. Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of

the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his resolutions.
19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the

signature of the sole manager or in case of plurality of managers by the joint signatures of a class A manager and a class
B manager or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been
delegated by the board of managers or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the
signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting
alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.

21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

145665

L

U X E M B O U R G

21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7. If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law  of  19  December  2002  regarding  the  Trade  and  Companies  Register  and  the  accounting  and  annual  accounts  of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

Art. 23. Profits.
23.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal

reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

23.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends - Share premium.
24.1. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,

under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions have been satisfied.

24.2. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 25 Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26 Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on December

31 

st

 , 2013.

2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

Thereupon the prenamed Shareholder of the Company, duly represented as stated above, declared to subscribe 12,500

(twelve thousand five hundred) Shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, and to make a payment in full
for the Shares and the share premium by a contribution in kind, consisting of 75 percent of the shares (Gesellschafte-
ranteile), in Rubber-Products &amp; Technologies GmbH, having its registered office at 53177 Bonn, Am Kurpark 7, registered
with the Amtsgerichts Bonn under number B18 853, held by the Shareholder, such contribution amounting in total to
EUR 55,836 (fifty-five thousand eight hundred thirty-six Euros) (the "Contribution").

145666

L

U X E M B O U R G

Such Contribution of EUR 55,836 (fifty-five thousand eight hundred thirty-six Euros) is to be allocated as follows:
(i) The amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) is allocated to the nominal capital amount of

the Company; and

(ii) The amount of EUR 43,336 (forty-three thousand three hundred thirty-six Euros) is to be allocated to a share

premium account of the Company.

It appears from a "Valuation certificate" prepared by the founding member and designated manager of the Company

and presented to the notary that the founding member and the designated sole manager of the company have evaluated
the Contribution at least at EUR 55,836 (fifty-five thousand eight hundred thirty-six Euros), which therefore is worth at
least the nominal value of the Shares issued in consideration and connected share premium.

Thereupon, it is resolved to accept the aforementioned subscription and Contribution. As a result, it is recorded that

the shareholding in the Company is as follows:

- Mr. Thomas Baumgartner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 shares

<i>Effective implementation of the contribution

The Shareholder declares that:
- he has the sole legal and beneficial title and right over the Contribution and possesses the power to assign it, it being

legally and conventionally freely transferable; and

- all further formalities are in course in the country of the location of the Contribution in order to duly carry out and

formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward the Rubber-Products &amp; Technologies GmbH and
any third party.

Proof of the existence, the value and the free transferability of the Contribution has been given to the Company, as it

has been justified to the undersigned notary.

The founding member of the Company declares that it will accomplish all formalities concerning the valid transfer to

the Company of the aforementioned contributions.

The aforementioned "Valuation certificate" shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with

the registration authorities.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand four hundred euro (EUR
1,400).

<i>General meeting of shareholders

The incorporating shareholders, representing the Company's entire share capital and considering themselves as duly

convened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. Having first verified that it was regularly
constituted, the general meeting of shareholders has passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of the board of managers is fixed at one (1).
2. The following person is appointed as sole manager of the Company for un unlimited period:
a) Mr. Thomas Baumgartner, prenamed;
3. The address of the Company's registered office is set at 20, rue du Genêt, L-8023 Strassen.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with

the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzwölf, am zwölften November.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Lu-

xemburg.

Ist erschienen:

Herr Thomas Baumgartner, schweizer Staatsangehöriger, geboren am 26. Mai 1965 in Thalwil, Schweiz, wohnhaft in

20, rue du Genêt, L-8023 Strassen, ordnungsgemäß vertreten durch Herr Erwin VANDE CRUYS, Angestellter, mit be-
ruflicher Adresse in L-1750 Luxemburg, 74, Avenue Victor Hugo, kraft einer in Luxemburg am 6. November 2012 erteilten
Vollmacht.

145667

L

U X E M B O U R G

Welche Vollmachten, nachdem sie „ne varietur" von den Komparenten und dem amtierenden Notar unterschrieben

wurden, der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt werden, um mit derselben einregistriert zu werden.

Solch erschienene Parteien haben die Notarin ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée

aufzunehmen, welche sie gründen möchten und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die

künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma Mako
Capital S.à r.l." (die "Gesellschaft").

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen

Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.
3.1. Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an luxemburgischen oder

ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen, sowie die Verwaltung, die Steuerung und die Entwicklung solcher Be-
teiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Rentenwerte, Geld-
markteinlagen und andere Schuldtitel aller Art durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonst wie erwerben, und im
Allgemeinen alle Wertschriften und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder
Art ausgegeben  werden.  Sie kann  an  der Gründung,  Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht  aller  Gesellschaften  oder
Unternehmen teilnehmen. Des Weiteren kann sie die direkten oder indirekten Immobilienanlagen weiterbilden und in
den Erwerb und die Verwaltung eines Bestands von Patenten oder anderen geistigen Eigentumsrechten jeder Art oder
jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen, außer auf dem Wege von öffentlichen Anleihen. Sie kann,

jedoch nur durch Privatplatzierung, Schuldscheine, Anleihen und Rentenwerte, sowie jede Art von Schuldtiteln und/oder
Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel verleihen, einschließlich und ohne Begrenzung, der Erlöse
aus Kreditverbindlichkeiten und/oder Emissionen von Schuld- oder Dividendenpapieren an ihre Zweigunternehmen, an-
gegliederte  Gesellschaften  und/oder  jede  andere  Gesellschaft.  Die  Gesellschaft  kann  in  Bezug  auf  ihr  gesamtes  oder
teilweises Vermögen Sicherheiten leisten; sie kann verpfänden, übertragen, belasten oder sonst Sicherheiten bestellen
und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und Vereinbarungen und/oder den Verpflichtungen und Vereinbarungen
jeder anderen Gesellschaft nachzukommen und diese im Allgemeinen zu eigenem Nutzen und/oder zum Nutzen jeder
anderen Gesellschaft oder Person abzusichern, ohne dass diese Tätigkeiten den Reglementierungen des Finanzdienstleis-
tungssektors unterliegen.

3.3. Mit dem Ziel einer effizienten Verwaltung kann sich die Gesellschaft im Allgemeinen in Bezug auf ihre Anlagen aller

Techniken und Instrumente bedienen, einschließlich der Techniken und Instrumente, die dazu gedacht sind, die Gesell-
schaft gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz-und andere Risiken abzusichern.

Die Gesellschaft darf im Allgemeinen alle Tätigkeiten und alle Transaktionen ausführen, die dazu bestimmt sind, ihren

Gesellschaftszweck zu fördern oder die sich auf ihren Gesellschaftszweck beziehen.

Art. 4. Sitz.
4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Strassen.
4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-

rerrats verlegt werden.

4.3. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxem-

burg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich
ist.

4.4.  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  im  Großherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland

durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Ge-

schäftsanteilen

Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) bestehend aus zwölftau-

sendfünfhundert (12,500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.

5.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesell-

schafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erfor-
derlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3. Alle neuen Geschäftsanteile, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden/dem bestehenden

Gesellschafter(n) zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden solche Geschäftsanteile den
Gesellschaftern im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Stammkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Geschäfts-

145668

L

U X E M B O U R G

anteile angeboten. Der Geschäftsführerrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Anteilsbezugs-
recht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines
an die Gesellschafter/den Gesellschafter gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung an-
kündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um
über eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft zu bestimmen, das bevorzugte Anteilsbezugsrecht der bestehen-
den Gesellschafter/des bestehenden Gesellschafters begrenzen oder aufheben. Ein solcher Beschluss muss in der Weise
gefasst werden wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig

(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

6.3. Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl

der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.

6.4. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betref-

fend den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.

6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-

gekauften  oder  zurückgenommenen  Geschäftsanteile  werden  sofort  gelöscht  und  das  Stammkapital  entsprechend
herabgesetzt.

6.6. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-

schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

7.2. Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung

mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1. Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-

schafterverzeichnis  erbracht  werden.  Auf  Ersuchen  und  auf  Kosten  eines  Gesellschafters  werden  Zertifikate  dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-

sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.

8.3. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter

Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4. Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des

Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber
der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Ge-
sellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das
Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.

8.5. Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen

und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1. Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe

der Gesellschaft bildet.

145669

L

U X E M B O U R G

9.2. Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-

terversammlung  aus.  In  einem  solchen  Fall,  soweit  anwendbar  und  wo  der  Begriff  "alleiniger  Gesellschafter"  nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
"Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.

9.3. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich

verliehenen Befugnisse.

9.4. Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,

statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.

Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die

satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-

sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

10.3. Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit

der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

10.4. Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass

sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1. In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-

denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2. In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3. Quorum und Stimmabgabe
11.3.1. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2. Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-

schafterbeschlüsse bei  der  ersten  Abstimmung  wirksam  gefasst,  wenn sie  von  Gesellschaftern angenommen  werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

11.4. Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,

Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5. Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz,

Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesell-
schafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durch-
gehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und
Mehrheit anwesend ist.

11.6. Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-

formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag  drei  Kästchen  enthalten,  die  es  dem  Gesellschafter  ermöglichen,  seine  Stimme  zugunsten  oder  gegen  den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-

145670

L

U X E M B O U R G

sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.

11.7. Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden

müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag

durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.

Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern

sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

13.2. Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Be-

schlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

13.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen

oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein

müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat"
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.

14.2. Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

14.3. Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts

können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.

14.4. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede

Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten

des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.

Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1. Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit

festlegt.

16.2. Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen

werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.

16.3. Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer

kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1. Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner

Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

17.2. Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung

anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort

145671

L

U X E M B O U R G

stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.

18.1. Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner

Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen

18.2. Quorum

Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mit-

glieder an der Sitzung anwesend oder vertreten ist inklusive einem Kategorie A und einem Kategorie B Geschäftsführer.

18.3. Abstimmung

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder

vertretenen  Mitglieder  gefasst,  inklusive  wenigstens  einem  Kategorie  A  Geschäftsführer  und  einem  Kategorie  B  Ge-
schäftsführer. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

18.4. Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein

anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5. Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-

okonferenz  oder  durch  ein  anderes  Kommunikationsmittel  teilnimmt,  welches  es  ermöglicht,  dass  dieses  Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet,  dass  eine  durch  solche  Kommunikationsmittel  abgehaltene  Sitzung  am  eingetragenen  Sitz  der  Gesellschaft
abgehalten wurde.

18.6. Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in

einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

18.7. Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt

oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss
den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreff-
enden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage
stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat
und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt
ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Inte-
ressenskonflikt  im  Protokoll  über  die  betreffende  Transaktion  aufgenommen  werden.  Dieser  Artikel  18.7  ist  nicht
anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.

19.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung

des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

19.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.

19.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden

sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die Unterschrift

des alleinigen Geschäftsführers oder, im Fall von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift eines
Kategorie A Geschäftsführers und eines Kategorie B Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die
alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäfts-
führerrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den
Grenzen einer Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauf-
tragten gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich
übertragen wurde.

145672

L

U X E M B O U R G

E. Aufsicht

Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder

mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

21.2. Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und

ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3. Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung

abberufen werden.

21.4. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Ge-

schäfte der Gesellschaft.

21.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten

der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

21.6. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher

aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.

21.7. Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am ein-

unddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Gewinne.
23.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme
der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2. Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage

zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

23.3. Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt

werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

23.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafter-

versammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.

Art. 24. Zwischendividenden - Emissionsagio.
24.1. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Vo-

raussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende
Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der
Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu
diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die
gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesell-
schaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen
erfüllt sind.

24.2. Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei
an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

145673

L

U X E M B O U R G

H. Anwendbares Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-

burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2013.

2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Darauf erklärt der zeichnenden Gesellschafter, vertreten wie oben erwähnt 12,500 (zwölftausendfünfhundert) Ge-

schäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 1,00 (ein Euro) wie folgt zu zeichnen gegen Sacheinlage von fünfundsiebzig
Prozent der Gesellschafteranteile der Rubber-Product &amp; Technologies GmbH, mit Sitz in 53177 Bonn, Am Kurpark 7,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter Nummer B18 853, gehalten von den zeichnenden Gesell-
schafter, zu einer Summe von EUR 55,836 (fünfundfünfzigtausendachthundertsechsunddreißig Euro) (die „Sacheinlage").

Die Sacheinlage von EUR 55,836 (fünfundfünfzigtausendachthundertsechsunddreißig Euro) wird wie folgt verteilt:
(i) Eine Summe von EUR 12,500 (zwölftausendfünfhundert Euro) wird einbezahlt als Stammkapital der Gesellschaft;

und

(ii) Die Summe von EUR 43,336 (dreiundvierzigtausenddreihundertsechsunddreißig Euro) wird der Agioreserve der

Gesellschaft zugerechnet.

Laut „Valuation Certificate", ausgestellt von den zeichnenden Gesellschafter und beabsichtigter Geschäftsführer der

Gesellschaft, und den Notar vorgelegt, haben den zeichnenden Gesellschafter und beabsichtigter Geschäftsführer die
Sacheinlage bewertet auf eine Summe von zumindest EUR 55,836 (fünfundfünfzigtausendachthundertsechsunddreißig Eu-
ro) was zumindest den Wert des im Gegenzug zu zeichnenden Stammkapitals und den des Agios entspricht.

Darauf wird entschieden die erwähnte Sacheinlage und Zeichnung der Gesellschaftsanteile zu akzeptieren. Es folgt das

die Gesellschaftsanteile wie folgt gezeichnet werden:

- Herr Thomas Baumgartner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Anteile

<i>Effektive Umsetzung der Sacheinlage

Den zeichnenden Gesellschaftern erklärt das.
- er die alleinige juristische und wirtschaftliche Verfügungsmacht über die Sacheinlage hat sowie die Befugnis diese zu

übertragen und dass die Sacheinlage juristisch und vertraglich frei übertragbar ist; und

- allen notwendigen Formalitäten zur vollständigen Übertragung der Sacheinlage, und deren Gültigkeit gegenüber der

Rubber-Products &amp; Technologies GmbH und sämtliche Drittparteien im Gange gesetzt wurden.

Jegliche Beweise der Existenz, der Wert und die Übertragbarkeit der Sacheinlage wurden der Gesellschaft überreicht

sowie gegenüber den Notar ausreichend nachgewiesen.

Der zeichnenden Gesellschafter verbindet sich allen notwendigen Formalitäten zur rechtsgültigen Übertragung der

Sacheinlage auf die Gesellschaft durchzuführen.

Das erwähnte Valuation Certificate wird der Urkunde beigelegt und mit diese beim zuständigen Amt hinterlegt.

<i>Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf eintausendvierhundert Euro (EUR 1,400) geschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Die Gründungsgesellschafter, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren und die sich selbst als ord-

nungsgemäß geladen erachten, haben sofort eine Gesellschafterversammlung abgehalten. Nachdem die Gesellschafter-
versammlung zunächst überprüft hat, ordnungsgemäß konstituiert zu sein, hat sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins (1) festgesetzt.
2) Die folgende Person wird für eine unbestimmte Dauer als einziger Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
a) Herr Thomas Baumgartner, vorbenannt;
3) Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 20, rue du Genêt, L-8023 Strassen
Die  unterzeichnete  Notarin,  die  Englisch  versteht  und  spricht,  erklärt  hiermit,  dass  die  Urkunde  auf  Anfrage  der

erschienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben er-
schienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische
Fassung vorrangig sein.

145674

L

U X E M B O U R G

Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten

Tag aufgenommen.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat der Bevollmäch-

tigte diese originale Urkunde zusammen mit der Notarin unterzeichnet.

Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53737. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150422/778.
(120198653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Yoaké Lounge Spa Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 98, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.546.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012152082/10.
(120199924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

3i GC Holdings Lab 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 152.368.

Les comptes annuels au 31 Mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Antoine Clauzel
<i>Gérant

Référence de publication: 2012152089/11.
(120199915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Scheffer Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 41.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154003/9.
(120202500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Skarman &amp; Skarman S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 71.698.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154017/9.
(120202521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

145675

L

U X E M B O U R G

LX Alpha Phi S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 155.583.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2012.

<i>Pour LX Alpha Phi S.C.A.
Représentée par LX Alpha S.à r.l.
<i>Gérant commandité
Stéphane Hépineuze
<i>Gérant de classe B

Référence de publication: 2012153855/16.
(120202938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Soluwatt s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 158.309.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012154020/10.
(120203057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

LSF5 Roundup Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 138.556.

In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of November.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg,

THERE APPEARED

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company {société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91796,

here represented by Ms. Josiane Meissener, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney, given in Luxembourg on 9 November 2012,

(the Shareholder).
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and by

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the

entire share capital of LSF5 Roundup Holdings S.à r.l. (the Company), a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée) established under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
138556,

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 13 May 2008, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations N°1414 of 9 June 2008, amended several times and for the last time by a deed of the
undersigned notary dated 9 January 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 618 of
8 March 2012.

The Shareholder, represented as stated above has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholder holds all the 100 (hundred) ordinary shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred

twenty-five euro) each, in the share capital of the Company which is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
euro),

II. that the Shareholder wishes to resolve on the following agenda:

145676

L

U X E M B O U R G

1. Decision to dissolve the Company and to begin on a voluntarily basis its liquidation process (liquidation volontaire);
2. Appointment of Mr Philippe Detournay as the Company's liquidator in relation to the voluntary liquidation of the

Company (the Liquidator);

3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company; and
4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their mandate.
After deliberation, the Shareholder agrees to pass the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to dissolve the Company and to begin on a voluntary basis its liquidation process (liquidation

volontaire).

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to appoint Mr. Philippe Detournay, private employee, born on 9 April 1966 in Hal (Belgium),

professionally residing at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, as the Company's Liquidator.

The Shareholder acknowledges that the Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation

of the Company and the disposal of its assets under his sole signature.

<i>Third resolution

The Shareholder resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the

Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Law).

The Shareholder also resolves to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances,

to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations

in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the
Shareholder. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several person
(s) or entity/ies, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation,

to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation
of the Company and the disposal of its assets.

The Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance

payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholder, in accordance with article
148 of the Law.

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolves to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken

by the managers of the Company up to the date of the present deed (the Effective Date), to waive any claim which the
Company may have against the managers of the Company arising as a result of their management of the Company and
to grant them discharge for the accomplishment of their mandate until the Effective Date.

<i>Costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1500.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le douze novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social à 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 91796,

ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Luxembourg le 9 novembre 2012,

(l'Associé).

145677

L

U X E M B O U R G

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la

société à responsabilité limitée dénommée LSF5 Roundup Holdings S.à r.l. (la Société), organisée sous le droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138556, constituée selon acte du notaire instrumentaire
en date du 13 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1414 du 9 juin 2008, modifié à
plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire du 9 janvier 2012, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations -N° 618 du 8 mars 2012 .

L'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire d'acter que:
I. l'Associé détient l'ensemble des 100 (cent) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent

vingt-cinq euros) chacune, dans le capital social de la Société, fixé à EUR 12.500,-(douze mille cinq cents euros);

II. l'Associé entend prendre des résolutions sur l'ordre du jour suivant:
1. Décision de dissoudre la Société et de procéder à l'ouverture de sa procédure de liquidation sur une base volontaire;
2. Nomination de Monsieur Philippe Detournay en tant que liquidateur de la Société en rapport avec la liquidation

volontaire de la Société (le Liquidateur);

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société; et
4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leur mandat.
Après délibération, l'Associé décide de prendre les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'Associé décide de dissoudre la Société et de procéder à l'ouverture de sa procédure de liquidation (sur une base

volontaire).

<i>Deuxième résolution

L'Associé décide de nommer Monsieur Philippe Detournay, employé privé, né le 9 avril 1966 à Hal (Belgique), de-

meurant professionnellement au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, comme Liquidateur de la Société.

L'Associé reconnaît que le Liquidateur a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et

à la réalisation de ses actifs sous sa seule signature.

<i>Troisième résolution

L'Associé décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et seq.

de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

L'Associé décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Associé décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé. Le
Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personne
(s) ou entité(s), tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Associé décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation,

afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatifs à tout contrat ou document requis pour la liquidation de
la Société et la liquidation de ses actifs.

L'Associé décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous verse-

ments d'avances en numéraire ou en nature du boni de liquidation à l'Associé, conformément à l'article 148 de la Loi.

<i>Quatrième résolution

L'Associé décide de reconnaître, d'approuver, de ratifier et d'adopter en tant qu'actes de la Société les actes accomplis

par les gérants de la Société jusqu'à la date du présent acte (la Date Effective), de renoncer à toute action que la Société
peut avoir contre les gérants de la Société en raison de leur gestion de la Société, et de leur accorder décharge pour
l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la Date Effective.

<i>Frais

Le montant des frais qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élève approximativement à EUR 1500.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

145678

L

U X E M B O U R G

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 novembre 2012. LAC/2012/53739. Reçu douze euros EUR 12,-

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150412/144.
(120198704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Spencer Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-4963 Clémency, 9, rue basse.

R.C.S. Luxembourg B 101.210.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clémency, le 26 Novembre 2012.

Référence de publication: 2012154022/10.
(120203300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

St. Georges Investment S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 34.251.

Les comptes annuels au 30-06-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154025/9.
(120203293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Staff Consulting &amp; Interim S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 25, rue Féderspiel.

R.C.S. Luxembourg B 45.732.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012154026/10.
(120202690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Steffen Salaisons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 8, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.788.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/11/2012.

Référence de publication: 2012154030/10.
(120202607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Val des Lauriers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 11, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 109.648.

L'an deux mille douze, le sept novembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «VAL DES LAURIERS S.A.»,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 5 juillet 2005, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 1347 du 8 décembre 2005.

145679

L

U X E M B O U R G

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges DEITZ, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse

professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 69.000.- (soixante-neuf mille euros) pour le porter de son

montant actuel de EUR 31.000.-(trente et un mille euros) à EUR 100.000.- (cent mille euros) sans émission d'actions
nouvelles.

2) Souscription à l'augmentation de capital et libération en espèces par les actionnaires actuels dans la proportion de

leur participation actuelle dans la Société.

3) Modification afférente de l'article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 69.000.- (soixante-neuf mille euros) pour le

porter de son montant actuel de EUR 31.000.- (trente et un mille euros) à EUR 100.000.- (cent mille euros) sans émission
d'actions nouvelles, par suppression de la désignation de valeur nominale des actions.

L'augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée en espèces par les actionnaires actuels, plus amplement

renseignés sur la liste de présence annexée aux présentes, dans la proportion de leur participation actuelle dans la Société,
de sorte que la somme de EUR 69.000.- (soixante-neuf mille euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) représenté par 31 (trente-et-

une) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, s'élève approximativement à la somme de
EUR 1.500.-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. DEITZ, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53416. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150645/60.
(120198368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

145680


Document Outline

1492i Investments &amp; Co S.C.A.

3i GC Holdings Lab 1 S.à r.l.

Aero Marketing S.A.

Aero Marketing S.A.

Blue Sky SPV 1 S.à r.l.

Captain Luxco 1 S.A.

Càput International S.A.

CEPF Bavaria Intermediate 2 &amp; Cy S.C.A.

Dekan S.A.

Ecolab lux 7 S.à r.l.

EPGF (Luxembourg), Sàrl

ESCO Luxembourg S.à r.l.

Eurolux Invest Group SC

Foncière Esterel SA

FREIF Wind Holdings II S.à r.l.

FREIF Wind Holdings S.à r.l.

Galaxy S.à r.l. SICAR

Global Fund House Management S.à r.l.

Joran S.à r.l.

L.C.A. S.à r.l.

LGS

Link Engineering S.A.

LSF5 Roundup Holdings S.à r.l.

LX Alpha Phi S.C.A.

Mako Capital S.à r.l.

NameBox Cy

Pecunia S.A.

Scheffer Participations S.A.

S.C.I. Kenza

Security Capital (EU) Management Holdings S.A.

Skarman &amp; Skarman S.A.

SKOK Holding S.à r.l.

Société de la Bourse de Luxembourg

Soluwatt s.à r.l.

Spencer Holding S.A.

Staff Consulting &amp; Interim S.àr.l.

Star-One

Steffen Salaisons S.A.

St. Georges Investment S.A. - SPF

Tacotec Packaging S.A.

Takeoff Investments S.A.

Take Up Investments S.A.

Thalie S.A.

The Private Equity Company SA

Top Sun s.à r.l.

Traction S.A.

TTG Cayuga Bavaria Intermediate 2 &amp; Cy S.C.A.

Val des Lauriers S.A.

Vap Restaurants S.A.

Whale International S.à r.l.

Wind Acquisition Finance S.A.

Yoaké Lounge Spa Luxembourg

Yuma Europe S.A.