This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2933
4 décembre 2012
SOMMAIRE
Agence Immobilière Mara Max S.àr.l. . . . .
140777
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A. . . .
140738
Altilands S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140740
Amalthee S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140742
Am Wenkel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140742
An der Klaus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140743
Ashmore Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140741
Askania S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140743
Avant Ireland Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .
140740
Avantor Performance Materials Holdings
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140738
Axo Compagnie Hôtelière S.à r.l. . . . . . . . .
140742
Azure Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140741
Barguzin Participation S.A. . . . . . . . . . . . . .
140749
Belfius Insurance Services Finance . . . . . . .
140747
Bio-cafes SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140746
BlackRock Alternative Strategies . . . . . . . .
140746
BLACKROCK Fund Management Compa-
ny S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140749
Blue Fin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140743
Boesen Ihr Gärtner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140750
Bois-Matériaux Willy Putz Sàrl . . . . . . . . . .
140754
Borderline Investholding S.A. . . . . . . . . . . .
140754
Bortran S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140755
BRE/CP Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
140756
Broadstreet Continental Finance S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140756
Broadstreet International Partners S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140747
Broadstreet Mexico S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
140748
Broadstreet of Münsbach S.à r.l. . . . . . . . . .
140747
Broadstreet S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140748
BSI Art Collection S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
140774
Cardoso S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140779
Cavalcade S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140779
CBM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140781
Cedar Capital Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
140776
Cerampart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140779
Chamberley S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140779
Chricat Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140780
Clermon Holding Company S.A. . . . . . . . .
140780
Clyde Blowers Capital (RCP) S.à r.l. . . . . .
140777
CMP German Opportunity Fund II (SCA)
SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140780
CMP German Opportunity Investors Fund
II (SCS) SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140780
C.M.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140773
Comptoir des Fournitures Industrielles du
Bâtiment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140783
Creo Hungary Luxembourg Branch Office
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140778
C.RO Ports S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140775
Crystal Pool (Luxembourg) S.àr.l. . . . . . . .
140778
D.B. International Finance S.A. SPF . . . . .
140783
DEXIA Insurance Services Finance . . . . . .
140747
DjR Group Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140784
Eldalux s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140775
EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l. . . . . . . . . .
140781
Euro Holiday Properties S.A. . . . . . . . . . . . .
140755
Evergreen Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
140750
Eversholt Investment Group SCS . . . . . . . .
140776
Julius Baer Multiflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140774
Les Espaces Saveurs S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
140783
Oaktree (Lux.) Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140756
Primus Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140784
Serco Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
140778
140737
L
U X E M B O U R G
Avantor Performance Materials Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 155.169.
<i>Extrait des décisions prises par l'assembléei>
<i>générale des actionnaires en date du 25 octobre 2012i>
La société à responsabilité limitée Deloitte Audit, R.C.S. Luxembourg B n° 67.895, avec siège social à L-2220 Luxem-
bourg, 560, rue de Neudorf, a été confirmée dans son mandat de réviseur d'entreprises agréé pour l'audit des comptes
consolidés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Avantor Performance Materials Holdings S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012145457/16.
(120191684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.-D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 165.116.
Im Jahre zweitausendzwölf, den zweiundzwanzigsten Oktober,
vor dem unterzeichneten Notar Joëlle BADEN, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),
sind anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung) erschienen,
die Aktionäre der Allianz Finance VIII Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société ano-
nyme) mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F. D. Roosevelt und eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165.116 (die
Gesellschaft), in deren Eigenschaft als Eigentümer von 3.100.000 Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je EUR
0,01.
Die Gesellschaft wurde gegründet durch notarielle Urkunde vom 18. November 2011, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 143, vom 18. Januar 2012. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt
abgeändert gemäß notarielle Urkunde vom 20. Juni 2012, im Wege der Veröffentlichung im Mémorial C, Rcueil des
Sociétés et Associations.
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Christophe ERNZEN, avocat, wohnhaft in Luxemburg, der Frau
Martine ZELLINGER, Private Angestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zum Schriftführer bestellt.
Die Generalversammlung bestimmt zum Stimmenzähler Frau Anita MAGGIPINTO, Private Angestellte, mit beruflicher
Anschrift in Luxemburg (der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden das Büro der Generalver-
sammlung).
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Erschienenen folgende Erklärungen ab,
welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:
I. Aus der Anwesenheitsliste (die Anwesenheitsliste) geht hervor, dass die gesamten 3.100.000 Aktien mit einem
Nennwert von je EUR 0,01 bei gegenwärtiger Generalversammlung rechtsgültig vertreten sind; demzufolge ist die Ge-
neralversammlung gemäß Artikel 67-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über die Punkte 1 bis 3 der Tagesordnung beschließen; diese Anwesen-
heitsliste wurde von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von den Mitgliedern des Büros und dem
Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch
das Büro und den Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.
II. Die Generalversammlung stellt fest, dass die Tagesordnung der Generalversammlung folgende Punkte zum Ge-
genstand hat:
<i>Tagesordnungi>
1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten;
2. Erhöhung (i) des Gesellschaftskapitals um EUR 10,00 (zehn Euro), um es von derzeit EUR 31.000 (einunddreißig-
tausend Euro) auf insgesamt EUR 31.010 (einunddreißigtausendundzehn Euro) zu erhöhen, gemeinsam mit der Einzahlung
eines Ausgabeagios in Höhe von EUR 13.200.169,83 (dreizehn Millionen zweihunderttausend und einhundertneunund-
sechzig Euro und dreiundachtzig Cent), durch Ausgabe von 1.000 (eintausend) gleichwertiger Aktien mit einem Nennwert
140738
L
U X E M B O U R G
von je EUR 0,01 (ein Cent) (die Neuen Aktien) sowie Zeichnung der Neuen Aktien durch die Aktionäre und (ii) Erhöhung
der gesetzlichen Rücklage von EUR3.100 (dreitausendeinhundert Euro) auf EUR 3.101 (dreitausendeinhunderteins Euro);
3. Abänderung des fünften Artikels der Satzung der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut:
" Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.010 (einunddreißigtausendundzehn Euro),
eingeteilt in 3.101.000 (dreimillioneneinhunderteinstausend) Aktien mit einem Nennwert je EUR 0,01 (ein Cent) pro
Aktie.
Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 10 dieser Satzung durch einen Beschluss des allei-
nigen Aktionärs oder der Hauptversammlung abgeändert werden.".
III. Sodann trifft die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre rechtmäßig vertreten sind, beschließt die Generalversammlung auf die
Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; die Aktionäre betrachten sich als rechtmäßig geladen und bestätigt
volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihnen vorher mitgeteilt wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, (i) das Gesellschaftskapital um einen Gesamtbetrag von EUR 10,00 (zehn Euro)
zu erhöhen, um es von EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro) auf insgesamt EUR 31.010 (einunddreißigtausendundzehn
Euro) zu erhöhen, gemeinsam mit der Einzahlung eines Ausgabeagios in Höhe von EUR 13.200.169,83 (dreizehn Millionen
zweihunderttausend und einhundertneunundsechzig Euro und dreiundachtzig Cent), durch die Ausgabe von insgesamt
1.000 (eintausend) gleichwertigen Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) und die Neuen Aktien durch
die Aktionäre wie folgt zeichnen zu lassen sowie (ii) die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft von gegenwärtig EUR 3.100
(dreitausendeinhundert Euro) auf EUR 3.101 (dreitausendeinhunderteins Euro) zu erhöhen.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Die Aktionäre, vorgenannt, vertreten wie eingangs erwähnt, erklären hiermit (i) 1.000 (eintausend) neu ausgegebene
Aktien an der Gesellschaft zu zeichnen und (ii) diese mittels einer Bareinzahlung in Höhe von EUR13.200.179,83 (dreizehn
Millionen zweihunderttausend und einhundertneunundsiebzig Euro und dreiundachtzig Cent), voll einzuzahlen.
Diese Bareinlage in Höhe von EUR 13.200.179,83 (dreizehn Millionen zweihunderttausend und einhundertneunund-
siebzig Euro und dreiundachtzig Cent), wird folgendermaßen in die Gesellschaft eingezahlt:
(i) ein Betrag von EUR 10,00 (zehn Euro) wird in das Gesellschaftskapital eingezahlt, und
(ii) der restliche Betrag von EUR 13.200.169,83 (dreizehn Millionen zweihunderttausend und einhundertneunund-
sechzig Euro und dreiundachtzig Cent) wird als Ausgabeagio eingezahlt, wobei insgesamt EUR 1 (ein Euro) zur Bildung
der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft verwendet wird, die damit von gegenwärtig EUR 3.100 (dreitausendeinhundert
Euro) auf EUR 3.101 (dreitausendeinhundertundein Euro) erhöht wird, während der restliche Betrag in Höhe von EUR
13.200.168,83 (dreizehn Millionen zweihunderttausend und einhundertachtundsechzig Euro und dreiundachtzig Cent) in
die freie Rücklage eingezahlt wird.
Der amtierende Notar stellt fest, dass die Summe in Höhe von EUR 13.200.179,83 (dreizehn Millionen zweihundert-
tausend und einhundertneunundsiebzig Euro und dreiundachtzig Cent) auf das Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt
wurde, und der Gesellschaft ab heute gemäß einer Bankbestätigung vom 22.Oktober 2012 zur Verfügung steht.
Daraus ergeben sich für die Gesellschaft nunmehr folgende Anteilsverhältnisse:
Aktionär
Anzahl der
gehaltenen
Aktien
Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
465.150
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620.200
Allianz Global Corporate & Speciality AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620.200
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.395.450
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.101.000
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, Artikel fünf der Satzung der Gesellschaft gemäß des vorstehenden Beschlusses
abzuändern, mit folgendem Wortlaut:
" Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.010 (einunddreißigtausendundzehn Euro),
eingeteilt in 3.101.000 (dreimillioneneinhunderteinstausend) Aktien mit einem Nennwert je EUR 0,01 (ein Cent) pro
Aktie..
Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 10 dieser Satzung durch einen Beschluss des allei-
nigen Aktionärs oder der Hauptversammlung abgeändert werden."
140739
L
U X E M B O U R G
Follows the English translation of the foregoing:
" Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31.010 (thirty-one thousand and ten euro), represented
by 3.101.000 (three million one hundred and one thousand) shares having a par value of EUR 0.01 (one cent) per share
each.
The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General
Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 10 below.".
<i>Gebühreni>
Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft
aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR 6.000,-bewertet
und fallen zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass die Satzung der
Gesellschaft auf Verlangen der Erschienenen in deutscher Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer englischen Version;
im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgeblich.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, haben dieselben zusammen
mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: C. ERNZEN, M. ZELLINGER, A. MAGGIPINTO und J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A. C., le 26 octobre 2012. LAC/2012/50444. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 8. November 2012.
Référence de publication: 2012145448/118.
(120191777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Altilands S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 171.267.
EXTRAIT
Il résulte de la décision prise par les actionnaires de la Société en date du 2 novembre 2012 que:
1. Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société: BELTHUR ACCOUNTING LTD, ayant son
siège social 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, UK - London N21 3NA dont le mandat prendra fin lors de l’assemblée
générale des actionnaires de la Société qui sera tenue en 2018, en remplacement de Arkai Domiciliation Sarl.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 novembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Un mandataire
Référence de publication: 2012145471/16.
(120192081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Avant Ireland Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 167.582.
EXTRAIT
1) Transfert de parts sociales:
La totalité des parts sociales de la Société détenues par Apollo European Principal Finance Fund L.P., une société en
commandite soumise au régime fiscal d'exemption, régie par les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à c/o Walkers
SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, les Iles Caïmans, ont été cédées
en date du 20 mai 2012, comme suit:
- six mille vingt-cinq parts (6.025) sociales représentant 48.2% du capital social de la Société ont été transférées à Avant
Holdings (MI) II, LLC, une société gouvernée par le droit de la République des Iles Marshall, ayant son siège social au Trust
140740
L
U X E M B O U R G
Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Iles Marshall, laquelle détient désormais six mille vingt-cinq
(6,025) parts sociales de la Société représentant l'entièreté de son capital.
- Quatre cent cinquante (450) parts sociales représentant 3.6% four ont été transférées à Avant Holdings (MI) III, LLC,
une société gouvernée par le droit de la République des Iles Marshall, ayant son siège social au Trust Company Complex,
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Iles Marshall, laquelle détient désormais quatre cent cinquante (450) parts sociales
de la Société représentant l'entièreté de son capital.
- six mille vingt-cinq (6.025) parts sociales représentant 48.2% du capital social de la Société ont été transférées à Avant
Holdings (MI), LLC, une société gouvernée par le droit de la République des Iles Marshall, ayant son siège social au Trust
Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Iles Marshall, laquelle détient désormais six mille vingt-cinq
(6.025) parts sociales de la Société représentant l'entièreté de son capital.
2) Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la Société qui s’est tenue en date du 26 octobre 2012 que:
- La démission de Monsieur William Lyle Schulze de ses fonctions de gérant de Catégorie A, a été acceptée avec effet
au 17 octobre 2012.
- Monsieur Jean-Christophe Gladek, né le 10 avril 1982 à Mont Saint Martin, avec adresse professionnelle au 44 avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommé gérant de Catégorie A en remplacement de Monsieur Schulze
démissionnaire avec effet au 17 octobre 2012, pour une durée indéterminée.
3) En outre, veuillez noter le changement d’adresse de Monsieur Patrick Mabry, gérant de Catégorie A, comme suit:
- 44 avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg, le 6 novembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012145455/37.
(120191722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Ashmore Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 90.279.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour ASHMORE SICAV
i>Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.
Référence de publication: 2012145478/12.
(120191804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Azure Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 135.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.054.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> novembre 2012i>
En date du 1
er
novembre 2012, l'associé unique de la Société a décidé:
- de révoquer Monsieur Michael Robert KIDD de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Stéphane REUL, né le 29 janvier 1975 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société
avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Madame Lisa WADLIN, gérant de catégorie A,
- Monsieur Martin Timothy BROWN, gérant de catégorie B,
- Monsieur Stéphane REUL, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
140741
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Azure Holdings S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012145458/22.
(120191648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Am Wenkel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8081 Bertrange, rue de Mamer.
R.C.S. Luxembourg B 99.085.
<i>Cession de partsi>
Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 31 octobre 2012 que Monsieur Marcel Meyer et Madame
Constance Meyer-Reuter ensemble, propriétaires de la totalité des parts sociales, soit 100 (cent) parts sociales de ladite
société, cèdent 100 % des parts sociales, à Madame Ilda Coelho Dos Santos épouse Nunes Gariso et à Monsieur José
Nunes Gariso, qui les acceptent.
Après cette cession, la répartition des parts au sein de la société est la suivante:
- Ilda Coelho Dos Santos épouse Nunes Gariso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
- José Nunes Gariso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
100 parts sociales
Pour extrait conforme et sincère
Signature
Référence de publication: 2012145472/18.
(120191519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Amalthee S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 122.864.
EXTRAIT
Il résulte de la décision prise par l’actionnaire unique de la Société en date du 2 novembre 2012 que:
1. Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société:
BELTHUR ACCOUNTING LTD, ayant son siège social 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, UK - London N21 3NA
dont le mandat prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui sera tenue en 2018, en rem-
placement de Mme LAVALLE Magdalena Anna
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 novembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Un mandataire
Référence de publication: 2012145473/17.
(120192079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Axo Compagnie Hôtelière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 108-110, rue de Muehlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 161.409.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenu le 30 octobre 2012i>
L'assemblée, aborde son ordre du jour et prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
- L'assemblée décide de transférer le siège social au 108/110 rue de MUEHLENBACH L-2168 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
André COLNEL
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012145482/13.
(120192276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
140742
L
U X E M B O U R G
An der Klaus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 83.873.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 2 octobre 2012
que:
- le mandat des administrateurs actuellement en place, à savoir Messieurs Max GALOWICH, Jacques REMY et Georges
GREDT
- ainsi que le mandat du commissaire aux comptes actuellement en place, à savoir LUX-AUDIT S.A.
sont reconduits jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2018.
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration lors d'une réunion tenue en date du 3 octobre 2012
que:
- Monsieur Max GALOWICH, a été nommé Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'ad-
ministrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>Un mandataire
Référence de publication: 2012145474/22.
(120192017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Askania S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 120.177.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 novembre 2012i>
<i>Première résolutioni>
Les associés de la société acceptent la démission de Messieurs Matthias Luecker et Sebastian Klatt de leurs postes de
gérant A de la société avec effet au 6 novembre 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés de la société nomment Madame Elke Birk-Hansel, né le 29 mai 1969 à Rüsselsheim (Allemagne), résidant
professionnellement à 6D Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, au poste de gérant A de la société avec effet au 6
novembre 2012.
Madame Elke Birk-Hansel est désignée pour une période illimitée jusqu’à sa démission ou son remplacement lors de
l’assemblée générale des associés.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012145479/20.
(120191737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Blue Fin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R.C.S. Luxembourg B 140.676.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of October.
Before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BLUE FIN S.A., a société anonyme, incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue de la Grève, L-1643
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 140.676 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in
Luxembourg, dated 2 July 2008, and whose articles of association (the "Articles") were published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on 26 August 2008 n°2062 page 98959. The Articles have been amended for the last
140743
L
U X E M B O U R G
time pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, prenamed, dated 27 April 2011, which were published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations on 3 August 2011 n° 1766 page 84734.
The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") elected as chairman, Maître Frédérique Davister,
lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Jean-Paul Schmit, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Ms Monique Drauth, employee, residing professionally in Luxembourg.
The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:
I. The names of the shareholders present or represented at the meeting by proxies (together the "Appearing Share-
holders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list at the end of these minutes. This
attendance list has been signed ne varietur with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by
proxies, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary.
II. The attendance list shows that the Appearing Shareholders holding all of the 256,200 shares representing the whole
share capital of the Company are present at the Meeting or represented at the Meeting by proxies. All the Appearing
Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the Meeting beforehand and have
waived all convening requirements and formalities. The Meeting is therefore properly constituted and can validly consider
all items of the agenda.
III. The agenda of the Meeting was the following:
<i>Agendai>
1) Resolution to reduce the share capital by an amount of one million twenty-four thousand eight hundred Euro (EUR
1,024,800.-) to bring the current share capital of one million two hundred eighty-one thousand Euro (EUR 1,281,000.-)
to two hundred fifty-six thousand two hundred Euro (EUR 256,200.-) by the reduction of the par value of the two hundred
fifty-six thousand two hundred (256,200) shares from five Euro (EUR 5.-) to one Euro (EUR 1.-) without reimbursement
to the shareholders;
2) Subsequent amendment of article 5 of the Articles of the Company;
3) Miscellaneous.
The appearing parties representing the whole Company's share capital require the notary to act the following reso-
lutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to reduce the share capital by an amount of one million twenty-four thousand eight hundred
Euro (EUR 1,024,800.-) to bring the current share capital of one million two hundred eighty-one thousand Euro (EUR
1,281,000.-) to two hundred fifty-six thousand two hundred Euro (EUR 256,200.-) by the reduction of the par value of
the two hundred fifty-six thousand two hundred (256,200) shares from five Euro (EUR 5.-) to one Euro (EUR 1.-) without
reimbursement to the shareholders.
The reduced amount shall be used as follows:
- eighty-nine thousand seven hundred eighty-one Euro and ninety-seven cent (EUR 89,781.97) shall settle the loss
carried forward of the Company; and,
- nine hundred thirty-five thousand eighteen Euro and three cent (EUR 935,018.03) shall be allocated to the share
premium account of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles in order to reflect the decision taken
under the preceding resolution. The first paragraph of Article 5 shall now read as follows:
Art. 5. (first paragraph). "The subscribed capital of the Company is fixed at two hundred fifty-six thousand two hundred
Euro (256,200.-) represented by two hundred fifty-six thousand two hundred (256,200) shares having a nominal value of
one Euro (EUR 1.-)."
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said persons signed together with the notary the present deed.
140744
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française:
L'an deux mille douze, le vingt-cinquième jour d'octobre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BLUE FIN S.A., une société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 140.676 (la "Société"),
constituée par un acte de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet 2008, et
dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2062 page
98959 en date du 26 août 2008. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jacques Delvaux,
préqualifié, en date du 27 avril 2011, et publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1766 page
84734 en date du 3 août 2011.
L'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") élit comme président Maître Frédérique Davister, Avocat, de-
meurant professionnellement à Luxembourg.
Le président nomme en qualité de secrétaire de séance Monsieur Jean-Paul Schmit, salarié, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L'Assemblée élit comme scrutateur, Madame Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,
Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le Président déclare et requiert du notaire instrumentant de prendre
acte que:
I. Les noms des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée par des mandataires (collectivement les "Action-
naires Comparants") et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont mentionnés sur la liste de présence à la fin de ce procès-
verbal. Cette liste de présence a été signée ne varietur avec les procurations par les actionnaires représentés à l'assemblée
par des mandataires, le notaire ainsi que le président, le scrutateur et le secrétaire.
II. La liste de présence montre que les Actionnaires Comparants détenant toutes les 256,200 actions représentant la
totalité du capital social de la Société sont présents à l'Assemblée ou représentés par des mandataires. Tous les Action-
naires Comparants ont déclaré qu'ils avaient été suffisamment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée préalablement
à celle-ci et qu'ils renonçaient aux formalités de convocation. L'Assemblée est donc valablement constituée et peut
valablement délibérer sur l'ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) Décision de réduire le capital social d'un montant d'un million vingt-quatre mille huit cents Euros (EUR 1.024.800,-)
pour porter le montant actuel d'un million deux cent quatre-vingt-un mille (EUR 1.281.000,-) à deux cent cinquante-six
mille deux cents Euros (EUR 256.200,-) par la réduction de la valeur nominale des actions de cinq Euros (EUR 5,-) à un
Euro (EUR 1,-) sans remboursement aux actionnaires;
2) Modification de l'article 5 des Statuts de la Société;
3) Divers.
Les parties comparantes représentant l'ensemble du capital social de la Société demande au notaire de prendre acte
des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social d'un montant d'un million vingt-quatre mille huit cents Euros (EUR
1.024.800,-) pour porter le montant actuel d'un million deux cent quatre-vingt-un mille (EUR 1.281.000,-) à deux cent
cinquante-six mille deux cents Euros (EUR 256.200,-) par la réduction de la valeur nominale des actions de cinq Euros
(EUR 5,-) à un Euro (EUR 1,-) sans remboursement aux actionnaires.
Le montant réduit sera alloué comme suit:
- quatre-vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-un Euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (EUR 89.781,97) serviront
à apurer les pertes reportées de la Société; et
- neuf cent trente-cinq mille dix-huit Euros et trois centimes (EUR 935.018,03) seront alloués au compte prime
d'émission de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le paragraphe 1
er
de l'article 5 des Statuts afin de refléter la décision prise dans la
résolution précédente. Le paragraphe 1
er
de l'article 5 sera dorénavant rédigé comme suit:
Art. 5. Paragraphe 1. «Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux cent cinquante-six mille deux cents Euros
(EUR 256.200,-) représenté par deux cent cinquante-six mille deux cents (256.200) actions ayant une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,-).»
140745
L
U X E M B O U R G
<i>Coûtsi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des personnes comparantes, le
présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de ces mêmes personnes, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.
Après que lecture de l'acte a été faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom, statut
marital, lieu de résidence, lesdites personnes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Davister, Schmit, Drauth, Grethen.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 octobre 2012. Relation: LAC/2012/50575. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145506/138.
(120191817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Bio-cafes SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 100.144.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 31 octobre 2012i>
L'Assemblée Générale décide de prononcer la clôture de la liquidation de la société BIO-CAFES S.A. (en liquidation)
qui cessera d'exister.
L'Assemblée Générale décide que les documents sociaux seront conservés, au minimum pendant 5 années, au siège
social de HRT FIDALUX S.A., qui est actuellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 31 octobre 2012.
<i>Pour BIO-CAFES S.A.
i>(en liquidation)
Référence de publication: 2012145485/17.
(120192269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
BlackRock Alternative Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.264.
Faisant suite à la résolution écrite de l’actionnaire unique en date du 16 Juillet 2012,
Il est noté que:
- Mme Ulla Pitha a démissionné de sa fonction d'administrateur de la Société avec effet au 28 Juin 2012;
Que les décisions suivantes ont été prises:
D’augmenter le nombre des Administrateurs de cinq à six.
En conséquence, est élu en qualité d’administrateur avec effet au 16 Juillet 2012, et jusqu’à la prochaine assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2013:
Adrian Lawrence, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, United Kingdom
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 Septembre 2012.
State Street Bank Luxembourg S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012145487/19.
(120191993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
140746
L
U X E M B O U R G
Belfius Insurance Services Finance, Société Anonyme,
(anc. DEXIA Insurance Services Finance).
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 37.631.
<i>Remplace la première version déposée le 25/10/2012 sous le N° RCS L12184650i>
Les comptes annuels au 30/06/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Rudy PARIDAENS
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012145483/13.
(120191761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Broadstreet of Münsbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 473.888.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 90.780.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> novembre 2012i>
En date du 1
er
novembre 2012, l'associé unique de la Société a décidé:
- de révoquer Monsieur Michael Robert KIDD de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Stéphane REUL, né le 29 janvier 1975 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société
avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Madame Lisa WADLIN, gérant de catégorie A,
- Monsieur Martin BROWN, gérant de catégorie B,
- Monsieur Stéphane REUL, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Broadstreet of Münsbach S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012145489/22.
(120191674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Broadstreet International Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.305.304.560,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 144.415.
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> novembre 2012i>
En date du 1
er
novembre 2012, les associés de la Société ont décidé:
- de révoquer Monsieur Michael Robert KIDD de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Stéphane REUL, né le 29 janvier 1975 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société
avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Madame Lisa WADLIN, gérant de catégorie A,
- Monsieur Martin Timothy BROWN, gérant de catégorie B,
- Monsieur Stéphane REUL, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
140747
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Broadstreet International Partners S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012145490/22.
(120191662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Broadstreet Mexico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: MXN 250.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.471.
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> novembre 2012i>
En date du 1
er
novembre 2012, les associés de la Société ont décidé:
- de révoquer Monsieur Michael Robert KIDD de son mandat de membre de catégorie B de la Société avec effet
immédiat;
- de nommer Monsieur Stéphane REUL, né le 29 janvier 1975 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que nouveau membre de catégorie B de la
Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Madame Lisa WADLIN, membre de catégorie A,
- Monsieur Martin BROWN, membre de catégorie B,
- Monsieur Stéphane REUL, membre de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Broadstreet Mexico S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012145491/23.
(120191669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Broadstreet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 150.060.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> novembre 2012i>
En date du 1
er
novembre 2012, l'associé unique de la Société a décidé:
- de révoquer Monsieur Michael Robert KIDD de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Stéphane REUL, né le 29 janvier 1975 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société
avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Madame Lisa WADLIN, gérant de catégorie A,
- Monsieur Martin BROWN, gérant de catégorie B,
- Monsieur Stéphane REUL, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Broadstreet S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012145492/22.
(120191663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
140748
L
U X E M B O U R G
Barguzin Participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 87.481.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012145495/13.
(120192054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
BLACKROCK Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 34.079.
I - Par résolutions prises en date du 17 février 2012, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Nicholas Hall, avec adresse au 85, Briarwood Road, SW4 9PJ London, Royaume Uni
de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.
2. Acceptation de la démission de Frank Le Feuvre, avec adresse au Grenville Street, JE1 OBR St. Helier, Channel
Islands, Jersey, de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.
3. Nomination de Barry O'Dwyer, avec adresse au Barrow Street, Grand Mill Quay, Block 2, Dublin 4, Irlande, au
mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant a échéance lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.
4. Nomination de Dominic Critchley, avec adresse professionnelle au 6D, route de Trêves, L-2633 Senningerberg, au
mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant a échéance lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.
5. Nomination de Guido van Berkel, avec adresse au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, au mandat d'adminis-
trateur, avec effet immédiat et pour une période venant a échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.
6. Nomination de Ulla Pitha, avec adresse professionnelle au 12, Throgmorton Avenue, EC2N 2DL Londres, Royaume
Uni, au mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant a échéance lors de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.
7. Nomination de Graham Bamping, avec adresse professionnelle au 12, Throgmorton Avenue, EC2N 2DL Londres,
Royaume Uni, au mandat d'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant a échéance lors de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en
2012.
II - Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 29 juin 2012, l'actionnaire unique a pris les décisions
suivantes:
1 - Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Radcliffe Geoffrey Richard, avec adresse professionnelle au 6D, route de Trêves, 5
th
floor, L-2633 Senningerberg,
- Graham Bamping, avec adresse professionnelle au 12, Throgmorton Avenue, EC2N 2DL Londres, Royaume Uni,
- Ulla Pitha, avec adresse professionnelle au 12, Throgmorton Avenue, EC2N 2DL Londres, Royaume Uni,
- Dominic Critchley, avec adresse professionnelle au 6D, route de Trêves, L-2633 Senningerberg,
- Guido van Berkel, avec adresse au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
- Barry O'Dwyer, avec adresse au Barrow Street, Grand Mil l Quay, Block 2, Dublin 4, Irlande,
pour une période venant a échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
2 - Nomination de Adrian Lawrence, avec adresse professionnelle au 12, Throgmorton Avenue, EC2N 2DL Londres,
Royaume Uni au mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant a échéance lors de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en
2013.
3 - Renouvellement de Deloitte Audit, avec siège social au 560, Rue de Neudorf, L2220 Luxembourg, au mandat de
reviseur d'entreprises agrée, pour une période venant a échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur
les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
140749
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 Novembre 2012.
Référence de publication: 2012145505/48.
(120192127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Boesen Ihr Gärtner, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 57, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 148.143.
Der Jahresabschluss auf den 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Breuer & Trinh Tax Consulting UG (haftungsbeschränkt) & Co. S.C.S.
Fiduciaire
Référence de publication: 2012145507/11.
(120191616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Evergreen Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.635.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf,
am dreißigsten Oktober.
Vor Uns Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
ist erschienen:
die Gesellschaft „Evergreen SICAV-FIS – Teilfonds 1“, mit Sitz in 43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Christian Lennig, beruflich ansässig in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 26. Oktober 2012.
Die Vollmacht nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar bleibt
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Erschienene hat in Ausführung seiner Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung einer Aktiengesellschaft,
die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
I. Name, Sitz, Zweck und Dauer
Art. 1. Name. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen “Ever-
green Investments S.A.”.
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum
Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.
Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-
tigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert
wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden.
Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form in
anderen in-und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Art von Investierung, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder jede andere Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder jede andere Weise von Wertpapieren jeder Art
sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und der Entwicklung von in-und ausländischen Handels-, Industrie- oder
Finanzgesellschaften beteiligen und sie kann diesen Gesellschaften jede Art von Beistand leisten, sei es in der Form von
Darlehen, Garantien oder auf jede andere Weise.
Die Gesellschaft kann Anleihen in jedweder Form aufnehmen, Schuldverschreibungen ausgeben und Sicherheiten bes-
tellen.
Allgemein kann die Gesellschaft alle Handels-, Industrie- oder Finanzgeschäfte betreiben und alle sonstigen Tätigkeiten
ausüben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.
140750
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Laufzeit. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit errichtet.
II. Aktienkapital
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- Euro). Es ist in
dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- Euro) eingeteilt und in voller Höhe
einbezahlt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-
ralversammlung, welcher in derselben Form wie für Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einschließlich nach-
folgender Änderungen und Ergänzungen ("Gesetz von 1915") und zu den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien
erwerben.
Art. 6. Aktien. Die Aktien werden ausschließlich in Form von Namensaktien ausgegeben.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.
Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgesehen sind. Das Eigentum an
Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein,
müssen diejenigen, die ein Recht auf die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen um die Aktie
bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen,
solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.
III. Verwaltungsrat
Art. 7. Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei (3) Mitgliedern, die nicht
Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestimmt.
Art. 8. Geschäftsführung und Vertretung. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten
und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich der
Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung
je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.
Art. 9. Übertragung auf Dritte. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung
Dritten gegenüber können an die in Artikel 60 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Personen übertragen werden; deren
Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.
Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungsrats-
mitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen und deren Zeichnungsberechtigung regeln. Er setzt
die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Gesellschaft getragen werden.
Art. 10. Bestellung und Amtszeit. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die ordentliche Generalversammlung
für die Dauer eines oder mehrerer Jahre bestellt.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die Ver-
waltungsräte bestellt, und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.
Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes frei, so können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei
gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl
von Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig. Die Generalversammlung kann die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und
ohne Angabe von Gründen abberufen.
Art. 11. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und
einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.
Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder zu-
sammen. Zeitpunkt und Ort sind in der Einladung zu benennen. Sofern kein Ort benannt ist, finden Verwaltungsratssi-
tzungen am Sitz der Gesellschaft statt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden zu jeder Verwaltungsratssitzung mindestens
drei (3) Tage vorher schriftlich eingeladen, sofern Zeitpunkt und Ort nicht bereits in einem Verwaltungsratsbeschluss
bestimmt wurden. In Eilfällen kann auf die Frist verzichtet werden. Der Grund hierfür ist in der Einladung zu benennen.
Auf die Einladung kann einvernehmlich in Textform verzichtet werden.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder erforderlichenfalls ordnungsgemäß geladen
wurden und mindestens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes
Quorum anwesend oder vertreten ist. Bei Entscheidungen des Verwaltungsrats über die Anlage in Vermögenswerte für
die Gesellschaft müssen alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sein, sofern die Anlage über Beteiligun-
gen an Tochtergesellschaften oder Beteiligungsgesellschaften erfolgt.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung durch Erklärung in Textform vertreten lassen,
wobei der Vertreter kein Verwaltungsratsmitglied sein muss. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere Verwaltungs-
140751
L
U X E M B O U R G
ratsmitglieder vertreten, jedoch nicht alle anderen gleichzeitig. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungs-
ratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche
ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer einander hören können, teilnehmen.
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsrats-
mitglieder, soweit sich aus dieser Satzung nichts anderes ergibt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Verwaltungsrats-
vorsitzende oder in dessen Abwesenheit sein Stellvertreter. Entscheidungen des Verwaltungsrats über die Anlage in
Vermögenswerte für die Gesellschaft bedürfen eines einstimmigen Beschlusses, sofern die Anlage über Beteiligungen an
Tochtergesellschaften oder Beteiligungsgesellschaften erfolgt.
Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder
zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch im schriftlichen Umlaufverfahren mit den Stimmen aller Verwaltungs-
ratsmitglieder fassen. Mit der Aufforderung zum schriftlichen Umlaufverfahren sind der Abstimmungsgegenstand sowie
ein Beschlussvorschlag bekanntzugeben. Ein im schriftlichen Umlaufverfahren gefasster Beschluss kann auch in Textform
erfolgen.
IV. Überwachung
Art. 12. Rechnungsprüfer. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer,
die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung
fest.
Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft. Sie
dürfen an Ort und Stelle in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und die sonstigen Geschäftsunterlagen der
Gesellschaft Einsicht nehmen.
Sie berichten der Generalversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer Ansicht geeignete
Vorschläge.
Die ordentliche Generalversammlung bestellt die Rechnungsprüfer für die Dauer eines oder mehrerer Jahre. Ihre
Amtszeit darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, die sie bestellt und
endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.
Die Wiederwahl der Rechnungsprüfer ist zulässig. Sie können jederzeit durch die Generalversammlung ohne Angabe
von Gründen abberufen werden.
V. Generalversammlung der Aktionäre
Art. 15. Generalversammlung. Die ordnungsmäßig gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der
Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die
Geschäfte der Gesellschaft.
Die ordentliche Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Ak-
tionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.
Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bes-
timmten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils um 13.30 Uhr am zweiten Donnerstag des Monats April eines
jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Tag fällt, der in Luxemburg nicht Bankarbeitstag ist, am nächsten darauffol-
genden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.
Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder außerhalb des
Großherzogtums Luxemburg einberufen werden.
Die außerordentliche Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder die Rechnungsprüfer einberufen. Sie
muss binnen einer Frist von fünfzehn (15) Tagen einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Zehntel des Gesellschafts-
kapitals vertreten, den Verwaltungsrat oder die Rechnungsprüfer hierzu schriftlich unter Angabe der Tagesordnung
auffordern.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer General-
versammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten.
Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein
stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversammlung
bestimmte Person.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Voll-
macht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen ge-
fasst, sofern die Vorschriften des Gesetzes von 1915 keine anderweitigen Bestimmungen treffen. Über die Verhandlungen
und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die vom jeweiligen Vorsitzenden unterzeichnet
werden.
140752
L
U X E M B O U R G
VI. Rechnungslegung
Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben
Jahres.
Art. 21. Jahresabschluss. Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und
Verlustrechnung auf. Es werden jährlich wenigstens fünf (5) Prozent des Reingewinnes vorweg dem gesetzlichen Reser-
vefonds so lange zugeführt bis dieser zehn (10) Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.
Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Ge-
winn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Rechnungsprüfern vor,
die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.
Die Generalversammlung befindet über die Bilanz sowie über die Gewinn- und Verlustrechnung und bestimmt über
die Verwendung des Jahresgewinns. Sie kann im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 aus den verteilungs-
fähigen Gewinnen und Reserven die Ausschüttung einer Dividende beschließen.
Gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes von 1915 ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden als Abschlag auf die
zu erwartende Dividendenberechtigung am Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen.
VII. Auflösung der Gesellschaft
Art. 22. Auflösung. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation
durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung
fest.
VIII. Schlussbestimmungen
Art. 23. Anwendbares Recht. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxem-
burgischen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Gesetz von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 2013 stattfinden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklären der Erschienene, die dreihundertzehn (310) Aktien wie folgt zu
zeichnen:
„Evergreen SICAV-FIS – Teilfonds 1“, vorgenannt, dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
TOTAL: DREIHUNDERTZEHN AKTIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- Euro) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes von 1915
erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gründer schätzt die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung
erwachsen, auf ungefähr tausend Euro.
<i>Generalversammlungi>
Die vorbezeichnete Partei, welche die Gesamtheit des übernommenen Grundkapitals vertritt und sich als ordnungs-
gemäß einberufen betrachtet, hat unmittelbar folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer auf einen (1).
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Volker Schmidt-Lafleur, geboren am 11. Mai 1962 in Wiesbaden, Deutschland, beruflich ansässig in 43, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxemburg;
- Silvan Trachsler, Golding Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l., geboren am 23. März 1954 in Basel, Schweiz, beruflich
ansässig in 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; und
- François Georges, Georges & Associés, geboren am 20. März 1967 in Luxemburg, beruflich ansässig in 43, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
Volker Schmidt-Lafleur wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 65.477).
140753
L
U X E M B O U R G
4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
5. Die Aufträge der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2017
befindet. Der Auftrag des Wirtschaftsprüfers endet mit der Generalversammlung, die über das erste Geschäftsjahr der
Gesellschaft befindet.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, hat derselbe
mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben
Gezeichnet: C. LENNIG, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 31. Oktober 2012. Relation: EAC/2012/14458. Erhalten fünfundsiebzig Euro
(75.- EUR).
<i>Der Einnehmeri>
(gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2012148251/216.
(120195489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Bois-Matériaux Willy Putz Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9122 Schieren, 4, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 95.807.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2012i>
Les associés de la société BOIS-MATERIAUX WILLY PUTZ S.à r.l. ayant son siège social à L-9122 Schieren, avenue
de la Gare se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la date du 31 octobre 2012 et ont pris la résolution
suivante:
«L'adresse actuelle du siège social est à L-9122 Schieren 4, rue de la Gare.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait à Schieren, le 31 octobre 2012.
BOIS-MATÉRIAUX Willy PUTZ Sàrl
Rue de la Gare L-9122 SCHIEREN
Marc MICHELS
<i>Associé-géranti>
Référence de publication: 2012145508/18.
(120191970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Borderline Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 63.389.
<i>Résolution 1.i>
<i>Changement d’administrateur/administrateur-délégué/Géranti>
Est révoqué le mandat de Monsieur Jan van Leuvenheim en tant que administrateurs et administrateurs-délégué à partir
du 22 Mai 2012;
Sont révoqué les mandats de Seline Management Ltd et Seline Finance Ltd en tant que administrateur à partir du 22
Mai 2012;
Est confirmé les nominations de Mr. Rob Drieduite, Mr. Gerard Ossevoort et Citadelle Corporate Services Sàrl en
tant que nouveaux administrateurs, les trois avec adresse professionnelle, 6 Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg
à partir du 22 Mai 2012;
Est confirmé la nomination de Mr. Gerard Ossevoort en tant que nouveau administrateur-délégué avec adresse pro-
fessionnelle, 6 Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg à partir du 22 Mai 2012;
<i>Résolution 2.i>
<i>Changement De commissaire aux Comptesi>
Est révoqué le mandat de CRT Register International SA en tant que commissaire aux comptes à partir du 22 Mai
2012;
Est confirmé la nomination de Oxford Tax Advisory SA en tant que nouveau commissaire aux comptes avec adresse
professionnelle, 6 Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg à partir du 22 Mai 2012;
140754
L
U X E M B O U R G
<i>Résolution 3.i>
<i>Changement d’adresse siège sociali>
Le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 6, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
Luxembourg à partir du 1
er
septembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 Novembre 2012.
Référence de publication: 2012145509/30.
(120192000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Euro Holiday Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 59.766.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 octobre 2012i>
L'assemblée, après lecture des lettres de démission de Monsieur Paul Laplume et de Monsieur Pierre Schill de leur
fonction d'administrateurs, décide d'accepter leur démission avec effet immédiat.
L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs, avec effet immédiat, Monsieur Elia Filiberti, résidant profes-
sionnellement Via Per Alzo, 39, I-28017 San Maurizio d'Opaglio (Italie) et Madame Valentina Giacomini, résidant
professionnellement Via Per Alzo, 39, I-28017 San Maurizio d'Opaglio (Italie), leurs mandats ayant la même échéance que
les mandats de leurs prédécesseurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliaire
i>Signatures
Référence de publication: 2012145612/20.
(120191717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Bortran S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 103.285.
<i>I. Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire le 06 novembre 2012i>
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’accepter, avec effet au 1
er
août 2012, la démission de la société Fiduciaire F. Winandy
& Associés S.A. de son mandat de Commissaire.
L’Assemblée Générale décide de nommer comme Commissaire, en remplacement du Commissaire démissionnaire,
la société anonyme H.R.T. REVISION S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 51238, ayant son siège social au 163, Rue du Kiem, L-8030 Strassen. Son mandat viendra à échéance à l’issue
de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2016.
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’accepter, avec effet au 1
er
août 2012, la démission de Monsieur Romain THILLENS
de son mandat d’Administrateur.
L’Assemblée Générale décide de nommer comme Administrateur, avec effet au 1
er
août 2012, en remplacement de
l’Administrateur démissionnaire, Monsieur Philippe RICHELLE, employé privé, né le 17 octobre 1962 à Verviers (Belgi-
que), résidant professionnellement au 163 Rue du Kiem, L-8030 Strassen. Son mandat viendra à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2016.
<i>II. Changement d’adressei>
La Société a été informée du changement d’adresse des administrateurs, Monsieur Christophe BLONDEAU et Madame
Cornelia METTLEN, ayant désormais leur adresse au 163 Rue du Kiem, L-8030 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
140755
L
U X E M B O U R G
<i>Pour BORTAN S.A.
i>HRT FIDALUX S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012145510/29.
(120191570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
BRE/CP Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 111.983.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 6 mars 2012, que BRE/Europe 3-A S.à r.l. a
transféré la totalité des 500 parts qu'elle détenait dans la Société à:
- BRE/CPE Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché du
Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B167458.
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
BRE/CPE Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
BRE/CP Europe Holdings S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012145511/19.
(120191529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Broadstreet Continental Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.720,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 90.255.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> novembre 2012i>
En date du 1
er
novembre 2012, l'associé unique de la Société a décidé:
- de révoquer Monsieur Michael Robert KIDD de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Stéphane REUL, né le 29 janvier 1975 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société
avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Madame Lisa WADLIN, gérant de catégorie A,
- Monsieur Martin BROWN, gérant de catégorie B,
- Monsieur Stéphane REUL, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
BROADSTREET CONTINENTAL FINANCE S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012145512/22.
(120191656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Oaktree (Lux.) Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 172.546.
STATUTES
In the year two thousand and twelve,
on the sixth day of the month of November.
140756
L
U X E M B O U R G
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
“Oaktree Fund GP II, LP”, a limited partnership with registered office in 2711 Centreville Road, Suite 400, in the City
of Wilmington, County of New Castle, 19808, United States,
represented by Mr Christian Lennig, Rechtsanwalt, professionally residing in L-1011 Luxembourg,
by virtue of a proxies given in Los Angeles, United States, on 31 October 2012, under private seal, which, initialled ne
varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a
public limited liability company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable capital (société
d'investissement à capital variable) governed by part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, as amended:
Title I. - Name - Registered office - Duration - Purpose
Art. 1. Denomination.
1.1 The Company is hereby formed as a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company
with variable share capital (société d'investissement à capital variable) under the name of "Oaktree (Lux.) Funds" (the
"Company").
1.2 If the Company ceases to be managed by Oaktree Capital Management, L.P., or by one of its affiliates, the Company
will cause its name to be changed without delay at the request of Oaktree Capital Management, L.P., or one of its affiliates,
to a name that does not have any resemblance with Oaktree (Lux.) Funds and which shall not include the word "Oaktree"
in the name of the Company.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
2.2 The Company's Board of Directors (the "Board of Directors" or the "Board") is authorised to transfer the regis-
tered office of the Company within the municipality of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other
municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder or in case of plurality
of holders of Shares ("Shareholders") by means of a resolution of an extraordinary general meeting of Shareholders
deliberating in the manner provided for any amendment to these articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").
2.3 Branches, Subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a decision of the Board of Directors.
2.4 In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military events have occurred
or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Purpose.
4.1 The exclusive purpose of the Company is to provide its Shareholders with a choice of professionally managed Sub-
Funds investing in a wide range of transferable securities in order to achieve an optimum return from capital invested,
while reducing investment risk through diversification.
4.2 The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfillment
and development of its purpose to the largest extent permitted under the Part I of the law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law").
Title II. - Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share capital - Funds - Classes and categories of Shares.
5.1 The capital of the Company shall be represented by fully paid up Shares (the "Shares") of no par value and shall at
any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The capital must reach one million
two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-) or the equivalent in the reference currency within the first six
months following its incorporation, and thereafter may not be less than this amount.
5.2 The initial capital shall be set at forty-one thousand USD (USD 41,000.00) divided into four hundred ten (410) class
B Shares in the Sub-Fund "Oaktree (Lux.) Funds – Oaktree Global Convertible Bond Fund" with no par value, which are
fully paid in.
140757
L
U X E M B O U R G
5.3 The Board of Directors may, at any time, issue different classes of Shares (each a "Class", and together referred
to as the "Classes"). If multiple Classes of Shares relate to one Sub-Fund, the assets attributable to such Classes shall be
commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned provided however, that within
a Sub-Fund, the Board of Directors is empowered to define Classes so as to correspond to (i) a specific distribution
policy, such as entitling to distributions or not entitling to distributions and/or (ii) a specific sales and redemption charge
structure and/or (iii) a specific management or advisory fee structure, and/or (iv) a specific assignment of distribution,
Shareholder services or other fees and/or (v) the currency or currency unit in which the Class may be quoted and based
on the rate of exchange between such currency or currency unit and the reference currency of the relevant Sub-Fund
and/or (vi) the use of different hedging techniques in order to protect in the reference currency of the relevant Sub-Fund
the assets and returns quoted in the currency of the relevant Class of Shares against long-term movements of their
currency of quotation and/or (vii) such other features as may be determined by the Board of Directors from time to time
in compliance with applicable law.
5.4 Each Class may be sub-divided in one or several category(ies) of Shares (each a "Category", together the "Cate-
gories") as more fully described in the prospectus of the Company (the "Prospectus").
5.5 The Board of Directors shall, at any time, establish one or several pool(s) of assets, each constituting a compartment
(a "Sub-Fund") within the meaning of article 181 of the 2010 Law.
5.6 The Board of Directors shall attribute specific investment objectives and policies and a specific denomination to
each Sub-Fund.
5.7 The Company shall be considered as a single legal entity. However, the right of Shareholders and creditors relating
to a particular Sub-Fund or raised by the incorporation, the operation or the liquidation of a Sub-Fund are limited to the
assets of such Sub-Fund. The assets of a Sub-Fund will be answerable exclusively for the rights of the Shareholders relating
to this Sub-Fund and for those of the creditors whose claim arose in relation to the incorporation, the operation or the
liquidation of this Sub-Fund. As far as the relation between Shareholders is concerned, each Sub-Fund will be deemed to
be a separate entity.
5.8 For consolidation purposes, the consolidated currency of the Company is the USD. The share capital of the
Company may be increased or decreased as a result of the issue by the Company of new fully paid up Shares or the
repurchase by the Company of existing Shares from its Shareholders.
Art. 6. Form of Shares.
6.1 The Company shall issue Shares in registered form only.
6.2 All issued registered Shares of the Company shall be registered in the register of Shareholders which shall be kept
by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the
name of each owner of registered Shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of
registered Shares held by him, the Class and Category of each such Share and the amount paid up on each Share, the
transfer of Shares and the dates of such transfer.
6.3 The inscription of the shareholder's name in the register of Shareholders evidences his right of ownership on such
registered Shares. The Company shall not issue certificates for such inscription, but each shareholder shall receive a
written confirmation of his shareholding. The Company treats the registered owner of a Share as the absolute and
beneficial owner thereof.
6.4 Any transfer of registered Shares shall be made by a written declaration of transfer to be inscribed in the register
of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to
act therefore. The Company may also accept and enter in the register of Shareholders a transfer on the basis of corres-
pondence or other documents recording the agreement of the transferor and transferee or accept as evidence of transfer
any other instruments of transfer satisfactory to the Company. Subject to Articles 6 and 10 hereof, any transfer of Shares
shall be entered into the register of Shareholders; such inscription shall be signed by any director or officer of the Company
or by any other person duly authorised thereto by the Board of Directors.
6.5 Shareholders entitled to receive the registered Shares shall provide the Company with an address to which all
notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of Shareholders.
6.6 In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to
be entered into the register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office
of the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his address as
entered into the register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
6.7 The Company recognises only one owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership
of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) must appoint a sole attorney to represent such
shareholding in dealings with the Company. The failure to appoint such attorney shall result in a suspension of all rights
attached to such Share(s). Moreover, in the case of joint Shareholders, the Company reserves the right to pay any
redemption proceeds, distributions or other payments to the first registered holder only, whom the Company may
consider to be the representative of all joint holders, or to all joint Shareholders together, at its absolute discretion.
140758
L
U X E M B O U R G
6.8 The Company may decide to issue fractional Shares up to three decimal places. Such fractional Shares shall not be
entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets of the relevant Class and/or Category on a pro rata
basis.
Art. 7. Issue of Shares.
7.1 The Board of Directors is authorised without limitation to issue an unlimited number of fully paid up Shares with
no par value at any time without reserving the existing Shareholders a preferential right to subscribe for the Shares to
be issued.
7.2 The conditions to which the issue of Shares would be submitted by the Board of Directors will be detailed in the
Prospectus.
7.3 Shares shall be issued at the subscription price applicable to the relevant Sub-Fund, Class and/or Category as
determined by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus. The Board of Directors may also, in respect of
any one given Sub-Fund, Class and/or Category, levy a subscription fee and has the right to waive partly or entirely this
subscription fee. Any taxes, commissions and other fees incurred in the respective countries in which the Shares of the
Company are marketed will also be charged.
7.4 Shares shall be allotted only upon acceptance of the subscription and payment of the subscription price. The
payment of the subscription price will be made under the conditions and within the time limits as determined by the
Board of Directors and described in the Prospectus.
7.5 The Board of Directors may delegate to any member of the Board of Directors (each a "Director"), manager,
officer or other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new
Shares to be issued and to deliver them.
7.6 The Company or its duly appointed agents may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind
of securities, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a
valuation report from the auditor of the Company qualifying as a réviseur d'entreprises agréé. Specific provisions relating
to in-kind contribution will be detailed in the Prospectus, if applicable.
7.7 The Company may reject any subscription in whole or in part, and the Directors may, at any time and from time
to time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of Shares of
any Class and/or Category in any one or more Sub-Funds.
7.8 If the Board of Directors determines that it would be detrimental to the existing Shareholders to accept a sub-
scription for Shares of any Sub-Fund that exceeds a certain level determined by the Board of Directors, the Board of
Directors may postpone the acceptance of such subscription and, in consultation with the incoming Shareholder, may
require him to stagger his proposed subscription over an agreed period of time.
7.9 If any subscription is not accepted in whole or in part, the subscription monies or the balance outstanding will be,
subject to applicable laws, returned without delay to the subscriber by post or bank transfer at the subscriber’s risk
without any interest.
Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 Any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company, under the terms and
procedures set forth by the Board of Directors in the Prospectus and within the limits provided by law and these Articles
of Incorporation. The Board may impose such restrictions as it deems appropriate on the redemption of Shares within
the limits provided by Luxembourg law and as further described in the Prospectus. The Board may, in particular, impose
notice periods, which must be respected in relation to redemptions, and in respect of a Sub-fund may levy a redemption
charge and has the right to waive partly or entirely this redemption charge.
8.2 The redemption price per Share shall be paid within a period as determined by the Board of Directors in accordance
with such policy as the Board of Directors may from time to time determine, provided that the redemption documents
have been received by the Company, subject to the provision of Article 12 hereof.
8.3 The redemption price shall be equal to the net asset value per Share of the relevant Class and/or Category of the
relevant Sub-Fund, as determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less such fees, charges and
commissions (if any) at the rate provided for in the Prospectus. The relevant redemption price may be rounded up or
down to the nearest cent, as the Board of Directors shall determine, the Company being entitled to receive the adjust-
ment. Moreover any taxes, commissions, and other fees incurred in connection with the transfer of the redemption
proceeds (including, among other things, those taxes, commissions and fees incurred in any country in which Shares are
sold) will be charged as a reduction to any redemption proceeds.
8.4 The Board of Directors may, in its entire discretion, decide that if as a result of any request for redemption, the
number or the aggregate net asset value of the Shares held by any Shareholder in any Sub-Fund, Class and/or Category
would fall below such number or such value as determined by the Board of Directors, the Company may decide to treat
this request as a request for redemption for the full balance of such Shareholder's holding of Shares in such Class, Category
and/or Sub-Fund.
8.5 Payments in cash will be made in the reference currency of the relevant Sub-Fund or Class or in any currency
provided by decision of the Board of Directors.
140759
L
U X E M B O U R G
8.6 Further, if on any given date redemption requests pursuant to this Article 8 (either singly or aggregated) exceed
a certain level determined by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus in relation to the net assets of a
specific Sub-Fund, the Board of Directors may decide to scale down pro rata each request for redemption so that the
redemptions do not exceed the level determined by the Board of Directors. On the next Valuation Day following that
period, these redemption requests will be met in priority to later requests.
8.7 The Company shall have the right, if the Board of Directors so determines and with the consent of the redeeming
Shareholder(s), to satisfy payment of the redemption price to any Shareholder "in-kind" by allocating to such Shareholder
assets of the relevant Class or Classes of Shares equal in value as of the Valuation Day on which the redemption price is
calculated to the net asset value of the Shares to be redeemed, less any applicable fees and charges. The nature and type
of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the
interests of the other Shareholders of the relevant Class(es) of Shares. Any such in-kind redemptions will be valued in a
report by the auditors which qualifies as a "réviseur d'entreprises agréé". The costs of such report shall be borne by the
redeeming Shareholder(s) unless such in-kind payments are in the interests of all the Shareholders in which case such
costs will be borne by the relevant Sub-Fund or Class.
8.8 In addition, under special circumstances, including but not limited to, the inability to liquidate positions at acceptable
price levels as of a redemption date or default or delay in payments due to the relevant Sub-Fund from brokers, banks
or other persons or entities, the Company in turn may delay payments to redeeming Shareholders of that part of the net
asset value represented by the sums which are the subject of such default or delay.
8.9 The Company may at any time compulsorily redeem Shares in accordance with the provisions of Article 24 or
from Shareholders who are excluded from the acquisition or ownership of Shares in the Company (such as a Prohibited
Person), any given Sub-Fund or Class and/or Category, pursuant to the procedure set forth in Article 10 and the Pros-
pectus.
8.10 All redeemed Shares shall be cancelled.
Art. 9. Conversion of Shares.
9.1 Any Shareholder is entitled to request the conversion of whole or part of his Shares, provided that the Board of
Directors may (i) set restrictions, terms and conditions as to the right for and frequency of conversions between certain
Shares and (ii) subject them to the payment of such charges and commissions as it shall determine.
9.2 The Board of Directors may, in its entire discretion, decide that if as a result of any request for conversion, the
number or the aggregate net asset value of the Shares held by any Shareholder in any Sub-Fund, Class and/or Category
would fall below the minimum holding requirement as determined by the Board of Directors, the Company may decide
to treat this request as a request for conversion for the full balance of such Shareholder's holding of Shares in such Class,
Category and/or Sub-Fund.
9.3 Further, if on any given date conversion requests pursuant to this Article 9 (either singly or aggregated) exceeds
a certain level determined by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus in relation to the net assets of a
specific Sub-Fund the Board of Directors may decide to scale down pro rata each application so that the conversions do
not exceed the level determined by the Board of Directors. On the next Valuation Day following that period, these
conversion requests will be met in priority to later requests.
9.4 The price for the conversion of Shares shall be computed by reference to the respective net asset value of the two
Classes and/or Categories concerned, calculated on the same Valuation Day or any other day as determined by the Board
of Directors in accordance with Article 11 of these Articles of Incorporation and the rules laid down in the Prospectus.
Conversion fees, if any, may be imposed upon the Shareholder(s) requesting the conversion of his Shares at a rate provided
for in the Prospectus.
9.5 The Shares which have been converted into Shares of another Sub-Fund shall be cancelled.
Art. 10. Restrictions on ownership of Shares and transfer of Shares.
10.1 The Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm or corporate
body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of
any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to
tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred (such persons, firms or
corporate bodies to be determined by the Board of Directors being herein referred to as "Prohibited Persons"). As the
Company is not registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, nor has the Company been
registered under the United States Investment Company Act of 1940, as amended, its Shares may not be offered or sold,
directly or indirectly, in the United States of America or its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction,
or to citizens or residents thereof (for these purposes, "U.S. Persons"). Furthermore, the Company may limit the sale of
certain Classes of Shares to institutional investors only, if provided for in the Prospectus (such institutional investors,
together with Prohibited Persons and U.S. Persons being "Non-Qualified Persons" for the purposes of these Articles of
Incorporation).
10.2 For such purposes the Company may:
(a) decline to issue any Shares and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registration
or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such Shares by a Non-Qualified Person; and
140760
L
U X E M B O U R G
(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares
on the register of Shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests in a Non-Qualified
Person, or whether such registration will result in beneficial ownership of such Shares by a Non-Qualified Person; and
(c) decline to accept the vote of any Non-Qualified Person at any meeting of Shareholders of the Company; and
(d) where it appears to the Company that any Non-Qualified Person either alone or in conjunction with any other
person is a beneficial owner of Shares, direct such Shareholder to sell his Shares and to provide to the Company evidence
of the sale within thirty (30) days of the notice. If such Shareholder fails to comply with the direction, the Company may
compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the
following manner:
(1) The Company shall serve a second notice (the "Purchase Notice") upon the Shareholder holding such Shares or
appearing in the register of Shareholders as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be purchased
as aforesaid, the manner in which the Purchase Price will be calculated and the name of the purchaser.
(2) Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope
addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. Immediately after
the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such Shareholder shall cease to be the owner of the
Shares specified in such notice and his name shall be removed from the register of Shareholders.
(3) The price at which each such Share is to be purchased (the "Purchase Price") shall be an amount based on the net
asset value per Share of the relevant Class and/or Category as at the Valuation Day specified by the Board of Directors
for the redemption of Shares in the Company next preceding the date of the Purchase Notice, as determined in accordance
with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.
(4) Payment of the Purchase Price will be made available to the former owner of such Shares normally in the currency
fixed by the Board of Directors for the payment of the redemption price of the Shares of the relevant Class and/or
Category and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere
(as specified in the Purchase Notice) upon final determination of the Purchase Price. Upon service of the Purchase Notice
as aforesaid such former owner shall have no further interest in such Shares or any of them, nor any claim against the
Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the Purchase Price (without interest) from such
bank. Any funds receivable by a Shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from
the date specified in the Purchase Notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the Sub-Fund relating to the
relevant Class and/or Category. The Board of Directors shall have power from time to time to take all steps necessary
to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.
(5) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Purchase Notice, provided in such case
the said powers were exercised by the Company in good faith.
10.3 The expression "Non-Qualified Person" as used herein does not include any subscriber to Shares of the Company
issued in connection with the incorporation of the Company while such subscriber holds such Shares.
Art. 11. Calculation of net asset value per Share.
11.1 Unless otherwise decided by the Board of Directors, the net asset value per Share of each Class and/or Category
of Shares in each Sub-Fund shall be calculated in the reference currency of the relevant Sub-Fund (as disclosed in the
Prospectus). It shall be determined as of any Valuation Day (as determined in the Prospectus).
11.2 The net asset value per Share or each Class in each Sub-Fund on any Valuation Day is determined by dividing the
net assets of the relevant Sub-Fund attributable to each Class and/or Category, being the value of the portion of assets
less the portion of liabilities attributable to such Class and/or Category, on any Valuation Day, by the total number of
Shares in the relevant Class and/or Category in issue on such Valuation Day, in accordance with the valuation rules set
forth below.
11.3 The subscription price and the redemption price of the different Classes, as the case may be, will differ within
each Sub-Fund as a result of the differing fee structure, dealing currency and/or distribution policy for each Class, as the
case may be.
11.4 In determining the net asset value per Share, income and expenditure are treated as accruing daily. The net asset
value per Share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant reference currency as the Board of
Directors shall determine.
11.5 The valuation of the net asset value of the different Classes and/or Categories shall be made in the following
manner:
The assets of the Company shall include:
(1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
(2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
140761
L
U X E M B O U R G
(3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights,
warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company
(provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (i) below with regards
to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
(4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information
thereon is reasonably available to the Company;
(5) all interest accrued on any interest bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such asset;
(6) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing Shares of the Company,
insofar as the same have not been written off;
(7) the liquidating value of all forward contracts, swaps and all call or put options the Company has an open position
in;
(8) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of such assets shall be determined as follows:
(i) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends, interest declared or accrued and not yet received, all of which are deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after
making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;
(ii) Securities listed on a recognized stock exchange or dealt on any other regulated market will be valued at their
latest available prices, or, in the event that there should be several such markets, on the basis of their latest available
prices on the main market for the relevant security;
(iii) In the event that the latest available price does not, in the opinion of the Company, truly reflect the fair market
value of the relevant securities, the value of such securities will be defined by the Company based on the reasonably
foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith;
(iv) Securities not listed or traded on a stock exchange or not dealt on another regulated market will be valued on
the basis of the probable sales proceeds determined prudently and in good faith by the Company (respectively by the
Management Company, if any); and the liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges
or on other regulated markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by
the Company, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures,
forward or options contracts traded on exchanges or on other regulated markets shall be based upon the last available
settlement prices of these contracts on exchanges and regulated markets on which the particular futures, forward or
options contracts are traded by the Company, provided that if a futures, forward or options contract could not be
liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating
value of such contract shall be such value as the Company may deem fair and reasonable. All other securities and other
assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Company;
(v) The net asset value per Share may be determined by using an amortized cost method for all investments with a
known short-term maturity date (i.e. maturity of less than three months). This involves valuing an investment at its cost
and thereafter assuming a constant amortization to maturity of any discount or premium, regardless of the impact of
fluctuating interest rates on the market value of the investments. While this method provides certainty in valuation, it
may result in periods during which value, as determined by amortization cost, is higher or lower than the price the relevant
Sub-Fund would receive if it sold the investment. The Company will continually assess this method of valuation and
recommend changes, where necessary, to ensure that the Sub-Fund’s investments will be valued at their fair value as
determined in good faith by the Company. If the Company believes that a deviation from the amortized cost per Share
may result in material dilution or other unfair results to Shareholders, the Company shall take such corrective action, if
any, as it deems appropriate to eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results;
(vi) The Sub-Funds shall, in principle, keep in their portfolio the investments determined by the amortization cost
method until their respective maturity date;
(vii) Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates
curve. Index and financial instruments related swaps will be valued at their market value established by reference to the
applicable index or financial instrument. The valuation of the index or financial instrument related swap agreement shall
be based upon the market value of such swap transaction established in good faith pursuant to procedures established
by the Company;
(viii) Shares or units of UCIs are valued on the basis of their latest available net asset value;
(ix) all other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established
by the Company;
(x) the Company, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such
valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.
The liabilities of the Company shall include:
(1) all loans, bills and accounts payable;
140762
L
U X E M B O U R G
(2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
(3) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;
(4) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the relevant Valuation Day, as determined
from time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the Board of Directors; and
(5) All other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares of the
Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable and all
costs incurred by the Company, which shall comprise the Global Management Fee and the Other Fees (as such terms
are defined in the Prospectus). The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring
nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over
any such period.
The assets shall be allocated as follows:
(1) The proceeds to be received from the issue of Shares of any Class and/or Category shall be applied in the books
of the Company to the Sub-Fund corresponding to that Class and/or Category, provided that if several Classes and/or
Categories are outstanding in such Sub-Fund, the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such
Sub-Fund attributable to that Class and/or Category;
(2) The assets and liabilities and income and expenditure applied to a Sub-Fund shall be attributable to the Class(es)
and/or Category(ies) corresponding to such Sub-Fund;
(3) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the
Company to the same Class(es) and/or Categories as the assets from which it was derived and on each revaluation of an
asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant Class(es) and/or Category(ies);
(4) Where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Class and/or Category within a Sub-
Fund or to any action taken in connection with an asset of a particular Class and/or Category within a Sub-Fund such
liability shall be allocated to the relevant Class and/or Category;
(5) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Class and/or Category, such asset or liability shall be allocated to all the Classes and/or Categories pro rata to their
respective net asset values or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith, provided
that (i) where assets, on behalf of several Sub-Funds, Classes and/or Categories are held in one account and/or are co-
managed as a segregated pool of assets by an agent of the Board of Directors, the respective right of each Class and/or
Category shall correspond to the prorated portion resulting from the contribution of the relevant Class and/or Category
to the relevant account or pool, and (ii) the right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals made
for the account of the Class and/or Category, as described in the Prospectus, and finally (iii) all liabilities, whatever the
Class and/or Category they are attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with the creditors, be binding upon
the Company as a whole;
(6) Upon the payment of distributions to the holders of any Class and/or Category, the net asset value of such Class
and/or Category shall be reduced by the amount of such distributions;
(7) All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles;
(8) In the absence of bad faith, negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by
the Board of Directors or by any bank, company or other organization which the Board of Directors may appoint for
the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future
Shareholders.
For the purpose of this Article:
(1) Shares of the Company to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the time specified by the Board of Directors on the Valuation Day on which such valuation is made
and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
(2) Shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the Board of
Directors on the Valuation Day on which such valuation is made and from such time and until received by the Company
the price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;
(3) All investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the reference currency of the
relevant Sub-Fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and
time for determination of the net asset value per Share; and
(4) where on any Valuation Day the Company has contracted to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
140763
L
U X E M B O U R G
- provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Day, then its value shall be estimated by the Company.
11.6 The net assets of the Company are at any time equal to the total of the net assets of the various Sub-Funds.
11.7 In determining the net asset value per Share, income and expenditure are treated as accruing daily.
11.8 The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a Sub-Fund will be converted into
the reference currency of such Sub-Fund at the rate of exchange determined on the relevant Valuation Day in good faith
by or under procedures established by the Board of Directors.
11.9 The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers
that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.
Art. 12. Frequency and temporary suspension of calculation of net asset value per Share, of issue, redemption and
conversion of Shares.
12.1 With respect to each Class and/or Category of Shares, the net asset value per Share and the price for the issue,
redemption and conversion of Shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed
thereto by the Company, at least twice a month at a frequency determined by the Board of Directors and determined
in the Prospectus, such date or time of calculation being referred to herein as the "Valuation Day".
12.2 The Company may suspend the determination of the net asset value per Share in one or more Sub-Fund(s) and
the issue, redemption and conversion of any Shares to and from its Shareholders in the following circumstances:
(1) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which a substantial portion of
the investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise
than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction
or suspension affects the valuation of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund quoted thereon;
(2) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Directors as a
result of which disposal or valuation of assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund would be imprac-
ticable;
(3) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price
or value of any of the investments of such Sub-Fund or the current price or value on any stock exchange or other market
in respect of the assets attributable to such Sub-Fund;
(4) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of Shares of such Sub-Fund, or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition
of investments or payments due on redemption of Shares cannot, in the opinion of the Directors, be effected at normal
rates of exchange;
(5) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to such Sub-Fund,
cannot promptly or accurately be ascertained;
(6) upon the publication of a notice convening a general meeting of Shareholders for the purpose of winding-up the
Company;
(7) in all other cases as provided for in the 2010 Law; or
(8) with respect to a feeder Sub-Fund, when its master UCITS temporarily suspends, on its own initiative or at the
request of its competent authorities, the redemption, the reimbursement or the subscription of its units; in such a case
the suspension of the calculation of the Net Asset Value at the level of the feeder Sub-Fund will be for a duration identical
to the duration of the suspension of the calculation of the Net Asset Value at the level of the master UCITS.
12.3 The Suspension of the determination of the net asset value of any particular Sub-Fund shall have no effect on the
determination of the net asset value per Share or on the issue, redemption and conversion of Shares of any Sub-Fund
that is not suspended.
12.4 Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of a suspension
of the determination of the net asset value per Share.
12.5 Any such suspension of the net asset value will be notified to investors having made an application for subscription,
redemption or conversion of Shares in the Sub-Fund(s) concerned and will be published if required by law.
Title III. - Administration and supervision
Art. 13. Directors.
13.1 The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members, who need
not be Shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. In case a Director is
elected without any indication on the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his
election. Upon expiry of its mandate, a Director may seek reappointment.
13.2 The Directors shall be elected by a general meeting of Shareholders, which shall further determine the number
of Directors, their remuneration and the term of their office.
13.3 Directors shall be elected by the majority of the votes of the Shares present or represented at such general
meeting.
140764
L
U X E M B O U R G
13.4 Any Director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the
general meeting. In case after such removal the number of Directors would fall below the minimum legal requirement,
the Director removed will remain in function until its successor is elected and take up its functions.
13.5 In the event of a vacancy in the office of a Director, the remaining Directors may temporarily fill such vacancy;
the Shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.
Art. 14. Board meetings.
14.1 The Board of Directors may choose from among its members a chairman. The first chairman may be appointed
by the first general meeting of Shareholders.
14.2 The Board of Directors may choose one or more vicechairmen. It may also choose a secretary, who need not
be a Director, who shall write and keep the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders.
The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two Directors, in Luxembourg or, as the case may
be from time to time, any such other place as indicated in the notice of meeting.
14.3 The chairman shall preside at the meetings of the Directors and of the Shareholders. In his absence, the Share-
holders or the Directors shall decide by a majority vote that another Director, or in case of a Shareholders' meeting,
that any other person shall be in the chair of such meetings.
14.4 Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours
prior to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex,
telefax, e-mail or any other similar means of communication, of each Director. Separate notice shall not be required for
meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the Board of Directors.
14.5 Any Director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex, e-mail or telefax or any other
similar means of communication another Director as his proxy. A Director may represent several of his colleagues.
14.6 Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video conference or
similar means of communications complying with technical features which guarantee an effective participation to the
meeting allowing all persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective
participation of such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered
office of the Company. Each participating Director shall be authorised to vote by video or by telephone or similar means
of communications.
14.7 The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The Directors may not bind
the Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the Board of Direc-
tors.
14.8 The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the Directors, or any other
number of Directors that the Board may determine, are present or represented.
14.9 Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, in
his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or by any two Directors. Copies of extracts of
such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting
or any two Directors.
14.10 Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented. In the event that at any
meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
14.11 Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at
the Board meetings; each Director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax, e-mail or any other
similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that
proves that such decision has been taken.
Art. 15. Powers of the Board of Directors.
15.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition, management and
administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as determined in Article 18 hereof
and the Prospectus.
15.2 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of
Shareholders are in the competence of the Board of Directors.
15.3 The Board of Directors may appoint a management company submitted to Chapter 15 of the 2010 Law in order
to carry out the functions described in Annex II of the 2010 Law.
Art. 16. Corporate signature.
16.1 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two Directors or by the joint
or single signature of any officer(s) of the Company or of any other person(s) to whom authority has been delegated by
the Board of Directors.
140765
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Delegation of powers.
17.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company
(including the right to act as authorized signatory for the Company) and the representation of the Company for such
daily management and affairs to any member of the Board of Directors, officers or other agents, legal or physical person,
who may but are not required to be Shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Board
of Directors shall determine and who may, if the Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.
17.2 The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any person, and may, in particular
appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any other officers that the
Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such appointments may be cancelled at
any time by the Board of Directors. The officers need not be directors or Shareholders of the Company. Unless otherwise
stipulated by these Articles of Incorporation, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the
Board of Directors.
17.3 Furthermore, the Board of Directors may create from time to time one or several committees composed of
directors and/or external persons and to which it may delegate powers as appropriate.
17.4 The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 18. Investment policies and restrictions.
18.1 The Board of Directors, based upon the principle of risk diversification, has the power to determine the investment
policy for the investments and the course of conduct of the management and business affairs of each Sub-Fund, all within
the investment powers and restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in the Prospectus, provided that
at all times the investment policy of the Company and of each Sub-Fund of the Company complies with Part I of the 2010
Law, and any other law or regulation with which it must comply in order to qualify as an undertaking for collective
investment in transferable securities ("UCITS") under article 1(2) (a) and (b) of Directive 2009/65/EC of 13 July 2009 of
the EU Parliament and of the Council on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to
UCITS.
18.2 The Board of Directors, acting in the best interests of the Company, may decide, in the manner described in the
Prospectus, that (i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-Fund be co-managed on a segregated basis
with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their Sub-Funds,
or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-Funds be co-managed amongst themselves on a segregated or on
a pooled basis.
18.3 Investment Policy
In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may cause the assets of each
Sub-Fund to be invested in:
(a) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market, as defined in
article 4 (1) (14) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004;
(b) transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in a Member State
which operates regularly and is recognised and open to the public. For the purpose of these Articles of Incorporation,
the term "Member State" refers to a member state of the European Union, it being understood that the states that are
contracting parties to the agreement creating the European Economic Area other than the Member States of the European
Union, within the limits set forth by this Agreement and related acts, are considered as equivalent to Member States of
the European Union;
(c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-
Member State or dealt in on another regulated market in a non-Member State which operates regularly and is recognised
and open to the public located within any other country of Europe, Asia, Oceania, the American continents or Africa;
(d) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an
undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated
market referred to under paragraphs (a) to (c) above and that such admission is secured within one year of issue;
(e) Shares or units of UCITS authorised according to Directive 2009/65/EC and/or other undertakings for collective
investment (the "UCIs", each a "UCI") within the meaning of article 1 (2)(a) and (b) of Directive 2009/65/EC, should they
be situated in a Member State or not, provided that:
i. such other UCI are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF") to be equivalent to that laid down in Community law, and
that cooperation between authorities is sufficiently ensured;
ii. the level of guaranteed protection for unit-holders in such other UCI is equivalent to that provided for unit-holders
in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable
securities and money market instruments are equivalent to the requirements of the Directive 2009/65/EC;
iii. the business of the other UCI is reported in semi annual and annual reports to enable an assessment to be made
of the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;
140766
L
U X E M B O U R G
iv. no more than 10% of the UCITS or the other UCI assets, whose acquisition is contemplated, can be, according to
its management regulations or instruments of incorporation, invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs;
Each Sub-Fund may also acquire Shares of another Sub-Fund subject to the provisions in section 18.2 below.
(f) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing
in no more than twelve (12) months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State or,
if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it is subject to prudential
rules considered by the competent authorities of UCITS home Member State as equivalent to those laid down in Com-
munity law;
(g) financial derivative instruments, including equivalent cashsettled instruments, dealt in on a regulated market referred
to in paragraphs (a) to (d); and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter (the "OTC Derivatives"),
provided that:
i. the underlying consists of instruments covered by paragraphs (a) to (h), financial indices, interest rates, foreign
exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to the investment objectives as stated in the
UCITS' management regulations or instruments of incorporation;
ii. the counter-parties to OTC Derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging
to the categories approved by the CSSF; and
iii. the OTC Derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a weekly basis and can be sold, liquidated or
closed by an offsetting transaction at any time at their fair market value at the Company' s initiative;
(h) money market instruments other than those dealt in on a regulated market and referred to in paragraphs (a) to
(c) above, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings,
and provided that they are:
i. issued or guaranteed by a central, regional or local authority, a central bank of a Member State, the European Central
Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by
one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States
belong; or
ii. issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in paragraphs (a), (b)
or (c); or
iii. issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by
Community law or by an establishment which is subject to and comply with prudential rules considered by the CSSF to
be at least as stringent as those laid down by Community law; or
iv. issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such ins-
truments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third indent of
this paragraph (h) and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount at least to ten million
euros (EUR 10,000,000.-) and which presents and publishes its annual accounts in accordance with Fourth Directive
78/660/EEC, is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated
to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit
from a banking liquidity line.
However, the Company and each of its Sub-Funds may invest no more than 10% of the net assets of any Sub-Fund in
transferable securities and money market instruments other than those referred to in paragraph (a) to (h) above.
Moreover, the Company and each of its Sub-Funds may hold liquid assets on an ancillary basis, and may acquire movable
and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business.
The Company may not acquire either precious metals or certificates representing them.
18.4 Risk diversification and investment restrictions
The Company may further invest up to 100% of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of
risk-spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, its local
authorities, a non-Member State which is member of the Organisation for Economic Co-Operation and Development or
public international bodies of which one or more Member States are members; provided that in such event, the Sub-Fund
concerned must hold securities from at least six different issues, but securities from any one issue may not account for
more than 30% of the total amount.
18.5 Each Sub-Fund may also subscribe for, acquire and/or hold Shares issued or to be issued by one or more other
Sub-Funds of the Company subject to additional requirements which may be specified in the prospectus, if:
(i) the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target Sub-Fund; and
(ii) no more than 10% of the assets of the target Sub-Fund whose acquisition is contemplated may be invested pursuant
to its instruments of incorporation in units of other UCIs; and
(iii) voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund
concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
140767
L
U X E M B O U R G
(iv) in any event, for as long as these securities are held by the Company, their value will not be taken into consideration
for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets
imposed by the 2010 Law; and
(v) there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund
having invested in the target Sub-Fund, and this target Sub-Fund.
18.6 The Company may invest in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be
set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations.
18.7 All other investment restrictions are specified in the Prospectus.
Art. 19. Conflict of interest.
19.1 No contract or other transaction which the Company and any other company or firm might enter into shall be
affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in such
other company or firm by a close relation, or is a Director, associate, officer or employee of such other company or legal
entity, provided that the Company obliges itself to never knowingly sell or lend assets of the Company to any of its
Directors or officers or any company or firm controlled by them. Any officer or director of the Company who serves
as an officer, director or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage
in business shall not by reason of such affiliation with such other company or firm be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
19.2 In the event that any Director or officer of the Company may have any opposite interest in any contract or
transaction of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such opposite interest
and shall not consider or vote upon any such contract or transaction. Such contract or transaction, and such Director's
or officer's opposite interest therein, shall be reported to the next succeeding general meeting of Shareholder(s).
19.3 The provisions of the preceding paragraph are not applicable when the decisions of the Board of Directors concern
day-to-day operations engaged at arm's length.
19.4 The term "conflict of interests", as used in this Article, shall not include any relationship with or without interest
in any matter, position or transaction involving the promoter, an investment manager, management company, custodian,
distributor as well as any other person, company or entity as may from time to time be determined by the Board of
Directors in its discretion.
Art. 20. Indemnification of Directors.
20.1 The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a Shareholder or a creditor and which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or wilful
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
20.2 The Board of Directors may decide that expenses incurred by any director or officer in accordance with article
20.1 hereof could be advanced to the indemnified director or officer, provided that this director or officer will repay the
advanced amounts if it is ultimately determined that he has not met the standard of care for which indemnification is
available.
20.3 The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which any Director or officer may be
entitled.
Art. 21. Auditors.
21.1 The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an auditor ("réviseur
d'entreprises agréé") appointed by the general meeting of Shareholders and remunerated by the Company.
21.2 The auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2010 Law.
Title IV. - General meetings - Accounting year - Distributions
Art. 22. General meetings of Shareholders of the Company.
22.1 The Company may have a sole Shareholder at the time of its incorporation or when all its Shares come to be
held by a single person. The death or dissolution of the sole Shareholder does not result in the dissolution of the Company.
22.2 If there is only one Shareholder, the sole Shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of
Shareholders and takes the decision in writing.
22.3 In case of plurality of Shareholders, the general meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire
body of Shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the Shareholders regardless of the Class
and/or Category held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
140768
L
U X E M B O U R G
22.4 The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the
Company or such other place in Grand Duchy of Luxembourg, as may be specified in the notice of meeting, on the first
Monday in March at 10:30 a.m. Luxembourg time. If such day is not a full Luxembourg bank business day (as defined in
the Prospectus) (a "Luxembourg Business Day"), the annual general meeting shall be held on the next following Luxem-
bourg Business Day. The annual general meeting may be held abroad if, in the judgement of the Board of Directors,
exceptional circumstances so require.
22.5 Other meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices
of meeting.
22.6 Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors pursuant to a notice setting forth the agenda. The
convening notice shall be made in the form prescribed by law. The convening notices to general meetings may provide
that the quorum and the majority requirements at the general meeting shall be determined according to the Shares issued
and outstanding at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the general meeting (referred to as "Record
Date").
22.7 A general meeting has to be convened at the written request of the Shareholders, which together represent one
tenth (10%) of the capital of the Company at such place and time as may be specified in the respective notices of meetings.
22.8 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of
the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
22.9 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to
attend any meeting of Shareholders.
22.10 Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction
of one or several items to the agenda of any general meeting of Shareholders. Such request must be addressed to the
Company's registered office be registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.
22.11 The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the
agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters except if all the Share-
holders agree to another agenda.
22.12 Each Share of whatever Class and/or Category in whatever Sub-Fund is entitled to one vote, in compliance with
Luxembourg law and these Articles of Incorporation. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing
another person as his proxy in writing or by cable, telegram or facsimile transmission. Such person need not be a Sha-
reholder and may be a Director.
22.13 Each Shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office
or to the address specified in the convening notice. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company
and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to
the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the Shareholder to vote in favour, against,
or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
22.14 Voting forms, which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void.
The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the general meeting of Shareholders
they relate to.
22.15 The Shareholders may be entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications
means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum and the majority conditions provided
that the Board of Directors is able to organise meetings by such means. These means must comply with technical features
guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.
22.16 Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority
vote of the Shares present or represented.
Art. 23. General meetings of Shareholders of a Sub-Fund, Class or of Category of Shares.
23.1 The Shareholders of a Sub-Fund, Class or Category issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time,
general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund, Class or Category.
23.2 The provisions set out in Article 22 of these Articles of Incorporation as well as in the Luxembourg law dated
10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law") shall apply to such general meetings.
23.3 Each Share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles of Incorporation.
Shareholders may act either in person or by giving a proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission
to another person who needs not be a Shareholder and may be a Director of the Company.
23.4 Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of Shareholders of a Sub-
Fund, Class or Category are passed by a simple majority vote of the Shares present or represented.
23.5 Any resolution of the general meeting of Shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of
Shares of any Sub-Fund, Class or Category vis-à-vis the rights of the holders of Shares of any other Sub-Fund, Class or
Category, shall be subject to a resolution of the general meeting of Shareholders of such Sub-Fund, Class or Category in
compliance with article 68 of the 1915 Law.
140769
L
U X E M B O U R G
Art. 24. Termination, Division and Merger of Sub-Funds, Classes and Categories.
24.1 In the event that for any reason the value of the total net assets in any Sub-Fund, Class or Category has decreased
to, or has not reached, an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level for such Sub-Fund,
Class or Category, to be operated in an economically efficient manner or in case of a modification in the political, economic
or monetary situation relating to the Sub-Fund, Class or Category which would have potential material adverse conse-
quences for that Sub-Fund, Class or Category or as a matter of economic rationalization, the Board of Directors may
decide to compulsorily redeem all the Shares of the relevant Sub-Fund, Class or Category at the net asset value per Share
(taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) as calculated on the Valuation Day
on which such decision shall take effect and subsequently close such Sub-Fund, Class or Category, as the case may be.
The Company shall serve a notice to the holders of the relevant Sub-Fund, Class or Category prior to the effective date
for the compulsory redemption, which will indicate the reasons for, and the procedures applicable to such compulsory
redemption: registered holders shall be notified in writing.
24.2 Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between, the Shareholders, the
Shareholders of the Sub-Fund, Class or Category concerned may continue to request redemption or conversion of their
Shares free of charge (but taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) prior to
the date effective for the compulsory redemption.
24.3 Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraphs, the general
meeting of Shareholders of any Sub-Fund, Class or Category may, upon proposal from the Board of Directors, resolve
to redeem all the Shares of the relevant Sub-Fund, Class or Category and refund to the Shareholders the net asset value
of their Shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the
Valuation Day on which such decision shall take effect. Furthermore, the general meeting of Shareholders may also put
a Sub-Fund into liquidation, under the same circumstances as provided for in the first paragraph of this Article 24. No
quorum shall be required for such a meeting and any decision to redeem shall be taken by simple majority of the Shares
present and/or represented at such meeting.
24.4 All redeemed Shares shall be cancelled by the Company. Assets which may not be distributed to their beneficiaries
upon the implementation of the redemption will be deposited at the end of the liquidation process with the Caisse de
Consignations on behalf of the persons entitled thereto, until the statutory limitation period has lapsed.
24.5 In addition, if a master UCITS is liquidated, divided into two or more UCITS or merged with another UCITS, the
feeder Sub-Fund shall also be liquidated, unless the CSSF approves:
a) the investment of at least 85 % of the assets of the feeder Sub-Fund in units of another master UCITS; or
b) the amendment of the fund documentation of the feeder Sub-Fund in order to enable it to convert into a Sub-Fund
which is not a feeder Sub-Fund.
24.6 Without prejudice to specific national provisions regarding compulsory liquidation, the liquidation of a master
Sub-Fund shall take place no sooner than three months after the master Sub-Fund has informed all of its shareholders
and the CSSF of the binding decision to liquidate.
24.7 The liquidation of a Sub-Fund shall not involve the liquidation of another Sub-Fund. Only the liquidation of the
last remaining Sub-Fund of the Company involves the liquidation of the Company.
24.8 The Board of Directors may decide, in accordance with the definitions and conditions set out in the UCI Law, to
allocate the assets of any Sub-Fund, Class or Category to (i) those of another existing Sub-Fund, Class or Category within
the Company; (ii) to another Luxembourg undertaking for collective investment in transferable securities subject to Part
I of the 2010 Law; or (iii) to a foreign UCITS subject to the Directive 2009/65/EC of 13 July 2009 of the EU Parliament
and of the Council on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS (the "New
Sub-Fund") and to redesignate the Shares of the relevant Sub-Fund, Class or Category concerned as Shares of another
Sub-Fund, Class or Category (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding
to any fractional entitlement to Shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in the
first paragraph of this Article (and, in addition, the publication will contain information in relation to the New Sub-Fund)
in such a way to enable Shareholders to request redemption or conversion of their Shares, free of charge, during one
month (prior to the date on which the merger becomes effective) and provided that such period will terminate five
Luxembourg Business Days before the exchange ratio is calculated.
24.9 Under the same circumstances as provided in the first paragraph of the Article 24, the Board of Directors may
decide to reorganise a Sub-Fund, Class or Category by means of a division into two or more Sub-Funds, Classes and/or
Categories. Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of this Article 24 (and,
in addition, the publication will contain information about the two or more New Sub-Funds) one month before the date
on which the division becomes effective, in order to enable the Shareholders to request redemption or conversion of
their Shares free of charge during such period.
24.10 Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraphs, the reorgani-
sation of Sub-Funds, Classes and/or Categories within the Company by way of a merger or division may also be decided
upon by a general meeting of the Shareholders of the relevant Sub-Fund(s), Class(es) and/or Category(ies) (i.e.: in the
case of a merger, this decision shall then be taken by the general meeting of the Shareholders of the contributing Sub-
140770
L
U X E M B O U R G
Fund, Class or Category). No quorum shall be required for such a meeting and any decision to redeem shall be taken by
simple majority of the Shares present and/or represented at such meeting.
24.11 Any request for subscription shall be suspended with effect from the date of the Board of Director’s decision
regarding the compulsory redemption, termination, the merger or the transfer of the relevant Sub-Fund, Class or Cate-
gory. Furthermore, no requests for subscription shall be possible anymore as of the decision by the Board of Directors
or, as the case may be, by the relevant general meeting of Shareholders, with regard to the compulsory redemption,
termination, the merger or the transfer of the relevant Sub-Fund, Class or Category.
24.12 Where a Sub-Fund has been established as a master Sub-Fund, no merger or division of shall become effective,
unless the relevant Sub-Fund has provided all of its Shareholders and the competent authorities of the home member
state of the feeder UCITS with the information required by law, by sixty days before the proposed effective date. Unless
the competent authorities of the home member state of the feeder UCITS have granted approval to continue to be a
feeder UCITS of the master Sub-Fund resulting from the merger or division of the relevant Sub-Fund, the relevant Sub-
Fund shall enable the feeder-UCITS to repurchase or redeem all Shares in the relevant Sub-Fund before the merger or
division of the relevant Sub-Fund becomes effective.
Art. 25. Master-Feeder structures.
25.1 The Board of Directors may, at any time it deems appropriate and to the widest extent permitted by applicable
laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the prospectus of the Company, (i) create any
Sub-Fund qualifying either as a feeder UCITS sub-fund or as a master UCITS sub-fund, (ii) convert any existing Sub-Fund
into a feeder UCITS sub-fund or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS sub-funds.
25.2 For conversions of existing Sub-Funds in feeder Sub-Funds and a change of the master UCITS the Shareholders
must be provided with the information required by the 2010 Law within the periods of time prescribed by law. The
Shareholders are entitled to redeem their Shares in the relevant Sub-Fund free of charge within thirty (30) days thereafter,
irrespective of the costs of the redemption.
Art. 26 Accounting year.
26.1 The accounting year of the Company shall begin on the first day of October of each year and shall terminate on
the thirtiest day of September of the next following year.
Art. 27. Distributions.
27.1 For any Sub-Fund, Class and/or Category entitled to distributions, the general meeting of Shareholders of the
relevant Sub-Fund, Class and/or Category issued in respect of any Sub-Fund shall, upon proposal from the Board of
Directors and within the limits provided by law, determine how the results of such Sub-Fund, Class and/or Category shall
be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the Board of Directors to declare, distributions.
27.2 For any Sub-Fund, Class and/or Category entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay
interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.
27.3 In any case, no distribution may be made if, after the declaration of such distribution, the Company's capital is
less than the minimum capital imposed by the 2010 Law.
27.4 Payments of distributions to holders of registered Shares shall be made to such Shareholders at their addresses
in the register of Shareholders.
27.5 Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the Board of Directors shall determine
from time to time.
27.6 Distributions will be made in cash. However, the Board of Directors may decide to foresee the possibility to
make in-kind distributions with the consent of the relevant Shareholder(s) in the Prospectus. Any such distributions/
payments in kind will be valued in a report established by an auditor qualifying as a réviseur d'entreprises agréé such
report to be drawn up in accordance with the requirements of Luxembourg law and the costs of which report will be
borne by the relevant Shareholder(s). To the extent possible, distributions in-kind will be made to the relevant Shareholder
(s) by taking into account the fair and equal treatment of the interests of all Shareholders. To the extent that the Company
makes in-kind payments in whole or in part, the Company will undertake its reasonable efforts, consistent with both
applicable law and the terms of the in-kind assets being distributed, to distribute such in-kind assets to each Shareholder
pro rata on the basis of the relevant Shareholder’s Shares of the relevant Sub-Fund.
27.7 Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the
relevant Sub-Fund, Class and/or Category. If the latter Sub-Fund, Class and/or Category has already been liquidated, the
distributions will accrue to the remaining Sub-Funds, Classes and/or Categories in proportion to their respective net
assets.
27.8 No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Title V. - Final provisions
Art. 28. Custodian.
28.1 To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking or saving
institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector as amended (the "Custodian").
140771
L
U X E M B O U R G
28.2 The Custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2010 Law.
28.3 If the Custodian desires to terminate the agreement with the Company, the Board of Directors shall use all its
reasonable endeavours to find another bank to be Custodian in place of the retiring Custodian, and the Board of Directors
shall appoint such bank as Custodian of the Company's assets. The Board of Directors may terminate the appointment
of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor Custodian shall have been appointed
to act in the place thereof.
Art. 29. Dissolution of the Company.
29.1 The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders subject to the
quorum and majority requirements referred to in Article 30 hereof.
29.2 Whenever the share capital of the Company falls below twothirds of the minimum capital indicated in Article 5
hereof, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the Board of Directors.
No quorum shall be required for such a meeting and any decision to redeem shall be taken by simple majority of the
Shares present and/or represented at such meeting.
29.3 The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the
share capital of the Company falls below one-fourth of the minimum capital set by Article 5 hereof. No quorum shall be
required for such a meeting, and the dissolution may be resolved by the Shareholders holding one quarter of the votes
present and represented at that meeting.
29.4 The extraordinary general meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from the date
when it is ascertained that the net assets of the Company have fallen below two-thirds or onefourth of the minimum
capital required by Luxembourg law, as the case may be.
Art. 30. Liquidation.
30.1 Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities,
appointed by the general meeting of Shareholders which shall determine their powers and the compensation. The liqui-
dator(s) must be approved by the Luxembourg supervisory authority.
30.2 The net product of the liquidation of each Sub-Fund shall be distributed by the liquidators to the Shareholder(s)
of the relevant Sub-Fund in proportion to the number of Shares which it/they hold in that Sub-Fund. The amounts not
claimed by the Shareholder(s) at the end of the liquidation shall be deposited with the Caisse des Consignations in
Luxembourg. If these amounts are not claimed before the end of a period of five years, the amounts shall become statute-
barred and cannot be claimed any more.
Art. 31. Amendments to the Articles of Incorporation.
31.1 These Articles of Incorporation may be amended by a general meeting of Shareholders subject to the quorum
and majority requirements provided by the 1915 Law.
Art. 32. Applicable law.
32.1 All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915
Law and the 2010 Law, as such laws have been or may be amended from time to time.
32.2 However the provisions contained in articles 13 (Directors) and 15 (Powers of the Board of Directors) of these
Articles of Incorporation may only be amended with a majority of seventy five per cent (75%) of the of the votes cast,
the quorum required being the one foreseen by the 1915 Law.
Art. 33. Statement.
33.1 Words importing a masculine gender also include the feminine gender and word importing persons or Share-
holders also include corporations, partnerships, associations, and any other organised group of persons, whether
incorporated or not.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year of the Company shall begin on the date of its incorporation and shall end on 30 September
2013.
The first annual report will be dated 30 September 2013.
The first annual general meeting of Shareholders shall be held in 2014.
<i>Subscriptioni>
The share capital has been subscribed as follows:
Class B Shares in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund
Subscriber
Subscribed capital
Number of Class B Shares
Oaktree Fund GP II, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD 41,000 (forty-one thousand)
410 (four hundred ten).
The four hundred ten (410) Class B Shares have been fully paid in cash, so that the sum of USD 41,000 (forty one
thousand) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proven to the notary.
140772
L
U X E M B O U R G
<i>First extraordinary general meeting of shareholdersi>
The above Shareholders, representing the totality of Shares and considering themselves as duly convened, have im-
mediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of Shareholders and have unanimously passed the following
resolutions:
1. The following are elected as Directors for a period of six years ending on the date of the annual general meeting of
Shareholders to be held in 2018:
- Mr Brian Beck, 333 South Grand Avenue, 28
th
Floor, Los Angeles, CA 90071, USA
- Mr John Edwards, 333 South Grand Avenue, 28
th
Floor, Los Angeles, CA 90071, USA; and
- Mr Tom Ware, 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom.
a. the initial chairman of the Board of Directors shall be Mr Brian Beck.
2. the Company's registered office is fixed at 5, rue Jean Monnet, L-2013 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
and
3. the following is appointed independent auditor for a period ending on the next annual general meeting of Share-
holders to be held in 2014: “PricewaterhouseCoopers”; 400, route d’Esch; L-1014 Luxembourg; Grand Duchy of
Luxembourg (RCS Luxembourg, section B number 65 477).
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the 1915 Law have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The above-named party has estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be
borne by the Sub-Fund or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about six thousand euro.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil
status and residence, said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Signé: C. LENNIG, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 novembre 2012. Relation: EAC/2012/14662. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012145845/950.
(120192230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
C.M.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 32, rue du Fort Dumoulin.
R.C.S. Luxembourg B 83.814.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 mai 2012 que:
- La société FIDUCIAL EXPERTISE S.A. est révoquée de sa fonction de Commissaire.
- La société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, Avenue de la Faïencerie, immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25 797 est nommée en tant que Commissaire
avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2012.
Le mandat de Commissaire de la société LUX-AUDIT S.A. arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2013.
Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 juin 2012
que:
Le mandat d’administrateur de Madame Cari PROCHAZKA arrivé à échéance, est renouvelé pour une période de
une année, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la Société
i>Un mandataire
Référence de publication: 2012145514/23.
(120192011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
140773
L
U X E M B O U R G
BSI Art Collection S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 79.264.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2012i>
1. La démission de la société Triple A Consulting, R.C.S. Luxembourg B 61417, ayant son siège social au 2, Millegässel
à L-2156 Luxembourg de son mandat de commissaire aux comptes est acceptée.
2. La société Alter Audit S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 110675, ayant son siège social au 2, Place de Strasbourg à L-2562
Luxembourg est nommée en tant que nouveau commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale de 2016.
3. L’adresse de la société est transférée du 3, Place Dargent – L-1413 LUXEMBOURG à la nouvelle adresse suivante:
6, avenue Marie-Thérèse - L-2132 LUXEMBOURG.
Certifié sincère et conforme
BSI ART COLLECTION S.A.
Référence de publication: 2012145513/17.
(120191757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Julius Baer Multiflex, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 130.982.
L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 22 octobre 2012 a décidé
I. de renouveler les mandats de
M. Freddy BRAUSCH
35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG
M. Andrew HANGES
12 St James's Place, GB-LONDON SW 1A 1NX,
M. Martin JUFER
Hardstrasse 201, CH-8005 ZÜRICH,
M. Jean-Michel LOEHR
14, Porte de France, L-4360 ESCH-SUR-ALZETTE,
M. Thomas VAN DITZHUYZEN
Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich,
M. Thomas VON BALLMOOS
Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich,
en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2013;
II. de renouveler le mandat de:
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2013.
<i>Pour Julius Baer Multiflex
i>Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012145742/31.
(120192217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
140774
L
U X E M B O U R G
C.RO Ports S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 149.469.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Particulière du 7 novembre 2012i>
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Franciscus, Johannes, Antonius Las, Administrateur de sociétés, demeurant
professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg, aux fonctions d’Administrateur. Son mandat expirera à
l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jozef Adriaens / Freddy Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012145515/14.
(120191644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Eldalux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9245 Diekirch, 2, Op der Meierchen.
R.C.S. Luxembourg B 102.845.
L'an deux mille douze, le cinq novembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
A comparu:
Monsieur Antoine Joseph DAHLEM, retraité, né à Wiltz le 19 mars 1942, demeurant à L-9556 Wiltz, 80, rue du Rocher.
Lequel comparant agissant en sa qualité d’associé représentant l'intégralité du capital social, de la société à responsa-
bilité limitée «ELDALUX s.à r.l», avec siège social à L-9556 Wiltz, 80, rue des Rochers, (matr: 1994 24 02 891),
devenu propriétaire des 10 parts existantes par acte sous seing privé daté du 16 juillet 2012, dont une copie, après
avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentaire, restera anenxée au présent acte pour être
enregistrée avec lui,
constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors de résidence à Wiltz, en date du 21 mars 1994, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 279 de 1994,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro B 102.845.
L’associé a ensuite requis le notaire d'acter la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’associé décide de transférer le siège social vers L-9245 Diekirch, 2, op der Meierechen et en conséquence de modifier
l’article 4 des statuts comme suit:
« Art. 4. Le siège de la société est établi dans la commune de Diekirch; Il pourra être transféré en coût autre lieu du
Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés»
<i>Déclaration du comparanti>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu’elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Antoine Joseph DAHLEM, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 7 novembre 2012. Relation: DIE/2012/13130. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> pd. (signé): P. Recken.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
140775
L
U X E M B O U R G
Ettelbruck, le 12 novembre 2012.
Référence de publication: 2012146958/40.
(120194306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Cedar Capital Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 120.643.
EXTRAIT
En date du 5 Novembre 2012, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Mr. Ivo Hemelraad comme gérant B de la société avec effet immédiat;
- Acceptation de la démission de Mr. Wim Rits comme gérant de la société avec effet immédiat;
- Nomination au poste de gérant B de Mr. Freddy De Petter, né le 29 août 1958 à Berchem (Belgique) et avec adresse
professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
- Nomination au poste de gérant B de Mr. Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling (Royaume Uni) et avec
adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet immédiat et pour une durée indé-
terminée;
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 08 Novembre 2012.
Référence de publication: 2012145518/19.
(120191830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Eversholt Investment Group SCS, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 156.437.
EXTRAIT
En date du 20 septembre 2012, l'associé commanditaire et les associés commandités ont decide de réduire le capital
social de la Société d'un montant de 19.938.465 GBP afin de le porter à un montant de 382.381.942 GBP.
Par conséquent, le capital social de la Société sera détenu de la manière suivante:
Associé
Type d'associé
Nombre de parts
d'intérêt détenues
Pourcentage de parts
d'intérêt détenues
Eversholt Investments G.P. Limited
Associé
Commandité
1 part d'associé
commandité
100% des parts
d'associées commandités
STAR Agatha investments S.à r.l.
Associé
Commanditaire
33.334 part d'intérêt
de classe A
122.873.980 parts
d'intérêt de classe B
33,33% des parts
d'intérêt de classe A
33,33 % des parts
d'intérêt de classe B
MSIP Sparrow B.V.
Associé
Commanditaire
33.334 part d'intérêt
de classe A
122.873.980 parts
d'intérêt de classe B
33,33 % des parts
d'intérêt de classe A
33,33 % des parts
d'intérêt de classe B
3i Infrastructure (Luxembourg) S.à r.l.
Associé
Commanditaire
33.334 part d'intérêt
de classe A
33,33 % des parts
d'intérêt de classe A
3i Infrastructure plc
Associé
Commanditaire
122.873.980 parts
d'intérêt de classe B
33,33 % des parts
d'intérêt de classe B
Suite à ces décisions, l'article 3.1 du Contrat de Partenariat est modifié comme suit:
"Le capital social de la Société payé par les associés de la Société à la date du présent contrat est établi à la somme
GBP 382.381.942 (trois cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-et-un mille neuf cent quarante-deux livres
Sterling)"
140776
L
U X E M B O U R G
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Eversholl Investment Group S.C.S.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012145616/35.
(120191886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Clyde Blowers Capital (RCP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 128.710,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 142.352.
<i>Extrait des résolutions prises à Luxembourg par l'associé unique de la société en date du 19 octobre 2012i>
Le mandat des gérants suivants est reconduit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant
les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2012:
- Madame Samia RABIA, demeurant professionnellement au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
- Monsieur Francois BROUXEL, demeurant professionnellement au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
- Monsieur James Allan McCOLL, demeurant Avenue Princesse Grace, MC-98000 Monaco,
- Monsieur Keith GIBSON, demeurant à Houston Road, GB - PA75NX Bishopton, Renfrewshire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145520/16.
(120191670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Agence Immobilière Mara Max S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 151, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 97.836.
L'an deux mille douze, le sept novembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Fernand HERTERT, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 16 juin 1964, demeurant à L-8352
Dahlem, 4, Um Paerchen.
2.- Madame Martine HOFFMANN, indépendante, née à Luxembourg, le 1
er
juin 1971, demeurant à L-4994 Sprinkange,
25, route de Longwy.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée «AGENCE IMMOBILIERE
MARA MAX S.àr.l.», établie et ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 33, rue Victor Hugo, société constituée aux
termes d'un acte reçu par Maître Georges d'Huart, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 9 décembre 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 98 du 24 janvier 2004, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 97836.
Ensuite les comparants, agissant en leurs dites qualités, représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité
la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-1750 Luxembourg, 33, rue Victor Hugo à L-4940
Bascharage, 151, avenue de Luxembourg, et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
« Art. 2. Le siège social de la société est établi à Bascharage. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: HERTERT, HOFFMANN, Moutrier Blanche.
140777
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08/11/2012. Relation: EAC/2012/14692. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 09 novembre 2012.
Référence de publication: 2012146102/38.
(120192496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.
Creo Hungary Luxembourg Branch Office, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 93.944.
FERMETURE D'UNE SUCCURSALE
Suite à une décision de la Budapest Metropolitan Court as Court of Registry prise en date du 18 octobre 2012 en
relation avec la radiation de la Société Creo Hungary Limited Liability Company, avec effet immédiat, il a été décidé de
prononcer la fermeture de la Succursale en date du 18 octobre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 8 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145527/13.
(120192229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Crystal Pool (Luxembourg) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 125.606.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Crystal Pool (Luxembourg) S.àr.l.
Tamir Ben Laiche / Christopher Jenner
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012145528/13.
(120191867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Serco Luxembourg S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 48.506.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2012i>
Il résulte des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 septembre 2012 que:
- Le siège social de la société est transféré du 560a, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 17, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg
- Le mandat de Monsieur Ian Mc Ilwrath, domicilié au 7, rue des Ecoles, B-1300 Limai en tant qu'administrateur-délégué
de la société, a été reconduit jusqu'au 21/09/2015.
- Les mandats d'administrateur de la société de:
* Monsieur Ian Mc Ilwrath, domicilié au 7, rue des Ecoles, B-1300 Limal
* Monsieur Simon Morton, domicilié au 1 Sundial Close, DE6 3DP Brailsford, Ashbourne,
* Monsieur Michael Alner, domicilié au The Cedars, Tile Barn, Woolton Hill, RG20 9UZ Hants,
* La société Serco International BV, ayant son siège social au 20A Ambachtsweg, 2222 Al Katwijk (Pays-Bas);
ont été reconduits jusqu'au 21/09/2015
- La démission de leurs mandats d'administrateur de Monsieur Emmanuel Adant et de la société Serco Europe Limited
ont été acceptées par les actionnaires.
- La société E.G.A. Management SPRL, ayant son siège social au 6 chaussée de Gembloux, B-5140 Tongrinne (Belgique)
a été nommée comme administrateur de la société jusqu'au 21/09/2015.
- Le mandat de Monsieur Jaques Massaria, en tant que commissaire aux comptes, a été reconduit jusqu'au 21/09/2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
140778
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 05 novembre 2012.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Référence de publication: 2012145956/28.
(120191705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Cardoso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6868 Wecker, 61B, Duchscherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 97.476.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2012i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-6868 Wecker, 7, Ieweschtgaass à L-6868 Wecker,
61b, Duchscherstrooss.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate le changement d'adresse de l'associé Monsieur Jaime CARDOSO DA SILVA et de l'associée-
gérante Madame Cristina Maria MARQUES MOREIRA de L-6868 Wecker, 7, Ieweschtgaass à L-6868 Wecker, 61b,
Duchscherstrooss.
POUR EXTRAIT CONFORME
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145529/17.
(120191584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Cavalcade S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 76.163.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145532/9.
(120192400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Cerampart, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 6, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 89.605.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145536/9.
(120192073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Chamberley S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 30.193.
Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 06 novembre 2012 ont été nommés,
jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2014:
- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur, Administrateur-délégué et Président;
- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a nommé
comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Madame Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxem-
bourg:
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.
140779
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012145539/18.
(120191847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Chricat Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 46.058.
Le siège social du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est dorénavant établi au 9, rue du Laboratoire, L - 1911
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145540/11.
(120191910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Clermon Holding Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 94.207.
Veuillez prendre note de la démission de la société Manacor (Luxembourg) S.A. comme Administrateur de la Société,
à compter du 5 novembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012145541/12.
(120192121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 158.131.
Les comptes annuels pour la période du 22 décembre 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Référence de publication: 2012145542/12.
(120192378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
CMP German Opportunity Investors Fund II (SCS) SICAR, Société en Commandite simple sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 159.488.
Les comptes annuels pour la période du 22 décembre 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Référence de publication: 2012145543/12.
(120192377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
140780
L
U X E M B O U R G
EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.000.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 168.467.
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 26 octobre 2012i>
En vertu de l'acte de transfert de parts daté du 26 octobre 2012, les associés Morgan Creek Partners V, L.P. et Morgan
Creek Partners Co-Investment Fund II, L.P. ont transféré la totalité de leurs parts détenues dans la Société de la manière
suivante:
- L'associé Morgan Creek Partners V, L.P. a transféré la totalité de ses parts détenues dans la Société de la manière
suivante:
506 actions de classe A, 506 actions de classe B, 506 actions de classe C, 506 actions de classe D et 507 actions de
classe E à la société MCP Baffin Lux S.à r.l., avec siège social au 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (Luxembourg)
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 170186.
- L'associé Morgan Creek Partners Co-Investment Fund II, L.P. a transféré la totalité de ses parts détenues dans la
Société de la manière suivante:
2.025 actions de classe A, 2.025 actions de classe B, 2.025 actions de classe C, 2.025 actions de classe D et 2.024
actions de classe E à la société MCP Baffin Lux S.à r.l., avec siège social au 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
(Luxembourg) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 170186.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012145604/26.
(120192037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
CBM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 175.000,00.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.855.
L'an deux mille douze, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Monsieur Philippe DE GROULAER, indépendant, né le 20 décembre 1962 à Gent (Belgique) et résidant à 9770
Kruishoutem (Belgique), Marolleweg 4,
ici représentée par Madame Irena COLAMONICO, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Lu-
xembourg, 74, avenue Victor Hugo en vertu d’une procuration sous seing privé du 28 septembre 2012;
et
2. Hunaudières Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.265, avec siège social à L-2561 Luxembourg, 31, rue
de Strasbourg, ici représentée par Madame Irena COLAMONICO, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing
privé du 28 septembre 2012;
Lesquelles procurations, paraphées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées au
présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions
suivantes, qui ont pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 162.500,- (cent soixante-deux mille cinq cents
euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 175.000,- (cent
soixante-quinze mille euros) avec émission de 1300 nouvelles parts sociales.
2.- Apport, intervention de l’apporteur, Monsieur Philippe DE GROULAER par apport en nature consistant en les
droits de propriété intellectuelle sur Carrera Motors Magazine d’une part (OBPI 0917702) et Daeninck Magazine d’autre
part (OBPI 0917703), pour un montant total de EUR 162.500.- (cent soixante-deux mille cinq cents euros).
140781
L
U X E M B O U R G
3.- Acceptation par les gérants de la Société.
4.- Modification afférente de l'article cinq des statuts de la Société
5.- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence d'un montant de EUR 162.500,- (cent
soixante-deux mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros)
à EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros), avec émission de 1.300 nouvelles parts sociales, laquelle augmentation
est souscrite et libérée par l’Associé Philippe De Groulaer par des apports autres qu’en numéraires consistant en:
les droits de propriété intellectuelle sur Carrera Motors Magazine d’une part (OBPI 0917702) et Daeninck Magazine
d’autre part (OBPI 0917703), pour un montant total de EUR 162.500 (cent soixante-deux mille cinq cents euros).
Les Associés déclarent que la valeur de l’apport a été calculée sur base d’un rapport établi par le Collège des Gérants
en date du 19 septembre 2012.
Ledit rapport, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et par le notaire instrumentant, demeurera annexé
au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.
<i>Interventioni>
Sont alors intervenus aux présentes:
1. Monsieur Philippe DE GROULAER, prénommé, tel que représenté, agissant en sa qualité de Gérant de la CBM S.à
r.l. lequel reconnaît avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagée en sa dite qualité de
gérant à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, et marque expressément son accord sur l'existence et la description
de l'apport en nature, sur son évaluation et confirme la validité des souscriptions et libération.
et
2. Hunaudières Invest S.à r.l., prénommée, telle que représentée, agissant en sa qualité de Gérant de la CBM S.à r.l.
lequel reconnaît avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagée en sa dite qualité de gérant
à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, et marque expressément son accord sur l'existence et la description de
l'apport en nature, sur son évaluation et confirme la validité des souscriptions et libération.
Les gérants s’engagent à faire toutes les formalités requises afin de rendre opposable aux tiers le susdit apport, no-
tamment l’inscription dans le registre des associés de la société CBM S.à r.l..
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, il est
décidé de modifier l'article cinq, premier alinéa, des statuts de CBM S.à r.l. pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. "Le capital social est fixé à EUR 175.000 (cent soixante-quinze mille euros), représenté par 1.400 (mille quatre
cents) parts sociales sans valeur nominale, libérées intégralement".
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, rémunération et charges, incombant à la Société en raison de la présente augmentation de capital,
est estimé approximativement à la somme de mille huit cents euros (1.800,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: I. Colamonico et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 03 octobre 2012. LAC/2012/46069. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145534/76.
(120192136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
140782
L
U X E M B O U R G
Les Espaces Saveurs S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 78.320.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 24 octobre
2012 que:
Le mandat des Administrateurs en place a été renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans. Le conseil d'administration
se compose comme suit:
- Madame Alexandra COLAIANNI-DILSCHNEIDER documentaliste, demeurant à L-2168 Luxembourg, 121, rue de
Mùhlenbach
- Monsieur Olivier FELLMANN, indépendant, demeurant à L-5222 Sandweiler, 2, Am Steffesgaart
- Madame Sandrine DILSCHNEIDER administrateur de société, demeurant à L-5750 Frisange, 63, route de Mondorf
Le mandat du Commissaire en place, la société LUX-AUDIT S.A. a été renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans.
Le mandat des Administrateurs et le mandat du Commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2018.
Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 24 octobre 2012
que:
- Madame Alexandra COLAIANNI-DILSCHNEIDER a été nommée Présidente du Conseil d'Administration pour la
durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des action-
naires qui se tiendra en 2018.
- Madame Alexandra COLAIANNI-DILSCHNEIDER a été nommée en tant qu'Administrateur-délégué de la société
pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.
Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux administrateurs,
ou encore par la signature individuelle de l'Administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012147125/32.
(120193462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
D.B. International Finance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 33.911.
La Société a été constituée suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°427 du
21 novembre 1990
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012145555/15.
(120191825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Comptoir des Fournitures Industrielles du Bâtiment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 28.176.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145547/9.
(120192068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
140783
L
U X E M B O U R G
Primus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.012.500,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 169.699.
Une erreur matérielle s'est glissée dans la totalité du dépôt du 7 novembre 2012 sous la référence L120191104.
Il convient dès lors de (a) ne pas tenir compte de la totalité du dépôt du 7 novembre 2012 sous la référence L120191104
et (b) noter qu'il résulte de l'assemblée générale ordinaire des associés de la Société du 16 octobre 2012 que:
(A) Les associés listés ci-dessous ont transféré des parts de Catégorie A à Stichting Administratiekantoor Tivox, une
société de droit néerlandais ayant son siège social à Johan Van Oldenbarneveltlaan 9D, 2582 NE Den Haag, Pays-Bays
suivant la répartition suivante:
- 3.250.000 parts de Catégorie A détenues par Clema Capital SPF S.à r.l.;
- 750.000 parts de Catégorie A détenues par Bugy Capital SPF S.à r.l.;
- 1.000.000 parts de Catégorie A détenues par Ernst Reichmayr;
- 160.000 parts de Catégorie A détenues par Hermann Lutzenberger;
- 150.000 parts de Catégorie A détenues par Gerhard Unterganschnigg;
- 150.000 parts de Catégorie A détenues par Hans Jörg Kaltenbrunner;
- 350.000 parts de Catégorie A détenues par Clair Ullmann;
- 622.499 parts de Catégorie A détenues par Rainer Ullmann; et
- 750.000 parts de Catégorie A détenues par Bright Water Investments AG.
(B) Les associés listés ci-dessous ont transféré leurs parts de Catégorie A à Stichting Administratiekantoor Hukvaldy,
une société de droit néerlandais ayant son siège social à Johan Van Oldenbarneveltlaan 9D, 2582 NE Den Haag, Pays-
Bays suivant la répartition suivante:
- 755.000 parts de Catégorie A détenues par Eddy Coppieters;
- 750.000 parts de Catégorie A détenues par Wim Vandererfven;
- 750.000 parts de Catégorie A détenues par Jan Vleugels;
- 750.000 parts de Catégorie A détenues par Jean-Baptiste Van Damme;
- 100.000 parts de Catégorie A détenues par Rebecca Dewachter;
- 100.000 parts de Catégorie A détenues par Philip Rigole;
- 100.000 parts de Catégorie A détenues par Pol Dewaele;
- 100.000 parts de Catégories A détenues par Khalid Yahia;
- 15.000 parts de Catégories A détenues par Bert Debevere;
- 100.000 parts de Catégories A détenues par Pascal Allardon;
- 100.000 parts de Catégories A détenues par Abdelhali El Kahhan;
- 30.000 parts de Catégories A détenues par Radovan Kudela;
(C) Monsieur Alain Engelschenschilt a transféré la totalité de ses 536.493 parts de Catégorie A à Stichting Adminis-
tratiekantoor Hatfield, une société de droit néerlandais ayant son siège social à Johan Van Oldenbarneveltlaan 9D, 2582
NE Den Haag, Pays-Bays.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Primus Holding S.à r.l.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012146488/45.
(120192354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.
DjR Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 144.954.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145558/9.
(120192103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
140784
Agence Immobilière Mara Max S.àr.l.
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A.
Altilands S.A.
Amalthee S.A.
Am Wenkel S.à r.l.
An der Klaus S.A.
Ashmore Sicav
Askania S.à r.l.
Avant Ireland Holdings S.à r.l.
Avantor Performance Materials Holdings S.A.
Axo Compagnie Hôtelière S.à r.l.
Azure Holdings S.à r.l.
Barguzin Participation S.A.
Belfius Insurance Services Finance
Bio-cafes SA
BlackRock Alternative Strategies
BLACKROCK Fund Management Company S.A.
Blue Fin S.A.
Boesen Ihr Gärtner
Bois-Matériaux Willy Putz Sàrl
Borderline Investholding S.A.
Bortran S.A.
BRE/CP Europe Holdings S.à r.l.
Broadstreet Continental Finance S.à r.l.
Broadstreet International Partners S.à r.l.
Broadstreet Mexico S.à r.l.
Broadstreet of Münsbach S.à r.l.
Broadstreet S.à r.l.
BSI Art Collection S.A.
Cardoso S.à r.l.
Cavalcade S.à r.l.
CBM S.à r.l.
Cedar Capital Luxembourg S.à r.l.
Cerampart
Chamberley S.A.
Chricat Investments
Clermon Holding Company S.A.
Clyde Blowers Capital (RCP) S.à r.l.
CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR
CMP German Opportunity Investors Fund II (SCS) SICAR
C.M.P. S.A.
Comptoir des Fournitures Industrielles du Bâtiment S.à r.l.
Creo Hungary Luxembourg Branch Office
C.RO Ports S.A.
Crystal Pool (Luxembourg) S.àr.l.
D.B. International Finance S.A. SPF
DEXIA Insurance Services Finance
DjR Group Sàrl
Eldalux s.à r.l.
EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l.
Euro Holiday Properties S.A.
Evergreen Investments S.A.
Eversholt Investment Group SCS
Julius Baer Multiflex
Les Espaces Saveurs S.A.
Oaktree (Lux.) Funds
Primus Holding S.à r.l.
Serco Luxembourg S.A.