This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2860
26 novembre 2012
SOMMAIRE
aeris CAPITAL Liquid Funds . . . . . . . . . . . .
137242
Austria Outlet Mall Holding Sàrl . . . . . . . .
137275
Brianfid-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137234
BZ Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137235
CBRE Global Investors Open-Ended GP
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137246
CBRE Global Investors Open-Ended GP
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137278
CEA Investments Limited . . . . . . . . . . . . . .
137280
Continental Investments and Management
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137280
Cusanus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137280
Depuration Management S.A. . . . . . . . . . . .
137280
DS Smith (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . .
137280
Eastman Chemical Luxembourg Holdings
1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137244
F&C Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137241
FDR Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137234
Flossbach von Storch SICAV . . . . . . . . . . . .
137238
IK Group s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137242
KBC Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137236
Kenross Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137246
LDF65 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137259
M77 Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137272
M7 Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137272
Maxiweb S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137234
MCP III Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
137279
MI-FONDS (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137240
MVM Lux Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137236
Outlet Mall Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
137275
Parador Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
137278
Parfinlux S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137278
Parts Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137279
PEC Brunnen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137271
PEC Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137272
PEC Moenchhof S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
137278
PE-Invest SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137240
Puma Rex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137279
Q & A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137279
Q & A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137279
ReGEN Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137279
SEB Absolute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137259
Sessions Finances Investments S.A. . . . . . .
137235
State Street Global Advisors Luxembourg
SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137237
Utopia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137238
137233
L
U X E M B O U R G
Brianfid-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 81.520.
Pour publication, conformément a l'article 60-8 de la loi de 1993, une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires de la société BRIANFID-LUX S.A. (l'«Assemblée Générale Extraordinaire») qui se tiendra par devant
notaire à Luxembourg, au siège social de la société au: 6, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>14 décembre
2012i> à 11 heures afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de dissoudre BRIANFID-LUX S.A.;
2. Nomination du liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur comme suit:
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibérera valablement sur le point 1 de l'ordre du jour que si au moins
50% du capital social émis de la Société est présent ou représenté et la résolution y relative ne sera valablement
adoptée que si elle est approuvée par au moins 2/3 des votes émis à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Les
résolutions relatives aux points 2 et 3 de l'ordre du jour seront adoptées à la majorité simple des voix valablement
exprimées des actionnaires présents ou représentés.
Référence de publication: 2012151361/20.
Maxiweb S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9543 Wiltz, 61B, route de Noertrange.
R.C.S. Luxembourg B 60.427.
L'ASSEMBLEE GENERALE 2012
se tiendra le <i>19 décembre 2012i> à 20h au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion
2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes
3. Approbation des comptes annuels de l'année 2011
4. Affectation du résultat pour l'année 2011
5. Décharge au conseil d'administration et au commissaire au compte
6. Divers
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012152090/16.
FDR Gestion, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 22.988.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires, tenue de façon exceptionnelle le <i>12 décembre 2012i> à 15 heures au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen
avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Statutaire ayant pour objet d'approuver
les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
- Présentation du rapport de contrôle du Commissaire relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
- Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2011 et du compte de profits et pertes y relatif ; affectation du résultat.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31
décembre 2011.
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi coordonnée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- Démission et nomination d'un administrateur.
- Divers.
137234
L
U X E M B O U R G
Pour prendre part à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012152091/24.
BZ Equity Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 157.402.
Die Aktionäre des BZ Equity Fund werden hiermit zu einer
ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>28. Dezember 2012i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-
Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
Änderung und Aktualisierung der Satzung mit Wirkung zum 1. Januar 2013
<i>Tagesordnung:i>
1. § 1 der Satzung wird aufgrund der Namensänderung der Investmentgesellschaft BZ Equity Fund geändert. Die
Investmentgesellschaft wird in BZ Fine Funds umbenannt.
2. § 4 der Satzung wird hinsichtlich der Techniken und Instrumente sowie der Risikostreuung an die gesetzlichen
Vorgaben angepasst.
3. In § 30 der Satzung werden redaktionelle Änderungen vorgenommen.
4. § 38 der Satzung wird hinsichtlich der Kostenstruktur modifiziert.
Ein Entwurf der Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 26. November 2012
standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht
wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.
Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-
quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können müssen Aktionäre, von in
Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen Gene-
ralversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 21. Dezember 2012 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle des BZ Equity Fund (DZ PRIVATBANK S.A.)
unter Telefon 00352/44903-4025, Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert
werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012152766/755/33.
S.F.I. S.A., Sessions Finances Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 149.919.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>18 décembre 2012i> à 14h00 au siège de la société avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des Comptes Annuels au 31/12/2011;
2. Lecture du Compte Rendu de la Réunion du Conseil d'Administration et du Rapport du Commissaire;
3. Approbation des Comptes Annuels et Affectation du Résultat pour l'exercice clôturé au 31/12/2011;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire;
5. Divers
Référence de publication: 2012152769/553/15.
137235
L
U X E M B O U R G
KBC Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 39.062.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société qui aura lieu le <i>12 décembre 2012i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2012 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Décharge à donner aux dirigeants de la société de gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des voix exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire repré-
senter à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée doit déposer ses actions au
plus tard 2 jours ouvrables avant l'Assemblée aux guichets des institutions suivantes :
Au Luxembourg:
KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg
En Belgique:
KBC Bank NV, 2, avenue du Port, B-1080 Bruxelles
CBC Banque S.A., 5, Grand'Place, B-1000 Bruxelles
Centea NV, 180, Mechelsesteenweg, B-2018 Anvers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012152770/755/28.
MVM Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 83.256.
Die Aktionäre der MVM LUX SICAV werden hiermit zu einer
ZWEITE AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>28. Dezember 2012i> um 11.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-
Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung der Satzung per 28. Dezember 2012
Zustimmung zur Änderung von Artikel 37 der Satzung. Das Geschäftsjahr 2012 beginnt am 1. Januar 2012 und
endet am 31. März 2013.
2. Fusion der Investmentgesellschaft per 31. März 2013
Zustimmung zur geplanten Fusion der Investmentgesellschaft mit ihrem einzigen Teilfonds MVM LUX SICAV -
frontrunner global gemäß Artikel 6 Nr. 1 der Satzung mit dem Teilfonds MVM Fonds - MVM Independent Global
des Umbrella-Fonds MVM Fonds, welcher in der Form eines fonds commun de placement errichtet wurde und
damit auch zum Verschmelzungsplan.
3. Auflösung der Investmentgesellschaft durch Fusion.
4. Beschluss über die Hinterlegung der Bücher und Dokumente der Investmentgesellschaft.
Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 26. November 2012
standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht
wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.
Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-
quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können müssen Aktionäre, von in
Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
137236
L
U X E M B O U R G
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen Gene-
ralversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 23. Dezember 2012 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der MVM LUX SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.)
unter Telefon 00352/44903-4025, Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert
werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012152767/755/35.
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.816.
Due to the lack of quorum, the extraordinary general meeting convened for 22 November 2012, was not able to
validly decide on its agenda. Thus, the shareholders are convened to attend a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV (the «Company») to be held on <i>28i>
<i>December 2012i>
, at 10.00 a.m., at 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg for the
purpose of considering and voting upon the agenda below.
<i>Agenda:i>
1. To amend article 3 to replace the references to the law of 20 December 2002 and to the 2002 Law by references
to the law of 17 December 2010 and the 2010 Law respectively.
2. To amend article 16 to (i) replace the references to the 2002 Law by references to the 2010 Law, (ii) replace the
references to Directive 85/611/EEC by references to Directive 2009/65/EC, (iii) replace the reference to Article 1
of the 2002 Law by a reference to Article 41 (1) a) of the 2010 Law, (iv) provide that one Fund of the Company
can, under the conditions of the law of 17 December 2010, invest into one or several other Funds of the Company
and (v) allow for the possibility of creating feeder Funds.
3. To amend article 20 to replace the reference to Article 113 of the 2002 Law by a reference to Article 154 of the
2010 Law.
4. To amend article 21 to (i) replace the reference to the 2002 Law by a reference to the 2010 Law and (ii) add that
the sub Investment Manager may decide to fix the level of the anti-dilution levy to be perceived on redemptions.
5. To amend article 22 to (i) add a paragraph e) providing that the determination of the net asset value of Shares may
be suspended in case of a merger of a Fund or of the Company, (ii) add a paragraph f) providing that that the
determination of the net asset value of Shares of a Fund that is a feeder fund may be suspended in case of suspension
of the determination of the net asset value of Shares of the master fund and (iii) change the numbering of current
paragraph e) to paragraph g).
6. To amend article 23 to (i) add a paragraph g) granting the power to the Board to perform an adjustment to the
Net Asset Value of a Fund in certain circumstances (swing pricing), (ii) include the sub Investment Manager regarding
the use of pools in the context of co-management and (iii) replace the reference to the 2002 Law by a reference
to the 2010 Law.
7. To amend article 24 to add that the sub Investment Manager may decide to fix the level of the anti-dilution levy to
be perceived on subscriptions.
8. To amend article 28 to (i) delete the provisions on fund mergers as they applied under the 2002 Law and (ii) add
two paragraphs with respect to the merger provisions applicable to Fund mergers and to a merger of the Company
under the 2010 Law.
9. To amend article 30 to replace the reference to the 2002 Law by a reference to the 2010 Law
10. To decide that the restated articles of the Company be solely drafted in English and be not followed by a French
translation.
11. That the effective date of the changes is 31 December 2012.
The resolutions shall be passed by a majority of two-thirds of the shares represented and voting. No presence quorum
is required.
<i>Voting Arrangementsi>
In order to vote at the meeting:
- The holders of registered shares may be present in person or represented by a duly appointed proxy;
- Shareholders who cannot attend the Extraordinary Meeting in person are invited to send a duly completed and signed
proxy form to State Street Bank Luxembourg S.A. ,49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg to arrive no later than 1.00 p.m. CET on 27 December 2012. Proxy forms can be obtained from the registered
office of the Company.
137237
L
U X E M B O U R G
The Directors of the Company accept responsibility for the accuracy of the contents of this notice.
If you have any questions, these may be directed to State Street Bank Luxembourg S.A., the Registrar, Secretary and
Transfer Agent at 49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, (Tel: +352 46 40 10 1,
Fax: +352 46 40 10 413).
Référence de publication: 2012152768/755/55.
Flossbach von Storch SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 133.073.
Die Aktionäre der Flossbach von Storch SICAV werden hiermit zu einer
ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>28. Dezember 2012i> um 11:30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-
Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Januar 2013
2. Die Satzung wird an das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.
3. Weiterhin wird Artikel 4 der Satzung angepasst. Dabei wird insbesondere die Anlagemöglichkeit der Teilfonds in
Single-Hedgefonds, sonstigen Sondervermögen im Sinne des § 90g des deutschen Investmentgesetzes ("InvG") sowie
die Möglichkeit von Leerverkäufen vollständig gestrichen. Unter anderem darf die Gesamtanlage der jeweiligen
Teilfonds in Edelmetalle, Derivate und unverbriefte Darlehensforderungen 30% des Teilfondsvermögens nicht
übersteigen. Derivate im Sinne des § 51 Abs. 1 InvG werden auf diese Grenze nicht angerechnet. Ebenfalls wird die
Möglichkeit der Wertpapierleihe und von Pensionsgeschäften gestrichen. Die Anlage in Zielfonds wird auf 10% des
jeweiligen Teilfondsvermögens begrenzt.
4. Artikel 10 der Satzung wird dahingehend angepasst, dass Aktionäre die von einer Verschmelzung betroffenen sind
und die mit der Verschmelzung nicht einverstanden sind, innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung der Mit-
teilung an die Aktionäre über die Verschmelzung, ihre Aktien kostenfrei zurückzugeben können. Aktionäre die von
diesem Recht keinen Gebrauch machen, sind grundsätzlich an den vom Verwaltungsrat gefassten Beschluss über
die Verschmelzung gebunden.
5. Artikel 37 p) wird dahin gehend angepasst, dass auch etwaige Honorare des Verwaltungsrates der Investmentge-
sellschaft vom jeweiligen Teilfonds getragen werden können.
6. Im Übrigen wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
Wir weisen darauf hin, dass aktuell nicht geplant ist die unter Tagesordnungspunkt 5 erwähnten etwaigen Honorare
für den Verwaltungsrat zu erheben.
Die Punkte der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 26. November 2012 verlangten
ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals das nicht erreicht wurde. Insofern ist die
Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.
Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-
quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre, von in
Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen General-
versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 23. Dezember 2012 anzumelden.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der FLossbach von Storch SICAV (DZ PRIVAT-
BANK S.A.) unter Telefon: 00352/44903-4025, Fax: 00352/44903-4506 oder E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com
angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012152765/755/45.
Utopia S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 5.254.090,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 29.756.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
137238
L
U X E M B O U R G
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu lundi, le <i>3 décembre 2012i> à 14.30 heures au siège social de la société, 45, avenue J.F. Kennedy, à Luxem-
bourg-Kirchberg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'objet social et par conséquent de l'article 4, paragraphe 1 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«La société a pour objet de réaliser, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ou en coopération
avec d'autres, l'achat, la vente, la distribution, la location, l'exploitation et la production de films cinématographiques,
de vidéogrammes et de matériel audiovisuel en général, l'aménagement et l'exploitation de centres de loisirs, de
centres culturels, de salles de cinéma et de conférence pour manifestations cinématographiques, culturelles, tou-
ristiques et autres, y compris toutes sortes de promotions, notamment publicitaires, qui s'y rattachent dans le sens
le plus large, la représentation de firmes de l'industrie audiovisuelle, la création, l'acquisition, l'exploitation et la
cession de magasins ayant un rapport avec le délassement et les loisirs, l'exploitation de débits de boissons et de
restauration, l'exploitation de parkings ainsi que toutes autres prestations de services ou autres opérations com-
merciales, financières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous
objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement.»
2. Modification de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de six membres, actionnaires ou non, nommés pour un terme
d'un an par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En cas de vacance d'une place
d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pour-
voir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
Le remplaçant termine le mandat de son prédécesseur.»
3. Modification de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'adminis-
trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le Conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et au moins quatre fois par an
sur la convocation du Président.
Il se réunit également sur la demande de deux administrateurs au moins.
Les convocations sont valablement effectuées par lettre, courrier électronique ou télécopie.
Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, par
vidéo-conférence, ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes
prenant part à cette réunion puissent s'entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, l'Administrateur utilisant
ce type de technologie sera réputé présent à la réunion et sera habilite à prendre part au vote.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou courrier électronique un autre adminis-
trateur pour le représenter, sans que celui-ci ne puisse représenter plus de deux de ses collègues.
Pour déterminer ce quorum, il est fait abstraction des administrateurs qui ne peuvent pas prendre part à la déli-
bération et au vote en raison d'une contrariété d'intérêts.
Lorsque à une séance, le Conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il peut dans une seconde réunion tenue sur seconde
convocation au plus tôt après 7 jours et au plus tard dans la quinzaine, délibérer sur les objets portés à l'ordre du
jour de la précédente séance, quel que soit le nombre des membres présents. Les administrateurs peuvent émettre
leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, téléfax ou par courrier électronique.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.»
4. Modification de l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres pré-
sents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du Président ne sera pas prépondérante.»
5. Ajout d'un nouvel article 17 dans les statuts qui aura la teneur suivante:
«Les décisions prises par l'assemblée générale devront rassembler une majorité des deux tiers des actionnaires
présents ou représentés, sauf majorité plus stricte prévue par la loi.
6. Modification de l'actuel article 17, paragraphe 1 pour lui donner la teneur suivante:
«Les actions au porteur ne donnent droit au vote que si elles ont été déposées entre les mains et aux endroits
indiqués dans les convocations au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée.» et renuméro-
tation de cet article.
7. Renumérotation de l'actuel article 18 jusqu'à l'actuel article 21, qui deviennent les articles 19 à 22 des statuts.
8. Divers
Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l'article 17 des statuts, déposer leurs
titres au porteur pour lundi, le 26 novembre 2012 au plus tard, auprès de la BIL à Luxembourg. Les actionnaires nominatifs
doivent également s'annoncer par écrit endéans le même délai.
137239
L
U X E M B O U R G
Les actionnaires peuvent se faire représenter, dans les conditions déterminées par l'article 17 des statuts, par une
autre personne ayant elle aussi un droit de vote, en déposant la procuration correspondante au siège social pour lundi,
le 26 novembre 2012 au plus tard.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Nico SIMON / Christian KMIOTEK
Administrateur-Délégué / Président
Référence de publication: 2012148686/74.
MI-FONDS (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.264.
Die Aktionäre der Mi-Fonds (Lux) (nachstehend als "Gesellschaft" bezeichnet) sind zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>5. DEZEMBER 2012i> um 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an ihrem Geschäftssitz
stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2012
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Satzungsgemäße Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes
Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen
Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, werden die die Aktionäre gebeten ihren Aktienbestand spätestens
um 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) fünf Tage vor der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg)
S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle zu hinterlegen. Die
Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Jahreshauptversammlung gesperrt gehalten wer-
den, muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Jahreshauptversammlung vorliegen. Für die Mehrheitserfordernisse der
Jahreshauptversammlung sind die um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) fünf Tage vor der Jahreshauptversammlung (der
"Stichtag") ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien massgebend. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die
gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit
der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt
jede Aktie zur Abgabe einer Stimme. Die Rechte der Aktionäre zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur
Ausübung der mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte werden auf der Grundlage der am Stichtag gehaltenen Aktien
bestimmt.
Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne durch den Vorsitzenden der Jahreshauptver-
sammlung vertreten werden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax
und/oder E-Mail spätestens fünf Tage vor der Jahreshauptversammlung (der "Stichtag") an UBS FUND SERVICES (LU-
XEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer
+352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse
bezogen werden.
Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Jahreshauptversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis
spätestens fünf Tage vor der Jahreshauptversammlung bei der Gesellschaft anzumelden.
Die Vollmacht ist nur dann gültig wenn sie den Vor- und Zunamen des Aktionärs und seines gesetzlichen Vertreters
sowie die Zahl der zum Stichtag gehaltenen Aktien und die offizielle Adresse, Unterschrift und Abstimmungsanweisungen
beinhaltet. Unvollständige oder fehlerhafte Vollmachten oder Vollmachten, die den vorstehenden Bestimmungen nicht
entsprechen, werden nicht berücksichtigt.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012148688/755/45.
PE-Invest SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.657.
Einberufung zur
137240
L
U X E M B O U R G
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre welche am <i>4. Dezember 2012i> um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet und folgende Tagesordnung
hat:
<i>Tagesordnung:i>
1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates
2. Entgegennahme des Berichtes des Wirtschaftsprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2012
4. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses des am 30. September 2012 endenden Geschäftsjahres
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Bestellung des Wirtschaftsprüfers
7. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können am Sitz der Gesellschaft unter der Telefonnummer 00352-2640-3009
oder unter der Faxnummer 00352-2640-2818 angefordert werden.
Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der
Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft unter den zuvor genannten Kontaktdaten anzumelden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012148689/755/29.
F&C Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 82.782.
We have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of F&C FUND (the "Company"), which will be held at the registered office of the Company at 49,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on <i>5 December 2012i> at 2.00 p.m. (the "Meeting"), with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the annual report comprising the audited annual accounts of the Company for the financial year ended
30 September 2012 and to approve the approved statutory auditor's report thereon;
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of 30 September 2012 and the allocation of net profits
for the financial year ended 30 September 2012 as proposed by the Board of Directors;
3. Approval of the dividend distribution amount for the shares of the F&C HVB-Stiftungsfonds as proposed by the
Board of Directors;
4. Discharge of the Directors with respect to the performance of their duties during the financial year ended 30
September 2012;
5. Re-election of the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of
Shareholders and until his successor is duly elected:
Mr. Jacques Elvinger, Mr. Patrick Johns, Mr. Bernd Kalis, Mr. Hugh Moir, Mr. Antonio Thomas and Mr. Enrico Turchi;
6. Re-appointment of PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, as the approved statutory auditor of the Com-
pany until the next annual general meeting to be held in 2013;
7. Any other business which may be properly brought before the Meeting.
<i>Voting:i>
Resolutions on the agenda of the Meeting are not subject to quorum or majority requirements and will be taken at
the majority of the votes cast. Each Share is entitled to one vote. Shareholders may vote in person or by proxy.
<i>Voting Arrangements:i>
If you want to be represented at the Meeting and receive a proxy form, please kindly contact: Luxembourg-
Domiciliary@statestreet.com
The proxy form, duly filled in, must be dated, signed and returned before 3 December 2012, by fax at the number :
(+ 352) 46 40 10 413 and by courier at the registered office of the Company:
49, avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg; Domiciliary Department.
137241
L
U X E M B O U R G
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012148692/755/35.
aeris CAPITAL Liquid Funds, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion d'aeris CAPITAL Liquid Funds a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
aeris CAPITAL Management Company S.A.
Signature
Référence de publication: 2012124455/10.
(120165967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
IK Group s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5620 Mondorf-les-Bains, 4, rue Jean-Pierre Ledure.
R.C.S. Luxembourg B 172.820.
STATUTS
L'an deux mil douze, le douze novembre.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1.- Monsieur Abdelkader CHERGUI, gérant de sociétés, né à Mondelange (France), le 25 avril 1967, demeurant à
L-5620 Mondorf-les-Bains, 4, rue Jean-Pierre Ledure;
2.- Madame Isabelle CAPOZZA, commerçante, née à Algrange (France), le 6 octobre 1968, demeurant à L-1212
Luxembourg, 19, rue des Bains.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu’elles constituent:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «IK GROUP
s.àr.l.».
Art. 2. Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le
financement et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés,
marques commerciales et marques de fabrique, dessins, modèles, logiciels informatiques, noms de domaines et en ex-
ploiter, en céder et en concéder toutes les licences.
La Société a également pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourra faire
partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de
nature à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans
son acception la plus large.
La Société pourra effectuer des prestations de services mais uniquement dans le cadre de la gestion de ses participations
et/ou des opérations de gestion internes du groupe dont elle pourrait faire partie.
137242
L
U X E M B O U R G
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres en-
treprises, associations ou sociétés.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.
De manière générale, la Société pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature à faciliter la réalisation
de son objet social.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (€ 12.400,-) par cent (100) parts sociales de cent-
vingt-quatre Euros (€ 124,-) chacune.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de
l'actif net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi
coordonnée sur les sociétés commerciales.
Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales
bien déterminées pourront faire l’objet d’un contrat d’association ou de partenariat sous seing privé.
Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les
présents statuts.
Un tel contrat sera opposable à la société après qu’il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d’effet vis-à-
vis des tiers qu’après avoir été dûment publié.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l’Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.
Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les 3/4 du capital social.
Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 12. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Chaque année le 31 décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces
comptables exigées par la loi.
Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ 1.100,-.
137243
L
U X E M B O U R G
Le notaire instrumentant attire l’attention des comparants qu'avant toute activité commerciale de la société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social.
Les comparants reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives
à l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre
des Notaires en date du 16 mai 2001.
<i>Loi anti-blanchimenti>
En application de la loi du 12 novembre 2004, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération
et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées à l’article 506-1
du code pénal luxembourgeois.
<i>Souscriptioni>
Toutes les parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au
notaire qui le constate expressément, et souscrites comme suit:
M. Abdelkader CHERGUI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Mme Isabelle CAPOZZA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.
<i>Assemblée généralei>
Les fondateurs prénommés, détenant l’intégralité des parts sociales, et représentées comme dit, se sont constituées
en Assemblée Générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le siège social est fixé à L-5260 Mondorf-les-Bains, 4, rue Jean-Pierre Ledure.
2) La société sera gérée par deux gérants, à savoir:
- Monsieur Abdelkader CHERGUI, gérant de sociétés, né à Mondelange (France), le 25 avril 1967, demeurant à L-5620
Mondorf-les-Bains, 4, rue Jean-Pierre Ledure;
- Madame Isabelle CAPOZZA, commerçante, née à Algrange (France), le 6 octobre 1968, demeurant à L-1212 Lu-
xembourg, 19, rue des Bains.
3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte, après
s’être identifiés au moyen de copies de leurs cartes d’identité.
Signé: A. CHERGUI, I. CAPOZZA, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 13 novembre 2012. Relation: CAP/2012/4344. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): I. Neu.
Pour copie conforme.
Capellen, le 19 novembre 2012.
.
Référence de publication: 2012151757/130.
(120200183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
Eastman Chemical Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 169.093.
CERTIFICATE
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of November, the undersigned Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg, certifies in accordance with article 273 of the law of 10 August 1915 on the commercial
companies, as amended (the “Law of 1915”) and in accordance with the certificates of the merging companies issued on
November 19, 2012:
1. that the joint merger plan between Eastman Chemical Luxembourg Holdings 1 S.à r.l.,a société à responsabilité
limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8,
avenue Charles de Gaulle, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B 169093
(the “Absorbing Company”), and the Eastman Chemical Luxembourg Holdings 5 S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue
137244
L
U X E M B O U R G
Charles de Gaulle, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B 169495 (the
“Absorbed Company“ and together with the Absorbing Company, the “Merging Companies“) signed in the form of a
notarial deed in front of the undersigned notary on 8 October 2012, has been validly published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 2585 of 18 October 2012 (the “Merger Plan“);
2. that the documents listed in article 267 paragraphe (1) a) b) and c), if applicable, of the Law of 1915 have been made
available to the shareholders of the Absorbing Company at the registered office of the latter as of 18 October 2012;
3. that article 2 of said Merger Plan provides that the merger shall be realised and take effect between the Merging
Companies one month and one day after the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the
Merger Plan;
4. that no shareholder of the Absorbing Company has requested, within one month after the publication of the Merger
Plan in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations the convening of a general meeting;
5. that the Absorbed Company has ceased to exist on this 19 November 2012;
6. that the merger will be effective vis-à-vis third parties at the date of the publication in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations of this certificate according to article 273 (1) of the Law of 1915;
7. that the Absorbed Company may therefore be struck off of the Trade and Companies’ Register.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the Merging Com-
panies, this certificate is worded in English, followed by a French version; and upon request of the same Merging Companies
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le dix-neuvième jour du mois de novembre, le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, certifie conformément à l’article 273 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915») et conformément aux certificats émis par les Sociétés Fusionnantes en
date du 19 novembre 2012:
1. que le projet commun de fusion entre Eastman Chemical Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169093 (la «Société Absorbante»),
et la Eastman Chemical Luxembourg Holdings 5 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169495 (la «Société Absorbée» et ensemble avec la Société
Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes») signé en la forme notariée par devant le notaire soussigné en date du 8 octobre
2012, a été régulièrement publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2585 du 18 octobre 2012
(le «Projet de Fusion»);
2. que les documents repris à l’article 267 paragraphe (1) a), b) et c), si applicables, de la Loi de 1915 ont été mis à la
disposition des associés de la Société Absorbante au siège social de cette dernière en date du 18 octobre 2012;
3. que l’article 2 du Projet de Fusion prévoit que la fusion sera considérée comme définitivement réalisée et prendra
effet entre les Sociétés Fusionnantes un mois et un jour après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du Projet de Fusion;
4. qu’aucun associé de la Société Absorbante n’a dans le délai d’un mois à partir de la publication du Projet de Fusion
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, demandé la convocation d’une assemblée générale;
5. que la Société Absorbée a dès lors cessé d’exister ce 19 novembre 2012;
6. que la fusion prendra effet vis-à-vis des tiers à la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations du présent certificat conformément à article 273 (1) de la Loi de1915;
7. que la Société Absorbée peut dès lors être rayée du Registre de commerce et des sociétés.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des Sociétés Fusionnantes, le présent
certificat a été établi en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes société et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2012.
Référence de publication: 2012150895/64.
(120198205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
137245
L
U X E M B O U R G
CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.331.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 7 novembre 2012 que monsieur Jean
Lamothe a démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet au 22 octobre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012151572/14.
(120200129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
Kenross Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 48.548.
PROJET DE SCISSION
du 21 novembre 2012
Dans un but de regroupement des différentes activités stratégiques du groupe,
le Conseil d'Administration de KENROSS Lux S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
au capital social de EUR 15.851.655,96 (quinze millions huit cent cinquante et un mille six cent cinquante-cinq virgule
quatre-vingt-seize euros), représenté par 3.069.051 (trois millions soixante-neuf mille cinquante et une) parts sociales de
catégorie A sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées,
ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 48.548 (ci-après définie «l'ancienne Kenross Lux S.àr.l.», la «Société» ou la
«Société à scinder»)
constituée par acte du notaire André SCHWACHTGEN en date du 16 août 1994, publié au Mémorial C numéro 501
de 1994 page 24027,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Cosita DELVAUX en date du 31 mai 2011,
publié au Mémorial C numéro 1914 du 20 août 2011
propose de procéder à la scission partielle de la Société par la constitution d'une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, dénommée ci-après la «nouvelle société», ayant le statut fiscal «soparfi» et transfert, sans disso-
lution de la Société à la société nouvellement constituée d'une partie ou l'ensemble de son patrimoine, activement et
passivement, moyennant l'attribution à ses associés de parts de la société bénéficiaire.
La nouvelle société portera la dénomination sociale de
- KENROSS LUX TWO S.àr.l., (dénommée ci-après: «TWO S.àr.l.») et aura son son siège social à L-1420 Luxembourg,
5, avenue Gaston Diderich.
Le capital social de TWO S.àr.l. sera de EUR 10.000.000,00 (dix millions d'euros), représenté par 1.936.107 (un million
neuf cent trente-six mille cent sept) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.
La scission partielle de la Société s'opère conformément aux dispositions des articles 288 et 307 de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tels que modifiés (ci-après «la loi sur les sociétés»).
Les comptes retenus pour déterminer les conditions de l'opération sont ceux arrêtés par le Conseil d'administration
en date du 31 août 2012.
Les associés de la Société sont appelés, à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société
qui se tiendra un mois au moins après la publication du présent projet, à approuver la scission partielle (date de la scission)
par laquelle la Société transfère, sans toutefois disparaître, à la nouvelle société TWO S.àr.l., une partie des actifs et passifs
de son portefeuille de participations avec les droits et obligations qui s'y rattachent, activement et passivement, la Société
continuant son activité commerciale avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
D'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées, à compter de la date du 1
er
septembre
2012 comme accomplies pour compte des nouvelles sociétés issues de la scission auxquelles ont été attribuées l'actif ou
le passif sur lequel portent les opérations concernées.
La Société réduira ainsi son capital social d'un montant de 10.000.000,00 euro par annulation de 1.936.107 parts sociales
de catégories A sans désignation de valeur nominale. Les nouvelles parts sociales de la société TWO S.àr.l. représentatives
137246
L
U X E M B O U R G
du capital social de 10.000.000,00 euro de TWO S.àr.l., crées en contrepartie de l'apport de la Société d'une partie de
son patrimoine avec les droits et obligations qui s'y rattachent résultant de la scission partielle, étant attribués et souscrits
par les associés de la Société au prorata des parts sociales annulées de la Société à raison de une part sociale de TWO
S.àr.l. contre une part sociale de la Société annulée.
La partie du patrimoine de la Société scindée, faisant l'objet de scission partielle, sera intégralement dévolue à la nouvelle
société dans l'état où le patrimoine se trouvera à la date de ladite scission partielle.
D'un point de vue comptable, les opérations de la Société en relation avec l'apport d'une partie du patrimoine composé
du portefeuille de participations avec les droits et obligations qui s'y rattachent seront considérées, à compter de la date
de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société approuvant la scission comme accomplies et pour compte de la
nouvelle société TWO S.àr.l. issue de la scission à la date à laquelle lui a été attribuée l'actif et le passif.
En application de l'article 296 de la loi sur les sociétés commerciales, tous les associés de la Société ont déclaré vouloir
renoncer à l'établissement du rapport du Conseil de Gérance et celui des experts indépendant prescrits par les articles
293 et 294.
Les parts sociales de la nouvelle société TWO S.àr.l. seront inscrites au nom des associés de la Société sur le registre
des parts nominatives des associés de la nouvelle société TWO S.àr.l. dès que la scission sera approuvée. Les parts sociales
de la Société, correspondant aux actifs nets transférées à la nouvelle société TWO S.àr.l. seront annulées le jour de
l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société approuvant la scission.
Un certificat d'inscription nominative sera remis à chaque associé de la nouvelle société au cas où ces associés le
demandent.
Les parts sociales de la nouvelle société TWO S.àr.l. donneront le droit de participer aux votes sur les bénéfices et
boni de liquidation éventuels de la nouvelle société, dès que l'assemblée générale des associés de la Société aura approuvé
la scission, sans modalités particulières relatives à ce droit.
La Société n'a émis aucune part bénéficiaire ni aucune part privilégiée. En conséquence, aucun associé ne dispose de
droits spéciaux et aucun titre autre que des parts n'est émis par la nouvelle société.
Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres de l'organe de gestion eu égard à l'opération de scission.
Les éléments du patrimoine total, actif et passif de la Société, avant scission, tels qu'arrêtés au 31 août 2012, sont les
suivants:
KENROSS LUX S.àr.l. - avant scission
BILAN ACTIF
31/08/2012
B
FRAIS D'ETABLISSEMENT:
BI
Frais d'établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.344,67
B
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.344,67
C
ACTIF IMMOBILISE:
CI
Immobilisations incorporelles:
CI2
concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64,83
CI
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64,83
Immobilisations corporelles:
CII1 terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.884.943,42
CII3 autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.755.409,26
CII4 acomptes versés et immobilisations corporelles en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.088.121,07
CII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.728.473,75
Immobilisations financières:
CIII1 parts dans des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252.885.889,57
CIII2 créances sur des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550.000,00
CIII6 autres prêts et créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.974,00
CIII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254.465.863,57
C
TOTAL ACTIF IMMOBILISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272.194.402,15
D
ACTIF CIRCULANT:
DII
Créances:
DII1 résultant de ventes et prestations de services:
DII1a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.276,57
DII2 créances sur des entreprises liées:
DII2a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.414,72
DII3 créances sur des entreprises avec lesquelles elle a un lien de participation:
DII3a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.261.169,42
137247
L
U X E M B O U R G
DII4 autres créances:
DII4a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.571,59
DII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.351.432,30
DIV Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . . . . .
1.123.120,56
D
TOTAL ACTIF CIRCULANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.474.552,86
E
COMPTE DE REGULARISATION ACTIFS
E
Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
829,56
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
829,56
TOTAL ACTIF
276.687.129,24
BILAN PASSIF
31/08/2012
CAPITAUX PROPRES:
AI
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,851,655.96
AIII
Réserves de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171,007,173.23
AIV1 Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,000,000.00
AV
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,177,426.48
AVI
Résultats de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42,109,428.46
A
TOTAL CAPITAUX PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256,145,684.13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES:
C2
Provisions pour impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186.00
C
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186.00
DETTES:
D1
Emprunts obligataires:
D1b Emprunts non convertibles:
D1bb - dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,038,250.00
D4
Dettes sur achats et prestations de services: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D4a - dont la durée résiduelle est Inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151,688.73
D6
Dettes envers des entreprises liées:
D6a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,303,191.19
D7
Dettes envers des entreprises avec lesquelles elle a un lien de participation:
D7b - dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
786,191.07
D8
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale:
D8a - dettes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45,833.50
D9
Autres dettes:
D
TOTAL DETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,530,003.93
COMPTE DE REGULARISATION PASSIFS:
E
Prorata et réescomptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,255.18
TOTAL COMPTE DE REG. PASSIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,255.18
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276,687,129.24
En contrepartie de l'apport de la partie du patrimoine, activement et passivement, faisant l'objet de la scission partielle
de la Société scindée, la nouvelle société recevra les éléments de patrimoine actif et passif suivants et aura par conséquent
la situation d'ouverture suivante:
<i>Répartitioni>
KENROSS LUX TWO S.àr.l.
BILAN ACTIF
01/09/2012
Immobilisations financières:
CIII1 parts dans des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
CIII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
C
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
DIV Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . . . . .
200.000,00
D
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,00
TOTAL ACTIF
239.680.751,16
BILAN PASSIF
01/09/2012
CAPITAUX PROPRES:
137248
L
U X E M B O U R G
AI
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000,00
AIII
Réserves de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168.765.751,54
AIV1 Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000,00
AV
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.922.706,70
AVI
Résultats de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.992.292,92
A
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237.680.751,16
D9
Autres dettes:
D9b - dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000,00
D
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000,00
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.680.751,16
La Société continuant à détenir les actifs et passifs suivants:
KENROSS Lux Sàrl
BILAN ACTIF
01/09/2012
B
FRAIS D'ETABLISSEMENT:
BI
Frais d'établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.344,67
B
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.344,67
C
ACTIF IMMOBILISE:
CI
Immobilisations incorporelles:
CI2
concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64,83
CI
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64,83
Immobilisations corporelles:
CII1 terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.884.943,42
CII3 autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.755.409,26
CII4 acomptes versés et immobilisations corporelles en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.088.121,07
CII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.728.473,75
Immobilisations financières:
CIII1 parts dans des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.405.138,41
CIII2 créances sur des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550.000,00
CIII6 autres prêts et créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.974,00
CIII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.985.112,41
C
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.713.650,99
D
ACTIF CIRCULANT:
DII
Créances:
DII1 résultant de ventes et prestations de services:
DII1a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.276,57
DII2 créances sur des entreprises liées:
DII2a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.414,72
DII3 créances sur des entreprises avec lesquelles elle a un lien de participation:
DII3a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.261.169,42
DII4 autres créances:
DII4a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.571,59
DII4b - dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000,00
DII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.351.432,30
DIV Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . . . . . .
923.120,56
D
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.274.552,86
E
COMPTE DE REGULARISATION ACTIFS
E
Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
829,56
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
829,56
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.006.378,08
BILAN PASSIF
01/09/2012
CAPITAUX PROPRES:
AI
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.851.655,96
AIII
Réserves de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.241.421,69
137249
L
U X E M B O U R G
AIV1 Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000,00
AV
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.254.719,78
AVI
Résultats de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1.882.864,46
A
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.464.932,97
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES:
C2
Provisions pour impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186,00
C
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186,00
DETTES:
D1
Emprunts obligataires:
D1b Emprunts non convertibles:
D1bb - dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.038.250,00
D4
Dettes sur achats et prestations de services:
D4a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151.688,73
D6
Dettes envers des entreprises liées:
D6a - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.303.191,19
Dettes envers des entreprises avec lesquelles elle a un lien
D7
de participation:
D7b - dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
786.191,07
D8
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale:
D8a - dettes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.833,50
D
20.530.003,93
COMPTE DE REGULARISATION PASSIFS:
E
Prorata et réescomptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.255,18
11.255,18
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.006.378,08
<i>Suit le projet d'acte constitutif de la nouvelle société:i>
KENROSS LUX TWO S.à r.l.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, av. Gaston Diderich.
Statuts
Titre I
er
. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. La Société prend la dénomination de «Kenross Lux Two S.à r.l.».
Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché
de Luxembourg.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au
Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-
tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Titre II. - Capital - Parts
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 10.000.000 (dix millions d'euros), représenté par 1.936.107 (un million neuf cent
trente-six mille cent sept) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 6. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
137250
L
U X E M B O U R G
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.
Titre III. - Gérance
Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le
cas, les associés.
Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société
vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature
individuelle du gérant unique, ou en cas de pluralité des gérants, par la signature conjointe de deux gérants, ou par la
signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec
les administrations publiques.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour
des affaires déterminées par le(s) gérant(s).
Les gérants sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.
Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés
Art. 8. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.
Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 9. L'année sociale commence le premier septembre et se termine le trente et un août de chaque année.
Art. 10. Chaque année, au trente et un août, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un
bilan et un compte de profits et pertes.
L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,
constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé
unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI. - Dissolution
Art. 11. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII. - Dispositions générales
Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera le 1
er
septembre 2012 et se terminera le 31 août 2013. Les premiers Gérant(s)
sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des associés suivant immédiatement la constitution de la société.
137251
L
U X E M B O U R G
<i>Libérationi>
Le capital social de Kenross Lux Two S.àr.l. est de EUR 10.000.000,00 (dix millions d'euros), tel que figurant à l'article
5 du projet des statuts ci-avant, sera détenu par les associés comme suit.
Bessmer Trust Company
agissant en qualité de Trustee de The Bluefield Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.936.075 parts sociales
Luciano Berti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 parts sociales
Le capital social sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société d'une partie des actifs et
des passifs de la Société, suivant la répartition proposée dans le projet de scission partielle, à savoir:
Kenross Lux Two S.à r.l.
BILAN ACTIF
01/09/2012
Immobilisations financières:
CIII1 parts dans des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
CIII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
C
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
DIV Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . . . . .
200.000,00
D
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,00
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.680.751,16
BILAN PASSIF
01/09/2012
CAPITAUX PROPRES:
AI
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000,00
AIII
Réserves de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168.765.751,54
AIV1 Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000,00
AV
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.922.706,70
AVI
Résultats de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.992.292,92
A
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237.680.751,16
D9
Autres dettes:
D9b - dont la durée résiduelle est supérieure à un an
2.000.000,00
D
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000,00
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.680.751,16
<i>Attributioni>
Les 1.936.107 (un million neuf cent trente-six mille cent sept) parts sociales représentatives du capital social de EUR
10.000.000,00 (dix millions d'euros) de la société présentement constituée, sont attribuées aux associés de la Société
proportionnellement à leurs droits dans le capital de la Société.
Luxembourg, le 21 novembre 2012.
<i>POUR LE CONSEIL DE GERANCE
i>KENROSS LUX Sàrl
Société à responsabilité limitée
Le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une traduction en anglais. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française prévaudra.
Suit la version anglaise de ce qui précède:
Project for Division
dated 21 November 2012
With the goal of grouping together the various strategic businesses of the group,
the Board of Directors of Kenross Lux S.àr.l., a société à responsabilité limitée [private limited company] governed
by the laws of Luxembourg,
with a share capital of EUR 15,851,655.96 (fifteen million eight hundred fifty one thousand six hundred fifty-five point
ninety-six euro) represented by three million sixty-nine thousand fifty-one (3,069,051) shares Class A without nominal
value, all fully paid-up,
with its registered office located at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, registered in the Trade and
Companies Register of Luxembourg under the number B 48.548 (hereinafter referred to as “Krenross Lux S.àr.l”, the
“Company” or the “Company Subject to partial Division”)
137252
L
U X E M B O U R G
incorporated pursuant a notarial deed received by Maître André SCHWACHTGEN, former notary with residence in
Luxembourg, on August 16, 1994, published in Mémorial C number 501 of 1994 page 24027 the Articles of Association
of which were amended most recently as of May 31, 2011, published in Mémorial C number 1914 of August 20, 2011,
proposes to proceed with a partial division of the Company through the incorporation of a new société à responsabilité
limitée [private limited company] governed by Luxembourg law, hereinafter referred to as the “New Company”, with
the tax status of a SOPARFI [société de participations financiers].
The New Company shall be named:
- Kenross Lux Two S.àr.l., (hereinafter referred to as: “Two S.àr.l.”) with its registered office located at L-1420 Lux-
embourg, avenue Gaston Diderich, 5.
The share capital of Two S.àr.l. shall be EUR 10,000,000 ( ten million euro), represented by one million nine hundred
thirty six thousand one hundred seven (1,936,107) shares without nominal value, all fully paid-up,
The partial division of the Company shall take place pursuant to the provisions of Articles 288 and 307 of the Lux-
embourg on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended (hereinafter the “Companies Law”).
The annual accounts for the determination of the terms of the transaction were established by the Board of Directors
as of 31 August 2012.
The shareholders of the Company are called upon, as of the date of the Extraordinary General Meeting of the share-
holders of the Company (the date of the re-merger) which will take place one month after the publication of this project,
to approve the partial division of the Company, pursuant to which the Company will transfer, without however disap-
pearing, to the New Company Two S.àr.l., its entire portfolio of equity interests with the rights and obligations attached
thereto, both assets and liabilities, while the Company continues its commercial activity with all of the rights and obligations
attached thereto.
From an accounting point of the view, the operations of the Company shall be deemed, as from the date of 1
st
September 2012 as made on behalf of the new companies resulting from the division to which has been assigned the asset
or liability and for which the respective operations has been accomplished.
The Company will thus reduce its share capital by an amount of ten million euro (EUR 10,000,000) through the
cancellation of one million nine hundred thirty-six thousand one hundred seven (1,936,107) shares Class A without
nominal value. The shares of the company Two S.àr.l., representing the share capital of ten million euros (EUR 10,000,000)
of Kenross Lux Two S.àr.l., created through the contribution of the portfolio of equity interests with the rights and
obligations attached thereto resulting from the partial division, being attributed to the shareholders of the Company pro
rata to the shares of the Company that are cancelled at a ratio of one share for every cancelled share of the Company.
The portion of the assets and liabilities of the Company partially divided shall be devolved entirely to the New Company
in the condition that they are in as of the date of the partial division.
From an accounting point of view, the transactions of the Company with respect to the contribution of the portfolio
of equity interests with the rights and obligations attached thereto, will be deemed, as of the date of the Extraordinary
General Meeting of the Company approving the partial division, to have been accomplished for the New Company
resulting from the partial division to which the assets and liabilities have been attributed.
In application of Article 296 of the Companies Law, all shareholders of the Company shall renounce the report of the
Board of Directors and the experts' reports provided for in Articles 293 and 294.
The shares of the New Company will be registered in the name of the shareholders of the Company in the nominal
share register of the New Company as soon as the partial division has been approved.
The shares of the Company, corresponding to the net assets transferred to Two S.àr.l., will be cancelled as of the date
of the Extraordinary General Meeting of the Company approving the re-merger.
A certificate of registration of the nominal shares will be delivered to each shareholder of the New Company on
request.
The shares of the New Company TWO Sàrl will carry voting rights as to the profits and the surplus upon liquidation,
if applicable, of the New Company as of the approval of the division by the general meeting of the shareholders of the
Company, without any specific procedures with respect to such rights.
The Company has not issued any profit participation shares nor any preferred shares. In consequence, no shareholder
holds special rights and no securities are to be issued other than the shares issued by the new company.
No specific advantages have been attributed to the members of the management with respect to the division trans-
action.
All items included in the balance sheet in total, assets and liabilities of the Company, as at the date of 31 August 2012,
are as follows:
BALANCE SHEET ASSETS
31/08/2012
B
BI
Formation expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.344,67
B
TOTAL FORMATION EXPENSES TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.344,67
137253
L
U X E M B O U R G
C
CI
Intangible assets:
CI2
Concessions, patents, licences, trade marks and similar rights and assets, if they were . . . .
64,83
CI
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64,83
Tangible assets:
CII1 Lands and buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.884.943,42
CII3 Other fixtures and fittings, tools and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.755.409,26
CII4 Payments on account and tangible assets in course of construction . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.088.121,07
CII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.728.473,75
Financial assets:
CIII1 Shares in affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252.885.889,57
CIII2 Loans to affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550.000,00
CIII6 Loans and claims held as fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.974,00
CIII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254.465.863,57
C
TOTAL FIXED ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272.194.402,15
D
CURRENT ASSETS:
DII
Debtors:
DII1 Trade debtors:
DII1a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.276,57
DII2 Amounts owed by affiliated undertakings
DII2a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.414,72
DII3 Amounts owed by undertakings with which the company is linked by virtue of participating
interests
DII3a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.261.169,42
DII4 Other debtors
DII4a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.571,59
DII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.351.432,30
DIV Cash at bank and in the hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.123.120,56
D
TOTAL CURRENT ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.474.552,86
E
PREPAYMENTS:
E
Prepayments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
829,56
TOTAL PREPAYMENTS TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
829,56
TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276.687.129,24
BALANCE SHEET ASSETS
31/08/2012
B
BI
Formation expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,344.67
B
TOTAL FORMATION EXPENSES Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,344.67
C
CI
Intangible assets:
CI2
Concessions, patents, licences, trade marks and similar rights and assets, if they were . . . .
64.83
CI
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.83
Tangible assets:
CII1 Lands and buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,884,943.42
CII3 Other fixtures and fittings, tools and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,755,409.26
CII4 Payments on account and tangible assets in course of construction . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,088,121.07
CII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,728,473.75
Financial assets:
CIII1 Shares in affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252,885,889.57
CIII2 Loans to affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,550,000.00
CIII6 Loans and claims held as fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29,974.00
CIII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254,465,863.57
C
TOTAL FIXED ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272,194,402.15
D
CURRENT ASSETS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DII
Debtors:
137254
L
U X E M B O U R G
DII1 Trade debtors: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DII1a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,276.57
DII2 Amounts owed by affiliated undertakings
DII2a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44,414.72
DII3 Amounts owed by undertakings with which the company is linked by virtue of participating
interests
DII3a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,261,169.42
DII4 Other debtors
DII4a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,571.59
DII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,351,432.30
DIV Cash at bank and in the hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,123,120.56
D
TOTAL CURRENT ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,474,552.86
E
PREPAYMENTS:
E
Prepayments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
829.56
TOTAL PREPAYMENTS TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
829.56
TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276,687,129.24
As counterparts of the contribution of part of the portfolio of equity interests with the rights and obligations attached
thereto, both assets and liabilities, being object of the partial division of the Company, the New Company will receive
the following items of the assets and liabilities and it will have therefore the following opening balance sheet.
<i>Divisioni>
KENROSS LUX TWO S.àr.l.
BALANCE SHEET ASSETS
01/09/2012
Financial assets:
CIII1 Shares in affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
CIII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
C
TOTAL FIXED ASSETS TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
DIV Cash at bank and in the hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,00
D
TOTAL CURRENT ASSETS TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,00
TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.680.751,16
EQUITY & LIABILITY
01/09/2012
EQUITY:
AI
Subscribed capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000,00
AIII
Revaluation reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168.765.751,54
AIV1 Legal reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000,00
AV
Profit or loss brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.922.706,70
AVI
Result for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.992.292,92
A
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237.680.751,16
D9
Other creditors
D9b becoming due and payable after more than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000,00
D
TOTAL NON SUBORDINATED DEBTS TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000,00
TOTAL LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.680.751,16
The Company continuing owning the assets and liabilities as follows:
KENROSS LUX S.àr.l.
BALANCE SHEET ASSETS
01/09/2012
B
BI
Formation expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.344,67
B
TOTAL FORMATION EXPENSES TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.344,67
C
CI
Intangible assets:
CI2
Concessions, patents, licences, trade marks and similar rights and assets, if they were . . . . .
64,83
CI
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64,83
Tangible assets:
137255
L
U X E M B O U R G
CII1 Lands and buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.884.943,42
CII3 Other fixtures and fittings, tools and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.755.409,26
CII4 Payments on account and tangible assets in course of construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.088.121,07
CII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.728.473,75
Financial assets:
CIII1 Shares in affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.405.138,41
CIII2 Loans to affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550.000,00
CIII6 Loans and claims held as fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.974,00
CIII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.985.112,41
C
TOTAL FIXED ASSETS TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.713.650,99
D
CURRENT ASSETS:
DII
Debtors:
DII1 Trade debtors:
DII1a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.276,57
DII2 Amounts owed by affiliated undertakings
DII2a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.414,72
DII3
Amounts owed by undertakings with which the company is linked by virtue of participating
interests
DII3a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.261.169,42
DII4 Other debtors
DII4a - becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.571,59
DII4b - becoming due and payable after more than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000,00
DII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.351.432,30
DIV Cash at bank and in the hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
923.120,56
D
TOTAL CURRENT ASSETS TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.274.552,86
E
PREPAYMENTS:
E
Prepayments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
829,56
TOTAL PREPAYMENTS TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
829,56
TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.006.378,08
EQUITY & LIABILITY
01/09/2012
EQUITY:
AI
Subscribed capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,851,655.96
AIII
Revaluation reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,241,421.69
AIV1 Legal reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000,000.00
AV
Profit or loss brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,254,719.78
AVI
Result for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1,882,864.46
A
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,464,932.97
PROVISIONS:
C2
Provisions for taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186.00
C
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186.00
NON SUBORDINATED DEBTS:
D1
Debenture loans:
D1b
Non convertible loans
becoming due and payable after more than one
D1bb year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,038,250.00
D4
Trade creditors: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D4a becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151,688.73
D6
Amounts owed to affiliated undertakings
D6a becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,303,191.19
D7
Amounts owed to undertakings with which the company is linked by virtue of participating
interests
D7b becoming due and payable after more than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
786,191.07
D8
Tax and social security
D8a Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45,833.50
137256
L
U X E M B O U R G
D
TOTAL NON SUBORDINATED DEBTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,530,003.93
DEFERRED INCOMES:
E
Deferred Incomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,255.18
TOTAL DEFERRED INCOMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,255.18
TOTAL LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,006,378.08
Follows the project of the Articles of association of the New Company
KENROSS LUX TWO Sàrl
Registered office: L-1420 Luxembourg, 5, av. Gaston Diderich
Articles of Association
Title I. - Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. The Company is incorporated under the name of “Kenross Lux Two S.àr.l.”.
Art. 2. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 3. The Company is constituted for an undetermined period.
Art. 4. The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other
companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contribu-
tions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents
and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked
to the said object.
The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, man-
agement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it
has a holding or in which it has a direct or indirect interest.
The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly
or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.
Title II. - Capital - Shares
Art. 5. The Company's capital is set at EUR 10.000.000 (ten millions euro), represented by 1.936.107 (one million nine
hundred thirty six thousand one hundred seven) shares without of a par value subscribed and entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
Art. 6. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are
transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of
the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior
approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
Titre III. - Management
Art. 7. The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the
case may be, the members.
Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.
The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in
the representation of the Company towards third parties.
Towards third parties the company will be validly committed under any circumstances, in case of a sole manager, by
the individual signature of the sole manager, an in case of a plurality of managers by the joint signatures of two managers,
or by the signature of a delegate of the board within his powers.
In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose
signature legally commits the company.
Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific
matters predetermined by the manager(s).
Managers should be able to represent one or more other manager(s) at managers, meetings.
137257
L
U X E M B O U R G
Titre IV. - Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 8. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII
of the law of August 10
th
, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the
meeting.
Titre V. - Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 9. The Company's financial year runs from the first of September to the thirty-first of August of each year.
Art. 10. Each year, as of the thirty-first of August there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the
Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until
such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.
Titre VI. - Dissolution
Art. 11. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial
failure of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in
office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The
liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of
debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Titre VII. - General provisions
Art. 12. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law
of 10 August 1915 on commercial companies as amended.
<i>Transitional dispositionsi>
The first fiscal year shall begin the 1
st
of September 2012 and shall terminate on the 31
st
of August 2013.
The first manager(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately
after the incorporation of the company.
<i>Paymentsi>
The Share Capital of Kenross Lux Two Sàrl up to EUR 10.000.000 (ten million), as represented at the article 5 of the
project of the articles of association here above, will be subscribed as follows:
- Bessmer Trust Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
agissant en qualité de Trustee de The Bluefield Trust
1,936,075 shares
- Luciano Berti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 shares
It will be paid in conformity with the partial division project by the transfer to the New Company of the assets and
liabilities of the Company subject to partial division, as per the partial division proposed in the present project of partial
division, namely:
KENROSS LUX TWO S.à.r.l.
BALANCE SHEET ASSETS
01/09/2012
Financial assets:
CIII1 Shares in affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
CIII
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
C
TOTAL FIXED ASSETS TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.480.751,16
137258
L
U X E M B O U R G
DIV Cash at bank and in the hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,00
D
TOTAL CURRENT ASSETS TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,00
TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.680.751,16
EQUITY & LIABILITY
01/09/2012
EQUITY:
AI
Subscribed capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000,00
AIII
Revaluation reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168.765.751,54
AIV1 Legal reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000,00
AV
Profit or loss brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.922.706,70
AVI
Result for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.992.292,92
A
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237.680.751,16
D9
Other creditors
D9b becoming due and payable after more than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000,00
D
TOTAL NON SUBORDINATED DEBTS TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000,00
TOTAL LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239.680.751,16
The present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing parties and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the French version will be prevailing.
Luxembourg, 21 November 2012.
<i>For the Board of Managers
i>Signature
Référence de publication: 2012152104/701.
(120200507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
SEB Absolute, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de SEB Absolute coordonné a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SEB Asset Management S.A.
Référence de publication: 2012152005/9.
(120200269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
LDF65 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 28.875,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 134.749.
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of LDF65 S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 31-33, Avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 134749 and having a
share capital of EUR 28,875 (the Company). The Company has been incorporated on 13 December 2007 pursuant to a
deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Recueil
des Sociétés et Associations, Mémorial C -N° 206 dated 25 January 2008.
There appeared:
Intrum Justitia Debt finance AG, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Switzerland,
having its registered office in Zug, Alpenstrasse 2, CH6300 Switzerland, registered with the Commercial Register of the
Canton of Zug, under number CH.020.3.202.910-7 (the Sole Shareholder),
here represented by Sarah-Nada Arfa, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given under private seal.
The proxy from the Sole Shareholder after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the
Sole Shareholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
137259
L
U X E M B O U R G
I. that it appears that all of the 231 (two hundred and thirty-one) shares of the Company, having a par value of EUR
125 (one hundred and twenty-five Euro) each, are duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted
and can validly deliberate on all the items on the agenda hereinafter reproduced.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
(1) Waiver of convening notice;
(2) Redenomination of class A and B shares into ordinary shares;
(3) Subsequent amendment and restatement of all of the articles of association of the Company (the Articles) to reflect,
inter alia, the changes mentioned above;
(4) Empowerment to and authorisation of any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy
Luxembourg to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to
the items on this agenda including, but not limited to, the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies
Register and the publication of excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and generally to perform
any other action that may be necessary or useful in relation thereto; and
(5) Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been made available to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the redenomination of 150 (one hundred and fifty) class A shares and 81
(eighty-one) class B shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five Euro) each, currently issued
by the Company and held by Intrum Justitia Debt finance AG, into 231 (two hundred and thirty-one) ordinary shares,
having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five Euro) each.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder further resolves to amend and restate the Articles to reflect, inter alia, the changes resulting
from the resolutions above so that those articles shall henceforth read as follows:
"I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of
LDF65 S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Company Law) and the law of 22 March 2004 on
securitisation (the Securitisation Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
board of Administrators of the Company (the Board). The registered office may further be transferred to any other place
within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of the Company shareholders
(the General Meeting -as used in these Articles, «General Meeting» means the sole shareholder if there is no more than
one shareholder) adopted in the manner required for the amendment of these Articles.
2.2. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or
are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Purpose of the Company.
3.1. The corporate objects of the Company are to enter into, perform and serve as a vehicle for, any securitisation
transactions as permitted under the Securitisation Law.
3.2. To that effect, the Company may, inter alia, acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the
risks relating to the holding or ownership of claims, receivables and/or other goods or assets (including securities of any
kind), either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks relating to liabilities or commitments of third
parties or which are inherent to all or part of the activities undertaken by third parties, by issuing securities (valeurs
mobilières) of any kind whose value or return is linked to these risks. The Company may assume or acquire these risks
by acquiring, by any means, claims, receivables and/or other goods, structured products relating to commodities or assets,
137260
L
U X E M B O U R G
by guaranteeing the liabilities or commitments of third parties or by binding itself in any other way. The method that will
be used to determine the value of the securitised assets will be set out in the relevant issue documentation.
3.3. The Company can, to the extent not prohibited by the Securitisation Law and the regulatory construction thereof,
purchase and hold fully-drawn loans or fractions thereof or take silent participations in loans. The Company can grant
new loans only subject to such granting not being in breach of the Securitisation Law and on the following conditions
being satisfied: (i) the loan must be negotiated by a third party or the Company must be assisted in the negotiation of the
terms of the loans by a third party, (ii) the loan, the borrower and the underlying activity financed by the loan must be
adequately disclosed to investors in the Company's issue documentation, (iii) the loan must relate to securitisation trans-
actions and (iv) the return on the activity financed by the loan must be sufficient to allow the Company to service the
securities issued by it (destined to fund the granting of the loans).
3.4. The Company may moreover, within the limits of the Securitisation Law, proceed, so far as they relate to secu-
ritisation transactions, to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly,
of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by
purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock,
bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued
by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings and exchangeable or convertible securities), structured
products relating to commodities or assets (including debt or equity securities of any kind), receivables, claims or loans
or other credit facilities (and the agreements or contracts relating thereto) as well as all other type of assets, and (iii) the
ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets
referred to in (i) and (ii) above) in accordance with the provisions of the relevant issue documentation. The Company
may also act as the acquisition vehicle in the context of a securitisation structure where another securitisation undertaking
acts as the funding vehicle, as provided for by article 1.(2) of the Securitisation Law. The Company may, within the limits
of the Securitisation Law and for as long as it is necessary to facilitate the performance of its corporate objects, borrow
in any form and enter into any type of loan agreement. It may issue (but not to the public) notes, bonds (including
exchangeable or convertible securities and securities linked to an index or a basket of indices or shares), debentures,
certificates, shares, warrants and any kind of debt or equity securities, including under one or more issue programmes.
The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities, within the limits of
the Securitisation Law and provided such lending or such borrowing relates to securitisation transactions, to its subsi-
diaries, affiliated companies or to any other company.
3.5. The Company may, within the limits of the Securitisation Law, give guarantees and grant security over its assets
in order to secure the obligations it has assumed for the securitisation of these assets or for the benefit of investors
(including their trustee or representative, if any) and/or any issuing entity participating in a securitisation transaction of
the Company. The Company may not pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its
assets or transfer its assets for guarantee purposes, unless permitted by the Securitisation Law.
3.6. The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions for as long as such agreements and transactions are necessary to
facilitate the performance of the Company's corporate objects. The Company may generally employ any techniques and
instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques
and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.7. The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The
corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.
3.8. In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or
transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects to
the largest extent permitted under the Company Law or Securisation Law.
3.9. The Company can only perform any of the activities described above involving assets located in Austria to the
extent such activities are permitted under section 2(60) of the Austrian Banking Act (§2 Ziffer 60 des Bundesgesetzes
über das Bankwesen).
Art. 4. Duration.
4.1 The duration of the Company is unlimited.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or other similar event affecting one or more of its shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's capital is set at EUR 28,875 (twenty-eight thousand eight hundred and seventy-five Euro), repre-
sented by 231 (two hundred and thirty one) shares with a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five Euro)
each (the Shares).
137261
L
U X E M B O U R G
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or more times by a resolution of the
General Meeting, adopted in the manner required for amendment of these Articles. Shares issued by the Company may
be expressed as being exclusively related to one or more specific Compartments of the Company.
5.3. The Company shall have power to acquire Shares in its own capital provided that the Company has sufficient
distributable reserves to that effect. The acquisition and disposal by the Company of Shares held by it in its own share
capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole
Shareholder or the General Meeting. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles
shall apply in accordance with article 13.
Art. 6. Shares.
6.1. Without prejudice to the provisions of articles 7 and 16 below, each share entitles the holder to a fraction of the
corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval
of the General Meeting representing at least three quarters of the share capital of the Company. A share transfer will
only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accor-
dance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the
Company Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Company Law and may be examined by each shareholder who so requests.
Art. 7. Compartments.
7.1. The Board may create one or more compartments ("compartiments" in the meaning of the Securitisation Law)
within the Company (the Compartment or the Compartments). Each Compartment shall, unless otherwise provided for
in the resolution of the Board creating such Compartment, correspond to a distinct part of the assets and liabilities
(«patrimoine» in the meaning of the Securitisation Law) of the Company. The resolution of the Board creating one or
more Compartments, or amending the same, shall be binding as of the date of such resolutions against any third party.
7.2. As between shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity.
Rights of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating
to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment
are, except if otherwise provided for in the resolution of the Board having created the relevant Compartment, strictly
limited to the assets of that Compartment and the assets of that Compartment shall be exclusively available to satisfy
such shareholders and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are not related to a Com-
partment shall have no rights to the assets of any Compartment.
7.3. Unless otherwise provided for in the resolution of the Board having created a specific Compartment, no resolutions
of the Board may be taken to amend the resolution having created such Compartment or to take any other decision
directly affecting the rights of the shareholders or creditors whose rights relate to such Compartment, including any
decision to liquidate the shares related to such Compartment, without the prior approval of the shareholders or creditors
whose rights relate to the relevant Compartment. Any decisions of the Board taken in breach of this article shall be void.
7.4 Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation
of another Compartment or of the Company itself.
7.5. Where pursuant to article 7.3. above, the prior approval of the shareholders of a specific Compartment is required,
the majority requirements set forth in article 14 below apply. Where the prior approval of the creditors of a specific
Compartment is required, the majority requirements set forth in either the board resolution creating such Compartment
or the issuing documents relating to the securities of such Compartment apply.
III. Management - Representation
Art. 8. Board of Administrators (gérant).
8.1. The Company is managed by several Administrators (gérant)s who constitute the Board. Each Administrator
(gérant) shall be assigned either an A signatory power (Administrator A) or a B signatory power (Administrator B). The
Administrators (gérants) need not to be shareholders.
8.2. The Administrators (gérants) are appointed, revoked and replaced by a decision of the General Meeting, adopted
by shareholders owning more than half of the share capital.
8.3. The General Meeting may at any time and without cause (ad nutum) dismiss and replace any Administrator (gérant).
Art. 9. Powers of the Board.
9.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or these Articles to the General Meeting shall fall within
the competence of the Board, which shall be empowered to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's purpose and the provisions of the Securitisation Law.
137262
L
U X E M B O U R G
9.2. Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by two Administrators acting jointly.
Art. 10. Procedure.
10.1 The Board shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any Administrator at the
place indicated in the convening notice.
10.2 Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Administrators at least 24 (twenty-four) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board.
10.3 No such convening notice is required if all Administrators of the Company are present or represented at the
meeting and if they all state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice
may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the
Board.
10.4 A Administrator may act at a meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another Administrator as his proxy provided however that a Administrator A (respectively B) may only grant a
power of attorney to another Administrator A (respectively B) in order to be represented at any meeting of the Board.
10.5 The Board can validly deliberate and act only if the majority of the Administrators are present or represented
(including at least one Administrator A and one Administrator B).
10.6 Resolutions of the Board are valid if approved by a majority of the Administrators present or represented at such
meeting.
10.7 Any Administrator may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference call or by any
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other.
Any Administrator participating in a meeting by such means is deemed to be present in person at such meeting.
10.8 Circular resolutions signed by all the Administrators of the Company shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple
counterparts of identical minutes and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 11. Representation.
11.1. The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one Administrator A (gérant
A) and one Administrator B (gérant), with the exception that any Administrator A or Administrator B acting alone has
single signing power and can legally bind and represent the Company in courts and tribunals, perform all relevant activities
in relation to legal debt collection in Spain (including but not limited to, the execution of documentation relating to the
Proceso Monitorio, Proceso Ordinario, Proceso Verbal, regular processes, execution processes, or any other need for
country specific documents for legal debt collection processes etc.) in relation to receivables owned by the Company or
in individual debt collection claims or cases owned by the Company in Spain.
11.2. The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person
to whom specific signatory power is granted by one Administrator A and one Administrator B acting jointly or by the
Board, but only within the limits of such power.
Art. 12. Liability of the Administrators (gérant). The Administrators (gérants) assume, by reason of their mandate, no
personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company provided that such
commitment is in compliance with these Articles and with applicable laws.
IV. General meetings
Art. 13. General meetings of the shareholders of the Company.
13.1. If the Company is owned by a sole shareholder, such shareholder shall have all powers conferred by the Company
Law to the General Meeting.
13.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of shareholders may be taken without a meeting
by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram,
telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the resolution. Signatures of shareholders may
appear on a single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may be evidenced by original or
facsimile signature. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given
by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
13.3. Each Share is entitled to one vote, except that with regard to shares which do not have an equal value, the voting
rights attached to such Shares shall be proportionate to the portion of the share capital represented by such Shares of
non equal value.
13.4. Collective decisions in respect of matters relating to the Company in general are only validly taken insofar as
they are adopted by shareholders owning more than one half of the share capital of the Company. However, resolutions
to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarters of the Company's share capital.
137263
L
U X E M B O U R G
Art. 14. General meetings of holders of shares relating to a specific Compartment.
14.1 The holders of shares of the Company relating to a specific Compartment of the Company may, at any time, hold
general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Compartment.
14.2 The holders of shares of the Company relating to other Compartments of the Company or the holders of Shares
relating to the Company and not related to a specific Compartment of the Company may attend, but shall not be entitled
to vote at such meetings.
14.3 The provisions of article 13 shall apply mutatis mutandis to the general meetings of holders of Shares relating to
a specific Compartment. Decisions affecting the rights of holders of shares of a specific Compartment or deciding upon
the liquidation of the Compartment are subject to the affirmative vote of the majority of holders of Shares representing
at least three quarters of the Shares relating to such Compartment.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 15. Annual accounts.
15.1 The financial year of the Company shall begin on the 1 January of each year and end on the 31 December of the
same year.
15.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts shall be esta-
blished, and the Board shall prepare a balance sheet setting out the Company's assets and liabilities and the profit and
loss accounts.
15.3 On separate accounts (in addition to the accounts held by the Company in accordance with the Company Law
and normal accounting practice), the Board shall determine at the end of each financial year, a result of each Compartment
to be determined as follows: The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other
receipts paid or due in any other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation
surplus, dividend distribution) and the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers of funds incurred by the
Company during its exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management and operation of
such Compartments (including fees, costs, corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribu-
tion). The shareholders will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in
accordance with the Company Law and normal practice.
15.4 All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Compartments
of the Company on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment or other reasonable manner determined
by the Board.
15.5 The accounts of Company shall be audited by an independent auditor to be appointed by the Board.
Art. 16. Allocation of Profits.
16.1 The gross profits of the Company as stated in its annual accounts, after deduction of general expenses and
amortisation, shall constitute the Company's net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal to ten per cent (10%) of the
Company's nominal share capital.
16.2 The balance of the net profits may be distributed to the Shareholder(s) in accordance with and in the proportions
as described under articles 15.3 and 15.4 above.
16.3 The Board may decide to pay interim dividends in accordance with and in the proportions as described under
articles 15.3 and 15.4 above.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not be shareholders, appointed by resolution of the General Meeting, which will determine the powers and remu-
neration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators
shall be invested with the broadest powers available under applicable law for the realisation of assets and payment of the
liabilities of the Company. Any liquidation of the Company must be conduced in accordance with article 7 on a Com-
partment by Compartment basis.
17.2 The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company on a Compart-
ment by Compartment basis shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares of each Compartment
held by them.
VII. General provision
18. Reference is made to the provisions of the applicable Company Law and the Securitisation Law of 22 March 2004
for all matters for which no specific provision is made in these Articles."
137264
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant power and authority to any manager of the Company or any lawyer or employee
of Allen & Overy Luxembourg to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg autho-
rities in relation to the items on this agenda including, but not limited to, the filing of documents with the Luxembourg
Trade and Companies Register and the publication of excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and
generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is approximately EUR 1,500.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausend und zwölf, am fünfzehnten November.
Vor dem Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Hat eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter der LDF65 S.à r.l. stattgefunden (die Hauptver-
sammlung), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz
in 31-33, Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 134749
mit einem aktuellen Grundkapital in Höhe von EUR 28,875 (die Gesellschaft). Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß
Urkunde vom 13. Dezember 2007, aufgenommen durch Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffent-
licht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, unter der Nummer C n°206 vom 25. Januar 2008.
Ist erschienen:
Intrum Justitia Debt finance AG, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung schweizerischen Rechts, mit Sitz in Zug,
Alpenstrasse 2, CH-6300 Schweiz, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug, unter der Nummer CH.
020.3.202.910-7 (der Alleinige Gesellschafter),
vertreten durch Sarah-Nada Arfa, Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten
Vollmacht.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und dem unterzeichnenden Notar dieser
Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
Der Alleinige Gesellschafter hat den Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:
I. dass sämtliche 231 (zweihunderteinunddreißig) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils EUR 125
(einhundertfünfundzwanzig Euro), anwesend oder ordnungsgemäß und gültig vertreten sind, und dass die gegenwärtige
Hauptversammlung somit rechtsgültig zusammengetreten ist und über alle Punkte der Tagesordnung rechtskräftig ent-
scheiden kann;
II. dass die Tagesordnung der Hauptversammlung folgende Punkte enthält:
(1) Verzicht auf die Einberufungsformalitäten;
(2) Umwandlung der Aktienklassen A und B in normale Aktien;
(3) Nachträgliche Änderung und Neufassung aller Artikel der Statuten, um inter alia die oben angeführten Änderungen
zu reflektieren;
(4) Vollmacht und Autorisierung an jeden Manager der Gesellschaft oder Anwalt oder Angestellten von Allen & Overy
Luxemburg, um im Auftrag der Gesellschaft alle Formalitäten gegenüber dem Handelsregister in Bezug darauf zu erledigen,
sowie die Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C; und
(5) Verschiedenes.
III. Sodann trifft die Hauptversammlung folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Da die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Hauptversammlung anwesend oder ordnungsgemäß
und gültig vertreten ist, verzichtet die Hauptversammlung ausdrücklich auf jede Anforderung in der Satzung der Gesell-
schaft oder anderweitig in Bezug auf die Einberufungsformalitäten; der Alleinige Gesellschafter betrachtet sich als
ordnungsgemäß geladen und bestätigt, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihm im voraus übermittelt wurde.
137265
L
U X E M B O U R G
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter veranlasst und genehmigt die Umschreibung von 150 (einhundertundfünfzig) A-Anteilen
und 81 (einundachtzig) B-Anteilen, mit einem Nennwert von jeweils EUR 125 (einhundertfünfundzwanzig), welche zurzeit
von der Gesellschaft ausgegeben und von Intrum Justitia Debt finance AG gehalten sind, in 231 (zweihunderteinunddreißig)
normale Anteile, mit einem Nennwert von jeweils EUR 125 (einhundertfünfundzwanzig).
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt die Satzung mit den Änderungen aus des, inter alia, obigen Beschlusses neu zu
formulieren; der Wortlaut ist demnach folgender:
"I. Name - Sitz - Gesellschaftsziel - Laufzeit
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen
LDF65 S.à r.l. (nachfolgend, die Gesellschaft) (Société à responsabilité limitée), welche den Rechten des Großherzogtums
Luxemburg unterliegt, insbesondere den Gesetzen vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften (nachfolgend, das Ge-
sellschaftsgesetz), vom 22. März 2004 zu Verbriefungen (nachfolgend, das Verbriefungsgesetz) in der jeweils gültigen
Fassung und der hier stehenden Satzung (nachfolgend, die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Die Gesellschaft hat ihren Firmensitz in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann per
Beschluss der Sitzung des Geschäftsführenden Vorstands (der Vorstand) der Gesellschaft an jeden anderen Ort innerhalb
des Gebiets von Luxemburg verlegt werden. Der Sitz kann weiter per Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter
(die Hauptversammlung der Gesellschafter bedeutet in dieser Satzung den alleinigen Gesellschafter, falls die Gesellschaft
nur einen Gesellschafter hat) der Gesellschaft an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtum Luxemburgs verlegt
werden.
2.2. Sollte der Geschäftsführende Vorstand entscheiden, dass außergewöhnliche Entwicklungen politischer, wirtschaft-
licher oder sozialer Natur stattfinden oder bevorstehen, welche die üblichen Geschäfte der Gesellschaft an ihrem Sitz
oder die Leichtigkeit der Kommunikation mit solchem Sitz oder zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beein-
trächtigen könnten, kann der Firmensitz kurzfristig ins Ausland verlegt werden bis zu dem Zeitpunkt, an dem die
unüblichen Umstände vollkommen beendet sind; ungeachtet dieser zeitlich begrenzten Verlegung des Firmensitzes, hat
diese vorübergehende Maßnahme keinerlei Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche luxemburgisch bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1 Zweck der Gesellschaft ist es, jegliche Verbriefungsgeschäfte im Rahmen des Verbriefungsgesetzes einzugehen oder
als Verbriefungsvehikel solche Geschäfte zu tätigen.
3.2 In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft, unter anderem, unmittelbar oder durch eine zwischengeschaltete
juristische Person oder ein zwischengeschaltetes Vehikel, Risiken bezüglich der Beteiligung oder dem Eigentum an For-
derungen, Außenständen und / oder an anderen Vermögenswerten oder Wirtschaftsgütern (einschließlich Wertpapieren
aller Art), ob beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, sowie Risiken, die aus, von Dritten eingegangenen,
Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten, oder sich auf alle oder Teile der Tätigkeiten von Dritten beziehen, erwerben
oder eingehen in dem die Gesellschaft Wertpapiere jeglicher Art, dessen Wert oder Ertrag an diese Risiken gebunden
ist, begibt. Die Gesellschaft kann diese Risiken eingehen oder erwerben durch jegliche Art von Aneignung von Forde-
rungen, strukturierter Anlagen, Außenständen und / oder anderer Wirtschaftsgüter, strukturierter Produkte basierend
auf Rohstoffen oder Vermögenswerten, durch die Absicherung von Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen Dritter oder
durch jegliche weitere Art von eigenen Verpflichtungen. Die Methode zur Beurteilung des Wertes der verbrieften Ver-
mögenswerte wird in der relevanten Emissionsdokumentation dargelegt.
3.3 Die Gesellschaft kann, sofern dies mit dem Verbriefungsgesetz vereinbar ist und dies mit Verbriefungsgeschäften
zusammenhängt, vollumfänglich bezogene Darlehen oder Teile davon erwerben und verwalten oder sich durch stille
Einlagen an Darlehen beteiligen. Die Gesellschaft kann nur dann neue Darlehen gewähren sofern dies mit dem Verbrie-
fungsgesetz vereinbar ist und wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: (i) Das Darlehen muss durch eine Drittpartei
verhandelt werden bzw. die Gesellschaft muss bei der Verhandlung der Bedingungen des Darlehens durch eine Drittpartei
unterstützt werden, (ii) die Anleger müssen in angemessener Weise in den Emissionsdokumenten über das Darlehen,
den Darlehensnehmer und die unterliegenden Tätigkeiten, die mittels des Darlehens finanziert werden, unterrichtet
werden, (iii) das Darlehen muss mit Verbriefungsgeschäften in Zusammenhang stehen und (iv) die mittels des Darlehens
finanzierte Tätigkeit muss eine ausreichende Rendite erbringen, um der Gesellschaft zu ermöglichen die Wertpapiere die
von ihr ausgegeben wurden, zu bedienen (zur Finanzierung der Darlehensgewährung bestimmt).
3.4 Die Gesellschaft kann, sofern dies mit dem Verbriefungsgesetz vereinbar ist und dies mit Verbriefungsgeschäften
zusammenhängt (i) mittel-oder unmittelbar, Beteiligungen, Rechte und Anteile sowie Schuldverschreibungen von luxem-
burgischen und ausländischen Gesellschaften erwerben, halten und veräußern, (ii) Beteiligungen, Anleihen, Pfandbriefe,
Schuldverschreibungen und andere Wertpapiere oder Finanzinstrumente aller Art (einschließlich Schuldverschreibungen,
Anteile, Einheiten welche durch luxemburgische oder ausländische Anlagefonds oder ähnliche Unternehmen begeben
wurden und wechselbare oder wandelbare Wertpapiere), strukturierte Produkte basierend auf Rohstoffen oder Ver-
137266
L
U X E M B O U R G
mögenswerten (einschließlich auf Schulden oder Kapital basierender Wertpapiere jeglicher Art), Außenstände, Forde-
rungen oder Darlehen oder andere kreditbasierte Verträge (und diesbezügliche Vereinbarungen oder Verträge) sowie
jede andere Art von Gütern in diesem Zusammenhang durch Kauf, Zeichnung oder jeglicher anderer Art erwerben sowie
auch durch Veräußerung, Tausch und jeglicher anderen Art übertragen und (iii) das Eigentum, die Verwaltung, die Ent-
wicklung und das Management eines Portfolios solcher Vermögenswerte (einschließlich, unter anderen, der in (i) und (ii)
aufgeführten Güter), unter Beachtung der relevanten Emissionsdokumentation, übernehmen. Die Gesellschaft kann au-
ßerdem als Ankaufsorganismus im Rahmen eines Verbriefungsgeschäftes tätig sein, in dem ein anderer Verbriefungsor-
ganismus als Finanzierungsorganismus tätig ist, sowie es der Artikel 1.(2) des Verbriefungsgesetzes vorsieht. Die
Gesellschaft darf, sofern dies mit dem Verbriefungsgesetz vereinbar und der Erreichung ihres Gesellschaftszwecks zu-
träglich ist, sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen und Darlehensverträge abschließen. Die Gesellschaft kann
(ohne sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen) Anleihen, Schuldverschreibungen (einschließlich wechselbarer oder
wandelbarer Wertpapiere und Wertpapieren welche auf einem oder einer Gruppe von Indizes oder Aktien basieren),
Pfandbriefe, Zertifikate, Aktien, Optionsscheine und jegliche Art von auf Schulden oder Kapital basierenden Wertpapieren
(einschließlich Genussscheine), sowohl unter einem als auch unter mehreren Programmen, begeben. Die Gesellschaft
kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften und andere Gesellschaften vergeben, dies
auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von Wertpapieren bezieht, soweit dies
im Rahmen des Verbriefungsgesetzes zulässig ist und die Darlehensvergabe und Kreditaufnahme in Zusammenhang mit
Verbriefungsgeschäften stehen.
3.5 Die Gesellschaft darf, sofern dies mit dem Verbriefungsgesetz vereinbar ist, Garantien und Sicherheiten über ihre
Aktiva gewähren um ihre Verpflichtungen aus der Verbriefung dieser Vermögenswerte, die Investoren (einschließlich
ihrer Treuhänder und Vertreter, sofern vorhanden) und / oder jegliche an einer Verbriefungstransaktion teilnehmende
emittierende juristische Person besichern. Sie darf nicht ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, abtreten, belasten
oder auf jede andere Art belasten oder ihre Aktiva zu Garantie Zwecken übereignen, außer dies wäre gemäß dem Ver-
briefungsgesetz zulässig.
3.6 Die Gesellschaft darf Swaps, Futures, Forwards, Derivate, Optionen, Rückkaufund Wertpapierdarlehensgeschäfte
sowie vergleichbare Transaktionen abschließen und ausführen, sofern solche Vereinbarungen oder Transaktionen der
Erreichung des Gesellschaftszwecks zuträglich sind. Die Gesellschaft darf grundsätzlich alle Investmenttechniken und
Investmentinstrumente zum Zwecke der wirtschaftlichen und effizienten Verwaltung ihrer Investitionen verwenden, ein-
schließlich aber nicht ausschließlich solcher Techniken und Instrumente, die der Absicherung gegen Kreditrisiken,
Wechselkursrisiken von Devisen, Zinssatzrisiken sowie sonstiger Risiken dienen.
3.7 Die vorangegangenen Schilderungen verstehen sich in ihrem weitesten Sinn und es soll sich hierbei nicht um eine
abschließende Aufzählung handeln. Der Gesellschaftszweck soll ebenfalls jede Transaktion oder Vereinbarung umfassen
welche von der Gesellschaft eingegangen wird, sofern diese nicht den vorhergehend aufgezählten Zwecken widerspricht.
3.8 Die Gesellschaft nimmt, im Allgemeinen, sämtliche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen und führt jegliche
Operation oder Transaktion, welche sie für die Erfüllung und Entwicklung des Gesellschaftszwecks als notwendig oder
zuträglich erachtet, im weitesten, unter dem Verbriefungsgesetz zulässigen Ausmaß aus.
3.9 Die Gesellschaft darf die oben genannten Aktivitäten, welche in Österreich befindliche Aktiva betreffen, nur aus-
üben sofern die Ausübung jener Aktivitäten mit dem österreichischen Bankengesetz vereinbar ist (§2 Ziffer 60 des
Bundesgesetzes über das Bankwesen).
Art. 4. Laufzeit.
4.1. Die Dauer der Gesellschaft ist unbefristet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, zeitweiligen Entzug der Ausübung von zivilen Rechten, Unfähigkeit,
Konkurs, Insolvenz oder andere gleichartige Ereignisse, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen, aufgelöst.
II. Grundkapital - Geschäftsanteilen
Art. 5. Grundkapital.
5.1. Das gezeichnete Stammkapital beträgt EUR 28.875 (achtundzwanzigtausend achthundertfünfundsiebzig Euro), auf-
geteilt in 231 (zweihunderteinunddreißig) Geschäftsanteile, wobei jeder Geschäftsanteil einem Nominalwert von je EUR
125 (einhundertfünfundzwanzig Euro) entspricht (die Geschäftsanteile).
5.2. Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann einmal oder öfter durch Beschluss der Hauptver-
sammlung der Gesellschaft, der unter den für eine Satzungsänderung in dieser Satzung vorgeschrieben Bedingungen gefasst
wird, erhöht oder herabgesetzt werden. Die von der Gesellschaft ausgegebenen Geschäftsanteile können so ausgedrückt
sein, dass sie sich ausschließlich auf eine oder mehrere bestimmte Abteilungen der Gesellschaft beziehen.
5.3 Die Gesellschaft kann Anteile von ihrem eigenen Stammkapital erwerben, vorausgesetzt dass die Gesellschaft
ausreichende Reserven zu diesem Zweck besitzt. Der Erwerb und die Veräußerung durch die Gesellschaft von Anteilen
in ihrem eigenen Stammkapital findet statt durch einen Beschluss zu den Bedingungen, die von dem Alleinigen Gesell-
schafter oder der Hauptversammlung gefasst werden. Die Quorumund Mehrheitserfordernisse für Abänderungen der
Satzung werden gemäß Artikel 13 angewandt.
137267
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 7 und 16, berechtigt jeder Geschäftsanteil den Eigentümer an einem
Teil des Vermögens und Gewinns der Gesellschaft im direkten Verhältnis zur Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.
6.2. Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer für jeden
Geschäftsanteil zugelassen ist. Mitinhaber von Geschäftsanteilen müssen eine einzelne Person als ihren Vertreter gegen-
über der Gesellschaft bestellen.
6.3. Die Geschäftsanteile sind frei unter Gesellschaftern und, wenn es nicht mehr als einen Gesellschafter gibt, an Dritte
übertragbar. Falls die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-
Gesellschafter von der vorherigen Zustimmung durch die Hauptversammlung der Gesellschafter, die mehr als Dreiviertel
des Grundkapitals vertritt, abhängig. Die Übertragung von Geschäftsanteilen ist für die Gesellschaft oder Dritte nur nach
Verständigung der Gesellschaft oder Annahme durch die Gesellschaft gemäß Artikel 1690 des Zivil Gesetzbuches rechts-
verbindlich. Hinsichtlich aller anderen Angelegenheiten wird auf Artikel 189 und 190 des Gesellschaftsgesetzes verwiesen.
6.4. Ein Gesellschafterregister wird am Gesellschaftssitz gemäß den Vorschriften des Gesellschaftsgesetzes geführt und
kann von jedem Gesellschafter, der es verlangt, überprüft werden.
Art. 7. Abteilungen.
7.1 Der Geschäftsführende Vorstand kann eine oder mehrere Abteilungen ("compartiment" im Sinne des Verbrie-
fungsgesetzes) innerhalb der Gesellschaft schaffen (die Abteilung oder die Abteilungen). Jede Abteilung hat einem
bestimmten Teil des Betriebsvermögens und der Verbindlichkeiten ("patrimoine" im Sinne des Verbriefungsgesetzes) der
Gesellschaft zu entsprechen, soweit der Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands, mit welchem diese Abteilung be-
gründet wurde, nichts anderes vorsieht. Der Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands, welcher eine oder mehrere
Abteilungen begründet, oder selbige abändert, ist gegenüber jedem Dritten mit Wirkung des Datums des Beschlusses
rechtsverbindlich.
7.2. Im Verhältnis der Gesellschafter zu den Gläubigern wird jede Abteilung als eigenständige Einheit behandelt. Die
Rechte der Gesellschafter und der Gläubiger der Gesellschaft, die (i) bei Entstehung als zu einer Abteilung zugehörig
bestimmt wurden oder (ii) im Zusammenhang mit der Schaffung, dem Geschäftsbereich oder der Liquidation einer Ab-
teilung entstanden sind, sind, soweit nichts anderes im Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands, welcher die jeweilige
Abteilung begründet hat, vorgesehen, absolut beschränkt auf die Vermögensgegenstände der jeweiligen Abteilung und
nur solche Vermögensgegenstände stehen für die Befriedigung der Ansprüche der Gesellschafter und Gläubiger zur Ver-
fügung. Die Gläubiger und Gesellschafter der Gesellschaft, deren Rechte sich nicht auf eine bestimmte Abteilung beziehen,
haben keine Rechte in Bezug auf die Vermögensgegenstände irgendeiner Abteilung.
7.3. Soweit nicht anders in dem Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands, welcher eine bestimmte Abteilung be-
gründet, vorgesehen ist, kann kein Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands gefasst werden, um einen Beschluss,
welcher eine solche Abteilung begründet, abzuändern oder um eine Entscheidung zu treffen, welche die Rechte der
Gesellschafter und Gläubiger, deren Rechte sich auf diese Abteilung beziehen, beeinträchtigen könnte, einschließlich einer
Entscheidung, die Geschäftsanteile, die sich auf diese Abteilung beziehen, zu liquidieren ohne vorheriger Zustimmung der
Gesellschafter und Gläubiger, deren Rechte sich auf die jeweilige Abteilung beziehen. Jeder Beschluss des Geschäftsführ-
enden Vorstands, welcher hiergegen verstößt, ist nichtig.
7.4. Jede Abteilung der Gesellschaft kann eigenständig liquidiert werden, ohne dass eine solche Liquidation eine Liqui-
dation einerweiteren Abteilung oder sogar der Gesellschaft selbst nach sich zieht.
7.5. Ist die vorherige Zustimmung der Gesellschafter einer bestimmten Abteilung gemäß des obenbeschriebenen Ar-
tikels 7.3 erforderlich, sind die Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 14 anzuwenden. Ist die vorherige Zustimmung der
Gläubigern einer bestimmten Abteilung erforderlich, sind die Mehrheitserfordernisse anwendbar, welche entweder in
dem Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands, welcher eine solche Abteilung begründet, oder in den ausgegebenen
Dokumenten in Bezug auf die Wertpapiere der jeweiligen Abteilung vorgeschrieben sind.
III. Geschäftsführung - Vertretung
Art. 8. Geschäftsführender Vorstand (Conseil de Gérance).
8.1. Die Gesellschaft wird vom Geschäftsführenden (gérants) Vorstand, bestehend aus mehreren Geschäftsführern
(gérants), geleitet, welcher aus A-Geschäftsführer(n) (A-Geschäftsführer) und aus B-Geschäftsführer(n) (B-Geschäftsfüh-
rer) besteht, die keine Gesellschafter sein müssen.
8.2. Die Geschäftsführer (gérants) werden ernannt, widerrufen oder ersetzt auf Grund eines Beschlusses, angenommen
von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Stammkapitals besitzen.
8.3. Der Geschäftsführende Vorstand kann die Geschäftsführer (gérant) jederzeit und ohne Grund (ad nutum) entlassen
oder ersetzen.
Art. 9. Befugnisse des Geschäftsführenden Vorstands.
9.1. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung der Hauptver-
sammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen unter den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführenden Vorstands,
der alle Befugnisse hat, um alle Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu bestätigen, die mit dem Gesellschaftszweck
und mit den Vorschriften des Verbriefungsgesetzes übereinstimmen.
137268
L
U X E M B O U R G
9.2. Besondere und begrenzte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten durch gemeinsame Unterschrift
von zwei Geschäftsführern an einen oder mehrere Vertreter vergeben werden, die keine Gesellschafter sein müssen.
Art. 10. Vorgehensweise.
10.1. Der Geschäftsführende Vorstand trifft am Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben ist, so oft, wie die
Interessen der Gesellschaft es verlangen oder auf Einberufung eines Geschäftsführers zusammen.
10.2. Schriftliche Verständigungen über jede Sitzung des Geschäftsführenden Vorstands ergehen mindestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor dem Tag der Sitzung an alle Geschäftsführer, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art
dieser Umstände im Einberufungsschreiben für die Sitzung des Geschäftsführenden Vorstands anzugeben ist.
10.3. Ein Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer der Gesellschaft in einer Sitzung
anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Tagesordnung der Sitzung ordnungsgemäß informiert worden zu
sein und diese vollständig zu kennen. Auf eine Verständigung kann von jedem Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands
der Gesellschaft schriftlich per Telegramm, Telex, Faksimile oder Email verzichtet werden.
10.4. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann an jeder Sitzung des Geschäftsführenden Vorstands teilnehmen,
indem er einen anderen Geschäftsführer in schriftlicher Form oder per Telefax oder elektronischer Mail (e-mail) der
Gesellschaft zu seinem Vertreter bestellt, jedoch unter der Voraussetzung, dass ein A-Geschäftsführer (bzw. ein B-Ge-
sellschafter) nur von einem anderen A-Geschäftsführers (bzw. einem anderen B-Gesellschafter) bei einer Sitzung vertreten
werden kann.
10.5. Der Geschäftsführende Vorstand kann nur gültig tagen und beschließen, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer
anwesend oder vertreten ist (einschließlich mindestens eines A-Geschäftsführers und eines B-Geschäftsführers).
10.6. Die Beschlüsse des Geschäftsführenden Vorstands sind gültig, wenn sie mit der Mehrheit der in der Sitzung
anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.
10.7. Jeder Geschäftsführer kann über Telefon-oder Videokonferenz oder durch jedwede andere, ähnliche Kommu-
nikationsmittel, die allen Personen, die an der Sitzung teilnehmen, ermöglichen, einander zu hören und miteinander zu
sprechen, an einer Sitzung des Geschäftsführenden Vorstands teilnehmen. Die Teilnahme eines Geschäftsführers an einer
Sitzung durch diese Mittel ist der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleichgestellt.
10.8. Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern der Gesellschaft unterzeichnet sind, sind ebenso gültig und
verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst wurden. Diese Unter-
schriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses
geleistet, und schriftlich oder per Faksimile bescheinigt werden.
Art. 11. Vertretung.
11.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift eines A-
Geschäftsführers und eines B-Geschäftsführers gebunden mit der Ausnahme, dass jeder A-oder B-Geschäftsführer über
eine alleinige Unterschriftsberechtigung verfügt, um die Gesellschaft vor Gericht oder in allen relevanten rechtlichen
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Eintreibung von rechtlichen Verbindlichkeiten in Spanien (einschließlich (ohne
Begrenzung) der Vollstreckung von Titeln in Proceso Monitario, Proceso Ordinario, Proceso Verbal, der regulären Ver-
fahren, der Vollstreckungsverfahren oder jeglichen Bedarfs betreffend landesspezifischer Dokumente, welche zur Ein-
treibung rechtlicher Verbindlichkeiten notwendig sind etc.) im Zusammenhang mit Forderungen der Gesellschaft oder in
individuellen Verbindlichkeitsklagen oder -fällen der Gesellschaft in Spanien.
11.2 Die Gesellschaft wird ferner durch die gemeinsame Unterschrift von Personen oder durch die alleinige Unter-
schrift einer Person gebunden, an die (eine) spezifische Zeichnungsberechtigung(en) durch einen A-Geschäftsführer und
einen B-Geschäftsführer oder durch den Geschäftsführenden Vorstand erteilt wurde(n), jedoch nur innerhalb des Rah-
mens dieser Vollmacht.
Art. 12. Verpflichtung der Geschäftsführer (gérants). Die Geschäftsführer übernehmen keine persönliche Haftung für
Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft gültig eingegangen sind, sofern solche Verpflichtungen in Überein-
stimmung mit dieser Satzung und dem anwendbaren Recht sind.
IV. Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 13. Hauptversammlungen der Gesellschafter der Gesellschaft.
13.1. Wenn die Gesellschaft einem einzigen Gesellschafter gehört, hat dieser Gesellschafter alle Befugnisse, die das
Gesellschaftsgesetz der Hauptversammlung der Gesellschafter zuweist.
13.2. Falls die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig nicht übersteigt, können ihre Entscheidungen ohne Sitzung
durch Umlaufbeschluss gefasst werden, dessen Text schriftlich, sei es im Original oder mit Telegramm, Telex, Faksimile
oder Email, an alle Gesellschafter zu senden ist. Die Gesellschafter geben ihre Stimme durch Unterzeichnung des Um-
laufbeschlusses ab. Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren
Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses geleistet werden, und per Original oder Faksimile-Unterschrift bescheinigt
werden. Jeder Gesellschafter kann eine Person oder juristische Person zum Vertreter mit schriftlicher Vollmacht, die mit
einem Schreiben. Telegramm, Telex, Faksimile oder Email erteilt wird, bestellen, um diesen in Hauptversammlungen der
Gesellschafter zu vertreten.
137269
L
U X E M B O U R G
13.3. Jeder Gesellschaftsanteil ist zu einer Stimme berechtigt, außer dass hinsichtlich der Stimmrechte aufgrund von
Gesellschaftsanteilen, die nicht gleichwertig sind, diese im Verhältnis zum Teil des Stammkapitals stehen, das durch solche
nicht gleichwertige Anteile vertreten ist.
13.4. Gemeinsame Beschlüsse in Zusammenhang mit die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten sind nur insoweit
gültig, als sie von Gesellschaftern gefasst wurden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen.
Beschlüsse, um die Satzung abzuändern oder die Gesellschaft aufzulösen oder zu liquidieren, können jedoch nur von einer
Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens dreiviertel des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen, gültig gefasst werden.
Art. 14. Hauptversammlung der Gesellschafter, die sich auf eine bestimmte Abteilung beziehen.
14.1. Die Eigentümer von Gesellschaftsanteilen an der Gesellschaft, die sich auf eine bestimmte Abteilung der Gesell-
schaft beziehen, können jederzeit Hauptversammlungen abhalten, um über Angelegenheiten zu entscheiden, die sich
ausschließlich auf diese Abteilung beziehen.
14.2. Die Eigentümer von Gesellschaftsanteilen an der Gesellschaft, die sich auf andere Abteilungen der Gesellschaft
beziehen, oder die Eigentümer von Gesellschaftsanteilen an der Gesellschaft, die sich auf die Gesellschaft und nicht auf
eine bestimmte Abteilung der Gesellschaft beziehen, können an diesen Hauptversammlungen teilnehmen, sind jedoch
nicht stimmberechtigt.
14.3. Die Bestimmungen von Artikel 13 gelten mutatis mutandis für die Hauptversammlungen von Eigentümern von
Gesellschaftsanteilen, die sich auf eine bestimmte Abteilung beziehen. Die Beschlüsse, die die Rechte der Eigentümer von
Gesellschaftsanteilen an einer bestimmten Abteilung beeinträchtigen oder die über die Auflösung der Abteilung entschei-
den, bedürfen der zustimmenden Stimmen der Gesellschafter an wenigstens drei Viertel der Anteilen, die sich auf solche
Abteilung beziehen.
V. Jahresabschluss -Gewinnzuteilung
Art. 15. Geschäftsjahr.
15.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember
desselben Jahres.
15.2. In Bezug auf das Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft hat der Geschäftsführende Vorstand jedes Jahr den
Jahresabschluss zu erstellen und die Bilanz, in der die Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Gewinn-und Verlust-
rechnung darstellt ist, vorzubereiten.
15.3. In gesonderten Geschäftsbüchern (zusätzlich zu den von der Gesellschaft gemäß dem Gesellschaftsgesetz und
der üblichen Buchhaltungspraxis geführten Geschäftsbüchern) wird der Geschäftsführende Vorstand am Ende jedes Ge-
schäftsjahres ein Ergebnis für jede Abteilung wie folgt ermitteln: Das Ergebnis jeder Abteilung besteht aus der Differenz
aus allen Einnahmen, Gewinnen oder sonstigen bezahlten oder auf sonstige Weise fälligen Eingängen, die sich auf die
jeweilige Abteilung beziehen (einschließlich Kapitalerträgen, Mehrbeträgen nach Liquidation, Dividendenausschüttung)
und dem Betrag aller Ausgaben, Verluste, Steuern und sonstiger Überweisungen von Geldern, die der Gesellschaft ent-
standen sind und die regelmäßig und vernünftigerweise der Geschäftsführung und dem Geschäftsbereich der jeweiligen
Abteilungen zugeordnet werden können (einschließlich Gebühren, Kosten, Körperschaftssteuer auf Kapitalerträge, Kos-
ten der Dividendenausschüttung). Die Gesellschafter werden diese gesonderten Geschäftsbücher zugleich mit den
Geschäftsbüchern der Gesellschaft gemäß dem Gesellschaftsgesetz und der üblichen Praxis bestätigen.
15.4. Alle Einnahmen und Ausgaben, die nicht einer bestimmten Abteilung zugeordnet werden können, sind allen
Abteilungen der Gesellschaft entsprechend der ausgegebenen Geschäftsanteilen anteilig oder auf sonstige, angemessene
Weise, welche vom Geschäftsführenden Vorstand zu bestimmen ist, zuzuordnen.
15.5. Die Geschäftsbücher der Gesellschaft werden von einem unabhängigen von dem Geschäftsführenden Vorstand
bestellten Wirtschaftsprüfer geprüft.
Art. 16. Gewinnverteilung.
16.1 Der in den Jahreskonten aufgeführte Bruttogewinn der Gesellschaft, nach Abzug der Allgemeinkosten, Tilgungen
und Kosten, stellt den Nettogewinn dar. Ein Betrag, der 5% (fünf Prozent) des Nettogewinns der Gesellschaft entspricht,
wird der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese 10% (zehn Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
16.2 Der Ertrag des Nettogewinns kann an die Gesellschafter ausgeschüttet werden gemäß und entsprechend den
ausgegebenen Geschäftsanteilen wie in obigen Artikeln 15.3 und 15.4 beschrieben.
16.3 Der Geschäftsführende Vorstand kann beschließen Zwischendividenden auszuzahlen gemäß und entsprechend
den ausgegebenen Geschäftsanteilen wie in obigen Artikeln 15.3 und 15.4 beschrieben.
VI. Auflösung - Liquidation
Art. 17. Auflösung - Liquidation.
17.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Insolvenzverwaltern
durchgeführt, die nicht Gesellschafter sein müssen und die durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter
bestellt werden, in der die Befugnisse und die Bezahlung der Insolvenzverwalter festlegt sind. Soweit im Beschluss der
Gesellschafter oder gesetzlich nicht anders geregelt, erhalten die Insolvenzverwalter die größtmöglichen Befugnisse gemäß
137270
L
U X E M B O U R G
anwendbarem Recht für die Veräußerung des Betriebsvermögens und Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Jede Abwicklung der Gesellschaft muss gemäß Artikel 7 Abteilung für Abteilung erfolgen.
17.2. Der Überschuss, der durch die Veräußerung des Betriebsvermögens und nach Zahlung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft Abteilung für Abteilung, übrig bleibt, ist unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen ge-
haltenen Geschäftsanteilen an jeder Abteilung zu verteilen.
VII. Allgemeine Bestimmung
Art. 18. Es wird auf die Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes und des Verbriefungsgesetzes vom 22. März 2004 in
Bezug auf alle Angelegenheiten verwiesen, die nicht ausdrücklich in dieser Satzung angeführt werden."
<i>Vierter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt die Erteilung der nötigen Einzelvollmachten an jeden Manager der Gesellschaft
oder Anwalt oder Angestellten von Allen & Overy Luxemburg, um im Auftrag der Gesellschaft, die Eintragung des Rück-
kaufes und der nachfolgenden Annullierung der Rückgekauften Anteile gemäß den oben gefassten Beschlüsse im
Anteilsregister der Gesellschaft einzutragen, und um alle Formalitäten gegenüber dem Handelsregister in Bezug darauf
zu erledigen, sowie die Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
<i>Gebühreni>
Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft
aufgrund der vorliegenden notariellen Urkunde entstehen, belaufen sich ungefähr auf EUR 1.500,.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit klar, dass auf Wunsch der erschienenen
Parteien, das vorliegende Dokument auf Englisch erstellt wurde und dass, auf Wunsch der selben Parteien, auch eine
deutsche Version erstellt worden ist. Falls Unterschiede zwischen dem deutschen und dem englischen Text bestehen,
hat die englische Version Vorrang.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Und nach Verlesung an den Bevollmächtigten des Komparenten hat dieser zusammen mit Uns Notar gegenwärtige
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: S.-N. ARFA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2012. Relation: LAC/2012/54535. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 22. November 2012.
Référence de publication: 2012152444/670.
(120200772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
PEC Brunnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 160.041.
AUSZUG
Berichtigung des am 18. Oktober 2012 im Handels- und Firmenregister Luxemburg
unter der Nummer L-120179269 hinterlegten und im Mémorial veröffentlichten Auszugs
Durch Beschluss vom 28. September 2012 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft den Rücktritt von Frau
Lieve Breugelmans als Geschäftsführerin mit Wirkung vom 24. September 2012 akzeptiert.
Der alleinige Gesellschafter hat dann beschlossen, Herrn Daniel Laurencin, geboren am 8. Oktober 1969 in Bastogne,
Belgien, mit Geschäftsadresse in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, als Geschäftsführer mit sofortiger
Wirkung und für unbestimmte Zeit zu ernennen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für PEC Brunnen S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012152559/18.
(120201234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
137271
L
U X E M B O U R G
PEC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 152.572.
EXTRAIT
Ce dépôt rectifie le dépôt L-120178482 initialement enregistré et déposé auprès du RCS en date du 17 octobre 2012
Par résolutions prises en date du 28 septembre 2012, l'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission
de Madame Lieve Breugelmans en tant que gérant avec effet au 24 septembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PEC Holdings S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012152560/14.
(120201235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
M7 Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 148.073.
M77 Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 157.989.
MERGER PROJECT
The Absorbing Company together with the Absorbed Company being referred to as the "Merging Companies".
In accordance with Article 261 and following and notably Article 278 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on
Commercial Companies, as amended (the "Law"),
(1) the board of directors of M7 Group S.A.; and
(2) the board of directors of M77 Group S.A.;
have together established the following common terms of the merger by absorption of the Absorbed Company by the
Absorbing Company (the "Merger Project") in order to specify the terms and conditions of such merger and declared
that:
- CDS Holdco II B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at 38 Jan
van der Heydenstraat, 1221 EJ HILVERSUM, the Netherlands registered with the Netherlands Chamber of Commerce
under number 32122602, holds one hundred percent (100%) of the shares of the Absorbing Company;
- it is intended that the sole shareholder of the Absorbed Company, being CDS Holdco I B.V., a company incorporated
under the laws of the Netherlands, having its registered office at 38 Jan van der Heydenstraat, 1221 EJ HILVERSUM, the
Netherlands registered with the Netherlands Chamber of Commerce under number 32122601, transfers all the shares
it holds in the share capital of the Absorbed Company to the Absorbing Company in the coming days and in any event
before 31 December 2012 (the "Transfer") in the coming days and in any event before the EGM (as such term is defined
below). As a result of the Transfer, the Absorbing Company shall be the sole shareholder of the Absorbed Company.
- following the implementation of the transfer and in any event before the Effective Date (as such term is defined
below), the Absorbing Company will hold one hundred percent (100%) of the shares of the Absorbed Company;
- the Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Company pursuant to the provisions of articles 278 and
following of the Law which provides for a simplified merger (the "Simplified Merger");
- none of the Merging Companies has been dissolved or declared bankrupt, or has a suspension of payment been
declared;
- the Simplified Merger is motivated by reasons of restructuring and rationalization of the M7 group of companies
relating to the development and the exploitation of digital television line of business and other related products or services
and the setting-up of an appropriate and efficient structure in connection thereof;
- the Merger Project will be registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register and published in the
"Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" (the "Mémorial") in accordance with Articles 262 and 9 of the
Law;
- the Simplified Merger is subject to the condition precedent of (i) its approval by the sole shareholder of both Merging
Companies and (ii) the completion of the Transfer before the EGM.
Thereupon, the following has been agreed:
137272
L
U X E M B O U R G
1. As from 1
st
January 2012, all operations and transactions of the Absorbed Company are considered for accounting
purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.
2. As of the Effective Date, all rights and obligations of the Absorbed Company vis-a-vis third parties shall be taken
over by the Absorbing Company. The Absorbing Company will in particular take over debts as own debts and all payment
obligations of the Absorbed Company. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be
transferred to the Absorbing Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto.
3. The Absorbing Company shall as from the Effective Date carry out all agreements and obligations of whatever kind
of the Absorbed Company such as these agreements and obligations exist on the Effective Date and in particular carry
out all agreements existing with the creditors of the Absorbed Company and shall be subrogated to all rights and obli-
gations resulting from such agreements.
4. All shareholders of the Absorbing Company and of the Absorbed Company have, within one month from the
publication of this Merger Project in the Memorial, access at the registered offices of the Absorbing Company and of the
Absorbed Company to all documents listed in article 267 paragraph (1) a) and b) of the Law as appropriate (i.e. the Merger
Project and the annual accounts of the (i) Absorbing Company for the financial years 2009 and 2010 and (ii) the Absorbed
Company for the financial year 2011) and may obtain copies thereof, free of charge.
5. No particular advantage is granted neither to the members of the board of directors of the Merging Companies nor
to the statutory auditors ("réviseurs d'entreprises agrées").
6. Full discharge is granted to the directors and to the statutory auditors of the Absorbed Company for the exercise
of their mandate.
7. The books and records of the Absorbed Company will be held at the registered office of the Absorbing Company
for the period legally prescribed.
8. The Simplified Merger shall take effect between the Merging Companies on the same day as at the time of the last
extraordinary general meeting of the Merging Companies to be held before a notary approving the Simplified Merger (the
"EGM") as stated in Article 272 of the Law (the "Effective Date").
9. The shareholders of the Merging Companies waive (i) the examination and the report on the Merger Project by
one or more independent expert(s), in application of article 266 (5) of Law, (ii) their right to examine a detailed written
report drawn up by the administrative and management bodies of each of the Merging Companies, in application of article
265 (3) of the Law and (iii) their right to have accounting statements of each of the Merging Companies dated less than
three months preceding the date of the present Merger Project in case the last annual accounts relate to a financial year
which ended more than six months before that date, in application of article 267 (1) subparagraph 2 of the Law.
10. Finally, due to time constraints, the shareholders of the Merging Companies acknowledge that the annual accounts
for the financial year 2011 of the Absorbing Company (the "2011 Annual Accounts") shall be audited within the coming
weeks by PricewaterhouseCoopers and therefore, they agree to waive their right to inspect the 2011 Annual Accounts
at the registered office of the Merging Companies.
11. The Simplified Merger shall become effective towards third parties as at the latest date of (i) the publication in the
Mémorial of the minutes of the EGM of the Absorbing Company approving the Simplified Merger or (ii) the publication
in the Mémorial of the minutes of the EGM of the Absorbed Company approving the Simplified Merger as stated in Article
273 of the Law, on which date notably the transfer of the totality of the assets and liabilities of the Absorbed Company
to the Absorbing Company will intervene by operation of law.
12. According to the terms and conditions of the simplified merger procedure, no new shares will be issued at the
Effective Date. As a result of the Simplified Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its issued shares
shall be cancelled.
The present document is worded in English followed by a French translation.
In case of discrepancies between the English and the French versions, the English version will prevail.
The Merger Project shall be executed in 3 (three) originals.
In Luxembourg on 20 November 2012.
Suit la traduction française du texte qui précède
La Société Absorbante ensemble avec la Société Absorbée étant désignées comme les "Sociétés Fusionnantes".
Conformément aux Articles 261 et suivants et notamment l'Article 268 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la "Loi"),
(1) le conseil d'administration de M7 Group S.A.; et
(2) le conseil d'administration de M77 Group S.A.;
ont ensemble élaboré le projet commun de fusion suivant, par voie d'absorption de la Société Absorbée par la Société
Absorbante (le "Projet de Fusion"), dans le but de préciser les modalités de ladite fusion et ont déclaré que:
- CDS Holdco II B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social sis au 38 Jan van der
Heydenstraat, 1121EJ HILVERSUM, Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous le
numéro 32122602, détient cent pourcent (100%) des actions de la Société Absorbante;
137273
L
U X E M B O U R G
- il est prévu que l'actionnaire unique de la Société Absorbée, étant CDS Holdco I B.V., une société constituée selon
les lois des Pays-Bas, ayant son siège social sis au 38 Jan van der Heydenstraat, 1221EJ HILVERSUM, Pays-Bas, enregistrée
auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 32122601, transfère toutes les actions qu'elle détient
dans le capital social de la Société Absorbée à la Société Absorbante dans les prochaines semaines et en tout état de
cause avant le 31 décembre 2012 (le "Transfert") dans les prochains jours et dans tous les cas avant l'EGM (tel que ce
terme est défini ci-dessous). En conséquence du Transfert, la Société Absorbante sera l'actionnaire unique de la Société
Absorbée.
- suite à la mise en place du Transfert et dans tous les cas avant la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini ci-
dessous), la Société Absorbante détiendra cent pourcent (100%) des actions de la Société Absorbée;
- la Société Absorbante propose d'absorber la Société Absorbée en vertu des dispositions des articles 278 et suivants
de la Loi qui régissent la fusion simplifiée (la "Fusion Simplifiée");
- aucune des Sociétés Fusionnantes n'a été dissoute, déclarée en faillite ou déclarée en état de cessation des paiements;
- la Fusion Simplifiée est motivée par des considérations de restructuration et rationalisation du groupe de société M7
Group S.A. se rapportant au développement et à l'exploitation du secteur d'activité de la diffusion télévisuelle et autres
produits et services associés, ainsi que la mise en place d'une structure appropriée et efficace dans ce cadre;
- le Projet de Fusion sera déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié au "Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" (le "Mémorial") conformément aux Articles 262 et 9 de la Loi;
- la Fusion Simplifiée est soumise à la condition suspensive de (i) son approbation par l'actionnaire unique des deux
Sociétés Fusionnantes et (ii) de la réalisation du Transfert avant l'EGM.
Ainsi, de ce qui précède, il est convenu de ce qui suit:
1. A partir du 1
er
janvier 2012, toutes les opérations et les transactions de la Société Absorbée sont considérées d'un
point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
2. A partir de la Date de Réalisation, tous les droits et obligations de la Société Absorbée vis-à-vis des tiers seront pris
en charge par la Société Absorbante. La Société Absorbante assumera en particulier toutes les dettes comme ses dettes
propres et toutes les obligations de paiement de la Société Absorbée. Les droits et créances compris dans les actifs de
la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante avec l'intégralité des sûretés, soit in rem soit personnelles,
y attachées.
3. La Société Absorbante exécutera à partir de la Date de Réalisation tous les contrats et obligations, de quelle que
nature qu'ils soient, de la Société Absorbée tels que ces contrats et obligations existent à la Date de Réalisation et
exécutera en particulier tous les contrats existants avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée dans tous
les droits et obligations provenant de ces contrats.
4. Tous les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont, pendant un mois à compter de la publi-
cation de ce Projet de Fusion au Mémorial, accès aux sièges sociaux de la Société Absorbante et de la Société Absorbée,
à tous les documents énumérés à l'article 267 paragraphe (1) a), et b) de la Loi le cas échéant (c'est-à-dire le Projet de
Fusion, les comptes annuels de (i) la Société Absorbante pour les exercices sociaux 2009 et 2010 et (ii) la Société Absorbée
pour l'exercice social 2011) et pourront obtenir copies de ceux-ci, sans frais.
5. Aucun droit ou avantage particulier n'a été attribué ni aux membres du conseil d'administration des Sociétés Fu-
sionnantes ni aux réviseurs d'entreprises agréés.
6. Décharge pleine et entière est accordée aux membres du conseil d'administration et aux réviseurs d'entreprises
agréés de la Société Absorbée pour l'exercice de leur mandat.
7. Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant
la période prescrite par la loi.
8. La Fusion Simplifiée prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes le même jour au moment de la dernière assemblée
générale extraordinaire des Sociétés Fusionnantes devant se tenir devant un notaire pour approuver la Fusion Simplifiée
(l'"AGE") ainsi qu'il résulte de l'Article 272 de la Loi (la "Date de Réalisation").
9. Les associés des Sociétés fusionnantes renoncent (i) à l'examen et au rapport effectué sur le Projet de Fusion par
un ou plusieurs experts indépendant(s) en application de l'article 266 (5) de la Loi, (ii) à leur droit d'examiner un rapport
détaillé rédigé par les organes d'administration et de direction de chacune des Sociétés Fusionnantes, en application de
l'article 265 (3) de la Loi et (iii) à leur droit d'inspecter l'état comptable de chacune des Sociétés Fusionnantes datant de
moins de trois mois avant la date du présent Projet de Fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un
exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date, en application de l'article 267 (1) alinéa 2 de la Loi.
10. Enfin, en raison de contraintes de temps, les associés des Sociétés Fusionnantes reconnaissent que les comptes
annuels pour l'exercice social de 2011 de la Société Absorbante (les "Comptes Annuels de 2011") seront audités par
PricewaterhouseCoopers dans les semaines à venir et par conséquent, ils renoncent à leur droit d'inspecter les Comptes
Annuels de 2011 au siège social des Sociétés Fusionnantes.
11. La Fusion Simplifiée sera effective vis-à-vis des tiers à la date d'occurrence en dernier lieu de l'un des événements
suivants (i) la publication au Mémorial du procès-verbal de l'AGE de la Société Absorbante approuvant la Fusion Simplifiée
ou (ii) la publication au Mémorial du procès-verbal de PAGE de la Société Absorbée approuvant la Fusion Simplifiée ainsi
137274
L
U X E M B O U R G
qu'il résulte de l'Article 273 de la Loi, date à laquelle le transfert de la totalité des actifs et passifs de la Société Absorbée
à la Société Absorbante interviendra de plein droit.
12. Conformément aux dispositions et conditions de la procédure de fusion simplifiée, il ne sera pas émis de nouvelles
actions à la Date de Réalisation. Par effet de la Fusion Simplifiée, la Société Absorbée cessera d'exister de plein droit et
ses actions émises annulées.
Le présent document est établi en anglais suivi d'une traduction en français.
En cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Le Projet de Fusion est signé en 3 (trois) originaux.
A Luxembourg le 20 Novembre 2012.
M7 Group S.A.
Jon Florsheim / Dirk Haesaert
<i>Director / Director
i>M77 Group S.A.
Jaromir Glisnik / Thibaut Hausman
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2012151135/173.
(120199278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Outlet Mall Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 719.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 95.977.
Austria Outlet Mall Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 300.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 96.433.
MERGER PROJECT
1. Outlet Mall Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg) under number B 95.977 and with an issued share capital of EUR 719,000 (seven hundred nineteen thousand
Euros) (the "Absorbing Company");
and
2. Austria Outlet Mall Holding SARL, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg) under number B 96.433 and with an issued share capital of EUR 300,000 (three hundred thousand Euros)
(the "Absorbed Company", together with the Absorbing Company referred to as the "Merging Companies");
In accordance with Article 261 and following of the Luxembourg law of 10 August 1915 on Commercial Companies,
as amended (the "Law"),
(1) the board of directors of Outlet Mall Holding S.à r.l; and
(2) the board of directors of Austria Outlet Mall Holding SARL;
have together established the following common terms of the merger by absorption of the Absorbed Company by the
Absorbing Company (the "Merger Project") in order to specify the terms and conditions of such merger and declared
that:
- the Absorbing Company holds one hundred per-cent (100%) of the shares of the Absorbed Company;
- the Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Company pursuant to the provisions of articles 278 and
following of the Law which provides for a simplified merger (the "Simplified Merger"):
- none of the Merging Companies has been dissolved or declared bankrupt, or has a suspension of payment been
declared;
- the Absorbed Company will have no employee as at the Effective Date (as defined below);
- the Simplified Merger is motivated by reasons of simplification and rationalization of the fund structure of the Outlet
Mall group of companies;
137275
L
U X E M B O U R G
- the Merger Project will be registered with the Luxembourg Trade and Companies Register and published in the
"Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" (the "Memorial") in accordance with Articles 262 and 9 of the
Law;
- the Simplified Merger is subject to the condition precedent of its approval by the sole shareholder of the Absorbing
Company;
- the Simplified Merger is subject to the condition precedent of its approval by the sole shareholder of the Absorbed
Company;
- the Simplified Merger is subject to the condition precedent of the consent of Deutsche Pfandbriefbank AG (formerly
Hypo Real Estate Bank International), in its capacity of pledgee over the shares of the Absorbed Company pursuant to a
pledge agreement dated 20 September 2004;
Thereupon, the following has been agreed:
1. As from 31 March 2012, all operations and transactions of the Absorbed Company are considered for accounting
purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.
2. As of the Effective Date, all rights and obligations of the Absorbed Company vis-à-vis third parties shall be taken
over by the Absorbing Company. The Absorbing Company will in particular take over debts as own debts and all payment
obligations of the Absorbed Company. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be
transferred to the Absorbing Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto.
3. The Absorbing Company shall as from the Effective Date (as defined below) carry out all agreements and obligations
of whatever kind of the Absorbed Company such as these agreements and obligations exist on the Effective Date and in
particular carry out all agreements existing with the creditors of the Absorbed Company and shall be subrogated to all
rights and obligations resulting from such agreements.
4. The shareholders of the Absorbing Company and of the Absorbed Company have, at least one month before the
date of the holding of the extraordinary general meetings of the Merging Companies to be held before a notary approving
the Simplified Merger (the "EGM"), access at the registered offices of the Absorbing Company and of the Absorbed
Company to all documents listed in article 267 paragraph (1) of the Law and may obtain copies thereof, free of charge.
5. No particular advantage is granted to the members of the board of directors of the Merging Companies.
6. Full discharge is granted to the directors of the Absorbed Company for the exercise of their mandate.
7. The books and records of the Absorbed Company will be held at the registered office of the Absorbing Company
for the period legally prescribed.
8. The Simplified Merger shall take effect between the Merging Companies as at the date of the latest EGM as stated
in Article 272 of the Law.
9. The Simplified Merger shall become effective towards third parties as at the latest date of (i) the publication in the
Memorial of the minutes of the EGM of the Absorbing Company approving the Simplified Merger or (ii) the publication
in the Memorial of the minutes of the EGM of the Absorbed Company approving the Simplified Merger as stated in Article
273 of the Law (the "Effective Date"), on which date notably the transfer of the totality of the assets and liabilities of the
Absorbed Company to the Absorbing Company will intervene by operation of law.
10. According to the terms and conditions of the simplified merger procedure, no new shares will be issued at the
Effective Date. As a result of the Simplified Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its issued shares
shall be cancelled.
The present document is worded in English followed by a French translation.
In case of discrepancies between the English and the French versions, the English version will prevail.
The Merger Project shall be executed in 3 (three) originals.
In Luxembourg on 20 November 2012.
Suit la version française du texte qui précède
1. Outlet Mall Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son
siège social à 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.977 et dont le capital social s'élève à EUR 719,000 (sept cent
dix-neuf mille Euros) (la "Société Absorbante");
et
2. Austria Outlet Mall Holding SARL, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Luxembourg, ayant
son siège social à 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.433 et dont le capital social s'élève à EUR 300,000 (trois
cent mille Euros) (la "Société Absorbée", ensemble avec la Société Absorbante désignées comme les "Sociétés Fusion-
nantes");
Conformément aux Articles 261 et suivants de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, (la "Loi"),
(1) le conseil d'administration de Outlet Mall Holding S.à r.l.; et
137276
L
U X E M B O U R G
(2) le conseil d'administration de Austria Outlet Mall Holding SARL;
ont ensemble élaboré le projet commun de fusion suivant, par voie d'absorption de la Société Absorbée par la Société
Absorbante (le "Projet de Fusion"), dans le but de préciser les modalités de ladite fusion et ont déclaré que:
- la Société Absorbante détient cent pourcents (100%) des parts de la Société Absorbée;
- la Société Absorbante propose d'absorber la Société Absorbée en vertu des dispositions des articles 278 et suivants
de la Loi qui régissent la fusion simplifiée (la "Fusion Simplifiée");
- aucune des Sociétés Fusionnantes n'a été dissoute, déclarée en faillite ou déclarée en état de cessation des paiements;
- la Société Absorbée n'aura aucun employé à la Date de Réalisation (telle que définie ci-après);
- la Fusion Simplifiée est motivée par des considérations de restructuration et de rationalisation de la structure de
financement du groupe de sociétés Outlet Mall;
- le Projet de Fusion sera déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié au "Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" (le "Mémorial") conformément aux Articles 262 et 9 de la Loi;
- la Fusion Simplifiée est soumise à la condition suspensive de son approbation par la Société Absorbante;
- la Fusion Simplifiée est soumise à la condition suspensive de son approbation par la Société Absorbée;
- la Fusion Simplifiée est soumise à la condition suspensive du consentement de la Deutsche Pfandbriefbank AG (an-
ciennement Hypo Real Estate Bank International), en sa qualité de créancier gagiste sur les parts de la Société Absorbée
en vertu d'un contrat de gage en date du 20 Septembre 2004.
Ainsi, de ce qui précède, il est convenu de ce qui suit:
1. A partir du 31 mars 2012, toutes les opérations et les transactions de la Société Absorbée sont considérées d'un
point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
2. A partir de la Date de Réalisation, tous les droits et obligations de la Société Absorbée vis-à-vis des tiers seront pris
en charge par la Société Absorbante. La Société Absorbante assumera en particulier toutes les dettes comme ses dettes
propres et toutes les obligations de paiement de la Société Absorbée. Les droits et créances compris dans les actifs de
la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante avec l'intégralité des sûretés, soit in rem soit personnelles,
y attachées.
3. La Société Absorbante exécutera à partir de la Date de Réalisation tous les contrats et obligations, de quelle que
nature qu'ils soient, de la Société Absorbée tels que ces contrats et obligations existent à la Date de Réalisation et
exécutera en particulier tous les contrats existants avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée dans tous
les droits et obligations provenant de ces contrats.
4. Les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont, au moins un mois avant la date de la tenue de
l'assemblée générale extraordinaire des Sociétés Fusionnantes devant se tenir devant un notaire pour approuver la Fusion
Simplifiée ("AGE"), accès aux sièges sociaux de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, à tous les documents
énumérés à l'article 267 paragraphe (1) de la Loi et pourront obtenir copies de ceux-ci, sans frais.
5. Aucun avantage particulier n'a été attribué aux membres du conseil d'administration des Sociétés Fusionnantes.
6. Décharge pleine et entière est accordée aux membres du conseil d'administration de la Société Absorbée pour
l'exercice de leur mandat.
7. Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant
la période prescrite par la loi.
8. La Fusion Simplifiée prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes à la date de la dernière AGE ainsi qu'il résulte de
l'Article 272 de la Loi.
9. La Fusion Simplifiée sera effective vis-à-vis des tiers à la date d'occurrence en dernier lieu de l'un des événements
suivants (i) la publication au Mémorial du procès-verbal de l'AGE de la Société Absorbante approuvant la Fusion Simplifiée
ou (ii) la publication au Mémorial du procès-verbal de l'AGE de la Société Absorbée approuvant la Fusion Simplifiée ainsi
qu'il résulte de l'Article 273 de la Loi (la "Date de Réalisation"), date à laquelle le transfert de la totalité des actifs et passifs
de la Société Absorbée à la Société Absorbante interviendra de plein droit.
10. Conformément aux dispositions et conditions de la procédure de fusion simplifiée, il ne sera pas émis de nouvelles
parts à la Date de Réalisation. Par effet de la Fusion Simplifiée, la Société Absorbée cessera d'exister de plein droit et ses
parts émises seront annulées.
Le présent document est établi en anglais suivi d'une traduction en français.
En cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Le Projet de Fusion est établi en 3 (trois) exemplaires.
A Luxembourg le 20 novembre 2012.
Outlet Mall Holding S.à r.l. / Austria Outlet Mall Holding SARL
John Sutherland / John Sutherland
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2012151895/151.
(120199941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
137277
L
U X E M B O U R G
CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.331.
EXTRAIT
Ce dépôt rectifie le dépôt L-120178481 initialement enregistré et déposé auprès du RCS en date du 17 octobre 2012
Par résolutions prises en date du 28 septembre 2012 l'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission
de Madame Lieve Breugelmans en tant que gérant avec effet au 24 septembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012152230/14.
(120201236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
PEC Moenchhof S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 163.579.
<i>Berichtigender Auszugi>
Berichtigung des am 17. Oktober 2012 im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer L-120178479
ersten hinterlegten und im Mémorial veröffentlichten Auszugs, der durch einen am 18. Oktober 2012 im Handels- und
Firmenregister Luxemburg unter der Nummer L-120179268 hinterlegten und im Mémorial veröffentlichten Auszugs
abgeändert wurde
Durch Beschluss vom 28. September 2012 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft den Rücktritt von Frau
Lieve Breugelmans als Geschäftsführerin mit Wirkung vom 24. September 2012 akzeptiert.
Der alleinige Gesellschafter hat dann beschlossen, Herrn Daniel Laurencin, geboren am 8. Oktober 1969 in Bastogne,
Belgien, mit Geschäftsadresse in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, als Geschäftsführer mit sofortiger
Wirkung und für unbestimmte Zeit zu ernennen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für PEC Moenchhof S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012152561/20.
(120201453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
Parfinlux S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 48.619.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141046/9.
(120186193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Parador Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5441 Remerschen, 10A, Wisswee.
R.C.S. Luxembourg B 89.669.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schwebsange, den 25.10.2012.
.
Référence de publication: 2012141045/10.
(120185701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
137278
L
U X E M B O U R G
Parts Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 88.712.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Référence de publication: 2012141048/10.
(120186288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
MCP III Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 154.543.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 30 août 2012, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 28 septembre 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012140985/13.
(120185749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
ReGEN Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 77.631.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141076/9.
(120185942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Q & A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7225 Bereldange, 38, rue de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 122.088.
Les comptes annuels au 31.03.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141066/9.
(120186034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Q & A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7225 Bereldange, 38, rue de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 122.088.
Les comptes annuels au 31.03.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141065/9.
(120186033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Puma Rex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 162.616.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
137279
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141062/9.
(120185886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Continental Investments and Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 34.032.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141442/9.
(120186967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
CEA Investments Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 126.259.
Les comptes annuels au 31 janvier 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141426/9.
(120186823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Depuration Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 124.329.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141483/9.
(120186598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Cusanus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 73.487.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141463/9.
(120186671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
DS Smith (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 93.199.
Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141492/9.
(120186517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
137280
aeris CAPITAL Liquid Funds
Austria Outlet Mall Holding Sàrl
Brianfid-Lux S.A.
BZ Equity Fund
CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l.
CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l.
CEA Investments Limited
Continental Investments and Management S.A.
Cusanus S.A.
Depuration Management S.A.
DS Smith (Luxembourg) S.à r.l.
Eastman Chemical Luxembourg Holdings 1 S.à r.l.
F&C Fund
FDR Gestion
Flossbach von Storch SICAV
IK Group s.àr.l.
KBC Bonds
Kenross Lux S.àr.l.
LDF65 S.à r.l.
M77 Group S.A.
M7 Group S.A.
Maxiweb S.A.
MCP III Investment S.à r.l.
MI-FONDS (Lux)
MVM Lux Sicav
Outlet Mall Holding Sàrl
Parador Real Estate S.A.
Parfinlux S.A. SPF
Parts Invest S.A.
PEC Brunnen S.à r.l.
PEC Holdings S.à r.l.
PEC Moenchhof S.à r.l.
PE-Invest SICAV
Puma Rex S.A.
Q & A S.à r.l.
Q & A S.à r.l.
ReGEN Sàrl
SEB Absolute
Sessions Finances Investments S.A.
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV
Utopia S.A.