This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2748
13 novembre 2012
SOMMAIRE
BlueBay Direct Lending I Investment
Green (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . .
131869
Café o Negrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131875
EKIAM S. à r. l. & Cie. KL.Z. Zweite S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131887
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.M. Erste S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131890
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.M. Zweite S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131891
IKAV Renewable S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
131876
Industry Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
131890
INNCONA S.à.r.l. & Cie Quatre cent qua-
tre-vingt-sixième (486.) . . . . . . . . . . . . . . . .
131892
Insurance Broker's Solution Europe . . . . .
131887
International Company for Developments
and Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131893
Interparfums S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131891
Jattis 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131892
Jattis 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131895
Jattis 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131898
Jattis 4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131898
Jolimon Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
131895
Karat S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131898
Kunert Beteiligung S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
131899
LMA German Investments . . . . . . . . . . . . . .
131890
LMB German Investments . . . . . . . . . . . . . .
131899
LMC German Investments . . . . . . . . . . . . . .
131900
LMD German Investments . . . . . . . . . . . . . .
131891
Luxembourg Designs S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
131900
McKesson China Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
131900
McKesson Information Solutions Tophol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131901
McKesson International Holdings IV S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131901
McKesson International Holdings VII S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131902
McKesson International Holdings V S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131902
McKey Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . .
131901
McKey Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
131902
Mediclinic Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
131903
Min Invest S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131902
Minmetals Exploration & Development
(Luxembourg) Limited S.à r.l. . . . . . . . . . .
131903
Mithris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131903
Munster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131894
Natural Resources Development Corp
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131904
Natural Resources Development Corp
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131904
Natural Resources Development Corp
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131904
Nile Capital II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131904
Nomura Bank (Luxembourg) S.A. . . . . . . .
131901
PeeBeeLux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131898
Pradera Central Militari S.à r.l. . . . . . . . . . .
131887
Pradera Southern Holdco S.à r.l. . . . . . . . .
131895
Real Impact Analytics S.A. . . . . . . . . . . . . . .
131877
Regio Office Center (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131899
Sefo Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131901
Tschingel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131902
VCG Lease S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131858
Whitehall European RE 4 S.à r.l. . . . . . . . . .
131892
WI-BA-Metall S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131900
Ziksana Development Group S.à r.l. . . . . .
131903
131857
L
U X E M B O U R G
VCG Lease S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 172.544.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the fifth day of November.
Before Me Jean-Paul MEYERS, notary, residing at Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
VCG Lease Stichting, a foundation organised under the laws of The Netherlands with its official seat in Amsterdam,
and its address at Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands;
represented by Mr Serge Bernard, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Amsterdam on
October 29
th
, 2012; such proxy, signed by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation").
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of "VCG Lease S.à r.l.".
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the Manager
(s).
Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the Company is the financing, leasing and remarketing of a Boeing, model 747-8F aircraft,
MSN 35812 (the "Aircraft") and to undertake or procure to undertake any such other actions, matters or things as may
be necessary to achieve, or which are incidental or conductive to, any of the above purposes.
In order to accomplish its purpose, the Company may acquire, lease and sell the Aircraft and finance such acquisition
through loans or other financial arrangements, in whatever form, and issue guarantees and grant any form of security
interest or other liens over its assets, including mortgages and pledges, to secure the financing obligations entered into
by the Company or by Cargolux Airlines International S.A. with respect to the acquisition, financing or leasing of the
Aircraft.
The Company may further issue guarantees, and grant any form of security interest or other liens over its assets,
including mortgages and pledges, to secure any indebtedness now or hereafter and directly or indirectly owing to Export-
Import Bank of the United States ("Ex-Im Bank") or to any agent or trustee acting for Ex-Im Bank or to any person or
entity who is the beneficiary, directly or indirectly, of any past, present or future guarantee by Ex-Im Bank (but only to
the extent such indebtedness, if not owed to Ex-Im Bank, is guaranteed by Ex-Im Bank), from any of (i) Cargolux Airlines
International S.A.; (ii) any affiliate of Cargolux Airlines International S.A.; (iii) any special purpose company arranged in
part by Cargolux Airlines International S.A.; or (iv) any other person or entity to the extent that Cargolux Airlines
International S.A., any affiliate thereof or any such special purpose company is obligated to pay or reimburse such other
person or entity for such indebtedness or has agreed to guarantee such indebtedness.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set
by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twenty-five thousand United States Dollars (USD
25,000.-) divided into two thousand five hundred (2,500) shares with a nominal value of ten United States Dollars (USD
10.-) each, all of which are fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
131858
L
U X E M B O U R G
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
but the shares may be transferred to nonshareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.
Chapter III. - Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the "Manager(s)").
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for reappointment and may be removed at any time but only for cause by a resolution
of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or
class B Managers (the "Class B Managers").
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary
or useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) or the Board of Managers (if more
than two Managers have been appointed) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or
temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint
signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to
whom special power has been delegated by the Manager(s), or the Board of Managers (if more than two Managers have
been appointed), but only within the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the "Secretary").
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any of its members so requires.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days’
written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
131859
L
U X E M B O U R G
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
All meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence of all Managers.
Decisions will be taken by the unanimous consent of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
In cases of urgency, one or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any
other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be
signed by the sole Manager or by two (2) Managers (including one Class A and one Class B Manager if the Managers have
been qualified Class A Managers and Class B Managers) acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the
pursuit of the Company’s corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Managers’ Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if
applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been Manager(s), officer or employee of the Company. The foregoing also applies if, at the request of the Company, he
incurs expenses for any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and by which he is not
entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or
proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided
only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel
that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be
entitled.
Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an approved independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including
more in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more
statutory auditors who need not be shareholders themselves.
131860
L
U X E M B O U R G
The statutory or approved independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine
the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved
independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.
Chapter IV. - Shareholders
Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to
the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general
meeting of shareholders.
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held in case the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the 10 May at 10 a.m. at the registered office of
the Company.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on
the next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five
(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as designated by the Manager(s).
Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in
a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated
by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of
amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, resolutions shall be
adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting
(or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be
adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for
the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be a
majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
131861
L
U X E M B O U R G
Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
two (2) Managers (including one Class A and one Class B Manager if the Managers have been qualified Class A Managers
and Class B Managers) acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. - Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twentyfive (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the sole shareholder or, as the
case may be, the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. Applicable law
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholder
subscribed
capital
number
of sha-
res
amount
paid-in
VCG Lease Stichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25,000.-
2,500 USD 25,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25,000.-
2,500 USD 25,000.-
The amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-) was thus as from that moment at the disposal
of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions
provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately 1.100 EUR.
131862
L
U X E M B O U R G
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of December of 2012.
<i>Shareholders resolutionsi>
<i>First Resolutioni>
The sole shareholder resolved to establish the registered office at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of Manager(s) and further resolved to appoint Mr Claude
Crauser, residing professionally at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, as manager;
<i>Third Resolutioni>
The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of approved independent auditors and further resolved
to appoint the following for a period ending at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts
of the financial year ending on 31 December 2017: Grant Thornton Lux Audit S.A., a société anonyme incorporated under
the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 83, Pafebruch, L-8308 Capellen and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B43.298.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present
deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, am fünfen November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Paul MEYERS, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
VCG Lease Stichting, eine Stiftung niederländischen Rechts mit Geschäftssitz in Amsterdam und mit Adresse in Stra-
winskylaan 411, 1077 XX Amsterdam,
vertreten durch Herrn Serge Bernard, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, kraft der am 29. Oktober 2012 in Amsterdam
erteilten Vollmacht;
die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wur-
de, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.
Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:
Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft") gegründet, die
den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen") und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die
„Satzung") unterliegt.
Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren
Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.
Die Gesellschaft wird unter dem Namen „VCG Lease S.à r.l." firmieren.
Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Stadt Luxemburg haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der
Stadt Luxemburg verlegt werden.
Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) im
Großherzogtum Luxemburg gegründet werden.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft ist die Finanzierung, das Leasing und Weitervermarktung eines
Flugzeugs, Typ Boeing, Model 747-8 MSN 35812 (das „Flugzeug") und solche Maßnahmen, Aufgaben oder Dinge durch-
zuführen oder herbeizuführen, die notwendig sind, um einen der genannten Zwecke zu erreichen oder zu fördern.
Um ihren Zweck zu erreichen kann die Gesellschaft das Flugzeug kaufen, leasen und verkaufen und diesen Erwerb
durch Darlehen oder andere Finanzierungsgeschäfte jeglicher Art finanzieren und Garantien und andere Sicherheiten oder
Gläubigerrechte, einschließlich Hypotheken und Pfandrechte, über ihre Güter gewähren, um die Finanzierungsverbind-
131863
L
U X E M B O U R G
lichkeiten die von der Gesellschaft oder von Cargolux Airlines International S.A. zum Erwerb, der Finanzierung oder dem
Leasing des Flugzeuges eingegangen wurden, abzusichern.
Die Gesellschaft kann außerdem Garantien gewähren und jede Art von Sicherheiten oder Gläubigerrechten, ein-
schließlich Hypotheken und Pfandrechte, über ihre Güter gewähren, um die Finanzierungsverbindlichkeiten, abzusichern,
die jetzt oder später und direkt oder indirekt gegenüber Export-Import Bank of the United States („Ex-Im Bank") oder
einem Vertreter oder Treuhänder, der für Ex-Im Bank handelt oder einer anderen Person oder Gesellschaft, die direkt
oder indirekt Begünstigte von einer vergangenen, gegenwärtigen oder zuküftigen Garantie von Ex-Im Bank ist (aber nur
soweit die Finanzierungsverbindlichkeit, wenn sie nicht Ex-Im Bank geschuldet ist, von Ex-Im Bank besichert wird) be-
stehen, durch jeden von (i) Cargolux Airlines International S.A; (ii) einer Tochtergesellschaft von Cargolux Airlines
International S.A.; (iii) einer Zweckgesellschaft, die zumindest teilweise von Cargolux Airlines International S.A. arrangiert
wurde; oder (iv) jeder anderen Person oder Gesellschaft soweit Cargolux Airlines International S.A., eine ihrer Toch-
tergesellschaften oder eine solche Zweckgesellschaft dieser anderen Person oder Gesellschaft gegenüber zur Zahlung
oder Erstattung dieser Finanzierungsverbindlichkeiten verpflichtet ist oder diese garantiert hat.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter(s), der in Übereinstimmung mit dem
nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.
Kapitel II. - Kapital, Anteile
Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend
US-Dollar (USD 25.000,-), und ist in zweitausendfünfhundert (2.500) Anteile mit einem Nennwert von je zehn US-Dollar
(USD 10,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und
Pflichten ausgestattet.
Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissions-
aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten, zur Auszahlung an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.
Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile
können nur dann an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.
Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.
Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft und Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser ange-
nommen worden ist.
Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-
fenen Beschlüsse mit sich.
Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-
sellschafter(s), der mit Anwesenheits-und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit, der Konkurs
oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der
Gesellschaft zur Folge.
Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer
Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschaf-
ter sein müssen, geführt (die (der) „Geschäftsführer").
Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat")
gegründet.
Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats
festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, aber nur aus gutem Grund,
durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.
131864
L
U X E M B O U R G
Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)
„Geschäftsführer A")) oder als Geschäftsführer B (die (der) „Geschäftsführer B")) zu qualifizieren.
Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.
Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,
um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-
prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).
Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer oder der Geschäfts-
führungsrat (wenn mehr als zwei Geschäftsführer ernannt wurden) können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten
an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder
zeitweiligen Funktionen ausstatten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers wenn mehr als
ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, gebunden.
Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben
(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen
gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) oder dem Geschäftsführungsrat (wenn mehr
als zwei Geschäftsführer ernannt wurden) übertragen worden ist, jedoch nicht über die Grenzen dieser speziellen Voll-
macht hinaus.
Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende
Regeln:
Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende"). Er kann auch einen
Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzung der
Geschäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer").
Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-
rungsrates muss einberufen werden, wenn eines seiner Mitglieder dies verlangt.
Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit
des Geschäftsführungsrates ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des
Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungs-
gemäß dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort
in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrich-
tigung erforderlich.
Alle Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg statt.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-
schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt.
Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit aller seiner amtierenden Mitglieder.
Entschlüsse werden per Einstimmigkeitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des
Geschäftsführungsrates gefasst.
In dringenden Fällen können ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates durch eine Telefonkonferenz-
schaltung oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen,
teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.
Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.
Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.
Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß
einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann
festgehalten werden in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-
weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer (d.h. einem
Geschäftsführer A und einem Geschäftsführer B, wenn die Geschäftsführer als Geschäftsführer A und Geschäftsführer B
qualifiziert worden sind) gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.
131865
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die
(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.
Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem
Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäfts-
führern anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.
Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-
schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.
Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Markt-
bedingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.
Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder
irgend einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder einem solchen
Unternehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmen sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit
einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte
tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu
handeln.
Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung
hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.
Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-
lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.
Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-
schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, kann,
und in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, muss, das Geschäft der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, ein-
schließlich der Bücher und Konten durch statutorische Wirtschaftsprüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
geprüft.
Die zugelassenen statutorischen oder unabhängigen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den)
Gesellschafter ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederer-
nannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen
werden außer in Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der unabhängige Wirtschaftsprüfer nur aus guten Gründen
oder einvernehmlich abberufen werden kann.
Kapitel IV. - Gesellschafter
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz
zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.
Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.
Art. 19 Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden
muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am 10. Mai um 10 Uhr am Gesell-
schaftsitz der Gesellschaft abgehalten.
Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-
genden Werktag abgehalten.
Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-
zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den
Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn
131866
L
U X E M B O U R G
(15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie
der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Be-
stimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.
Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-
halten oder an jedem anderen von den Geschäftsführern bestimmten Ort im Großherzogtum Luxemburg.
Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die
Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-
schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.
Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über
die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.
Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-
und Rederecht.
Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes
Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.
Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu
von den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.
Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafter-
versammlung anwesend sind, gewählt wird.
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-
lung.
Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von
Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, werden
Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren. Wenn eine
solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Beschlussfassung
erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden dann unabhängig
von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der
Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen werden, ist das Quorum die Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter,
die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-
zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.
Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter
unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls
der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer (d.h. einem Geschäftsführer A und einem Geschäftsführer B, wenn
die Geschäftsführer als Geschäftsführer A und Geschäftsführer B qualifiziert worden sind) gemeinsam, wenn mehr als ein
Geschäftsführer ernannt worden ist, unterzeichnet werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von Gewinnen
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Tag des
Monats Dezember eines jeden Jahres.
Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die
Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung.
Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
131867
L
U X E M B O U R G
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr
als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.
Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der
gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage"). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmt die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn
verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr
vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Akti-
onäre ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.
Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation
Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der Gesellschafter, oder gegebenenfalls
des alleinigen Gesellschafters, aufgelöst werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei
viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-
liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.
Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-
quidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Aktionäre so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.
Kapitel VII. - Geltendes Recht
Art. 30. Geltendes Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen
sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt
geltenden Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert und gege-
benenfalls das Emmissionsaufgeld zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:
Gesellschafter
gezeichnetes
Kapital
Anzahl
der
Anteile
eingezahlter
Betrag
VCG Lease Stichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25.000,-
2.500 USD 25.000,-
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25.000,-
2.500 USD 25.000,-
Die Summe von fünfundzwanzigtausend US-Dollar (USD 25.000,-) stand der Gesellschaft daher von diesem Moment
an zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Voraus-
setzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden
Fassung, gewahrt wurden.
<i>Kosteni>
Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.100,geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2012.
<i>Gesellschafterbeschlüssei>
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleingesellschafter hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleingesellschafter hat beschlossen die Anzahl der Geschäftsführer auf einen (1) festzulegen und Herrn Claude
Crauser, geschäftlich ansässig in 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg auf unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer
zu ernennen.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleingesellschafter hat die Anzahl von zugelassenen Wirtschaftsprüfern auf einen (1) festgelegt und die folgenden
Person werden bis zur Gesellschafterversammlung, die über die Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres,
131868
L
U X E M B O U R G
das am 31 Dezember 2017 endet, als zugelassener Wirtschaftsprüfer ernannt: Grant Thornton Lux Audit S.A., eine
Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in 83, Pafebruch, L-8308 Capellen und eingetragen beim Handels-und
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B43.298.
Der unterzeichnende Notar, der Englischen spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten
Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.
Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg
aufgenommen wurde.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-
nenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: Bernard, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 07 novembre 2012. Relation: RED/2012/1464. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
[Authentifizierte elektronische Unterschrift bei der Übermittelung an das Handelsregister.]
<i>Le Receveuri>
(signé): Kirsch.
AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, ausgedruckt auf Normalpapier zwecks Eintragung beim
Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, den 07. November 2012.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2012146029/621.
(120192122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
BlueBay Direct Lending I Investment Green (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 172.532.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of October.
Before Us Maître Henri HELLINCKX notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
"BlueBay Direct Lending I Investments (Luxembourg) S.à r.l.", a Luxembourg société à responsabilité limitée organized
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 168.670
and having a share capital of EUR 12,500.-;
duly represented by Mrs. Jennyfer Nündel, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (the "Company"), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the
"Law"), as well as by the present articles of incorporation (the "Articles"), which specify in articles 7, 10, 11 and 14 the
exceptional rules applying to a single shareholder company.
Art. 2. The object of the Company is to invest in a portfolio of securities and loans of a restricted circle of borrowers
or other financial instruments, and to invest into bonds, debentures, funds, notes, equity and other debt instruments or
securities, trade receivables or other forms of claims, obligations (including but not limited to synthetic securities / obli-
gations), to acquire rights or participations in loans and in financial derivatives agreements or instruments, to enter into
any agreements relating to such portfolio and to administrate, develop and manage such portfolio.
The Company may also raise funds through, including, but not limited to, the issue of certificates, bonds, notes, obli-
gations and other debt instruments or debt securities, the use of financial derivatives or otherwise and obtain loans or
any other form of credit facility.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment
or development of its purpose remaining always however within the limits established by the Law.
131869
L
U X E M B O U R G
The Company may also invest in bilateral loans and sub-participations with a restricted circle of borrowers.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name "BlueBay Direct Lending I Investment Green (Luxembourg) S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1) each. Each share is entitled to one vote in ordinary
and extraordinary general meetings.
The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid
on any share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the manager
(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the
general meeting of the shareholders of the Company, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law only.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders, in case of plurality of shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders.
The manager(s) may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of any one manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex,
facsimile or email another manager as his proxy, provided that the represented manager does not direct his proxy how
to vote. A manager may represent more than one of his colleagues.
If several managers have been appointed, any manager may participate in any meeting of the board of managers by
conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the
meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting.
The board of managers may, unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes
giving the evidence of the resolution.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders.
131870
L
U X E M B O U R G
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Save a higher majority
as provided herein, collective decisions are only valid taken insofar as they are adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.
The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Resolutions
to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the
Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of
plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
The manager(s) as appropriate may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial
year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial
year, increased by carried forward profits, share premium and other distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and
that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant
shareholder(s).
Any share premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the pro-
visions of the Luxembourg law and these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-
first December 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
Twelve thousand five hundred (12,500) shares have been entirely subscribed by "BlueBay Direct Lending I Investments
(Luxembourg) S.à r.l.", prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately Euro (EUR 1,200.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr. William Jones, residing at 137, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Henry Kelly, residing at 4, rue Jean-Pierre Lanter, L-5943 Itzig, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Terrence Farrelly, residing professionally at 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the sole signature of any one manager.
2) The registered office of the Company is fixed at 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg.
131871
L
U X E M B O U R G
3) Deloitte Audit, a Luxembourg public limited company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B67895 has been appointed as auditor of the Company.
The term of office of the auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts of the first accounting
year which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first December
2013 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may determine.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
«BlueBay Direct Lending I Investments (Luxembourg) S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.670, et dont le capital social
s'élève à EUR 12.500,-,
ici représentée par Madame Jennyfer Nündel, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui délivrée.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire
instrumentant, annexée aux présents pour être soumise avec les présents à la formalité de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte
d'une société à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après, la «Société»), et en particulier par la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts de la Société (les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles
exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. L'objet de la Société est d'investir dans un portefeuille comprenant des titres et des prêts d'un cercle restreint
d'emprunteurs ou d'autres instruments financiers, et d'investir dans des obligations, des fonds, des effets, des actions et
d'autres titres de créance ou valeurs mobilières, des créances commerciales ou d'autres formes de créances, des obli-
gations (notamment sans que ceci soit limitatif, instruments synthétiques/des obligations), d'acquérir des droits ou des
participations dans des prêts ou contrats sur des produits dérivés ou autres instruments, de conclure tout contrat relatif
au portefeuille en question et d'administrer, développer et gérer ledit portefeuille.
La Société peut également lever des fonds, notamment en émettant des certificats, des obligations, des effets, et autres
titres de créance, utiliser des instruments financiers dérivés ou autres et obtenir des prêts ou toute autre forme de moyen
de crédit.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut mettre en oeuvre toutes mesures et exécuter toutes opérations qu'elle estime nécessaires à l'accom-
plissement ou au développement de son objet, le tout en restant dans les limites imposées par la Loi.
La Société peut également investir dans des prêts bilatéraux et des sous-participations impliquant un cercle restreint
d'emprunteurs.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination «BlueBay Direct Lending I Investment Green (Luxembourg) S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut faire l'objet d'un transfert au sein de la commune par simple décision du gérant, ou en
cas de pluralité des gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
131872
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix
aux assemblées générales ordinaires et assemblées générales extraordinaires.
La Société peut créer un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute part sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par le(s) gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par décision de
l'assemblée générale des associés de la Société, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre de parts sociales existantes.
Art. 9. Vis-à-vis de la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est
admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente à l'égard de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont
transmissibles que moyennant l'application des dispositions de l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés.
Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la
Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social, et pourvu que les dispo-
sitions du présent article aient été respectées.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou par les Statuts seront
de la compétence du gérant et en cas de pluralité des gérants, du conseil de gérance.
La société est engagée par la signature individuelle de l'un quelconque de ses gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer à un ou plusieurs agents ad hoc
une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (le
cas échéant) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, télécopie ou email un autre gérant comme son mandataire, à condition que le gérant représenté ne
donne pas d'instructions en matière de vote à son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Si plusieurs gérants ont été désignés, tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par audioconfé-
rence, vidéoconférence ou tout autre moyen similaire de communication permettant à toutes les personnes participant
à la réunion de s'entendre. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne
à une telle réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre ses résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
En cas de pluralité des gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants (le cas échéant) ne contracte(ent), en raison de sa/leur fonction, aucune responsabilité
personnelle relativement à tout engagement régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts qu'il détient. Sous
réserve d'une majorité plus importante prévue par les Statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que
pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Les résolutions modifiant les
Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du
capital social, sous réserve des prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'exercice financier de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
131873
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice financier, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité des gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actif et passif
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance dudit inventaire et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
les besoins de la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s), proportionnellement à sa/leur participation dans le
capital de la Société.
Le ou les gérants, le cas échéant, peuvent décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de
l'exercice financier sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la
distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, le cas échéant, les bénéfices réalisés depuis
la fin du dernier exercice financier, augmentés des bénéfices reportés, d'une prime d'émission et d'autres réserves dis-
tribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi de 1915 ou selon
les Statuts, et que (ii) les sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés sont récu-
pérables auprès du ou des associés concernés.
Toute prime d'émission ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés, sous réserve des dispo-
sitions de la loi luxembourgeoise et aux présents Statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice comptable commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre
2013.
<i>Souscription - Paiementi>
L'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales a été souscrit par «BlueBay Direct Lending I Investments
(Luxembourg) S.à r.l.», telle que qualifiée ci-avant.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.200,-.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur William Jones, demeurant au 137, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Henry Kelly, demeurant au 4, rue Jean-Pierre Lanter, L-5943 Itzig, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Monsieur Terrence Farrelly, demeurant professionnellement au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par signature individuelle de l'un quelconque
de ses gérants.
2) Le siège social de la Société est établi au 6, rue Gabriel Lippmann, L5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
3) Deloitte Audit, une société anonyme constituée et régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 560,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B67895, a été nommée réviseur d'entreprise de la Société.
Le mandat du réviseur d'entreprise se terminera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du premier
exercice comptable, lequel commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le trente et un décembre
2013 ou à toute date antérieure que l'assemblée générale des associés pourra déterminer.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,
ledit comparant a signé le présent acte avec le notaire.
131874
L
U X E M B O U R G
Signé: J. NÜNDEL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 novembre 2012. Relation: LAC/2012/51742. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145488/309.
(120191818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Café o Negrita, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3324 Bivange, 5, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 172.497.
STATUTS
L'an deux mil douze.
Le premier octobre.
Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
Monsieur Joaquim Manuel CARDOSO NEGRITA, gérant, né à Campo Maior (Portugal), le 15 mai 1955, (No. Matricule
19550515418), demeurant à L-3250 Bettembourg, 29, rue Emile Klensch;
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de «CAFE O NEGRITA».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bivange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite restau-
ration, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Par dérogation,
le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (12.500.-EUR) représenté par CENT (100)
parts sociales de CENT VINGT-CINQ EURO (125.-EUR) chacune.
Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par l'associé unique
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE
CINQ CENTS EURO (12.500.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition
de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l'obligation pour lesdits parts sociales de désigner un mandataire.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe leurs
pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances.
131875
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Frais.i>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à MILLE DEUX CENT CINQUANTE EURO (Euro 1.250.-).
<i>Assemblée générale.i>
Et à l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, fait désigner lui-même comme gérant
unique.
Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Le siège social est établi à L-3324 Bivange, 5, rue Edward Steichen.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité
d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.
DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Cardoso Negrita, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 10 octobre 2012. Relation: EAC/2012/13161. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de l'inscription au Registre dé Commerce
et des Sociétés.
Bettembourg, le 18 octobre 2012.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2012145428/74.
(120190914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
IKAV Renewable S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place de Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 163.931.
Im Jahre zweitausendzwölf, den siebenundzwanzigsten September.
Vor Uns Maître Patrick SERRES, Notar mit Amtssitz in Remich, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
die Gesellschaft „IKAV General Partner S. à r.l.", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 2, place Dargent,
L-1413 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 163 916), handelnd als Kom-
plementärin der „IKAV SICAV-FIS SCA", einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, spezialisierter Investment-
fonds (société d'investissement à capital variable, fonds d'investissement spécialisé) gegründet unter luxemburgischem
Recht als Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions), mit Sitz in 2, place Dargent, L-1413
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 163 930),
hier vertreten durch Herrn Horst Baumann, Angestellter, beruflich ansässig Luxemburg,
handelnd in eigenem Namen in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer, als auch aufgrund einer privatrechtlichen Voll-
macht, ausgestellt in Luxemburg, am 19 September 2012.
Die von dem Komparenten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde
beigefügt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.
Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die nachstehenden von ihr
gefassten Beschlüsse wie folgt zu beurkunden:
I.- Die Erschienene („IKAV General Partner S.à r.l.") ist die alleinige Teilhaberin (die „Gesellschafterin") der Gesellschaft
„IKAV Renewable S.à r.l.", (die "Gesellschaft"), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen im Handels- und
131876
L
U X E M B O U R G
Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, unter Sektion B und Nummer 163 931, mit Sitz in 2, place Dargent, L-1413
Luxemburg, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 21. September 2011, und welche Urkunde im Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 27. Oktober 2011, unter der Nummer 2607 und Seite 125108,
veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde seit ihrer Gründung niemals abgeändert.
II. - Das Gesellschaftskapital ist derzeit festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), aufgeteilt in ein-
hundertfünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (100.- EUR), alle voll in bar eingezahlt.
III. - Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1) Abänderung des Geschäftsjahres, so dass das Geschäftsjahr fortan am ersten (1) Tag des Monats Oktober eines
jeden Jahres beginnt und am dreißigsten (30) Tag des Monats September des darauffolgenden Jahres endet; das gegenwärtig
laufende Geschäftsjahr, welches am Tag der Gesellschaftsgründung (21. September 2011) begonnen hat, wird folglich zum
30. September 2012 enden, es handelt sich somit um ein verkürztes erstes Geschäftsjahr.
2) Dementsprechende Abänderung von Artikel dreizehn (13) der Gesellschaftsordnung wie folgt:
Art. 13. Geschäftsjahr. „Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten (1) Tag des Monats Oktober eines jeden
Jahres und endet am dreißigsten (30) Tag des Monats September des darauffolgenden Jahres." Alsdann fasst die alleinige
Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterin beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, so dass das Geschäftsjahr fortan am
ersten Tag des Monats Oktober eines jeden Jahres beginnt und am dreißigsten Tag des Monats September des darauf-
folgenden Jahres endet.
Das gegenwärtig laufende Geschäftsjahr, welches am Tag der Gesellschaftsgründung (21. September 2011) begonnen
hat, wird folglich zum 30. September 2012 enden, es handelt sich somit um ein verkürztes erstes Geschäftsjahr.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als direkte Folge des vorhergehenden Beschlusses, beschließt die Gesellschafterin die Abänderung von Artikel DREI-
ZEHN (13) der Gesellschaftsordnung wie folgt:
Art. 13. Geschäftsjahr. „Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten (1) Tag des Monats Oktober eines jeden
Jahres und endet am dreißigsten (30) Tag des Monats September des darauffolgenden Jahres."
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, hat dieser mit Uns,
Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben,
Gezeichnet: H. BAUMANN, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 5 octobre 2012. Relation: REM/2012/1208. Reçu soixante-quinze euros 75.-€
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
erteilt.
Remich, den 11. Oktober 2012.
Patrick SERRES.
Référence de publication: 2012144844/61.
(120175627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2012.
Real Impact Analytics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 172.031.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the ninth of October.
Before Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
1.- Mr. Sébastien DELETAILLE, independent, residing in B-1000 Bruxelles, Rue aux laines, 32.
2.- Mr. Loïc JACOBS VAN MERLEN, independent, residing in B-1180 Bruxelles, Avenue des Hespérides,1.
3.- Mr. Didier BACLIN, employee, residing in L-2273 Luxembourg, Rue de l'Ouest, 6.
4.- Mr. Pierre-François CROUSSE, independent, residing in B-1630 Linkebeek, Hollekensweg, 22.
5.- Mr. Nicolas QUARRE, independent, residing in B-1060 Bruxelles (Belgique), Place van Meenen, 15.
131877
L
U X E M B O U R G
6.- Mr. Raphaël KRINGS, independent, residing in B-1160 Bruxelles, Avenue du Parc de Woluwe, 11.
7.- Mr. Gautier KRINGS, independent, residing in B-1050 Bruxelles, Rue du Tabellion, 72.
8.- Mr. Frédéric PIVETTA, independent, residing in B-1180 Bruxelles, Avenue de Fré, 55.
9.- Mr. Alexis EGGERMONT, independent, residing in B-1390 Grez-Doiceau, Verte voie, 1.
hereby represented by Mr. Didier BACLIN, employee, residing in L-2273 Luxembourg, Rue de l'Ouest, 6 by virtue of
eigth proxies given under private seal on October 3, 2012.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing person and the under-
signed notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing person, represented as aforesaid, have requested the officiating notary to enact the following articles
of incorporation (the Articles) of a company, which they declare to establish as follows:
Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of Real
Impact Analytics S.A (the Company).
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg (Luxembourg). It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution
of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision
of the Sole Director.
Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the
manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 19. below.
Art. 4. Corporate object. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form
whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.
The company will be allowed to act as a commercial intermediary on the markets.
The company may also buy, sell, rent and administer any real estates as well in the Grand-Duchy of Luxembourg as in
foreign countries.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises and may render every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. Share capital. The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (€ 31.000.-), represented by
thirty-one thousand (31.000) shares with a par value of ONE EURO (€ 1.-) each.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Art. 6. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the
register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Any Transfer of Shares either to an existing Shareholder or to a third party shall be subject to a pre-emptive right in
favor of the other Shareholders (hereinafter the «Other Shareholders») in proportion to their respective shareholdings
in accordance with these Articles.
Art. 7. Meeting of the shareholders of the Company. In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes
all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General
Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the single shareholder as long as the Company
has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.
In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the
General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
131878
L
U X E M B O U R G
The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the
registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in
the convening notice of the meeting, on the on the second Monday of June at 14.00 p.m. If such day is not a business day
for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
Art. 8. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices. The notice periods and quorum provided for by
law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original,
by telefax, cable, or email.
If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as
being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 9. Management. In these Articles, any reference to the Board shall be a reference to the Sole Director (as defined
below) (in the case that the Company has only one director) as long as the Company has only one shareholder.
For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does
not need to be a shareholder of the Company.
Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least
three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at
least two new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not
exceeding six years and shall be re-eligible.
When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a
permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51 bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the Companies Act 1915).
The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the
number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.
Art. 10. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose
a secretary, who need not be a director, and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the single shareholder. The
Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or
the other members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at
the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.
The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting
which shall be in Luxembourg.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance
of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.
No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and
if they state to have been duly informed, an d to have had full knowledge of the agenda, of the meeting.
Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax,
cable or email another director as his or her proxy.
The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-
sented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.
Article 10 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole
Director are documented and written minutes held at the company's registered office.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at
such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.
131879
L
U X E M B O U R G
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).
Art. 12. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed
all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies
Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.
Art. 13. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder
or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.
The Board may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative
for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative
will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as
member of the board of directors of any such entity.
The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.
Art. 14. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily
management) by:
- (i) by the sole signature of the sole director, or
- (ii) the joint signatures of any two members of the Board or
- (iii) by the sole signature of the managing director regarding the daily management of the company, or
- (iv) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been
granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
Art. 15. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors
(commissaire(s) aux comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be
re-eligible.
The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remune-
ration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting
with or without cause.
Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
of January and shall terminate
on the 31
st
of December.
Art. 17. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent
(10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time.
The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone
decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.
The dividends may be paid in Euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places
and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Companies Act 1915.
Art. 18. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General
Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 10. below. In the event
of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).
Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,
subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915 and the amendments hereto.
Art. 20. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Companies Act 1915 and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
a) The first business year begins on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31
st
of
December 2012.
b) The first annual General Meeting will be held in 2013.
<i>Subscriptioni>
The thirty-one thousand (31.000) shares have been subscribed as follows:
1.- Mr. Sébastien DELETAILLE, independent, residing in B-1000 Bruxelles, Rue aux laines, 32,
10.075
131880
L
U X E M B O U R G
ten thousand and seventy-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.- Mr. Loïc JACOBS VAN MERLEN, independent, residing in B-1180 Bruxelles, Avenue des Hespérides, 1,
ten thousand and seventy-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.075
3.- Mr. Didier BACLIN, employee, residing in L-2273 Luxembourg, Rue de l'Ouest, 6,
one thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
4.- Mr. Pierre-François CROUSSE, independent, residing in B-1630 Linkebeek, Hollekensweg, 22,
one thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
5.- Mr. Nicolas QUARRE, independent, residing in B-1060 Bruxelles, Place van Meenen, 15,
one thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
6.- Mr. Raphaël KRINGS, independent, residing in B-1160 Bruxelles, Avenue du Parc de Woluwe, 11,
one thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
7.- Mr. Gautier KRINGS, independent, residing in B-1050 Bruxelles, Rue du Tabellion, 72,
one thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
8.- Mr. Frédéric PIVETTA, independent, residing in B-1180 Bruxelles, Avenue de Fré, 55,
one thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
9.- Mr. Alexis EGGERMONT, independent, residing in B-1390 Grez-Doiceau, Verte voie, 1,
one thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
Total: thirty-one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000
All the shares have been paid up to the extent of twenty-five percent (25%) by payment in cash, so that the amount
of SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FIFTY EURO (€ 7.750.-) is now available to the corporation, evidence
thereof having been given to the notary.
The shares will remain in registered form until they have been fully paid up.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nineteen
hundred and fifteen on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation is estimated at about one thousand six hundred
Euro (€ 1.600.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named party, representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions:
1) The number of directors is fixed at nine and the number of auditors at one.
2) The following are appointed directors:
1.- Mr. Sébastien DELETAILLE, independent, born in Uccle (Belgium) on October 22, 1984, residing in B-1000 Bruxelles,
Rue aux laines, 32.
2.- Mr. Loïc JACOBS VAN MERLEN, independent, born in Grabs (Switzerland) on April 18, 1984, residing in B-1180
Bruxelles, Avenue des Hespérides,1.
3.- Mr. Didier BACLIN, employee, born in Charleroi (Belgium) on October 18, 1983, residing in L-2273 Luxembourg,
Rue de l'Ouest, 6.
4.- Mr. Pierre-François CROUSSE, independent, born in Bruxelles (Belgium) on December 19, 1982, residing in B-1630
Linkebeek, Hollekensweg, 22.
5.- Mr. Nicolas QUARRE, independent, born in Uccle (Belgium) on July 1, 1986, residing in B-1060 Bruxelles, Place
van Meenen, 15.
6.- Mr. Raphaël KRINGS, independent, born in Etterbeek (Belgium) on May 27, 1984, residing in B-1160 Bruxelles,
Avenue du Parc de Woluwe, 11.
7.- Mr. Gautier KRINGS, independent, born in Etterbeek (Belgium) on February 15, 1985, residing in B-1050 Bruxelles,
Rue du Tabellion, 72.
8.- Mr. Frédéric PIVETTA, independent, born in Ixelles (Belgium) on May 21, 1975 residing in B-1180 Bruxelles, Avenue
de Fré, 55.
9.- Mr. Alexis EGGERMONT, indépendant, born in Ottignies on March 4,1985, residing in B-1390 Grez-Doiceau, Verte
voie, 1,
2) Mr. Loïc JACOBS VAN MERLEN, prenamed, is appointed as chairman of the board of directors.
3) Has been appointed statutory auditor:
131881
L
U X E M B O U R G
The company MGI FISOGEST S.à r.l., having it's registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, re-
gistered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 20.114,
4) Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2017.
5) In accordance with the provisions of the present articles of incorporation and the law, the meeting decides to
appoint Mr. Sébastien DELETAILLE, prenamed, as managing director of the company, his term of office expiring at the
annual meeting of shareholders of the year 2017, with the authority to represent the company in the daily management
and to bind the company by his sole signature within the daily management.
6) The registered office of the company is established at L-1660 Luxembourg, Grand-Rue, 30.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the French version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, acting as above-stated,
known to the undersigned notary by name, Christian name, civil status and residence, the said appearing person signed
together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze.
Le neuf octobre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Sébastien DELETAILLE, indépendant, demeurant à B-1000 Bruxelles, Rue aux laines, 32.
2.- Monsieur Loïc JACOBS VAN MERLEN, indépendant, demeurant à B-1180 Bruxelles, Avenue des Hespérides,1.
3.- Monsieur Didier BACLIN, employé, demeurant à L-2273 Luxembourg, Rue de l'Ouest, 6.
4.- Monsieur Pierre-François CROUSSE, indépendant, demeurant à B-1630 Linkebeek, Hollekensweg, 22.
5.- Monsieur Nicolas QUARRE, indépendant, demeurant à B-1060 Bruxelles, Place van Meenen, 15.
6.- Monsieur Raphaël KRINGS, indépendant, demeurant à B-1160 Bruxelles, Avenue du Parc de Woluwe, 11.
7.- Monsieur Gautier KRINGS, indépendant, demeurant à B-1050 Bruxelles, Rue du Tabellion, 72.
8.- Monsieur Frédéric PIVETTA, indépendant, demeurant à B-1180 Bruxelles, Avenue de Fré, 55.
9.- Monsieur Alexis EGGERMONT, indépendant, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, Verte voie, 1.
Lesquels comparants sont ici représentés par Monsieur Didier BACLIN, employé, demeurant à L-2273 Luxembourg,
Rue de l'Ouest, 6, en vertu de huit procurations sous seing privé lui délivrées en date du 3 octobre 2012,
lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif
d'une société anonyme qu'ils déclarent vouloir constituer et dont ils ont arrêté, les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de Real Impact Analytics
S.A. (ci-après la Société).
La Société peut avoir un associé unique (l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra pas être
dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique.
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être
transféré dans les limites de la commune de la Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société
(le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de
l'Administrateur Unique.
Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de
la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 19. ci-après.
Art. 4. Objet Social. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes
espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra faire de l'intermédiation commerciale sur les marchés.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger.
131882
L
U X E M B O U R G
La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par trente-
et-un mille (31.000) actions d'une valeur nominale de UN EURO (€ 1.-) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Art. 6. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au
registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans
lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.
Tout transfert d'actions que ce soit à un Actionnaire actuel ou à un tiers sera sujet à un droit de préemption en faveur
des autres Actionnaires (ciaprès les «Autres Actionnaires») en proportion de leurs participations respectives conformé-
ment aux présents Statuts
Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un associé unique, l'Associé Unique
aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé
Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie
de procès-verbaux.
Dans l'Hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée
Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour
ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la
Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, chaque année le deuxième lundi
du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis
par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en
est pas disposé autrement dans les Statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale
dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble ou par email une autre personne comme mandataire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués
et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans
convocation préalable.
Art. 9. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence
à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un associé unique.
Tant que la Société n'a qu'un associé unique, la Société peut être administrée seulement par un administrateur unique
qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un actionnaire, la
Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas
nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins deux (2) nouveaux
administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administra-
teurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.
Toute référence dans les Statuts au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (lorsque
la Société n'a qu'un associé unique) tant que la Société a un associé unique.
131883
L
U X E M B O U R G
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit
désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la loi lu-
xembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi sur les Sociétés de 1915).
Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également
le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra être
rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.
Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)
parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le
Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'As-
semblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.
Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu
indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont
présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour.
Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'Administration en
désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble ou par email à un autre administrateur comme son mandataire.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.
L'article 10 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 11. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les
résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président qui en aura assumé la
présidence. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur
Unique.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux
membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes de disposition et d'Administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressé-
ment réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du
Conseil d'Administration.
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, ac-
tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.
Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de
représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du conseil d'administration de toute telle entité.
Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation
préalable de l'Assemblée Générale, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 14. Signatures autorisées. La Société sera engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par:
- (i) la signature individuelle de l'administrateur unique, ou
- (ii) les signatures conjointes de deux administrateurs de la Société, ou
- (iii) la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière de la société, ou
131884
L
U X E M B O U R G
- (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs
de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés.
Art. 15. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.
Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur fonction. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans
motif, par l'Assemblée Générale.
Art. 16. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre.
Art. 17. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent
(10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre.
L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des
dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.
Les dividendes pourront être payés en Euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et
devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 10 ci-avant. En
cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent
être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette
liquidation. L'assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée
Générale extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 20. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
a) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
b) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscriptioni>
Les trente-et-un mille (31.000) actions ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Sébastien DELETAILLE, indépendant, demeurant à B-1000 Bruxelles, Rue aux laines, 32,
dix mille soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.075
2.- Monsieur Loïc JACOBS VAN MERLEN, indépendant, demeurant à B-1180 Bruxelles,
Avenue des Hespérides,1, dix mille soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.075
3.- Monsieur Didier BACLIN, employé, demeurant à L-2273 Luxembourg, Rue de l'Ouest, 6,
mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
4.- Monsieur Pierre-François CROUSSE, indépendant,, demeurant à B-1630 Linkebeek, Hollekensweg, 22,
mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
5.- Monsieur Nicolas QUARRE, indépendant, demeurant à B-1060 Bruxelles, Place van Meenen, 15,
mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
6.- Monsieur Raphaël KRINGS, indépendant, demeurant à B-1160 Bruxelles, Avenue du Parc de Woluwe, 11,
mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
7.- Monsieur Gautier KRINGS, indépendant, demeurant à B-1050 Bruxelles, Rue du Tabellion, 72,
mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
8.- Monsieur Frédéric PIVETTA, indépendant, demeurant à B-1180 Bruxelles, Avenue de Fré, 55,
mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
9.- Monsieur Alexis EGGERMONT, indépendant, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, Verte voie, 1,
mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
Total: trente-et-un mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire à un compte
bancaire, de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (€ 7.750,00) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.
131885
L
U X E M B O U R G
Les actions resteront nominatives jusqu'à leur libération intégrale.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents Euros
(€ 1.600.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à neuf et celui des commissaires à un.
1.- Monsieur Sébastien DELETAILLE, indépendant, né à Uccle (Belgique) le 22 octobre 1984, demeurant à B-1000
Bruxelles, Rue aux laines, 32.
2.- Monsieur Loïc JACOBS VAN MERLEN, indépendant, né à Grabs (Suisse) le 18 avril 1984, demeurant à B-1180
Bruxelles, Avenue des Hespérides,1.
3.- Monsieur Didier BACLIN, employé, né à Charleroi (Belgique) le 18 octobre 1983, demeurant à L-2273 Luxembourg,
Rue de l'Ouest, 6.
4.- Monsieur Pierre-François CROUSSE, indépendant, né à Bruxelles le 19 décembre 1982, demeurant à B-1630 Lin-
kebeek, Hollekensweg, 22.
5.- Monsieur Nicolas QUARRE, indépendant, né à Uccle (Belgique) le 1er juillet 1986, demeurant à B-1060 Bruxelles,
Place van Meenen, 15.
6.- Monsieur Raphaël KRINGS, indépendant, né à Etterbeek (Belgique) le 27 mai 1984, demeurant à B-1160 Bruxelles,
Avenue du Parc de Woluwe, 11.
7.- Monsieur Gautier KRINGS, indépendant, né à Etterbeek (Belgique) le 15 février 1985, demeurant à B-1050 Bru-
xelles, Rue du Tabellion, 72.
8.- Monsieur Frédéric PIVETTA, indépendant, né à Ixelles (Belgique) le 21 mai 1975, demeurant à B-1180 Bruxelles,
Avenue de Fré, 55.
9.- Monsieur Alexis EGGERMONT, indépendant, né à Ottignies le 4 mars 1985, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau,
Verte voie, 1.
2) Monsieur Loïc JACOBS VAN MERLEN, prénommé, est nommé président du conseil d'administration.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée MGI FISOGEST S.à r.l., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue
Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 20.114.
4) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2017.
5) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale décide de nommer comme
administrateur-délégué de la société, Monsieur Sébastien DELETAILLE, prénommé, son mandat expirant à l'assemblée
générale de 2017, avec pouvoir de représenter la société dans le cadre de la gestion journalière et d'engager la société
par sa signature individuelle dans le cadre de cette gestion journalière.
6) Le siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, Grand-Rue, 30.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Sur demande du même comparant, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: D. BACLIN, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 12 octobre 2012. Relation: ECH/2012/1724. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 16 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135443/501.
(120178196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
131886
L
U X E M B O U R G
EKIAM S. à r. l. & Cie. KL.Z. Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.898.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszug aus dem Protokolli>
Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn
Dr. Dr. Klaus Zack, D-14979 Grossbeeren, Diedersdorferstr. 5e, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer
und Herr Hermann Stute als Stimmzähler.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftevertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Ent-
lastung erteilt.
2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Dr. Dr. Klaus Zack, D-14979
Grossbeeren, Diedersdorferstr. 5e, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Dr. Dr. Klaus Zack, D-14979 Gross-
beeren, Diedersdorferstr. 5e, verwahrt.
5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.
Moersdorf, den 12.10.2012.
Dr. Niggemeyer / Peler Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.i>
Référence de publication: 2012135095/28.
(120178771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Insurance Broker's Solution Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-4972 Dippach, 68, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 108.838.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135208/10.
(120178999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Pradera Central Militari S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.024.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of September.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Pradera Central Holdco S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (RCS Luxembourg B
111 721),
represented by Mrs Gwendoline LALOUX, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney signed on 21 September 2012.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of the registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
131887
L
U X E M B O U R G
- that it is the sole actual shareholder of Pradera Central Militari S.à r.l. (the "Company"), société à responsabilité
limitée with its registered office at 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incor-
porated in Luxembourg by a deed of the undersigned notary on 28 November 2006, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 51 on 25 January 2007, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under n° B 122.024. The articles of association have been amended for the last time by deed of the undersigned
notary on December 21, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 468 on 22
February 2008;
- that it has been fully informed of the resolution to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the subscribed capital by an amount of 100.- EUR to bring it from its present amount of 12,500.- EUR
to 12,600.- EUR by the issuance of 1 new share with a par value of 100.- EUR.
2. Contribution of the said increase of capital in kind of a certain, liquid and immediately payable claim held by the sole
shareholder against Pradera Central Militari S.à r.l. of an amount of 62,217.11 EUR, the surplus between the nominal value
of the share issued and the total value of the contribution being transferred to a share premium account of the corporation.
3. To amend accordingly article 6 of the articles of incorporation of the Company.
4. Miscellaneous.
- that it has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder, represented as stated hereabove, resolves to increase the Company's subscribed capital by an
amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro
(EUR 12,500.-) to twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-) divided into one hundred and twenty-six (126) shares,
each share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), by creation of one (1) new share.
<i>Subscription - Liberationi>
The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe to the one (1) new share and to have
it fully paid up by contribution in kind of a certain, liquid and immediately payable claim held by it against the company
Pradera Central Militari S.a r.l. of an amount of sixty-two thousand two hundred and seventeen euro and eleven cents
(62,217.11.- EUR).
The existence and the value of the said claim has been certified to the undersigned notary.
The surplus between the nominal value of the share issued and the total value of the contribution in kind, being the
amount of sixty-two thousand one hundred and seventeen euro and eleven cents (62,117.11.- EUR) shall be transferred
to a share premium account of the corporation.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder, represented as stated hereabove, decides to amend article 6 of the articles of incorporation,
which will henceforth have the following wording:
" Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) represented by one hundred
twenty-six (126) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share."
<i>Expensesi>
There being no further item on the agenda, the meeting is closed.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately one thousand two hundred euro (1,200.- EUR).
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Pradera Central Holdco S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (RCS Luxembourg B 111.721),
131888
L
U X E M B O U R G
représentée aux fins des présentes par Madame Gwendoline LALOUX, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 21 septembre 2012.
Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- qu'elle est la seule et unique associée de Pradera Central Militari S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son
siège social au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée
par acte du notaire soussigné du 28 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 51
le 25 janvier 2007, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro
B-122.024. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du 21 décembre 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 468 le 22 février 2008;
- qu'elle reconnaît être parfaitement informée des décisions à intervenir sur la base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du Jouri>
1. Augmenter le capital social d'un montant de 100.- EUR pour le porter de son montant actuel de 12.500.- EUR à
12.600.- EUR par l'émission de 1 nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 100.- EUR.
2. Apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par le seul associé à l'encontre de Pradera
Central Militari S.à r.l. d'un montant de 62.217,11 EUR, la différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et
la valeur totale de l'apport étant transférée à un compte prime d'émission de la société.
3. Modification concordante de l'article 6 des statuts.
4. Divers.
- qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de cent euros (100,- EUR) de manière
à porter le capital de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), à douze mille six cents euros
(12.600,- EUR) divisé en cent vingt six (126) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR),
le tout par émission d'une (1) part sociale nouvelle.
<i>Souscription - Libérationi>
L'associé unique, représenté comme dit est, déclare souscrire à la nouvelle part sociale et la libérer moyennant apport
en nature d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par lui-même contre Pradera Central Militari S.à r.l. d'un
montant de soixante deux mille deux cent dix sept euros et onze cents (62.217,11 EUR).
L'existence et la valeur de la dite créance a été certifiée au notaire instrumentant.
La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la participation apportée, étant de
soixante deux mille cent dix sept euros et onze cents (62.117,11 EUR) sera transférée à un compte de prime d'émission
de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique, représenté comme dite est, décide de modifier en conséquence l'article 6 de statuts de la société
pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Capital social. Le capital est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) représenté par cent vingt-six
(126) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée était levée.
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent
acte sont évalués à approximativement mille deux cents euros (1.200.- EUR).
Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant précité,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce
dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. LALOUX, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 septembre 2012. Relation: LAC/2012/45080. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
131889
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135361/124.
(120178709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.M. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.741.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszug aus dem Protokolli>
Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn
Dr. Markus Metzger, D-86757 Wallerstein, Im Unterdorf 4a, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und
Herr Hermann Stute als Stimmzähler.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Ent-
lastung erteilt.
2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Dr. Markus Metzger, D-86757
Wallerstein, Im Unterdorf 4a, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Dr. Markus Metzger, D-86757 Wallerstein,
Im Unterdorf 4a, verwahrt.
5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt..
Moersdorf, den 12.10.2012.
Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.i>
Référence de publication: 2012135096/28.
(120178977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Industry Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 109.790.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012135218/9.
(120178698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
LMA German Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 135.712.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 16 octobre 2012, a renouvelé les mandats des gérants.
- Mr Brian McCARTHY, gérant de catégorie A, directeur financier, La Valette, 5, Melbourne Park, JE3 4EQ, St. John,
Jersey;
- Mr Richard HAWEL, gérant de catégorie B, directeur de société, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
131890
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 16 octobre 2012.
<i>Pour LMA GERMAN INVESTMENTS
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012135268/17.
(120178852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.M. Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.734.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszug aus dem Protokolli>
Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn
Dr. Markus Metzger, D-86757 Wallerstein, Im Unterdorf 4a, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und
Herr Hermann Stute als Stimmzähler.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Ent-
lastung erteilt.
2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Dr. Markus Metzger, D-86757
Wallerstein, Im Unterdorf 4a, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Dr. Markus Metzger, D-86757 Wallerstein,
Im Unterdorf 4a, verwahrt.
5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.
Moersdorf, den 12.10.2012.
Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.i>
Référence de publication: 2012135097/28.
(120178983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Interparfums S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 45.802.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012135225/9.
(120178663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
LMD German Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 141.012.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 16 octobre 2012, a décidé de renouveler le mandat des gérants:
- Monsieur Brian McCARTHY, directeur financier, La Valette, 5, Melbourne Park. JE3 4EQ, St John, Jersey, gérant de
catégorie A,
- Monsieur Richard HAWEL, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, gérant de catégorie B.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
131891
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 16 octobre 2012.
<i>Pour LMD GERMAN INVESTMENTS
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012135271/17.
(120178849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
INNCONA S.à.r.l. & Cie Quatre cent quatre-vingt-sixième (486.), Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 159.173.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszug aus dem Protokolli>
Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter der Frau
Dr. Karin Burkhardt, D-38350 Helmstedt, Hegelstr. 1b, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und Herr
Hermann Stute als Stimmzähler.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesellsehafterversammlung ist gemäß Art, 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Ent-
lastung erteilt.
2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf die Gesellschafterin, Frau Dr. Karin Burkhardt, D-38350
Helmstedt, Hegelstr. 1b, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei der Kommanditistin, Frau Dr. Karin Burkhardt D-38350 Helmstedt,
Hegelstr. 1b, verwahrt.
5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.
Moersdorf, den 12.10.2012.
Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.i>
Référence de publication: 2012135221/28.
(120179000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Jattis 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 65.931.
Le Bilan du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135235/11.
(120178870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Whitehall European RE 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.593.575,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 128.511.
Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 mai 2007, acte publié au
Mémorial C no 1475
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
131892
L
U X E M B O U R G
Whitehall European RE 4 S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012135539/15.
(120178258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
I.C.F.D.A.I. SA, International Company for Developments and Investments, Société Anonyme.
Enseigne commerciale: Le Centre International des Affaires et Services.
Siège social: L-3260 Bettembourg, 91, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 58.757.
L'an deux mille douze, le cinq septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL COM-
PANY FOR DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS, en abrégé I.C.F.D.A.I. S.A., pouvant faire le commerce sous
l'enseigne de LE CENTRE INTERNATIONAL DES AFFAIRES ET SERVICES, (ci-après la "Société"), ayant son siège social
à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21-23, avenue des Bains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 58.757
constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 2 décembre
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 114 du 11 mars 1997,
dont les statuts ont été modifiés:
- suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 21 février 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 330 du 27 juin 1997,
- suivant acte reçu par Maître Roger ARRENSDORFF, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 9
février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 400 du 2 juin 1999,
- suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 avril 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 556 du 22 mai 2003,
dont le capital social a été converti et augmenté à deux cent soixante-treize mille euros (273.000,- EUR) suivant acte
d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 29 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1253 du 28 août
2002
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Noëlle REGARD, assistante de production, demeurant
professionnellement à Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Linda KADOUCHE, assistante de production, demeurant
professionnellement à Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pascal COLIN, administrateur de sociétés, demeurant profession-
nellement à Bettembourg, 91, route de Mondorf.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social vers L-3260 Bettembourg, 91, route de Mondorf.
2. Modification du premier alinéa de l'article 4 des statuts.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
131893
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer l'adresse du siège social vers L-3260 Bettembourg, 91, route de Mondorf.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts
comme suit:
« Art. 4. (1
er
alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Bettembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).»
<i>Troisième résolutioni>
L' assemblée générale, par vote spécial, accepte les démissions des administrateurs, Nelly CHARTIER-COLIN, et
Christian DUPONT, et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale confirme Monsieur Pascal COLIN, né à Enghein les Bains (F), le 12 juillet 1955, demeurant à
L-3260 Bettembourg, 91, route de Mondorf, comme administrateur et administrateur délégué, son mandat expirant à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale nomme aux fonctions d'administrateurs:
Madame Claire-Marie, Pascale COLIN, étudiante, née à Paris (F), le 19 janvier 1989, demeurant à L-3260 Bettembourg,
91, route de Mondorf,
Monsieur Pierre COLIN, salarié, né à Paris (F), le 1
er
décembre 1985, demeurant à F-74100 Vetraz Monthoux, 31,
route de Livron.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à neuf cent cinquante euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Marie-Noëlle REGARD, Linda KADOUCHE, Pascal COLIN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 septembre 2012. Relation GRE/2012/3359. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 17 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135224/84.
(120178624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Munster, Société Anonyme.
Siège social: L-2160 Luxembourg, 5-7, rue Munster.
R.C.S. Luxembourg B 19.885.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2012, que les personnes suivantes sont
mandataires de la société:
<i>Conseil d'Administrationi>
- Monsieur ACKERMANN Charles-Louis, Administrateur, demeurant à L-1021 Luxembourg;
- Monsieur CLASEN Carlo, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, demeurant à L-1833 Luxem-
bourg, 33, Boulevard Gustave Jacquemart;
- Monsieur ROELANTS André, Administrateur, demeurant à L-1855 Luxembourg, 42, avenue John F. Kennedy;
- Monsieur SCHWACHTGEN André, Administrateur, demeurant à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nic. Welter;
- Madame CHEVREMONT Marie-Jeanne, Administrateur, demeurant à L-1014 Luxembourg;
- Monsieur KNEIP Bob, Administrateur, demeurant à L-1727 Luxembourg, 25, rue Arthur Herchen.
131894
L
U X E M B O U R G
Leur mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'an 2018.
<i>Commissaire aux comptesi>
- Monsieur Romain Bontemps, né le 27 décembre 1960 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-1445 Strassen, 7A, rue
Thomas Edison.
Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012135334/24.
(120178889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Jolimon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 171.817.
Changement suivant les contrats de cession de parts du 3 octobre 2012:
- Ancienne situation associées:
Intertrust (Luxembourg) S.A.: 12.500 parts sociales
- Nouvelle situation associées:
Parts
sociales
DOTCORP FINANCE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250
Mr. Warren BARTHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.563
Mr. Johann BARTHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.563
Mr. Davy BARTHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.563
Ms. Chelsea BARTHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.561
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Jolimon Investments S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012135233/23.
(120178847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Jattis 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 65.932.
Le Bilan du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135236/11.
(120178864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Pradera Southern Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 22.600,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 121.601.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of September.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Pradera Southern Management S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
acting for the account of and in the exclusive interest of the unitholders on behalf of Pradera European Retail Fund 2,
having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (RCS Luxembourg B
119 316),
131895
L
U X E M B O U R G
represented by Mrs Gwendoline LALOUX, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney signed on 21 September 2012.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of the registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of Pradera Southern Holdco S.à r.l. (the "Company"), société à responsabilité
limitée with its registered office at 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-121 601 and incorporated following a
deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, of 17 November 2006, published in the Mémorial C number
2424 of 28 December 2006, which articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following
a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, of 10 April 2008, published in the Mémorial C number
1332 of 30 May 2008;
- that it has been fully informed of the resolution to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the subscribed capital by an amount of 100.- EUR to bring it from its present amount of 22,500.- EUR
to 22,600.- EUR by the issuance of 1 new share with a par value of 100.- EUR.
2. Contribution of the said increase of capital in kind of a certain, liquid and immediately payable claim held by the sole
shareholder against Pradera Southern Holdco S.à r.l. of an amount of 1,149,079.- EUR, the surplus between the nominal
value of the share issued and the total value of the contribution being transferred to a share premium account of the
corporation.
3. To amend accordingly article 6 of the articles of incorporation of the Company.
4. Miscellaneous.
- that it has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder, represented as stated hereabove, resolves to increase the Company's subscribed capital by an
amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to raise it from its current amount of twenty two thousand five hundred
euro (EUR 22,500.-) to twenty two thousand six hundred euro (EUR 22,600.-) divided into two hundred and twenty-six
(226) shares, each share with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), by creation of one (1) new share.
<i>Subscription - Liberationi>
The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe to the one (1) new share and to have
it fully paid up by contribution in kind of a certain, liquid and immediately payable claim held by it against the company
Pradera Southern Holdco S.a r.l. of an amount of one million one hundred forty nine thousand and seventy nine euro
(1,149,079.- EUR).
The existence and the value of the said claim has been certified to the undersigned notary.
The surplus between the nominal value of the share issued and the total value of the contribution in kind, being the
amount of one million one hundred forty eight thousand nine hundred and seventy nine euro (1,148,979.- EUR) shall be
transferred to a share premium account of the corporation.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder, represented as stated hereabove, decides to amend the first paragraph of article 6 of the articles
of incorporation, which will henceforth have the following wording:
" Art. 6. Capital. 1
st
paragraph. The capital is set at twenty two thousand six hundred Euro (EUR 22,600.-) represented
by two hundred twenty-six (226) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share."
<i>Expensesi>
There being no further item on the agenda, the meeting is closed.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately at two thousand two hundred euro (2,200.- EUR).
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
131896
L
U X E M B O U R G
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Pradera Southern Management S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (RCS Luxembourg B 119 316), agissant pour le compte et
les intérêts des porteurs de parts de Pradera European Retail Fund 2,
représentée aux fins des présentes par Madame Gwendoline LALOUX, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 21 septembre 2012.
Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- qu'elle est la seule et unique associée de Pradera Southern Holdco S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son
siège social au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121 601, constituée suivant un acte de Maître
Gérard Lecuit, notaire, résidant à Luxembourg, en date du 17 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2424 du 28 décembre 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte
de Maître Gérard Lecuit, notaire, résidant à Luxembourg en date du 10 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1332 du 30 mai 2008;
- qu'elle reconnaît être parfaitement informé des décisions à intervenir sur la base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du Jouri>
1. Augmenter le capital social d'un montant de 100.- EUR pour le porter de son montant actuel de 22.500.- EUR à
22.600.- EUR par l'émission de 1 nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 100.- EUR.
2. Apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par le seul associé contre Pradera Southern
Holdco S.à r.l. d'un montant de 1,149,079.- EUR, la différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur
totale de l'apport étant transférée à un compte prime d'émission de la société.
3. Modification concordante de l'article 6 des statuts.
4. Divers.
- qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de cent euros (100,- EUR) de manière
à porter le capital de son montant actuel de vingt deux mille cinq cents euros (22.500,- EUR), à vingt deux mille six cents
euros (22.600,- EUR) divisé en cent vingt six (126) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR), le tout par émission d'une (1) part sociale nouvelle.
<i>Souscription - Libérationi>
L'associé unique, représenté comme dit est, déclare souscrire à la nouvelle part sociale et la libérer moyennant apport
en nature d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par lui-même contre Pradera Southern Holdco S.à r.l. d'un
montant de un million cent quarante neuf mille et soixante dix neuf euros (1.149.079,- EUR).
L'existence et la valeur de la dite créance a été certifiée au notaire instrumentant.
La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la participation apportée, étant de
un million cent quarante huit mille et neuf cent soixante dix neuf euros (1.148.979,- EUR) sera transférée à un compte
de prime d'émission de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique, représenté comme dit est, décide de modifier en conséquence l'article 6 alinéa 1
er
des statuts de la
société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Capital social - alinéa 1
er
. Le capital est fixé à vingt deux mille six cents euros (EUR 22.600,-) représenté
par deux cent vingt-six (226) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée était levée.
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent
acte sont évalués à approximativement à deux mille deux cents euros (2.200.- EUR).
Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
131897
L
U X E M B O U R G
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant précité,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce
dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. LALOUX, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 septembre 2012. Relation: LAC/2012/45079. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135362/128.
(120178710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Jattis 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 65.933.
Le Bilan du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135237/11.
(120178869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Jattis 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 65.934.
Le Bilan du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135238/11.
(120178868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Karat S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 80.634.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135244/10.
(120178860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
PeeBeeLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.419.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 127.141.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 4 juillet 2012.i>
En date du 4 juillet 2012 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Monsieur Johan DEJANS, en tant que Gérant de la Société et ce avec effet au 4 juillet
2012.
131898
L
U X E M B O U R G
- de nommer Madame Elizabeth TIMMER, née le 24 juillet 1965 à Zuidelijke IJsselmeerpolder (Pays-Bas), ayant comme
adresse professionnelle 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que Gérant, pour une durée illimitée
et ce avec effet au 4 juillet 2012.
Les gérants de la Société sont désormais les suivants:
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Elizabeth TIMMER
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012135355/22.
(120178747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Kunert Beteiligung S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 55.285.
Je vous informe que j'ai décidé de démissionner de mon poste de Commissaire de votre société KUNERT BETEILI-
GUNG SA inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B55285 avec effet immédiat.
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
BENOY KARTHEISER MANAGEMENT Sàrl
Référence de publication: 2012135249/11.
(120178693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
LMB German Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 140.466.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 16 octobre 2012, a décidé de renouveler le mandat des gérants:
- Monsieur Brian McCARTHY, gérant de catégorie A, directeur financier, La Valette, 5, Melbourne Park, JE3 4EQ, St
John, Jersey;
- Monsieur Richard HAWEL, gérant de catégorie B, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes pour l'exercice clos au
31 décembre 2012.
Luxembourg, le 16 octobre 2012.
<i>Pour LMB GERMAN INVESTMENTS
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012135269/18.
(120178851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Regio Office Center (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 97.197.
La soussignée, CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social et ses bureaux au 60, Grand-Rue /
Niveau 2, L-1660 Luxembourg, atteste par la présente que la domiciliation respectivement l'établissement du siège de la
société
REGIO OFFICE CENTER (Luxembourg) SARL
R.C. Luxembourg Section B Numéro B 97.197
prend fin le 17 octobre 2012
et que par conséquent cette société n'a plus son siège social ni ses bureaux à cette adresse.
131899
L
U X E M B O U R G
Le 17 octobre 2012.
CRT REGISTER INTERNATIONAL SA
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2012135444/16.
(120178774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
LMC German Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 140.584.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 16 octobre 2012, a décidé de renouveler le mandat des gérants:
- Monsieur Brian McCARTHY, directeur financier, La Valette, 5, Melbourne Park, JE3 4EQ, St John, Jersey, gérant de
catégorie A,
- Monsieur Richard HAWEL, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, gérant de catégorie B.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes pour l'exercice clos au
31 décembre 2012.
Luxembourg, le 16 octobre 2012.
<i>Pour LMC GERMAN INVESTMENTS
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012135270/18.
(120178850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Luxembourg Designs S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8050 Bertrange, Centre la Belle Etoile, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 52.103.
Le Bilan au 31 mars 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Erik Baeten
<i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2012135282/11.
(120178731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
McKesson China Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 133.513.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135294/10.
(120178647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
WI-BA-Metall S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 55, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 138.432.
Aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 15.10.2012, welche am Gesellschaftssitz abge-
halten wurde, gehen folgende Beschlüsse hervor:
Alle Teilhaber waren anwesend.
Die Gesellschaftsanteile sind nunmehr wie folgt verteilt:
Herr Guido BRÜLS besitzt 60 Anteile
Und Herr Patrick FEIDLER besitzt 60 Anteile.
131900
L
U X E M B O U R G
Guido BRÜLS
<i>Gesellschafteri>
Référence de publication: 2012135546/15.
(120178810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Nomura Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 32.921.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012135345/9.
(120178876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Sefo Luxembourg S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 81.375.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 12 juillet 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société
anonyme SEFO Luxembourg S.A., dont le siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, a été dénoncé en date du
31 décembre 2007.
Le même jugement dit que les frais sont à prélever sur l'actif réalisé, le solde étant à charge de l'Etat.
Pour extrait conforme
Maître Katya VASILEVA
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012135479/16.
(120178126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
McKesson Information Solutions Topholdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 151.987.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135297/10.
(120178661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
McKesson International Holdings IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 94.840.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135301/10.
(120178649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
McKey Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.025,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 155.686.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
131901
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135306/11.
(120178680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
McKey Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 787.575,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 101.381.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135308/11.
(120178829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Min Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
R.C.S. Luxembourg B 50.412.
La société PREMIER VOET sàrl, domiciliataire, dénonce le siège social de la société
MIN INVEST S.A, SPF (B50412) situé au 59, Bd Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg et ce, avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Premier Voet Sàrl
Référence de publication: 2012135320/12.
(120178769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
McKesson International Holdings V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 101.214.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135309/10.
(120178650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
McKesson International Holdings VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 103.505.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135310/10.
(120178648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Tschingel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 88.236.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, lei>
<i>12 juin 2012 à 14.00 heuresi>
Reconduction des mandats de Monsieur Reinald Loutsch, Madame Elise Lethuillier et Madame Catherine Roux en tant
qu'administrateurs et de Fiduciaire Simmer & Lereboulet S.A.. ayant son siège social au 18 B Rue de la Chapelle L-8017
131902
L
U X E M B O U R G
Strassen, inscrit au RCS Luxembourg sous le numéro B 73846, en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée
d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un Administrateuri>
Référence de publication: 2012135602/18.
(120178766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Mediclinic Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 25.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 129.758.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135312/11.
(120178832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Minmetals Exploration & Development (Luxembourg) Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 160.819.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135314/10.
(120178842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Mithris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 62.478.
Le Bilan du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135325/11.
(120178867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Ziksana Development Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 172.013.
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 23 septembre 2012i>
En vertu de l'acte de transfert de parts daté du 23 septembre 2012, SIMANTA DAS B.V., a transféré 2.500 de ces
parts détenues dans la Société de la manière suivante:
- 1.750 parts sociales d'une valeur de 1 Euro chacune, à la société Vishwamitra Labs Inc., constituée et organisée en
vertu des lois de l'Illinois, États-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Suite 201, 1300 E Irving Park Road, Streamwood,
IL-60107, États-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du secrétaire d'État de l'Illinois sous le numéro 68493293;
- 500 parts sociales d'une valeur de 1 Euro chacune, à Shalin Garg, un citoyen Indien, né le 1
er
mars 1974, à Bareilly,
Inde, demeurant au 2J40, Sarjapur Road, Kaikondahalli, Bangalore - 560035 Inde;
131903
L
U X E M B O U R G
- 250 parts sociales d'une valeur de 1 Euro chacune, à Vinay Krishna Neeli, un citoyen Indien, né le 10 mai 1978 à
Warangal, Inde, demeurant au 341, Begur Road, Karnataka, Bangalore - 560068 Inde.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012135559/22.
(120178191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Nile Capital II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 153.567.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Nile Capital II S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012135335/11.
(120178896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Natural Resources Development Corp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 136.040.
Je suis au regret, par la présente, de vous remettre ma démission en tant qu'administrateur de votre société, avec effet
au 16 octobre 2012.
Luxembourg, le 16 octobre 2012.
Olivier LIEGEOIS.
Référence de publication: 2012135337/10.
(120178873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Natural Resources Development Corp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 136.040.
Je suis au regret, par fa présente, de vous remettre ma démission en tant qu'administrateur de votre société, avec effet
au 16 octobre 2012.
Luxembourg le 16 octobre 2012.
Patrick MOINET.
Référence de publication: 2012135338/10.
(120178873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Natural Resources Development Corp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 136.040.
Nous sommes au regret, par la présente, de vous remettre notre démission en tant que commissaire de votre société,
avec effet au 16 octobre 2012.
Luxembourg le 16 octobre 2012.
REVICONSULT S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012135339/12.
(120178873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
131904
BlueBay Direct Lending I Investment Green (Luxembourg) S.à r.l.
Café o Negrita
EKIAM S. à r. l. & Cie. KL.Z. Zweite S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.M. Erste S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. M.M. Zweite S.e.c.s.
IKAV Renewable S.à r.l.
Industry Investment S.A.
INNCONA S.à.r.l. & Cie Quatre cent quatre-vingt-sixième (486.)
Insurance Broker's Solution Europe
International Company for Developments and Investments
Interparfums S.A.
Jattis 1 S.A.
Jattis 2 S.A.
Jattis 3 S.A.
Jattis 4 S.A.
Jolimon Investments S.à r.l.
Karat S.àr.l.
Kunert Beteiligung S.A.
LMA German Investments
LMB German Investments
LMC German Investments
LMD German Investments
Luxembourg Designs S.A.
McKesson China Holdings S.à r.l.
McKesson Information Solutions Topholdings S.à r.l.
McKesson International Holdings IV S.à r.l.
McKesson International Holdings VII S.à r.l.
McKesson International Holdings V S.à r.l.
McKey Luxembourg Holdings S.à r.l.
McKey Luxembourg S.à r.l.
Mediclinic Luxembourg S.à r.l.
Min Invest S.A., SPF
Minmetals Exploration & Development (Luxembourg) Limited S.à r.l.
Mithris S.A.
Munster
Natural Resources Development Corp S.A.
Natural Resources Development Corp S.A.
Natural Resources Development Corp S.A.
Nile Capital II S.à r.l.
Nomura Bank (Luxembourg) S.A.
PeeBeeLux S.à r.l.
Pradera Central Militari S.à r.l.
Pradera Southern Holdco S.à r.l.
Real Impact Analytics S.A.
Regio Office Center (Luxembourg) S.à r.l.
Sefo Luxembourg S.A.
Tschingel S.A.
VCG Lease S.à r.l.
Whitehall European RE 4 S.à r.l.
WI-BA-Metall S.à r.l.
Ziksana Development Group S.à r.l.