logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2580

17 octobre 2012

SOMMAIRE

AV Chartering SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123815

Helvetia Communication Participations

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123840

Immo & Business Consult S.à r.l., en abré-

gé I.B.C. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123815

Immoffice S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123815

Information Business Integration A.G.  . . .

123816

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesell-

schaft S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123816

Intertrade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123816

Invesco European Hotel Real Estate IV S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123799

Invesco The Hague Hotel Investment S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123807

Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123804

Investissements Euro Finance S.A. . . . . . . .

123817

Iron Paradox S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123817

Island Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123818

ISOS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123818

IT Investments Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

123824

IVG Cannon Street S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

123794

Jopoly S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123824

Kaval S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123835

Kermorio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123811

KÖHL Aktiengesellschaft  . . . . . . . . . . . . . . .

123835

Kompass Wohnen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

123834

Konatra S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123835

KPI Sierra 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123835

K.Y.O. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123834

Laboratoire Dentaire Graffe S.à.r.l.  . . . . . .

123838

La Chamade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123838

La Fiduciaire Comptable Comptafisc Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123838

Landesbank Berlin AG Niederlassung Lu-

xemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123836

Laser Développement S.A. . . . . . . . . . . . . . .

123839

Laser Développement S.A. . . . . . . . . . . . . . .

123839

LBC Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123839

LBC Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123840

LBC Vesta Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

123840

LBC Vesta Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

123840

L.D.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123836

LEA Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

123835

Legacy Pharmaceuticals International Hol-

dings (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

123802

Leitz-Service G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

123836

LGT Solutions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123837

Lighthouse Holdings Limited S.A.  . . . . . . .

123837

LNG International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

123838

Lower Thames S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123837

Lutèce S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123837

Lutèce S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123837

Luxono S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123838

Moesdorf S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123836

NGR Consulting S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

123817

Prim Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123818

RL Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123814

Sarucci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123839

Sea Dream S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123818

TII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123825

123793

L

U X E M B O U R G

IVG Cannon Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 171.559.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the eighteenth of September;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

IVG Institutional Funds GmbH, having its registered office at The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main,

Germany, acting for the account of CEFI, a German real estate investment fund,

here duly represented by Mrs. Manuela MAUSEN, employee, residing professionally at 412F, route d’Esch, L-2086

Luxembourg, by virtue of a proxy dated September 14, 2012.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association of

a limited liability company, ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), to establish as follows:

Art. 1. A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these

articles and by the relevant legislation.

The name of the company is “IVG Cannon Street S.à r.l.” (the “Company”).

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the Company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

acquisition of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management,
the control and the development of such participating interests subject to the provisions of the German Investment Act
(Investmentgesetz – InvG).

In that framework, the Company shall not render any activities which differ from the activities which its shareholder

IVG Institutional Funds GmbH, Frankfurt am Main, Germany (“IIF”) may exercise for the open-ended real estate invest-
ment fund called CEFI (the “Fund”) in accordance with the InvG.

In this frame, the Company shall only acquire and hold certain assets (the “Eligible Assets”) as set out below:
(a) residential real estate designated for tenanting, commercial real estate and mixed-use real estate;
(b) real estate under development if the approved construction plans satisfy the requirements mentioned under (a)

above and completion of the development can, under the prevailing circumstances, be expected within an appropriate
period of time;

(c) undeveloped real estate designated and suitable for a development in due course in accordance with (a) above;
(d) hereditary building rights (Erbbaurecht) subject to the conditions mentioned in (a) to (c) above;
(e) other real estate and hereditary building rights as well as ownership rights in condominium property, co-ownership

rights, hereditary building rights in condominium property and partial hereditary building rights if a long-term income can
reasonably be expected from the assets;

(f) interests in other property companies;
and any assets, that are necessary for the management of the Eligible Assets held by IIF on behalf of the Fund.
The Company may borrow funds in any form subject to the provisions of the InvG. Furthermore, the Company may

develop, promote, manage, lease and sell Eligible Assets located in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the Company is fixed at GBP 25,000,- (twenty-five thousand pound sterling) divided

into 1,000 (one thousand) corporate units with a nominal value of GBP 25.- (twenty-five pound sterling) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may

only be done in accordance with the law on commercial companies. Any kind of disposition (Verfügung) of the Company’s
shares owned by IIF, including the transfer of such shares, is subject to the approval of the Fund’s custodian bank.

123794

L

U X E M B O U R G

Art. 9. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the Company.

Art. 11. The Company will be managed by at least two managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties, the Company is in all circumstances committed by the signature of one manager in case there

are only two managers and by the joint signature of two managers in case of more than two managers.

In its current relations with the public administration, the Company is validly represented by one manager, whose

signature legally commits the Company.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on

commercial companies.

Art. 15. The business year begins on June 1 

st

 and ends on May 31 

st

 of the following year.

Art. 16. Every year on May 31 

st

 the annual accounts are drawn up by the managers and will be audited by an auditor;

the first annual accounts to be audited are the ones as of May 31 

st

 , 2013.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution

will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 19. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to

be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the Company shall exist as a single member

company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.

Art. 21. Any amendment of these articles and any disposition (Verfügung) of the Eligible Assets including sale and

encumbrances during the time of (direct or indirect) ownership of any of the Company shares by IIF requires the approval
of the Fund’s custodian bank.

Art. 22. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the Company and ends on May 31 

st

 , 2013.

<i>Subscription and Payment

The 1,000 (one thousand) corporate units have been subscribed to by the sole member IVG Institutional Funds GmbH,

having its registered office at The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany, acting for the account
of CEFI, a German real estate investment fund.

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the Company has now at its disposal the sum of

GBP 25,000.- (twenty five thousand pound sterling) as was certified to the notary executing this deed.

123795

L

U X E M B O U R G

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred and fifty Euros.

<i>Decisions taken by the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of

the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole member:

<i>First resolution

The appointed managers with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation are:
- Mr. Peter FEHR, fund manager, born on 18 October 1967 in Langenberg, now Velbert (Germany), residing profes-

sionally in The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany;

- Mr. Frank MÜLLER, lawyer, born on 31 December 1974 in Kaiserslautern (Germany), residing professionally in The

Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany;

- Mr. Osman SARITARLA, fund manager, born on 25 November 1977 in Recklinghausen (Germany), residing profes-

sionally in The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany.

The managers may appoint agents, fix their powers and competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period and may be re-elected.

<i>Second resolution

The Company's registered office is established at 24, avenue Emile Reuter, 2420 Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning.
The deed having been read to the proxy-holder of appearing party, known to the notary by their first and last name,

civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzwölf, den achtzehnten September;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

IVG Institutional Funds GmbH, mit Sitz in The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland,

handelnd für Rechnung des CEFI, ein deutsches Immobilien-Sondervermögen,

hier wirksam vertreten durch Frau Manuela MAUSEN, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in 412F, route d’Esch,

L-2086 Luxembourg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 14. September 2012.

Diese Vollmacht wird, nachdem sie durch die Bevollmächtige und den unterzeichneten Notar "ne varietur" gegenge-

zeichnet wurde, dieser Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt bleiben.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu

gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Die Unterzeichneten gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die durch diese Satzung sowie

die einschlägige Gesetzgebung geregelt wird.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „IVG Cannon Street S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“).

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft liegt in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Tätigkeiten auszuüben, welche direkt oder indirekt zum Erwerb von

Beteiligungen in jeglicher Form an beliebigen Unternehmen führen, sowie die Verwaltung, Leitung, Kontrolle und Ent-
wicklung dieser Beteiligungen; dies unterliegt den Bestimmungen des deutschen Investmentgesetzes („InvG“).

123796

L

U X E M B O U R G

In diesem Rahmen darf die Gesellschaft keine Tätigkeiten erbringen, die von denen abweichen, die IVG Institutional

Funds GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland (“IIF”) für das Immobilien-Sondervermögen CEFI (“Fonds”) gemäß dem
InvG ausüben darf.

In diesem Rahmen darf die Gesellschaft nur die folgenden Vermögensgegenstände erwerben und halten (“zulässige

Vermögensgegenstände”):

(a) Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke;
(b) Grundstücke im Zustand der Bebauung, wenn die genehmigte Bauplanung den unter (a) genannten Voraussetzungen

entspricht und nach den Umständen mit einem Abschluss der Bebauung in angemessener Zeit zu rechnen ist;

(c) unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung nach Maßgabe von (a) oben bestimmt und geeignet

sind;

(d) Erbbaurechte unter den Voraussetzungen von (a) bis (c) oben;
(e) andere Grundstücke und andere Erbbaurechte sowie Rechte in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums,

Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts, wenn hiervon ein dauernder Ertrag erwartet werden kann;

(f) Anteile an Immobilien-Gesellschaften;
und alle Gegenstände, die zur Bewirtschaftung der von IIF für Rechnung des Fonds gehaltenen zulässigen Vermögens-

gegenstände erforderlich sind.

Die Gesellschaft kann Kredite in jeglicher Form aufnehmen vorbehaltlich der Bestimmungen des InvG. Die Gesellschaft

darf außerdem im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland belegene zulässige Vermögensgegenstände entwickeln,
fördern, verwalten, vermieten und veräußern.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt GBP 25.000,- (fünfundzwanzigtausend Pfund Sterling) geteilt in 1.000 (ein tau-

send) Anteile zu je GBP 25,- (fünfundzwanzig Pfund Sterling).

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden unter den in Artikel 199 des Gesetzes

über Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 7. Jeder Anteil berechtigt den Anteilseigner zu einer proportionalen Beteiligung an den Aktiva und am Gewinn.

Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte

unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften. Jede Verfügung über einschließlich der Übertra-
gung der von IIF gehaltenen Anteile an der Gesellschaft bedarf der Zustimmung der Depotbank des Fonds.

Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigen-

tums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mindestens zwei Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen, geführt.

Diese werden von der Gesellschafterversammlung ernannt.

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft im Falle von zwei Geschäftsführern durch einen Geschäftsführer, im Falle

von mehr als zwei Geschäftsführern durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich vertreten.

Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Geschäftsführers rechts-

wirksam vertreten.

Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Die Anzahl seiner Stimmen entspricht

der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtswirksam
vertreten lassen.

Art. 14. Die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über Handelsgesellschaften sind für die Beschlüsse der Ge-

neralversammlung zu beachten.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai des darauffolgenden Jahres.

Art. 16. Am 31. Mai eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss, der von einem Abschlussprüfer

geprüft wird; der erste zu prüfende Jahresabschluss ist der zum 31. Mai 2013.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung besteht nicht mehr, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Restbetrag steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

123797

L

U X E M B O U R G

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. die Geschäftsführung stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschließlich der übertragenen Gewinne,
3.  die  Entscheidung  Vorschüsse  auf  Dividenden  zu  gewähren  wird  anlässlich  einer  außerordentlichen  Generalver-

sammlung der Gesellschafter gefasst,

4. die Auszahlung erfolgt sobald die Gesellschaft die Sicherheit hat, dass die Rechte der Gläubiger nicht beeinflusst

wurden.

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.

Art. 20. Wenn und solange ein Gesellschafter alle Anteile hält, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne

von Artikel 179 (2) des Gesetzes über Handelsgesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem Artikel 200-1 und 200-2
dieses Gesetzes Anwendung.

Art. 21. Jede Änderung dieser Satzung und jede Verfügung über zulässige Vermögensgegenstände einschließlich deren

Veräußerung und Belastung während der Zeit, in der IIF Anteile der Gesellschaft (direkt oder indirekt) hält, bedarf der
Zustimmung der Depotbank des Fonds.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, verweisen die Gesellschafter auf die einschlägigen

gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Mai 2013.

<i>Kapitalzeichnung - Einzahlung

Die 1.000 (ein tausend) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter IVG Institutional Funds GmbH, mit Sitz in

The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland, handelnd für Rechnung des CEFI, ein deutsches
Immobilien-Sondervermögen, gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von GBP 25.000,- (fünfundzwanzigtausend Pfund Sterling)

der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über Handelsgesellschaften

vom 18. September 1933 erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft  aus  Anlass  dieser  Urkunde  entstehen  und  für  die  sie  haftet,  wird  auf  ungefähr  neunhundertfünfzig  Euro
abgeschätzt.

<i>Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterin

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die vorgenannte erschienene Partei, welche das gesamte ge-

zeichnete Gesellschaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Es werden zu Geschäftsführern mit den in Artikel 11 der Satzung festgesetzten Befugnissen ernannt:
- Herr Peter FEHR, Fondsmanager, geboren am 18. Oktober 1967 in Langenberg, jetzt Velbert (Deutschland), mit

beruflicher Anschrift in The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland;

- Herr Frank MÜLLER, Rechtsanwalt, geboren am 31. Dezember 1974 in Kaiserslautern (Deutschland), mit beruflicher

Anschrift in The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland;

- Herr Osman SARITARLA, Fondsmanager, geboren am 25. November 1977 in Recklinghausen (Deutschland), mit

beruflicher Anschrift in The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland.

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Verantwortlichkeiten festlegen und sie

abberufen.

Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig; die Geschäftsführer können wieder ernannt werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in 24, avenue Emile Reuter, 2420 Luxemburg.

123798

L

U X E M B O U R G

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Person, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird
die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienene Person, dem instrumentierenden

Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar,
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. MAUSEN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2012. LAC/2012/43711. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 25 septembre 2012.

Référence de publication: 2012124173/272.
(120165364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 148.127.

In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of September.
Before Us, Maître Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

Invesco European Hotel Real Estate Fund, a société d'investissement à capital variable, incorporated under the laws

of Luxembourg, having its registered office at 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and entered in the Trade
and Companies Register in Luxembourg, Section B, under number B 116.664, being the sole shareholder of Invesco
European Hotel Real Estate IV S.à r.l.;

here represented by Nadja Zimmer, Corporate Secretary, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on 06 September 2012. The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of Invesco European Hotel
Real Estate IV S.à r.l., has requested the undersigned notary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l., a limited liability company

(société à responsabilité limiteé) incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 37A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, having a share capital of EUR 811,100, incorporated by a deed of the notary Anja Holtz,
residing in Luxembourg, on 1 July 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1929
on 3 October 2009 (the 'Mémorial C'), and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section
B, under number B 148.127 (the'Company'). The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant
to a deed of Maitre Martine Schaeffer, residing in Luxembourg, dated 27 

th

 May 2011, published in the Memorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 1754 of 2 

nd

 August 2011;

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company's subscribed capital by an amount of two hundred fourteen thousand four hundred Euro

(EUR 214,400) and to issue eight thousand five hundred seventy-six (8,576) new shares, each share with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitlement
to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on the proposed share capital increase.

2. To accept the subscription of eight thousand five hundred seventy-six (8,576) shares with a par value of twenty-five

Euro (EUR 25) each by Invesco European Hotel Real Estate Fund and to accept payment by contribution in cash (the
'Contribution')

3. To authorise Ms. Nadja Zimmer or any other employee of Invesco Real Estate Management S.à r.l. to state the

abovementioned capital increase before a Luxembourg notary, inter alia to amend the first paragraph of article 5 of the
articles of association of the Company, and

4. To authorize Ms. Nadja Zimmer or any other employee of Invesco Real Estate Management S.à r.l. to record the

capital increase in the share register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the
Luxembourg Trade and Companies Register and the Mémorial C, with power to sign any documents, delegate under her

123799

L

U X E M B O U R G

own responsibility the present power of attorney to another representative, consent to the above on behalf of the
principal and, in general, do whatever seems appropriate or useful.

<i>First resolution

The sole shareholder decided to increase the issued share capital of the Company from eight hundred eleven thousand

one hundred Euro (EUR 811,100) to one million twenty-five thousand five hundred Euro (EUR 1,025,500),

by the issue of eight thousand five hundred seventy-six (8,576) new shares with a nominal value of twenty-five Euro

(EUR 25) each against the contribution in cash of two hundred fourteen thousand four hundred Euro (EUR 214,400).

<i>Subscription and Payment

All new shares will be subscribed by the sole shareholder of the Company. The payment has been proved to the notary

by a bank certificate which has been accepted by the undersigned.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company.

The first paragraph of article 5 of the articles of association shall now read as follows:

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at one million twenty-five thousand five hundred Euro (EUR

1,025,500) divided into forty-one thousand twenty (41,020) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to authorize Ms. Nadja Zimmer or any other employee of Invesco Real Estate Mana-

gement S.á r.l. to record the capital increase in the share register of the Company and to accomplish any necessary
formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the Memorial C with power to sign any
documents, delegate under her own responsibility the present power of attorney to another representative, consent to
the above on behalf of the principal and, in general, do whatever seems appropriate or useful.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document, are estimated at approximately EUR 1500.

The undersigned notary who understands English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a German version, on request of the same person and in case of any
differences between the English and the German text, the English text will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Texts:

Im Jahre zweitausendundzwölf, am zwölften September.
Vor der unterzeichnenden Notarin Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Invesco European Hotel Real Estate Fund, eine société d'investissement à capital variable, gegründet nach luxembur-

gischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, eingetragen im luxemburgischen
Handels- und Gesellschaftsregiert unter der Nummer B 116.664, ist der alleinige Gesellschafter der Invesco European
Hotel Real Estate IV S.à r.l.

Vertreten durch Frau Nadja Zimmer, Corporate Secretary, mit Geschäftsadresse in 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxemburg, durch Vollmacht vom 06. September 2012.

Die Erschienene, die im Namen des alleinigen Gesellschafters der Invesco European Hotel Real Estáte IV S.á r.l. handelt,

bittet die Notarin folgendes festzuhalten:

Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter der Invesco European Hotel Real Éstate IV S.á r.l., eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung (société á responsabilité limitée), gegründet nach luxemburgischen Recht, mit Gesell-
schaftssitz in 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 811,100, am
1. Juli 2009 von Frau Anja Holtz, tätig in Luxembourg, gegründet, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1929 am 3.
Oktober 2009, und eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 148.127
(die ,Gesellschaft'). Die Satzung wurde das letzte Mal abgeändert durch Urkunde der Notarin Martine Schaeffer, mit
Amstsitz in Luxembourg, am 27. Mai 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétes et Associations n° 1754
vom 2. August 2011

Die Erschienene, vertreten wie oben erwähnt, gibt an, über die folgenden Beschlüsse der Agenda informiert zu sein:

123800

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda:

1.  Erhöhung  des  Stammkapitals  der  Gesellschaft  um  zweihundertvierzehntausendvierhundert  Euro  (EUR  214,400)

durch Ausgabe von achttausendfünfhundertsechsundsiebzig (8,576) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25). Die Anteile haben dieselben Rechte und Privilegien wie die vorherigen Anteile und sind ab dem
Tag des Gesellschafterbeschlusses, der über die Kapitalerhöhung bestimmt, zur Dividende berechtigt.

2. Genehmigung der Zeichnung von achttausendfünfhundertsechsundsiebzig (8,576) Anteilen mit einem Nennwert von

je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) durch Invesco European Hotel Real Estate Fund und die Genehmigung der Zahlung der
Anteile durch Bareinlage (die ,Bareinlage').

3. Beauftragung von Frau Nadja Zimmer oder jedem anderen Mitarbeiter der Invesco Real Estate Management S.á r.l.

diese Kapitalerhöhung vor der Notarin zu beantragen und somit den ersten Paragraph des Artikel 5 der Statuten der
Gesellschaft zu ändern, und

4. Beauftragung von Frau Nadja Zimmer oder jedem anderen Mitarbeiter der Invesco Real Estate Management S.á r.l.

den Beschluss über die Kapitalerhöhung im Anteilsregister der Gesellschaft zu dokumentieren, sowie alle notwendigen
Formalitäten im Zusammenhang mit dem luxemburgischen Firmen- und Handelsregister und dem Mémorial C zu veran-
lassen.  Die  Vollmacht  erstreckt  sich  auf  die  Unterzeichnung  aller  notwendigen  Dokumente.  Die  Vollmacht  kann
eigenverantwortlich und im Sinne des oben genannten an Dritte weitergegeben werden, im Allgemeinen ist die Bevoll-
mächtigte zu jeder Handlung, die angemessen und hilfreich ist, bevollmächtigt.

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt das Stammkapital der Gesellschaft von achthundertelftausendeinhundert Euro

(EUR 811,100) auf eine Million fünfundzwanzigtausendfünfhundert Euro (EUR 1,025,500) zu erhöhen,

durch  Ausgabe  von  achttausendfünfhundertsechsundsiebzig  (8,576)  neuen  Anteilen  mit  einen  Nominalwert  von  je

fünfundzwanzig Euro (EUR 25) gegen Bareinlage von zweihundertvierzehntausendvierhundert Euro (EUR 214,400).

<i>Zeichnung und Zahlung

Alle neuen Anteile werden vom alleinigen Gesellschafter gezeichnet. Die Zahlung wurde der Notarin durch ein Bank-

zertifikat nachgewiesen, welches die Notarin akzeptierte.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den ersten Paragraph des 5. Artikels der Satzung der Gesellschaft zu ändern.

Der erste Paragraph des 5. Artikels der Satzung soll wie folgt lauten:

Art.  5.  Das  Stammkapital  der  Gesellschaft  beträgt  eine  Million  fünfundzwanzigtausendfünfhundert  Euro  (EUR

1,025,500) geteilt in einundvierzigtausendzwanzig (41,020) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR
25).

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter hat beschlossen Frau Nadja Zimmer oder jeden Mitarbeiter der Invesco Real Estate Ma-

nagement S.à r.l. zu bevollmächtigen die Kapitalerhöhung im Anteilsregister der Gesellschaft zu dokumentieren, sowie
alle notwendigen Formalitäten im Zusammenhang mit dem luxemburgischen Firmen- und Handelsregister und dem Mé-
morial  C  zu  veranlassen.  Die  Vollmacht  erstreckt  sich  auf  die  Unterzeichnung  aller  notwendigen  Dokumente.  Die
Vollmacht kann eigenverantwortlich und im Sinne des oben genannten an Dritte weitergegeben werden, im Allgemeinen
ist die Bevollmächtigte zu jeder Handlung, die angemessen und hilfreich ist, bevollmächtigt.

<i>Kosten

Sämtliche Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren, welche der Gesellschaft erwachsen, werden auf EUR 1500

geschätzt.

Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxembourg ausgestellt, an dem zu Beginn des Do-

kumentes aufgeführten Tag.

Nachdem das Dokument der erschienen Person vorgelegt wurde, hat die Bevollmächtigte das vorliegende Protokoll

zusammen mit der Notarin unterzeichnet.

Signé: N. Zimmer et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43537. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

123801

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Référence de publication: 2012124167/147.
(120165398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Legacy Pharmaceuticals International Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 150.220.

In the year two thousand and twelve,
on the twenty-eighth day of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SAN EM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

Legacy Pharmaceuticals International, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the

State of Delaware, U.S.A., having its registered office at c/o Legacy Pharmaceuticals US, Inc., 959 South Coast Drive, Suite
325, Costa Mesa, California, U.S.A., and registered with the Office of the Secretary of State of the State of Delaware
under number 4350069,

here represented by Mr. François Deprez, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23

August 2012.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder entitled to vote of Legacy Pharmaceuticals International Holdings (Lu-

xembourg)  S.à  r.l.  (hereinafter  the  "Company"),  a  société  à  responsabilité  limitée,  having  its  registered  office  at  65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 150.220, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 18 December 2009,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 169, dated 27 January 2010. The articles of
association of the Company have not been amended since then.

The appearing party required the notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to reduce the subscribed corporate capital of the Company by one thousand US dollars

(USD 1,000.-) in order to reduce it from its present amount of one hundred ninety-nine thousand US dollars (USD
199,000.-) to one hundred ninety-eight thousand US dollars (USD 198,000.-) by cancellation of the one thousand (1,000)
Class I Shares of a par value of one US dollar (USD 1.-) each that are temporarily held by the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting decides to amend article 6 of the Company's articles

of incorporation, which article shall henceforth read as follows:

Art. 6. The Company's share capital is set at one hundred and ninety-eight thousand US dollars US (USD 198,000-)

represented by one hundred and ninety thousand (190,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), one thousand (1,000)
Class A Shares, one thousand (1,000) Class B Shares, one thousand (1,000) Class C Shares, one thousand (1,000) Class
D Shares, one thousand (1,000) Class E Shares, one thousand (1,000) Class F Shares, one thousand (1,000) Class G Shares
and one thousand (1,000) Class H Shares with a par value of one US dollar (USD 1.00) each.

Any reference made herein to "share" shall be construed as a reference to Ordinary Shares and/or Class A Shares

and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or Class D Shares and/or Class E Shares and/or Class F Shares and/or
Class G Shares and/or Class H Shares, depending on the context and as applicable.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

<i>Third resolution

To the extent required, the general meeting decides to confer all powers to the Company's board of managers to

execute, for and on behalf of the Company, all documents, agreements, certificates, instruments and do everything ne-
cessary in connection with the cancellation of the shares.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

partiy, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the said proxyholder of the person

appearing signed together with the notary, the present original deed.

123802

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Legacy Pharmaceuticals International, LLC, une limited liability company constituée et régie selon les lois de l'Etat du

Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social à c/o Legacy Pharmaceuticals US, Inc., 959 South Coast Drive, Suite 325,
Costa Mesa, California, Etats-Unis, enregistrée auprès du l'Office of the Secretary of State of the State of Delaware sous
le numéro 4350069,

ici représentée par M. François Deprez, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée le 23 août 2012.

La procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est le seul associé ayant droit de vote de Legacy Pharmaceuticals International Holdings

(Luxembourg) S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 65, boulevard
Grande-Duchesse  Charlotte,  L-1331  Luxembourg,  enregistrée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg sous le numéro B 150.220, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 18 décembre
2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1119, daté du 27 janvier 2010. Les statuts de la
Société n'ont pas encore été modifiés depuis lors.

La partie comparante requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société de mille dollars US (USD 1.000,-) afin de le réduire

de son montant actuel de cent quatre-vingt-dix-neuf mille dollars US (USD 199.000,-) à cent quatre-vingt-dix-huit mille
dollars US (USD 198.000,-) par l'annulation de mille (1.000,-) parts sociales de Catégorie I d'une valeur nominale d'un
dollar US (USD 1,-) chacune qui sont temporairement détenues par la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura

désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille dollars US (USD 198.000,-) représenté

par cent quatre-vingt-dix mille (190.000) parts sociales ordinaires ("Parts Sociales Ordinaires"), mille (1.000) parts sociales
de Catégorie A, mille (1.000) parts sociales de Catégorie B, mille (1.000) parts sociales de Catégorie C, mille (1.000) parts
sociales de Catégorie D, mille (1.000) parts sociales de Catégorie E, mille (1.000) parts sociales de Catégorie F, mille
(1.000) parts sociales de Catégorie G et mille (1.000) parts sociales de Catégorie H d'une valeur d'un dollar US (USD
1,00) chacune.

Toute référence faite ci-après aux "parts sociales", devra être interprétée comme incluant les Parts Sociales Ordinaires,

et/ou parts sociales de Catégorie A, et/ou parts sociales de Catégorie B, et/ou parts sociales de Catégorie C, et/ou parts
sociales de Catégorie D, et/ou parts sociales de Catégorie E, et/ou parts sociales de Catégorie F, et/ou parts sociales de
Catégorie G, et/ou parts sociales de Catégorie H, en fonction du contexte et dans la mesure applicable.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

<i>Troisième résolution

Dans le mesure requise, l'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société aux

fins de signer, au nom et pour le compte de la Société, tout document, acte, contrat, certificat et instrument et de prendre
toute mesure nécessaire en rapport avec l'annulation des parts sociales.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: F. DEPREZ, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 septembre 2012. Relation: EAC/2012/11467. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012124188/106.
(120165577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

123803

L

U X E M B O U R G

Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 153.881.

In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of September,
Before Us, Maître Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)

THERE APPEARED:

Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 37A, Avenue J.F. Kennedy, L -1855 Luxembourg, and entered
in the Trade and Companies Register in Luxembourg, Section B, under number B148127, being the sole shareholder of
Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l.

Hereby represented by Ms. Nadja Zimmer, Corporate Secretary, professionally residing in Luxembourg, by virtue of

a proxy given on 04 September 2012.

The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l., has requested

the undersigned notary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l., a limited liability company

(société à responsabilité limitée) incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 37A, Avenue
J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg, having a share capital of EUR 3,186,533, incorporated by a deed of the notary Martine
Schaeffer, residing in Luxembourg, on 24 June 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number  1622  on  10  August  2010  (the  'Memorial  C'),  and  entered  in  the  Register  of  Commerce  and  Companies  in
Luxembourg, Section B, under number B153881 (the 'Company'). The articles of incorporation have been amended for
the last time pursuant to a deed of Maitre Martine Schaeffer, residing in Luxembourg, dated 25th May 2010, published in
the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1760 of 3rd August 2010;

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To increase the Company's subscribed capital by an amount of one million four hundred twenty-nine thousand three

hundred and twelve Euro (EUR 1,429,312) and to issue one million four hundred twenty-nine thousand three hundred
and twelve (1,429,312) new shares, each share with a par value of one Euro (EUR 1), having the same rights and privileges
as those attached to the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder
resolving on the proposed share capital increase.

2. To accept the subscription of one million four hundred twenty-nine thousand three hundred and twelve (1,429,312)

shares with a par value of one Euro (EUR 1) each by Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l. and to accept payment
in full of each of these shares by a contribution in kind (the 'Contribution')

3. To authorise Ms. Nadja Zimmer or any other employee of Invesco Real Estate Management S.à r.l. to state the

abovementioned capital increase before a Luxembourg notary, inter alia to amend the first paragraph of article 5 of the
articles of association of the Company, and

4. To authorize Ms. Nadja Zimmer or any other employee of Invesco Real Estate Management S.à r.l. to record the

capital increase in the share register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the
Luxembourg Trade and Companies Register and the Mémorial C, with power to sign any documents, delegate under her
own responsibility the present power of attorney to another representative, consent to the above on behalf of the
principal and, in general, do whatever seems appropriate or useful.

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company's subscribed capital by an amount of one million four hundred

twenty-nine thousand three hundred and twelve Euro (EUR 1,429,312),

so as to raise it from its current amount of three million one hundred eighty-six thousand five hundred thirty-three

Euro (EUR 3,186,533) divided into three million one hundred eighty-six thousand five hundred thirty-three (3,186,533)
shares, each share with a par value of one Euro (EUR 1),

to four million six hundred fifteen thousand eight hundred forty-five Euro (EUR 4,615,845) divided into four million

six hundred fifteen thousand eight hundred forty-five (4,615,845) shares, each share, with a par value of one Euro (EUR
1),

and to issue one million four hundred twenty-nine thousand three hundred twelve (1,429,312) new shares so as to

raise the number of shares from three million one hundred eighty-six thousand five hundred thirty-three (3,186,533)
shares to four million six hundred fifteen thousand eight hundred forty-five (4,615,845) shares, each share with a par value
of one Euro (EUR 1), having the same rights and privileges as those attached to the existing share and entitlement to
dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on the proposed capital increase.

123804

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and Payment

Thereupon appeared Ms. Nadja Zimmer, Corporate Secretary, residing professionally in Luxembourg, in her capacity

as duly authorized attorney in fact of Invesco European Hotel Real Estate IV S.a r.l., by virtue of the proxy referred to
hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Invesco European Hotel Real Estate IV S.a

r.l. for one million four hundred twenty-nine thousand three hundred twelve (1,429,312) new shares so as to raise the
number of shares from three million one hundred eighty-six thousand five hundred thirty-three (3,186,533) shares to
four million six hundred fifteen thousand eight hundred forty-five (4,615,845) shares, each share with a par value of one
Euro (EUR 1 )

and to accept payment in full of each of these shares by the conversion into capital of a claim free of interest against

Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l. in the amount of eight hundred twenty-nine thousand three hundred and twelve
Euro (EUR 829,312) as well as a claim free of interest against Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l. in the amount of
six hundred thousand Euro (EUR 600,000). (the 'Contribution in Kind').

Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l. acting through its duly authorized attorney in fact declared that there

exists no impediment to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without any restriction or
limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

Proof of the existence and the ownership of Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l. of the Contribution in Kind

have been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to accept the subscription and payment in full of each of these shares by a contribution

in kind consisting in the Contribution in Kind and to allot one million four hundred twenty-nine thousand three hundred
twelve (1,429,312) new shares to Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l.

<i>Third Resolution

The sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company.

The first paragraph of article 5 of the articles of association shall now read as follows:

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at four million six hundred fifteen thousand eight hundred forty-

five Euro (EUR 4,615,845) divided into four million six hundred fifteen thousand eight hundred forty-five (4,615,845)
shares with a par value of one Euro (EUR 1 ) each.

<i>Forth resolution

The sole shareholder resolves to authorize Ms. Nadja Zimmer or any other employee of Invesco Real Estate Mana-

gement S.à r.l. to record the capital increase in the share register of the Company and to accomplish any necessary
formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the Mémorial C with power to sign any
documents, delegate under her own responsibility the present power of attorney to another representative, consent to
the above on behalf of the principal and, in general, do whatever seems appropriate or useful.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document, are estimated at approximately EUR 3000.

The undersigned notary who understands English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a German version, on request of the same person and in case of any
differences between the English and the German text, the English text will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Texts:

Im Jahre zweitausendundzwölf, am zwölften September.
Vor der unterzeichnenden Notarin Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée) gegründet nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 37A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg,
eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregiert unter der Nummer B148127, ist der alleinige Gesell-
schafter der Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l.

123805

L

U X E M B O U R G

Vertreten durch Frau Nadja Zimmer, Corporate Secretary, mit Geschäftsadresse in 37A, Avenue J.F. Kennedy, L -

1855 Luxemburg, durch Vollmacht vom 4. September 2012.

Die Erschienene, die im Namen des alleinigen Gesellschafters der Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l. handelt,

bittet den Notar folgendes festzuhalten:

Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter der Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l., eine Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz
in 37A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 3,186,533, am 24.
Juni 2010 von Frau Notarin Martine Schaeffer, tätig in Luxembourg, gegründet, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
1622 am 10. August 2010, und eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer
B153881 (die,Gesellschaft').Die Satzung wurde das letzte Mal abgeändert durch Urkunde der Notarin Martine Schaeffer,
mit Amstsitz in Luxembourg, am 25. Mai 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétes et Associations n° 1760
vom 3. August 2010;

Die Erschienene, vertreten wie oben erwähnt, gibt an, über die folgenden Beschlüsse der Agenda informiert zu sein:

<i>Agenda

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einemillionvierhundertneunundzwanzigtausenddreihundertzwölf

Euro (EUR 1,429,312) durch Ausgabe von einemillionvierhundertneunundzwanzigtausenddreihundertzwölf (1,429,312)
neuen Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1). Die Anteile haben dieselben Rechte und Privilegien wie
die vorherigen Anteile und sind zur Dividende berechtigt ab dem Tag des Gesellschafterbeschlusses der über die Kapi-
talerhöhung bestimmt.

2. Genehmigung der Zeichnung von einemillionvierhundertneunund-zwanzigtausenddreihundertzwölf (1,429,312) An-

teilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) durch Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l. und die
Genehmigung der Zahlung der Anteile durch Sacheinlage (die,Sacheinlage').

3. Beauftragung von Frau Nadja Zimmer oder jedem anderen Mitarbeiter der Invesco Real Estate Management S.à r.l.

diese Kapitalerhöhung vor dem Notar zu beantragen und somit den ersten Paragraph des Artikel 5 der Statuten der
Gesellschaft zu ändern, und

4. Beauftragung von Frau Nadja Zimmer oder jedem anderen Mitarbeiter der Invesco Real Estate Management S.à r.l.

den Beschluss über die Kapitalerhöhung im Anteilsregister der Gesellschaft zu dokumentieren, sowie alle notwendigen
Formalitäten im Zusammenhang mit dem luxemburgischen Firmen-und Handelsregister und dem Memorial C zu veran-
lassen.  Die  Vollmacht  erstreckt  sich  auf  die  Unterzeichnung  aller  notwendigen  Dokumente.  Die  Vollmacht  kann
eigenverantwortlich und im Sinne des oben genannten an Dritte weitergegeben werden, im Allgemeinen ist die Bevoll-
mächtigte zu jeder Handlung, die angemessen und hilfreich ist, bevollmächtigt.

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt das Stammkapital der Gesellschaft um einemillionvierhundertneunundzwanzig-

tausenddreihundertzwölf  Euro  (EUR  1,429,312),  von  derzeitigen  dreimillioneneinhundertsechsundachtzigtausendfünf-
hundertdreiunddreißig Euro (EUR 3,186,533) aufgeteilt in dreimillioneneinhundertsechsundachtzigtausendfünfhundertd-
reiunddreißig (3,186,533) Anteile, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), auf viermillionensechshundertfünf-
zehntausendachthundertfünfundvierzig Euro (EUR 4,615,845) unterteilt in viermillionensechshundertfünfzehntausendach-
thundertfünfundvierzig (4,615,845) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1 ) zu erhöhen.

Es werden einemillionvierhundertneunundzwanzigtausenddreihundertzwölf (1,429,312) neue Anteile ausgegeben, was

die  derzeitige  Anzahl  der  Anteile  von  dreimillioneneinhundertsechsundachtzigtausendfünfhundertdreiunddreißig
(3,186,533)  auf  viermillionensechshundertfünfzehntausendachthundertfünfundvierzig  (4,615,845)  Anteile  mit  einem
Nennwert von einem Euro (EUR 1) erhöht. Die Anteile haben dieselben Rechte und Privilegien wie die vorherigen Anteile
und sind zur Dividende berechtigt ab dem Tag des Gesellschafterbeschlusses der über die Kapitalerhöhung bestimmt.

<i>Zeichnung und Zahlung

Hier erschien Frau Nadja Zimmer, Corporate Secretary, mit Geschäftssitz in Luxembourg, in Ihrer Funktion als Be-

vollmächtigte der Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l. bevollmächtigt wie oben beschrieben.

Die Erschienene gibt an im Namen und im Auftrag von Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l. für einemillion-

vierhundertneunund-zwanzigtausenddreihundertzwölf (1,429,312) neuer Anteile zu zeichnen,

um die Anzahl der Anteile von dreimillioneneinhundertsechs-undachtzigtausendfünfhundertdreiunddreißig (3,186,533)

auf viermillionensechshundertfünfzehntausendachthundertfünfundvierzig (4,615,845) mit einem Nennwert von einem Eu-
ro (EUR 1 ) zu erhöhen.

Die Zahlung der Anteile erfolgt durch Umwandlung eines Anspruches gegen die Invesco Vienna Hotel Investment S.à

r.l. auf Zahlung in Höhe von achthundertneunundzwanzigtausenddreihundertzwölf Euro (EUR 829,312) und in Höhe von
sechshunderttausend Euro (EUR 600,000) in Gesellschaftskapital. (die,Sachkapitalerhöhung')

Die im Namen der Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l. Handelnde erklärt, dass es keine Einschränkung

hinsichtlich der freien Übertragbarkeit des Sachkapitals an die Gesellschaft besteht. Klare Anweisung zur Anmeldung,
Registrierung und anderen notwendigen Formalitäten, um die Sachkapitalerhöhung durchzuführen, wurden erteilt.

123806

L

U X E M B O U R G

Dem Notar wurde bestätigt, dass das Sachkapital besteht und im Besitz von Invesco European Hotel Real Éstate IV

S.ä r.l. ist.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Zeichnung und die Zahlung der Anteile durch Kapitalerhöhung zu akzep-

tieren und einemillionvierhundertneunundzwanzigtausenddreihundertzwölf (1,429,312) neue Anteile an Invesco Euro-
pean Hotel Real Éstate IV S.ä r.l. auszugeben.

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den ersten Paragraph des 5. Artikels der Satzung der Gesellschaft zu ändern.

Der erste Paragraph des 5. Artikels der Satzung soll wie folgt lauten:

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt viermillionensechshundertfünfzehntausendachthundertfünfundvier-

zig  Euro  (EUR  4,615,845)  geteilt  in  viermillionensechshundertfünfzehntausendachthundertfünfundvierzig  (4,615,845)
Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1).

<i>Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter hat beschlossen Frau Nadja Zimmer oder jeden Mitarbeiter der Invesco Real Estate Ma-

nagement S.ä r.l. zu bevollmächtigen die Kapitalerhöhung im Anteilsregister der Gesellschaft zu dokumentieren, sowie
alle notwendigen Formalitäten im Zusammenhang mit dem luxemburgischen Firmen- und Handelsregister und dem Me-
morial  C  zu  veranlassen.  Die  Vollmacht  erstreckt  sich  auf  die  Unterzeichnung  aller  notwendigen  Dokumente.  Die
Vollmacht kann eigenverantwortlich und im Sinne des oben genannten an Dritte weitergegeben werden, im Allgemeinen
ist die Bevollmächtigte zur jeden Handlung, die angemessen und hilfreich ist, bevollmächtigt.

<i>Kosten

Sämtlich Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren, welche der Gesellschaft erwachsen, werden auf EUR 3000

geschätzt.

Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxembourg ausgestellt, an dem zu Beginn des Do-

kumentes aufgeführten Tag.

Nachdem das Dokument der erschienen Person vorgelegt wurde, hat die Bevollmächtigte das vorliegende Protokoll

zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: N. Zimmer et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43538. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 25 septembre 2012.

Référence de publication: 2012124156/204.
(120165400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.783.

In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of September,
Before Us, Maître Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)

THERE APPEARED:

Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 37A, Avenue J.F. Kennedy, L -1855 Luxembourg, and entered
in the Trade and Companies Register in Luxembourg, Section B, under number B142600, being the sole shareholder of
Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l.

Hereby represented by Ms. Nadja Zimmer, Corporate Secretary, professionally residing in Luxembourg, by virtue of

a proxy given on 05 September 2012.

The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l., has

requested the undersigned notary to document the following:

123807

L

U X E M B O U R G

The appearing party is the sole shareholder of Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l., a limited liability company

(société à responsabilité limitée) incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 37A, Avenue
J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg, having a share capital of EUR 4,861,000, incorporated by a deed of the notary Henri
Hellinckx, residing in Luxembourg, on 2 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 148 on 22 January 2009 (the 'Memorial C'), and entered in the Register of Commerce and Companies in
Luxembourg, Section B, under number B143783 (the 'Company'). The articles of incorporation have been amended for
the last time pursuant to a deed of Maitre Martine Schaeffer, residing in Luxembourg, dated 18 

th

 March 2010, published

in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1038 of 18 

th

 May 2010;

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To increase the Company's subscribed capital by an amount of seven hundred fifty thousand Euro (EUR 750,000)

and to issue thirty thousand (30,000) new shares, each share with a par value of twenty-five Euro (EUR 25), having the
same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the
decision of the sole shareholder resolving on the proposed share capital increase.

2. To accept the subscription of thirty thousand (30,000) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each

by Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l. and to accept payment in full of each of these shares by a contribution
in kind (the 'Contribution')

3. To authorise Ms. Nadja Zimmer or any other employee of Invesco Real Estate Management S.à r.l. to state the

abovementioned capital increase before a Luxembourg notary, inter alia to amend the first paragraph of article 5 of the
articles of association of the Company, and

4. To authorize Ms. Nadja Zimmer or any other employee of Invesco Real Estate Management S.à r.l. to record the

capital increase in the share register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the
Luxembourg Trade and Companies Register and the Mémorial C, with power to sign any documents, delegate under her
own responsibility the present power of attorney to another representative, consent to the above on behalf of the
principal and, in general, do whatever seems appropriate or useful.

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company's subscribed capital by an amount of seven hundred fifty

thousand Euro (EUR 750,000),

so as to raise it from its current amount of four million eight hundred sixty-one thousand Euro (EUR 4,861,000) divided

into one hundred ninety-four thousand four hundred forty (194,440) shares, each share with a par value of twenty-five
Euro (EUR 25),

to five million six hundred eleven thousand Euro (EUR 5,611,000) divided into two hundred twenty-four thousand

four hundred forty (224,440) shares, each share, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25),

and to issue thirty thousand (30,000) new shares so as to raise the number of shares from one hundred ninety-four

thousand four hundred forty (194,440) shares to two hundred twenty-four thousand four hundred forty 224,440) shares,
each share with a par value of twenty-five Euro (EUR 25), having the same rights and privileges as those attached to the
existing share and entitlement to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on the
proposed capital increase.

<i>Subscription and Payment

Thereupon appeared Ms. Nadja Zimmer, Corporate Secretary, residing professionally in Luxembourg, in her capacity

as duly authorized attorney in fact of Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l., by virtue of the proxy referred to
hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l.

for thirty thousand (30,000) new shares so as to raise the number of shares from one hundred ninety-four thousand four
hundred forty (194,440) shares to two hundred twenty-four thousand four hundred forty (224,440) shares, each share
with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) and to accept payment in full of each of these shares by the conversion
into capital of a claim against Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l. in the amount of seven hundred fifty thousand
Euro (EUR 750,000) (the 'Contribution in Kind').

Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l. acting through its duly authorized attorney in fact declared that there

exists no impediment to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without any restriction or
limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

Proof of the existence and the ownership of Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l. of the Contribution in Kind

have been given to the undersigned notary.

123808

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to accept the subscription and payment in full of each of these shares by a contribution

in kind consisting in the Contribution in Kind and to allot thirty thousand (30,000) new shares to Invesco European Hotel
Real Estate II S.à r.l.

<i>Third Resolution

The sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company.

The first paragraph of article 5 of the articles of association shall now read as follows:

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at five million six hundred eleven thousand Euro (EUR 5,611,000)

divided into two hundred twenty-four thousand four hundred forty (224,440) shares with a par value of twenty-five Euro
(EUR 25) each.

<i>Forth resolution

The sole shareholder resolves to authorize Ms. Nadja Zimmer or any other employee of Invesco Real Estate Mana-

gement S.à r.l. to record the capital increase in the share register of the Company and to accomplish any necessary
formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the Memorial C with power to sign any
documents, delegate under her own responsibility the present power of attorney to another representative, consent to
the above on behalf of the principal and, in general, do whatever seems appropriate or useful.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document, are estimated at approximately EUR 2200.

The undersigned notary who understands English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a German version, on request of the same person and in case of any
differences between the English and the German text, the English text will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Texts:

Im Jahre zweitausendundzwölf, am zwölften September,
Vor der unterzeichnenden Notarin Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée) gegründet nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 37A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg,
eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregiert unter der Nummer B 142600, ist der alleinige Ge-
sellschafter der Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l. Vertreten durch Frau Nadja Zimmer, Corporate Secretary,
mit Geschäftsadresse in 37A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg, durch Vollmacht vom 5. September 2012.

Die Erschienene, die im Namen des alleinigen Gesellschafters der Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l. handelt,

bittet den Notar folgendes festzuhalten:

Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter der Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l., eine Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz
in 37A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 4,861,000, am 2.
Dezember 2008 von Herrn Notar Henri Hellinckx, tätig in Luxembourg, gegründet, veröffentlicht im Mémorial C, Num-
mer 148 am 22. Januar 2009, und eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer
B143783 (die,Gesellschaft'). Die Satzung wurde das letzte Mal abgeändert durch Urkunde der Notarin Martine Schaeffer,
mit Amstsitz in Luxembourg, am 18. März 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétes et Associations n°
1038 vom 18. Mai 2010;

Die Erschienene, vertreten wie oben erwähnt, gibt an, über die folgenden Beschlüsse der Agenda informiert zu sein:

<i>Agenda

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 750,000) durch Ausgabe

von dreißigtausend (30,000) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25). Die Anteile haben
dieselben Rechte und Privilegien wie die vorherigen Anteile und sind ab dem Tag des Gesellschafterbeschlusses, der über
die Kapitalerhöhung bestimmt, zur Dividende berechtigt.

2. Genehmigung der Zeichnung von dreißigtausend (30,000) Anteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro

(EUR  25)  durch  Invesco  European  Hotel  Real  Estate  II  S.à  r.l.  und  die  Genehmigung  der  Zahlung  der  Anteile  durch
Sacheinlage (die,Sacheinlage').

123809

L

U X E M B O U R G

3. Beauftragung von Frau Nadja Zimmer oder jedem anderen Mitarbeiter der Invesco Real Estate Management S.à r.l.

diese Kapitalerhöhung vor dem Notar zu beantragen und somit den ersten Paragraph des Artikel 5 der Statuten der
Gesellschaft zu ändern, und

4. Beauftragung von Frau Nadja Zimmer oder jedem anderen Mitarbeiter der Invesco Real Estate Management S.à r.l.

den Beschluss über die Kapitalerhöhung im Anteilsregister der Gesellschaft zu dokumentieren, sowie alle notwendigen
Formalitäten im Zusammenhang mit dem luxemburgischen Firmen-und Handelsregister und dem Memorial C zu veran-
lassen.  Die  Vollmacht  erstreckt  sich  auf  die  Unterzeichnung  aller  notwendigen  Dokumente.  Die  Vollmacht  kann
eigenverantwortlich und im Sinne des oben genannten an Dritte weitergegeben werden, im Allgemeinen ist die Bevoll-
mächtigte zu jeder Handlung, die angemessen und hilfreich ist, bevollmächtigt.

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt das Stammkapital der Gesellschaft um siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR

750,000),

von  derzeitigen  viermilionachthunderteinundsechzigtausend  Euro  (EUR  4,861,000)  aufgeteilt  in  einhundertvierund-

neunzigtausend-vierhundertvierzig (194,440) Anteile, mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25),

auf fünfmilionsechshundertelftausend Euro (EUR 5,611,000) unterteilt in zweihundervierundzwanzigtausendvierhun-

dertvierzig (224,440) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) zu erhöhen.

Es werden dreißigtausend (30,000) neue Anteile ausgegeben, was die derzeitige Anzahl der Anteile von einhundert-

vierundneunzig-tausendvierhundertvierzig 

(194,440) 

auf 

zweihundertvierundzwanzig-tausendvierhundertvierzig

(224,440) Anteile mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) erhöht.

Die Anteile haben dieselben Rechte und Privilegien wie die vorherigen Anteile und sind ab dem Tag des Gesellschaf-

terbeschlusses, der über die Kapitalerhöhung bestimmt, zur Dividende berechtigt.

<i>Zeichnung und Zahlung

Hier erschien Frau Nadja Zimmer, Corporate Secretary, mit Geschäftssitz in Luxembourg, in Ihrer Funktion als Be-

vollmächtigte der Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l. bevollmächtigt wie oben beschrieben.

Die Erschienene gibt an im Namen und im Auftrag von Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l. für dreißigtausend

(30,000) neuer Anteile zu zeichnen, um die Anzahl der Anteile von einhundertvierundneunzigtausendvierhundertvierzig
(194,440) auf zweihundertvierundzwanzigtausendvierhundertvierzig (224,440) mit einem Nennwert von fünfundzwanzig
Euro (EUR 25) zu erhöhen.

Die Zahlung der Anteile erfolgt durch Umwandlung eines Anspruches gegen die Invesco The Hague Hotel Investment

S.à r.l. auf Zahlung in Höhe von siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 750,000) in Gesellschaftskapital. (die,Sachkapi-
talerhöhung')

Die im Namen der Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l. Handelnde erklärt, dass es keine Einschränkung

hinsichtlich der freien Übertragbarkeit des Sachkapitals an die Gesellschaft besteht. Klare Anweisung zur Anmeldung,
Registrierung und anderen notwendigen Formalitäten, um die Sachkapitalerhöhung durchzuführen, wurden erteilt.

Dem Notar wurde bestätigt, dass das Sachkapital besteht und im Besitz von Invesco European Hotel Real Estate II S.à

r.l. ist.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Zeichnung und die Zahlung der Anteile durch Kapitalerhöhung zu akzep-

tieren und dreißigtausend (30,000) neue Anteile an Invesco European Hotel Real Estate II S.à r.l. auszugeben.

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den ersten Paragraph des 5. Artikels der Satzung der Gesellschaft zu ändern.

Der erste Paragraph des 5. Artikels der Satzung soll wie folgt lauten:

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfmillionsechshundertelftausend Euro (EUR 5,611,000) geteilt in

zweihundertvierundzwanzigtausendvierhundertvierzig (224,440) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro
(EUR 25).

<i>Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter hat beschlossen Frau Nadja Zimmer oder jeden Mitarbeiter der Invesco Real Estate Ma-

nagement S.à r.l. zu bevollmächtigen die Kapitalerhöhung im Anteilsregister der Gesellschaft zu dokumentieren, sowie
alle notwendigen Formalitäten im Zusammenhang mit dem luxemburgischen Firmen- und Handelsregister und dem Me-
morial  C  zu  veranlassen.  Die  Vollmacht  erstreckt  sich  auf  die  Unterzeichnung  aller  notwendigen  Dokumente.  Die
Vollmacht kann eigenverantwortlich und im Sinne des oben genannten an Dritte weitergegeben werden, im Allgemeinen
ist die Bevollmächtigte zur jeden Handlung, die angemessen und hilfreich ist, bevollmächtigt.

123810

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten

Sämtlich Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren, welche der Gesellschaft erwachsen, werden auf EUR 2.200

geschätzt.

Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxembourg ausgestellt, an dem zu Beginn des Do-

kumentes aufgeführten Tag.

Nachdem das Dokument der erschienen Person vorgelegt wurde, hat die Bevollmächtigte das vorliegende Protokoll

zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: N. Zimmer et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43540. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 25 septembre 2012.

Référence de publication: 2012124155/195.
(120165399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Kermorio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 171.565.

STATUTS

L'an deux mil douze, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois P3M Holding S.A., établie et ayant son siège social au 16, rue de Nassau,

L-2213 Luxembourg, constituée en date du 25 juillet 2012 par le notaire instrumentaire et en cours d'enregistrement
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ici représentée par Monsieur Marc Van Hoek, expert-
comptable, domicilié professionnellement au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
le 14 septembre 2012;

2) Monsieur Jean-Louis VERLAINE, dirigeant de société, né le 10 octobre 1972 à Paris, demeurant à 22, rue de Lesseps,

F-75020 Paris, ici représentée Monsieur Marc Van Hoek, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 23 août
2012.

Lesquelles procurations, après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles

vont constituer entre elles:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "Kermorio S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet le développement, l'achat, l'exploitation et la vente de tous droits intellectuels liés aux

droits d'auteurs (informatiques et littéraires), brevets d'inventions, marques de fabrique ou de commerce et noms de
domaine.

La Société a également pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la

123811

L

U X E M B O U R G

création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".

La Société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en

valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3 . Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille cent (3.100) actions

d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de

l'administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures à Lu-

xembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

123812

L

U X E M B O U R G

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.

<i>Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) P3M Holding S.A., préqualifiée,
Deux mille sept cent vingt-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.728

2) Monsieur Jean-Louis Verlaine, préqualifié,
Trois cent soixante-douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

372

Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (31.000,-

EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents (1.500,-)
euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l'instant, les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un(1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Madame Annie FALQUERHO-STECK, employée privée, née le 20 septembre 1967 à Thionville, France, domiciliée

au 15, rue Vignon, F-75008 Paris.

b) P3M Holding S.A., établie et ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en cours d'enregis-

trement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ayant comme représentant permanent est
Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;

c) Monsieur Jean-Louis VERLAINE, prénommé;
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
LUXFIDUCIA, S.àr.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.529.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2017.

5) Le siège de la Société est fixé à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

123813

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: M. Van Hoek et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2012. LAC/2012/43319. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Référence de publication: 2012124178/150.
(120165484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

RL Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 145.057.

L'an deux mille douze, le vingt-sept août.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Madame Orianne COLLINS, administrateur de société, demeurant 1, Place du Marché 1260 Nyon (Suisse),
ici représentée par Monsieur Eric NOLEN, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 2 juillet 2012.
Laquelle  procuration,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"par  le  mandataire  de  la  partie  comparante  et  le  notaire

soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle comparante est l'actionnaire unique de la société "RL Group S.A.", (la "Société") une société anonyme établie

et ayant son siège social au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et numéro 145 057, constituée selon un acte notarié reçu par le notaire
soussigné en date du 30 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 649 du 25
mars 2009.

Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis la date de sa création.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant d'un million d'euros

(1'000'000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50'000.- EUR) divisé en cinq mille
(5'000) actions sans désignation de valeur nominale à un montant d'un million cinquante mille euros (1'050'000.- EUR),
lequel sera divisé, après cette augmentation de capital réalisé, en cent cinq mille (105'000) actions sans désignation de
valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide de créer et d'émettre cent mille (1000'000) actions nouvelles ordinaires sans désignation

de valeur nominale, chaque action nouvelle avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant
droit à des dividendes à partir du jour de la constatation des présentes résolutions.

<i>Souscription - Libération

Les cent mille (1000'000) actions nouvelles émises présentement par la Société ont été entièrement souscrites par la

personne comparante, Madame Orianne COLLINS, en sa qualité d'actionnaire unique et intégralement libérées par elle-
même par un apport en numéraire pour un montant d'un million d'euros (1'000'000.- EUR).

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport intégralement libéré en numéraire ont été

présentés au notaire soussigné qui les constate expressément.

<i>Troisième résolution

Afin de refléter ladite augmentation de capital ci-avant réalisée, l'actionnaire unique décide de modifier l'article 5, des

statuts de la Société lequel aura désormais la nouvelle teneur qui suit:

Art. 5. Le capital social est fixé à un million cinquante mille euros (1'050'000.- EUR) représenté par cent cinq mille

(105'000) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale.

123814

L

U X E M B O U R G

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi."

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge en raison des présentes s'élève à environ deux mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, celui-ci a signé avec Nous

notaire soussigné le présent acte.

Signé: E. NOLEN, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 août 2012. Relation: EAC/2012/11303. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012124342/60.
(120165566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Immo &amp; Business Consult S.à r.l., en abrégé I.B.C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5775 Weiler-la-Tour, 32, rue Emile Marx.

R.C.S. Luxembourg B 60.368.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124161/9.
(120165319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Immoffice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 156.002.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2012124162/11.
(120165465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

AV Chartering SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 83.238.

<i>Extrait de la résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 17 septembre 2012

1. Le mandat de l'Administrateur-délégué étant venu à échéance, le Conseil a décidé de réélire à la fonction d'Admi-

nistrateur-délégué, la personne suivante:

MAGELLAN MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 89A,

Parc d'Activités de Capellen, L-8308 Capellen représentée par Monsieur Bezzina Arnaud, né le 29 novembre 1974 à
Nancy (France) et demeurant professionnellement à L-8308 Capellen, 89A, Parc d'Activités de Capellen.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2017.

<i>Extrait de la résolution du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, en date

<i>du 17 septembre 2012

1. Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes

suivantes:

123815

L

U X E M B O U R G

MAGELLAN MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 89A,

Parc d'Activités de Capellen, L-8308 Capellen représentée par Monsieur Bezzina Arnaud, né le 29 novembre 1974 à
Nancy (France) et demeurant professionnellement à L-8308 Capellen, 89A, Parc d'Activités de Capellen.

Monsieur Bezzina Arnaud, né le 29 novembre 1974 à Nancy (France) et demeurant professionnellement à L-8308

Capellen, 89A, Parc d'Activités de Capellen.

Monsieur Ramon Jean-Claude, né le 10 janvier 1944 à Carcassonne (France) et demeurant professionnellement à

L-8308 Capellen, 89A, Parc d'Activités de Capellen.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2017.
2. Le mandat du Commissaire aux comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux

Comptes la personne suivante:

EUROPEAN FIDUCIARY OF LUXEMBOURG S.A R.L. (EFL), ayant son siège social au 2, Rue des Dahlias, L-1411

Luxembourg représentée par Monsieur Troisfontaines John, né le 16 mars 1974 à Verviers (Belgique) et demeurant
professionnellement au 2, Rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2017.

Pour extrait sincère et conforme
AV CHARTERING SA

Référence de publication: 2012126237/34.
(120167299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.

Information Business Integration A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 38.854.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’administration du 21 septembre 2012

Est élu Président du Conseil d’administration Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant pro-

fessionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg,

qui déclare accepter.
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d’administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 25 septembre 2012.

Référence de publication: 2012124163/16.
(120165761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 76.569.

<i>Auszug des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 05.09.2012

Die Generalversammlung der Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft fasste folgenden Beschluss:
Als Wirtschaftsprüfer wurde BDO Compagnie Fiduciaire bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013 bestellt.
Référence de publication: 2012124164/10.
(120165348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Intertrade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 106.709.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124166/9.
(120165341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

123816

L

U X E M B O U R G

NGR Consulting S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 74.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 102.357.

<i>Extrait du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale du 9 mars 2012

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de:
prendre acte de la nouvelle répartition des parts sociales de la Société suite au contrat de cession de parts signé entre

Monsieur Julien Palissot et la société Ambrinvest S.A..

Suite à la cession des parts, les parts sociales sont réparties comme il suit:

NOM

Nombres

de Parts

sociales

Monsieur Joubert Vincent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

293

Monsieur Granboulan Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

Monsieur Marq Jean-Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

Madame Cremer Nathalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

La société Ambrinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2102

La société Kaizen Invest S.A.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

La société Beoogo S.A.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Monsieur Yazi Abdelaziz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

TOTAL: DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.960

Pour copie conforme
Lionel Lider / Emmanuel Lebeau
<i>Le secrétaire / Le Président

Référence de publication: 2012124269/28.
(120165888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Investissements Euro Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 85.820.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Référence de publication: 2012124168/10.
(120165433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Iron Paradox S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2268 Luxembourg, 30, rue d'Orchimont.

R.C.S. Luxembourg B 69.172.

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 faisant l’objet du rectificatif ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg le 10 juillet 2012 sous la référence L120117061.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124169/12.
(120165944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

123817

L

U X E M B O U R G

Sea Dream S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 82.191.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 avril 2012 que:
Madame Carine BITTLER, employée privée, née le 10.10.1949 à Horgenzell (Allemagne), demeurant à L-2613 Luxem-

bourg, 1, Place du Théâtre, a été renommée administrateur de la société avec droit de signature individuelle jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2016.

INTEGRAL MARITIME SOLUTIONS (IMS) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg 1, Place du

Théâtre,  immatriculée  au  RCSL  sous  le  numéro  B147396,  représentée  par  Monsieur  Jean-Pierre  VERNIER,  né  le
02.10.1952 à Nantes, demeurant à L-2210 Luxembourg, 84, boulevard Napoléon I 

er

 , a été renommé administrateur et

administrateur-délégué de la société avec droit de signature individuelle jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'exer-
cice 2016.

Monsieur André HARPES, juriste, né le 17/03/1960 à Luxembourg, demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, Place du

Théâtre, est renommé administrateur de la société avec droit de signature individuelle jusqu'à l'assemblée générale or-
dinaire de l'exercice 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Le domiciliataire

Référence de publication: 2012125560/23.
(120166951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.

Island Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 97.403.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124170/9.
(120165573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

ISOS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 19, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 44.520.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2012.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012124171/12.
(120165506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Prim Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 171.572.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the twelfth day of September.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

"Psons Limited", having its registered office at 22/F, Hong Kong Diamond Exchange Building, 8-10 Duddell Street,

Central, Hong Kong registered with Hong Kong Companies Registry number 0909863,

123818

L

U X E M B O U R G

represented by Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally L-2740 Luxembourg, by virtue of proxy given

under private seal on August 2 

nd

 , 2012.

Such proxy after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party has requested the notary to state the following Articles of Incorporation of a société anonyme

which they declare to be incorporated:

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation (the Articles)

of a company, which it declares to establish as follows:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of "PRIM HOLDINGS".

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the sole director or

the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of
any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprise and

may lend its assistance to such company through loans, guarantees or otherwise. It may lend or borrow without interest,
issue bonds and other acknowledgments of debts.

It can achieve its purpose directly or indirectly for itself or for third parties, alone or in combination by performing

any operation which promotes its purpose or that of companies in which it holds directly or indirectly interests.

Generally, the company may take any controlling or monitoring and perform any operations that may have seemed

useful in carrying out its purpose and aim.

Title II. - Share capital, Shares

Art. 5. The Company has an issued capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into thirty-one thousand

(31,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-).

The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of shareholders, with

the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The Company may issue multiple share certificates.

Title III. - Management

Art. 6. The corporation shall in case there is only one shareholder be managed by a sole director or by a board of

directors, or in case there are two or more shareholders, be managed by a board of directors composed of at least three
members, being either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general
meeting of shareholders. The sole director or the board of directors may be re-elected and may be removed at any time
by a general meeting of shareholders.

Art. 7. In case a board of directors exists, the board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors. The board of directors can only validly debate and take decisions if a majority of its members is
present or represented by proxies and provided that at least two directors are physically present. Any decisions by the
board of directors shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the directors
present at the meeting.

One or more directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

The board of directors may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,

telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving

123819

L

U X E M B O U R G

evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of directors.

Art. 8. The sole director or if applicable the board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders,

shall fall within the competence of the board of directors.

The sole director or if applicable the board of directors is authorized to decide and to distribute interim dividends at

any time, under the following conditions:

1. The sole director or if applicable the board of directors will prepare interim statement of accounts which are the

basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the signature of the sole director or in case more

directors are appointed by the joint signature of any two directors or by the sole signature of the managing director
(administrateur-délégué), provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in
the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors (administrateurs-délégués).

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the March 20 

th

 at 2:00 p.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the

general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1 

st

 of January and shall terminate on the 31 

st

 of

December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve;  such  appropriation  shall  cease  when  the  legal  reserve  amounts  to  ten  per  cent  (10%)  of  the  capital  of  the
corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will

be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10 

th

 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

123820

L

U X E M B O U R G

<i>Transitory provisions

1.- The first business year begins today and ends on 31 December 2013.
2.- The first annual General Meeting will be held in 2014.

<i>Subscription and liberation

The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribed

to thirty-one thousand (31.000) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been paid up by the sole Shareholder to an extent of 100% (one hundred per cent) by payment

in cash so that the sum of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) paid by the sole shareholder is from now on at the
free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be born by the Company as a

result of its formation are estimated at one thousand two hundred fifty euros (EUR 1,250.).

<i>Decisions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the appearing party, represented as stated above, representing

the whole of the share capital, considering herself to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and
unanimously passed the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at one (1) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following person is appointed director:
Mr. Pradeep AGARWAL, Entrepreneur, Plot No 4, Villa B, Pochkhanwala RD, Near Godrej Tower, Worli, Mumbai

4000030, India

His term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2018.
3. The following person is appointed statutory auditor:
PKF  Abax  Audit,  6,  Place  de  Nancy  L-2212  Luxembourg,  registered  with  Luxembourg  Companies  register  under

number B 142.867

The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2018.
3.- The registered office of the company is established at L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read in the language of the person appearing, known to the notary by surname, Christian

name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le douze septembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire résidant à Luxembourg.

A comparu:

"Psons Limited", une société ayant son siège social à 22/F, Hong Kong Diamond Exchange Building, 8-10 Duddell Street,

Central, Hong Kong, inscrite au Registre de Commerce de Hong Kong sous le numéro 0909863,

représentée par Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-2740 Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 2 août 2012,

laquelle procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (ci-après, les Statuts) d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «PRIM HOLDINGS».

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision de l'administrateur-unique ou du conseil

d'administration.

123821

L

U X E M B O U R G

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises et

toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision
et le développement de ces participations.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter
ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
directement ou indirectement des participations.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou surveillance et effectuer toute opé-

ration qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. La Société a un capital social émis de trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trente et un mille (31.000)

actions d'une valeur nominale de un euros (1,- EUR) chacune.

Les actions sont soit nominatives soit au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des actions pour lesquelles

la loi prévoit la forme nominative.

La Société pourra émettre des certificats nominatifs ou au porteur d'actions multiples.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée en cas d'un actionnaire unique par un administrateur unique ou par un conseil

d'administration ou en cas de pluralité d'actionnaires par un conseil d'administration, composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires.
L'administration unique ou les membres du Conseil peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée
générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. En cas d'existence d'un conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs. Le

conseil d'administration pourra seulement valablement délibérer et prendre des décisions si la majorité de ses membres
est présente ou représentée par procurations, et si au moins deux administrateurs seront physiquement présents. Toute
décision prise par le conseil d'administration sera adopté à la simple majorité. Les procès-verbaux des réunions seront
signés par tous les administrateurs présents à la réunion.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer par le biais d'une conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de télécommunication permettant à différentes personnes de participer à la même réunion et de communiquer entre
eux. Une telle participation est à considérer comme étant égale à une présence physique. Une telle décision peut être
documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu signé par tous les membres ayant
participé à la réunion.

Le Conseil d'administration peut prendre différentes décisions par des résolutions circulaires, si l'approbation est faite

par écrit, câble, télégramme, telex, Fax, E-mail ou tout autre moyen de communication agréé. Une telle décision peut
être documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu signé par tous les membres
ayant participé à la réunion.

Art. 8. L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-
dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale.

123822

L

U X E M B O U R G

L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration préparera une situation intérimaires des comp-

tes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique ou en

cas d'existence d'un conseil d'administration par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un
administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs
et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le 20 mars à 14:00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,

l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (10%) du capital social, mais devrait tou-
tefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve constitue moins de dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2013.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

123823

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparant, représentée comme ci-avant, déclare qu'elle a souscrit

les trente et un mille (31.000) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en numéraire de sorte que le

montant de trente-et-un mille euros (31.000.-EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentant qui le constate.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est estimé à mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

<i>Décisions de l'actionnaire unique

La comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l'entièreté du capital social, s'est constituée en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Est nommé administrateur de la société:
M. Pradeep AGARWAL, Entrepreneur, Plot No 4, Villa B, Pochkhanwala RD, Near Godrej Tower, Worli, Mumbai

4000030, India Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2018.

3. Est nommé commissaire:
PKF Abax Audit, 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous

le numéro B 142.867

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2018.
3.- Le siège social de la Société est fixé au L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: V. PIERRU, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43591. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Référence de publication: 2012124311/303.
(120165744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

IT Investments Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

R.C.S. Luxembourg B 143.836.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2012

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société IT Investments Group S.à r.l., tenue en date du 3

septembre 2012:

- Acceptation du changement du siège social du 74 rue Adolphe Fischer L-1521 Luxembourg au 44 rue de wiltz L-2734

Luxembourg, avec effet au 3 septembre 2012

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012124172/16.
(120165303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Jopoly S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7246 Walferdange, 31, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 47.869.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

123824

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012124176/10.
(120165917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

TII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 171.556.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the thirty-first day of August.
Before the undersigned Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

National Industrialization Company, a company incorporated and existing under the laws of Saudi Arabia, registered

in Saudi Arabia under registration number 1010059693, having its registered office at Salahuddine Street, Second Building,

th

 Floor, having P.O. Box 26707, Riyadh 11496, Kingdom of Saudi Arabia,

here represented by Maître Olivier Yau, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Riyadh,

Saudi-Arabia on 4 August 2012.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the
articles of association of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

of "TII S.à r.l." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial
companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control
and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations

of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any

debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several
managers, of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
- one thousand two hundred fifty (1,250) ordinary shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each. (the "Ordinary

shares");

123825

L

U X E M B O U R G

- one thousand two hundred fifty (1,250) Class A preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each. (the

"Class A shares");

- one thousand two hundred fifty (1,250) Class B preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each. (the

"Class B shares");

- one thousand two hundred fifty (1,250) Class C preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each. (the

"Class C shares");

- one thousand two hundred fifty (1,250) Class D preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each. (the

"Class D shares");

- one thousand two hundred fifty (1,250) Class E preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each. (the

"Class E shares");

- one thousand two hundred fifty (1,250) Class F preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each. (the

"Class F shares");

- one thousand two hundred fifty (1,250) Class G preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each. (the

"Class G shares");

- one thousand two hundred fifty (1,250) Class H preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each. (the

"Class H shares");

- one thousand two hundred fifty (1,250) Class I preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each. (the

"Class I shares");

Any reference made hereinafter to the "shares" shall be construed as a reference to shares of the above-mentioned

ordinary or classes of shares, depending on the context and as applicable. The same construction applies to any reference
made hereinafter to the "shareholders" of the Company.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least in accordance with the provisions of the Law.

The share capital of the Company may be reduced through repurchase and subsequent cancellation of shares including

by cancellation of one or more entire classes of shares through repurchase and cancellation of all the shares in issue in
such class(es). The redemption price payable to the holders of the repurchased and cancelled shares shall be determined
in accordance with articles 22 and 23.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 8. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder

is subject to the approval of such transfer given by the other shareholders representing a majority of three quarters of
the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the owners of shares representing three quarters of the rights of the survivors,
subject to and in accordance with the Law. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency of any of the shareholders will not

cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company is managed by a board of managers composed of at least one A manager and one B manager,

who need not to be shareholders.

In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are ap-
pointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of their office. They may
be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any A manager together with any B manager

or by the signature of any duly authorised representative within the limits of such authorisation.

Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and, as the case may be, a vice-

chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

123826

L

U X E M B O U R G

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, e-mail
or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at
a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any

other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his
colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous
basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting. In case of tied votes, the chairman shall have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

Art. 15. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared

by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established by law or by these articles of association.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as
they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three
quarters of the share capital at least.

Art. 18. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the "general
meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as
applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's financial year commences on 1 

st

 January and ends on 31 

st

 December of the same year.

Art. 20. Each year on 31 

st

 December, the accounts are closed and the manager or, as the case may be, the board of

managers, prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until

such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. Each share is entitled to the same fraction of such balance.

123827

L

U X E M B O U R G

Art. 22. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of one or more class(es)

of shares, the holders of shares of the repurchased and cancelled class(es) of shares shall receive from the Company an
amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class(es) held by them and cancelled.
For the purpose of this article, "Cancellation Value Per Share" means (i) the nominal value per share to be cancelled plus
(ii) the Available Amount attributable to the share to be cancelled. "Available Amount" means the total amount of realized
profits since the Interim Account Date of the previous Class Period increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of association, determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period. If the
aggregate Cancellation Value Per Share paid for shares so repurchased and cancelled exceeded the relevant amount
available for distribution, future distributions to the shareholders and/or the Cancellation Value Per Share of further
shares repurchased, as applicable, shall be reduced accordingly. In the event the shareholders decide to redeem and cancel
a class of shares for a repurchase price per share lower than the Cancellation Value Per Share (the "Adjusted Cancellation
Value Per Share"), then the amount resulting from the difference between such Adjusted Cancellation Value Per Share
and the Cancellation Value Per Share shall be deemed to be attributed to the next class of shares.

The board of managers shall calculate the Available Amount for a class of Shares so redeemed on the basis of interim

accounts of the Company which shall be dated not less than eight (8) days prior to the date of repurchase (the "Interim
Accounts").

Art. 23. The Available Amount is determined by reference to Class Periods (as defined below), which are determined

as follows:

- The period for the Class A shares is the period starting on the date of incorporation of the Company and ending on

the Interim Account Date for the Class A Interim Accounts (the "Class A Period");

- The period for the Class B shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on the Interim

Account Date for the Class B Interim Accounts (the "Class B Period");

- The period for the Class C shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending on the Interim

Account Date for the Class C Interim Accounts (the "Class C Period");

- The period for the Class D shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending on the Interim

Account Date for the Class D Interim Accounts (the "Class D Period");

- The period for the Class E shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on the Interim

Account Date for the Class E Interim Accounts (the "Class E Period");

- The period for the Class F shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on the Interim

Account Date for the Class F Interim Accounts (the "Class F Period");

- The period for the Class G shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on the Interim

Account Date for the Class G Interim Accounts (the "Class G Period");

- The period for the Class H shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending on the Interim

Account Date for the Class H Interim Accounts (the "Class H Period"); and

- The period for the Class I shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending on the Interim

Account Date for the Class I Interim Accounts (the "Class I Period");

For the purpose of this article:
- a "Class Period" means each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the

Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, and the Class I Period;

- an "Interim Account Date" means the date on which Interim Accounts are drawn up and approved by the board of

managers of the Company, which shall be no later than on the last day of the third month following the last day of the
financial year in which the relevant Class Period started; and

- the "Class A Interim Accounts" means the Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of the

Class A shares, and Class B Interim Accounts, Class C Interim Accounts, Class D Interim Accounts, Class E Interim
Accounts, Class F Interim Accounts, Class G Interim Accounts, Class H Interim Accounts and Class I Interim Accounts
shall be construed accordingly.

Art. 24. The Ordinary Shares shall be entitled to receive one hundred percent (100%) of the distributable amounts

which have not been allocated to the preferred classes of shares.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 25. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who

need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

123828

L

U X E M B O U R G

G. Final clause - Applicable law

Art. 26. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and Payment

All of the twelve thousand five hundred (12,500) shares of Classes A to I and the Ordinary Shares have been subscribed

by National Industrialization Company, prenamed.

All the shares subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 December

2012.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and considering itself as fully

convened, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company for an unlimited period:
- Mr Saleh Fahad Al Nazha, born in Hail, Saudi Arabia on 11 January 1959, professionally residing at Salahuddine Street,

Second Building, 7 

th

 Floor, having P.O. Box 26707, Riyadh 11496, Kingdom of Saudi Arabia, A manager; and

- Mr Fayez Abdullah Al-Asmari, born in Riyadh, Saudi Arabia on 24 September 1968, professionally residing at Sala-

huddine Street, Second Building, 7 

th

 Floor, having P.O. Box 26707, Riyadh 11496, Kingdom of Saudi Arabia, A manager;

and

- Ms Catherine Koch, born in Sarreguemines, France on 12 February 1965, professionally residing at 19, rue de Bitbourg,

L-1273 Luxembourg, B manager; and

- Ms Antonella Graziano, born in Orvieto, Italy on 20 January 1966, professionally residing at 19, rue de Bitbourg,

L-1273 Luxembourg, B manager.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le trente et unième jour d'août.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

National Industrialization Company, une société constituée et existant selon les lois de l'Arabie Saoudite, enregistrée

en Arabie Saoudite sous le numéro 1010059693, ayant son siège social à Salahuddine Street, Second Building, 7 

th

 Floor,

avec P.O. Box 26707, Riyadh 11496, Royaume d'Arabie Saoudite,

ici représentée par Maître Olivier Yau, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée à Riyadh, Arabie Saoudite le 4 août 2012.

La procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée qu'elle/il déclare constituer et dont elle/il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est établi conformément aux présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «TII

S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

123829

L

U X E M B O U R G

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portfolio.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toute forme et émettre des titres obligataires, des obligations garanties, des lettres

de change ainsi que généralement toute sorte de titres de participation, d'obligations et/ou d'obligations hybrides con-
formément au droit luxembourgeois.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être

transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil
de gérance.

Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple

décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre ce siège
social et des personnes à l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être provisoirement
transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembour-
geoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par:
- Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ordinaires d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts

Sociales Ordinaires»);

- Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de Catégorie A d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts

Sociales de Catégorie A»);

- Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de Catégorie B d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts

Sociales de Catégorie B»);

- Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de Catégorie C d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts

Sociales de Catégorie C»);

- Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de Catégorie D d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts

Sociales de Catégorie D»);

- Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de Catégorie E d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts

Sociales de Catégorie E»);

- Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de Catégorie F d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts

Sociales de Catégorie F»);

- Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de Catégorie G d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts

Sociales de Catégorie G»);

- Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de Catégorie H d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts

Sociales de Catégorie H»); and

- Mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de Catégorie I d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts

Sociales de Catégorie I»).

Toute référence faite ci-dessous aux «parts sociales» sera réputée faire référence aux parts sociales ordinaires ou de

catégories de parts sociales ci-dessus, selon le contexte et le cas échéant. La même construction s'applique à toute
référence faite ci-dessous aux «associés» de la Société.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social conformément aux dispositions de la Loi.

Le capital social de la Société peut être réduit par le rachat et l'annulation qui s'en suit des parts sociales, y compris

l'annulation de toute une ou plusieurs catégories de parts sociales en vertu de rachats et d'annulations de toutes les parts

123830

L

U X E M B O U R G

sociales émises dans lesdites catégories de parts sociales. Le prix de rachat à payer aux propriétaires des parts sociales
rachetées et annulées sera déterminé en conformité avec les articles 22 et 23.

Art. 7. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part sociale. Des copropriétaires indivis de parts

sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné par les autres associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux associés
survivants sujet à et conformément aux dispositions de la Loi. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas
requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés ne saurait entraîner la

dissolution de la Société.

C. Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un conseil de gérance, composé d'au moins un gérant A et un gérant B, qui n'ont pas

besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations conformes à son objet. Les gérants sont nommés par l'associé
unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixent la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocable
(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature la signature conjointe de tout gérant A ensemble avec

un gérant B ou par la signature de tout représentant dûment mandaté dans les limites de son mandat.

Art. 11. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et, le cas échéant, un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin
d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil

de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie,

courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant
peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou

par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de
s'entendre les unes les autres de façon continue et permettant une participation effective de toutes ces personnes à la
réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion. En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication
similaire, l'ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 12. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par

le vice-président, ou par deux gérants. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de
gérance.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

123831

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle par rapport aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 15. Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé

par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque

associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et

par les présents statuts. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société.
Toute autre modification des statuts nécessite l'accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les

trois quarts du capital social.

Art. 18. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la Loi.

Dans ce cas, toute référence dans les présentes à «l'assemblée générale des associés» devra être interprétée comme

désignant l'associé unique, selon le contexte et selon le cas, et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés
seront exercés par l'associé unique.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 19. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 20. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dresse(nt) un inventaire

comprenant l'indication de la valeur de l'actif et du passif de la Société. Chaque associé peut prendre communication au
siège social de cet inventaire et du bilan.

Art. 22. Dans le cas d'une réduction de capital social par le rachat et l'annulation d'une ou plusieurs classes d'actions,

les propriétaires des parts sociales des catégories de parts sociales rachetées et annulées recevront de la Société un
montant équivalent à la Valeur d'Annulation Par Part Sociale pour chaque part sociale de la catégorie concernée détenue
par eux et annulée. Pour les besoins de cet article, «Valeur d'Annulation Par Part Sociale» signifie (i) la valeur nominale
par part sociale devant être annulée plus (ii) le Montant Disponible attribuable à la part sociale devant être annulée.
«Montant Disponible» signifie le montant total des profits réalisés depuis la Date des Comptes Intérimaires de la Période
de Catégorie précédente augmenté de profits reportés et les réserves distribuables, mais diminué par les pertes reportées
et montants devant être alloués à une réserve prévue par la loi ou par les présents statuts, établis à partir des Comptes
Intérimaires relatifs à la Période de Catégorie concernée. Si le montant total de la Valeur d'Annulation Par Part Sociale
versé pour les parts sociales ainsi rachetées et annulées est supérieur au montant disponible pour la distribution, les
distributions futures aux associés et/ou la Valeur d'Annulation Par Part Sociale seront réduites en conséquence. Dans le
cas où les associés décident de racheter et annuler une Catégorie de Parts Sociales pour un prix de rachat inférieur à la
Valeur d'Annulation Par Part Sociale (la «Valeur d'Annulation Par Part Sociale Ajustée»), alors le montant résultant de la
différence entre cette Valeur d'Annulation Par Part Sociale Ajustée et la Valeur d'Annulation Par Part Sociale sera réputé
être attribué à la prochaine catégorie de parts sociales.

Le conseil de gérance calculera le Montant Disponible pour une catégorie de Parts Sociales ainsi rachetée à partir de

comptes intérimaires de la Société qui ne seront pas datés de moins de huit (8) jours avant la date de rachat (les «Comptes
Intérimaires»).

Art. 23. Le Montant Disponible est déterminé en faisant référence à des Périodes de Catégories (telles que définies

ci-dessous), qui seront déterminées tel qu'il suit:

- La période pour les Parts Sociales de Catégorie A est la période commençant à la date de constitution de la Société

et terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires de Catégorie A (la «Période de Catégorie
A»);

- La période pour les Parts Sociales de Catégorie B est la période commençant le jour après la Période de Catégorie

A  et  terminant  à  la  Date  des  Comptes  Intérimaires  pour  les  Comptes  Intérimaires  de  Catégorie  B  (la  «Période  de
Catégorie B»);

123832

L

U X E M B O U R G

- La période pour les Parts Sociales de Catégorie C est la période commençant le jour après la Période de Catégorie

B  et  terminant  à  la  Date  des  Comptes  Intérimaires  pour  les  Comptes  Intérimaires  de  Catégorie  C  (la  «Période  de
Catégorie C»);

- La période pour les Parts Sociales de Catégorie D est la période commençant le jour après la Période de Catégorie

C et terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires de Catégorie D (la «Période de
Catégorie D»);

- La période pour les Parts Sociales de Catégorie E est la période commençant le jour après la Période de Catégorie

D  et  terminant  à  la  Date  des  Comptes  Intérimaires  pour  les  Comptes  Intérimaires  de  Catégorie  E  (la  «Période  de
Catégorie E»);

- La période pour les Parts Sociales de Catégorie F est la période commençant le jour après la Période de Catégorie

E et terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires de Catégorie F (la «Période de Catégorie
F»);

- La période pour les Parts Sociales de Catégorie G est la période commençant le jour après la Période de Catégorie

F  et  terminant  à  la  Date  des  Comptes  Intérimaires  pour  les  Comptes  Intérimaires  de  Catégorie  G  (la  «Période  de
Catégorie G»);

- La période pour les Parts Sociales de Catégorie H est la période commençant le jour après la Période de Catégorie

G et terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires de Catégorie H (la «Période de
Catégorie H»); and

- La période pour les Parts Sociales de Catégorie I est la période commençant le jour après la Période de Catégorie

H et terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires de Catégorie I (la «Période de Catégorie
I»).

Pour les besoins de cet article:
- Une «Période de Catégorie» signifie chacune de la Période de Catégorie A, Période de Catégorie B, Période de

Catégorie C, Période de Catégorie D, Période de Catégorie E, Période de Catégorie F, Période de Catégorie G, Période
de Catégorie H et la Période de Catégorie I;

- Une «Date des Comptes Intérimaires» signifie la date à laquelle les Comptes Intérimaires sont établis et approuvés

par le conseil de gérance de la Société, qui ne pourra pas être après le dernier jour du troisième mois suivant le dernier
jour de l'année sociale durant laquelle la Période de Catégorie a débuté; et

- «Comptes Intérimaires de Catégorie A» signifie les Comptes Intérimaires établis pour le rachat et l'annulation des

Parts  Sociales  de  Catégorie  A,  et  les  Comptes  Intérimaires  de  Catégorie  B,  Comptes  Intérimaires  de  Catégorie  C,
Comptes Intérimaires de Catégorie D, Comptes Intérimaires de Catégorie E, Comptes Intérimaires de Catégorie F,
Comptes Intérimaires de Catégorie G, Comptes Intérimaires de Catégorie H et les Comptes Intérimaires de Catégorie
I seront interprétés en conséquence.

Art. 24. Les Parts Sociales Ordinaires donneront droit à la réception de cent pour cent (100%) des montants distri-

buables qui n'ont pas été alloués aux catégories de parts sociales préférentielles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 25. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les
liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement des dettes de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes sera partagé entre les associés en proportion

des parts sociales détenues par eux dans la Société.

G. Final clause - Applicable law

Art. 26. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et libération

Toutes les douze mille cinq cent (12.500) parts sociales des Catégories A à I et les Parts Sociales Ordinaires ont été

souscrites par National Industrialisation Company, prénommée.

Toutes les parts sociales souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille

cinq cent euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille euros (EUR 1.000,-).

123833

L

U X E M B O U R G

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et se considérant dûment convoquée, a

par la suite pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M Saleh FahadAlNazha, né à Hail, Arabie Saoudite le 11 janvier 1959, ayant sa résidence professionnelle à Salahuddine

Street, Second Building, 7 

th

 Floor, avec P.O. Box 26707, Riyadh 11496, Royaume d'Arabie Saoudite, gérant A;

- M Fayez Abdullah Al-Asmari, né à Riyadh, Arabie Saoudite le 24 septembre 1968, ayant sa résidence professionnelle

à Salahuddine Street, Second Building, 7 

th

 Floor, avec P.O. Box 26707, Riyadh 11496, Royaume d'Arabie Saoudite, gérant

A;

- Mme Catherine Koch, née à Sarreguemines, France le 12 février 1965, ayant sa résidence professionnelle à 19, rue

de Bitbourg, L-1273, Luxembourg, gérant B; et

- Mme Antonella Graziano, née à Orvieto, Italie le 20 janvier 1966, ayant sa résidence professionnelle à 19, rue de

Bitbourg, L-1273, Luxembourg, gérant B.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du comparant que le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par nom,

prénom, état et demeure, le mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Yau, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2012. Relation: LAC/2012/41455. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Frising.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2012.

Référence de publication: 2012124410/514.
(120165344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

K.Y.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 41.031.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

G.T. Management Services S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2012124177/12.
(120165685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Kompass Wohnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 145.663.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2012.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012124179/13.
(120165891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

123834

L

U X E M B O U R G

Kaval S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 112.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
KAVAL S.A.
Signature

Référence de publication: 2012124180/12.
(120165911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

LEA Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

R.C.S. Luxembourg B 138.038.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2012

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société LEA finance Luxembourg Sàrl, tenue en date du 3

septembre 2012:

- Acceptation du changement du siège social du 74 rue Adolphe Fischer L-1521 Luxembourg au 44 rue de wiltz L-2734

Luxembourg, avec effet au 3 septembre 2012;

- Changement de l’adresse de LEA au 8 passage Driancourt F-75012 Paris;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012124208/17.
(120165302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Konatra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 83.584.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124182/9.
(120165451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

KPI Sierra 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 117.700.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KPI Sierra 1 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2012124183/11.
(120165643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

KÖHL Aktiengesellschaft, Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 17, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 43.668.

Les comptes annuels au 31/03/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

123835

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124184/9.
(120165953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Moesdorf S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 131.476.

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales effectuée en date du 17 septembre 2012 que la société A.S.

PARTIMMO S.A., ayant son siège social à 257, route d’Esch L-1471 Luxembourg a cédé ses 250 (deux cent cinquante)
parts sociales qu’elle détenait dans la société MOESDORF Sàrl, ayant son social à 257, route d’Esch L-1471 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le no B131476 à M. Pierre TEL, né le 4.11.1943 à Paris (France),
demeurant à 15, rue Josh Haendel L-5839 Alzingen

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales effectuée en date du 17 septembre 2012 que Monsieur Jean-

Marc CHARLES, demeurant à 1, sous les Chênes F-5780 Varsberg (France) a cédé ses 125 (cent vingt-cinq) parts sociales
qu’il détenait dans la société MOESDORF Sàrl, ayant son social à 257, route d’Esch L-1471 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le no B131476 à M. Pierre TEL, né le 4.11.1943 à Paris (France), demeurant
à 15, rue Josh Haendel L-5839 Alzingen

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales effectuée en date du 17 septembre 2012 que Madame Nathalie

CHARLES, demeurant à 1, sous les Chênes F-5780 Varsberg (France) a cédé ses 125 (cent vingt-cinq) parts sociales qu’elle
détenait dans la société MOESDORF Sàrl, ayant son social à 257, route d’Esch L-1471 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le no B131476 à M. Pierre TEL, né le 4.11.1943 à Paris (France), demeurant à 15, rue
Josh Haendel L-5839 Alzingen

Suite à ce transfert M. Pierre TEL détient en total 500 parts sociales dans la société MOESDORF Sàrl

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012124250/25.
(120165791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Leitz-Service G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8436 Steinfort, 17A, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 23.218.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LEITZ-SERVICE GMBH
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012124185/11.
(120165257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

L.D.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 122.412.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124186/9.
(120165158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Landesbank Berlin AG Niederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.708.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124187/9.
(120164780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

123836

L

U X E M B O U R G

Lighthouse Holdings Limited S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 84.593.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2012.

Référence de publication: 2012124189/11.
(120165958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Lower Thames S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 150.639.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012124190/10.
(120165799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Lutèce S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 153.531.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124191/9.
(120165371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Lutèce S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 153.531.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124192/9.
(120165372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

LGT Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

R.C.S. Luxembourg B 167.412.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2012

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société LGT Solutions Sàrl, tenue en date du 3 septembre 2012:
- Acceptation du changement du siège social du 74 rue Adolphe Fischer L-1521 Luxembourg au 44 rue de Wiltz L-2734

Luxembourg, avec effet au 3 septembre 2012;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012124213/15.
(120165314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

123837

L

U X E M B O U R G

Luxono S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 112.302.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2012.

Référence de publication: 2012124195/10.
(120165960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

La Chamade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 1, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 88.099.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LA CHAMADE S.A.

Référence de publication: 2012124196/10.
(120165695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

La Fiduciaire Comptable Comptafisc Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 144.397.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012124197/10.
(120165945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Laboratoire Dentaire Graffe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 113, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 80.782.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012124198/10.
(120165390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

LNG International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 153.576.

Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, a dénoncé,

en date du 18 septembre 2012, tout office de domiciliation fourni à la société:

LNG International S.A.,
enregistrée au RCS de Luxembourg sous le numéro B153 576,
et ce avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2012.

Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012124214/14.
(120165856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

123838

L

U X E M B O U R G

Laser Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 73.354.

Les  comptes  annuels,  les  comptes  de  Profits  et  Pertes  ainsi  que  les  Annexes  de  l'exercice  cloturant  en  date  du

31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2012124199/11.
(120165204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Laser Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 73.354.

Les  comptes  annuels,  les  comptes  de  Profits  et  Pertes  ainsi  que  les  Annexes  de  l'exercice  cloturant  en  date  du

31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2012124200/11.
(120165205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 131.558.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 17 Septembre 2012.

Référence de publication: 2012124202/10.
(120165725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Sarucci, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel.

R.C.S. Luxembourg B 32.202.

<i>Constatation de cession de parts sociales du 28/09/2012

Il est porté à la connaissance des tiers que suite à deux conventions de cession de parts sociales du 28/09/2012, signées

sous seing privé par le cédant et les cessionnaires et acceptées par la gérance au nom de la société, le capital social de la
société à responsabilité limitée SARUCCI ayant son siège social à L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 32.202, est désormais réparti comme suit:

Monsieur Faramarz KHABIRPOUR, psychologue, né à Téhéran (Iran) le 7 novembre 1951, demeurant à
L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel,
Treize mille huit cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.850
Madame Lina AFYATPOUR- KHABIRPOUR, architecte, née à Téhéran (Iran)le 3 janvier 1950, demeurant à
L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel,
Treize mille huit cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.850
Total vingt-sept mille sept cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.700

Kehlen, le 28/09/2012.

Faramarz Khabirpour / Lina Afyatpour-Khabirpour
<i>Les associés

Référence de publication: 2012125550/22.
(120167244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.

123839

L

U X E M B O U R G

Helvetia Communication Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 97.687.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2012 que:
- Madame Orietta RIMI a démissionné de sa fonction d’administrateur et Président du Conseil d’administration, et que

Monsieur Vincent WILLEMS a démissionné de sa fonction d'administrateur.

- La société SER.COM S.à.r.l. a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
- Le siège social de la société est transféré au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, BP 2501, L-1025 Luxembourg.
- Madame Ada FAVA, consultante, née le 23 février 1970 à Pavia (PV) Italie, et demeurant professionnellement Via

Geritto, 21, CH-6900 Paradiso, a été élu administrateur et Président du Conseil d’administration et administrateur délégué
de la société;

- Madame Malgorzata Anna GRONEK, consultante, née le 11 avril 1972 en Pologne, et demeurant professionnellement

Piazza Cioccaro, 10, CH-6900 Lugano, a été élu administrateur;

- Monsieur Alexandre BRUNCHER, general manager, né le 07 juin 1976 à Neufchâteau (France) et demeurant pro-

fessionnellement au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg a été élu administrateur.

- FIDEURO S.A., ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen inscrite au RCS Luxembourg sous le

matricule B 151.304 a été nommée commissaire aux comptes.

Ces mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 27 septembre 2012.

Référence de publication: 2012126474/25.
(120167146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.

LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 131.558.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 17 Septembre 2012.

Référence de publication: 2012124203/10.
(120165726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

LBC Vesta Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.611.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 17 Septembre 2012.

Référence de publication: 2012124204/10.
(120165727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

LBC Vesta Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.611.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 17 Septembre 2012.

Référence de publication: 2012124205/10.
(120165728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

123840


Document Outline

AV Chartering SA

Helvetia Communication Participations S.A.

Immo &amp; Business Consult S.à r.l., en abrégé I.B.C. S.à r.l.

Immoffice S.A.

Information Business Integration A.G.

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.

Intertrade S.A.

Invesco European Hotel Real Estate IV S.à r.l.

Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l.

Invesco Vienna Hotel Investment S.à r.l.

Investissements Euro Finance S.A.

Iron Paradox S.à r.l.

Island Capital S.à r.l.

ISOS S.à r.l.

IT Investments Group S.à r.l.

IVG Cannon Street S.à r.l.

Jopoly S.A.

Kaval S.A.

Kermorio S.A.

KÖHL Aktiengesellschaft

Kompass Wohnen S.à r.l.

Konatra S.à r.l.

KPI Sierra 1 S.à r.l.

K.Y.O. S.A.

Laboratoire Dentaire Graffe S.à.r.l.

La Chamade S.A.

La Fiduciaire Comptable Comptafisc Sàrl

Landesbank Berlin AG Niederlassung Luxemburg

Laser Développement S.A.

Laser Développement S.A.

LBC Luxco S.à r.l.

LBC Luxco S.à r.l.

LBC Vesta Holdings S.à r.l.

LBC Vesta Holdings S.à r.l.

L.D.M. S.A.

LEA Finance Luxembourg S.à r.l.

Legacy Pharmaceuticals International Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Leitz-Service G.m.b.H.

LGT Solutions S.à r.l.

Lighthouse Holdings Limited S.A.

LNG International S.A.

Lower Thames S.à r.l.

Lutèce S.A.

Lutèce S.A.

Luxono S.à r.l.

Moesdorf S.à.r.l.

NGR Consulting S. à r.l.

Prim Holdings

RL Group S.A.

Sarucci

Sea Dream S.A.

TII S.à r.l.