logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2515

10 octobre 2012

SOMMAIRE

Bastion Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

120719

BigBoard Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120680

CCM Pharma Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

120686

Corestate Turbo HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . .

120674

Curvacerta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120719

Elles s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120699

EU Research Fund General Partner S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120695

Frank Lux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120720

Golden Heights S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120699

Jet Discount S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120720

Jet Discount S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120720

Jet Discount S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120720

Jet Discount S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120720

Knockon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120699

Landewyck Group Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

120694

Luvefi-Developpement S. à r. l.  . . . . . . . . . .

120700

Matrix EPH 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120700

Matrix German Portfolio No 1 Celle S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120701

Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120702

Matrix German Portfolio No. 1 Frankfurt

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120702

Matrix St Etienne Holdco S.à r.l.  . . . . . . . .

120703

Metro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120703

Moncour S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120700

Northam Property Funds Management S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120704

Plo Luximmo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120705

Portman Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

120704

Precious Objects S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120703

Pyxis Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120705

Queensgate Investments Fund I  . . . . . . . . .

120705

Radetzky S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120716

RA Investments Luxembourg I S.à r.l.  . . .

120715

R A J Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120715

Repondo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120714

RPS FinCo SCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120716

Safety Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120692

Sato Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120716

SHL Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

120715

Société du Parking de la Piscine Olympique

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120717

Société du Parking d'Esch-sur-Alzette  . . .

120717

Sofia Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120700

Star Trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120717

Telecommunications Industry S.A.  . . . . . .

120718

THIEFELS et BOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . .

120719

Truck International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

120718

Twelve Fir S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120692

Twelve Fringe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120718

Usina S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120719

Verny Infrastructure Holding S.à r.l.  . . . . .

120718

120673

L

U X E M B O U R G

Corestate Turbo HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 171.413.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the tenth day of September.
Before, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

CORESTATE CAPITAL AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at

Baarerstrasse  135,  CH-6300  Zug  (Switzerland),  registered  with  the  trade  register  of  Kanton  Zug  under  number
CH-020.3.030.000-1,

here represented by Mr Michael Jonas, avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in London on 5 September 2012.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Co-

restate Turbo HoldCo S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.

In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or
indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 50,000.-(fifty thousand Euro), represented

by 50,000 (fifty thousand) shares having a par value of EUR 1.-(one Euro) per share each.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

120674

L

U X E M B O U R G

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,

they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager

or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf

of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-

holders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may subdelegate his powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers
attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the

minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

120675

L

U X E M B O U R G

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the

registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the

general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in

number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 

st

 December, the Company's accounts are established

and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for

which no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

CORESTATE CAPITAL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 (fifty thousand) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 (fifty thousand) shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 50,000.-(five thousand Euro) is at

the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2012.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro ( EUR 1,200.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an

unlimited period of time:

120676

L

U X E M B O U R G

- Mr. Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address at

L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey; and

2. the registered office is established at L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.

Es folgt die deutsche übersetzung des vorstehenden textes:

Im Jahre zweitausendzwölf, am zehnten September.
Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

CORESTATE CAPITAL AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts mit Gesellschaftssitz in Baarerstrasse 135, CH-6300

Zug (Schweiz), eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug unter der Nummer CH020.3.030.000-1,

vertreten durch Herrn Michael Jonas, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht

unter Privatschrift, ausgestellt in London, am 5. September 2012.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten

Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter

der Bezeichnung " Corestate Turbo HoldCo S.à r.l." (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art
und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-

ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.

Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,

sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder

indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum

Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 50.000,-(fünfzigtausend Euro), eingeteilt in 50.000

(fünfzigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,-(ein Euro) pro Anteil.

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht

auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die

Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.

120677

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter

Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens

drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,

soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses

durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

Art. 11.Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-

stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer

bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei
eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die  Gesellschafterversammlung  kann  jederzeit  den  Geschäftsführer,  oder  wenn  mehrere  Geschäftsführer  bestellt

wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten

und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen

Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflich-

tet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne

Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevoll-
mächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern,
der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein

Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden

im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer

zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des

120678

L

U X E M B O U R G

Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon-oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel  (wie  oben  beschrieben)  teilnimmt,  gilt  als  persönlich  anwesend;  eine  solche  über  Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden  oder  vertretenen  Geschäftsführern,  im  Falle  einer  von  einem  Vorsitzenden  geleiteten  Sitzung  von  diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen

Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.

Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en

nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.

Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder

bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-

nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-

lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein
präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befug-

nisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-

zunehmen,  unabhängig  von  seiner  Kapitalbeteiligung.  Jeder  Gesellschafter  hat  so  viele  Stimmen,  wie  Anteile  auf  ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch

eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach

Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere

Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-

prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des abge-
änderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels-und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine Anwen-
dung findet.

Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

120679

L

U X E M B O U R G

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

CORESTATE CAPITAL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 (fünfzigtausend) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 (fünfzigtausend) Anteile

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 50.000,-(fünfzigtausend Euro) ab sofort

der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegenüber er-
bracht.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2012.

<i>Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich

auf ungefähr eintausendzweihundert euro (EUR 1.200,-).

<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-

schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person

für eine unbestimmte Zeit ernannt:

- Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163

Luxemburg, 35, avenue Monterey; und

2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen

Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten

Datum unter diese Urkunde setzen.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, dem

Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit
dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Jonas, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch le 13 septembre 2012. Relation: DIE/2012/10655. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 13. September 2012.

Référence de publication: 2012118968/364.
(120160923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

BigBoard Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 135.383.

In the year two thousand and twelve, on the tenth of September.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replacement of

Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will remain
the depositary of the present deed.

Is  held  an  extraordinary  general  meeting  of  the  shareholders  of  "BigBoard  Holding  S.A.",  a  Luxembourg  "société

anonyme"", having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Company Register under number B 135.383, incorporated by notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary,
residing in Luxembourg, on December 13 

th

 , 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

number 375 dated February 13 

th

 , 2008 and whose articles of association have been amended for the last time by a deed

of the undersigned notary dated October 13 

th

 , 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

number 2506, dated November 18 

th

 , 2010.

The meeting is chaired by Ms. Mariette SCHOU, private employee, with professional address at Echternach, 9, Rabatt.

120680

L

U X E M B O U R G

The chairman appointed as secretary an the meeting elected as scrutineer Ms. Peggy SIMON, private employee, with

professional address at Echternach, 9, Rabatt.

The chairman declares and requests the notary to act:
I. That the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the

chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered
with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, twenty-seven million, six hundred and fifty thousand (27,650,000) shares

with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, out of a total of thirty-one million, one hundred thousand (31,100,000)
shares are represented at the present extraordinary general meeting.

Considering that the remaining three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) shares with a nominal value

of one Euro (EUR 1.-) each are held by the Corporation and thus have no voting right, the shares represented constitute
together one hundred per-cent (100 %) of the voting share capital of the Corporation, so that the meeting can validly
decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Decrease of the Corporation's share capital by three million, four hundred and fifty thousand Euro (EUR 3,450,000.-)

in order to bring it from its present amount of thirty-one million, one hundred thousand Euro (EUR 31,100,000.-) down
to twenty-seven million, six hundred and fifty thousand Euro (EUR 27,650,000.-) by cancellation of three million, four
hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class I Shares» with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and currently
held by the Corporation.

2. Restatement of article 6.1. of the Corporation's articles of association in order to give it the following wording:

6.1. The corporate capital is set at twenty-seven million, six hundred and fifty thousand Euro (EUR 27,650,000.-),

divided into:

- fifty thousand (50,000) ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid

up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class A Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class B Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class C Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class D Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class E Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class F Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class G Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up; and

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class H Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up.

The terms defined in this Article 6, wherever appearing in the Articles, shall have the meanings set forth below:
«Class A Shares» means class A Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class B Shares» means class B Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class C Shares» means class C Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class D Shares» means class D Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class E Shares» means class E Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class F Shares» means class F Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class G Shares» means class G Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class H Shares» means class H Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class A Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class A Shares».
«Class B Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class B Shares».
«Class C Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class C Shares».
«Class D Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class D Shares».
«Class E Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class E Shares».
«Class F Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class F Shares».
«Class G Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class G Shares».

120681

L

U X E M B O U R G

«Class H Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class H Shares». "
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to decrease the Corporation's share capital by three million, four hundred and fifty thousand

Euro (EUR 3,450,000.-) in order to bring it from its present amount of thirty-one million, one hundred thousand Euro
(EUR 31,100,000.-)

down to twenty-seven million, six hundred and fifty thousand Euro (EUR 27,650,000.-) by cancellation of three million,

four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class I Shares» with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all currently
held by the Corporation.

<i>Second resolution

The meeting resolves to restate article 6.1 of the Corporation's articles of association in order to give it the following

wording:

6.1. The corporate capital is set at twenty-seven million, six hundred and fifty thousand Euro (EUR 27,650,000.-),

divided into:

- fifty thousand (50,000) ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid

up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class A Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class B Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class C Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class D Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class E Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class F Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class G Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up; and

- three million, four hundred and fifty thousand (3,450,000) «Class H Shares» with a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each, all subscribed and fully paid up.

The terms defined in this Article 6, wherever appearing in the Articles, shall have the meanings set forth below:
«Class A Shares» means class A Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class B Shares» means class B Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class C Shares» means class C Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class D Shares» means class D Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class E Shares» means class E Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class F Shares» means class F Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class G Shares» means class G Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class H Shares» means class H Shares of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each in the capital of the Corporation.
«Class A Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class A Shares».
«Class B Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class B Shares».
«Class C Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class C Shares».
«Class D Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class D Shares».
«Class E Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class E Shares».
«Class F Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class F Shares».
«Class G Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class G Shares».
«Class H Shareholders» means the Shareholders of the Corporation, which hold at any time «Class H Shares».
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

120682

L

U X E M B O U R G

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille douze, le dix septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en rem-

placement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel
dernier restera dépositaire du présent acte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BigBoard Holding S.A.", ayant

son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 135.383, constituée par acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire à Luxembourg,
en date du 13 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 375 du 13 février
2008 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné du 13 octobre 2010, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2506, le 18 novembre 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Mariette SCHOU, employée privée, ayant son adresse pro-

fessionnelle à Echternach, 9, Rabatt.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Peggy SIMON, employée

privée, ayant son adresse professionnelle à Echternach, 9, Rabatt.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,

signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procu-
rations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que vingt-sept millions, six cent cinquante mille (27.650.000) actions avec

une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, sur un total de trente-et-un millions, cent mille (31.100.000) actions,
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Considérant que les trois millions, quatre cent cin-
quante mille (3.450.000) autres actions restantes avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, sont détenues
par la Société, et par conséquent que leur droit de vote est suspendu, l'ensemble des actions représentées constituent
ensemble cent pour-cent (100%) du capital social avec droit de vote de la Société, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social d'un montant de trois millions, quatre cent cinquante mille Euro (EUR 3.450.000,-) afin

de le réduire de son montant actuel de trente-et-un millions, cent mille Euro (EUR 31.100.000,-) à vingt-sept millions, six
cent cinquante mille Euro (EUR 27.650.000,-), par l'annulation de trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000)
«Actions de Classe I» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues à ce jour par la Société.

2. Modification de l'article 6.1 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

« 6.1. Le capital social est fixé à vingt-sept millions, six cent cinquante mille Euro (EUR 27.650.000,-) divisé en:
- cinquante mille (50.000) Actions ordinaires d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement sou-

scrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe A» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe B» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe C» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe D» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe E» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe F» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe G» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées; et

120683

L

U X E M B O U R G

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe H» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les notions définies dans cet Article 6 et figurant dans les Statuts ont la signification suivante:
«Actions de Classe A» signifie les Actions de classe A d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le capital

de la Société.

«Actions de Classe B» signifie les Actions de classe B d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le capital

de la Société.

«Actions de Classe C» signifie les Actions de classe C d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le

capital de la Société.

«Actions de Classe D» signifie les Actions de classe D d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le

capital de la Société.

«Actions de Classe E» signifie les Actions de classe E d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le capital

de la Société.

«Actions de Classe F» signifie les Actions de classe F d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le capital

de la Société.

«Actions de Classe G» signifie les Actions de classe G d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le

capital de la Société.

«Actions de Classe H» signifie les Actions de classe H d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le

capital de la Société.

«Actionnaire de Classe A» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

A».

«Actionnaire de Classe B» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

B».

«Actionnaire de Classe C» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

C».

«Actionnaire de Classe D» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

D».

«Actionnaire de Classe E» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

E».

«Actionnaire de Classe F» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

F».

«Actionnaire de Classe G» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

G».

«Actionnaire de Classe H» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

H».

3. Divers.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à hauteur de trois millions, quatre cent cinquante mille Euro (EUR

3.450.000,-) afin de le réduire de son montant actuel de trente-et-un millions, cent mille Euro (EUR 31.100.000,-) à vingt-
sept millions, six cent cinquante mille Euro (EUR 27.650.000,-) par annulation de trois millions, quatre cent cinquante
mille (3.450.000) «Actions de Classe I» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues à ce jour par la
Société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

« 6.1. Le capital social est fixé à vingt-sept millions, six cent cinquante mille Euro (EUR 27.650.000,-) divisé en:
- cinquante mille (50.000) Actions ordinaires d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement sou-

scrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe A» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe B» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe C» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

120684

L

U X E M B O U R G

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe D» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe E» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe F» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe G» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées; et

- trois millions, quatre cent cinquante mille (3.450.000) «Actions de Classe H» d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les notions définies dans cet Article 6 et figurant dans les Statuts ont la signification suivante:
«Actions de Classe A» signifie les Actions de classe A d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le capital

de la Société.

«Actions de Classe B» signifie les Actions de classe B d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le capital

de la Société.

«Actions de Classe C» signifie les Actions de classe C d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le

capital de la Société.

«Actions de Classe D» signifie les Actions de classe D d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le

capital de la Société.

«Actions de Classe E» signifie les Actions de classe E d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le capital

de la Société.

«Actions de Classe F» signifie les Actions de classe F d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le capital

de la Société.

«Actions de Classe G» signifie les Actions de classe G d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le

capital de la Société.

«Actions de Classe H» signifie les Actions de classe H d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune dans le

capital de la Société.

«Actionnaire de Classe A» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

A».

«Actionnaire de Classe B» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

B».

«Actionnaire de Classe C» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

C».

«Actionnaire de Classe D» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

D».

«Actionnaire de Classe E» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

E».

«Actionnaire de Classe F» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

F».

«Actionnaire de Classe G» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

G».

«Actionnaire de Classe H» signifie tout actionnaire de la Société, qui détient à tout moment des «Actions de Classe

H».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Junglinster, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur Noms, Prénoms, statut marital et

résidences, ont signé avec Nous, le notaire instrumentant, le présent procès-verbal.

Signé: M. SCHOU, P. SIMON, Jean SECKLER
Enregistré à Echternach, le 12 septembre 2012. Relation: ECH/2012/1544. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

120685

L

U X E M B O U R G

Echternach, le 18 septembre 2012.

Référence de publication: 2012118930/292.
(120160913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

CCM Pharma Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.706,60.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 170.147.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,
ON THE THIRTIETH DAY OF THE MONTH OF AUGUST;
before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg;

there appeared

CCM Pharma Midco Limited, a limited company, incorporated in Jersey, having its registered office at 11-15 Seaton

Place, St Helier, JE4 0QH, and being registered with the Jersey Financial Services Commission under number 111296 (the
"Sole Shareholder"), being the sole shareholder of CCM Pharma Luxco S.àr.l." (previously know as Orchard Luxembourg
S.àr.l.) (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 170.147
incorporated on 10 July 2012 by deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 2034, of 16 August 2012; represented by Me Toinon
Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 29 August 2012 (which shall remain annexed
to the present deed to be registered therewith).

The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of Me Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, of 22 August 2012, not yet published in the Mémorial.

The Sole Shareholder declared and asked the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all the one million five hundred and seventy thousand six hundred and sixty (1,570,660)

shares in issue of the Company.

2. The Sole Shareholder hereby takes decisions on the following agenda:
1. To restructure the issued share capital of the Company by:
(A) creating ten different classes of shares, namely classes A, B, C, D, E, F, G, H, I and J and determining the rights and

obligations thereof by amending of the articles of association of the Company (the "Articles") as set forth below under
item (D) below;

(B) reclassifying all the one million five hundred and seventy thousand six hundred and sixty (1,570,660) shares in issue

in the Company into one million five hundred and seventy thousand six hundred and sixty (1,570,660) class A shares;

(C) increasing the issued share capital of the Company from its current amount of fifteen thousand seven hundred and

six Pounds Sterling and sixty Pence (£15,706.60) to five hundred thousand Pounds Sterling (£500,000) by the issue of a
total of forty-eight million four hundred twenty-nine thousand three hundred and forty (48,429,340) shares of ten (10)
different classes (namely three million four hundred twenty-nine thousand three hundred and forty (3,429,340) shares in
class A and five million (5,000,000) shares per classes B to J) of a nominal value of one Pounds Sterling pence (£0.01) each
for a total subscription price of eight million eight hundred forty-nine thousand six hundred and fifty-three Pounds Sterling
and twenty pence (£8,849,653.20); subscription to the new shares by the Sole Shareholder; confirmation of payment of
the subscription price by the Sole Shareholder in cash; allocation from the subscription price of an amount equal to the
nominal value of the new shares so issued to the share capital, an amount of fifty thousand Pounds Sterling (£50,000) to
the legal reserve and the balance to the freely distributable share premium;

(D) amendment of articles 5 and 14 of the Articles and insertion of a new article as article 16 (with a consequential

amendment of the numbering of the article thereafter) to reflect the above resolutions, as set forth below:

(i) amendment of article 5 as follows:

Art. 5. Share capital.
5.1 The issued share capital of the Company is set at five hundred thousand Pounds Sterling (£500,000) represented

by a total of fifty million (50,000,000) shares divided into

- five million (5,000,000) Class A shares,
- five million (5,000,000) Class B shares,
- five million (5,000,000) Class C shares,
- five million (5,000,000) Class D shares,
- five million (5,000,000) Class E shares,
- five million (5,000,000) Class F shares,

120686

L

U X E M B O U R G

- five million (5,000,000) Class G shares,
- five million (5,000,000) Class H shares,
- five million (5,000,000) Class I shares, and
- five million (5,000,000) Class J shares,
each Share with a nominal value of one Penny (£0.01) and with such rights and obligations as set out in the present

Articles of Incorporation.

5.2 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the

manner required for amendment of these articles of association.

5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation

of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such Class
(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall
be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).

5.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of shares (in the

order provided for in article 5.3.), such Class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the
general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of shares shall receive
from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant Class held by
them and cancelled.

5.4.1 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

5.4.2. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the

general meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J,
I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the
relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment
of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.4.3 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will

become due and payable by the Company.

5.5 Any share premium of the Company shall be freely distributable.
(ii) amendment of article 14 as follows:

Art. 14. Distributions.
14.1 Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

14.2 The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in ac-

cordance with the provisions set forth hereafter.

14.3. The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared

by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting
year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums
to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

14.4.  The  share  premium  account  may  be  distributed  to  the  shareholders  upon  decision  of  a  general  meeting  of

shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to
allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

14.5 The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or as the case may be the board of

managers and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be the board
of managers. The manager or as the case may be the board of managers may make a final determination of the rate of
exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on
a share during five years and not thereafter claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such
share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by
the Company on behalf of holders of shares.

14.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) an amount equal to 0.25% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro

rata to their shares regardless of class, then

(ii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the

reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class I shares and in such
continuation until only class A shares are in existence).

(iii) insertion of a new article 16 "Definitions" to the articles of association as follows and renumbering of the following

articles in consequence:

120687

L

U X E M B O U R G

Available Amount

Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward
profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely
distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital
reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled
but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to
be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each
time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt,
any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating
to the Class of Shares to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or
of the Articles

Class

Means a class of shares of the Company

Interim Accounts

Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date

Interim Account Date

Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant Class of Shares

After having approved the foregoing, the Sole Shareholder passed the following resolutions:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolved to restructure the issued share capital of the Company as set forth below.
The Sole Shareholder resolved to create ten different classes of shares, namely classes A, B, C, D, E, F, G, H, I and J

and to determine the rights and obligations thereof by amending the articles of incorporation as set forth in the agenda.

The Sole Shareholder resolved to reclassify all the one million five hundred and seventy thousand six hundred and

sixty (1,570,660) existing shares of the Company into one million five hundred and seventy thousand six hundred and
sixty (1,570,660) Class A shares.

The Sole Shareholder then resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount to

five hundred thousand Pounds Sterling (£500,000) by the issue of a total of forty-eight million four hundred twenty-nine
thousand three hundred and forty (48,429,340) shares of ten (10) different classes (namely three million four hundred
twenty-nine thousand three hundred and forty (3,429,340) shares in class A and five million (5,000,000) shares per classes
B to J) of a nominal value of one penny (£ 0.01) each for a total subscription price of eight million eight hundred forty-
nine thousand six hundred and fifty-three Pounds Sterling and twenty pence (£8,849,653.20).

The Sole Shareholder, represented by Me Toinon Hoss, prenamed, thereupon subscribed for the new shares so issued

for the subscription price.

The subscriber has fully paid the subscription price in cash, evidence of which was shown to the undersigned notary.
The Sole Shareholder resolved to allocate from the subscription price an amount equal to the nominal value of the

new shares so issued to the share capital, an amount of fifty thousand Pounds Sterling (£50,000) to the legal reserve and
the balance to the freely distributable share premium.

The Sole Shareholder then resolved to amend articles 5 and 14 of the Articles as set forth in the agenda and to insert

a new article 16 "Definitions" to the Articles as set forth in the agenda and to renumber the following article in conse-
quence.

All items in the agenda have thus been resolved on.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at EUR 4.800.- .

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of discrepancies between the English and French version, the English version will prevail.

WHEREAFTER the present deed was done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE DOUZE,

120688

L

U X E M B O U R G

LE TRENTIEME JOUR DU MOIS AOUT,
par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

la société CCM Pharma Midco Limited, une limited company constituée sous les lois de Jersey, ayant son siège social

au 11-15 Seaton Place, St Helier, JE4 0QH, et enregistrée auprès de la Jersey Financial Services Commission sous le
numéro 111296 (l'«Associé Unique»), associé unique de CCM Pharma Luxco S.à r.l. (anciennement Orchard Luxembourg
S.à r.l.) (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 170.147,
constituée le 10 juillet 2012 suivant acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2034 du 16 août 2012; représentée par Maître Toinon
Hoss, maître en droit, résidant à Luxembourg, suivant procuration du 29 août 2012 (laquelle restera annexée au présent
acte pour être enregistrée avec lui).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de

résidence à Luxembourg, du 22 août 2012, pas encore publié au Mémorial.

L'Associé Unique a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. L'Associé Unique détient l'intégralité des un million cinq cent soixante-dix mille six cent soixante (1.570.660) parts

sociales émises de la Société.

2. L'Associé Unique se prononce sur l'ordre du jour suivant:
1. Recomposition du capital social émis de la Société par:
(A) la création de dix classes de parts sociales différentes, à savoir les classes A, B, C, D, E, F, G, H, I et J et la

détermination des droits et obligations s'y rapportant en modifiant les statuts de la Société (les «Statuts») tel qu'indiqué
au point (D) ci-dessous;

(B) la reclassification de l'intégralité des un million cinq cent soixante-dix mille six cent soixante (1.570.660) parts

sociales émises de la Société en un million cinq cent soixante-dix mille six cent soixante (1.570.660) parts sociales de
classe A;

(C) l'augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel de quinze mille sept cent six livres sterling

et soixante pence (15.706,60 £) à cinq cent mille livres sterling (500.000 £) par l'émission d'un total de quarante-huit
millions quatre cent vingt-neuf mille trois cent quarante (48.429.340) parts sociales de dix (10) classes différentes (à savoir
trois  millions  quatre  cent  vingt-neuf  mille  trois  cent  quarante  (3.429.340)  parts  sociales  de  classe  A  et  cinq  millions
(5.000.000) de parts sociales par classe B à J) d'une valeur nominale d'un penny de livre sterling (0,01 £) chacune pour
un prix total de souscription de huit millions huit cent quarante-neuf mille six cent cinquante-trois livres sterling et vingt
pence (8.849.653.20 £); souscription aux nouvelles parts sociales par l'Associé Unique; confirmation du paiement en
numéraire du prix de souscription par l'Associé Unique; allocation d'une partie du prix de souscription égale à la valeur
nominale des nouvelles parts sociales ainsi émises au capital social, d'un montant de cinquante mille livres sterling (50.000
£) à la réserve légale et le solde à la prime d'émissions librement distribuable;

(D) modification des articles 5 et 14 des Statuts et insertion d'un nouvel article 16 (impliquant une renumérotation

des articles suivants) afin de refléter les résolutions ci-dessus, comme suit: (i) modification de l'article 5 comme suit:

5. Capital social.
5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à cinq cent mille livres sterling (500.000 £) représenté par un total de

cinquante millions (50.000.000) de parts sociales divisé en

- cinq millions (5.000.000) de Parts Sociales de Classe A,
- cinq millions (5.000.000) Parts Sociales de Classe B,
- cinq millions (5.000.000) de Parts Sociales de Classe C,
- cinq millions (5.000.000) de Parts Sociales de Classe D,
- cinq millions (5.000.000) de Parts Sociales de Classe E,
- cinq millions (5.000.000) de Parts Sociales de Classe F,
- cinq millions (5.000.000) de Parts Sociales de Classe G,
- cinq millions (5.000.000) de Parts Sociales de Classe H,
- cinq millions (5.000.000) de Parts Sociales de Classe I,
- cinq millions (5.000.000) de Parts Sociales de Classe J,
chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'un penny de livre sterling (0,01 £) et les droits et obligations tels que

mentionnés dans les présents Statuts.

5.2 Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Associés adoptée de la manière requise

pour la modification des présents statuts.

5.3 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de Parts Sociales, y compris par l'annulation d'une

ou plusieurs Classes entières de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans la (les)

120689

L

U X E M B O U R G

Classe(s) concernée(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de classes de parts sociales, ces rachats et annulations de
parts sociales devront être effectués, dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la Classe J).

5.4. Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe de parts sociales (dans

l'ordre prévu à l'article 5.3.), cette Classe de parts sociales donne droit à ses détenteurs au pro rata de leur participation
dans cette classe au Montant Disponible (dans la limite toutefois du Montant d'Annulation Total tel que déterminé par
l'assemblée générale des associés) et les détenteurs des Parts Sociales de la Classe de parts sociales rachetée et annulée
recevront de la part de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de
la Classe concernée détenue par eux et annulée.

5.4.1. La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre

de parts sociales émises dans la Classe de Parts Sociales devant être rachetées et annulées.

5.4.2 Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée

générale sur la base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes J, I,
H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la (des) Classe(s) concernée(s) au moment de l'annulation de la
(des) Classe(s) concernée(s) sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés de la manière requise pour la
modification des Statuts étant entendu toutefois que le Montant Total d'Annulation ne doit jamais être supérieur à ce
Montant Disponible.

5.4.3. Après rachat et annulation des Part Sociales de la Classe concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale sera

due et payable par la Société.

5.5 Toute prime d'émission de la Société est librement distribuable.

(ii) modification de l'article 14 comme suit:

Art. 14. Distributions.

14.1 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) qui constitueront un compte de réserve légale. Ce prélè-

vement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

14.2 Le solde peut être distribué aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés conformément aux

dispositions ci-après.

14.3 Les associés peuvent décider de déclarer et payer des dividendes intérimaires sur la base de relevés de compte

préparés par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices nets réalisés
depuis la fin du dernier exercice comptable augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminués
des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi, conformément aux dispositions
ci-dessous.

14.4 Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par une décision d'une assemblée générale des

associés conformément aux dispositions ci-dessous. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout mon-
tant du compte de prime d'émission au compte de la réserve légale.

14.5 Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise sélectionnée par le gérant ou, le cas échéant, le conseil

de gérance et peuvent être payés aux lieux et heures tel que déterminé par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de
gérance. Le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance peut déterminer de manière définitive le taux de change
applicable pour convertir les montants des dividendes dans la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non
payé pour une part sociale pendant une période de cinq ans ne sera réputé renoncé par le détenteur de cette part sociale
et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés mais non réclamés qui sont détenus par
la Société pour le compte des associés.

14.6 Dans le cas d'une déclaration de dividendes, ces dividendes seront alloués et payés comme suit:

(i) un montant égal à 0,25% de la valeur nominale de chaque part sociale sera distribué de manière égale entre les

associés au pro rata du nombre de parts sociales détenues indépendamment de la Classe à laquelle la part sociale appar-
tient, puis

(ii) le solde du montant total distribué sera entièrement alloué aux détenteurs de la dernière classe dans l'ordre

alphabétique inverse à savoir d'abord parts sociales de Classe J, puis, si aucune part sociale de Classe J n'existe, les parts
sociales de Classe I et ainsi de suite jusqu 'à ce qu'il ne reste que des parts sociales de Classe A).

(iii) insertion d'un nouvel article 16 «Définitions» des statuts comme suit et renumérotation des articles suivants en

conséquence:

120690

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Définitions.

Montant Disponible

Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices
reportés) augmentés de (i) toute prime d'émission librement distribuable et autres
réserves librement distribuables et (ii) le cas échéant du montant de la réduction du
capital social et de la réduction de la réserve légale relative à la Classe de Parts
Sociales à annuler mais réduits de (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées)
et (ii) toutes sommes devant être placées en réserve(s) selon les exigences légales
ou statutaires, à chaque fois tel que mentionné dans les Comptes Intérimaires
concernés (sans, afin d'éviter tout doute, double comptage) de sorte que:
MD = (BN + P + RC) - (PE + RL)
Où:
MD = Montant Disponible
BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)
P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement
distribuables
RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve
légale relative à la Classe de Parts Sociales à annuler
PE = pertes (y compris les pertes reportées)
RL = toutes sommes devant être placées en réserve selon les exigences légales ou
statutaires

Classe

Signifie une classe de parts sociales de la Société

Comptes Intérimaires

Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires
concernés.

Date des Comptes Intérimaires Signifie la date ne dépassant pas huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation

de la Classe de Parts Sociales concernée.

Après délibération, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:

<i>Résolution unique

L'Associé Unique à décidé de recomposer le capital social émis de la Société comme indiqué ci-dessous.
L'Associé Unique a décidé de créer dix classes de parts sociales différentes, à savoir les classes A, B, C, D, E, F, G, H,

I et J et de déterminer les droits et obligations s'y rapportant en modifiant les statuts de la Société tel qu'indiqué à l'ordre
du jour.

L'Associé  Unique  a  décidé  de  reclasser  l'intégralité  des  un  million  cinq  cent  soixante-dix  mille  six  cent  soixante

(1.570.660) parts sociales émises de la Société en un million cinq cent soixante-dix mille six cent soixante (1.570.660)
parts sociales de Classe A.

L'Associé Unique a ensuite décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel à cinq cent

mille livres sterling (500.000 £) par l'émission d'un total de quarante-huit millions quatre cent vingt-neuf mille trois cent
quarante (48.429.340) parts sociales de dix (10) classes différentes (à savoir trois millions quatre cent vingt-neuf mille
trois cent quarante (3.429.340) parts sociales de classe A et cinq millions (5.000.000) de parts sociales par classe B à J)
d'une valeur nominale d'un penny de livre sterling (0,01 £) chacune pour un prix total de souscription de huit millions
huit cent quarante-neuf mille six cent cinquante-trois livres sterling et vingt pence (8.849.653,20£).

L'Associé Unique, représenté par Me Toinon Hoss, prénommée, a ensuite souscrit les nouvelles parts sociales ainsi

émises au prix de souscription.

Le souscripteur a payé l'intégralité du prix de souscription en numéraire, une preuve de ce paiement ayant été montrée

au notaire soussigné.

L'Associé Unique a décidé d'allouer une partie du prix de souscription égale à la valeur nominale des nouvelles parts

sociales ainsi émises au capital social, un montant de cinquante mille livres sterling (50.000 £) à la réserve légale et le solde
à la réserve librement distribuable.

Puis l'Associé Unique a décidé de modifier les articles 5 et 14 des Statuts tel qu'indiqué dans l'ordre du jour et d'insérer

un nouvel article 16 «Définitions» dans les Statuts tel qu'indiqué dans l'ordre du jour et de renuméroter les articles
suivants en conséquence.

Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont donc fait l'objet d'une décision.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés

à EUR 4.800.- .

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

120691

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. HOSS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 03 septembre 2012. Relation: RED/2012/1140. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 18 septembre 2012.

e

 Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012118981/339.
(120161165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Safety Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Twelve Fir S.à r.l.).

Capital social: EUR 19.837.500,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 168.602.

In the year two thousand twelve on the thirtieth day of August,
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing professionally in Luxembourg,

There appeared:

Safety Global Lux S.à r.l.,a société à responsabilité limitée duly incorporated and validly existing under the laws of the

Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, having a share capital of EUR 12,500.-, registered with the Luxembourg trade and companies register under
section B, number 170.729 (the “Sole Shareholder”),

duly represented by Mrs. Marie-Madeleine Werner, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

on 28 August 2012.

This proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of Twelve Fir S.à r.l., a société à responsabilité limitée organized and

existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.-, having its registered
office at 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies register under number B 168.602, incorporated on 3 April 2012 under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1454 of 12 June 2012 (hereafter
the “Company”).

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The  Sole  Shareholder  resolves  to  change  the  name  of  the  Company,  as  effect  as  from  the  present  shareholder’s

decision, from Twelve Fir S.à r.l. to "Safety Lux S.à r.l.”.

As a consequence of the above resolution, Article 2 of the articles of association of the Company is amended and shall

henceforth read as follows:

“ Art. 2. The Company's name is "Safety Lux S.à r.l.".

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s share capital from its current amount of twelve thousand

five hundred euro (EUR 12,500.-) up to an amount of nineteen million eight hundred thirty-seven thousand five hundred
euro (EUR 19,837,500.-) through the issuance of nineteen million eight hundred twenty-five thousand (19,825,000) shares
with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

The shares so subscribed have been entirely paid up by the Sole Shareholder through a contribution in cash of a total

amount of one hundred ninety-eight million two hundred fifty thousand (EUR 198,250,000.-), whereof:

- nineteen million eight hundred twenty-five thousand euro (EUR 19,825,000.-) have been allocated to the share capital

of the Company; and

- one hundred seventy-eight million four hundred twenty-five thousand euro (EUR 178,425,000.-) have been allocated

to the share premium account of the Company,

so that the total amount of one hundred ninety-eight million two hundred fifty thousand euro (EUR 198,250,000.-) is

at the disposal of the Company, as it has been proven to the undersigned notary.

120692

L

U X E M B O U R G

As a consequence of the above resolution, Article 8 of the articles of association of the Company is amended and shall

henceforth read as follows:

“ Art. 8. The Company's capital is set at EUR 19,837,500.-(nineteen million eight hundred thirty-seven thousand five

hundred Euro), represented by 19,837,500 (nineteen million eight hundred thirty-seven thousand five hundred) shares of
EUR 1 (one Euro) each".

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company so that the financial year shall run every

year from the 1 

st

 of May until the 30 

th

 of April.

As a result, the current and first financial year begins on 3 April 2012 and ends on 30 April 2013.
As a consequence of the above resolution, Article 16 and Article 17 of the articles of association of the Company are

amended and shall henceforth read as follows:

“ Art. 16. The Company's financial year begins on May 1 

st

 and closes on April 30 

th

 ”.

“ Art. 17. Each year, as of the 30 

th

 of April, the management will draw up the balance sheet which will contain a record

of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of shareholders together with the balance sheet.”

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to seven thousand euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le trente-et-un août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Safety Global Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant sous les lois du Grand-

Duché  de  Luxembourg,  dont  le  siège  social  se  situe  au  8,  rue  Notre-Dame,  L-2240  Luxembourg,  Grand-Duché  de
Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 170.729 («l’Associé Unique»),

dûment représentée par Mme Marie-Madeleine Werner, maître en droit, résidant à Luxembourg en vertu d'un pouvoir

le 28 août 2012.

Ce pouvoir, après avoir été signé «ne varietur» par le fondé de pouvoir et le notaire soussigné, demeure annexé au

présent document afin d’être enregistré avec celui-ci.

Le comparant est l’associé unique de Twelve Fir S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée et existant sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-, dont le siège social se situe au 8, rue
Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 168.602, constituée par acte du 3 avril 2012 selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 1454 le 12 juin 2012 (ci-après la «Société»).

L’Associé Unique, représentant la totalité du capital social, adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société, avec effet à la date des présentes résolutions,

d’anciennement «Twelve Fir S.à r.l»., nouvellement en «Safety Lux S.à r.l.».

En conséquence de la résolution ci-dessus, l’article 2 des statuts de la Société est modifié et se lira désormais comme

il suit:

« Art. 2. La dénomination de la Société est «Safety Lux S.à r.l.».»

120693

L

U X E M B O U R G

<i>Seconde résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cent

euros (EUR 12.500,-) pour le porter à un montant de dix-neuf millions huit cent trente-sept mille cinq cent euros (EUR
19.837.000,-) au moyen de l’émission de dix-neuf millions huit cent vingt-cinq mille (19.825.000) parts sociales ayant une
valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par l’Associé Unique au moyen d’un apport en numéraire

pour un montant total de cent quatre-vingt-dix-huit millions deux cent cinquante mille euros (EUR 198.250.000,-), comme
il suit:

- dix-neuf millions huit cent vingt cinq mille euros (EUR 19.825.000,-) ont été attribués au capital social de la Société;

et

- cent soixante-dix-huit millions quatre cent vingt-cinq mille euros (EUR 178.425.000,-) ont été attribués au compte

prime d’émission de la Société,

de telle manière à ce que le montant total de cent quatre-vingt dix-huit millions deux cent cinquante mille euros (EUR

198.250.000,-) soit à mis à la disposition de la Société, comme cela a été prouvé auprès du notaire soussigné.

En conséquence de la résolution ci-dessus, l’article 8 des statuts de la Société est modifié et se lira désormais comme

il suit:

« Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 19.837.500 (dix neuf millions huit cent trente-sept mille cinq cent Euro),

représenté par 19.837.500 (dix-neuf millions huit cent trente-sept mille cinq cent) parts sociales de EUR 1 (un Euro)
chacune"

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’exercice social de la Société de façon à ce que l’exercice social courre du 1 

er

mai jusqu’au 30 avril.

Il en résulte que le premier exercice social, actuellement en cours, débute le 3 avril 2012 et prendra fin le 30 avril

2013.

En conséquence de la résolution ci-dessus, l’article 16 et l’article 17 des statuts de la Société sont modifiés et se liront

désormais comme il suit:

« Art. 16. L’exercice social de la Société débute le 1 

er

 mai et prend fin le 30 avril».

« Art. 17. Chaque année, à partir du 30 avril, la gérance établira une situation comptable contenant un registre des

actifs de la Société ainsi que de ses dettes et de son passif et qui sera accompagnée d’une annexe contenant un rapport
récapitulant tous les engagements et les dettes des gérant(s) envers la Société

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à sept mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: M-M Werner, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 août 2012. Relation: LAC/2012/40842. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): C. Frising.

Référence de publication: 2012114549/141.
(120153893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

Landewyck Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 54.000.000,00.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 7.190.

Suite au décès de Madame Fanny GRETSCH-SCHMITZ en date du 24 novembre 2009, le capital social de la Société

représenté par 9.000 parts sociales d’une valeur nominale de 6.000,00.- EUR chacune est désormais réparti comme suit:

120694

L

U X E M B O U R G

Mademoiselle Nina GRETSCH, demeurant au 18, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg . . . . . . . . .

50 parts

Madame Diane LASKARIS-MEYER, demeurant au 14, Narkissou, GR-15452 Psychico . . . . . . . . . . . . . .

2 parts

Mademoiselle Iro LASKARIS, demeurant au 32, Lemessou, GR-15669 Papagov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Mademoiselle Anna LASKARIS, demeurant au 14, Narkissou, GR-15452 Psychico . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Madame Rita KROMBACH-MEYER, demeurant au 131, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg . . . . .

4 parts

Monsieur Christian KROMBACH, demeurant au 22, rue Michel Engels, L-1465 Luxembourg . . . . . . . .

1 part

Monsieur Thierry KROMBACH, demeurant au 8, rue du Parc, L-8031 Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Monsieur Patrick KROMBACH, demeurant au 19, Stresemannstrasse, D-68165 Mannheim . . . . . . . . .

1 part

Monsieur Georges KROMBACH, demeurant au 83, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg . . . . . . . . . . .

1 part

Monsieur François MEYER, demeurant au 94, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg . . . . . . . .

4 parts

Monsieur Max MEYER, demeurant au 36, rue de Reichlange, L-8508 Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 parts

La société ROMEY S.à r.l., ayant son siège social au 31, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57 096 . . . . . . . . . 2.921 parts
Madame Claudie CALAME-MEYER, demeurant au 14, rue Ancienne, CH-2227 Carouge . . . . . . . . . . . .

233 parts

Monseiur Yvan CALAME, demeurant au 14, rue Ancienne, CH-2227 Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

Monsieur Oleg CALAME, demeurant au 8C, Avenue de Miremont, CH-1206 Genève . . . . . . . . . . . . .

20 parts

Monsieur Boris CALAME, demeurant au 16, rue Albert Gos, CH-1206 Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

Madame Christiane TONNAR-MEYER, demeurant au 30, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234 parts

Monsieur Serge TONNAR, demeurant au 15a, rue de La Gare, L-7535 Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

Monsieur Manuel TONNAR, demeurant au 60, rue du Verger, L-2665 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

Monsieur Yann TONNAR, demeurant au 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

20 parts

Monsieur Charles MEYER-GOERGEN, demeurant au 1, rue Dicks, L-7221 Bereldange . . . . . . . . . . . . .

1 part

La société FRAME S.à r.l., ayant son siège social au 121, Avenue de la Faïencerie L-1511
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous parts le
numéro B 57 395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.970 parts
Mademoiselle Alexandra TURK, demeurant au 25, rue de Longchamp, F-75116 Paris . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

en nu-

propriété

Mademoiselle Roxanne TURK, demeurant au 17, Boulevard Beauséjour, F-75016 Paris . . . . . . . . . . . . .

600 parts

en nu-

propriété

La société British American Tobacco (Hamburg International) GmbH, ayant son siège social au
Alsterufer, 4, D-20354 Hamburg, inscrite au registre de commerce de Hamburg sous le
numéro HRB 77 356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.251 parts
Madame Gaby TURK, demeurant au 17, Boulevard Beauséjour, F-75016 Paris en usufruit . . . . . . . . . . . 1.000 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2012.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012114397/51.
(120153936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.

EU Research Fund General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7531 Mersch, 16, rue Dr Ernest Feltgen.

R.C.S. Luxembourg B 161.673.

In the year two thousand and twelve, on the seventeenth of July.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "EU Research Fund General Partner S.à r.l.", a "société

à responsabilité limitée", having its registered office at 24, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg and registered with
the Registrar of Companies of Luxembourg ("RCS") under the number B 161.673, incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary, on 15 June 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2024 of 1st September 2011.

120695

L

U X E M B O U R G

The meeting is presided by Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE, professionally residing in 3, rue Thomas Edison,

L-1445 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Mrs Corinne PETIT, private employee, professionally residing in Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond THILL, "maître en droit", professionally residing in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg,

The Chairman declares and the meeting of shareholders agrees:
- that the shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance

list attached to these minutes and duly signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented
and the members of the board of the general meeting of shareholders;

- that it appears from the attendance list, the twelve thousand six hundred Euro (EUR 12.600,-) represented by one

hundred and twenty-six (126) shares representing the whole share capital of the Company, are represented so that the
meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed beforehand.

- that the present meeting of shareholders is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following

agenda:

The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. The transfer of the registered office of the Company from:
(i) 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; to
(ii) 16, rue. Dr. Ernest Feltgen, L-7531 Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.
2. To approve and ratify the transfer of forty-two (42) shares in the Company with a nominal value of one hundred

Euros (EUR 100,-) from Mr Pierre Alexandre DELAGARDELLE, residing in 12, rue André Duchscher, L-1424 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg to Mr John Michael Preston, residing in L-8024 Strassen, 30A, rue Henri Dunant, for a
purchase price of one Euro (EUR 1,-).

3. To acknowledge and accept the resignation of Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE as a manager of the Company,

which shall take effect on 17 July 2012 and to fully grant discharge to Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE for the
performance of its duties as manager of the Company until then.

4. Miscellaneous.
After deliberation, whereas pursuant to Article 189 of the Law on Commercial Companies of 10 August 1915, as

amended, the agreement of the shareholders representing three-quarters of the share capital of the Company is necessary
prior to the contribution and transfer of shares of the Company to a non shareholder, the following resolutions were
taken unanimously:

<i>First resolution

After deliberation, the meeting of shareholders acknowledges and accepts the transfer of the registered office of the

Company from:

(i) 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; to
(ii) 16, rue Dr. Ernest Feltgen, L-7531 Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.
As a consequence Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 3. Registered office.
3.1 The registered office of the Company is established in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg .
3.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

3.3 However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company

within the municipality of Mersch.

3.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board
of Managers of the Company.

3.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad."

<i>Second resolution

The Extraordinary Meeting of Shareholders unanimously resolves to approve the contribution and transfer of forty-

two (42) shares in the Company with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100,-) from Mr Pierre Alexandre

120696

L

U X E M B O U R G

DELAGARDELLE, residing in 12 rue André Duchscher, L-1424 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Mr John
Michael Preston, residing in L-8024 Strassen, 30A, rue Henri Dunant, for a purchase price of one Euro (EUR 1,-).

As a consequence of this transfer, the shares are held in the following manner:
1) Mr John PRESTON, professionally residing in 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132, Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg:

eighty-four (84) shares,
2) Mr Roland HABER, professionally residing in 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132, Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg:

forty-two (42) shares.
Total: one hundred and twenty-six shares 126

<i>Third resolution

The Extraordinary Meeting of Shareholders acknowledges and accepts the resignation of Dr Pierre Alexandre DELA-

GARDELLE as a manager of the Company which shall take effect on 17 July 2012 and the meeting of shareholders resolves,
without reservation, to fully grant discharge to Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE for the performance of its duties
as Manager of the Company until then.

Nothing further being on the agenda and no one asking to speak, the meeting was adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix-sept juillet.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de "EU Research Fund General Partner S.à r.l.", une

société à responsabilité limitée, avec siège social au 24, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, enregistrée auprès
le Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 161.673, constituée suivante acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2024 du 1 

er

 septembre 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE, demeurant professionnellement

au 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, domicilié professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
- que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des ac-
tionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.

- conformément à la liste de présence, les douze mille six cents Euros (EUR 12.600,-) représentés par cent vingt-six

(126) parts représentant tout le capital social de la Société, sont représentés de sorte que l'assemblée peut valablement
délibérer sur tous les points de l'ordre du jour dont les associés ont été informés auparavant.

- que la présente assemblée des associés est valablement constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre

du jour qui suit:

Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Le transfert du siège social de la Société de:
(i) 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; à
(ii) 16, rue. Dr. Ernest Feltgen, L-7531 Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,
2. Approbation et ratification du transfert de quarante-deux (42) parts de la Société d'une valeur nominale de cent

euros (EUR 100,-) de Monsieur Pierre Alexandre DELAGARDELLE, demeurant au 12, rue André Duchscher, L-1424
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à Monsieur John Michael Preston, demeurant à L-8024 Strassen, 30A, rue
Henri Dunant, pour un prix de vente d'un Euro (EUR 1,-).

120697

L

U X E M B O U R G

3. Prise de connaissance et acceptation de la démission de Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE de son poste de

gérant de la Société, qui prendra effet le 17 juillet 2012 et décharge complète à Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE
pour l'exécution de son mandat comme gérant de la Société jusqu'à cette date.

4. Divers.
Après délibération, alors que suivant l'article 189 de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915, telle que

modifiée, l'accord d'associés représentant les trois quarts du capital social est nécessaire pour la contribution et la cession
de parts de la Société à un non-associé, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Après délibération, l'assemblée des associés approuve et accepte le transfert du siège social de la Société de:
(i) 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; à
(ii) 16, rue. Dr. Ernest Feltgen, L-7531 Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,
En conséquence l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 3. Siège social.
3.1 Le siège social de la Société est établi à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
3.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

3.3 Toutefois, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la commune de

Mersch.

3.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être  transféré  provisoirement  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance de la
Société.

3.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée extraordinaire des associés approuve et ratifie à l'unanimité le transfert de quarante-deux (42) parts de

la Société d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) de Monsieur Pierre Alexandre DELAGARDELLE, demeurant
au 12, rue André Duchscher, L-1424 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à Monsieur John Michael Preston,
demeurant à L-8024 Strassen, 30A, rue Henri Dunant, pour un prix de vente d'un Euro (EUR 1,-).

En conséquence de ce transfert, les parts sont détenues de la manière suivante:
1) Monsieur John PRESTON, residant professionnellement au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132, Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg:

quatre-vingt-quatre (84) parts,
2) Monsieur Roland HABER, résidant professionnellement au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132, Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg:

quarante-deux (42) parts
Total: cent vingt-six parts 126

<i>Troisième résolution

L'assemblée extraordinaire des associés prend connaissance et accepte la démission de Dr Pierre Alexandre DELA-

GARDELLE de son poste de gérant de la Société, qui prendra effet le 17 juillet 2012 et donne décharge complète à Dr
Pierre Alexandre DELAGARDELLE pour l'exécution de son mandat comme gérant de la Société jusqu'à cette date.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. A. Delagardelle, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35305. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

120698

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Référence de publication: 2012119049/176.
(120161153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Elles s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 136.333.

La société AD CORPORATE SERVICES S.A.R.L. dénonce le contrat de domiciliation du 6 février 2008 et le siège social

mis à disposition au 165A, Route de Longwy à L - 4751 PETANGE de la société ELLES s. à r.l., immatriculée au RCSL
sous le numéro B 136333, avec effet immédiat pour résiliation du contrat.

Pétange, le 31 août 2012.

Signature
<i>LE DOMICILIATAIRE

Référence de publication: 2012119042/12.
(120161253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Knockon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 132.397.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 août 2012

Server Group Europe S.A. a été révoquée de son poste de commissaire aux comptes de la société.
Luxembourg Offshore Management Company S.A., en abrégé LOMAC S.A., immatriculée au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 22206, ayant son siège social 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, a été
élue au poste de commissaire aux comptes de la société. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui sera tenue en 2013.

Référence de publication: 2012119150/13.
(120161185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Golden Heights S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 117.313.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du 19

juin 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1607 du 24 août 2006;

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en

date du 14 novembre 2011 que les mandats des membres du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
actuellement en fonction sont renouvelés, à savoir:

1) aux postes d’administrateurs:
- Monsieur Sten WARBORN, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à GB-GUILDFORD GU 48 HR,

Grove Cottage, Shalford,

- Monsieur Bengt WARBORN, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à Madalena, Villa Nova de Gaia

(Portugal), rua Moinho de Vento 125, Edificio B Andar 3 DTO 3,

- Monsieur Sverker ALBREKTSON, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à S-41266 Götteborg, Saint

Sigfridsgatan, 83B,

2) au poste de commissaire aux comptes:
- La société REVILUX S.A., avec siège social à L-2450 LUXEMBOURG, 17, boulevard Roosevelt, inscrite au R.C.S.

LUXEMBOURG sous le numéro B-25.549.

Tous ces mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Luxembourg, le 19 septembre 2012.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2012119087/26.
(120161127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

120699

L

U X E M B O U R G

Luvefi-Developpement S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 144.386.

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 5 septembre 2012

Est nommé gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur

Guy HORNICK, gérant démissionnaire:

- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L - 1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2012.

Référence de publication: 2012119192/15.
(120161199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Moncour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.596.

Suite à l'assemblée générale annuelle de la Société en date du 12 septembre 2012 la décision suivante a été prise:
1. Le mandat du Reviseur d'entreprises agréé suivant est renouvelé à compter du 6 décembre 2011 jusqu'à l'assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2017:

La société Ernst &amp; Young S.A., ayant son siège social au Parc d'Activité Sydrall 2, L-5365 Munsbach, et immatriculée

sous le numéro B47771 avec le Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg et en tant que Réviseur d'entreprises
agréé de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Moncour S.à r.l.
Marco Weijermans
<i>Gérant A

Référence de publication: 2012119219/18.
(120160961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Sofia Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.523.

Le siège social du commissaire aux comptes HRT Révision S.A. a changé et se trouve à présent au 163, rue du Kiem,

L-8030 Strassen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2012.

Référence de publication: 2012119342/11.
(120160992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Matrix EPH 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 123.530.

<i>Extrait des résolutions des associés du 11 septembre 2012

Il résulte des dites résolutions que:
1. Mr. Ian Blake, demeurant professionnellement One Vine Street, London, W1J OAH Great Britain à démissionné de

sa fonction de Geschäftsführer de la Société avec effet au 11 Septembre 2012.

120700

L

U X E M B O U R G

2. Mr. Philip Gittins demeurant professionnellement 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé Ge-

schäftsführer de la Société avec effet au 11 Septembre 2012 pour une durée indéterminée.

3. Mr. Anthony Smedley demeurant professionnellement 31 Gresham Street, London EC2V 7QA United Kingdom a

été nommé Geschäftsführer de la Société avec effet au 11 Septembre 2012 pour une durée indéterminée.

Les adresses des Geschäftsführer ont été modifiée avec effet au 5 décembre 2011
- Monsieur Costas Constantinides, Geschäftsführer, né le 17 septembre 1979 à Nicosie, Chypre, demeurant profes-

sionnellement au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; et

- Monsieur Russell Perchard, Geschäftsführer, né le 16 janvier 1978 à Jersey, demeurant professionnellement au 40,

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Mr. Philip Gittins, Geschäftsführer
- Mr. Russell Perchard, Geschäftsführer
- Mr. Anthony Smedley, Geschäftsführer
- Mr. Stephen Coe, Geschäftsführer
- Mr. Costas Constantinides, Geschäftsführer

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 18 Septembre 2012.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2012119203/32.
(120160969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Matrix German Portfolio No 1 Celle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.625,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 112.075.

<i>Extrait des résolutions des associés du 11 septembre 2012

Il résulte des dites résolutions que:
1. Mr. Ian Blake, demeurant professionnellement One Vine Street, London, W1J OAH Great Britain à démissionné de

sa fonction de Gérant de la Société avec effet au 11 Septembre 2012.

2. Mr. Philip Gittins demeurant professionnellement 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé Ge-

schäftsführer de la Société avec effet au 11 Septembre 2012 pour une durée indéterminée.

3. Mr. Anthony Smedley demeurant professionnellement 31 Gresham Street, London EC2V 7QA United Kingdom a

été nommé Geschäftsführer de la Société avec effet au 11 Septembre 2012 pour une durée indéterminée.

Les adresses des Geschäftsführer ont été modifiée avec effet au 5 décembre 2011
- Monsieur Costas Constantinides, Geschäftsführer, né le 17 septembre 1979 à Nicosie, Chypre, demeurant profes-

sionnellement au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; et

- Monsieur Russell Perchard, Geschäftsführer, né le 16 janvier 1978 à Jersey, demeurant professionnellement au 40,

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Mr. Philip Gittins, Geschäftsführer
- Mr. Russell Perchard, Geschäftsführer
- Mr. Anthony Smedley, Geschäftsführer
- Mr. Stephen Coe, Geschäftsführer
- Mr. Costas Constantinides, Geschäftsführer

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 18 Septembre 2012.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2012119204/32.
(120160971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

120701

L

U X E M B O U R G

Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.625,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 112.076.

<i>Extrait des résolutions des associés du 11 septembre 2012

Il résulte des dites résolutions que:
1. Mr. Ian Blake, demeurant professionnellement One Vine Street, London, W1J OAH Great Britain à démissionné de

sa fonction de Gérant de la Société avec effet au 11 Septembre 2012.

2. Mr. Philip Gittins demeurant professionnellement 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé Ge-

schäftsführer de la Société avec effet au 11 Septembre 2012 pour une durée indéterminée.

3. Mr. Anthony Smedley demeurant professionnellement 31 Gresham Street, London EC2V 7QA United Kingdom a

été nommé Geschäftsführer de la Société avec effet au 11 Septembre 2012 pour une durée indéterminée.

Les adresses des Geschäftsführer ont été modifiée avec effet au 5 décembre 2011
- Monsieur Costas Constantinides, Geschäftsführer, né le 17 septembre 1979 à Nicosie, Chypre, demeurant profes-

sionnellement au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; et

- Monsieur Russell Perchard, Geschäftsführer, né le 16 janvier 1978 à Jersey, demeurant professionnellement au 40,

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Mr. Philip Gittins, Geschäftsführer
- Mr. Russell Perchard, Geschäftsführer
- Mr. Anthony Smedley, Geschäftsführer
- Mr. Stephen Coe, Geschäftsführer
- Mr. Costas Constantinides, Geschäftsführer

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 18 Septembre 2012.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2012119205/32.
(120160970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Matrix German Portfolio No. 1 Frankfurt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.050,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 117.358.

<i>Extrait des résolutions des associés du 11 septembre 2012

Il résulte des dites résolutions que:
1. Mr. Ian Blake, demeurant professionnellement One Vine Street, London, W1J OAH Great Britain à démissionné de

sa fonction de Geschäftsführer de la Société avec effet au 11 Septembre 2012.

2. Mr. Philip Gittins demeurant professionnellement 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé Ge-

schäftsführer de la Société avec effet au 11 Septembre 2012 pour une durée indéterminée.

3. Mr. Anthony Smedley demeurant professionnellement 31 Gresham Street, London EC2V 7QA United Kingdom a

été nommé Geschäftsführer de la Société avec effet au 11 Septembre 2012 pour une durée indéterminée.

Les adresses des Geschäftsführer ont été modifiée avec effet au 5 décembre 2011
- Monsieur Costas Constantinides, Geschäftsführer, né le 17 septembre 1979 à Nicosie, Chypre, demeurant profes-

sionnellement au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; et

- Monsieur Russell Perchard, Geschäftsführer, né le 16 janvier 1978 à Jersey, demeurant professionnellement au 40,

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Mr. Philip Gittins, Geschäftsführer
- Mr. Russell Perchard, Geschäftsführer

120702

L

U X E M B O U R G

- Mr. Anthony Smedley, Geschäftsführer
- Mr. Stephen Coe, Geschäftsführer
- Mr. Costas Constantinides, Geschäftsführer

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 18 Septembre 2012.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2012119207/32.
(120160967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Metro, Société Anonyme.

Siège social: L-9278 Diekirch, 9, rue Sauerwiss.

R.C.S. Luxembourg B 98.022.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 26 juillet

<i>2012 à 11.00 heures

Suite au décès de Monsieur Joseph JACOB administrateur de la société, l'assemblée générale décide à l'unanimité de

nommer au poste d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2016 Madame Marie-Louise JACOB-
ZIGER, née à Luxembourg le 12.05.1944, demeurant à L - 9278 Diekirch, 9, Rue Sauerwiss.

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.
Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2016.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2012119238/17.
(120160907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Precious Objects S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 147.762.

<i>Extrait des résolutions prises par l'unique actionnaire du 26 avril 2012

Il résulte des résolutions prisent par l'unique actionnaire le 26 avril 2012 que:
- Suite à la démission de Madame Bos Marie-Anne de sa fonction d'Administrateur, est nommé, la société DMS Ma-

nagement Services (Luxembourg) S.à r.l. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B165956, ayant son siège social au 43, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg et ce, avec effet immédiat et jusqu'à
la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18/09/2012.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012119287/17.
(120161148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Matrix St Etienne Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.591.

<i>Extrait des résolutions des associés du 11 septembre 2012

Il résulte des dites résolutions que:
1. Mr. Ian Blake, demeurant professionnellement One Vine Street, London, W1J OAH Great Britain à démissionné de

sa fonction de Gérant de la Société avec effet au 11 Septembre 2012.

120703

L

U X E M B O U R G

2. Mr. Philip Gittins demeurant professionnellement 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé Gérant

de la Société avec effet au 11 Septembre 2012 pour une durée indéterminée.

3. Mr. Anthony Smedley demeurant professionnellement 31 Gresham Street, London EC2V 7QA United Kingdom a

été nommé Gérant de la Société avec effet au 11 Septembre 2012 pour une durée indéterminée.

Les adresses des Gérant ont été modifiée avec effet au 5 décembre 2011
- Monsieur Costas Constantinides, Gérant, né le 17 septembre 1979 à Nicosie, Chypre, demeurant professionnelle-

ment au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; et

- Monsieur Russell Perchard, Gérant, né le 16 janvier 1978 à Jersey, demeurant professionnellement au 40, Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg;

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Mr. Philip Gittins, Gérant
- Mr. Russell Perchard, Gérant
- Mr. Anthony Smedley, Gérant
- Mr. Stephen Coe, Gérant
- Mr. Costas Constantinides, Gérant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 18 Septembre 2012.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2012119212/32.
(120160968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Portman Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 164.469.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Référence de publication: 2012119264/10.
(120161106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Northam Property Funds Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 335.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 140.838.

Par résolution prise en date du 4 août 2010 le Conseil de Gérance a pris la décision suivante:

<i>Alleiniger Beschluss

Der Vorstand beschliesst, die Vollmacht der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten bezüglich ihrer Tagesge-

schäfte auf Herrn Thomas Melchior, Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit, Geschäftsadresse 2,
Route de Mondorf, L-3260 Peppange, Luxembourg, zu übertragen und ihn mit weitreichenden Befugnissen auszustatten,
Verwaltungshandlungen in den Interessen der Gesellschaft und des Fonds auszuüben.

Folglich beschliesst der Vorstand die Ermächtigung Herrn Thomas Melchiors, Management-und Geschäftsangelegen-

heiten der Gesellschaft zu bestimmen und als alleiniger Zeichnungsberechtigter im Namen der Gesellschaft alle Verwal-
tungshandlungen in den Interessen der Gesellschaft und des Fonds umzusetzen

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2012.

Référence de publication: 2012119249/19.
(120160984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

120704

L

U X E M B O U R G

Plo Luximmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 400.000,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 166.210.

<i>Extrait de résolution de l'associé unique du 19 juillet 2012

L'associé unique de la société PLO LUXIMMO S.à.r.l. a décidé, en date du 19 juillet 2012, de prendre les résolutions

suivantes:

La démission de:
- Monsieur Emile DI SERIO, chef d'entreprise, demeurant à F-69840 Chenas, Le Bief
de son poste de gérant de la société est accepté à l'unanimité.
Par conséquent, l'assemblée générale décide de nommer:
- Monsieur Max GALOWICH, juriste, né le 30 juillet 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 4, rue

Henri Schnadt

au poste de gérant de la société.
Par la même occasion, l'associé unique décide de changer de siège social.
Le siège se trouve désormais au:
4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Pour extrait conforme
Emile DI SERIO
<i>L'associé unique

Référence de publication: 2012119284/25.
(120160915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Pyxis Partners S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 22, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 100.658.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 2012

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 31 juillet 2012:
L’assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social de la société au:
- 22, rue de Mühlenbach L-2168 Luxembourg.
Suite à la démission de Madame Anna-Maria GENCO de son poste d’Administrateur Unique, l’Assemblée nomme en

remplacement à compter du 31 juillet 2012 et jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2018:

- Monsieur Michel THIBAL, né le 8 juillet 1951 à Carcassonne (France), demeurant à L-9233 Diekirch, 12, avenue de

la Gare.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2012119293/17.
(120161040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Queensgate Investments Fund I, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 167.648.

1. Exit of a Limited Partner and Increase of the Commitment of an existing Limited Partner. Vandalay Capital Limited

(A) with its registered office at Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands and registered
with the Registry of Commerce of the British Virgin Islands under the number 1402391 exited the Partnership on 20
March 2012 while Red Rock Limited with its registered office at Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,
British Virgin Island and registered with the Registry of Commerce of the British Virgin Island under the number 5751
increased its Commitment from one hundred sixty-eight thousand pounds (GBP 168,000.-) to two hundred fifty-one
thousand five hundred pounds (GBP 251,500.-).

120705

L

U X E M B O U R G

2. Transfer and Novation of a portion of Commitment of a Limited Partner and Admission of a new Limited Part-

ner. ABS Holding Limited with its registered office at C/O Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands and registered with the Registry of Commerce of Cayman Islands with the number
C08011019, on 20 April 2012, transferred and novated 90,90% of its Commitment representing ten million pounds (GBP
10,000,000.-) to LJ Capital (Mauritius) Limited with registered office at C/O Kross Border Trust Services Limited, St.
Louis Business Centre, Cnr Desroches &amp; St. Louis Streets, Port Louis, Mauritius and retained 9,10% of its initial Com-
mitment representing one million pounds (GBP 1,000,000.-).

As of 20 April 2012, LJ Capital (Mauritius) Limited has been admitted as an (A) Investor in the Partnership and has

made a Commitment of ten million pounds (GBP 10,000,000.-) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof
representing an amount of one hundred thousand pounds (GBP 100,000.-) and a Premium Contribution of 99% thereof
representing an amount of nine million nine hundred thousand pounds (GBP 9,900,000.-) in consideration of which it has
received one (1) Interest in the Partnership.

3. Exit of a Limited Partner following the transfer and Novation of its Commitment and Admission of a new Limited

Partner. LJ Capital (Mauritius) Limited, with its registered office is at C/O Kross Border Trust Services Limited, St. Louis
Business Centre, Cnr Desroches &amp; St. Louis Streets, Port Louis, Mauritius, exited the Partnership on 24 April 2012
following the transfer and novation of its entire Commitment to Prime Special Investment Portfolio I whose registered
office is at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 registered with the Registry of Commerce of Cayman
Islands.

As of 24 April 2012, Prime Special Investment Portfolio I has been admitted as an (A) Investor in the Partnership and

it has made a Commitment of ten million pounds (GBP 10,000,000.-) which is composed of a Capital Contribution of 1%
thereof representing an amount of one hundred thousand pounds (GBP 100,000.-) and a Premium Contribution of 99%
thereof representing an amount of nine million nine hundred thousand pounds (GBP 9,900,000.-) in consideration of
which it received one (1) Interest in the Partnership.

4. Funding of Commitments by the Limited Partners. On 18 May 2012, the Limited Partners funded a portion of 3.5%

of their respective Commitments as follows:

I. Lavane Limited with its registered office at Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2 floor, P.C 1066, Nicosia, Cyprus

and registered with the Registry of Commerce of Nicosia under the number HE269653 has been admitted as an (A)
Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment of fifty million pounds (GBP 50,000,000.-).

Lavane Limited funded an amount of 3.5% of its Commitment representing one million seven hundred and fifty pounds

(GBP 1,750,000.-) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an amount of five hundred
thousand pounds (GBP 500,000.-) and a Premium Contribution of 2.5% thereof representing an amount of one million
two hundred fifty thousand pounds (GBP 1,250,000.-).

As of 18 May 2012, Lavane Limited remains liable for an amount of forty-eight million two hundred and fifty thousand

pounds (GBP 48,250,000.-) representing Premium Contribution.

II. Serimnir Fund with its registered office at 20, Boulevard Emmanuel Servais, L–2535, Luxembourg and registered

with the Registry of Commerce of Luxembourg under the number B 137142 has been admitted as a (B) Investor in the
Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment of twenty million pounds (GBP 20,000,000.-).

Serimnir Fund funded an amount of 3.5% of its Commitment representing seven hundred thousand pounds (GBP

700,000.-) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an amount of two hundred thousand
pounds (GBP 200,000.-) and a Premium Contribution of 2.5% thereof representing an amount of five hundred thousand
pounds (GBP 500,000.-).

As of 18 May 2012, Serimnir Fund remains liable for an amount of thirteen million pounds (GBP 13,000,000.-) repre-

senting Premium Contribution.

III. ABS Holdings Limited with its registered office at C/O Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,

Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands and registered with the Registry of Commerce of Cayman Islands under the
number C08011019 has been admitted as a (B) Investor in the Partnership as of 19 March 2012. Following the transfer
of a portion of its initial Commitment on 20 April 2012, ABS Holdings Limited has a Commitment of one million pounds
(GBP 1,000,000.-).

ABS Holdings Limited funded an amount of 3.5% of its Commitment representing thirty-five thousand pounds (GBP

35,000.-) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an amount of ten thousand pounds
(GBP 10,000) and a Premium Contribution of 2.5% thereof representing an amount of twenty-five thousand pounds (GBP
25,000.-).

As of 18 May 2012, ABS Holdings Limited remains liable for an amount of nine hundred sixty-five thousand pounds

(GBP 965,000.-) representing Premium Contribution.

IV. Alexey Kukura, born on 22 April 1979, in Russia, having its residence at 44 Lowndes Square, Flat 3, SW1X 9JT,

London, United Kingdom has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made
a Commitment of one million pounds (GBP 1,000,000.-).

120706

L

U X E M B O U R G

Alexey Kukura funded an amount of 3.5% of its Commitment representing thirty-five thousand pounds (GBP 35,000.-)

which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an amount of ten thousand pounds (GBP 10,000)
and a Premium Contribution of 2.5% thereof representing an amount of twenty-five thousand pounds (GBP 25,000.-).

As of 18 May 2012, Alexey Kukura remains liable for an amount of nine hundred sixty-five thousand pounds (GBP

965,000.-) representing Premium Contribution.

V. Paisy Inc with its registered office at Offices of International Trust Company B.V.I. Limited, P.O. Box 659, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands and registered with the Registry of Commerce of the British Virgin Islands under
the number 6556 has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Com-
mitment of one hundred sixty eight thousand pounds (GBP 168,000.-).

Paisy Inc funded an amount of 3.5% of its Commitment representing five thousand eight hundred and eighty pounds

(GBP 5,880.-) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an amount of one thousand six
hundred and eighty pounds (GBP 1,680.-) and a Premium Contribution of 2.5% thereof representing an amount of four
thousand two hundred pounds (GBP 4,200.-).

As of 18 May 2012, Paisy Inc remains liable for an amount of one hundred sixty-two thousand one hundred and twenty

pounds (GBP 162,120.-) representing Premium Contribution.

VI. Di Santo Investments Inc with its registered office at the Office of Sucre &amp; Sucre Bahamas Limited, Village Road

North, P.O. Box N-4589, Island of New Providence and registered with the Registry of Commerce of the Commonwealth
of the Bahamas under the number 153153 (B) has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March
2012 and has made a Commitment of one hundred sixty eight thousand pounds (GBP 168,000.-).

Di Santo Investments Inc funded an amount of 3.5% of its Commitment representing five thousand eight hundred and

eighty pounds (GBP 5,880.-) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an amount of one
thousand six hundred and eighty pounds (GBP 1,680.-) and a Premium Contribution of 2.5% thereof representing an
amount of four thousand two hundred pounds (GBP 4,200.-).

As of 18 May 2012, Di Santo Investments Inc remains liable for an amount of one hundred sixty-two thousand one

hundred and twenty pounds (GBP 162,120.-) representing Premium Contribution.

VII. Red Rock Limited with its registered office at Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin

Island and registered with the Registry of Commerce of the British Virgin Island under the number 5751, has been admitted
as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and, as of 20 March 2012 it has increased its Commitment to
hundred fifty-one thousand five hundred pounds (GBP 251,500.-).

Red Rock Limited funded an amount of 3.5% of its Commitment representing eight thousand eight hundred and two

pounds and fifty pence (GBP 8,802.50) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an amount
of o thousand five hundred and fifteen pounds (GBP 2,515.-) and a Premium Contribution of 2.5% thereof representing
an amount of six thousand two hundred eighty-seven pounds and fifty pence (GBP 6,287.50).

As of 18 May 2012, Red Rock Limited remains liable for an amount of two hundred forty-two thousand and six hundred

ninety-seven pounds and fifty pence (GBP 242,697.50) representing Premium Contribution.

VIII. CLL Investment Holdings Limited with its registered office at Flemming House, Wickhams Cay, P.O. Box 662,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands and registered with the Registry of Commerce of Bahamas under the number
154656 B, has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment
of one hundred sixty eight thousand pounds (GBP 168,000.-).

CLL Investment Holdings Limited funded an amount of 3.5% of its Commitment representing five thousand eight

hundred and eighty pounds (GBP 5,880.-) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an
amount of one thousand six hundred and eighty pounds (GBP 1,680.-) and a Premium Contribution of 2.5% thereof
representing an amount of four thousand two hundred pounds (GBP 4,200.-).

As of 18 May 2011, CLL Investment Holdings remains liable for an amount of one hundred sixty-two thousand one

hundred and twenty pounds (GBP 162,120.-) representing Premium Contribution.

IX. Sandman Capital LLC with its registered office at 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, Delaware 19901 and

registered with the Registry of Commerce of Montgomery County, Pennsylvania under the number 5034595, has been
admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment of eighty three thousand
one hundred fifty-five pounds (GBP 83,155.-).

Sandman Capital LLC funded an amount of 3.5% of its Commitment representing two thousand nine hundred and ten

pounds and forty-three pence (GBP 2,910.43) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing
an amount of eight hundred thirty-one pounds and fifty-five pence (GBP 831.55) and a Premium Contribution of 2.5%
thereof representing an amount of two thousand seventy-eight pounds and eighty-eight pence (GBP 2,078.88).

As of 18 May 2012, Sandman Capital LLC remains liable for an amount of eighty thousand two hundred and forty-four

pounds and fifty-seven pence (GBP 80,244.57) representing Premium Contribution.

X. LRV Limited with its registered office at Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands and registered with the Registry of Commerce of the British Virgin Islands under the number 685842, has
been admitted as an (A) Investor in the Partnership on 19 March 2012 and it has made a Commitment of one hundred
four thousand six hundred five pounds (GBP 104,605.-).

120707

L

U X E M B O U R G

LRV Limited funded an amount of 3.5% of its Commitment representing three thousand six hundred and sixty-one

pounds and eighteen pence (GBP 3,661.18) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an
amount of one thousand forty-six pounds and five penny (GBP 1,046.05) and a Premium Contribution of 2.5% thereof
representing an amount of two thousand six hundred fifteen pounds and thirteen pence (GBP 2,615.13).

As of 18 May 2012, LRV Limited remains liable for an amount of one hundred thousand nine hundred and forty-three

pounds and eighty-two pence (GBP 100,943.82) representing Premium Contribution.

XI. Santo Espiritu Inc with its registered office at Flemming House, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola,

British  Virgin  Islands  and  registered  with  the  Registry  of  Commerce  of  the  British  Virgin  Islands  under  the  number
1595715, has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment
of three hundred twenty two thousand nine hundred pounds (GBP 322,900.-).

Santo Espiritu Inc funded an amount of 3.5% of its Commitment representing eleven thousand three hundred and one

pounds and fifty pence (GBP 11,301.50) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an
amount of three thousand two hundred and twenty-nine pounds (GBP 3,229.-) and a Premium Contribution of 2.5%
thereof representing an amount of eight thousand seventy-two pounds and fifty pence (GBP 8,072.50).

As of 18 May 2012, Santo Espiritu Inc remains liable for an amount of three hundred eleven thousand five hundred

ninety-eight pounds and fifty pence (GBP 311,598.50) representing Premium Contribution.

XII. El Sauce Investment Inc with its registered office at Cititrust (Bahamas) Limited in the Citibank Building, Thompson

Boulevard, P.O. Box N-1576, Nassau, Island of New Providence, the Bahamas, and registered with the Registry of Com-
merce of the Esquipulas Private Foundation under the number 120074 (0), has been admitted as an (A) Investor in the
Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment of three hundred twenty two thousand nine hundred
pounds (GBP 322,900.-).

El Sauce Investment Inc funded an amount of 3.5% of its Commitment representing eleven thousand three hundred

and one pounds and fifty pence (GBP 11,301.50) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing
an amount of three thousand two hundred and twenty-nine pounds (GBP 3,229.-) and a Premium Contribution of 2.5%
thereof representing an amount of eight thousand seventy-two pounds and fifty pence (GBP 8,072.50).

As of 18 May 2012, El Sauce Investment Inc remains liable for an amount of three hundred eleven thousand five hundred

and ninety-eight pounds and fifty pence (GBP 311,598.50) representing Premium Contribution.

XIII. Blackrock Park Investments Limited with its registered office at Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands and registered with the Registry of Commerce of the British Virgin Islands under
the number 1607018, has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a
Commitment of eighty two thousand six hundred forty five pounds (GBP 82,645.-).

Blackrock Park Investments Limited funded an amount of 3.5% of its Commitment representing two thousand eight

hundred and ninety-two pounds and fifty-eight pence (GBP 2,892.58) which is composed of a Capital Contribution of 1%
thereof representing an amount of eight hundred and twenty-six pounds and forty-five pence (GBP 826.45) and a Premium
Contribution  of  2.5%  thereof  representing  an  amount  of  two  thousand  sixty-six  pounds  and  thirteen  pence  (GBP
2,066.13).

As of 18 May 2012, Blackrock Park Investments Limited remains liable for an amount of seventy-nine thousand seven

hundred and fifty-two pounds and forty-two pence (GBP 79,752.42) representing Premium Contribution.

XIV. Integra Orbis Corporation with its registered office at Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands and registered with the Registry of Commerce of the British Virgin Islands under the number
1605010, has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment
of eighty two thousand six hundred forty-five pounds (GBP 82,645.-).

Integra Orbis Corporation funded an amount of 3.5% of its Commitment representing two thousand eight hundred

and ninety-two pounds and fifty-eight pence (GBP 2,892.58) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof
representing  an  amount  of  eight  hundred  and  twenty-six  pounds  and  forty-five  pence  (GBP  826.45)  and  a  Premium
Contribution  of  2.5%  thereof  representing  an  amount  of  two  thousand  sixty-six  pounds  and  thirteen  pence  (GBP
2,066.13).

As of 18 May 2012, Integra Orbis Corporation remains liable for an amount of seventy-nine thousand seven hundred

and fifty-two pounds and forty-two pence (GBP 79,752.42) representing Premium Contribution.

XV. Dantooine Investors Inc with its registered office at Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands and registered with the Registry of Commerce of the British Virgin Islands under the number
1598679, has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment
of eighty two thousand six hundred forty-five pounds (GBP 82,645.-).

Dantooine Investors Inc funded an amount of 3.5% of its Commitment representing two thousand eight hundred and

ninety-two pounds and fifty-eight pence (GBP 2,892.58) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof
representing  an  amount  of  eight  hundred  and  twenty-six  pounds  and  forty-five  pence  (GBP  826.45)  and  a  Premium
Contribution  of  2.5%  thereof  representing  an  amount  of  two  thousand  sixty-six  pounds  and  thirteen  pence  (GBP
2,066.13).

120708

L

U X E M B O U R G

As of 18 May 2012, Dantooine Investors Inc remains liable for an amount of seventy-nine thousand seven hundred and

fifty-two pounds and forty-two pence (GBP 79,752.42) representing Premium Contribution.

XVI. Faciebat Corporation with its registered office at Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road Town, Tortola,

British  Virgin  Islands  and  registered  with  the  Registry  of  Commerce  of  the  British  Virgin  Islands  under  the  number
1598257, has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment
of eighty two thousand six hundred forty-five pounds (GBP 82,645.-).

Faciebat Corporation funded an amount of 3.5% of its Commitment representing two thousand eight hundred and

ninety-two pounds and fifty-eight pence (GBP 2,892.58) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof
representing  an  amount  of  eight  hundred  and  twenty-six  pounds  and  forty-five  pence  (GBP  826.45)  and  a  Premium
Contribution  of  2.5%  thereof  representing  an  amount  of  two  thousand  sixty-six  pounds  and  thirteen  pence  (GBP
2,066.13).

As of 18 May 2012, Faciebat Corporation Inc remains liable for an amount of seventy-nine thousand seven hundred

and fifty-two pounds and forty-two pence (GBP 79,752.42) representing Premium Contribution.

XVII. Aljopi Corporation with its registered office at Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road Town, Tortola,

British  Virgin  Islands  and  registered  with  the  Registry  of  Commerce  of  the  British  Virgin  Islands  under  the  number
1605007, has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and has made a Commitment of
eighty two thousand six hundred forty-five pounds (GBP 82,645.-).

Aljopi Corporation funded an amount of 3.5% of its Commitment representing two thousand eight hundred and ninety-

two pounds and fifty-eight pence (GBP 2,892.58) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing
an amount of eight hundred and twenty-six pounds and forty-five pence (GBP 826.45) and a Premium Contribution of
2.5% thereof representing an amount of two thousand sixty-six pounds and thirteen pence (GBP 2,066.13).

As of 18 May 2012, Aljopi Corporation remains liable for an amount of seventy-nine thousand seven hundred and fifty-

two pounds and forty-two pence (GBP 79,752.42) representing Premium Contribution.

XVIII. El Chepito Limited with its registered office at Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road Town, Tortola,

British  Virgin  Islands  and  registered  with  the  Registry  of  Commerce  of  the  British  Virgin  Islands  under  the  number
1619550, has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment
of eighty-two thousand six hundred forty-five pounds (GBP 82,645.-).

El Chepito Limited funded an amount of 3.5% of its Commitment representing two thousand eight hundred and ninety-

two pounds and fifty-eight pence (GBP 2,892.58) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing
an amount of eight hundred and twenty-six pounds and forty-five pence (GBP 826.45) and a Premium Contribution of
2.5% thereof representing an amount of two thousand sixty-six pounds and thirteen pence (GBP 2,066.13).

As of 18 May 2012, El Chepito Limited remains liable for an amount of seventy-nine thousand seven hundred and fifty-

two pounds and forty-two pence (GBP 79,752.42) representing Premium Contribution.

XIX. Gardenia Investments Group Limited with its registered office at Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands and registered with the Registry of Commerce of the British Virgin Islands
under the number 1619546, has been admitted as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made
a Commitment of eighty two thousand six hundred forty five pounds (GBP 82,645.-).

Gardenia Investments Group Limited funded an amount of 3.5% of its Commitment representing two thousand eight

hundred and ninety-two pounds and fifty-eight pence (GBP 2,892.58) which is composed of a Capital Contribution of 1%
thereof representing an amount of eight hundred and twenty-six pounds and forty-five pence (GBP 826.45) and a Premium
Contribution  of  2.5%  thereof  representing  an  amount  of  two  thousand  sixty-six  pounds  and  thirteen  pence  (GBP
2,066.13).

As of 18 May 2012, Gardenia Investments Group Limited remains liable for an amount of seventy-nine thousand seven

hundred and fifty-two pounds and forty-two pence (GBP 79,752.42) representing Premium Contribution.

XX. RBC cees Nominees Limited O0410/O1O06 with its registered office at 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey,

JE1 3PB, Channel Islands and registered with the Registry of Commerce of Jersey under the number 83756, has admitted
as an (A) Investor in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment of two hundred fifty thousand
pounds (GBP 250,000.-).

RBC cees Nominees Limited O0410/O1O06 funded an amount of 3.5% of its Commitment representing eight thousand

seven hundred and fifty pounds (GBP 8,750.-) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing
an amount of two thousand five hundred pounds (GBP 2,500.-) and a Premium Contribution of 2.5% thereof representing
an amount of six thousand two hundred and fifty pounds (GBP 6,250.-).

As of 18 May 2012, RBC cees Nominees Limited O0410/O1O06 remains liable for an amount of two hundred forty-

one thousand two hundred fifty pounds (GBP 241,250.-) representing Premium Contribution.

XXI. Hiking Corporation with its registered office at 28-30 The Parade, St Helier, Jersey, JE4 8XY, Channel Islands

and registered with the Registry of Commerce of Jersey under the number 78351, has been admitted as an (A) Investor
in the Partnership as of 19 March 2012 and it has made a Commitment of five hundred thousand pounds (GBP 500,000.-).

Hiking Corporation funded an amount of 3.5% of its Commitment representing seventeen thousand five hundred

pounds (GBP 17,500.-) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an amount of five thousand

120709

L

U X E M B O U R G

pounds (GBP 5,000.-) and a Premium Contribution of 2.5% thereof representing an amount of twelve thousand five
hundred pounds (GBP 12,500.-).

As of 18 May 2012, Hiking Corporation remains liable for an amount of four hundred eighty-two thousand five hundred

pounds (GBP 482,500.-) representing Premium Contribution.

XXII. Prime Special Investment Portfolio I with its registered office is at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,

KY1-1104 registered with the Registry of Commerce of Cayman Islands, has been admitted as an (A) Investor in the
Partnership as of 24 April 2012 and it has made a Commitment of ten million pounds (GBP 10,000,000.-).

Prime Special Investment Portfolio I funded an amount of 3.5% of its Commitment representing three hundred fifty

thousand pounds (GBP 350,000.-) which is composed of a Capital Contribution of 1% thereof representing an amount
of one hundred thousand pounds (GBP 100,000.-) and a Premium Contribution of 2.5% thereof representing an amount
of two hundred fifty thousand pounds (GBP 250,000.-).

As of 18 May 2012, Prime Special Investment Portfolio I remains liable for an amount of nine million six hundred fifty

thousand pounds (GBP 9,650,000.-) representing Premium Contribution.

5. Share capital. The entire share capital of the Partnership of eight hundred forty-nine thousand two hundred seventy-

five pounds and seventy-five penny (GBP 849,275.75) has been fully paid up.

EXTRAITS

1. Sortie d’un Associé Commanditaire et Augmentation de la Promesse d’Apport d’un Associé Commanditaire exi-

stant. Vandalay Capital Limited (A), ayant son siège social au Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, les
Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 1402391 a
quitté la Société le 20 Mars 2012 tandis que Red Rock Limited ayant son siège social Palm Grove House, P.O. Box 438,
Road Town, Tortola, les Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges Britanniques sous
le numéro 5751 a augmenté sa Promesse d’Apport de cent soixante-huit mille livres sterling (GBP 168.000) à deux cent
cinquante et un mille cinq cent livres sterling (GBP 251.500).

2. Transfert et Novation d’une partie de la Promesse d’Apport d’un Associé Commanditaire et Admission d’un nouvel

Associé Commanditaire dans la Société. ABS Holdings Limited, ayant son siège social au C/O Corporate Services Limited,
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, les Îles Cayman et inscrit au Registre de Commerce des Îles
Cayman sous le numéro C08011019, a transféré et nové, le 20 Avril 2012, 90.90% de sa Promesse d’Apport qui représente
dix millions de livres sterling (GBP 10.000.000) à LJ Capital (Mauritius) Limited ayant son siège social au C/O Kross Border
Trust Services Limited, St Louis Business Centre, Cnr Desroches &amp; St. Louis Streets, Port Louis, Îles Maurice et conserve
9.10% de sa Promesse d’Apport initiale, ce qui représente un million de livres sterling (GBP 1.000.000).

Le 20 Avril 2012, LJ Capital (Mauritius) Limited a été admis dans la Société comme Investisseur (A) et a fait une

Promesse d’Apport de dix millions de livres sterling (GBP 10.000.000) qui se compose d’un Apport en Numéraire de 1%
dudit montant représentant cent mille livres sterling (GBP 100.000) et d’une Prime d’Emission de 99% dudit montant
représentant neuf millions neuf cent mille livres sterling (GBP 9.900.000) et a reçu en contrepartie une (1) Part dans la
Société.

3. Transfert et Novation d’une Promesse d’Apport d’un Associé Commanditaire et Admission d’un nouvel Associé

Commanditaire dans la Société. LJ Capital (Mauritius) Limited, ayant son siège social au C/O Kross Border Trust Services
Limited, St Louis Business Centre, Cnr Desroches &amp; St. Louis Streets, Port Louis, Îles Maurice a quitté la Société le 24
Avril 2012 suivant le transfert et la novation de 100% de sa Promesse d’Apport dans la Société à Prime Special Investment
Portfolio I ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 et inscrit au Registre de
Commerce des Îles Cayman.

Le 24 Avril 2012, Prime Special Investments I a été admis dans la Société comme Investisseur (A) et a fait une Promesse

d’Apport de dix millions de livres sterling (GBP 10.000.000) qui se compose d’un Apport en Numéraire de 1% dudit
montant représentant cent mille livres sterling (GBP 100.000) et d’une Prime d’Emission de 99% dudit montant repré-
sentant neuf millions neuf cent mille livres sterling (GBP 9.900.000) et a reçu en contrepartie une (1) Part dans la Société.

4. Exécution des Promesses d’Apport. Le 18 Mai 2012, les Associés Commanditaires ont versé 3.5% de leurs Promesses

d’Apport comme suit:

I. Lavane Limited, ayant son siège social au Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2 

e

 étage, P.C 1066, Nicosia, Chypre

et inscrite au Registre de Commerce de Nicosie sous le numéro HE269653 a été admis dans la Société comme Investisseur
(A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de cinquante million de livres sterling (GBP 50.000.000).

Lavane Limited a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de un million sept cent cinquante mille

livres sterling (GBP 1.750.000) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un montant de cinq cent
mille livres sterling (GBP 500.000) et d’une Prime d’Emission de 2.5% représentant un montant de un million deux cent
cinquante mille livres sterling (GBP 1.250.000)

Au 18 Mai 2012, Lavane Limited reste redevable d’un montant de quarante-huit millions deux cent cinquante mille

livres sterling (GBP 48.250.000) représentant la Prime d’Emission.

120710

L

U X E M B O U R G

II. Serimnir Fund, ayant son siège social au 20, Boulevard Emmanuel Servais L–2535, Luxembourg et inscrit au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137142 a été admis dans la Société comme Investisseur
(B) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de vingt millions livres sterling (GBP 20.000.000).

Serimnir Fund a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de sept cent mille livres sterling (GBP

700.000) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un montant de deux cent mille livres sterling
(GBP 200.000) et d’une Prime d’Emission de 2.5% représentant un montant de cinq cent mille livres sterling (GBP 500.000).

Au 18 Mai 2012, Serimnir Fund reste redevable d’un montant de treize millions de livres sterling (GBP 13.000.000)

représentant la Prime d’Emission.

III. ABS Holdings Limited, ayant son siège social au C/O Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,

Grand  Cayman,  KY1-1104,  les  Îles  Cayman  et  inscrit  au  Registre  de  Commerce  des  Îles  Cayman  sous  le  numéro
C08011019 a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012. Le 20 Avril 2012, suivant le transfert
d’une partie de sa Promesse d’Apport initiale, ABS Holdings Limited a fait une Promesse d’Apport de un million de livres
sterling (GBP 1.000.000).

ABS Holdings Limited a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de trente-cinq mille livres

sterling (GBP 35.000) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un montant de dix mille livres
sterling (GBP 10,000) et d’une Prime d’Emission de 2.5% représentant un montant de vingt-cinq mille livres sterling (GBP
25.000).

Au 18 Mai 2012, ABS Holdings Limited reste redevable d’un montant de neuf cent soixante-cinq mille livres sterling

(GBP 965.000) représentant la Prime d’Emission.

IV. Alexey Kukura, né le 22 April 1979, en Russie, ayant sa résidence au 44 Lowndes Square, appartement 3, SW1X

9JT, Londres, Royaume-Uni a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse
d’Apport de un million livres sterling (GBP 1.000.000).

Alexey Kukura a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de trente-cinq mille livres sterling

(GBP 35.000) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un montant de dix mille livres sterling
(GBP 10.000) et d’une Prime d’Emission de 2.5% représentant un montant de vingt-cinq mille livres sterling (GBP 25.000)

Au 18 Mai 2012 Alexey Kukura reste redevable d’un montant de neuf cent soixante-cinq mille livres sterling (GBP

965.000) représentant la Prime d’Emission.

V. Paisy Inc, ayant son siège social au Offices of International Trust Company B.V.I. Limited, P.O. Box 659, Road Town,

Tortola, les Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro
6556 a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de cent soixante-
huit mille livres sterling (GBP 168.000).

Paisy Inc a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de cinq mille huit cent quatre vingt livres

sterling (GBP 5.880) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un montant de mille six cent quatre-
vingt livres sterling (GBP 1,680) et d’une Prime d’Emission de 2.5% représentant un montant de quatre mille deux cent
livres sterling (GBP 4,200)

Au 18 Mai 2012 Paisy Inc reste redevable d’un montant de cent soixante-deux mille cent vingt livres sterling (GBP

162,120) représentant la Prime d’Emission.

VI. Di Santo Investments Inc, ayant son siège social au Office of Sucre &amp; Sucre Bahamas Limited, Village Road North,

P.O. Box N-4589, Île de la Nouvelle Providence, Bahamas et inscrit au Registre de Commerce de Bahamas sous le numéro
153153 (B) a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de cent
soixante-huit mille livres sterling (GBP 168.000).

Di Santo Investments Inc a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de cinq mille huit cent

quatre-vingt livres sterling (GBP 5,880) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un montant de
mille six cent quatre-vingt livres sterling (GBP 1,680) et d’une Prime d’Emission de 2.5% représentant un montant de
quatre mille deux cent livres sterling (GBP 4,200).

Au 18 Mai 2012 Di Santo Investments Inc reste redevable d’un montant de cent soixante-deux mille cent vingt livres

sterling (GBP 162,120) représentant la Prime d’Emission.

VII. Red Rock Limited, une société de droit des Îles Vierges Britanniques, ayant son siège social au Palm Grove House,

P.O. Box 438, Road Town, Tortola, les Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges
Britanniques sous le numéro 5751 a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et, le 20 Mars
2012, a augmenté sa Promesse d’Apport à deux cent cinquante et un mille cinq cent livres sterling (GBP 251.500).

Red Rock Limited a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de huit mille huit cent deux livres

sterling et cinquante pence (GBP 8.802,50) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un montant
de deux mille cinq cent quinze livres sterling (GBP 2.515) et d’une Prime d’Emission de 2.5% représentant un montant
de six mille deux cent quatre-vingt-sept livres sterling et cinquante pence (GBP 6.287,50)

Au 18 Mai 2012 Red Rock Limited reste redevable d’un montant de deux cent quarante-deux six cent quatre-vingt-

sept livres sterling et cinquante pence (GBP 242.697,50) représentant la Prime d’Emission.

VIII. CLL Investment Holdings Limited, ayant son siège social au Flemming House, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road

Town, Tortola, les Îles Vierges Britanniques, et inscrit au Registre de Commerce de Bahamas sous le numéro 154656 B

120711

L

U X E M B O U R G

a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de cent soixante-
huit mille livres sterling (GBP 168.000).

CLL Investment Holdings Limited a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de cinq mille huit

cent quatre vingt livres sterling (GBP 5.880) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un montant
de mille six cent quatre-vingt livres sterling (GBP 1.680) et d’une Prime d’Emission de 2,5% représentant un montant de
quatre mille deux cent livres sterling (GBP 4.200).

Au 18 Mai 2012 CLL Investment Holdings Limited reste redevable d’un montant de cent soixante-deux mille cent vingt

livres sterling (GBP 162.120) représentant la Prime d’Emission.

IX. Sandman Capital LLC, ayant son siège social au 1679 S Dupont Highway, Suite 100, Dover, Delaware 19901, les

Etats-Unis et inscrit au Registre de Commerce de Montgomery County, Pennsylvanie sous le numéro 5034595 a été
admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de quatre-vingt-trois mille
cent cinquante-cinq livres sterling (GBP 83.155).

Sandman Capital LLC a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de deux mille neuf cent dix

livres sterling et quarante-trois pence (GBP 2.910,43) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant
un montant de huit cent trente et une livres sterling et cinquante-cinq pence (GBP 831,55) et d’une Prime d’Emission de
2,5% représentant un montant de deux mille soixante-dix-huit livres sterling et quatre-vingt-huit pence (GBP 2.078,88).

Au 18 Mai 2012 Sandman Capital LLC reste redevable d’un montant de quatre-vingt mille deux cent quarante-quatre

livres sterling et cinquante-sept pence (GBP 80.244,57) représentant la Prime d’Emission.

X. LRV Limited, ayant son siège social au Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, les Îles

Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 685842 a été admis
dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de cent quatre mille six cent
cinq livres sterling (GBP 104.605).

LRV Limited a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de trois mille six cent soixante et une

livres sterling et dix-huit pence (GBP 3.661,18) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un
montant de mille quarante-six livres sterling et cinq pence (GBP 1.046,05) et d’une Prime d’Emission de 2,5% représentant
un montant de deux mille six cent quinze livres sterling et treize pence (GBP 2.615,13).

Au 18 Mai 2012 LRV Limited reste redevable d’un montant de cent mille neuf cent quarante-trois livres sterling et

quatre-vingt-deux pence (GBP 100.943,82) représentant la Prime d’Emission.

XI. Santo Espiritu Inc, ayant son siège social au Flemming House, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola,

les Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 1595715
a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de trois cent vingt-
deux mille neuf cent livres sterling (GBP 322.900).

Santo Espiritu Inc a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant onze mille trois cent et une livres sterling et

cinquante pence (GBP 11.301,50) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un montant de trois
mille deux cent vingt-neuf livres sterling (GBP 3.229) et d’une Prime d’Emission de 2,5% représentant un montant de huit
mille soixante-douze livres sterling et cinquante pence (GBP 8.072,50).

Au 18 Mai 2012 Santo Espiritu Inc reste redevable d’un montant de trois cent onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-

huit livres sterling et cinquante pence (GBP 311.598,50) représentant la Prime d’Emission.

XII. El Sauce Investment Inc, ayant son siège social au Cititrust (Bahamas) Limited in the Citibank Building, Thompson

Boulevard, P.O. Box N-1576, Nassau, Île de la Nouvelle Providence, Bahamas et inscrit au Registre de Commerce de
Esquipulas Private Foundation sous le numéro 120074 (0) a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars
2012 et a fait une Promesse d’Apport de trois cent vingt-deux mille neuf cent livres sterling (GBP 322.900).

El Sauce Investment Inc a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de onze mille trois cent et

une livres sterling et cinquante pence (GBP 11.301,50) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant
un montant de trois mille deux cent vingt-neuf livres sterling (GBP 3.229) et d’une Prime d’Emission de 2,5% représentant
un montant de huit mille soixante-douze livres sterling et cinquante pence (GBP 8.072,50).

Au 18 Mai 2012 El Sauce Investment Inc reste redevable d’un montant de trois cent onze mille cinq cent quatre-vingt-

dix-huit livres sterling et cinquante pence (GBP 311.598,50) représentant la Prime d’Emission.

XIII. Blackrock Park Investments Limited, une société de droit des Îles Vierges Britanniques, ayant son siège social au

Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road Town, Tortola, les Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de
Commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 1607018 a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le
19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de quatre-vingt-deux mille six cent quarante-cinq livres sterling (GBP
82.645).

Blackrock Park Investments Limited a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de deux mille

huit cent quatre-vingt-douze livres sterling et cinquante-huit pence (GBP 2.892,58) qui est composé d’un Apport en
Numéraire de 1% représentant un montant de huit cent vingt-six livres sterling et quarante-cinq pence (GBP 826,45) et
d’une Prime d’Emission de 2,5% représentant un montant de deux mille soixante-six livres sterling et treize pence (GBP
2.066,13).

120712

L

U X E M B O U R G

Au 18 Mai 2012 Blackrock Park Investments Limited reste redevable d’un montant de soixante-dix-neuf mille sept cent

cinquante-deux livres sterling et quarante-deux pence (GBP 79.752,42) représentant la Prime d’Emission.

XIV. Integra Orbis Corporation, ayant son siège social au Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road Town,

Tortola, les Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro
1605010 a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de quatre-
vingt-deux mille six cent quarante-cinq livres sterling (GBP 82.645).

Integra Orbis Corporation a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de deux mille huit cent

quatre-vingt-douze livres sterling et cinquante-huit pence (GBP 2.892,58) qui est composé d’un Apport en Numéraire de
1% représentant un montant de huit cent vingt-six livres sterling et quarante-cinq pence (GBP 826,45) et d’une Prime
d’Emission de 2,5% représentant un montant de deux mille soixante-six livres sterling et treize pence (GBP 2.066,13).

Au 18 Mai 2012 Integra Orbis Corporation Limited reste redevable d’un montant de soixante-dix-neuf mille sept cent

cinquante-deux livres sterling et quarante-deux pence (GBP 79.752,42) représentant la Prime d’Emission.

XV. Dantooine Investors Inc, ayant son siège social au Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road Town, Tortola,

les Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 1598679
a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de quatre-vingt-
deux mille six cent quarante-cinq livres sterling (GBP 82.645).

Dantooine Investors Inc a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de deux mille huit cent

quatre-vingt-douze livres sterling et cinquante-huit pence (GBP 2.892,58) qui est composé d’un Apport en Numéraire de
1% représentant un montant de huit cent vingt-six livres sterling et quarante-cinq pence (GBP 826,45) et d’une Prime
d’Emission de 2,5% représentant un montant de deux mille soixante-six livres sterling et treize pence (GBP 2.066,13).

Au 18 Mai 2012 Dantooine Investors Inc reste redevable d’un montant de soixante-dix neuf mille sept cent cinquante-

deux livres sterling et quarante-deux pence (GBP 79.752,42) représentant la Prime d’Emission.

XVI. Faciebat Corporation, ayant son siège social au Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road Town, Tortola,

les Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 1598257
a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de quatre-vingt-
deux mille six cent quarante-cinq livres sterling (GBP 82.645).

Faciebat Corporation a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de deux mille huit cent quatre-

vingt-douze livres sterling et cinquante-huit pence (GBP 2.892,58) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1%
représentant un montant de huit cent vingt-six livres sterling et quarante-cinq pence (GBP 826,45) et d’une Prime d’Emis-
sion de 2,5% représentant un montant de deux mille soixante-six livres sterling et treize pence (GBP 2.066,13).

Au 18 Mai 2012 Faciebat Corporation reste redevable d’un montant de soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante-

deux livres sterling et quarante-deux pence (GBP 79.752,42) représentant la Prime d’Emission.

XVII. Aljopi Corporation, ayant son siège social au lemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road Town, Tortola,

les Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 1605007
a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de quatre-vingt-
deux mille six cent quarante-cinq livres sterling (GBP 82.645).

Aljopi Corporation a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de deux mille huit cent quatre-

vingt-douze livres sterling et cinquante-huit pence (GBP 2.892,58) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1%
représente un montant de huit cent vingt-six livres sterling et quarante-cinq pence (GBP 826,45) et d’une Prime d’Emission
de 2,5% représentant un montant de deux mille soixante-six livres sterling et treize pence (GBP 2.066,13).

Au 18 Mai 2012 Aljopi Corporation reste redevable d’un montant de soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante-deux

livres sterling et quarante-deux pence (GBP 79.752,42) représentant la Prime d’Emission.

XVIII. El Chepito Limited, ayant son siège social au Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road Town, Tortola,

les Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 1619550
a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de quatre-vingt-
deux mille six cent quarante-cinq livres sterling (GBP 82.645).

El Chepito Limited a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de deux mille huit cent quatre-

vingt-douze livres sterling et cinquante-huit pence (GBP 2.892,58) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1%
représentant un montant de huit cent vingt-six livres sterling et quarante-cinq pence (GBP 826,45) et d’une Prime d’Emis-
sion de 2,5% représentant un montant de deux mille soixante-six livres sterling et treize pence (GBP 2.066,13).

Au 18 Mai 2012 El Chepito Limited reste redevable d’un montant de soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante-deux

livres sterling et quarante-deux pence (GBP 79.752,42) représentant la Prime d’Emission.

XIX. Gardenia Investments Group Limited, ayant son siège social au Flemming House, Wickhams Cay, P.O. 662, Road

Town, Tortola, les Îles Vierges Britanniques et inscrit au Registre de Commerce des Îles Vierges Britanniques sous le
numéro 1619546 a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport
de quatre-vingt-deux mille six cent quarante-cinq livres sterling (GBP 82.645).

Gardenia Investments Group Limited a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de deux mille

huit cent quatre-vingt-douze livres sterling et cinquante-huit pence (GBP 2.892,58) qui est composé d’un Apport en
Numéraire de 1% représentant un montant de huit cent vingt-six livres sterling et quarante-cinq pence (GBP 826,45) et

120713

L

U X E M B O U R G

d’une Prime d’Emission de 2,5% représentant un montant de deux mille soixante-six livres sterling et treize pence (GBP
2.066,13).

Au 18 Mai 2012 Gardenia Investments Group Limited reste redevable d’un montant de soixante-dix-neuf mille sept

cent cinquante-deux livres sterling et quarante-deux pence (GBP 79.752,42) représentant la Prime d’Emission.

XX. RBC cees Nominees Limited O0410/O1O06, ayant son siège social au 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey, JE1

3PB, les Îles de la Manche et inscrit au Registre de Commerce de Jersey sous le numéro 83756 a été admis dans la Société
comme Investisseur (A) le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de deux cent cinquante mille livres sterling
(GBP 250.000).

RBC cees Nominees Limited O0410/O1O06 a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de huit

mille sept cent cinquante livres sterling (GBP 8.750) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un
montant de deux mille cinq cents livres sterling (GBP 2.500) et d’une Prime d’Emission de 2,5% représentant un montant
de six mille deux cent cinquante livres sterling (GBP 6.250).

Au 18 Mai 2012 RBC cees Nominees Limited O0410/O1O06 reste redevable d’un montant de deux cent quarante et

un mille deux cent cinquante livres sterling (GBP 241.250) représentant la Prime d’Emission.

XXI. Hiking Corporation, ayant son siège social au 28-30 The Parade, St Helier, Jersey, JE4 8XY, les Îles de la Manche

et inscrit au Registre de Commerce de Jersey sous le numéro 78351 a été admis dans la Société comme Investisseur (A)
le 19 Mars 2012 et a fait une Promesse d’Apport de cinq cent mille livres sterling (GBP 500.000).

Hiking Corporation a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant dix-sept mille cinq cent livres sterling (GBP

17.500) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un montant de cinq mille livres sterling (GBP
5.000) et d’une Prime d’Emission de 2,5% représentant un montant de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500).

Au 18 Mai 2012 Hiking Corporation reste redevable d’un montant de quatre cent quatre vingt deux mille cinq cents

livres sterling (GBP 482.500) représentant la Prime d’Emission.

XXII. Prime Special Investment Portfolio I ayant son siège social au PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,

KY1-1104 et inscrit au Registre de Commerce des Iles Cayman a été admis dans la Société comme Investisseur (A) le 24
Avril 2012 et a fait une Promesse d’Apport de dix millions de livres sterling (GBP 10.000.000).

Prime Special Investment Portfolio I a versé 3.5% de sa Promesse d’Apport représentant un montant de trois cent

cinquante mille livres sterling (GBP 350.000) qui est composé d’un Apport en Numéraire de 1% représentant un montant
de cent mille livres sterling (GBP 100.000) et d’une Prime d’Emission de 2,5% représentant un montant de deux cent
cinquante mille livres sterling (GBP 250.000).

Au 18 Mai 2012 Prime Special Investment Portfolio I reste redevable d’un montant de neuf millions six cent cinquante

mille livres sterling (GBP 9.650.000) représentant la Prime d’Emission.

6. Capital social. Le montant entier du capital social de la Société de huit cent quarante-neuf mille deux cent soixante-

quinze livres sterling et soixante-quinze pence (GBP 849.275,75) a été entièrement libéré.

Queensgate Investments I S.à r.l.

Référence de publication: 2012119294/514.
(120160834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Repondo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6680 Mertert, 6A, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 150.770.

<i>Auszug der Versammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 18. Juni 2012

Die Versammlung beschließt die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder bis zur Generalversammlung zu

verlängern, welche im Jahre 2013 stattfinden wird:

- Herr Dieter Peter, geboren am 20. September 1964 in Völklingen, wohnhaft in Johann-Morbach-Straße 6, D-54329

Konz, Deutschland;

- Herr Gisbert Wegmann, geboren am 11. Juni 1955 in Menden, wohnhaft in Friedrich-Wilhelm-Straße 3, D-54290

Trier, Deutschland;

- Herr Stefan Speicher, geboren am 27. April 1965 in Saarlouis, wohnhaft in Lücknerstraße 4, D-66071 Beckingen,

Deutschland;

- Herr Patrick Becker, geboren am 29. April 1973 in Trier, wohnhaft in Irminenstraße 16, D-54329 Konz, Deutschland.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Die Gesellschaft

Référence de publication: 2012119301/19.
(120160947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

120714

L

U X E M B O U R G

R A J Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 47.824.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 4 septembre 2012

que:

1. L’Assemblée a pris acte de la démission de leurs mandats d’administrateurs de:
- Madame Laurence CRUCIFIX, employée privée, demeurant 93, rue d’Enhaive – B-5100 Jambes;
- Monsieur Olivier TILMANT, employé privé, demeurant 31, Place Didier – B-6700 Arlon;
- Monsieur Francis CRUCIFIX, retraité, demeurant 101, Mount Taal Street, Tipolo Barangay, 6014 Mandaue/Cebu aux

Philippines;

2. L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Madame Martine PEYROT, directrice exploitation, demeurant 10, rue des Cornouilliers - F-78130 Chapet;
- Monsieur Roger PEYROT, gérant, demeurant 10, rue des Cornouilliers - F-78130 Chapet;
- Monsieur Tommy PEYROT, grutier, demeurant 10, rue des Cornouilliers - F-78130 Chapet;
- Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2017.
3. L’Assemblée a pris acte de la démission des fonctions d’administrateur délégué de Monsieur Francis CRUCIFIX,

retraité, demeurant 101, Mount Taal Street, Tipolo Barangay, 6014 Mandaue/Cebu aux Philippines.

4. L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur délégué démissionnaire, pour une période de six ans,

avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature Monsieur Roger PEYROT, gérant, demeurant 10, rue des Cor-
nouilliers - F-78130 Chapet;

5. L’Assemblée a pris acte de la démission de son mandat de commissaire aux comptes de Madame Gabrielle ROELS,

demeurant 8, avenue du Petit Sart – B-5100 Jambes.

6. L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société SOCOGESCO IN-

TERNATIONAL SA, avec siège social 84, Grand-Rue – L-1660 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n° B 44 906. Son mandat
prendra fin lors de l’Assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2017.

Luxembourg, le 4 septembre 2012.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012119297/33.
(120161024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

RA Investments Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 128.163.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 6 juillet 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 6 août 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012119305/13.
(120161070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

SHL Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 29.118.231,50.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.387.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 22 mai 2012, l'associé unique a pris la décision de ne pas

renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de Ernst &amp; Young, avec siège social au 7, parc d'activité syrdall,
L-5365 Munsbach.

120715

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2012.

Référence de publication: 2012119329/13.
(120160985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Radetzky S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.555.

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire

aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Stéphane Sabella
- Sébastian Coyette
- Andrea Dany
- Marie-Anne Back
Le commissaire aux comptes est CEDERLUX-SERVICES S.A R.L.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012119307/18.
(120161151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

RPS FinCo SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 150.407.

<i>Extrait des décisions prises par les actionnaires en date du 27 juin 2012

1. Madame Virginie DOHOGNE a été reconduite dans son mandat de membre du conseil de surveillance jusqu’à l’issue

de l’assemblée générale statutaire de 2016.

2. Monsieur Hans DE GRAAF a été reconduit dans son mandat de membre du conseil de surveillance jusqu’à l’issue

de l’assemblée générale statutaire de 2016.

3. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de membre du conseil

de surveillance jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 18.9.2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour RPS FinCo SCA
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012119315/18.
(120161088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Sato Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 160.522.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 17 septembre 2012:
que Famax International Corp. a transféré 12.500 parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 euro chacune, à Galena

Investments Limited, une société régie par le droit de Malte, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Malte,
sous le numéro C55472, ayant son siège social au Leicester Court, Suite 2, Edgar Bernard Street, Gzira, GZR, 1702, Malta.

Désormais, l'associé unique de la Société est donc le suivant:
- Galena Investments Limited

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

120716

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2012119317/19.
(120161150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

S P E S A, Société du Parking d'Esch-sur-Alzette, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 24B, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 104.610.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 juin 2012

L'assemblée générale ordinaire a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de confier à la société RSM Audit Luxembourg S.à r.l. 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg, le mandat de réviseur d'entreprise agrée des comptes annuels de l'année 2012. Le mandat
expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2013.

Luxembourg, le 17 septembre 2012.

Pour extrait conforme et sincère
Signature

Référence de publication: 2012119337/15.
(120161038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

S.P.P.O., Société du Parking de la Piscine Olympique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 24B, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 87.933.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13.06.2012

L'assemblée générale ordinaire a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de confier à la société RSM Audit Luxembourg S.à r.l. 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg, le mandat de réviseur d'entreprise agrée des comptes annuels de l'année 2012. Le mandat
expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2013.

Luxembourg, le 17 septembre 2012.

Pour extrait conforme et sincère
Signature

Référence de publication: 2012119338/15.
(120161039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Star Trade, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 89.749.

Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 3 septembre 2012

à Luxembourg que:

- Bloomsdale Limited a démissioné de ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat; et
- Monsieur Théo de Kievit, né le 9 juin 1967 à Rotterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au Tromplaan

5, 3342 TR Hendrik Ido Ambacht (Pays-Bas), a été nommé nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat et
pour une période de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2012.

<i>Pour la Société
Un Mandataire

Référence de publication: 2012119348/17.
(120161121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

120717

L

U X E M B O U R G

Verny Infrastructure Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 166.090.

Par résolutions prises en date du 21 août 2012, le gérant unique a décidé de transférer le siège social de la société du

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 septembre

2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2012.

Référence de publication: 2012119384/13.
(120160991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Truck International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 119.156.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 19 septembre 2012.

Référence de publication: 2012119361/10.
(120161094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Twelve Fringe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 168.601.

En date du 27 juin 2012, l'associé unique Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, a cédé la totalité de ses 12,500 parts sociales à BOP (Luxembourg) Holdings SARL, avec siège social
au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est BOP (Luxembourg) Holdings SARL, avec 12,500 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2012.

Référence de publication: 2012119362/14.
(120160990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Telecommunications Industry S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 166.220.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 août 2012.

1. L'assemblée accepte la démission des trois administrateurs, Messieurs Knut GRODEM. Pierre MACQUET et Anders

KALLERUD.

2 L'assemblée décide de nommer au poste d'administrateur et ce, à dater de ce jour, pour une durée de trois ans:
1. Monsieur Waleed Jamil I. ALHEJAILAN, au poste d'administrateur, de nationalité saoudienne, né le 26 mai 1968 à

Riyadh (Arable Saoudite), demeurant à Al Si Heen Road, Malaz. PO Box 9175 Riyadh 11413, Arabie Saoudite.

2. Monsieur Hisham Akhter Rafi ANSARI, au poste d'administrateur, de nationalité Indienne, né le 16 octobre 1972 à

Hyderabad (Inde), demeurant aux Emirats Arabes Unis, Dubai, Office 406, Zee Tower, DMC.

3. Monsieur Mostafa EL FAROUK, au poste d'administrateur de nationalité marocaine, né le 27 octobre 1966 à Meknes

(Maroc), demeurant aux Emirats Arabes Unis, Dubai, Office 406, Zee Tower, DMC.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012119365/19.
(120161109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

120718

L

U X E M B O U R G

Curvacerta, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-4684 Differdange, 2A, rue Batty Weber.

R.C.S. Luxembourg B 155.302.

Par la présente, je soussignée Mme Simoes Varela Paula Maria, résidente à 2A, Rue Batty Weber L-4684 Differdange,

déclare démissionner de mes fonctions de gérante de la société et représentante permanente de la succursale à partir
du 15/09/2012.

Differdange, le 31 août 2012.

SIMOES VARELA Paula Maria.

Référence de publication: 2012120429/11.
(120159937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

THIEFELS et BOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 24, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 38.525.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 11 septembre

<i>2012 à 10.00 heures

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.
Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2012119369/14.
(120160906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Usina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 8, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 115.058.

Suite aux cessions de parts du 10 août 2012, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

Actionnaires:

Nombre

d'actions:

Anne KIEFFER
11, rue JP Brasseur
L-1258 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Signature.

Référence de publication: 2012119381/15.
(120160903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Bastion Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 170.707.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2012.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2012119391/14.
(120160980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

120719

L

U X E M B O U R G

Jet Discount S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 13, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 101.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012114911/11.
(120154876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

Jet Discount S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 13, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 101.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012114912/11.
(120154879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

Jet Discount S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 13, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 101.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012114913/11.
(120154880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

Jet Discount S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 13, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 101.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012114914/11.
(120154887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

Frank Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4845 Rodange, 90-92, rue Joseph Philippart.

R.C.S. Luxembourg B 99.740.

Les comptes annuels du 01/01/2011 au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012114809/10.
(120154827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

120720


Document Outline

Bastion Investments S.à r.l.

BigBoard Holding S.A.

CCM Pharma Luxco S.à r.l.

Corestate Turbo HoldCo S.à r.l.

Curvacerta

Elles s.à r.l.

EU Research Fund General Partner S.à r.l.

Frank Lux S.àr.l.

Golden Heights S.A.

Jet Discount S.à r.l.

Jet Discount S.à r.l.

Jet Discount S.à r.l.

Jet Discount S.à r.l.

Knockon S.A.

Landewyck Group Sàrl

Luvefi-Developpement S. à r. l.

Matrix EPH 2 S.à r.l.

Matrix German Portfolio No 1 Celle S.à r.l.

Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf S.à r.l.

Matrix German Portfolio No. 1 Frankfurt S.à r.l.

Matrix St Etienne Holdco S.à r.l.

Metro

Moncour S.à r.l.

Northam Property Funds Management S.à r.l.

Plo Luximmo S.à r.l.

Portman Investments S.à r.l.

Precious Objects S.A.

Pyxis Partners S.A.

Queensgate Investments Fund I

Radetzky S.A.

RA Investments Luxembourg I S.à r.l.

R A J Europe S.A.

Repondo S.A.

RPS FinCo SCA

Safety Lux S.à r.l.

Sato Holding S.à r.l.

SHL Luxembourg S.à r.l.

Société du Parking de la Piscine Olympique S.A.

Société du Parking d'Esch-sur-Alzette

Sofia Holding S.A.

Star Trade

Telecommunications Industry S.A.

THIEFELS et BOURG S.A.

Truck International S.à r.l.

Twelve Fir S.à r.l.

Twelve Fringe S.à r.l.

Usina S.à r.l.

Verny Infrastructure Holding S.à r.l.