This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2272
12 septembre 2012
SOMMAIRE
International Packaging Technologies
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109010
Joh. A. Benckiser s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
109024
Manoval S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109019
Parthenon International S.A. . . . . . . . . . . . .
109019
Patrilar Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109019
PATR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109019
PHT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109023
PHT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109023
Pixel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109023
Pizzeria Peperoncino S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
109023
Planinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109055
Pollyane Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
109044
Premium House S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109044
PSH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109044
Puraye S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109044
QLux Aviation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109045
Quee S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109045
Qui.Lu.Cru S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109045
Rafa Enterprises SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109046
Real Estate Management S.A. . . . . . . . . . . .
109046
Red Grafton S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109046
Reflex'it S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109046
Reflex'it S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109046
Riverways SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109047
Roland International Holding, S.à r.l. SPF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109047
Romos Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109047
Rub S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109047
Safe Ship Investment Company S.C.A., SI-
CAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109048
Saint Ange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109048
Saint Ange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109048
Saint Ange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109053
Saint Ange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109053
Saint Ange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109048
Sainte Augustine Asset Management S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109053
Sarabel B.V. / S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109054
SBRE Luxco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109047
Select Development Luxembourg S.A. . . .
109054
Senc Houben - Vaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109055
SGBT European Major Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109054
Six Payment Service (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109045
SL Bielefeld Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
109048
Smiths Detection International Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109055
Spheretech International S.A. . . . . . . . . . . .
109054
Spheretech International S.A. . . . . . . . . . . .
109056
Thalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109023
Vilret Avocats S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109049
WALSER Absolute Return . . . . . . . . . . . . . .
109053
109009
L
U X E M B O U R G
International Packaging Technologies S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 170.704.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the second day of July, appeared before me, Maître Francis KESSELER, notary
public, officiating in Esch/Alzette, the Grand Duchy of Luxembourg,
Greif CV-Management II LLC., a limited liability company under the laws of Delaware, United States of America, having
its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, United States of America and its office address
at 1676 International Drive, McLean, Virginia 22102, United States of America, acting in its capacity as general partner of
Greif International Holding Supra II C.V., a limited partnership under the laws of the Netherlands (commanditaire ven-
nootschap), having its official seat in Amsterdam, the Netherlands and its office address at Asterweg 25, 1031 HL
Amsterdam, the Netherlands, registered in the Dutch Commercial Register under number 51121328 (the “Incorpora-
tor”), duly represented herein by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in
Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney given on June 28, 2012, which proxy, after having been signed "ne varietur"
by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of regis-
tration.
Such appearing party, represented as stated hereinabove, has requested the undersigned notary, to record the following
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is hereby formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the
name “International Packaging Technologies S.à.r.l.” (hereinafter the “Company”), which will be governed by the laws of
Luxembourg, in particular by the law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the
“Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality of the city of Luxembourg by a resolution of the single manager, or
as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any
other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder or the general meeting
of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin and may license the use and/or the right to exploit those patents or
intellectual property rights.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
109010
L
U X E M B O U R G
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property, which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. Upon incorporation, the Company's capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), divided
into one hundred (100) ordinary shares in registered form and each with a par value of one hundred and twenty five Euro
each (EUR 125.-) each, all subscribed for and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
5.3 Upon the issuance of shares, each shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate
nominal value of its shares.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and the profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval
of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company. A share
transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company
in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190
of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a single manager or by a board of managers, consisting of more than one member.
The single manager is, or in the event a board of managers has been established, the members of the board of managers
are appointed by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, which sets the term of his/
their office. In the event of plurality of board members, the general meeting of shareholders may designate such members
as members “Class A” or members “Class B”. The single manager does not, or in the event a board of managers has been
established, the members of such board do not need to be shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager, or, in the event a board of managers has been established, within the
competence of the board of managers and the single manager, or as the case may be, the board of managers, shall have
all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the single manager or the board of managers.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
109011
L
U X E M B O U R G
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy. The proxy shall be given in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any member of the board of managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or
video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting
to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation
in person at such meeting.
9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the single
manager. In the even the board of managers is composed of various members and the general meeting of shareholders
has designated members to act as “Class A” or “Class B” managers, the Company is bound towards third parties by the
joint signature of a manager “Class A” and a manager “Class B” or, as the case may be, by the joint or single signatures
of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are less than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be adopted without a
formally convened general meeting of shareholders, provided that the resolutions to be adopted shall be communicated
to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail and such resolutions are
adopted in writing by the unanimous consent thereto of all shareholders. The shareholders shall cast their vote by signing
the resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall commence on the first day (1
st
) of November of each year and end
on the thirty first (31
st
) day of October of any calendar year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the single manager, or as the case may
be, the board of managers shall prepare a balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an
inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the
Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend on the shares or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. In calculating the amount of any distribution on shares, shares held by the Company shall be disregarded.
109012
L
U X E M B O U R G
15.4. Unless the general meeting of shareholders determines another date of payment, distributions on shares shall
be made payable immediately after they have been declared.
15.5. Interim distributions may be made upon decision thereto by the board of managers of the Company, at any time,
under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the single manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve; and
(iii) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder
(s) or by Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments
of the liabilities of the Company.
16.2 From the balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company, all amounts remaining will be
distributed to the Company's shareholders in proportion to the aggregate nominal value of the shares held by each.
VII. General provision
Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, Greif CV-Management II LLC., represented as stated hereinabove intervened and declared to subscribe
for all of the one hundred (100) ordinary shares, in registered form and each with a par value of one hundred and twenty
five Euro (EUR 125.-) each, to be issued at incorporation and to pay these shares up by way of a contribution in kind of
a portfolio of patents and trademarks, as further detailed in Annexe 1 hereto, which has been valued for the purpose of
this notarial deed at five million Euro (EUR 5,000,000) and resolved that the amount exceeding the aggregate nominal
value of the contribution in kind, being an amount of four million nine hundred and eighty seven thousand five hundred
Euro (EUR 4,987,500) shall be accounted for as share premium.
To the extent that at any point in time after the date of this deed it is determined that the value of the contribution
in kind is inferior or, as the case may be superior to five million Euro (EUR 5,000,000), the share premium reserve formed
by way of the contribution in kind will be adjusted accordingly.
<i>Proof of existence of the contribution in kindi>
Proof of the ownership and existence of the portfolio of patents and trademarks which form part of the contribution
in kind has been given by way of a valuation and descriptive certificate and an interim balance sheet as per June 29, 2012
by the board of directors of the Greif CV-Management II LLC., expressing the fair market value of the patents and
trademarks forming part of the contribution in kind.
All shares so emitted have thus been fully paid up by way of the contribution in kind, which contribution in Kind is at
the disposal of the Company.
<i>Execution of the contribution in kindi>
It appears from valuation and descriptive certificate that The Incorporator:
(1) is the sole legal and economic beneficiary of the patents and trademarks forming part of the contribution in kind;
(2) it possesses all requisite power to dispose of the patents and trademarks, which are unencumbered and freely
transferable;
(3) there are no rights of first refusal or any other rights on the basis of which any third party can demand that one
or more of the patents and trademarks which form part of the contribution in kind would need to be transferred or
assigned;
(4) the contribution in kind is from an economic point of view effected as per the date of this notarial deed;
(5) all other (transfer) formalities in order to effectuate the proper transfer of the patents and trademarks which form
part of the contribution in kind, in order to render them effective vis-à-vis third parties will be effected in accordance
with the laws of the jurisdictions where such patents and trademarks have been registered.
109013
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately four thousand euro (€ 4,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Incorporator, representing the entirety of the subscribed
share capital passed the following resolutions:
1. The Company shall have a board of managers, composed of three (3) members;
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company for an unlimited period
of time:
a. Mr Teunis Christiaan AKKERMAN, of Dutch nationality, director, born on December 30, 1948 in Dirksland, the
Netherlands, professionally residing at 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, the Grand Duchy of Luxembourg
as Manager “Class A”;
b. Mr Jean LEMAIRE, of Belgian nationality, director, residing at 12A, rue Randlingen, L-8366 Hagen, the Grand Duchy
of Luxembourg as Manager “Class A”, and
c. Mr Everardus Antonius ARIËNS, of Dutch nationality, vice president Greif Packaging, born on May 31, 1957 in
Nijmegen, the Netherlands, residing at Bergseweg 6, 3633 AK Vreeland, the Netherlands as Manager “Class B”;
3. The registered office of the Company shall be in Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg at 5, rue des
Capucins, L-1313 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg.
4. The first accounting year of the Company shall begin on the date of this deed and shall end on 31 October 2012.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Follows the french translation of the preceding text
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le deuxième jour du mois de juillet, par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.
a comparu:
Greif CV-Management II LLC., une société à responsabilité limitée (limited liability company) selon les lois de Delaware,
Etats Unis, ayant son siège au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, Etats Unis et son établissement principal
au 1676 International Drive, McLean, Virginia 22102, Etats Unies, agissant en sa qualité de associé commandité (general
partner) de Greif International Holding Supra II C.V., une société en commandite selon les lois des Pays-bas (comman-
ditaire vennootschap), ayant son siège à Amsterdam, les Pays-Bas et son établissement principal au Asterweg 25, 1031
HL Amsterdam, les Pays-Bas, immatriculée auprès le registre de commerce d'Amsterdam sous le numéro 51121328, ici
dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, ayant son adresse profession-
nelle à Esch/Alzette en vertu d'une procuration émise le 28 juin, 2012, ladite procuration après signature ne varietur par
le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de
l'enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts (les «Statuts») d'une société
qu'il déclare constituer comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «International Packaging
Technologies S.à.r.l.”» (la «Société» ), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents Statuts (les «Statuts» ).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg, le Grand Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans
les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, dans le cas où un conseil de gérance de la
Société a été établie, par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés
délibérant comme en matière de modification des Statuts.
109014
L
U X E M B O U R G
2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication
aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une
société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l'acquisition et l'octroi de brevets concernant
de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,
par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le risque
de change, de fluctuations de taux d'intérêt et tout autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de
son objet social.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500), représenté par cent (100) parts sociales
sous forme nominative d'une valeur nominale de cent vingt cinq Euros (EUR 125.-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
5.3. En cas d'émission des parts sociales, chacun associé aura le droit de pre-emption en proportion de les parts sociales
tenus.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers. En cas de pluralité
d'associés, la cession de parts sociales à des non associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.La cession de parts sociales n'est
opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec
les dispositions de l'article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des
articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé qui le souhaite.
109015
L
U X E M B O U R G
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par un conseil de gérance, composé de plusieurs personnes (gérants).
Le gérant unique est nommé, ou, dans le cas où un conseil de gérance a été établie, sont nommés par résolution de
l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de son/leur mandat. Au cas où le conseil de gérance est composé
de plusieurs membres l'assemblée générale des associés de la Société peut designer les membres du conseil de gérance
«Classe A» ou «Classe B». Gérants ne doivent pas nécessairement être des associés.
7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant unique, ou, dans le cas où un conseil de gérance a été établie, de la compétence du
conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le conseil de gérance de la Société.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6. Tout membre du conseil de gérance peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo
conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation
en personne à la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenu. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la signature simple du
gérant unique. Au cas où un conseil de gérance a été établie et l'assemblée générale des associés de la Société a désigné
les membres du conseil de gérance «Classe A» ou «Classe B», par la signature conjointe d'un membre du conseil de
gérance désigné «Classe A» et d'un membre du conseil de gérance désigné «Classe B», ou, le cas échéant, par la ou les
signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués
conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par
la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier
électronique une autre personne comme mandataire.
109016
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par
téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou
sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par un original ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital social
de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier (1
er
) novembre de chaque année et se termine le trente et un (31)
octobre de chaque année.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant unique, où dans le
cas ou un conseil de gérance a été établie, le conseil de gérance prépare un bilan avec l'indication des valeurs actives et
passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engagements et des dettes du/des gérants et associés
à l'égard de la Société et un compte des pertes et profits.
14.3. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des associés
qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la
Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de
la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. En calculer des montants qui seront distribués, les parts sociales tenus par la Société seront négligées.
15.4. Toutes acomptes sur dividendes seront distribués immédiatement après la déclaration des acomptes, à moins
que l'assemblée générale des associés a déterminé une certaine date.
15.5. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués par décision du conseil de gérance, à tout moment sous
réserve du respect des conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires doivent être établis par au moins de conseil de gérants;
(ii) ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice. L'assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d'acomptes sur
dividendes;
(iii) la décision susvisée n'est adoptée que dans la mesure où la Société s'est assurée que les droits des créanciers de
la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales
de la Loi.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
A ce stade, Greif CV-Management II LLC. est intervenu et a déclaré de souscrire toutes les cent (100) parts sociales
de la Société à emitter, et de payer les parts sociales par voie d'un apport en nature d'un portefeuille de brevêts et des
marques («l'Aport en Nature»), détaillés en Annex 1, qui est évalué pour les besoins du présent acte à cinq million Euros
109017
L
U X E M B O U R G
(EUR 5.000.000), et Greif CV-Management II LLC. a décidé que la partie de la valeur de l'Apport en Nature qui excède
la valeur nominale totale des parts sociales à emitter par la Société, étant un montant de quatre million neuf cent quatre-
vingt sept mille cinq cent Euros (EUR 4.987.500), sera comptabilisée par la Société en tant que prime d'émission.
Dans la mesure où, à n'importe quel moment après la passation du présent ate, il est déterminé que la valeur de
l'Apport en Nature est inférieure, ou, le cas échéant, plus élevée que cinq million d'Euros (EUR 5.000.000), le solde de
la réserve de prime d'émission de la Société devra être ajusté en conséquence.
<i>Preuve de l'existence de l'Apport en Naturei>
Preuve de la propriété des brevêts et des marques formant partie de l'Apport en Nature a été donnée sous la forme
d'un certificat descriptif et de évaluation et un bilan intérimaire établis par le conseil de gérance de 29 juin, 2012 en
exprimant la valeur juste marchande des brevêts et des marques formant partie de l'Apport en Nature.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par contribution de l'Apport en Nature, lequel l'Apport en
Nature est à la disposition de la Société.
<i>Réalisation effective de l'Apport en Naturei>
Il résulte du certificat descriptif et de évaluation que Greif CV-Management II LLC.:
(i) est le seul et propriétaire économique et juridique des brevêts et des marques faisant partie de l'Apport en Nature,
et qu'il possède les pouvoirs de disposer des brevêts et des marques, lesquels sont légalement et conventionnellement
librement transmissibles;
(ii) qu'il n'existe aucun droit de préemption, ni aucun autre droit en vertu duquel une personne quelle qu'elle soit
pourrait être fondée à exiger qu'une ou plusieurs des brevêts et des marques formant partie de l'Apport en Nature lui
soient cédés ou transférés.
(iii) que l'apport en nature est effectivement réalisé sans réserves à la date du présent acte;
(iv) que toutes autres formalités aux fins d'effectuer les transferts des brevêts et des marques formant partie de l'Apport
en Nature et de les rendre effectives en tout lieu vis-à-vis de toute tierce partie seront réalisés conformément aux
dispositions du droit des juridictions ou les brevêts et les marques sont enregistrées.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ quatre mille euros (€ 4.000,-).
<i>Assemblée générale des associési>
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social souscrit et se considérant comme ayant été dûment convoqué,
a immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale des associés de la Société.
Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, les résolutions suivantes ont étés prises à l'unanimité:
1. Par la présente, le conseil de gérance de la Société est établi, composé de trois (3) membres;
2. Sont nommé membres du conseil de gérance de la Société pour une période illimitée:
(a) Monsieur Teunis Christiaan Akkerman, directeur des sociétés, de nationalité Néerlandaise, né le 30
ème
décembre
1948 à Dirksland, les Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, Grand
Duché de Luxembourg comme gérant de «Classe A»;
(b) Monsieur Jean LEMAIRE, directeur des sociétés, demeurant au 12A, rue Randlingen, L-8366 Hagen, Grand Duché
de Luxembourg comme gérant de «Classe A»; et
(c) Monsieur Everardus Antonius ARIËNS, vice-président des affaires financières de Greif Packaging, de nationalité
Néerlandaise, né le 31 mai 1957 à Nijmegen, Les Pays-Bas, ayant on adresse professionnellement au Bergseweg 6, 3622
AK Vreeland, Les Pays-Bas comme gérant de «Classe B»;
3. Le siège social de la société est établi au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
4. La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au trente et un octobre 2012.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle et lit l'anglais, constate que sur demande de personne comparante, le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 juillet 2012. Relation: EAC/2012/8831. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
109018
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012102300/488.
(120139897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Parthenon International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 97.141.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104031/9.
(120141767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
PATR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5244 Sandweiler, 2A, Ennert dem Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 144.428.
Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wurde von Herrn SIMON Axel wohnhaft in D-54634 BITBURG, 44,
Hanenberg übernommen am 30/06/2009 an Stelle von Herrn Dr. LIETHEN Paul. Das Mandat für die tägliche Geschäfts-
führung ist unbegrenzt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104033/11.
(120142103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Patrilar Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 43.240.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PATRILAR Sàrl
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012104034/11.
(120141800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Manoval S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3912 Mondercange, 10, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg E 4.856.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1) Monsieur Alain VITALE, retraité, né à Audun-le-Tiche (France), le 19 avril 1949 (numéro d'identité 1949 04 19 333),
demeurant à L-3912 Mondercange, 10, rue des Champs, époux de Madame Jacqueline SCHAEFFER, avec laquelle il déclare
être marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire instrumentant en date
du 22 mars 2006, leur mariage civil ayant été célébré à Mondercange, le 31 mars 2006.
2) Madame Valérie VITALE, institutrice, née à Esch-sur-Alzette le 20 août 1974 (numéro d'identité 1974 08 20 284),
demeurant à L-3924 Mondercange, 2, am Rousegaertchen, épouse de Monsieur Yves TAPELLA, avec lequel elle déclare
être mariée sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire instrumentant en date
du 21 mars 2005, leur mariage civil ayant été célébré à Mondercange, le 1
er
avril 2005.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte de constitution d'une société civile im-
mobilière qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination - Objet - Durée - Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: "MANOVAL S.C.I.".
109019
L
U X E M B O U R G
Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles ou parts d'immeubles qu'elle
pourrait acquérir, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension, le développement ou l'exploitation.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu'avec les majorités prévues pour la modification
des statuts.
Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Mondercange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Titre II.- Capital - Apports - Parts
Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent soixante mille euros (€ 260.000.-), représenté par deux cent soixante (260)
parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (€ 1.000.-) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à
partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Elle n'est opposable à
la société et aux tiers qu'après qu'elle ait été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié conformément
à l'article 1690 du code civil.
Le ou les gérants devront, sous peine de nullité, accepter toute cession de parts sociales.
Art. 8. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du
code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.
Titre III.- Administration
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou
les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous
actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.
Art. 10. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
Art. 11. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du
conseil ou sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'assemblée.
L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité
des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées par les trois quarts des voix des associés, chaque part
donnant droit à une voix.
Titre IV.- Durée - Dissolution - Liquidation
Art. 12. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 13. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou du ou des
gérant(s).
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l'assemblée n'en décide
autrement.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 15. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par
la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts.
109020
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et Libérationi>
Les deux cent soixante (260) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Alain VITALE, préqualifié, cent trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
2) Madame Valérie VITALE, préqualifiée, cent trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Total: deux cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Les comparants déclarent libérer intégralement les prédites deux cent soixante (260) parts sociales comme suit:
a) cent trente (130) parts sociales, par un apport à la société de:
Un terrain à bâtir sis à Zoufftgen (Moselle/France) 57330, inscrit au cadastre comme suit:
<i>- Commune de ZOUFFTGEN (Moselle) -i>
Section 49, numéro 116/107, lieu-dit "Pfafferlicher Wiese", d'une contenance de 8 ares 11 centiares.
<i>Provenancei>
L'immeuble prédésigné appartient à Monsieur Alain VITALE, préqualifié, pour lui avoir été attribué en vertu d'un acte
de donation-partage reçu par le notaire Denis REINERT, notaire associé membre de la société civile professionnelle
«Denis REINERT & Philippe KRUMMENACKER», titulaire d'un office notarial à la résidence de Thionville (Moselle/
France), en date du 12 septembre 2008 et est inscrit au Livre Foncier au nom de Monsieur Alain VITALE.
<i>Droit de préemption - Demande générale de renseignements (mutation en l'état)i>
Il résulte d'un certificat daté du 21 mai 2012 que la Commune de Zoufftgen n'entend pas faire valoir son droit de
préemption sur l'immeuble apporté.
Le prédit certificat, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera
annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.
Une demande générale de renseignements (mutation en l'état) dûment complétée et signée, portant le sceau de la
mairie de Zoufftgen, datée du 7 mai 2012, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instru-
mentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
<i>Permis de construirei>
Il est ici mentionné l'existence d'un certificat de permis tacite délivré en date du 13 mai 2011 par le Maire de la
Commune de Zoufftgen au nom de la commune, sous la référence dossier n° PC 057 764 10 N0029 concernant l'édifi-
cation d'un immeuble de 7 appartements, adresse terrain: 5 Rue Principale, à Zoufftgen (57330).
Ce certificat est libellé comme suit:
«Le maire de la Commune de Zoufftgen certifie que VITALE Alain est titulaire d'un permis de construire enregistré
sous le numéro PC 057 764 10 N0029 pour le projet ci-dessus référencé depuis le 21/01/2011.
Ce certificat est délivré en application de l'article R.424-13 du code de l'urbanisme.
Fait à Zoufftgen, le 13 mai 2011.
Le Maire, (signé Michel PAQUET)»
Monsieur Alain VITALE fera son affaire personnelle du transfert dudit certificat de permis tacite au nom de la société
«MANOVAL S.C.I.».
b) cent trente (130) parts sociales, par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent trente mille euros
(€ 130.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
<i>Evaluation de l'apport en naturei>
Les comparants déclarent fixer la valeur vénale en pleine propriété de l'immeuble prédécrit sub a) à cent trente mille
euros (€ 130.000.-), correspondant à l'évaluation figurant dans le prédit acte de donation-partage du 12 septembre 2008.
<i>Conditions de l'apporti>
L'immeuble est apporté tel et ainsi qu'il se comporte, avec toutes les appartenances et dépendances ainsi qu'avec
toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes, continues et discontinues pouvant y être attachées, sauf
à la société à faire valoir les unes et se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls et sans recours contre les
apporteurs.
A ce sujet, il est ici fait mention de l'existence d'une convention d'accès datée du 18 août 2009, signée entre la société
civile luxembourgeoise «VAL», ayant son siège social à L-3912 Mondercange, 10, rue des Champs, propriétaire de l'im-
meuble sis Commune de Zoufftgen (Moselle), Section 49, numéro 117, lieu-dit "Pfafferlicher Wiese" (fonds servant) et
Monsieur Alain VITALE, préqualifié, propriétaire de l'immeuble objet du présent apport (fonds dominant). En vertu des
conditions financières figurant dans la susdite convention, le passage est concédé, à la charge du propriétaire du fonds
dominant, Monsieur Alain VITALE, qui devra supporter tous les frais d'établissement du passage, y compris les revête-
109021
L
U X E M B O U R G
ments. En outre, tous les frais d'entretien ou de réparation sont à la charge exclusive de Monsieur Alain VITALE, lesquels
frais seront ultérieurement à la charge exclusive des propriétaires successifs dudit fonds.
Les indications cadastrales et les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins excédât-elle un
vingtième, fera profit ou perte à la société.
La société a la jouissance et la propriété de l'immeuble apporté à compter de ce jour, à charge d'en payer et d'en
supporter à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques.
<i>Pouvoiri>
Pouvoir est conféré à tout clerc de l'Etude des notaires associés Gilbert GRAZIOSI et Fabienne MARTIN à Thionville
(France) afin d'accomplir, conformément à la législation française en matière de publicité et propriété immobilière, auprès
des bureaux compétents, tout acte relatif à la transcription de l'immeuble prédécrit et la publicité foncière des servitudes
à charge et au profit de l'immeuble concerné.
Les formalités de publicité foncière ci-devant relatées seront effectuées par Maître Fabienne MARTIN, Notaire à
Thionville (France), 6, Square du 11 Novembre, à qui les parties confèrent tout pouvoir à cet effet.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approxi-
mativement à deux mille euros (€ 2.000.-).
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-
dinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Alain VITALE, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- Le siège social est fixé à L-3912 Mondercange, 10, rue des Champs.
<i>Interventioni>
Sont ensuite intervenus aux présentes:
a) Monsieur Joseph VITALE, retraité, né à Dudelange, le 14 février 1923 (numéro d'identité 1923 02 14 258), veuf en
uniques noces de Madame Lucie LAUF, demeurant à L-3743 Rumelange, 7, rue Nicolas Pletschette.
b) Madame Monique VITALE, sans profession, née à Audun-le-Tiche (France), le 28 novembre 1951 (numéro d'identité
1951 11 28 202), divorcée, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 81, rue Victor Hugo.
Lesquels, en considération de ce que l'immeuble présentement apporté à la société a fait l'objet d'une donation à titre
de partage par Monsieur Joseph VITALE au profit de ses deux enfants et seuls présomptifs héritiers, Monsieur Alain
VITALE, apporteur susnommé, auquel il a été attribué, et Madame Monique VITALE, en vertu du prédit acte du 12
septembre 2008, ont déclaré donner leur consentement pur et simple à l'apport à la société de l'immeuble prédésigné,
dans les termes de l'article 924-4 alinéa 2 du Code civil français, afin que l'action en réduction ou revendication instituée
par le 1
er
alinéa du même article ne puisse être exercée contre la société bénéficiaire de l'apport ou les tiers détenteurs
de l'immeuble apporté et que ceux-ci obtiennent la propriété incommutable dudit bien; ceci à la condition expresse que
l'ensemble des héritiers réservataires y aient renoncé.
<i>Témoinsi>
Etant donné que l'intervenant Monsieur Joseph VITALE ne peut signer, le notaire est assisté de deux témoins, à savoir:
a) Monsieur Jean-Paul HATZ, fonctionnaire communal en retraite, demeurant à Hautcharage,
b) Monsieur Roland SIEBENBOUR, fonctionnaire communal, demeurant à Bascharage,
dont l'assistance est requise conformément à l'article 25 de la loi du 9 décembre 1978 relative à l'organisation du
notariat.
Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
DONT ACTE, fait et passé à Rumelange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire qui certifie l'état civil des comparants
et des intervenants d'après deux cartes d'identité, respectivement deux extraits des registres de l'état civil.
109022
L
U X E M B O U R G
Signé: A. VITALE, V. VITALE, M. VITALE, HATZ, SIEBENBOUR, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 20 juillet 2012. Relation: CAP/2012/2827. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 8 août 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012104803/185.
(120142616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
PHT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 136.102.
Par la présente, je remets avec effet immédiat ma démission en tant qu'administrateur de type B de votre estimée
société.
Luxembourg, le 1
er
août 2012.
Toby Herkrath.
Référence de publication: 2012104036/10.
(120141793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
PHT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 136.102.
Par la présente, nous remettons avec effet immédiat notre démission en tant que Commissaire aux Comptes de votre
estimée société.
Luxembourg, le 1
er
août 2012.
TRIPLE A CONSULTING
Référence de publication: 2012104037/11.
(120142256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Pixel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 66.434.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104038/9.
(120141705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Pizzeria Peperoncino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 55, rue de Vianden.
R.C.S. Luxembourg B 111.527.
Les comptes annuels clôturés au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104039/10.
(120141728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Thalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 150.071.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
109023
L
U X E M B O U R G
Luxembourg.
THALUX S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2012104135/14.
(120142125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Joh. A. Benckiser s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 6.354.568,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 164.586.
In the year two thousand and twelve, on the fourth day of July, at 11 am before Maître Joseph Elvinger, Civil Law
Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Joh. A. Benckiser s.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of notary Maître Elvinger dated 8 November 2011, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies (the RCS) under number B 164.586 and having a share capital amounting to USD 6,327,198.-
(the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended most recently on 9 January
2012 pursuant to a deed of Maître Elvinger published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 25 January
2012 under number 204.
THERE APPEARED
Parentes Holding SE (previous company name: Joh. A. Benckiser SE), a company incorporated under the laws of Austria,
having its registered office at Rooseveltplatz 4-5/Top 10, A-1090 Vienna, Austria, registered with the Commercial Court
of Vienna, under number FN 288590 y,
Dr Renate Reimannn-Haas, with professional address at Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A1090, Vienna, Austria,
HFS s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered
office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.525,
Bansk s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.349,
Platin Investments s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg registered with the RCS under number B 165.345,
1998 Grat s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.604,
AC Revocable Trust s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.629,
- each individually a “Shareholder” or jointly the “Shareholders” Parentes Holding SE hereby represented by Sara
Lecomte, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxy given under private
seal; and Dr Renate Reimannn-Haas, HFS s.à r.l., Bansk s.à r.l., Platin Investments s.à r.l., 1998 Grat s.à r.l. and AC Revocable
Trust s.à r.l., each hereby represented by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties
and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. increase of the share capital of the Company by an amount of twenty-seven thousand three hundred seventy United
States dollars (USD 27,370.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of six million
three hundred twenty-seven thousand one hundred ninety-eight United States dollars (USD 6,327,198.-) to six million
three hundred fifty-four thousand five hundred sixty-eight United States dollars (USD 6,354,568.-) by way of the issuance
of twenty-seven thousand three hundred seventy (27,370) new shares, having a nominal value of one United States dollar
(USD 1.-) each (the Share Capital Increase);
2. subscription for and payment of the share capital increase specified under item 1 above by several contributions in
cash;
3. approval of the amendment and full re-statement of the Articles;
109024
L
U X E M B O U R G
4. amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes including the
change of the company name of Joh. A. Benckiser SE, with power and authority given to any manager of the Company,
each acting individually, to (i) register, in the name and on behalf of the Company, the newly issued shares in the register
of shareholders of the Company, and (ii) complete any formalities in connection with the Share Capital Increase (including,
for the avoidance of doubt, the signing of the said registers);
5. approval of share pledges; and
6. miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-seven thousand three
hundred seventy United States dollars (USD 27,370.-) in order to bring the share capital of the Company from its present
amount of six million three hundred twenty-seven thousand one hundred ninety-eight United States dollars (USD
6,327,198.-) to six million three hundred fifty-four thousand five hundred sixty-eight United States dollars (USD
6,354,568.-) by way of the issuance of twenty-seven thousand three hundred seventy (27,370) new shares, having a nominal
value of one United States dollar (USD 1.-) each (the Share Capital Increase).
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions for and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
At this point in time, Jorina s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, in the process of being registered with the
RCS, represented by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal,
the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,
intervenes and declares to subscribe for five thousand (5,000) new class B4 Ordinary Shares by a payment of fifteen
thousand United States dollars (USD 15,000.-) in cash.
The contribution in cash to the Company made by Jorina s.à r.l. shall be allocated as follows:
- an amount of five thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share capital account of the
Company; and
- an amount of ten thousand United States dollars (USD 10,000.-) is allocated to the share premium account of the
Company.
The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which
each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.
At this point in time, F.A.M.P.A. s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, in the process of being registered
with the RCS, represented by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal,
the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,
intervenes and declares to subscribe for five thousand (5,000) new class B5 Ordinary Shares by a payment of fifteen
thousand United States dollars (USD 15,000.-) in cash.
The contribution in cash to the Company made by F.A.M.P.A. s.à r.l. shall be allocated as follows:
- an amount of five thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share capital account of the
Company; and
- an amount of ten thousand United States dollars (USD 10,000.-) is allocated to the share premium account of the
Company.
At this point in time, Aliyah s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L2449 Luxembourg, in the process of being registered with the
RCS, represented by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal,
the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,
intervenes and declares to subscribe for seven thousand three hundred seventy (7,370) new class B6 Ordinary Shares
by a payment of two million eight hundred thousand United States dollars (USD 2,800,000.-) in cash.
The contribution in cash to the Company made by Aliyah s.à r.l. shall be allocated as follows:
109025
L
U X E M B O U R G
- an amount of seven thousand three hundred seventy United States dollars (USD 7,370.-) is allocated to the share
capital account of the Company; and
- an amount of two million seven hundred ninety two thousand six hundred thirty United States dollars (USD
2,792,630.-) is allocated to the share premium account of the Company.
The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which
each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.
At this point in time, Markus Hopmann, with professional address at Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090, Vienna,
Austria, represented by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,
intervenes and declares to subscribe for five thousand (5,000) new class B7 Ordinary Shares by a payment of one
million two hundred and ninety thousand Euros (EUR 1,290,000.-), to be converted into United States dollars at the
exchange rate published by the US Federal Reserve Bank for the last business day prior to the date of this deed.
The contribution in cash to the Company made by Markus Hopmann shall be allocated as follows:
- an amount of five thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share capital account of the
Company; and
- an amount being the United States dollar equivalent of one million two hundred and ninety thousand Euros (EUR
1,290,000.-) at the exchange rate published by the US Federal Reserve Bank for the last business day prior to date of this
deed, minus five thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.
The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which
each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.
At this point in time, Joachim Creus, with professional address at 26 Boulevard Royal L2449 Luxembourg, represented
by Siobhán McCarthy, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,
the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,
intervenes and declares to subscribe to five thousand (5,000) new class B8 Ordinary Shares by a payment of one
hundred forty-five thousand United States dollars (USD 145,000.-) in cash. The contribution in cash to the Company
made by Joachim Creus shall be allocated as follows:
- an amount of five thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share capital account of the
Company; and
- an amount of one hundred forty thousand United States dollars (USD 140,000.-) is allocated to the share premium
account of the Company.
The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which
each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.
The contributions in cash to the Company referred to above shall be allocated in aggregate as follows:
- an amount of twenty-seven thousand three hundred seventy United States dollars (USD 27,370.-) is allocated to the
share capital account of the Company; and
- an amount of two million nine hundred fifty-two thousand six hundred thirty United States dollars (USD 2,952,630.-)
plus the United States dollar equivalent of one million two hundred and ninety thousand Euros (EUR 1,290,000.-) at the
exchange rate published by the US Federal Reserve Bank for the last business day prior to date of this deed, minus five
thousand United States dollars (USD 5,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.
The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which
each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.
Evidence of full payment of these contributions in cash has been provided to the undersigned notary.
All the above contributors join the meeting as shareholders and are collectively referred to, together with the Sha-
reholders, as the Shareholders.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders (including for the avoidance of doubt those parties that have become shareholders of the Company
by virtue of the above contributions) resolve to amend and fully restate the Articles as follows:
I. Name – Registered office – Object – Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Joh. A. Benckiser s.à.r.l.” (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).
109026
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the Board. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of
Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment
of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such tem-
porary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management and sale of those participations. The Company may in particular
acquire and dispose of, by subscription, purchase, sale and exchange or in any other manner, any stock, shares and other
participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any
securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of, and
dispose of, a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies or persons. It may also give guarantees
and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own
obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person.
For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having
obtained the requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments and other business
efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital – Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at six million three hundred fifty-four thousand five hundred and sixty-eight United States
Dollars (USD 6,354,568.-), represented by six million three hundred fifty-four thousand five hundred and sixty-eight
(6,354,568) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, divided in several
classes as follows: five million three hundred forty-two thousand two hundred (5,342,200) class A ordinary shares (the
Class A Ordinary Shares), one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) class B1 ordinary
shares (the Class B1 Ordinary Shares), fifty thousand (50,000) class B2 ordinary shares (the Class B2 Ordinary Shares),
one hundred twenty thousand (120,000) class BN ordinary shares (the Class BN Ordinary Shares), fifteen thousand
(15,000) class B3 ordinary shares (the Class B3 Ordinary Shares), five thousand (5,000) class B4 ordinary shares (the
Class B4 Ordinary Shares), five thousand (5,000) class B5 ordinary shares (the Class B5 Ordinary Shares), seven thousand
three hundred seventy (7,370) class B6 ordinary shares (the Class B6 Ordinary Shares), five thousand (5,000) class B7
ordinary shares (the Class B7 Ordinary Shares), five thousand (5,000) class B8 ordinary shares (the Class B8 Ordinary
Shares; the Class B1 Ordinary Shares, the Class B2 Ordinary Shares, the Class BN Ordinary Shares, the Class B3 Ordinary
Shares, the Class B4 Ordinary Shares, the Class B5 Ordinary Shares, the Class B6 Ordinary Shares, the Class B7 Ordinary
Shares and the Class B8 Ordinary Shares are collectively referred to as the Class B Ordinary Shares; the Class A Ordinary
Shares and the Class B Ordinary Shares are collectively referred to as the Ordinary Shares), one hundred thirty-three
thousand three hundred and thirty-three (133,333) special 1 shares (S1 Shares) and five hundred thirty-three thousand
three hundred and thirty-two (533,332) special 2 shares (the S2 Shares, the S1 Shares and the S2 Shares are collectively
referred to as the Special Shares). The rights attached to each category of shares are further defined in these Articles.
One Class S1 Share and one Class S2 Share together carry the rights of one Ordinary Share subject to the limitations
set forth in Articles 17.2, 18.1, 18.2, 20.3 and 20.4.
109027
L
U X E M B O U R G
5.2. Contributions to the share premium and special equity reserve account of the Company shall remain attached to
each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.
5.3. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. For the avoidance of doubt, in case of seizure over shares of the Company, any enforcement resulting in a transfer
of the shares from the current shareholders requires shareholders' approval pursuant to article 6.4. If the shareholders
do not grant their approval pursuant to article 6.4, the shares subject to enforcement shall be automatically redeemed
by the Company pursuant to a shareholders resolution and against payment to the party enforcing the sale of the fair
market value of the shares determined by a réviseur d'entreprises appointed by the board of managers of the Company,
whose choice shall be final. The determination of the fair market value by the réviseur d'entreprises shall also be final.
6.6. If the Company is legally prevented from redeeming its own shares pursuant to the previous paragraph, the
shareholder holding the most shares, or, at that shareholder's discretion, all shareholders (other than the shareholder
whose shares are redeemed) shall purchase the shares subject to enforcement pro rata of their shareholdings against
payment of the fair market value of the shares as determined by the réviseur d'entreprises.
6.7. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-
quarters of the shares held by the other shareholders. In case such approval is not granted, the shares of the deceased
shareholder shall be acquired by the Company for a price equalling the net asset value of the shares of the deceased
shareholder as at the end of the calendar quarter during which the approval was refused.
6.8. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.9. A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company and may be examined by any
shareholder on request.
6.10. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management – Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers (gérants) appointed by a resolution of the shareholders,
which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
109028
L
U X E M B O U R G
the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented, provided that the failure to comply with such recording requirement shall not affect the validity of the
respective resolution.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers. If
the shareholders have appointed different classes of managers, namely class A and class B managers, the Company will
be bound by the joint signature of any class A manager and any class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board in accordance with the rules applicable to such delegations of authority as approved
by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law. The managers shall further be liable only for wilful breaches of their duties involved in the conduct of their
office. The Company shall, in accordance with any indemnity agreement entered into, from time to time, by and between
the managers and the Company, and without prejudice to any other indemnity to which the managers may otherwise be
entitled, indemnify the managers on a full indemnity basis and to the fullest extent permitted by law against all liabilities
losses, damages, penalties, costs, expenses and disbursements (including, without limitation, reasonable and documented
out-of-pocket costs and expenses) (the “Charges”) incurred or suffered by the managers due to, arising out of, or in
connection with, the actual or purported execution of their mandate as managers of the Company, in particular, but
without limitation, where any such Charges (i) arise out of any claim, action, demand, investigation or proceeding (whether
civil, criminal or regulatory) made, brought or threatened against the managers or (ii) result from any applicable Luxem-
bourg or foreign legal provision or regulation (including without limitation any applicable tax provision or regulation). No
indemnification shall be provided to the managers against any liability to the Company or of any of its direct or indirect
subsidiary or its shareholders by reason of wilful breach of the duties involved in the conduct of their office or fraud. The
managers shall continue to be indemnified under the terms of the indemnities provided in any indemnity agreement
entered into, from time to time, by and between the managers and the Company even after they have ceased to be
managers of the Company or any affiliated entity of the Company. Expenses in connection with the preparation and
representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be
advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the managers
to repay such amount if and to the extent it is ultimately determined that they are not entitled to indemnification under
this Article.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with Article 11.1(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted
at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) (i.e. 10%) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
109029
L
U X E M B O U R G
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than half (i.e. 50%)
of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by
registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a
majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
Art. 13. Shareholders' Committee.
13.1. The shareholders may, from time to time, appoint by a simple majority vote a Shareholders' Committee, com-
posed as the shareholders deem fit to facilitate the information flow between the Company and the shareholders.
13.2. The Shareholders Committee shall also deal with matters that may be entrusted to it by any shareholders
agreement that may be entered into among the shareholders from time to time.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 14. Financial year and Approval of annual accounts.
14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
14.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by its managers, other members of the Company's management team and shareholders to the Company.
The annual accounts shall be drawn up in USD.
14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following
the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders' Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
Art. 15. Auditors.
15.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
15.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be
supervised by one or more statutory auditors (commissaires), unless the Law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The statutory auditors are subject to re-appointment at the
annual General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 16. Allocation of profits - General principles.
16.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
16.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
16.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
109030
L
U X E M B O U R G
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
16.4. Shares issued in the course of a calendar year shall be entitled to share in the dividend distribution during that
year only on a pro rata temporis basis, i.e. only for that portion of the year for which the shares have been outstanding.
16.5. If shares are issued at a price which is less than the per share value at the time of issuance, but with a contractual
commitment of the subscriber to pay the difference to the per share value into the special equity reserve of the Company,
then that shall be treated for the dividend entitlement as if, on the basis of the per share value at the time of issuance of
those shares, not all of those shares have been issued at that time, but these shares had been issued only over time in
proportion to the extent that the payments (issue price and additional payment into the equity reserve) equal the per
share value of the issued shares at the time of the issuance.
16.6. For purposes of Articles 16 and 19, the issue of shares and the payment for shares, if made in the first half of a
calendar month, shall be deemed to have taken place at the beginning of the month and otherwise shall be deemed to
have taken place at the beginning of the next following month.
Art. 17. Special dividend entitlements of Class BN Shares.
17.1. The Class BN Shares shall receive a priority interest in dividend distributions (PPI) in addition to their dividend
entitlements which are identical to those of the Ordinary Shares and the Special Shares.
17.2. The PPI shall apply to dividend distributions made at any time after the issue of the Class BN shares. That priority
shall not affect the dividend entitlement of shares of other subclasses of Class B Ordinary Shares, the normal dividend
entitlement of Class BN Shares and/or the dividend rights of Class S1 Shares and Class S2 Shares. The PPI shall be taken
exclusively from the dividend which otherwise would be distributable on Class A Ordinary Shares. It shall be in addition
to the normal dividend entitlement of Class BN Shares.
17.3. The priority distributions pursuant to this Article 17 shall not exceed the aggregate sum of net long-term capital
gains and “qualifying dividend income” within the meaning of section 1(h)(11) of the US Internal Revenue Code of 1986
(as amended) (“QDI”) that has been recognized by the Company for U.S. federal income tax purposes after January 1,
2012 (the “Applicable Profits”). The following income items shall be regarded as Applicable Profits
(a) Proceeds from a sale of investments with a long-term holding period for U.S. federal income tax purposes to the
extent they exceed the original value of such investments in the books of the Company;
(b) QDI received by the Company other than dividends whose expected amount was included in the original book
value of the underlying portfolio company; dividends received by the Company in 2012 for periods preceding January 1,
2012 shall be deemed not to have been included in the original book value of the underlying portfolio company if and to
the extent
(i) the market value of the underlying portfolio company immediately after the distribution of such dividend, or
(ii) the sum of the highest market value of the underlying portfolio company in the period from January 1, 2012 to the
date of the distribution and the market value immediately after the distribution less the market value immediately before
the distribution
is at least equal to the value that (if applicable on conversion into US Dollars) was the basis of the original book value.
Dividends received for periods after December 31, 2011 shall be deemed not to have been included in the original book
value.
17.4. The initial amount of the priority interest shall be equal to USD 90 million, increased for interest at the rate to
be determined; such amount of USD 90 million increased for interest as aforesaid (the “Accrued Priority”) shall be further
grossed up for all taxes payable by the holder of the Class BN Shares (whether withholding taxes or taxes payable by
assessments in Luxembourg or the country of the holder of the Class BN Shares's residence, including without limitation
a gross-up for any taxes payable on such grossed up taxes) on account of the distribution of and entitlement to such
priority interest, such that the total amount payable hereunder (the “Total Profit Allocation”) shall be (i) the Accrued
Priority divided by (ii) a number, expressed as a decimal, equal to 100% minus the applicable tax rate. The applicable taxes
and the effective tax rate shall be determined jointly by the holders of the Class BN Shares and Class A Ordinary Shares.
If it should turn out later that the taxes are higher, the rights under the PPI shall increase so as to cover these additional
taxes (if applicable on grossed up basis) as well, including any interest or penalties imposed by the taxing authorities that
are not attributable to acts or omissions of the holder of the Class BN Shares. If they are lower, the holders of the Class
BN shares shall turn over the excess to the holders of the Class A Ordinary Shares.
109031
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Dividend entitlements of Class S1 Shares and Class S2 Shares.
18.1. Each Class S1 Share and each Class S2 Share is entitled to 1/5
th
(one-fifth) of the dividend distributed on an
Ordinary Share (other than the PPI of Class BN shares) provided that Class S1 Shares do not participate in that part of
a dividend by which the distributions in any given calendar year in aggregate exceed 0.7% of the net asset value of the
Company as at the beginning of such calendar year, and
18.2. Class S2 Shares participate each with 25% of the dividend attributable to an Ordinary Share out of that part of
the distribution of the dividends in which Class S1 Shares do not participate according to Article 18.1 but subject to
Article 19.2.
Art. 19. Regular distributions.
19.1. Unless otherwise decided by the shareholders, the Company shall make annual distributions of 0.7% of the
Company's own net asset value as at the beginning of the then current year. These distributions shall be made in addition
to the distribution on the PPI. To the extent necessary, such distributions shall be made from reserves.
19.2. If the Company resolves to make a distribution of dividends in any calendar year in excess of 0.7% of the Com-
pany's own net asset value but such that the amount of the dividend does not exceed 0.7% of the net asset value of a
Virtual Pool (as may be defined from time to time) as at the beginning of the year, then the amount by which this dividend
exceeds the amount of 0.7% of the net asset value of the Company's own net assets up to the amount of 0.7% of the net
asset value of such Virtual Pool as at the beginning of the year shall be distributed exclusively to the holders of the Class
A1 Ordinary Shares.
19.3. The first general distribution of dividends shall be made in October 2012 and shall be measured against the
Company's own net asset value as at January 1, 2012; for this purpose, the contributions made with respect to the shares
referred to in Article 5.1 prior to July 2012 shall be regarded as part of the Company's net assets as at January 1, 2012.
19.4. To the extent a shareholder or the ultimate shareholder of a shareholder, as the case may be, is subject to pass-
through income taxation on profits of the Company or its subsidiaries allocated to him/her by the relevant tax authorities
and such taxable income allocations for any year exceed the amount of cash distributed to such shareholder for such
year (in each case, not taking into account any allocations or distributions pursuant to the PPI), that shareholder shall be
entitled to an additional distribution (each such distribution: a “Tax Distribution”) in the amount of his, her, its or its
ultimate shareholder's tax liability attributable to such excess taxable income allocation. For purposes of calculating the
net asset value of the Company (whether in connection with the issue of shares or in connection with redemption of
shares) and for the determination of the proceeds of liquidation available for distribution the amount of all such Tax
Distributions made to any shareholders shall be added to the net asset value of the Company as if it were a loan to the
recipients of the relevant Tax Distributions. The amount of such Tax Distributions shall be regarded as a prepayment of
the recipient's share in the liquidation proceeds and accordingly shall reduce the amount the holder of the shares con-
cerned receives in the liquidation.
VI. Dissolution - Liquidation
20.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.
20.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them except for what is provided in Articles 20.3 and 20.4.
20.3. Class S1 Shares participate in liquidation proceeds only up to the amount of a distribution of 120% of the per
share value at the time of their issue (which would be the Full Issue Price for Ordinary Shares, as may be defined from
time to time, issued at the same time) (the “Ordinary Issue Price”), as it may be adjusted from time to time pursuant to
anti-dilution provisions in option or similar agreements.
20.4. Class S2 Shares do not participate in the distribution of liquidation proceeds up to an amount of 120% of the
Ordinary Issue Price (as adjusted, if applicable), but they participate in the distribution of liquidation proceeds to the
extent they exceed 120% of the Ordinary Issue Price (as adjusted, if applicable). However, the holder of a Class S2 Share
is entitled to this participation in liquidation proceeds in excess of 120% of the Ordinary Issue Price (as adjusted, if
applicable) only to the extent the holder has a corresponding number of Class S1 Shares in such a way that rights of a
Class S2 Share in respect of liquidation proceeds can be exercised only in conjunction with the exercise of the rights
under an existing Class S1 Share held by the same holder to participate in the liquidation proceeds up to 120% of the
Ordinary Issue Price.
VII. General provisions
21.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
109032
L
U X E M B O U R G
21.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described in Article 21.1 above. Powers of attorney in
connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted
by the Board.
21.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
21.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
including the change of the company name of Joh. A. Benckiser SE, with power and authority given to any manager of the
Company, each acting individually, to (i) register, in the name and on behalf of the Company, the newly issued shares in
the register of shareholders of the Company, and (ii) complete any formalities in connection with the Share Capital
Increase (including, for the avoidance of doubt, the signing of the said registers).
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to approve (A) the pledge of (i) five thousand (5,000) new class B4 Ordinary Shares by Jorina
s.à r.l. in accordance with any pledge agreement that may be entered into from time to time by Jorina s.à r.l. and (ii) five
thousand (5,000) new class B5 Ordinary Shares by F.A.M.P.A. s.à r.l. in accordance with any pledge agreement that may
be entered into from time to time by F.A.M.P.A. s.à r.l., (iii) seven thousand three hundred seventy (7,370) new class B6
Ordinary Shares by Aliyah s.à r.l. in accordance with any pledge agreement that may be entered into from time to time
by Aliyah s.à r.l., (iv) five thousand (5,000) new class B7 Ordinary Shares by Markus Hopmann in accordance with any
agreement that may be entered into from time to time by Markus Hopmann and (v) five thousand (5,000) new class B8
Ordinary Shares by Joachim Creus in accordance with any agreement that may be entered into from time to time by
Joachim Creus and (B) the transfer of these shares upon enforcement of these pledges in accordance with applicable
provisions.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately three thousand euro (EUR 3.000,-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed. The meeting was closed at 11:30 a.m.
Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes
Im Jahr zweitausendzwölf fand am 4. Juli um 11:00 Uhr vor Maître Joseph Elvinger, Notar in Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg,
eine außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) der Gesellschafter der Joh. A. Benckiser s.à r.l. statt,
einer privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg, gegründet gemäß einer Urkunde des Notars Maître Elvinger vom 8. November 2011, eingetragen im Luxem-
burger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 164.586, mit einem Stammkapital von 6.327.198,--USD
(die Gesellschaft). Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde erst kürzlich am 9. Januar 2012 durch eine Urkunde
von Maître Elvinger, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 25. Januar 2012 unter Num-
mer 204, geändert.
ES ERSCHIENEN
Parentes Holding SE (vormaliger Firmenname: Joh. A. Benckiser SE), eine Gesellschaft nach österreichischem Recht,
mit Gesellschaftssitz in Rooseveltplatz 4-5/Top 10, A-1090 Wien, Österreich, eingetragen beim Handelsgericht Wien
unter der Nummer FN 288590 y,
Dr. Renate Reimann-Haas mit Geschäftsadresse in Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090 Wien, Österreich,
109033
L
U X E M B O U R G
HFS s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung mit eingetragenem Sitz in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.525,
Bansk s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.349,
Platin Investments s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger
Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.345,
1998 Grat s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.604,
AC Revocable Trust s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger
Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.629,
- jeder einzeln ein „Gesellschafter“ oder gemeinsam die „Gesellschafter“-
Parentes Holding SE hier vertreten durch Sara Lecomte, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht.
Dr. Renate Reimann-Haas, HFS s.à r.l., Bansk s.à r.l., Platin Investments s.à r.l., 1998 Grat s.à r.l. und AC Revocable
Trust s.à r.l., werden jeweils vertreten durch Siobhán McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmachten.
Besagte Vollmachten, welche von den Stellvertretern, handelnd für die erschienenen Parteien, und dem unterzeichn-
enden Notar ne varietur unterzeichnet wurden, werden der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt.
Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben dargestellt, haben den unterzeichnenden Notar um Inkraftsetzung des
Folgenden ersucht:
I. Dass die Gesellschafter alle Geschäftsanteile des Stammkapitals der Gesellschaft halten;
II. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von siebenundzwanzigtausenddreihundertsiebzig US-
Dollar (27.370,--USD), um das Stammkapital der Gesellschaft von seiner gegenwärtigen Höhe von sechs Millionen
dreihundertsiebenundzwanzigtausendeinhundertachtundneunzig US-Dollar (6.327.198,--USD) auf sechs Millionen drei-
hundertvierundfünfzigtausendfünfhundertachtundsechzig US-Dollar (6.354.568,--USD) anzuheben, durch Ausgabe von
siebenundzwanzigtausenddreihundertsiebzig (27.370) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--
USD) (die Erhöhung des Stammkapitals);
2. Zeichnung und Einzahlung der im vorstehenden Punkt 1 angegebenen Erhöhung des Stammkapitals durch mehrere
Bareinlagen;
3. Genehmigung der Änderung und vollständigen Neufassung der Satzung;
4. Änderung des Gesellschafterverzeichnisses der Gesellschaft zur Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen
einschließlich der Änderung der Firmennamens der Joh. A. Benckiser SE, wobei jedem Manager der Gesellschaft die
Befugnis und Vollmacht erteilt wird, jeweils einzeln handelnd, (i) für und im Namen der Gesellschaft die neu ausgegebenen
Geschäftsanteile in das Gesellschafterverzeichnis der Gesellschaft einzutragen und (ii) alle Formalitäten in Verbindung mit
der Erhöhung des Stammkapitals abzuschließen (zur Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die
Unterzeichnung der genannten Verzeichnisse gehört);
5. Genehmigung von Anteilsverpfändungen; und
6. Verschiedenes.
III. Dass die Gesellschafter die nachstehenden Beschlüsse gefasst haben.
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von siebenund-
zwanzigtausenddreihundertsiebzig US-Dollar (27.370,--USD), um das Stammkapital der Gesellschaft von seiner gegen-
wärtigen Höhe von sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendeinhundertachtundneunzig US-Dollar
(6.327.198,-USD), repräsentiert durch sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendeinhundertachtundneunzig
(6.327.198) Geschäftsanteile im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--USD) auf sechs Millionen dreihundertvierund-
fünfzigtausendfünfhundertachtundsechzig US-Dollar (6.354.568,--USD) anzuheben, durch Ausgabe von siebenundzwan-
zigtausenddreihundertsiebzig (27.370) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--USD) (die
Erhöhung des Stammkapitals);
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen die Annahme und Eintragung der nachstehenden Zeichnungen und vollständigen Ein-
zahlung der Erhöhung des Stammkapitals wie folgt:
109034
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Zu diesem Zeitpunkt interveniert die Jorina s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende
private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, derzeit
im Registrierungsverfahren beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister befindlich, vertreten durch Siobhán
McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Vollmacht,
besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne va-
rietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt,
und erklärt, fünftausend (5.000) neue Stammanteile Klasse B4 durch Einzahlung von fünfzehntausend US-Dollar
(15.000,--USD) in bar zu zeichnen.
Die von der Jorina s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von fünftausend US-Dollar (5.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und
- ein Betrag von zehntausend US-Dollar (10.000,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.
Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die
jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.
Zu diesem Zeitpunkt interveniert die F.A.M.P.A. s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende
private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, derzeit
im Registrierungsverfahren beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister befindlich, vertreten durch Siobhán
McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Vollmacht,
besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne va-
rietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt,
besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne va-
rietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt,
und erklärt, fünftausend (5.000) neue Stammanteile Klasse B5 durch Einzahlung von fünfzehntausend US-Dollar
(15.000,--USD) in bar zu zeichnen.
Die von der F.A.M.P.A. s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von fünftausend US-Dollar (5.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und
- ein Betrag von zehntausend US-Dollar (10.000,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.
Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die
jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.
Zu diesem Zeitpunkt interveniert die Aliyah s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende
private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, derzeit
im Registrierungsverfahren beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister befindlich, vertreten durch Siobhán
McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsan-
waltsvollmacht,
besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne va-
rietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt,
und erklärt, siebentausenddreihundertsiebzig (7.370) neue Stammanteile Klasse B6 durch Einzahlung von zwei Millionen
achthunderttausend US-Dollar (2.800.000,--USD) in bar zu zeichnen.
Die von der Aliyah s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von siebentausenddreihundertsiebzig US-Dollar (7.370,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesell-
schaft zugewiesen; und
- ein Betrag von zwei Millionen siebenhundertzweiundneunzigtausendsechshundertdreißig US-Dollar (2.792.630,-
USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.
Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die
jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.
Zu diesem Zeitpunkt interveniert Markus Hopmann mit Geschäftsadresse in Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090 Wien,
Österreich, vertreten durch Siobhán McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, auf-
grund der privatschriftlichen Vollmacht,
besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne va-
rietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt,
und erklärt, fünftausend (5.000) neue Stammanteile Klasse B7 in bar zu zeichnen durch Einzahlung von einer Million
zweihundertneunzigtausend Euro (1.290.000,--EUR), in US-Dollar umzurechnen nach dem Wechselkurs, der von der US
Federal Reserve Bank am letzten Werktag vor dem Datum dieser Urkunde veröffentlicht wurde.
Die von Markus Hopmann geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von fünftausend US-Dollar (5.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und
109035
L
U X E M B O U R G
- der Gegenwert in US-Dollar von einer Million zweihundertneunzigtausend Euro (EUR 1.290.000), umgerechnet nach
dem Wechselkurs, der von der US-Federal Reserve Bank für den letzten Tag vor dem Datum dieser Urkunde veröffent-
licht wurde, minus fünftausend US-Dollar (5.000,--USD), wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.
Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die
jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.
Zu diesem Zeitpunkt interveniert Joachim Creus mit Geschäftsadresse 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, ver-
treten durch Siobhán McCarthy mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privat-
schriftlichen Vollmacht,
besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne va-
rietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt,
und erklärt, fünftausend (5.000) neue Stammanteile Klasse B8 durch Einzahlung von einhundertfünfundvierzigtausend
US-Dollar (145.000,--USD) in bar zu zeichnen.
Die von der Joachim Creus geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von fünftausend US-Dollar (5.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und
- ein Betrag von einhundertvierzigtausend US-Dollar (140.000,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewie-
sen.
Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die
jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.
Die Bareinlagen in die Gesellschaft, wie oben aufgeführt, werden insgesamt wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von siebenundzwanzigtausenddreihundertsiebzig US-Dollar (27.370,-USD) wird dem Stammkapitalkonto
der Gesellschaft zugewiesen; und
- ein Betrag von zwei Millionen neunhundertzweiundfünfzigtausendsechshundertdreißig US-Dollar (2.952.630,-USD)
plus der Gegenwert in US-Dollar von einer Million zweihundertneunzigtausend Euro (1.290.000,--EUR), umgerechnet
nach dem Wechselkurs, der von der US-Federal Reserve Bank für den letzten Tag vor dem Datum dieser Urkunde
veröffentlicht wurde, minus fünftausend US-Dollar (5.000,--EUR), wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.
Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die
jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.
Der Nachweis der vollen Einzahlung dieser Bareinlagen wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.
Alle vorgenannten Einleger nehmen als Gesellschafter an der Versammlung teil und werden zusammen mit den Ge-
sellschaftern als die Gesellschafter bezeichnet.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter (zur Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Parteien gehören, die durch
die vorgenannten Einlagen Gesellschafter der Gesellschaft geworden sind) beschließen, die Satzung wie folgt zu ändern
und neu zu fassen:
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Firma. Der Firma der Gesellschaft lautet „Joh. A. Benckiser s.à.r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und dieser Gesellschaftssatzung (die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss
des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb dieser Gemeinde verlegt werden. Der Sitz
der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungs-
änderung an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Wenn der Geschäftsführungsrat feststellt, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder bevorstehen und dass diese
Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Kommuni-
kation zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz vorübergehend ins
Ausland verlegt werden, bis die fraglichen Entwicklungen oder Ereignisse vollständig beendet sind. Derartige vorüberge-
hende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden
Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in-oder ausländischen Gesellschaften oder Un-
ternehmen jeder Art in Luxemburg oder im Ausland, sowie die Verwaltung und der Verkauf solcher Beteiligungen.
Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einla-
109036
L
U X E M B O U R G
gezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf, Verkauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben und
veräußern, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtsper-
sönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und
Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb, die
Verwaltung und die Veräußerung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden
Ursprungs investieren.
3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt, die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaften oder Personen verleihen. Des
Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten,
verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Ver-
pflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum
Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt
ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Techniken, Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen und
anderen Geschäfte effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz-und andere
Risiken abzusichern.
3.4. Die Gesellschaft ist befugt alle gewerblichen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug
auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschafts-
zweck beziehen lassen oder diesen fördern.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft soll nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, In-
solvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst
werden.
II. Kapital - Geschäftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital wird auf sechs Millionen dreihundertvierundfünfzigtausendfünfhundertachtundsechzig US-Dollar
(6.354.568,-USD) festgesetzt, repräsentiert durch sechs Millionen dreihundertvierundfünfzigtausendfünfhundertachtund-
sechzig (6.354.568) Anteile in Form von Namensanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--USD), unterteilt in
mehrere Klassen wie folgt: fünf Millionen dreihundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.342.200) Stammanteile Klasse
A (die Stammanteile Klasse A), einhundertdreiunddreißigtausenddreihundertdreiunddreißig (133.333) Stammanteile Klas-
se B1 (die Stammanteile Klasse B1), fünfzigtausend (50.000) Stammanteile Klasse B2 (die Stammanteile Klasse B2),
einhundertzwanzigtausend (120.000) Stammanteile Klasse BN (die Stammanteile Klasse BN), fünfzehntausend (15.000)
Stammanteile Klasse B3 (die Stammanteile Klasse B3), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B4 (die Stammanteile
Klasse B4), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B5 (die Stammanteile Klasse B5), siebentausenddreihundertsiebzig
(7.370) Stammanteile Klasse B6 (die Stammanteile Klasse B6), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B7 (die Stamm-
anteile Klasse B7), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B8 (die Stammanteile Klasse B8; die Stammanteile Klasse B1,
die Stammanteile Klasse B2, die Stammanteile Klasse BN, die Stammanteile Klasse B3, die Stammanteile Klasse B4, die
Stammanteile Klasse B5, die Stammanteile Klasse B6, die Stammanteile Klasse B7 und die Stammanteile Klasse B8 werden
zusammen als Stammanteile Klasse B bezeichnet; die Stammanteile Klasse A und die Stammanteile Klasse B werden
zusammen als die Stammanteile bezeichnet), einhundertdreiunddreißigtausenddreihundertdreiunddreißig (133.333) Son-
deranteile 1 (Anteile S1) und fünfhundertdreiunddreißigtausenddreihundertzweiunddreißig (533.332) Sonderanteile 2 (die
Anteile S2; die Anteile S1 und die Anteile S2 werden zusammen als Sonderanteile bezeichnet). Die mit den einzelnen
Anteilskategorien verbundenen Rechte werden in dieser Satzung festgelegt. Ein Anteil Klasse S1 und ein Anteil Klasse S2
gemeinsam haben vorbehaltlich der in Artikel 17.2, 18.1, 18.2, 20.3 und 20.4 aufgeführten Beschränkungen die Rechte
eines einzigen Stammanteils.
5.2. Einlagen in das Agiokonto und das Kapitalreserve-Sonderkonto der Gesellschaft sind weiterhin mit jedem Anteil
verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bilden keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.
5.3. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-
stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.
6.3. Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.
109037
L
U X E M B O U R G
6.4. Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen (inter vivos) an
Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Ge-
sellschaft vertreten müssen.
6.5. Zur Klarstellung, im Falle einer Pfändung von Anteilen der Gesellschaft, bedarf jede Vollstreckung, die zu einer
Übertragung der Anteile von den gegenwärtigen Anteilsinhabern führt, der Genehmigung der Gesellschafter gemäß Art.
6.4. Wenn die Gesellschafter ihre Genehmigung gemäß Art. 6.4 nicht erteilen, werden die Anteile, die der Vollstreckung
unterliegen, automatisch von der Gesellschaft durch einen Gesellschafterbeschluss und gegen Zahlung des Verkehrswer-
tes der Anteile, der durch den von der Geschäftsführung abschließend bestimmten réviseur d'entreprises ermittelt wird,
an die Partei, die die Vollstreckung betreibt, eingezogen. Die Bestimmung des Verkehrswertes durch den réviseur d'ent-
reprises ist ebenfalls abschließend.
6.6. Wenn die Gesellschaft nach dem vorstehenden Abschnitt rechtlich daran gehindert ist, ihre eigenen Anteile ein-
zuziehen, soll der Gesellschafter, der die meisten Anteile hält – oder, nach Ermessen dieses Gesellschafters, – sollen alle
Gesellschafter (außer dem, dessen Anteile eingezogen werden) die Anteile, die der Vollstreckung unterliegen, anteilig,
entsprechend ihrer Beteiligungshöhe, gegen Zahlung des durch den réviseur d'entreprises ermittelten Verkehrswertes
der Anteile erwerben.
6.7. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten. Wird eine solche Zustimmung nicht erteilt,
werden die Anteile des verstorbenen Gesellschafters von der Gesellschaft zu einem Preis in Höhe des Nettoinventar-
wertes der Anteile des verstorbenen Gesellschafters am Ende des Kalendervierteljahrs, in dem die Zustimmung
verweigert wurde, erworben.
6.8. Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
6.9. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden
Gesellschafters eingesehen werden kann.
6.10. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt,:
(i) die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven; oder
(ii) falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern (gérants) verwaltet. Diese werden durch einen
Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine
Gesellschafter der Gesellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen
werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Ge-
schäftsführungsrat (der Rat). Die Gesellschafter können beschließen, Geschäftsführer von zwei verschiedenen Klassen zu
ernennen, dass heißt einen oder mehrere Klasse A Geschäftsführer und einen oder mehrere Klasse B Geschäftsführer.
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung den Gesellschaftern vorbehalten
sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnisse zustehen, jegliche Handlungen und Tätigkeiten
auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.
(ii) Der Rat kann besondere oder eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere
Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch von zwei (2) Geschäftsführern findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung
genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
109038
L
U X E M B O U R G
(v) Der Rat ist nur tagungs-und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Ge-
schäftsführer gefasst werden, vorausgesetzt dass, wenn die Gesellschafter einen oder mehrere Klasse A Geschäftsführer
und einen oder mehrere Klasse B Geschäftsführer ernannt haben, mindestens ein (1) Klasse A Geschäftsführer und ein
(1) Klasse B Geschäftsführer den Beschlüssen zugestimmt haben. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen
festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei
der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden, unter der Bedingung, dass die Nicht-
einhaltung dieser Vorschrift der Aufzeichnung die Gültigkeit des jeweiligen Beschlusses nicht berührt.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon-oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommuni-
kationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Schriftliche Beschlüsse der
Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abge-
haltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von
mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden. Wenn die Gesellschafter verschiedene Klassen von Geschäftsführern,
nämlich die Klasse A und die Klasse B Geschäftsführern, ernannt haben wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche
Unterschrift eines Klasse A Geschäftsführer und eines Klasse B Geschäftsführer gebunden sein.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichung der Personen gebunden welchen vom
Rat durch den Rat genehmigte Spezialvollmachten in Übereinklang mit den für Bevollmächtigungen anwendbaren Regeln
erteilt wurden.
Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer. Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, ist jede oben
genannte Bestimmung welche für den Geschäftsführungsrat gilt, auch auf den einzelnen Geschäftsführer sinngemäß an-
zuwenden.
Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften auf Grund ihres Amtes nicht persönlich für Ver-
pflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft rechtsgültig eingegangen sind, sofern diese Verpflichtungen der Satzung
und dem Gesetz entsprechen. Die Geschäftsführer haften darüber hinaus nur für eine vorsätzliche Verletzung der mit
ihrer Amtsführung verbundenen Pflichten. Die Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit einem jeweils durch und zwi-
schen den Geschäftsführern und der Gesellschaft geschlossenen Freistellungsvertrag und unbeschadet sonstiger Freistel-
lungen, auf die die Geschäftsführer anderweitig Anspruch haben können, die Geschäftsführer mit voller Entschädigung
und im weitesten gesetzlich zulässigen Umfang von allen Verbindlichkeiten, Verlusten, Schäden, Strafen, Kosten, Aufwen-
dungen und Auslagen (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, angemessener und dokumentierter Barauslagen)
(die „Kosten“) freistellen, die den Geschäftsführern auf Grund, aus oder in Verbindung mit der tatsächlichen oder ange-
blichen Ausübung ihres Amtes als Geschäftsführer der Gesellschaft entstanden sind oder die sie zu tragen hatten,
insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf solche Fälle, in denen diese Kosten (i) aus einem Anspruch, einer Klage, For-
derung, Ermittlung oder einem (zivilrechtlichen, strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen) Verfahren entstehen, das
gegen die Geschäftsführer geltend gemacht oder geführt oder ihnen angedroht wird, oder (ii) sich aus einer anwendbaren
luxemburgischen oder ausländischen Rechtsvorschrift oder Verordnung ergeben (einschließlich, ohne darauf beschränkt
zu sein, anwendbare Steuervorschriften oder verordnungen). Eine Freistellung von einer Haftung gegenüber der Gesell-
schaft oder einer ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder ihren Gesellschaftern wird den Geschäfts-
führern bei vorsätzlicher Verletzung der mit ihrer Amtsführung verbundenen Pflichten oder bei Betrug nicht gewährt.
Die Geschäftsführer werden auch dann, wenn sie nicht mehr Geschäftsführer der Gesellschaft oder eines verbundenen
Unternehmens der Gesellschaft sind, weiterhin gemäß den Bestimmungen der Freistellungen in einer jeweils durch und
zwischen den Geschäftsführern und der Gesellschaft geschlossenen Freistellungsvereinbarung freigestellt. Aufwendungen
in Verbindung mit der Vorbereitung und Vertretung einer Abwehr gegen eine Klage, Forderung, Ermittlung oder ein
Verfahren der in diesem Artikel beschriebenen Art werden von der Gesellschaft vorgestreckt bis zur endgültigen Ver-
fügung über dieselbe, gegen Erhalt einer Verpflichtungserklärung durch oder im Namen der Geschäftsführer zur
Rückzahlung des betreffenden Betrages, falls und insoweit endgültig entschieden wird, dass sie keinen Anspruch auf Frei-
stellung gemäß diesem Artikel haben.
IV. Gesellschafter
Art. 11. Hauptversammlung und Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Sofern nicht Beschlüsse in Übereinstimmung mit Artikel 11.1. (ii) getroffen werden, werden Beschlüsse der Ge-
sellschafter in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) gefasst.
(ii) Wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft nicht fünfundzwanzig (25) überschreitet, können Beschlüsse der
Gesellschafter in schriftlicher Form (die Schriftlichen Beschlüsse) erlassen werden.
109039
L
U X E M B O U R G
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative des Rates, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen. Der Rat muss auf Antrag der
Gesellschafter, welche mehr als ein Zehntel (1/10) (d.h. 10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, eine Hauptversammlung
einberufen.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage
im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Wenn Beschlüsse schriftlich angenommen werden sollen, soll der Rat den Text dieser Beschlüsse an alle Gesell-
schafter schicken. Die Gesellschafter stimmen schriftlich ab und sollen ihre Stimme der Gesellschaft innerhalb der Frist,
die durch den Rat festgelegt wurde, übermitteln. Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, die Stimmen zu zählen.
(iv) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt.
(v) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung bekannt ist und sie sich selbst als ordnungsgemäβ einberufen
betrachten.
(vi) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss,
eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vii) Die in den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern
getroffen, welche mehr als die Hälfte (d.h. 50%) des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der
ersten Hauptversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung
geladen und die Beschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst,
unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(viii) Die Satzung kann nur mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden.
(ix) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
(x) Schriftliche Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der oben genannten Beschlussfähigkeit und Mehrheits-
anforderungen gefasst und tragen das Datum der letzten, vor Ablauf der durch den Rat festgelegten Frist, erhaltenen
Unterschrift.
Art. 12. Alleingesellschafter. Wenn die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird:
(i) übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden;
(ii) Bezugnahmen auf die Gesellschafter, die Hauptversammlung oder die Schriftlichen Beschlüsse der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse; und
(iii) die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind in eine Niederschrift aufzunehmen oder schriftlich zu
verfassen.
Art. 13. Gesellschafterausschuss.
13.1. Die Gesellschafter können von Zeit zu Zeit mit einfacher Mehrheit einen Gesellschafterausschuss mit einer
Zusammensetzung bilden, die den Gesellschaftern zur Erleichterung des Informationsflusses zwischen der Gesellschaft
und den Gesellschaftern geeignet erscheint.
13.2. Der Gesellschafterausschuss behandelt ferner Angelegenheiten, mit denen er durch eine jeweils zwischen den
Gesellschaftern geschlossene Gesellschaftervereinbarung betraut werden kann.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung – Aufsicht
Art. 14. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
14.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember jeden Jahres.
14.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn-und Verlustkonten der Gesellschaft gemeinsam mit einer
Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt mit einem Anhang welcher alle Verpflichtungen
der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der/des Geschäftsführer(s), von anderen Angehörigen des Geschäftsführungsteams
der Gesellschaft und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst. Der Jahresabschluss wird in USD
erstellt.
14.3. Ein jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
14.4. Die Bilanz und die Gewinn-und Verlustkonten müssen in der folgenden Weise genehmigt werden:
(i) wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft nicht fünfundzwanzig (25) überschreitet, innerhalb von sechs (6)
Monaten nach dem Ende des jeweiligen Geschäftsjahres entweder (a) bei der jährlichen Hauptversammlung (soweit vor-
handen) oder (b) durch Schriftliche Beschlüsse; oder
(ii) wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, auf der jährlichen Hauptver-
sammlung.
109040
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Wirtschaftsprüfer (auditeurs).
15.1. Sofern dies vom Gesetz vorgeschrieben ist, wird der Betrieb der Gesellschaft von einem oder mehreren externen
Wirtschaftsprüfer(n) (réviseur d' entreprises) kontrolliert. Die Gesellschafter ernennen die zugelassenen externen Wirt-
schaftsprüfer, falls erforderlich, und bestimmen ihre Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Amtes.
15.2. Wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, wird die Geschäftstätigkeit
der Gesellschaft durch eine oder mehrere Abschlussprüfer (commissaires) überwacht werden, sofern das Gesetz nicht
die Ernennung eines oder mehrerer zugelassenen externen Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agrées) verlangt.
Die Abschlussprüfer können bei der jährlichen Hauptversammlung wieder ernannt werden. Sie können oder können nicht
Gesellschafter sein.
Art. 16. Gewinnausschüttung - Allgemeine Grundsätze.
16.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
16.2. Die Gesellschafter bestimmen die Verteilung des Überschusses des jährlichen Nettogewinns. Sie können, in
Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vor-
nehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
16.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss muss zeigen, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur
Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende
des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und auszuschüttenden Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten
ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und
(iv) unter Berücksichtigung der Vermögenswerte der Gesellschaft, dürfen die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft
durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet werden.
16.4. Im Laufe eines Kalenderjahres ausgegebenen Anteile haben nur zeitanteilig Anspruch auf Beteiligung an der Di-
videndenausschüttung im betreffenden Jahr, d.h. nur für den Teil des Jahres, in dem die Anteile in Umlauf waren.
16.5. Werden Anteile zu einem Preis ausgegeben, der unter dem Wert je Anteil zum Zeitpunkt der Ausgabe liegt,
jedoch mit einer vertraglichen Verpflichtung des Zeichners, die Differenz zum Wert je Anteil in das Kapitalreserve-
Sonderkonto der Gesellschaft einzuzahlen, wird dies im Zusammenhang mit dem Dividendenanspruch so behandelt, als
wären auf der Grundlage des Wertes je Anteil zum Zeitpunkt der Ausgabe dieser Anteile nicht alle diese Anteile zum
betreffenden Zeitpunkt ausgegeben worden, sondern als seien diese Anteile erst im Laufe der Zeit ausgegeben worden,
jeweils im Verhältnis der Höhe der Zahlungen (Ausgabepreis und zusätzliche Einzahlung in die Kapitalreserve) zum Wert
je Anteil der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt der Ausgabe.
16.6. Im Sinne von Artikel 16 und 19 gelten die Ausgabe von Anteilen und die Einzahlung für Anteile dann, wenn sie
in der ersten Hälfte eines Kalendermonats vorgenommen wurden, als am Monatsanfang erfolgt und ansonsten gelten sie
als am Anfang des nächsten Monats erfolgt.
Art. 17. Sonderdividendenansprüche von Anteilen Klasse BN.
17.1. Die Anteile Klasse BN erhalten eine Vorzugsbeteiligung an Dividendenausschüttungen (PPI) zusätzlich zu ihren
Dividendenansprüchen, die denen der Stammanteile und der Sonderanteile entsprechen.
17.2. Die PPI gelten für Dividendenausschüttungen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ausgabe der Anteile Klasse
BN erfolgen. Diese Vorzugsbeteiligung berührt nicht den Dividendenanspruch von Anteilen anderer Teilklassen der
Stammanteile Klasse B, des normalen Dividendenanspruchs von Anteilen Klasse BN und/oder der Dividendenansprüche
von Anteilen Klasse S1 und Anteilen Klasse S2. Die PPI sind ausschließlich den Dividenden zu entnehmen, die andernfalls
an Stammanteile Klasse A auszuschütten wären. Sie gilt zusätzlich zu dem normalen Dividendenanspruch von Anteilen
Klasse BN.
17.3. Die Vorzugsausschüttungen gemäß diesem Artikel 17 dürfen nicht höher sein als die Gesamtsumme aus lang-
fristigen Nettokapitalgewinnen und „qualifizierten Dividendenerträgen” im Sinne von Abschnitt 1(h)(11) des US Internal
Revenue Code von 1986 (in der jeweils gültigen Fassung) („QDI“), der von der Gesellschaft für die Zwecke der US-
Bundeseinkommensteuer nach dem 1. Januar 2012 anerkannt wurde (die „anwendbaren Gewinne“). Die nachstehenden
Ertragsposten werden als anwendbare Gewinne betrachtet:
(a) Erlös aus dem Verkauf von Anlagen mit einer langen Haltefrist im Sinne der US-Bundeseinkommensteuer, soweit
dieser den ursprünglichen Wert dieser Anlagen in den Geschäftsbüchern der Gesellschaft übersteigen;
(b) Von der Gesellschaft erhaltene QDI außer Dividenden, deren erwarteter Betrag im ursprünglichen Buchwert der
zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft enthalten war; von der Gesellschaft im Jahr 2012 erhaltene Dividenden für Zei-
109041
L
U X E M B O U R G
träume vor dem 1. Januar 2012 gelten nicht als im ursprünglichen Buchwert der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft
enthalten, falls und insoweit:
(i) der Marktwert der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft unmittelbar nach der Ausschüttung dieser Dividende
oder
(ii) der Betrag des höchsten Marktwerts der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft in dem Zeitraum vom 1. Januar
2012 bis zum Datum der Ausschüttung und der Marktwert unmittelbar nach der Ausschüttung, abzüglich des Marktwerts
unmittelbar vor der Ausschüttung,
mindestens dem Wert entspricht, der (falls bei Umrechnung in US-Dollar zutreffend) die Grundlage des ursprünglichen
Buchwerts war. Für Zeiträume nach dem 31. Dezember 2011 erhaltene Dividenden gelten nicht als im ursprünglichen
Buchwert enthalten.
17.4. Der Erstbetrag der Vorzugsbeteiligung entspricht 90 Millionen USD zuzüglich Zinsen in einer zu ermittelnden
Höhe; dieser Betrag von 90 Millionen USD zuzüglich Zinsen wie vorgenannt (der „aufgelaufene Vorzugsbetrag“) wird
weiter erhöht um alle Steuern, die vom Inhaber der Anteile Klasse BN auf die Ausschüttung und den Anspruch auf diese
Vorzugsbeteiligung zu zahlen sind (gleich ob Quellensteuern oder auf Grund von Veranlagungen in Luxemburg oder im
Domizilland des Inhabers der Anteile Klasse BN zu entrichtende Steuern, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein,
einer Erhöhung um Steuern, die auf diese wegen der Ausschüttung und des Anspruchs auf diese Vorzugsbeteiligung
erhöhten Steuern zu zahlen sind), so dass der gemäß diesem Artikel zu zahlende Gesamtbetrag (die „gesamte Gewinn-
verteilung“) sich auf (i) den aufgelaufenen Vorzugsbetrag beläuft, dividiert durch (ii) eine als Dezimale angegebene Zahl in
Höhe von 100% abzüglich des anwendbaren Steuersatzes. Die anwendbaren Steuern und der effektive Steuersatz werden
gemeinsam von den Inhabern der Anteile Klasse BN und der Stammanteile Klasse A ermittelt. Sollte sich später heraus-
stellen, dass die Steuern höher sind, erhöhen sich die Rechte aus der Vorzugsbeteiligung in der Weise, dass sie auch diese
zusätzlichen Steuern (falls nach der Erhöhung zutreffend) abdecken, einschließlich Zinsen oder Bußgeldern, die von den
Finanzbehörden erhoben wurden und nicht auf Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers der Anteile Klasse BN
entfallen. Sind die Steuern niedriger, übergeben die Inhaber der Anteile Klasse BN den Überschussbetrag an die Inhaber
der Stammanteile Klasse A.
Art. 18. Dividendenansprüche von Anteilen Klasse S1 und Anteilen Klasse S2.
18.1. Jeder Anteil Klasse S1 und jeder Anteil Klasse S2 hat Anspruch auf 1/5 (ein Fünftel) der an einen Stammanteil
ausgeschütteten Dividende (außer der Vorzugsbeteiligung von Anteilen Klasse BN), vorausgesetzt, dass Anteile Klasse S1
nicht an dem Teil einer Dividende beteiligt sind, um den die Ausschüttungen in einem bestimmten Kalenderjahr insgesamt
0,7% des Nettoinventarwertes der Gesellschaft zu Anfang dieses Kalenderjahres übersteigen, und
18.2. Anteile Klasse S2 sind jeweils mit 25% der Dividende beteiligt, die auf einen Stammanteil aus dem Teil der
Dividendenausschüttung entfällt, an dem Anteile Klasse S1 gemäß Artikel 18.1 nicht beteiligt sind, jedoch vorbehaltlich
Artikel 19.2.
Art. 19. Regelmäßige Ausschüttungen.
19.1. Sofern nicht von den Gesellschaftern anders entschieden, nimmt die Gesellschaft jährliche Ausschüttungen von
0,7% des eigenen Nettoinventarwertes der Gesellschaft am Anfang des dann laufenden Jahres vor Diese Ausschüttungen
erfolgen zusätzlich zur Ausschüttung der Vorzugsbeteiligung. Soweit erforderlich, werden diese Ausschüttungen aus den
Reserven vorgenommen.
19.2. Wenn die Gesellschaft beschließt, in einem bestimmten Kalenderjahr eine Dividendenausschüttung von mehr als
0,7% des eigenen Nettoinventarwertes der Gesellschaft vorzunehmen, jedoch so, dass der Dividendenbetrag sich auf
nicht mehr als 0,7% des Nettoinventarwertes eines virtuellen Fundus (nach der jeweils geltenden Definition) am Anfang
des Jahres beläuft, wird der Betrag, um den diese Dividende die Höhe von 0,7% des Nettoinventarwertes des eigenen
Nettovermögens der Gesellschaft übersteigt, bis zur Höhe von 0,7% des Nettoinventarwertes dieses virtuellen Fundus
am Jahresanfang ausschließlich an die Inhaber der Stammanteile Klasse A1 der Gesellschaft ausgeschüttet.
19.3. Die erste allgemeine Dividendenausschüttung erfolgt im Oktober 2012 und wird anhand des eigenen Nettoin-
ventarwertes der Gesellschaft am 1. Januar 2012 bemessen; zu diesem Zweck werden die Einlagen für die in Artikel 5.1
genannten Anteile vor Juli 2012 als Teil des Nettovermögens der Gesellschaft per 1. Januar 2012 betrachtet.
19.4. Soweit ein Gesellschafter oder gegebenenfalls dessen oberster Anteilshalter einer Verlagerung der Steuerlast für
Gewinne der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften unterliegt, die ihm von den zuständigen Finanzbehörden zu-
gewiesen werden, und diese Zuweisungen zu versteuernden Einkommens für ein bestimmtes Jahr den Barbetrag
übersteigt, der für dieses Jahr an diesen Gesellschafter ausgeschüttet worden war (in jedem Falle ohne Berücksichtigung
von Gewinnverteilungen oder Ausschüttungen gemäß der Vorzugsbeteiligung), hat dieser Gesellschafter Anspruch auf
eine zusätzliche Ausschüttung (jeweils: eine „steuerbezogene Ausschüttung“) in Höhe seiner oder seines obersten An-
teilseigners auf diese überschüssige Zuweisung zu versteuernden Einkommens entfallenden Steuerlast. Zur Berechnung
des Nettoinventarwertes der Gesellschaft (gleich ob in Verbindung mit der Ausgabe von Anteilen oder in Verbindung mit
der Rücknahme von Anteilen) und zur Ermittlung des zur Ausschüttung verfügbaren Liquidationserlöses wird der Betrag
dieser gesamten an Gesellschafter vorgenommenen steuerbezogenen Ausschüttungen dem Nettoinventarwert der Ge-
sellschaft so hinzugerechnet, als handele es sich um ein Darlehen an die Empfänger dieser jeweiligen steuerbezogenen
Ausschüttungen. Der Betrag dieser steuerbezogenen Ausschüttungen wird als Anzahlung auf den Anteil des Empfängers
109042
L
U X E M B O U R G
am Liquidationserlös betrachtet und mindert daher den Betrag, den der Inhaber der betreffenden Anteile bei der Liqui-
dation erhält.
VI. Auflösung - Liquidation
20.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche min-
destens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder
mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung
und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesell-
schafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu
erfüllen.
20.2. Der Überschuss nach der Veräußerung der Vermögenswerte und der Erfüllung der Verbindlichkeiten wird (sofern
vorhanden) unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen jeweils gehaltenen Anteilen aufgeteilt, außer soweit
in den Artikeln 20.3 und 20.4 anders vorgesehen.
20.3. Anteile Klasse S1 sind am Liquidationserlös nur bis zu einem Ausschüttungsbetrag von 120% des Wertes je Anteil
zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe dieses Anteils beteiligt (der der volle Ausgabepreis für Stammanteile in der jeweiligen
Definition wäre, die zum gleichen Zeitpunkt ausgegeben werden) (der „Stammausgabepreis”), jeweils berichtigt gemäß
den Verwässerungsschutzbestimmungen in Options-oder ähnlichen Verträgen.
20.4. Anteile Klasse S2 sind an der Ausschüttung des Liquidationserlöses bis zur Höhe von 120% des Stammausgabe-
preises (gegebenenfalls berichtigt) nicht beteiligt, sind jedoch an der Ausschüttung des Liquidationserlöses in dem Umfang
beteiligt, in dem dieser 120% des Stammausgabepreises (gegebenenfalls berichtigt) übersteigt. Der Inhaber eines Anteils
Klasse S2 hat jedoch Anspruch auf diese Beteiligung am Liquidationserlös von mehr als 120% des Stammausgabepreises
(gegebenenfalls berichtigt) nur insoweit, als der Inhaber eine entsprechende Anzahl von Anteilen Klasse S1 besitzt, so
dass Rechte eines Anteils Klasse S2 in Bezug auf den Liquidationserlös nur in Verbindung mit der Ausübung der Rechte
aus einem vorhandenen Anteil Klasse S1, den der gleiche Inhaber besitzt, auf Beteiligung am Liquidationserlös bis zu 120%
des Stammausgabepreises ausgeübt werden kann.
VII. Allgemeine Bestimmungen
21.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Schriftliche
Beschlüsse der Geschäftsführer und Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telefax, E-Mail
oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
21.2. Vollmachten können auf eine der im vorstehenden Artikel 21.1 beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten
im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den
vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden
21.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-
den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Schriftliche
Beschlüsse der Geschäftsführer, Beschlüsse die in einer Telefon-oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise
Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen
desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
21.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden
Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich gesetzlicher Vorschriften, auf die nicht verzichtet werden kann, nach jeglicher
jeweils von den Gesellschaftern getroffenen Vereinbarung.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen eine Änderung des Gesellschafterverzeichnisses der Gesellschaft zur Berücksichtigung
der vorstehenden Änderungen einschließlich der Änderung des Firmennamens der Joh. A. Benckiser SE, wobei jedem
Geschäftsführer der Gesellschaft die Befugnis und Vollmacht erteilt wird, jeweils einzeln handelnd, (i) für und im Namen
der Gesellschaft die neu ausgegebenen Anteile in das Gesellschafterverzeichnis der Gesellschaft einzutragen und (ii) alle
Formalitäten in Verbindung mit der Erhöhung des Stammkapitals (zur Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass
dazu auch die Unterzeichnung der genannten Verzeichnisse gehört).
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen (A) die Verpfändung von (i) fünftausend (5.000) neuen Stammaktien Klasse B4 durch
Jorina s.à r.l. gemäß jeglicher Verpfändungsvereinbarung, die von Jorina s.à r.l. zu jedweder Zeit geschlossen werden kann,
(ii) von fünftausend (5.000) neuen Stammanteilen Klasse B5 durch F.A.M.P.A s.à r.l. gemäß jeglicher Verpfändungsverein-
barung, die von F.A.M.P.A s.à r.l. zu jedweder Zeit geschlossen werden kann und (iii) von siebentausenddreihundertsiebzig
(7.370) neuen Stammanteilen Klasse B6 durch Aliyah s.à r.l. gemäß jeglicher Verpfändungsvereinbarung, die von Aliyah s.à
r.l. zu jedweder Zeit geschlossen werden kann, (iv) von fünftausend (5.000) neuen Stammaktien Klasse B7 durch Markus
Hopmann gemäß dem Investment Agreement, dass zu jedweder Zeit von Markus Hopmann geschlossen werden kann
und (v) von fünftausend (5.000) neuen Stammaktien Klasse B8 durch Joachim Creus gemäß dem Investment Agreement
das von Joachim Creus zu jedweder Zeit geschlossen werden kann, sowie (B) die Übertragung dieser Anteile nach Voll-
streckung dieser Pfandrechte gemäß den anwendbaren Bestimmungen, zu genehmigen.
109043
L
U X E M B O U R G
<i>Veranschlagung der Kosteni>
Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Abgaben gleich welcher Art, die von der Gesellschaft auf Grund der vor-
liegenden Urkunde zu tragen sind, werden auf ca. dreitausend Euro (3.000,--EUR) veranschlagt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der des Englischen aktiv und passiv mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde
auf Wunsch der erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Wunsch
der gleichen erschienenen Partei ist bei Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Wortlaut die
englische Fassung maßgebend.
Urkundlich dessen wird die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem eingangs angegebenen Datum er-
richtet.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden war, unterzeichnete der
Bevollmächtigte der erschienenen Partei gemeinsam mit mir, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde. Die Ver-
sammlung wurde um 11.30 Uhr geschlossen.
Signé: R. REIMANN-HAAS, S. MCCARTHY, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 05 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31443. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 10 juillet 2012.
Référence de publication: 2012101632/1140.
(120138813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Pollyane Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 145.901.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
POLLYANE INVESTMENT S.A.
Référence de publication: 2012104040/11.
(120142173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Premium House S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 71.150.
Les comptes annuels au 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104043/9.
(120142251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
PSH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 128.071.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104045/9.
(120142280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Puraye S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 154, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 17.391.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
109044
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PURAYE SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2012104046/11.
(120141923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Six Payment Service (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 29.697.
Il résulte de la délibération du conseil d'administration de la société SIX Payment Service (Luxembourg) S.A. datée du
4 avril 2012 que Monsieur Niklaus Santschi né le 23/10/1968 à Sigriswil (Suisse) demeurant professionnellement au 201,
Hardturmstrasse, 8021 Zurich Suisse a été nommé administrateur à compter du 4 avril 2012, pour une durée indéter-
minée.
Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Signature
<i>Un mandataire autoriséi>
Référence de publication: 2012104187/14.
(120142277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Quee S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 783.264,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 115.904.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 3 juillet 2012i>
Conformément aux résolutions prises par l'associé unique, en date du 3 juillet 2012, il a été décidé:
- De renouveler avec effet immédiat, le mandat de Monsieur Nicolas Brimeyer, résidant au 15, rue Michel Lentz, L-1928
Luxembourg, au poste d'administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale décidant de l'approbation
des comptes au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2012.
<i>Pour QUEE S.à r.l.
i>SGG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012104047/18.
(120142300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
QLux Aviation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.693.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Peter Diehl
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012104049/11.
(120141687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Qui.Lu.Cru S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1530 Luxembourg, 111, rue Anatole France.
R.C.S. Luxembourg B 100.109.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
109045
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012104050/10.
(120141729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Red Grafton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 136.002.
Par résolutions prises en date du 31 juillet 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Christoph Unger, avec adresse professionnelle au 22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg,
de son mandat de Gérant, avec effet au 31 juillet 2012
- nomination de Michael Sacher, avec adresse professionnelle au 20, Grafton Street, W1S 4DZ Londres, Royaume-
Uni, au mandat de Gérant, avec effet au 31 juillet 2012 et pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2012.
Référence de publication: 2012104053/15.
(120141894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Real Estate Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6962 Senningen, 57, rue Wiltheim.
R.C.S. Luxembourg B 138.102.
<i>Beschluss des Verwaltungsratesi>
Der Verwaltungsrat der Real Estate Management S.A. beschließt die Annahme des Rücktritts von Herrn Helge Knedlik
als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.
Senningen, den 28. Juni 2012.
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitgliedi>
Référence de publication: 2012104051/12.
(120141785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Reflex'it S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 131.757.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104055/9.
(120142346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Reflex'it S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 131.757.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104056/9.
(120142347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Rafa Enterprises SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 117.869.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
109046
L
U X E M B O U R G
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012104057/11.
(120141842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
SBRE Luxco, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 116.953.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SBRE Luxco
i>SGG S. A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012104090/13.
(120141844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Riverways SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 85.142.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A-M. Griedert / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012104059/11.
(120141813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Roland International Holding, S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patri-
moine familial.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 49.601.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104060/10.
(120142219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Romos Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 145.678.
Les comptes annuels au 31-12-2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104061/9.
(120142107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Rub S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 89.361.
Par la présente, nous remettons avec effet immédiat notre démission en tant que Commissaire aux Comptes de votre
estimée société.
109047
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 1
er
août 2012.
TRIPLE A CONSULTING
Référence de publication: 2012104064/11.
(120141792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
SL Bielefeld Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 129.633.
Les comptes annuels concernant la période du 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 aout 2012.
Mr. Wayne Fitzgerald / Mr. Russell Perchard
<i>Gérant de catégorie A / Gérant de catégorie Bi>
Référence de publication: 2012104103/13.
(120142062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Safe Ship Investment Company S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 127.739.
Les Comptes Annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2012.
*.
Référence de publication: 2012104067/11.
(120142190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Saint Ange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 116.000.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104068/9.
(120141758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Saint Ange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 116.000.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104069/9.
(120141759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Saint Ange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 116.000.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104070/9.
(120141760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
109048
L
U X E M B O U R G
Vilret Avocats S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.812.
STATUTS
L'AN DEUX MILLE DOUZE,
LE HUIT AOÛT,
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, soussigné.
A comparu:
Maître Karine Vilret domiciliée professionnellement 37 A, avenue J F Kennedy L-1855 Luxembourg
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont ils ont
arrêté les statuts comme suit:
I Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi») et la loi du 10 août 1991 sur l'exercice de la profession d'avocat telle que modifiée (la «Loi de 1991»),
ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat.
La Société ne pourra accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un avocat inscrit au tableau de
l'Ordre des Avocats.
Conformément à la Loi de 1991, pour les actes requérant le ministère d'avocat à la Cour, la Société ne pourra être
représentée que par un avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des Avocats.
La Société pourra également effectuer toutes les opérations financières, civiles, immobilières ou mobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à son objet social et de nature à favoriser son extension et son développement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «VILRET AVOCATS Sàrl».
Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre II. Capital, Parts Sociales
Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et
dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une ou de plusieurs parts sociales
emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
109049
L
U X E M B O U R G
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.
Toute émission ou cession de parts sociales ne pourra être faite qu'à un avocat inscrit à un ordre ou à une organisation
représentant l'autorité compétente d'un état membre de l'Union Européenne. En accord avec les dispositions de la Loi
de 1991, l'émission ou la cession pourra intervenir à un avocat inscrit à un ordre ou à une organisation représentant
l'autorité professionnelle d'un état non membre de l'union Européenne.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
En cas de décès d'un associé, la Société continuera entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de
l'associé décédé, sous réserve de leur agrément par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales
appartenant aux survivants.
Les héritiers, ayants droit ne remplissant pas les conditions pour exercer la profession d'avocat au sein de la Société
devront céder leurs parts aux associés survivants, conformément aux dispositions du présent article 8, dans le délai de
trois mois à compter de l'événement leur ayant donné vocation à être associés. Ce délai expiré, la Société peut, nonobstant
leur opposition, décider de les racheter à la valeur nette comptable conformément à l'article 189 de la Loi.
En cas de décès de l'associé unique, les parts sociales pourront être librement transférées par les héritiers, ayants droit
à un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats.
Tous les droits rattachés aux parts sociales de l'associé décédé seront suspendus d'office à dater du décès jusqu'à
régularisation conformément aux dispositions légales et statutaires.
Art. 9. Cessation d'activité, Retrait d'un associé. Tout associé peut cesser son activité à condition d'en informer la
Société par lettre recommandée avec accusé de réception, six (6) mois à l'avance.
La cessation d'activité emporte de plein droit la perte de la qualité d'associé. Les parts sociales de l'associé retrayant
seront soit rachetées par un ou plusieurs associé(s), soit par un acquéreur agrée dans les conditions de l'article 8. S'il
n'est pas trouvé de cessionnaire, la Société rachètera les parts sociales de l'associé retrayant, à la valeur nette comptable
conformément à l'article 189 de la Loi.
Art. 10. Exclusion, Suspension. Tout associé exerçant sa profession au sein de la Société peut être exclu lorsqu'il est
frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice professionnel d'une durée égale ou supérieur à
6 mois.
L'exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales, cette majorité étant
calculée sans prendre en compte l'associé exclu.
Les parts sociales de l'associé exclu seront rachetées par les autres associés ou par un cessionnaire agréé dans les
conditions de l'article 8. A défaut, elles seront acquises par la Société à la valeur nette comptable conformément à l'article
189 de la Loi.
Chapitre III. Gérant(s)
Art. 11. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les gérants doivent obligatoirement être associés. Ils peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime, par décision de l'associé unique ou des associés représentant
la majorité des voix.
Chaque gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la
durée de leur mandat.
Art. 12. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir
pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération
conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant ou du conseil de gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par
l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.
Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires,
sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.
109050
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Gestion Journalière. Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un
ou plusieurs gérant(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants, la durée de la période
de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite
aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de financement et refinancement
doit être préalablement approuvé par le gérant ou le conseil de gérance.
Art. 14. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Lu-
xembourg.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant
sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Un gérant peut en représenter un autre au conseil.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n'importe quel moyen de communication
incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de
la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents
ou représentés.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est
présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple. En cas
de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre
moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et délibérant
au conseil puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.
Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même
contenu, signé(s) par tous les participants.
Chapitre IV. Associé(s)
Art. 15. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs
qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout
moyen de communication. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux
conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s'il existe,
ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale
ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un man-
dataire, lequel n'est pas obligatoirement associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.
Art. 16. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée repré-
sente l'ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément
à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.
Art. 17. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est
soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des Statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
L'assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts
sociales représentées à l'assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin
secret ne devront pas être pris en compte.
109051
L
U X E M B O U R G
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chapitre V. Année Sociale, Répartition.
Art. 18. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre. Exceptionnellement
le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le 31 décembre 2012.
Art. 19. Approbation des Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont
établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas,
des associés.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 20. Affectation des Résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société. Chaque année, cinq pour cent (5%) du
bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider
qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 21. Dividendes Intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve
du respect des conditions suivantes:
- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Chapitre VII. Loi Applicable
Art. 23. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi et à la Loi de 1991.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales ont été souscrites par Maître Karine Vilret, prénommé.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200.-.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
L'associé unique décide de:
1. Déterminer le nombre de gérant à un (1).
2. Nommer la personne suivante en tant que gérant unique et gérant exécutif de la Société:
- Maître Karine Vilret, prénommée.
La durée du mandat du gérant est illimitée.
3. Déterminer l'adresse du siège social au 37 A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg.
109052
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. VILRET, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 09 août 2012. Relation: RED/2012/1091. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. ELS.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 10 août 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012104156/230.
(120142310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Saint Ange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 116.000.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104071/9.
(120141761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Saint Ange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 116.000.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104072/9.
(120142205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Sainte Augustine Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 170.545.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2012.
Référence de publication: 2012104073/10.
(120141686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
WALSER Absolute Return, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 161.844.
<i>Auszug aus dem Protokolli>
der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, am 29. Juni 2012
um 11.30 Uhr abgehalten wurde.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt Herrn Dr. Carsten Kotas mit Wirkung zum 29. Juni 2012, als Mitglied des
Verwaltungsrates der Gesellschaft, gemäß Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft, abzuberufen.
Die Gesellschafterversammlung beschließt Herrn Magister Gökhan Kula mit Wirkung zum 29. Juni 2012, als Mitglied
des Verwaltungsrates der Gesellschaft, gemäß Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft, abzuberufen.
109053
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Frau Silke Büdinger, geboren am 14. August 1969 in Trier, geschäftsansässig
in 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach mit Wirkung zum 29. Juni 2012 als Mitglied des Verwaltungsrates der
Gesellschaft, zu ernennen.
Die Gesellschafterversammlung beschließt die Beibehaltung des Verwaltungsratsvorsitzenden Erhard Tschmelitsch und
des Verwaltungsratsmitglieds Herrn Stephan M. Modler (geschäftsansässig in 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach).
Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die im
Jahr 2013 stattfinden wird.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bestellt KPMG Luxembourg S.à r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg zum Abs-
chlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr welches am 30. April 2013 endet.
Luxemburg, den 29. Juni 2012.
Référence de publication: 2012104754/26.
(120142726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Sarabel B.V. / S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège de direction effectif: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 136.083.
Les comptes annuels au 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104075/9.
(120141702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
SGBT European Major Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 105.764.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104076/9.
(120141688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Select Development Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6962 Senningen, 57, rue Wiltheim.
R.C.S. Luxembourg B 138.103.
<i>Beschluss des Verwaltungsratesi>
Der Verwaltungsrat der Select Development Luxembourg S.A. beschließt die Annahme des Rücktritts von Herrn Helge
Knedlik als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.
Senningen, den 28. Juni 2012.
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitgliedi>
Référence de publication: 2012104078/12.
(120141786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Spheretech International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 137.867.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104082/9.
(120142341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
109054
L
U X E M B O U R G
Senc Houben - Vaes, Société en nom collectif.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 93.622.
L'an deux mille douze, le onze juillet,
L'assemblée des associés décide le transfert du siège social de L-9911 Troisvierges 9, rue de Drinklange à L-9227
Diekirch, 50, Esplanade,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DIEKIRCH, le 10 août 2012.
<i>Pour la Société
i>COFICOM Trust S.à r.l.
B.P. 126
50, Esplanade
L-9227 DIEKIRCH
Signature
Référence de publication: 2012104093/18.
(120142284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Smiths Detection International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 106.277.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique le 6 août 2012i>
En date du 6 août 2012, l'Associé Unique de Smiths Detection International Luxembourg Sàrl («la Société») a pris les
résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Monsieur Ian Vallance en qualité de gérant de la Société avec effet au 6 août 2012;
- D'accepter la démission de Madame Carolina, Andrea Kitzinger en qualité de gérant de la Société avec effet au 3 août
2012;
- De nommer Monsieur Shaun Doherty, dont l'adresse professionnelle est à Wellside Godstone Road, Lingfield, Surrey,
RH7 6BT, Royaume-Uni en tant que gérant de la Société, avec effet au 6 août 2012, pour une durée indéterminée et avec
pouvoir de signature conjointe avec tout autre gérant.
Luxembourg, le 10 août 2012.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2012104080/19.
(120142018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Planinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 159.620.
L'an deux mille douze, le vingt juillet.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
PLANIGEST S.A., une société ayant son siège social à L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140544,
Ici représentée par ses administrateurs Monsieur Olimpio DAS NEVES CARDOSO et Monsieur Olivio MARQUES
CARDOSO pouvant valablement engager la société par leurs signatures conjointes.
Laquelle a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'elle est la seule associée de la société PLANINVEST S. à r. l., "la société", ayant son siège social au L-2440 Luxem-
bourg, 158, rue de Rollingergrund, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro
159.620, constituée suivant acte reçu le 10 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 1164, du 31 mai 2011, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés jusqu'ici.
Qu'il a pris les résolutions suivantes:
109055
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolution:i>
L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société, de sorte que l'article 4 aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. La société a comme objet:
- l'étude, la conception, la promotion et la réalisation de tous projets immobiliers;
- l'achat, la vente et l'échange d'immeubles bâtis et non bâtis;
- la construction, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son propre
compte que pour le compte de tiers;
- la location et la prise à bail de tous biens immobiliers avec ou sans promesse de vente;
- la gérance, l'administration et l'exploitation de tous biens immobiliers;
- l'exploitation d'une agence immobilière.
Elle pourra notamment réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières
ainsi que toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou
qui le favorisent.»
<i>Deuxième résolution:i>
L'associé unique décide de modifier l'article 11 des Statuts comme suit:
« Art. 11. «La société est administrée conjointement par un ou plusieurs gérants administratifs et par un ou plusieurs
gérants techniques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, dont
obligatoirement celle du gérant dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme à exercer les
activités décrites dans l'objet social. La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement
la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de nommer gérant administratif Monsieur Olimpio DAS NEVES CARDOSO, entrepreneur de
construction, né le 18 mai 1948 à Mata Mourisca/Pombal, Portugal, demeurant à L-1863 Luxembourg, 158, rue de Rol-
lingergrund, et Monsieur Olivio MARQUES CARDOSO, ingénieur diplômé, né le 4 juin 1975 à Luxembourg, demeurant
à L-6989 Hostert, 12, Chaussée St.Martin gérant technique.
Les mandats des gérants sont établis pour une durée indéterminée.
Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est clôturée.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la société comme
résultat du présente acte sont approximativement évalués à huit cents Euros (800.-Eur)
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. DAS NEVES CARDOSO, O. MARQUES CARDOSO, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35412. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2012.
Référence de publication: 2012104607/59.
(120142765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2012.
Spheretech International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 137.867.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104083/9.
(120142342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
109056
International Packaging Technologies S.à.r.l.
Joh. A. Benckiser s.à.r.l.
Manoval S.C.I.
Parthenon International S.A.
Patrilar Sàrl
PATR S.A.
PHT S.A.
PHT S.A.
Pixel S.A.
Pizzeria Peperoncino S.à r.l.
Planinvest S.à r.l.
Pollyane Investment S.A.
Premium House S.A.
PSH S.A.
Puraye S.à r.l.
QLux Aviation S.à r.l.
Quee S.à r.l.
Qui.Lu.Cru S.à r.l.
Rafa Enterprises SA
Real Estate Management S.A.
Red Grafton S.à r.l.
Reflex'it S.A.
Reflex'it S.A.
Riverways SA
Roland International Holding, S.à r.l. SPF
Romos Invest S.A.
Rub S.A.
Safe Ship Investment Company S.C.A., SICAR
Saint Ange S.A.
Saint Ange S.A.
Saint Ange S.A.
Saint Ange S.A.
Saint Ange S.A.
Sainte Augustine Asset Management S.A.
Sarabel B.V. / S.àr.l.
SBRE Luxco
Select Development Luxembourg S.A.
Senc Houben - Vaes
SGBT European Major Investments S.A.
Six Payment Service (Luxembourg) S.A.
SL Bielefeld Capital S.à r.l.
Smiths Detection International Luxembourg S.à r.l.
Spheretech International S.A.
Spheretech International S.A.
Thalux S.A.
Vilret Avocats S.à r.l.
WALSER Absolute Return