This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2247
10 septembre 2012
SOMMAIRE
Alain Afflelou International S.A. . . . . . . . . .
107825
ALF Participations 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
107825
Alimede Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
107825
All Import S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107826
Alltra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107826
Altea Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107826
Altea Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107825
Altercap Lux Co-Invest S.A. . . . . . . . . . . . . .
107827
Alzette Funding N°1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
107837
Amplio Filtration Group S.A. . . . . . . . . . . .
107837
Ansea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107810
Antimo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107837
Apollo Feeder TH Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107838
Armada835 SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107838
ASF IV Symphony S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
107840
Assya Asset Management Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107812
Atelier de Serrurerie Raymond Weiland,
société à responsabilité limitée . . . . . . . . .
107841
Attika S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107841
Auris Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107841
Autodream s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107842
Avaya Luxembourg Investments S.àr.l. . .
107842
Avelec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107842
Batisica S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107855
Belgravia European Properties . . . . . . . . . .
107856
Belval Plaza I Apartments S.à r.l. . . . . . . . .
107846
Belval Plaza II Apartments S.à r.l. . . . . . . .
107847
Belval Plaza II Mall S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
107854
Belval Plaza II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107854
Belval Plaza I Mall S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
107846
Belval Plaza I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107846
Belval Plaza Tower S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
107854
Benelux Distribution Systems S.A. . . . . . . .
107855
Betsah S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107843
BizzDev Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
107855
Blue Skye Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
107856
Bravida HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
107856
Burotrend SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107851
Cersanit Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
107846
CFNR LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107840
C. Hypothek Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
107813
Cinven (Luxco 1) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107851
Coprom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107843
EEE 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107842
Europ Continents Holding . . . . . . . . . . . . . .
107824
Global Finance Sàrl SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
107855
Goodway S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107843
HayFin Special Ops LuxCo 3 S.à r.l. . . . . . .
107827
Inmet Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107837
Jalor Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107826
Luxury Brand Development S.A. . . . . . . . .
107839
Moventum Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
107840
Pfizer Asset Management Luxembourg
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107810
Starpack S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107841
Vallis Construction Sector Consolidation
Fund SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107813
Veep Technology Luxembourg Sàrl . . . . . .
107847
Winchester Square Holdings S.à.r.l. . . . . .
107856
107809
L
U X E M B O U R G
Ansea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 73.658.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 09 août 2012 que les Admi-
nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du no. 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg au no. 19,
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 août 2012.
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Référence de publication: 2012102814/15.
(120141345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Pfizer Asset Management Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.524.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of July.
Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.
THERE APPEARED:
PFIZER EUROPE HOLDINGS SARL having its registered office at 51 Av JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B number 135006,
represented by Mrs Maria DACAL, private employee, residing professionally at 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald |
Luxembourg by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 25, 2012.
Which proxy shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named person and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed entity PFIZER EUROPE HOLDINGS SARL, is the sole part holder in PFIZER ASSET MANAGEMENT
LUXEMBOURG SARL, incorporated on December 15, 2011 by deed of Me Paul BETTINGEN, with registered office at
51 avenue JF Kennedy, L-1885 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 165524, published in the Mémorial C number 287 of 2 February 2012 (the “Company”) and the articles have
been modified by deed of the undersigned notary on 23 December 2011, published in the Mémorial C number 388 of 14
February 2012.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner resolves to increase the share capital of the Company by an amount of SIXTY MILLION U.S. DOL-
LARS (USD 60,000,000.-) to bring it from its present amount of SIXTY MILLION U.S. DOLLARS (USD 60,000,000.-) to
the amount of ONE HUNDRED TWENTY MILLION U.S. DOLLARS (USD 120,000,000.-) by the creation and the issue
of SIXTY MILLION (60,000,000) new shares having a par value of ONE U.S. DOLLAR (USD 1.-) each (the “New Shares”),
having the same rights and obligations as the existing shares, together with total issue premium of SIX HUNDRED FOUR
MILLION NINE HUNDRED SEVENTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 604,977,500.-).
The aggregate contribution of SIX HUNDRED SIXTY FOUR MILLION NINE HUNDRED SEVENTY SEVEN THOU-
SAND FIVE HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 664,977,500.-) in relation to the New Shares is allocated as follows: (i)
SIXTY MILLION U.S. DOLLARS (USD 60,000,000.-) to the share capital of the Company and (ii) SIX HUNDRED FOUR
MILLION NINE HUNDRED SEVENTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 604,977,500.-) to
the share premium account of the Company.
<i>Subscriptioni>
PFIZER EUROPE HOLDINGS SARL, prenamed, represented as stated hereabove has declared to subscribe for the
SIXTY MILLION (60,000,000) New Shares, and to pay them a total price of SIXTY MILLION U.S. DOLLARS (USD
60,000,000.-) together with total issue premium of six hundred four million nine hundred seventy seven thousand five
hundred U.S. DOLLARS (USD 604,977,500.-) by a contribution in kind consisting in the contribution of a claim.
The above contribution in kind has been dealt with in a statement issued by the management of the Company, based
on accounts of the Company as at July 25, 2012 which certifies the existence and the total value of the claim contributed.
107810
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The sole partner resolves to amend the first paragraph of article 7 of the by-laws of the Company in order to reflect
such increase of capital, which now reads as follows:
Art. 7. First paragraph. “The corporate capital of the company is set at ONE HUNDRED TWENTY MILLION US
DOLLARS (USD 120,000,000.-) divided into ONE HUNDRED TWENTY MILLION (120,000,000.-) shares having a par
value of ONE US DOLLAR (USD 1.00) each.”
<i>Valuation - Costsi>
For the sake of the present deed, the share capital is estimated at EUR 549,555,000 (exchange rate (median price) on
24 July 2012: USD 1.-= EUR 0.82643).
The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged
to it by reason of the present deed are estimated at EUR [x].
Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby
grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign
any deed rectifying the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le 25 juillet.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
A COMPARU
PFIZER EUROPE HOLDINGS SARL constituée suivant acte reçu par acte du notaire instrumentant en date du 15
décembre 2011, ayant son siège social au 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 135 006,
représentée par Madame Maria DACAL, employée privée, ayant sa résidence professionnelle au 2 rue Peternelchen,
L-2370 Howald | Luxembourg , en vertu d'une procuration donnée en Luxembourg le 25 juillet 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la personne représentant la partie comparante susnom-
mée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
La société prénommée, PFIZER EUROPE HOLDINGS SARL, est l'associé unique de Pfizer Asset Management Lu-
xembourg SARL, constituée suivant acte reçu par acte du notaire instrumentant en date du 15 décembre 2011, ayant son
siège social au 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès registre
de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 165 524, encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 287 du 2 février 2012 (la «Société») et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire instrumentant le 23 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 388 du 14 février 2012.
Laquelle personne comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société par un montant de SOIXANTE MILLIONS de
DOLLARS AMERICAINS (USD 60.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de SOIXANTE MILLIONS de DOL-
LARS AMERICAINS (USD 60.000.000,-) à un montant de CENT VINGT MILLIONS de DOLLARS AMERICAINS (USD
120.000.000,-) par l'émission de SOIXANTE MILLIONS (60.000.000) de nouvelles parts sociales ayant une valeur D'UN
U.S. DOLLAR (USD 1,00) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission de SIX CENT QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE
DIX-NEUF MILLE CINQ CENT DOLLARS AMERICAINS (USD 604.977.500,-).
L'apport total de SIX CENT SOIXANTE QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE DIX-NEUF MILLE CINQ
CENT DOLLARS AMERICAINS (USD 664.977.500,-) relativement aux Nouvelles Parts Sociales est alloué comme suit:
(i) SOIXANTE MILLIONS de DOLLARS AMERICAINS (USD 70.000.000,-) au capital social de la Société et (ii) SIX CENT
QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE DIX-NEUF MILLE CINQ CENT DOLLARS AMERICAINS (USD
604.977.500,-) au compte de prime d'émission de la Société.
107811
L
U X E M B O U R G
<i>Souscriptioni>
PFIZER EUROPE HOLDINGS SARL, a déclaré souscrire toutes les SOIXANTE MILLIONS (60.000.000) de nouvelles
parts sociales et les libérer pour un prix total de SOIXANTE MILLIONS de DOLLARS AMERICAINS (USD 60.000.000,-)
ensemble avec une prime d'émission de SIX CENT QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE DIX-NEUF MILLE
CINQ CENT DOLLARS AMERICAINS (USD 604.977.500,-), par un apport par l'apport en nature d'une créance.
L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'une confirmation de l'existence et de la valeur émise par les gérants de la
Société, sur base d'un bilan de la Société daté du 25 juillet 2012, qui certifient la valeur totale de l'apport en nature.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide alors de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société pour refléter
l'augmentation de capital, lequel article sera comme suit:
Art. 7. Premier paragraphe. «Le capital social de la société est fixé à CENT VINGT MILLIONS de DOLLARS AMERI-
CAINS (EUR 120.000.000,-) divisé en CENT VINGT MILLIONS (120.000.000) parts sociales ayant une valeur nominale
de 1 DOLLAR AMERICAIN (USD 1.00) chacune.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins du présent acte, le capital social est évalué à EUR 549.555.000 (taux de change (median price) du 24
juillet 2012: USD 1,-= EUR 0,82643).
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, sont évalués à EUR 6.800 (six mille huit cents euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à
tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête e la personne compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état
et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Maria Dacal, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 31 juillet 2012. LAC / 2012 / 36432. Reçu 75.-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
- Pour copie conforme Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 7 août 2012.
Référence de publication: 2012102507/126.
(120140380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Assya Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 102.499.
Nous vous remercions de bien vouloir noter que la démission de Monsieur Philippe VAN MALDER, domicilié au 22-24,
Boulevard Royal, L–2449 Luxembourg, n’est pas encore effective, contrairement à ce qui a été déposé le 7 août 2012.
Sa démission effective fera l’objet d’une autre réquisition.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ASSYA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
i>Mélanie Sauvage
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012102824/14.
(120140894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
107812
L
U X E M B O U R G
C. Hypothek Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.213.
En date du 19 juillet 2012, un des associés de la Société, TCS II Opportunities Lu S.à r.l., a transféré une partie des
parts sociales de Classe B qu'ils détenait à un autre associé de la Société, TCS II Lu S.à r.l., c'est-à-dire qu'il a transféré
au total 136,160 parts sociales de Classe B à TCS II Lu S.à r.l. Les parts sociales sont réparties à présent de manière
suivante:
TCS II Lu S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,760 parts sociales de Classe A
972,900 parts sociales de Classe B
TCS II Opportunities Lu S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,240 parts sociales de Classe A
62,100 parts sociales de Classe B
Crown Westfalen Investments S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 parts sociales de Classe A
115,000 parts sociales de Classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2012.
<i>Pour la Société
i>Pedro Fernandes das Neves
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012102885/23.
(120141265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Vallis Construction Sector Consolidation Fund SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la
forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 170.647.
In the year two thousand and twelve, on the fourth day of July.
Before the undersigned, Maître Kesseler Francis, a notary resident in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Vallis Construction Sector Consolidation, a private limited liability company (société à responsabilités limitée) in-
corporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in
the process of registration with the Luxembourg trade and companies register,
here represented by Ms Laure Mersch, attorney, whose professional address is at 18-20 rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 4 July 2012, and
2. Vallis Consolidation Strategies I, S.A., a public limited liability company incorporated and existing under the laws of
Portugal, having its registered office at 236, Av Montevideu, 4150 - 516 Porto, Portugal, registered with the Portuguese
Companies Registry under number 510099815,
here represented by Ms Laure Mersch, attorney, whose professional address is at 18-20 rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Porto, Portugal, on 3 July 2012.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing parties and the undersigned notary, the
powers of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing parties, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state, as follows, the
articles of incorporation of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), which is hereby
incorporated:
I. Name - Form - Types of shareholders - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name / Form / Types of Shareholders. The name of the fund is "Vallis Construction Sector Consolidation Fund
SICAV-SIF" (the Fund). The Fund is a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) go-
verned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial
companies, as amended (the 1915 Law), the law dated 13 February 2007 on specialised investment funds, as amended
(the 2007 Law) and these articles of incorporation (the Articles).
The Fund's shareholders are (i) Vallis Construction Sector Consolidation, a private limited liability company incorpo-
rated under the laws of Luxembourg (the Managing Shareholder also referred to as the General Partner in the Private
Placement Memorandum) and (ii) the limited shareholders (associés commanditaires) upon incorporation of the Fund
107813
L
U X E M B O U R G
and any person or entity that becomes a limited shareholder (associé commanditaire) from time to time (collectively the
Limited Shareholders).
The Managing Shareholder is jointly and severally liable for all liabilities of the Fund to the extent that they cannot be
paid out of the assets of the Fund.
The Limited Shareholders are liable up to the amount of the capital committed by them to the Fund on subscribing
for the shares.
The Limited Shareholders and the Managing Shareholder are, in the Articles, collectively referred to as the Shareholders
and individually as a Shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The Fund's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the Managing Shareholder. It may be transferred to any other location in the
Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of Shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Managing Shareholder. If the Managing Shareholder determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the
normal activities of the Fund at its registered office, or with ease of communication between that office and persons
abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have
completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Fund, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Fund is to invest the funds available to it in any kind of assets eligible under the 2007 Law with
the aim of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its assets.
3.2 The Fund may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the accomplishment
and development of its purpose to the fullest extent permitted under the 2007 Law.
Art. 4. Duration.
4.1 The Fund is established for an unlimited duration.
4.2 The Fund shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several of the Shareholders.
4.3 The Fund shall not come to an end in the event of the resignation, removal, dissolution or bankruptcy or insolvency
of the Managing Shareholder. The general meeting of Shareholders may appoint an interim manager, who need not be a
Shareholder, subject to the prior approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the CSSF).
4.4 The interim manager shall adopt urgent measures and those of ordinary administration until the holding of a general
meeting of Shareholders, which has to resolve on the continuation or discontinuation of the Fund and in case of a decision
to continue the Fund's activities, the appointment of a replacement Managing Shareholder. The interim manager shall,
within fifteen days of his appointment, convene a general meeting of Shareholders in accordance with the procedures laid
down in Article 22 below.
4.5 The interim manager shall be liable only for the performance of his mandate.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital of the Fund shall be represented by shares of no nominal value and shall at any time be equal to
the total net assets of the Fund and its Compartments (as defined below), if any. The initial share capital of the Fund upon
incorporation amounts to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), represented by one (1) management share (the Ma-
nagement Share) and thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999) ordinary shares (the Ordinary Shares), all in
registered form, without nominal value.
The Management Share and the Ordinary Shares are collectively referred to as the Shares and individually as a Share.
5.2. The Management Share is exclusively reserved to the Managing Shareholder. The Ordinary Shares are offered to
well-informed investors within the meaning of article 2 of the 2007 Law (the Well-Informed Investors).
5.3. The minimum capital of the Fund shall be one million two hundred and fifty thousand euro (EUR 1,250,000), which
must be reached within twelve months after the date on which the Fund has been authorised in accordance with the
2007 Law.
Art. 6. Compartments.
6.1 The Fund is composed of one or more compartments (the Compartments), in accordance with article 71 of the
2007 Law, each of them constituting a distinct pool of assets, managed in the exclusive benefit of the Limited Shareholders
of the relevant Compartment. The name of each Compartment shall comprise the first part of the name of the Fund,
followed by the denomination determined at the discretion of the Managing Shareholder.
107814
L
U X E M B O U R G
6.2 The Managing Shareholder may, at any time, establish additional Compartment(s) and determine the name and
specific features thereof (including, but not limited to investment objectives, policy, strategy and/or restrictions, specific
fee structure, reference currency) as further set out in the private placement memorandum of the Fund, as amended and
updated from time to time (the Private Placement Memorandum) and which shall be fully described in the relevant Part
II of the Private Placement Memorandum (the Compartment Specifications), which forms an integral part of the Private
Placement Memorandum for purposes of the relevant Compartment.
6.3 The Fund is one single legal entity. However, by way of derogation to article 2093 of the Luxembourg Civil Code
and in accordance with the provisions of article 71 of the 2007 Law, the assets of any given Compartment are only available
for the satisfaction of the debts, obligations and liabilities, which are attributable to such Compartment.
Amongst Limited Shareholders, each Compartment is treated as a separate entity.
Art. 7. Shares.
7.1 The Shares are indivisible and the Fund recognises only one (1) owner per Share.
7.2 The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
7.3 The registrar and transfer agent holds a share account for each Shareholder in which the Shareholder's Shares are
registered.
7.4 The Managing Shareholder may, at any time, issue different classes of Ordinary Shares (each a Class or Classes as
appropriate) in respect of each Compartment, which may carry different rights and obligations inter alia with regard to
eligible investors, income and profit entitlements, redemption features, reporting obligations and/or fee and cost features
as described in the relevant Compartment Specifications.
7.5 The Ordinary Shares may only be subscribed for by investors who comply with the status of Well-Informed
Investor. The compliance of each subscriber with the status of Well-informed Investor will be verified by the Managing
Shareholder or any agent to which such function has been delegated by the Managing Shareholder. This restriction is not
applicable to the Managing Shareholder.
7.6 The issue price of Ordinary Shares is determined by the Managing Shareholder on a Class by Class basis as fully
described in the relevant Compartment Specifications.
7.7 The Managing Shareholder may delegate to any duly authorised director, manager, officer or to any other duly
authorised agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the issue price of any Ordinary Shares and to
deliver the Ordinary Shares.
Art. 8. Transfer of Shares.
8.1 Ordinary Shares are generally freely transferable between Well-informed Investors but may be subject to such
transfer conditions as set forth in the relevant Compartment Specifications.
8.2 A transfer of Ordinary Shares shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer,
duly signed and dated by either:
(i) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or
(ii) any authorised representative of the Fund,
following a notification to, or acceptance by, the Fund, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
8.3 Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both
parties, may be accepted by the Fund as evidence of a share transfer.
8.4 The Management Share is exclusively and mandatorily transferable upon replacement of the Managing Shareholder.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 Unless otherwise provided for in the relevant Compartment Specifications, a redemption of Ordinary Shares is
only possible at the discretion of the Managing Shareholder in accordance with the relevant Compartment Specifications
and the Shareholders are not entitled to request any redemption of their Ordinary Shares.
9.2 The Managing Shareholder may, upon serving a repurchase notice, decide to repurchase the Ordinary Shares of
any Shareholder and such Shareholder shall be obliged to sell its Ordinary Shares to the Fund at a price determined in
accordance with the relevant Compartment Specifications. The Managing Shareholder shall furthermore cause the transfer
or the repurchase of the Ordinary Shares of any Shareholder, if the Shareholder ceases to qualify as a Well-Informed
Investor.
9.3 No distribution for redemption of Shares may be made as a result of which the capital of the Fund would fall below
the minimum capital amount required by Luxembourg law.
9.4 A redemption of Ordinary Shares shall be subject to such further terms and conditions, including but not limited
to any redemption charges, as set forth in the relevant Compartment Specifications.
9.5 Any Share repurchased by a Compartment cannot be reissued and shall be cancelled.
Art. 10. Conversion of Shares.
10.1 The conversion of Ordinary Shares in a particular Compartment into Ordinary Shares of another Compartment
or the conversion (or switching) of Ordinary Shares of one Class into another Class within the same Compartment or
107815
L
U X E M B O U R G
of another Compartment may be authorised on a Compartment by Compartment basis as well as on a Class by Class
basis as set forth in the relevant Compartment Specifications.
10.2 The Management Share is not convertible.
III. Net asset value
Art. 11. Calculation of the NAV.
11.1 The reference currency of the Fund is the Euro. Each Compartment may have a different reference currency.
The net asset value of each Compartment's Shares is expressed in the reference currency of the respective Compartment
and within each Compartment the NAV of each Class, if applicable, is expressed in the reference currency of the respective
Class, as further described in the relevant Compartment Specifications. The NAV is calculated by the administrative agent
of the Fund under the responsibility of the Managing Shareholder.
The NAV per Share (being the assets less the liabilities) is calculated on a Class by Class basis (if applicable) on such
frequency as set forth in the relevant Compartment Specifications.
For the purpose of determining the NAV of the Fund, the net assets attributable to each Class within each Compart-
ment shall, if not denominated in Euro, be converted into Euro and the NAV of the Fund shall be the aggregate of the
net assets of all the Compartments.
The Fund reserves the right to suspend the determination of the NAV of a Compartment under circumstances set
forth under Article 12 below.
As regards relations between Shareholders, each Compartment is treated as a separate entity, generating without
restriction its own contributions, capital gains and capital losses, fees and expenses. The Fund constitutes a single legal
entity. However with regard to third parties, in particular towards the Fund's creditors, each Compartment shall be
exclusively responsible for all liabilities attributable to it.
The Managing Shareholder will adopt a policy of valuing the investments at fair value in accordance to the terms set
in the Private Placement Memorandum. The Managing Shareholder, in its discretion and in good faith, may permit some
other method of valuation to be used, if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the
Fund.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with Luxembourg generally
accepted accounting principles (Luxembourg GAAP).
If since the time of determination of the net asset value there has been a material change in the quotations in the
markets on which a substantial portion of the investments of the Fund are dealt in or quoted, the Fund may, in order to
safeguard the interests of the Shareholders and the Fund, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
In the absence of bad faith, negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the
Managing Shareholder or by the administrative agent of the Fund, shall be final and binding on the Fund and present, past
or future Shareholders.
11.2 The assets of the Fund shall include:
1 all cash in hand, receivable or on deposit, including any interest accrued thereon;
2 all bills and notes payable on demand and any account due (including the proceeds of securities sold but not delivered);
3 all securities, shares, bonds, time notes, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants and other se-
curities, money market instruments and similar assets owned or contracted for by the Fund;
4 all interest accrued on any interest-bearing assets, except to the extent that the same is included or reflected in the
principal amount of such assets;
5 all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Fund to the extent information thereon
is reasonably available to the Fund;
6 all goodwill related with any acquisition of securities, shares, bonds, time notes, debentures, debenture stocks,
subscription rights, warrants and other securities, and similar assets owned or contracted for by the Fund, or any goodwill
resulting from any conversion of debt instruments into equity instruments or similar assets owned or contracted by the
Fund;
7 the preliminary expenses of the Fund, including the cost of issuing and distributing Shares of the Fund, insofar as the
same have not been written off and insofar the Fund shall be reimbursed for the same;
8 the marketing and distribution costs, which are to be amortised equally over 5 years;
9 the liquidating value of all forward contracts and all call or put options the Fund has an open position in; and
10 all other assets of any kind and nature, including expenses paid in advance.
11.3 The value of such assets shall be determined at fair value with due regard to the following principles:
1 the value of any cash on hand or deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after
making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true thereof;
107816
L
U X E M B O U R G
2 securities listed and traded primarily on one or more recognised securities exchanges shall be valued at their last
known prices on the valuation date;
3 investment in underlying undertakings for collective investment are taken at their last official net asset value known
in Luxembourg at the time of calculating the net asset value of the relevant Compartment. If such price is not represen-
tative of the fair value of such assets, then the price shall be determined by the Managing Shareholder on a fair value basis.
Investments subject to bid and offer prices are valued at their mid-price, if not otherwise determined by the Managing
Shareholder;
4 unlisted securities for which over-the-counter market quotations are readily available (included listed securities for
which the primary market is believed to be the over-the-counter-market) shall be valued, in case there are materially
significant transactions with the respective security, at a price equal to the last reported price as supplied by recognised
quotation services or broker-dealers; and
5 all other non-publicly traded securities, other securities or instruments or investments for which reliable market
quotations are not available, and securities, instruments or investments which the Fund determines in its discretion that
the foregoing valuation methods do not fairly represent the fair value of such securities, instruments or investments, will
be valued by the Fund either at their cost basis to the Compartment or in good faith using methods it considers appro-
priate, namely (but not limited to) the method of discounted cash flows and any other method recommended by the
International Private Equity and Venture Capital Valuation (IPEV) Guidelines Board. The Managing Shareholder, in its
discretion and in good faith, may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such valuation
better reflects the fair value of any asset of the Fund.
Assets expressed in a currency other than the reference currency of the Compartment concerned respectively in [US
Dollar] shall be converted on the basis of the rate of exchange ruling on the relevant Valuation Day. If such rate of
exchange is not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by
the Managing Shareholder.
11.4 The liabilities of the Fund shall include:
1 all loans, bills and accounts payable;
2 all accrued interest on loans (including accrued fees for commitment for such loans);
3 all accrued or payable expenses (including administrative expenses, advisory and management fees, including incentive
fees, custodian fees, and corporate agents' fees);
4 all known liabilities, present or future, including all matured contractual obligations for payment of money, including
the amount of any unpaid distributions declared by the Fund;
5 an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the calculation day, as determined from
time to time by the Fund, and other reserves (if any) authorised and approved by the Managing Shareholder, as well as
such amount (if any) as the Managing Shareholder may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent
liabilities of the Fund; and
6 all other liabilities of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted accounting prin-
ciples.
In determining the amount of such liabilities the Managing Shareholder shall, with due regard to the expenses borne
by the Managing Shareholder out of its management fee, take into account all expenses payable by the Fund which shall
include formation expenses, fees, expenses, disbursements and out-of-pocket expenses payable to its accountants, cus-
todian and its correspondents, management company as well as any other agent employed by the Fund, the remuneration
of the directors and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage and reasonable travelling costs in
connection with Managing Shareholder meetings and investment committee meetings, fees and expenses for legal and
auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Fund with any
governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, licensing fees
for the use of the various indexes, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing, translating, printing,
advertising and distributing the Private Placement Memorandum, further explanatory sales documents, periodical reports
or registration statements, the costs of publishing the Net Asset Value and any information relating to the estimated value
of the Fund, the cost of printing certificates, if any, and the costs of any reports to Shareholders, the cost of convening
and holding Shareholders', Managing Shareholder and committee meetings, all taxes, duties, governmental and similar
charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, transaction fees, the cost of
publishing the issue and redemption prices, interests, bank charges and brokerage, postage, insurance, telephone and
telex. The Fund may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated
amount rateably for yearly or other periods.
11.5 The assets and liabilities of different Compartments or different Classes shall be allocated as follows:
1 the proceeds to be received from the issue of Shares of a Compartment shall be applied in the books of the Fund
to the relevant Compartment;
2 where an asset is derived from another asset, such derived asset shall be applied in the books of the Fund to the
same Compartment as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant Compartment;
107817
L
U X E M B O U R G
3 where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular Compartment or to any action taken in
connection with an asset of a particular Compartment, such liability shall be allocated to the relevant Compartment;
4 upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on Shares of any Compart-
ment, the assets of such Compartment shall be reduced by the amount of such dividends; and
5 in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular Com-
partment, such asset or liability shall be allocated to all the Compartments pro rata to the net asset value of the relevant
Compartment.
11.6 For the purposes of the net asset value computation:
1 Shares of the Fund to be redeemed hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after
the time specified by the Managing Shareholder on the relevant valuation time and from such time and until paid by the
Fund the price therefore shall be deemed to be a liability of the Fund;
2 Shares to be issued by the Fund shall be treated as being in issue as from the time specified by the Managing Share-
holder on the valuation time, and from such time and until received by the Fund the price therefore shall be deemed to
be a debt due to the Fund;
3 all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the currency in which the net
asset value for the relevant Compartment is calculated shall be valued after taking into account the rate of exchange
prevailing on the principal regulated market of each such asset on the dealing day preceding the valuation time; and
4 where on any valuation time the Fund has contracted to:
(i) purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Fund
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Fund;
(ii) sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Fund
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Fund;
provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such valuation
time, then its value shall be estimated by the Managing Shareholder.
Art. 12. Suspension of the calculation of the net asset value. The Fund is authorised to temporarily suspend the
calculation of the NAV and the issue, conversion and redemption of any Class of Shares in any Compartment in the
following cases:
(a) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of
the investments of the Fund attributable to such Compartment from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise
than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction
or suspension affects the valuation on the investments of the Fund attributable to a Compartment quoted thereon; or
(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Managing Share-
holder as a result of which disposals or valuation of assets owned by the Fund attributable to such Compartment would
be impracticable; or
(c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments of such Compartment or the current price or values on any stock exchange or other market in respect
of the assets attributable to such Compartment; or
(d) when for any other reason the prices of any investments owned by the Fund attributable to any Compartment
cannot promptly or accurately be ascertained; or
(e) during any period when the Managing Shareholder is unable to repatriate funds for the purpose of making payments
on the redemption of the Shares of such Compartment or during which any transfer of funds involved in the realisation
or acquisition, of investments or payments due on redemption of Shares cannot in the opinion of the Managing Shareholder
be effected at normal rates of exchange; or
(f) if the Fund is being or may be wound up or merged, from the date on which notice is given of a general meeting of
shareholders at which a resolution to wind up or merge the Fund is to be proposed or if a Compartment is being liquidated
or merged, from the date on which the relevant notice is given.
Where possible, all reasonable steps will be taken to bring any period of suspension to an end as soon as possible.
VI. Management - Representation
Art. 13. Management.
13.1 The Fund shall be managed by the Managing Shareholder for the duration of the Fund, unless the provisions of
article 4.3. apply or the Managing Shareholder is dismissed or resigns for legitimate cause.
13.2 All powers not expressly reserved to the General Meeting by the 1915 Law, the 2007 Law or the Articles fall
within the competence of the Managing Shareholder, who has all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Fund's corporate object.
13.3 The Managing Shareholder is responsible for all investment management of the assets of the Fund and each of its
Compartments, for the day-to-day management of the affairs of the Fund as well as for the administration and marketing
functions related to the Fund and its Compartments. The Managing Shareholder retains legal decision-making power and
107818
L
U X E M B O U R G
has the exclusive authority with regard to any decisions not specifically delegated or attributed to another entity or service
provider and supervises the administrative agent, the registrar and transfer agent, the investment advisor and any other
service providers of the Fund in the performance of their duties.
Art. 14. Removal of the Managing Shareholder for cause.
14.1 Upon occurrence of a Cause Event (as defined below), Limited Shareholders representing at least ten per cent
(10%) of the voting rights of the Fund [or the Investor's Committee (as defined in the Private Placement Memorandum)]
shall be entitled to call, or require the Managing Shareholder to call, a Shareholders' general meeting to initiate a vote on
the removal for cause of the Managing Shareholder.
For the purpose of this section, each of the following event shall be a cause event (a Cause Event):
(a) any of the Related Persons (as defined in the Private Placement Memorandum) has committed a material breach
of the Private Placement Memorandum or the Articles, or any side letter or similar agreement or any other contractual
arrangement in relation to the activities of the Fund;
(b) any of the Related Persons has committed gross negligence, wilful misconduct, fraud, bad faith or reckless disregard
of their duties in the course of the operation of the Fund;
(c) the Managing Shareholder has been declared insolvent, bankrupt, or is the subject of an administration procedure
or involuntary reorganization of its assets;
(d) there has been an unauthorised change of control (as defined in the Private Placement Memorandum in relation
to the Managing Shareholder.
Upon occurrence of a Cause Event, the Limited Shareholders willing to initiate a vote on the removal of the Managing
Shareholder shall send a written notice (the Removal for Cause Notice) to the Managing Shareholder indicating (i) the
Limited Shareholders' intention to seek the removal of the Managing Shareholder for cause and (ii) a detailed description
of the relevant Cause Event.
Upon receipt of the Removal for Cause Notice, the Managing Shareholder shall convene a meeting of the Investor's
Committee, following the procedure as further detailed in the Private Placement Memorandum. After the holding of the
meeting of the Investor's Committee, and at the latest fifteen Business Days after receipt of the Removal for Cause Notice,
the Managing Shareholder shall convene a Shareholders' general meeting to resolve upon the removal of the Managing
Shareholder. The Managing Shareholder shall procure that such meeting is held within a maximum period of one (1)
month from the date of the receipt by the Managing Shareholder of the Removal for Cause Notice.
The Limited Shareholders shall procure that the Managing Shareholder is replaced by a resolution of the Shareholders'
general meeting in the conditions required for amendment to these Articles and with the consent of the CSSF within 180
calendar days of the resolution that a Cause Event has occurred failing which the Managing Shareholder will resign and
provoke the winding up of the Fund.
In case the Managing Shareholder defaults on its obligations under this article, any of the Shareholders is entitled to
convene a General Meeting of Shareholders to nominate a representative or agent to temporarily replace the role the
role of the Managing Shareholder until final decision is taken.
Art. 15. Removal of the Managing Shareholder without cause.
15.1 Limited Shareholders representing at least 10% of the voting rights of the Fund [or the Investor's Committee]
shall be entitled to call, or require the Managing Shareholder to call, a Shareholders' general meeting to initiate a vote for
removal without cause of the Managing Shareholder and or the Investment Advisor.
15.2 The Limited Shareholders or Investor's Committee willing to initiate a vote on the removal without cause of the
Managing Shareholder shall send a written notice (the Removal Without Cause Notice) to the Managing Shareholder
indicating the Limited Shareholders' intention to seek the removal of the Managing Shareholder without cause.
15.3 Upon receipt of the Removal Without Cause Notice, the Managing Shareholder shall convene a meeting of the
Investor's Committee, following the procedure as further detailed in the Private Placement Memorandum. After the
holding of the meeting of the Investor's Committee, and at the latest fifteen Business Days after receipt of the Removal
Without Cause Notice, the Managing Shareholder shall convene a Shareholders' general meeting to resolve upon the
removal of the Managing Shareholder. The Managing Shareholder shall procure that such meeting is held within a maximum
period of one (1) month from the date of the receipt by the Managing Shareholder of the Removal Without Cause Notice.
15.4 Limited Shareholders representing at least 75% of the voting rights of the Fund (excluding the capital subscribed
by the Related Persons) may resolve to remove the Managing Shareholder and or the Investment Advisor without cause.
The Managing Shareholder shall not have any veto right on this decision.
15.5 The Limited Shareholders shall procure that the Managing Shareholder is replaced by a resolution of the Share-
holders' general meeting in the conditions required for amendment to these Articles and with CSSF's consent within 180
calendar days of the resolution that a Cause Event has occurred failing which the Managing Shareholder will resign and
provoke the winding up of the Fund.
In case the Managing Shareholder defaults on its obligations under this article, any of the Shareholders is entitled to
convene a General Meeting of Shareholders to nominate a representative or agent to temporarily replace the role of the
Managing Shareholder until final decision is taken.
107819
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Representation.
16.1 The Fund shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the Managing Shareholder.
16.2 The Fund shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom
special signatory powers have been delegated.
Art. 17. Delegation of powers.
17.1 The Managing Shareholder may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers
as well as any other officers that the Fund deems necessary for the operation and management of the Fund or any
Compartment. Such appointments may be cancelled at any time by the Managing Shareholder. The officers need not be
Limited Shareholders of the Fund. Unless otherwise provided for by these Articles, the officers shall have the rights and
duties conferred upon them by the Managing Shareholder. The Managing Shareholder may furthermore appoint other
agents, who need not to be members of the Managing Shareholder and who will have the powers determined by the
Managing Shareholder.
17.2 The Managing Shareholder may, under its full responsibility, be assisted, while managing the Fund's assets by one
or several investment managers and/or investment advisors or, delegate its powers in relation to the management of the
Fund or a specific Compartment to one or several agents.
17.3 The Managing Shareholder may establish on a Compartment per Compartment basis an advisory committee and/
or an investors' committee, which shall have those powers as provided for in the relevant Compartment Specifications.
Art. 18. Investment policies and Restrictions.
18.1 The Managing Shareholder, based upon the principle of risk diversification and in accordance with the Private
Placement Memorandum, has the power to determine the investment policies and strategies of each Compartment of
the Fund and the course of conduct of the management and business affairs of the Fund, within the restrictions as shall
be set forth by the Managing Shareholder in compliance with applicable laws and regulations.
18.2 The Fund may employ, for each Compartment as set forth in the relevant Compartment Specifications, techniques
and instruments relating to transferable securities, currencies or any other financial assets or instruments for the purpose
of hedging.
Art. 19. Conflicts of interest.
19.1 No contract or other transaction between the Fund and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the fact that any one or more of the directors or officers of the Fund is interested in, or is a director, associate, officer
or employee of such other company or firm, except if such transaction is not in the best interest of the Fund. Any director
or officer of the Fund who serves as a director, officer or employee of any company or firm, with which the Fund shall
contract or otherwise engage in business or who is interested in such company or firm shall, by reason of such interest
or affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with
respect to such contract or other business.
19.2 In the event that any director or officer of the Fund may have in any transaction of the Fund an interest different
to the interests of the Fund, such director or officer shall make known to the Managing Shareholder such conflict of
interest and shall not consider or vote on any such transaction and such transaction, and such director's or officer's
interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.
19.3 The term conflict of interests, as used in the preceding paragraph, shall not include any relationship with or interest
in any matter, position or transaction involving the initiator, the investment advisor, the custodian, the administrative
agent, the distributors as well as any other person, company or entity as may from time to time be determined by the
Managing Shareholder on its discretion.
Art. 20. Indemnification. The Fund shall indemnify any member of the board of managers the Managing Shareholder,
the Managing Shareholder, the investment advisor, the custodian, the administrative agent, the registrar and transfer agent
and their affiliates as well as any officer and their heirs, executors and administrators (each an Indemnified Person) against
expenses reasonably incurred by them in connection with any action, suit proceeding to which they may be made a party
by reason of them being or having been a member of the board of the Managing Shareholder, the Managing Shareholder,
the investment advisor, the custodian, the administrative agent, the registrar and transfer agent and their affiliates or
officer or, at its request, being or having been a member of any other entity of which the Fund or a Compartment is an
investor or creditor and from which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters in respect of
which they may be finally declared to be liable for wilful misconduct, bad faith or gross negligence; in the event of a
settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which
the Fund is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a wilful misconduct, bad faith or
gross negligence. The indemnification shall be provided only where such person has acted pursuant to the receipt of
proper instructions and within the terms and conditions of any contractual agreement in full force and in effect between
the indemnified person and the Fund. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the
Indemnified Person may be entitled.
An Indemnified Person seeking indemnification pursuant to this clause shall, upon reasonable request, be advanced by
the Fund, expenses (including legal fees and costs) reasonably incurred by such Indemnified Person in defence of any
107820
L
U X E M B O U R G
proceeding against such Indemnified Person prior to the final disposition thereof; provided that such Indemnified Person
has agreed in writing to repay such amount to the Fund within three (3) months of the date it is ultimately determined
that such Indemnified Person is not entitled to be indemnified as authorised in this section and repay any excess between
such advanced amount and the Indemnified Amount.
As such the Fund and or the Compartments will enter into a D&O Insurance to cover the Indemnified Persons and
limit the liabilities of the Company.
V. General meetings of shareholders
Art. 21. Powers and Voting rights.
21.1 Resolutions of the Shareholders shall be adopted at a general meeting of Shareholders (each a General Meeting).
In accordance with article 111 of the 1915 Law, no decision of a general meeting will be validly taken without the prior
approval of the Managing Shareholder except for the decision of Removal of the Managing Shareholder.
21.2 Each Share entitles the holder to one (1) vote.
Art. 22. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.
22.1 The Limited Shareholders may be convened to General Meetings by the Managing Shareholder. The Limited
Shareholders must be convened to a General Meeting following a request from Limited Shareholders representing more
than one-tenth of the share capital.
22.2 Written notice of any General Meeting shall be given to all Limited Shareholders at least eight (8) days prior to
the date of the meeting.
22.3 General Meetings shall be held at such place and time as specified in the notices.
22.4 If all the Shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
22.5 A Shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order
to be represented at any General Meeting.
22.6 Any Shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to a participation in person at the meeting.
22.7 Any Shareholder may vote by using the forms provided by the Fund for that purpose. Voting forms must contain
the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must
contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the
voting forms to the Fund's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be taken into
account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor an abstention
shall be considered void.
22.8 Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the
proportion of the share capital present or represented.
22.9 An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is repre-
sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment
to the Fund's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of
notices published twice in the Memorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and
fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results
of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of the
capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast, which
shall include the consent of the Managing Shareholder unless otherwise specified by these Articles. If the Managing Sha-
reholder is dismissed for legitimate cause (cause legitime) or without cause (sans cause), any amendment to article 1 of
the Articles shall not require the consent of the Managing Shareholder.
22.10 In accordance with article 67-1 of the 1915 Law, any change in the nationality of the Fund and any amendment
of the Articles, which increases the commitments of the Shareholders in the Fund shall require the unanimous consent
of the Shareholders and bondholders (if any).
Art. 23. General Meetings of Compartment(s).
23.1 The Managing Shareholder may at any time convene a general meeting of Shareholders of one or several specific
Compartment(s) in order to decide on any matter, which relate exclusively to such Compartment(s).
23.2 Legal provisions as well as provisions of these Articles relating to the general meetings of Shareholders of the
Fund shall apply to the extent possible mutatis mutandis to the general meetings of Shareholders of one or several specific
Compartment(s).
107821
L
U X E M B O U R G
VI. - Annual accounts - Allocation of profits
Art. 24. Financial year and Approval of annual accounts.
24.1 The financial year begins on the first (1) of October and ends on the thirty (30) of September of the following
year.
24.2 Each year, the Managing Shareholder must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with
an inventory stating the value of the Fund's assets and liabilities, with an annex summarising the Fund's commitments and
the debts owed by the officer(s), the Managing Shareholder and the Auditor to the Fund.
24.3 One month before the annual General Meeting, the Managing Shareholder shall provide the Auditor with a report
on, and documentary evidence of, the Fund's operations. The Auditor shall then prepare a report setting out its proposals.
24.4 The annual General Meeting shall be held at the registered office or any other place within the municipality of the
registered office, as specified in the notice, on the 3
rd
Tuesday of the month of March at 2:00 p.m. If such day is not a
business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.
24.5 The annual General Meeting may be held abroad if, in the Managing Shareholder's absolute discretion, exceptional
circumstances so require.
Art. 25. Reference currency.
25.1 The Fund shall prepare annual accounts in Euro. For the purpose of determining the capital of the Fund, the net
assets attributable to each Compartment shall, if not denominated in Euro, be converted into Euro at the rates used in
the most recent NAV calculation and the capital shall be the aggregate of the net assets of all the Compartments.
Art. 26. Auditor.
26.1 The accounting data related in the annual report of the Fund shall be examined by an auditor (réviseur d'entreprises
agréé) appointed by the Managing Shareholder and remunerated by the Fund (the Auditor).
26.2 The Auditor shall fulfil the duties prescribed by the 2007 Law.
Art. 27. Allocation of profits.
27.1 The annual General Meeting shall approve the profit allocation proposed by the Managing Shareholder in accor-
dance with the allocations rules set out in the Private Placement Memorandum and in particular as set forth in each
Compartment Specifications.
27.2 The Managing Shareholder may in its discretion decide to pay interim dividends at any point in time unless
otherwise provided for in the Private Placement Memorandum and, in particular, as set forth in the relevant Compartment
Specifications.
27.3 Distributions shall be paid in Euro or in the base currency of a Compartment and at such time and place that the
Managing Shareholder shall determine from time to time.
27.4 No distribution may be made which would result in the NAV of the Fund to fall below the minimum capital
required by the 2007 Law, as set out in Art. 5.3 above.
VII. Dissolution - Liquidation
Art. 28. Term, Liquidation and Amalgamation of Compartments.
28.1 The Compartments may be created for any undetermined period or for a fixed period as provided for in the
Private Placement Memorandum and, specifically, in the relevant Compartment Specifications. Any Compartment created
for a fixed period will terminate automatically on its maturity date provided for in the relative Compartment Specifications.
28.2 The Managing Shareholder may also decide to liquidate one Compartment if the net assets of such Compartment
have decreased to, or have not reached, an amount determined by the Managing Shareholder to be the minimum level
for such Compartment to be operated in an economically efficient manner or if a change in the economic or political
situation relating to the Compartment concerned would justify such liquidation. Limited Shareholders of the relevant
Compartment will be notified by the Managing Shareholder of any decision to liquidate the relevant Compartment prior
to the effective date of the liquidation and the notice will indicate the reasons for, and the procedures applicable to, the
liquidation.
28.3 In the same circumstances as provided above, the Managing Shareholder may decide to terminate one Compart-
ment and contribute its assets into another existing or new Compartment or into another collective investment vehicle.
The Managing Shareholder may organise the amalgamation of two or more Compartments if it believes that such a course
of action is in the best interests of the Limited Shareholders of the relevant Compartments. Affected Limited Shareholders
will be notified of any such decision and relevant information in relation to the new Compartment. Notice will be provided
at least one month before the date on which the amalgamation becomes effective in order to enable Limited Shareholders
to request that their Shares be redeemed, without any fees or costs, before the amalgamation is completed.
28.4 Where assets are to be contributed to another collective investment vehicle, the amalgamation will be binding
only on Limited Shareholders in the relevant Compartment who expressly consent to such amalgamation. Where the
Managing Shareholder does not have the authority to do so or where the Managing Shareholder determines that the
decision should be put to the Limited Shareholders for their approval, the decision to liquidate or to merge a Compart-
107822
L
U X E M B O U R G
ment shall instead be taken at a general meeting of Shareholders of the relevant Compartment. In such an event, the
general meeting of Shareholders of the Compartment shall be held without any quorum requirements and the dissolution
may be decided by the votes of Shareholders holding 50% of the Shares represented at such general meeting. Shareholders
will be notified by the Fund of any resolution to proceed with liquidation or amalgamation at least one month before the
effective date of the liquidation or amalgamation of the Compartment in order to enable Limited Shareholders to request
redemption or conversion of their Shares, without any fees or costs, before the liquidation or amalgamation of the
Compartment takes place.
28.5 Notwithstanding the foregoing, no amalgamation will take place during any period during which the calculation
of the NAV and the issue, conversion or redemption of any Shares in any Class involved in the amalgamation has been
suspended, except if the consent of all of the Shareholders holding Shares in each of the involved Compartments has
been obtained.
28.6 As soon as the decision to liquidate or merge a Compartment is taken, the issue of Shares in such Compartment
is prohibited and shall be deemed void.
28.7 Each Compartment may be separately dissolved without impacting any other Compartment. The dissolution of
the last Compartment causes ipso jure the liquidation of the Fund.
Art. 29. Dissolution and Liquidation of the Fund.
29.1 The Fund may at any time be dissolved by a resolution of the General Meeting resolving in the conditions pre-
scribed for the amendment of these Articles. The Fund shall also be dissolved upon dissolution of the last existing
Compartment.
29.2 Whenever the share capital falls below two third of the minimum capital indicated in Art. 5.3 above, the question
of the dissolution of the Fund shall be referred to the General Meeting by the Managing Shareholder. In such an event,
the General Meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by the votes of
Shareholders holding 50% of the Ordinary Shares represented at such General Meeting.
29.3 Whenever the share capital falls below one quarter of the minimum capital indicated in Art. 5.3 above, the question
of the dissolution of the Fund shall be referred to the General Meeting by the Managing Shareholder. In such an event,
the General Meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by the votes of
Shareholders holding 25% of the Ordinary Shares represented at such General Meeting.
29.4 Where the holding of a General Meeting is required in accordance with article 29.2 or 29.3 above, such General
Meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from the assessment that the net assets of the
Fund have fallen below two third or one quarter of the legal minimum, as the case may be.
29.5 In the event of dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be
physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding on such dissolution and subject to the
approval of the CSSF. The operations of liquidation will be carried out pursuant to Luxembourg applicable laws.
Art. 30. Liquidation proceeds.
30.1 The net proceeds of liquidation corresponding to each Compartment shall be distributed, including distributions
in kind, by the liquidator(s) to the Shareholders of the relevant Compartment in accordance with the rules applicable to
the allocation of profits in such Compartment as referred to under Article 27 above.
30.2 Any liquidation proceeds that cannot be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the liqui-
dation will be deposited with the Luxembourg «Caisse de Consignations.
Art. 31. Consolidation and Splitting of Shares. The Managing Shareholder may decide to consolidate or split the Shares
of a Compartment within a given Share Class.
IX. General provision
Art. 32. Notices and communications are made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by fax,
e-mail or any other means of electronic communication.
Art. 33. Powers of attorney may be granted by any of the means described above.
Art. 34. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video
conference may appear on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together,
shall constitute one and the same document.
Art. 35. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable
law and, subject to any non waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the Shareholders from
time to time.
<i>Transitory provisioni>
The Fund's first financial year shall begin on the date of this deed and end on the thirtieth (30
th
) of September 2012.
107823
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and Paymenti>
Vallis Construction Sector Consolidation represented as stated above, subscribes for:
- one (1) Management Share in registered form, without nominal value and agrees to pay it in full by a contribution in
cash in the amount of one Euro (EUR 1), and
- twenty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (29,999) Ordinary Shares in registered form, without nominal
value, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twenty-nine thousand nine hundred and
ninety-nine Euro (EUR 29,999.-).
Vallis Consolidation Strategies I, S.A., represented as stated above, subscribes for one thousand (1000) Ordinary Shares
in registered form, without nominal value, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of one
thousand Euro (EUR 1,000.-).
The amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is at the Fund's disposal and evidence of such amount has been
given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Fund in connection with its incor-
poration are estimated at approximately three thousand two hundred euro (€ 3,200.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Fund, its Shareholders, representing the entire subscribed share capital,
adopted the following resolutions:
1. Deloitte S.A., a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 67.895, is appointed as approved external auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Fund for a period
of one year.
2. The registered office of the Fund is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Whereof, this deed has been signed in Esch/Alzette, on the date at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed with us, the
notary, the present original deed.
Signé: Mersch, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9007. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012101237/629.
(120138658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2012.
Europ Continents Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 16.913.
EXTRAIT
Lors de sa réunion en date du 27 juillet 2012, et à la suite de l'Assemblée générale ordinaire du 26 juillet 2012, le
Conseil d'administration de la société anonyme EUROP CONTINENTS HOLDING a confirmé Monsieur Jean-Marc
BEAUJOLIN, demeurant à CH-1131 Tolochenaz (VD), en qualité de Président de la Société pour toute la durée de son
mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
Se référant à l'autorisation conférée par l'Assemblée générale des actionnaires du 26 juillet 2012 de déléguer les
pouvoirs nécessaires à la gestion journalière de la Société, le Conseil d'administration a également confirmé les pouvoirs
de Monsieur Jean-Marc BEAUJOLIN en tant que Administrateur-délégué de la Société pour toute la durée de son mandat
d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
Pour extrait conforme
EUROP CONTINENTS HOLDING
Société anonyme
Référence de publication: 2012103050/19.
(120141079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
107824
L
U X E M B O U R G
Alain Afflelou International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 58.334.
Les comptes annuels au 31 juillet 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102800/9.
(120140835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
ALF Participations 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 155.650.
Ce document remplace le dépôt L120139585
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102803/11.
(120141627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Alimede Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.955,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 128.645.
I. Lors de l'assemblée générale annuelle en date du 2 juillet 2012, les associés ont pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Roberto MURONI, avec adresse professionnelle au DAM 7F, Royal Damcenter, 1012
JS Amsterdam, Pays-Bas, de son mandat de Gérant B, avec effet immédiat
- nomination de Daniela FRASCA, avec adresse professionnelle au DAM 7F, 6
th
Floor, 1012 JS Amsterdam, Pays-Bas,
au mandat de Gérant B, avec effet immédiat et pour une duree indeterminee
II. La dénomination de l'associé Tregi Fin S.p.A., avec siège social au 21, Via B. Bedosti, Pesaro, Italie a changé et est à
présent Tregi Holdings S.p.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012102804/17.
(120141412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Altea Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 65.220.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2012 que:
- Monsieur Alessandro GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI, né le 10 janvier 1966 à Milan (Italie), demeurant à
I - 20090 Buccinasco, Via Vigevanese,1, a été nommé administrateur pour terminer !e mandat de Monsieur Jacopo BINI
SMAGHI.
- Monsieur Jacopo BINI SMAGHI a démissionné de ses fonctions d'administrateur délégué.
Luxembourg, le 31 juillet 2012.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2012102808/17.
(120141596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
107825
L
U X E M B O U R G
All Import S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 6A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 81.978.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102805/10.
(120141337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Alltra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 101.403.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102806/10.
(120140704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Altea Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 65.220.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2012.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2012102807/12.
(120140959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Jalor Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 69.601.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 juin 2011i>
<i>Deuxième résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,
l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'administrateur de Monsieur Claude
SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue
Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, Monsieur Thierry FLEMING, Expert-comptable, né à Luxembourg le 24/07/1948,
domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Gerdy
ROOSE, né à Wevelgem (Belgique) le 14.02.1966, expert comptable, demeurant professionnellement 2, Avenue Charles
De Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9,
Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
la section B et le numéro 65.469, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire
annuelle qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
JALOR FINANCE S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012103227/22.
(120141227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
107826
L
U X E M B O U R G
Altercap Lux Co-Invest S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.237.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 juillet 2012.
Référence de publication: 2012102809/10.
(120140816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
HayFin Special Ops LuxCo 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 170.715.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the first day of August.
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, a Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
THERE APPEARED:
HayFin Special Ops LuxCo 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (RCS),
here represented by Maître Tina Fettes, lawyer, whose professional address is Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given in Luxembourg, on August 1, 2012,
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "HayFin Special Ops LuxCo 3 S.à r.l." (the Company). The Company is a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of
incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit, loans, receivables and other debt instruments and, more generally, any securities and
financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management
and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of
patents or other intellectual property rights of any nature or origin.
107827
L
U X E M B O U R G
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred twenty
five (125) shares in registered form, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders
6.8. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders
will not terminate the Company.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
107828
L
U X E M B O U R G
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle
shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, provided that
if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall be validly taken
by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one
or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B
manager votes in favour of the resolution. Such quorum cannot exist if there is a preponderance of managers physically
present in one country unless that country is the Grand Duchy of Luxembourg.
(vi) Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting, which must be physically
present in the Grand Duchy of Luxembourg, or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or
represented.
(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other
means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(viii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The signature of the sole manager shall bind the Company. If several managers are appointed, the joint signature of
any two managers, or, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B
managers, the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager, shall bind the Company.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article resolutions of the shareholders shall be adopted at a general
meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
107829
L
U X E M B O U R G
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year. The Company's first financial year begins on the date of its incorporation and ends on the thirty-
first (31) of December 2013. Thereafter, each financial year shall begin on the first (1) of January and ends on the thirty-
first (31) of December of each year.
Art. 14. Financial Statements.
14.1. Each year, with reference to the end of the financial year, the Company's accounts shall be established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of
the value of the Company's assets and liabilities.
14.2. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Auditors.
15.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
15.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 16. Allocation of profits.
16.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
16.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
16.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
107830
L
U X E M B O U R G
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2013.
<i>Subscription and paymenti>
HayFin Special Ops LuxCo 1 S.à r.l., represented as stated above, subscribes for one hundred twenty five (125) shares
in registered form, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100,.-) each, and agrees to pay them in full by a
contribution in cash of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred euro is at the free disposal of the Company as was evidenced to the
notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-)
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as managers of the Company for an unlimited duration:
(i) Mrs Carmen lonescu, born on 26 March 1974 in Bucharest (Romania), with professional address at 124, boulevard
de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, as class A manager;
(ii) Mr John Molloy, born on 9 March 1962 in Gaillimh/Galway (Ireland), with personal address at 6, rue du Château,
L-6961 Senningen (Grand Duchy of Luxembourg), as class A manager;
(iii) Mr Tej Gujadhur, born on 21 October 1971 in Curepipe (Mauritius), with professional address at 9
th
Floor Orange
Tower, Ebene, Cybercity (Mauritius), as class A manager;
(iv) Mrs Heike Kubica, born on 23 July 1974 in Lutherstadt Eisleben (Germany), with professional address at 2, Bou-
levard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, as class B manager; and
(v) Mrs Anja Wunsch, born on 23 December 1977 in Schlema (Germany), with professional address at 2, Boulevard
Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, as class B manager.
2. The registered office of the Company is located at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
107831
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le premier jour d'août.
Par-devant le soussigné, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
HayFin Special Ops LuxCo 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie et existant sous le droit du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, dont l'enregistrement
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) est en cours,
représentée par Maître Tina Fettes, avocate, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée à Luxembourg, le 1
er
août 2012.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-
curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "HayFin Special Ops LuxCo 3 S.à r.l." (la Société). La Société est
une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt, prêts, créances et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mo-
bilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société sœur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés
sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
107832
L
U X E M B O U R G
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à
la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés.
6.8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin
à la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et
un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au
Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
et si un ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins
un gérant de classe A et un gérant de classe B est présent ou représenté. Les décisions du Conseil seront valablement
prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, à la condition qu'un ou les associés ont nommé
un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant de classe A et un gérant
de classe B votent en faveur de la décision. Un tel quorum ne peut être atteint s'il existe une majorité de gérants physi-
quement présents dans un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg.
107833
L
U X E M B O U R G
(vi) Les décisions du Conseil, sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion, qui doit
être physiquement présent au Grand-Duché de Luxembourg, ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.
(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables
et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société sera engagée par la signature du gérant unique. Si plusieurs gérants sont nommés, la Société sera engagée
par les signatures conjointes de deux gérants ou, si un ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et
un ou plusieurs gérants de classe B, par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont
adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
107834
L
U X E M B O U R G
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social. Le premier exercice social de la Société commence à la date de sa constitution et finit le trente
et un (31) décembre 2013. Chaque exercice social suivant commencera le premier (1) janvier et se terminera le trente
et un (31) décembre de chaque année.
Art. 14. Approbation des comptes annuels.
14.1. Par référence à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis chaque année et le gérant, ou en
cas de pluralité de gérants, le Conseil, prépare un inventaire comprenant une indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
14.2. Chaque actionnaire peut prendre inspection de l'inventaire susmentionné et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.
15.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés.
Les commissaires sont sujets à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
16.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
16.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux
réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.
107835
L
U X E M B O U R G
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente et un (31) décembre
2013.
<i>Souscription et Libérationi>
HayFin Special Ops LuxCo 1 S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent vingt-cinq (125)
parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, et de les libérer inté-
gralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé
au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée illimitée:
(i) Mme Carmen lonescu, née le 26 mars 1974 à Bucarest (Roumanie), avec adresse personnelle est au 124, boulevard
de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, en tant que gérant de classe A;
(ii) M. John Molloy, né le 9 mars 1962 à Gaillimh/Galway (Irlande), avec adresse personnelle est au 6 rue du Chateau,
L-6961 Senningen (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de classe A;
(iii) M. Tej Gujadhur, né le 21 octobre 1971 à Curepipe (Ile Maurice), avec adresse professionnelle est au 9
th
Floor
Orange Tower, Ebene, Cybercity (Ile Maurice), en tant que gérant de classe A;
(iv) Mme Heike Kubica, née le 23 juillet 1974 à Lutherstadt Eisleben (Allemagne), avec adresse professionnelle au 2,
Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, en tant que gérant de classe B; et
(v) Mme Anja Wunsch, née le 23 décembre 1977 à Schlema (Germany), (Allemagne), avec adresse professionnelle au
2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, en tant que gérant de classe B.
2. Le siège social de la Société est établi au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête des parties comparantes que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: T. FETTES, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 3 août 2012. Relation: LAC/2012/37193. Reçu Soixante-Quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2012.
Référence de publication: 2012102288/525.
(120140041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
107836
L
U X E M B O U R G
Alzette Funding N°1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 90.589.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102810/10.
(120141591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Amplio Filtration Group S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 151.635.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102813/9.
(120141451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Antimo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 99.956.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2012.
Référence de publication: 2012102817/10.
(120141434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Inmet Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.271.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions des actionnaires de la société INMET MINING CORPORATION (la Société) que le mandat
des Administrateurs de la Société suivants a été renouvelé jusqu’à nouvel ordre:
- Yilmaz ARGÜDEN,
- David R. BEATTY,
- John H. CLAPPISON,
- John C. EBY,
- Paul E. GAGNE,
- Oyvind HUSHOVD,
- Thomas MARA,
- Jochen TILK, et
- Douglas WHITEHEAD.
De plus, Monsieur Gerald W. GRANDEY né le 25 juin 1946 à Long Beach, Californie, Etats-Unis d’Amérique, résidant
au 320 Saskatchewan Crescent West, Saskatoon, Saskatchewan S7M 0A4, Canada a été nommé administrateur de la
Société avec effet immédiat et ce jusqu’à nouvel ordre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 9 août 2012.
Référence de publication: 2012103207/25.
(120141568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
107837
L
U X E M B O U R G
Apollo Feeder TH Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 152.138.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012102819/10.
(120140673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Armada835 SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5863 Alzingen, 36, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
R.C.S. Luxembourg E 4.850.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-six juillet.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- Gilles THOUVENIN, fonctionnaire CE, née à Thionville (France) le 23 octobre 1957, demeurant à L-2435 Luxem-
bourg, 6, rue Pierre-Joseph Redouté;
2.- Manon KAYSER, enseignante, née à Luxembourg, le 4 juin 1962, demeurant à L-5863 Alzingen, 36, allée de la
Jeunesse Sacrifiée.
Ils constituent une société civile immobilière dont les statuts auront la teneur suivante:
Titre 1
er
. Dénomination - Objet - Durée - Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: ARMADA835 SCI.
Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs
immeubles en-dehors de toute opération commerciale.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège de la société est établi dans la commune de Hesperange.
Titre II. - Capital - Apports - Parts
Art. 5. Le capital est fixé à deux mille cinq cents (2.500.-) euros, divisé en vingt-cinq (25) parts de cent (100.-) euros
chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:
1.- Gilles THOUVENIN, fonctionnaire CE, née à Thionville (France) le 23 octobre 1957, demeurant à L-2435
Luxembourg, 6, rue Pierre-Joseph Redouté, treize parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.- Manon KAYSER, enseignante, née à Luxembourg, le 4 juin 1962, demeurant à L-5863 Alzingen, 36, allée
de la Jeunesse Sacrifiée, douze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Total: Vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession projetée de parts à un non-associé, les associés bénéficient d'un droit de préemption qui fonctionnera
comme suit: L'associé désireux de céder tout ou partie de ses parts, communiquera les nom, prénom, profession et
adresse du cessionnaire potentiel non-associé ainsi que le prix convenu avec lui, par lettre recommandée à la poste avec
accusé de réception, à la gérance. Celle-ci continuera cette information aux associés endéans un (1) mois, également par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les parts peuvent être reprises par ceux-ci dans le mois de leur information en proportion de leur participation dans
la société.
Chaque associé peut céder son droit de reprise à un autre associé. S'ils laissent passer le dit délai, sans exercer leur
droit de préemption, la cession des parts au non-associé est permise.
Toute cession faite en infraction à ce droit de préemption est nulle.
Art. 7. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts que chacun détient.
107838
L
U X E M B O U R G
À l'égard des tiers, ils sont tenus conformément aux dispositions des articles 1862 et 1863 du Code Civil.
Titre III. Administration
Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 10. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé et du (des) gérant
(s).
Art. 11. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l'assemblée n'en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approxi-
mativement à la somme de quatre cents (400.-) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme
dûment convoqués et, à l'unanimité et par votes séparés, ils ont pris les résolutions suivantes:
1 ) Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2) Est nommé gérant:
Gilles THOUVENIN, fonctionnaire CE, née à Thionville (France) le 23 octobre 1957, demeurant à L-2435 Luxembourg,
6, rue Pierre-Joseph Redouté.
3) La société est engagée par la signature du gérant unique.
4) La durée de leurs fonctions est illimitée.
5) Le siège social est fixé à L-5863 Alzingen, 36, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
Dont acte, fait et passé à
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Thouvenin, Kayser et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 2 août 2012. Relation EAC/2012/10388. Reçu soixante quinze euros 75.-
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
Référence de publication: 2012102821/71.
(120140560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Luxury Brand Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 71.330.
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 juin 2012i>
<i>Sixième résolution:i>
L’Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat des administrateurs suivant:
- Monsieur Patrick Chalhoub, administrateur de société, domicilié professionnellement 261075, Michel Chalhoub
Trading, 1000 Dubai, Emirats Arabes Unis;
- Monsieur Paul Jeanbart, administrateur de société, domicilié professionnellement au 30-32 Chemin du Petit-Saconnex,
CH-1211 Genève 19, Suisse;
- la société Rolaco Holding SA, ayant son siège social au 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg et immatriculée
auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 15748;
- Monsieur Antoine Chalhoub, administrateur de société, domicilié professionnellement au Salhia Commercial Com-
plex, Gate8 – 1
st
floor, PO Box 21074, 13071 Safat – Kuwait;
- Monsieur Charles-Helen des Isnards, administrateur de société, domicilié professionnellement au 4-6 rue Gaillon,
F-75002 Paris.
ainsi que celui de Réviseur d’entreprise agrée de la société Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, parc d’activités
Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
47771
pour une nouvelle période de un an jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
107839
L
U X E M B O U R G
LUXURY BRAND DEVELOPMENT S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012103288/27.
(120140547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
CFNR LUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 48.292.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 19 juin 2012i>
L’Assemblée Générale entérine la cooptation de M. Michel BAUM en qualité d’administrateur en remplacement de M.
Pierre GUERIN, démissionnaire, avec effet au 1
er
juillet 2011, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, à
savoir jusqu’à l’assemblée générale réunie en 2012 pour statuer sur les comptes de 2011.
L’Assemblée Générale renouvelle des mandats d’administrateurs de M. Michel BAUM, demeurant 95, rue des Bruyères
à F-92310 SEVRES (France), Patrice HAEGY, demeurant 11, rue Louis Pasteur à F-67380 LINGOLSHEIM, Christian KLEIN,
demeurant 1, rue Saint-Pierre à F-67140 STOTZHEIM et Aloyse SCHERER, demeurant 16, rue Dante à L-1412 Luxem-
bourg, pour une nouvelle période d’un an, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2012 et renouvelle le mandat d’administrateur-délégué et de président de M. Patrice HAEGY pour la durée de son mandat.
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de réviseur d’entreprises agréé de la société FIDUO, représentée par
Monsieur Philippe SLENDZAK, enregistrée au Registre de Commerce et de Sociétés Luxembourg sous le numéro
B56248, pour une durée d’un an, soit jusqu’à l’assemblée générale appelé à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.
FIDUO
<i>Réviseur d’entreprises agrééi>
Référence de publication: 2012102926/21.
(120140935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Moventum Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 124.292.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle de la Société tenue en date du 4 Juillet 2012i>
En date du 4 Juillet 2012, l'assemblée générale annuelle de la Société a pris les Résolutions suivantes:
De renouveler le mandat des personnes suivantes jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en l'année 2018:
Monsieur Todd ROBINSON, Administrateur A,
Monsieur James S. PUTNAM, Administrateur A,
Monsieur Pierre AHLBORN, Administrateur B,
Monsieur Fernand REINERS, Administrateur B,
Monsieur John PAULY, Administrateur B
De renouveler le mandat des personnes suivantes jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en l'année 2013:
DELOITTE Audit, Réviseur d'entreprises agréé
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 Aout 2012.
Moventum Holdings S.A.
John PAULY
<i>Chief Executive Officeri>
Référence de publication: 2012103314/22.
(120141268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
ASF IV Symphony S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 152.512.
Ce document remplace le dépots L120139282
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
107840
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012102822/11.
(120141347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Atelier de Serrurerie Raymond Weiland, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1141 Luxembourg, 34, rue des Artisans.
R.C.S. Luxembourg B 22.444.
Les comptes annuels rectifiés au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
en remplacement de la 1
ère
version du 30.07.2012 et portant le numéro de dépôt initial au RCS: L120132798.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 9 août 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012102825/11.
(120141182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Attika S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 143.240.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ATTIKA S.A.
Référence de publication: 2012102826/10.
(120141102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Starpack S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 165.986.
<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Directors held in Luxembourg on January 20 i>
<i>sti>
<i> , 2012 at 9.00 o'clocki>
Mr. Michel LOMZIK, private employee, bom on December 31
th
, 1976 in Verviers, Belgium, professionally residing
at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, be appointed as Chairman of the Board of Directors for the whole period of
his mandate as Director, until the Annual General Meeting of 2017.
Certified true copy
Suit la traduction en français de ce qui précède:
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 20 janvier 2012 à 9 heuresi>
Monsieur Michel LOMZIK, employé privé, né le 31 décembre 1976 à Verviers, Belgique, demeurant professionnelle-
ment au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration pendant toute la
durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.
Fait à Luxembourg, le 2 août 2012.
Certifié sincère et conforme
STARPACK S.A.
M. LOMZIK / C. MATHU
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2012103535/22.
(120140587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Auris Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 146.374.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
107841
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102827/9.
(120141553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Autodream s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3505 Dudelange, 59, rue Dominique Lang.
R.C.S. Luxembourg B 136.631.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue en date du 1
er
août 2012, que
- Le siège social est transféré de L - 3541 Dudelange 88A, Rue de la Paix
à L – 3505 DUDELANGE, 59, Rue Dominique Lang
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102829/11.
(120140616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Avaya Luxembourg Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 80.572.
Les comptes annuels de la Société au 30.09.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102832/10.
(120141375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
EEE 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 43.750,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 132.812.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des associés (l'«Assemblée») de la Société tenue au siège social dei>
<i>la Société le 31 juillet 2012.i>
L'Assemblée a réélu Deloitte Audit («anciennement Deloitte SA.»), société à responsabilité limitée ayant son siège
social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 67.895, réviseur d'entreprises agréé de la Société, pour une période venant à expiration à
l'issue de l'assemblée générale devant se tenir en l'année 2013 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels au 31
décembre 2012.
L'Assemblée a également redésigné:
- Monsieur Peter CLUFF comme Gérant de Classe A,
- Monsieur Eric BIREN comme Gérant de Classe A,
- Monsieur Vincent GOY comme Gérant de Classe A, et
- Monsieur Richard MacDonald comme Gérant de Classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012103025/24.
(120141583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Avelec S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8508 Redange-sur-Attert, 1, rue Seitert.
R.C.S. Luxembourg B 142.118.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
107842
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 6 août 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012102834/14.
(120141674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Betsah S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon, Belle Etoile.
R.C.S. Luxembourg B 14.649.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 30 mai 2012i>
Est nommé Réviseur d'entreprises agréé:
- La société
BDO AUDIT
SOCIETE ANONYME
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 LUXEMBOURG
Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2012.
Max LEESCH
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012102873/16.
(120141065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Goodway S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 158.282.
<i>Cession de parts socialesi>
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales datée du 1
er
juillet 2012, que:
Monsieur Marc Bonavia Solé, né à Barcelone le 11 mars 1976, demeurant à 08328 Barcelone, Passeig Maria Estrada,
12,
a cédé à Monsieur Juan Carlos Del Rio, né à Las Palmas de Gran Canaria le 11 février 1969. demeurant à CH - 6300
ZUG, General Guisan Strasse, 6,
100 parts sociales de la société GOODWAY SàRL, ayant son siège social L- 4963 Clémency, rue Basse, 9, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 158282. L'ensemble des parts cédées représente
l'entièreté du capital social de la société, soir EUR 12.500,00.-
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012103116/19.
(120141637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Coprom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 35.526.
L’an deux mil douze, le vingt-septième jour de juillet.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COPROM S.A., avec siège social au 12,
rue de Mersch, L-7535 Mersch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B
et le numéro 35526, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en
date du 5 décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 177 du 12 avril 1991 (la
"Société").
107843
L
U X E M B O U R G
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et une dernière fois suivant acte reçu par le notaire Tom
Metzler en date du 24 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 203 du 7
mars 2005.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nico Arend, demeurant professionnellement au 12, rue de
la Gare L-7535 Mersch,
qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Wikin-Hansen demeurant professionnellement au 12, rue de la Gare
L-7535 Mersch.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Carine Murges, demeurant professionnellement au 12, rue de la
Gare L-7535 Mersch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Création de trois classes d'administrateurs A, B et C et modification subséquente de l'article 6 premier paragraphe
des statuts de la Société.
2. Modification du pouvoir de représentation de la Société et en
conséquence de l'article 12 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante: La société est engagée en toutes
circonstances (i) par la signature individuelle d'un administrateur de la classe A, (ii) ou par la signature conjointe d'un
moins un administrateur de la classe B et d'au moins un administrateur de la classe C, (iii) ou par la signature individuelle
d'un administrateur-délégué appartenant à la classe A d'administrateurs ou (iv) par la signature conjointe d'un adminis-
trateur-délégué appartenant à la classe B d'administrateurs et d'un administrateur-délégué appartenant à la classe C
d'administrateurs, (v) sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs
et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 11 des statuts.
3. Répartition des administrateurs en place dans les classes A (Monsieur Nico AREND et Monsieur Carlo FISCH-
BACH), B (Madame Sylvie WINKIN-HANSEN et Monsieur ALY GEHLEN) et C (Monsieur Laurent FISCHBACH).
4. Suppression de l'autorisation préalable de l'assemblée à la délégation de la gestion journalière à un administrateur
et en conséquence adaptation de l'article 11 des statuts de la Société.
5. Ajout d'un nouveau paragraphe à l'article 7 dont le texte est le suivant: Tout administrateur peut participer à la
réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication
similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant
à la réunion peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les membres
du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion par un tel moyen de communi-
cation équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
6. Modification de l'article 16 des statuts de la Société, l'assemblée devant être convoquée sur la demande écrite
d'actionnaires représentant le dixième du capital social.
7. Rectification/modification de l'adresse du siège social à savoir 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch.
8. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence;
cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés,
a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
„ne varietur“ par les comparants.
III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée à savoir 2.800 actions, il
a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de créer trois classes d'administrateurs A, B et C.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société qui aura
la teneur suivante:
Art. 6. §1. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, répartis
en trois classes d'administrateurs A, B et C, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Ils sont élus
par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme ne pouvant excéder six ans et toujours révocables par elle. Ils
seront rééligibles.
107844
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le pouvoir de représentation de la Société et en conséquence l'article 12 des statuts
de la Société qui aura la teneur suivante:
La société est engagée en toutes circonstances (i) par la signature individuelle d'un administrateur de la classe A, (ii)
ou par la signature conjointe d'un moins un administrateur de la classe B et d'au moins un administrateur de la classe C,
(iii) ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué appartenant à la classe A d'administrateurs ou (iv) par la
signature conjointe d'un administrateur-délégué appartenant à la classe B d'administrateurs et d'un administrateur-délégué
appartenant à la classe C d'administrateurs, (v) sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 11 des statuts.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de répartir les administrateurs actuellement en fonction dans les classes A, B et C comme
suit:
Monsieur Nico AREND et Monsieur Carlo FISCHBACH comme administrateurs de classe A, jusqu'à l'issue de l'as-
semblée générale annuelle de 2016:
Madame Sylvie WINKIN-HANSEN et Monsieur Aly GEHLEN, comme administrateurs de classe B, jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de 2016:
Monsieur Laurent FISCHBACH, en qualité d'administrateur de classe C, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2016.
Monsieur Nico AREND et Monsieur Carlo FISCHBACH sont ainsi administrateurs délégués appartenant à la classe A
d'administrateurs; Madame Sylvie WINKIN-HANSEN et Monsieur Aly GEHLEN ainsi administrateurs délégués apparte-
nant à la classe B d'administrateurs et Monsieur Laurent FISCHBACH administrateur délégué appartenant à la classe C
d'administrateurs.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer l'autorisation préalable de l'assemblée à la délégation de la gestion journalière à un
administrateur et en conséquence de supprimer la dernière phrase de l'article 11 des statuts de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d'ajouter un nouveau paragraphe à placer immédiatement avant le dernier paragraphe de l'article
7 des statuts de la Société dont le texte est le suivant:
Nouveau paragraphe immédiatement avant le dernier paragraphe de l'article 7:
Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-
rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent
être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la
réunion est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la par-
ticipation à une réunion par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société, l'assemblée devant être convoquée sur la demande
écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.
L'article 16 sera lira comme suit:
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou le ou les commissaires.
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide de rectifier/modifier l'adresse du siège social de à savoir au 12 rue de la Gare, L-7535 Mersch (en
lieu et place de 12 rue de Mersch, L-7535 Mersch).
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de
l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe
(s)) au présent acte.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100).
107845
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: Nico Arend, Wikin-Hansen, Carine Murges, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 juillet 2012. LAC/2012/35934. Reçu 75,- EUR.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 7 août 2012.
Référence de publication: 2012102955/132.
(120140729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Cersanit Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 116.349.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 aout 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012102898/13.
(120141278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Belval Plaza I Apartments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 120.931.
Les statuts coordonnés au 1
er
août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012102841/11.
(120140960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Belval Plaza I Mall S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 120.932.
Les statuts coordonnés au 1
er
août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012102842/11.
(120140964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Belval Plaza I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 115.595.
Les statuts coordonnés au 1
er
août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
107846
L
U X E M B O U R G
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012102843/11.
(120140953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Belval Plaza II Apartments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 120.933.
Les statuts coordonnés au 1
er
août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012102844/11.
(120140982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Veep Technology Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 170.723.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Global Project Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions établie et ayant son siège social à L-1637
Luxembourg, 22, rue Goethe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la ville de Luxembourg sous le
numéro B 162.513.
Ici représentée par Me Jérôme BACH, Avocat à la Cour avec adresse professionnelle à 2 A Boulevard Joseph II, L 1840
Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts
(les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par les lois modifiées (la «Loi») du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à respon-
sabilité limitée.
A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la Société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la Société sera VEEP TECHNOLOGY LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet dans le domaine de l'aéronautique, pour compte propre et ou pour compte de tiers
ou en participation le conseil économique ainsi que la gestion d'entreprises et toutes prestations de services annexes ou
complémentaires tel que la restructuration et la transmission d'entreprises dans ce domaine ceci tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
La société a pour également pour objet la location, l'achat et la vente d'avions ainsi que la gestion d'un parc d'avions.
La Société peut également prendre des participations, dans toute société ou entreprise, qu'elles soient luxembour-
geoises ou étrangères sous quelque forme que ce soit ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par la souscription, l'achat, l'échange, ou de n'importe quelle
autre manière, n'importe quelles actions, parts et/ou autres valeurs de participation, obligations avec ou sans garantie,
certificat de dépôts et/ou autres instruments de dette et plus généralement toutes les valeurs. Elle peut de plus acquérir,
administrer et vendre un portefeuille de brevets, licences, marques déposées, modèles, savoir-faire et/ou autres droits
de propriété industrielle ou intellectuelle de n'importe quelle nature ou origine, que la Société jugera approprié et plus
107847
L
U X E M B O U R G
généralement le détenir, le gérer, le développer, le vendre ou en disposer, en tout ou en partie aux conditions que la
société jugera appropriées.
La Société peut emprunter sous n'importe quelle forme exceptée par appel public à l'épargne. Elle peut émettre,
uniquement par le placement privé, des billets à ordre, des obligations avec ou sans garantie et n'importe quel genre de
titres de créances ou de participations. La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, les montants reçus
de tous ses emprunts et/ou de l'émission de dettes ou actions à ses filiales, à ses sociétés liées et/ou à n'importe quelles
autres sociétés et la Société peut également donner des garanties et des nantissements, transférer, grever d'hypothèque
ou alors mettre en gage tout ou partie de ses actifs pour garantir ses propres obligations et engagements et/ou les
obligations et engagements de n'importe quelles autres sociétés, et, généralement, pour son propre bénéfice et/ou le
bénéfice d'autre sociétés ou personnes, dans chaque cas dans la mesure où ces activités ne sont pas considérées comme
des activités régulées par le secteur financier.
La Société peut généralement utiliser tous les techniques et instruments concernant ses investissements pour leur
gestion efficace, y compris des techniques et des instruments conçus pour protéger la société contre le risque de crédit,
le risque de change, le risque de taux d'intérêt et d'autres risques.
La Société peut réaliser toutes opérations et toutes transactions, en relation directe ou indirecte avec les activités
prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil») ou du gérant
unique.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision
modificatrice des Statuts. La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature
à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le Conseil.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant la totalité du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 11. La Société peut racheter ses propres parts sociales en contrepartie d'un apport en numéraire ou non. Les
parts ainsi rachetées, ainsi que toutes parts sociales que la Société aurait reçues, devront être immédiatement annulées
dès qu'elles sont reçues et possédées par la Société.
Tout rachat devra être autorisé par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, adoptée à la
majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.
Si le prix de rachat des parts excède la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne pourra être décidé
que si la Société dispose des sommes distribuables suffisantes, telles que définies par l'article 72-1 de la Loi, eu égard au
surplus du prix de rachat.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution à la majorité des associés.
107848
L
U X E M B O U R G
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui
un tel pouvoir de signature à été délégué par le conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs gérants ou à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents ou représentés.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de
technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.
Les pouvoirs et rémunérations des Gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers Gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 13. Un Gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout Gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous
frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas
où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs
envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits
auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 14. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque Gérant peut prendre part aux réunions du Conseil en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme
ou télex un autre Gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du Conseil.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 15. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément
formulées par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique, télécopie ou par tout autre moyen approprié de
télécommunication/électronique. Chaque associé émettra son vote par écrit
Art. 16. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
107849
L
U X E M B O U R G
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale, en désignant, par écrit ou fax, câble, télégramme, télex
ou par tout autre moyen de télécommunication/électronique approprié, une autre personne qui peut ne pas être un
associé.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux Gérants sont prises par l'associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, avec effet au 31 décembre, le conseil de gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire
des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses
engagements, ainsi que les dettes des Gérants et associés envers la société.
Au même moment le Conseil préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 20. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés (au pro rata de leur participation respective au capital de la
Société) à moins qu'un accord entre les associés n'en dispose autrement.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes aux conditions suivantes:
(i) sur base d'un état comptable préparé par le Gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les
fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve
en vertu d'une obligation légale ou statutaire;
(iii) la décision de payer des acomptes sur dividendes est prise par l'associé unique ou par les associés, le cas échéant;
(iv) une assurance suffisante a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le
capital de la Société à moins qu'un accord entre les associés n'en dispose autrement.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à
sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 22. Les lois mentionnées à l'article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n'est pas dérogé par les Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont été souscrites de la façon suivante:
Global Project Investment S.C.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
107850
L
U X E M B O U R G
Les 500 parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'associé unique, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Monsieur Richard DRAPEAU, né le 27 décembre 1955 à Cholet, Maine et Loire (49) (France), demeurant
au 27, rue Ferdinand Jacob à F-95650 Boissy-l'Aillerie,
b) Monsieur Pascal ROBINET, né le 21 mai 1950 Charleville (France), demeurant à L-7412 Bour, 5, rue d'Arlon
Conformément à l'article 12 des statuts, la société sera engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil
de gérance
3) Le siège social de la Société est établi à 117 Avenue Gaston DIDERICH, L-1420 Luxembourg
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute
Signé: J. Bach et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 août 2012. LAC/2012/36801. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2012.
Référence de publication: 2012102678/226.
(120140209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
Burotrend SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 21.883.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblé Générale Ordinaire tenue le 13 juillet 2012 au siège social de la sociétéi>
Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:
1. L'assemblée générale décide de révoquer le mandat d'Administrateur-délégué de:
- Monsieur Guy Lamesch, né à Walferdange (Luxembourg) le 03 juillet 1951;
2. L'assemblée générale décide de nommer au poste d'Administrateur-délégué:
- Madame Linda Niesen, née le 14 février 1958 à Frisange (Luxembourg), demeurant professionnellement à 5, Rue de
l'Eglise L-1458 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012102884/16.
(120141468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Cinven (Luxco 1) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 163.382.
In the year two thousand twelve, on the thirtieth day of July.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mrs Danielle Arendt-Michels, Company director, residing in Luxembourg, and
Mr. Marc Lamberty, Company director, residing in Luxembourg,
acting as special attorneys in fact of the board of directors (the "Board of Directors") of Cinven (Luxco 1) S.A., a
société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 4, rue A. Borschette, L-1246 Luxembourg,
107851
L
U X E M B O U R G
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, of 13 September 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 2689 of 4 November 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 163.382 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended
following a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 21 No-
vember 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 585 of 6 March 2012,
by virtue of the authority conferred on them by resolutions adopted by the Board of Directors of the Company on
11 May 2012 and on 26 June 2012, a copy of which resolutions, signed "ne varietur" by the appearing persons and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed.
The said appearing persons have requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:
I. That the issued share capital of the Company is presently set at two hundred thirty-five thousand euro (EUR
235,000.-), divided into twenty-three million five hundred thousand (23,500,000) class A ordinary shares, each having a
nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and fully paid up.
II. That pursuant to Article 6 of the Company's articles of incorporation, the authorized capital of the Company has
been fixed at eighteen thousand euros (EUR 18,000.-) divided into one hundred thousand (100,000) class B shares, one
hundred thousand (100,000) class C shares, one hundred thousand (100,000) class D shares, one hundred thousand
(100,000) class E shares, one hundred thousand (100,000) class F shares, one hundred thousand (100,000) class G shares,
one hundred thousand (100,000) class H shares, one hundred thousand (100,000) class I shares, one hundred thousand
(100,000) class J shares, one hundred thousand (100,000) class K shares, one hundred thousand (100,000) class L shares,
one hundred thousand (100,000) class M shares, one hundred thousand (100,000) class N shares, one hundred thousand
(100,000) class O shares, one hundred thousand (100,000) class P shares, one hundred thousand (100,000) class Q shares,
one hundred thousand (100,000) class R shares, and one hundred thousand (100,000) class S shares, each with a nominal
value of one euro cent (EUR 0.01).
III. That the Board of Directors, in its meetings of 11 May 2012 and of 26 June 2012 and in accordance with the authority
conferred on it pursuant to the Company's articles of incorporation, has decided to issue eight thousand four hundred
and six (8,406) new class B shares and to cancel the preferential subscription rights of the Company's existing shareholders
to subscribe for the new shares.
IV. That Mrs. Danielle Arendt-Michels and Mr. Marc Lamberty, acting in their capacity as directors of the Company
and according to the authority granted to them pursuant to the resolutions of the Board of Directors of the Company
dated 11 May 2012 and 26 June 2012, have acknowledged and confirmed, in a confirmation dated 25 July 2012, a copy of
which shall remain attached to the present deed, that the capital of the Company is increased by an amount of eighty-
four euro and six cents (EUR 84.06) by the issuance of eight thousand four hundred and six (8,406) new class B shares.
V. That further to the above capital increase, the Board of Directors, in its meeting of 26 June 2012 and in accordance
with the authority conferred on it pursuant to the Company's articles of incorporation, has decided to issue ninety-two
thousand seven hundred thirty-two (92,732) new class C shares and to cancel the preferential subscription rights of the
Company's existing shareholders to subscribe for the new shares.
VI. That Mrs. Danielle Arendt-Michels and Mr. Marc Lamberty, acting in their capacity as directors of the Company
and according to the authority granted to them pursuant to the resolutions of the Board of Directors of the Company
dated 26 June 2012, have acknowledged and confirmed, in a confirmation dated 25 July 2012, a copy of which shall remain
attached to the present deed, that the capital of the Company is increased by an additional amount of nine hundred
twenty-seven euro and thirty-two cents (EUR 927.32) by the issuance of ninety-two thousand seven hundred thirty-two
(92,732) new class C shares.
VII. That as a consequence of the above mentioned issue of class B shares, effective as of 25 July 2012, and as a
consequence of the above mentioned issue of class C shares, effective as of 25 July 2012, paragraph one of Article 5 of
the Company's articles of incorporation is amended and shall read as follows:
" Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at two hundred thirty-six thousand eleven euro and
thirty-eight cents (EUR 236,011.38) divided into twenty-three million five hundred thousand (23,500,000) class A ordinary
Shares (the "Class A Ordinary Shares"), eight thousand four hundred and six (8,406) class B shares (the "Class B Shares")
and ninety-two thousand seven hundred thirty-two (92,732) class C shares (the "Class C Shares") with a nominal value
of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up.".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at nine hundred euro (EUR 900.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
107852
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,
first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille et douze, le trentième jour de juillet.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
Madame Danielle Arendt-Michels, administrateur de la Société, demeurant à Luxembourg, et
Monsieur Marc Lamberty, administrateur de la Société, demeurant à Luxembourg,
agissant comme mandataires spéciaux du conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») de Cinven (Luxco
1) S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue A. Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 13 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 2689 du 4 novembre 2011, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 163.382 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par un
acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 21 no-
vembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 585, en date du 6 mars 2012,
en vertu d'une procuration qui leur a été conférée par les résolutions adoptées par le Conseil d'Administration de la
Société en date du 11 mai 2012 et 26 juin 2012, et une copie desdites résolutions, après avoir été signée «ne varietur»
par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'enregistrer les déclarations et constatations suivantes:
I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à deux cent trente-cinq mille euros (EUR 235.000,-), divisé
en vingt-trois millions cinq cent mille (23.500.000) actions, ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) et entièrement libérées.
II. Qu'en vertu de l'Article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à dix-huit mille euros
(EUR 18.000,-), divisé en cent mille (100.000) actions de catégorie B, cent mille (100.000) actions de catégorie C, cent
mille (100.000) actions de catégorie D, cent mille (100.000) actions de catégorie E, cent mille (100.000) actions de caté-
gorie F, cent mille (100.000) actions de catégorie G, cent mille (100.000) actions de catégorie H, cent mille (100.000)
actions de catégorie I, cent mille (100.000) actions de catégorie J, cent mille (100.000) actions de catégorie K, cent mille
(100.000) actions de catégorie L, cent mille (100.000) actions de catégorie M, cent mille (100.000) actions de catégorie
N, cent mille (100.000) actions de catégorie O cent mille (100.000) actions de catégorie P, cent mille (100.000) actions
de catégorie Q, cent mille (100.000) actions de catégorie R, cent mille (100.000) actions de catégorie S, ayant chacune
une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).
III. Que le Conseil d'Administration, lors des réunions en date du 11 mai 2012 et du 26 juin 2012 et conformément
au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé d'émettre huit mille quatre cent six (8.406)
nouvelles actions de catégorie B et de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la
Société pour la souscription des nouvelles actions.
IV. Que Madame Danielle Arendt-Michels et Monsieur Marc Lamberty, agissant en leur qualité d'administrateurs de la
Société et conformément au pouvoir qui leur a été conféré par les résolutions du Conseil d'Administration en date du
11 mai 2012 et du 26 juin 2012, ont constaté et confirmé dans une confirmation en date du 25 juillet 2012, dont une
copie restera annexée au présent acte, que le capital social de la Société est augmenté d'un montant de quatre-vingt-
quatre euros et six centimes (EUR 84,06), par l'émission de huit mille quatre cent six (8.406) nouvelles actions de catégorie
B.
V. Que suite à l'augmentation de capital ci-dessus, le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 26 juin 2012 et
conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé d'émettre quatre-vingt-douze
mille sept cent trente-deux (92.732) nouvelles actions de catégorie C et de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires existants de la Société pour la souscription des nouvelles actions.
VI. Que Madame Danielle Arendt-Michels et Monsieur Marc Lamberty, agissant en leur qualité d'administrateur de la
Société et conformément au pouvoir qui leur a été conféré par les résolutions du Conseil d'Administration en date du
26 juin 2012, ont constaté et confirmé dans une confirmation en date du 25 juillet 2012, dont une copie restera annexée
au présent acte, l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de neuf cent vingt-sept euros et trente-deux
centimes (EUR 927,32), par l'émission de quatre-vingt-douze mille sept cent trente-deux (92.732) nouvelles actions de
catégorie C.
VII. Que suite à l'émission des actions de catégorie B mentionnée ci-dessus, avec effet au 25 juillet 2012, et suite à
l'émission des actions de catégorie C mentionnée ci-dessus, avec effet au 25 juillet 2012, le paragraphe premier de l'article
5 des statuts de la Société des statuts est modifié et sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital Emis. Le capital émis de la Société est fixé à deux cent trente-six mille onze euros et trente-huit
centimes (EUR 236.011,38) divisé en vingt-trois millions cinq cent mille (23.500.000) actions ordinaires de catégorie A
(les «Actions de Catégorie A»), huit mille quatre cent six (8.406) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»)
107853
L
U X E M B O U R G
et quatre-vingt-douze mille sept cent trente-deux (92.732) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C») ayant
une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant toutes souscrites et entièrement libérées.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges toute nature payable par la Société suite en raison du présent acte sont
estimés à neuf cents euros (EUR 900,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des personnes
comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des
mêmes personnes comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire soussigné par
leurs noms, prénoms usuel, états et demeures, elles ont signé avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: D. Arendt-Michels, M. Lamberty, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 1 août 2012. Relation: DIE/2012/9093. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Diekirch, le 1
er
août 2012.
Référence de publication: 2012102905/146.
(120140577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Belval Plaza II Mall S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 120.934.
Les statuts coordonnés au 1
er
août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012102845/11.
(120140990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Belval Plaza II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 119.547.
Les statuts coordonnés au 1
er
août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012102846/11.
(120140973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Belval Plaza Tower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 119.548.
Les statuts coordonnés au 1
er
août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012102847/11.
(120140951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
107854
L
U X E M B O U R G
Global Finance Sàrl SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 161.956.
Il résulte de l'assemblée générale de l'associé unique de la Société tenue en date du 31 juillet 2012 que les mandats
des gérants suivants ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes
annuels au 31 décembre 2012:
- Jamshid Ahmadi Niri, né le 31 décembre 1961 à Téhéran (Iran), demeurant au 213264 Dubai, Emmar Properties,
Villa 16/6 W SUB METER, 394 - Emirates Hills Third (Emirats Arabes Unis);
- Hamed Ahmadi Niri, né le 16 août 1986 à Téhéran (Iran), demeurant à CH-1205 Genève, 8, rue Vignier, Appartement
609;
- Mehrdad Shamshirsaz, né le 2 février 1957 à Téhéran (Iran), demeurant à Deira (Dubai), 69, Al Regga street, Apt.
603 (Emirats Arabes Unis).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 août 2012.
Pour extrait
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012103112/21.
(120141097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Benelux Distribution Systems S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 50.762.
1. Avec effet au 11 octobre 2006, M. Gérard MATHEIS a démissionné de ses mandats d’administrateur et d’adminis-
trateur-délégué.
2. Avec effet au 11 octobre 2006, M. Dennis BOSJE a démissionné de ses mandats d’administrateur et d’administrateur-
délégué.
3. Avec effet au 11 octobre 2006, Mme Elisabetta TRIVISANI a démissionné de son mandat d’administrateur.
Luxembourg, le 8 août 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Benelux Distribution Systems S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012102848/15.
(120140836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Batisica S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 35.595.
Les comptes consolidés de la société FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS au 31 décembre 2011 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012102860/14.
(120140948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
BizzDev Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2267 Luxembourg, 18, rue d'Orange.
R.C.S. Luxembourg B 159.124.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
107855
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2012.
Référence de publication: 2012102851/10.
(120141276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Blue Skye Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 159.631.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012102853/9.
(120140845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Bravida HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 122.235.
Les statuts coordonnés au 2 août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012102855/11.
(120141242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Belgravia European Properties, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 825.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 113.404.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 6 août 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Madame
Stéphanie GRISIUS et de Messieurs Laurent HEILIGER et Manuel HACK aux fonctions de gérants de la société et a nommé
comme nouveau gérant:
- TERES, société à responsabilité limitée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, RCS Luxembourg B 141.013, gérant.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes au 31 décembre 2011.
Luxembourg, le 6 août 2012.
<i>Pour BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012102867/17.
(120140599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
Winchester Square Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 78.513.
Les comptes annuels au 27 juillet 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012104160/9.
(120141906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
107856
Alain Afflelou International S.A.
ALF Participations 2 S.A.
Alimede Luxembourg S.à.r.l.
All Import S.à.r.l.
Alltra S.A.
Altea Europe S.A.
Altea Europe S.A.
Altercap Lux Co-Invest S.A.
Alzette Funding N°1 S.à r.l.
Amplio Filtration Group S.A.
Ansea S.A.
Antimo S.A.
Apollo Feeder TH Sàrl
Armada835 SCI
ASF IV Symphony S.à r.l.
Assya Asset Management Luxembourg S.A.
Atelier de Serrurerie Raymond Weiland, société à responsabilité limitée
Attika S.A.
Auris Finance S.A.
Autodream s.à r.l.
Avaya Luxembourg Investments S.àr.l.
Avelec S.à r.l.
Batisica S.à.r.l.
Belgravia European Properties
Belval Plaza I Apartments S.à r.l.
Belval Plaza II Apartments S.à r.l.
Belval Plaza II Mall S.à r.l.
Belval Plaza II S.à r.l.
Belval Plaza I Mall S.à r.l.
Belval Plaza I S.à r.l.
Belval Plaza Tower S.à r.l.
Benelux Distribution Systems S.A.
Betsah S.A.
BizzDev Luxembourg S.à r.l.
Blue Skye Capital S.à r.l.
Bravida HoldCo S.à r.l.
Burotrend SA
Cersanit Luxembourg S.à r.l.
CFNR LUX
C. Hypothek Lux S.à r.l.
Cinven (Luxco 1) S.A.
Coprom S.A.
EEE 4 S.à r.l.
Europ Continents Holding
Global Finance Sàrl SPF
Goodway S.à r.l.
HayFin Special Ops LuxCo 3 S.à r.l.
Inmet Luxembourg
Jalor Finance S.A.
Luxury Brand Development S.A.
Moventum Holdings S.A.
Pfizer Asset Management Luxembourg Sàrl
Starpack S.A.
Vallis Construction Sector Consolidation Fund SICAV-SIF
Veep Technology Luxembourg Sàrl
Winchester Square Holdings S.à.r.l.