logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2151

30 août 2012

SOMMAIRE

ACM Bernstein Value Investments  . . . . . .

103237

ASR Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103202

BNP Paribas L Fix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103203

Centralis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103238

Cogeco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103236

CP Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

103220

Dahlia A SICAR S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

103243

d'Amico International Shipping S.A.  . . . . .

103205

Danaher Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

103240

DCORP, S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103244

DC Systèmes de Sécurité S.à r.l.  . . . . . . . .

103246

D.E.H. Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103239

Dekode S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103246

Delhaize Distribution Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103243

Delhaize Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .

103246

DesCap S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103243

DHC Luxembourg V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

103247

DHCT II Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

103247

DH K S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103245

Difrulux s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103247

Digital Realty (Cressex) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

103244

Digital Realty (Manchester) S.à r.l. . . . . . . .

103244

Dome 4 0909 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103244

Dominium Dortmund S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

103245

Dominium Palmaille S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

103245

Dominium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103245

Electroengine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103239

Eucalyptus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103208

EuroPRISA Poland Warehouse S. à r.l. . . .

103248

Fidam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103207

Immobilière C.M.R. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

103204

La Paix Immobilière S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

103218

Lighthouse International Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103215

Lighthouse International Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103238

Lighthouse International Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103238

Médecins Sans Frontières  . . . . . . . . . . . . . . .

103240

Médecins Sans Frontières  . . . . . . . . . . . . . . .

103248

MGP Europe AIV (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

103246

Prodest Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103247

SEB JINIFE Global Equity Fund 11 - SICAV

- FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103204

Smart Informatique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

103241

Speedlingua S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103241

Tishman Speyer Brienner Strasse G.P. S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103208

Tishman Speyer Valentinskamp G.P. S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103208

Tishman Speyer Valentinskamp L.P. S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103208

UniDividendenAss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103219

UniDynamicFonds: Europa . . . . . . . . . . . . . .

103208

UniEM Fernost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103215

UniEM Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103215

UniEuropaRenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103214

UniProfiAnlage (2015)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103220

UniProfiAnlage (2015/II)  . . . . . . . . . . . . . . . .

103238

UniProfiAnlage (2016)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103238

UniProfiAnlage (2017)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103237

UniProfiAnlage (2017/6J)  . . . . . . . . . . . . . . .

103237

UniProfiAnlage (2019)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103237

UniProfiAnlage (2020)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103237

UniProfiAnlage (2021)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103237

UniProfiAnlage (2023)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103236

UniProfiAnlage (2024)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103236

UniProfiAnlage (2025)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103220

UniProfiAnlage (2027)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103220

UniValueFonds: Europa . . . . . . . . . . . . . . . . .

103217

UniValueFonds: Global  . . . . . . . . . . . . . . . . .

103215

Zellam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103203

103201

L

U X E M B O U R G

ASR Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Howald, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 109.355.

An

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

shall be held on Tuesday <i>September 25, 2012 at 2.30p.m., at the premises of BNP Paribas Investment Partners Lux-

embourg, Building H2O, Block A, Ground Floor, located at 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

<i>Agenda:

Updating of the Articles of Association as follows:

1. Articles 3 and 35: making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning under-

takings for collective investment, replacing the law of 20 December 2002;

2. Article 6: redefinition of the notion of "sub-fund";
3. Article 7: redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares";

Articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24, 29, and 31: replacement of the term "sub-category" by "class of shares";

4. Articles 8 and 9§5: cancellation of the issuance of share certificates

Deletion of previous Article 9 concerning lost or damaged certificates;

5. Article 9§1: opening up the possibility for the Board of Directors to reject any new subscription;
6. Article 12§3: opening up the possibility of rounding off to the higher or lower unit or fraction in the event of share

buybacks;

7. Creation of a new article following Article 13 authorizing the Board of Directors to split or regroup shares;
8. Article 14(b) and (e): addendum to valuation date as the date of determination of the value of the funds invested

(14b) and exchange rate (14e);
Article 14(d): elimination of the depositary bank's consent for the appointment of the appraiser appointed for the
valuation of unlisted assets;

9. Article 15 (e) and (f): addition of the terms "categories or classes of shares" for suspensions of NAV and orders in

the event of merger or liquidation;
Article 15 (f): elimination of the maximum time period of 2 days for suspension of NAV and orders in the event of
merger;

10. Article 15§3 and 4: replacement of the limit of 10% by a limit to be defined by the Board of Directors to determine

the percentage of repurchased assets requiring either a suspension or a postponement of the processing of orders;

11. Article 17§5: the decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast;
12. Article 27: The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital repre-

sented. Resolutions shall be taken by a simple majority of the votes cast;

13. Articles 31 and 32: replacement of the time period of 9 months following liquidation by a reference to the regulations

in force for the depositing of undistributed assets at the Caisse de Consignation;

14. Article 32: Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions con-

cerning the effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of sub-funds, categories or classes of
shares within the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010;

In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholders'

Meeting shall be able to validly deliberate only if at least one half of the Company's capital is present or represented.
Decisions shall be taken by at least two-thirds of the votes cast. The votes expressed do not comprise those attached to
the shares for which the shareholder has not taken part to the vote or has not voted or whose vote was considered as
null or void.

Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their

shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.

Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon

proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.

The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available

from the bodies listed in the prospectus.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2012111491/755/54.

103202

L

U X E M B O U R G

Zellam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.199.

You are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the sole shareholder of the Company to be held in Luxembourg at the registered office of the Company on Mon-

day, <i> September 17 

<i>th

<i> , 2012  at 2.00 p.m., in order to deliberate and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. To receive and adopt the reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor for the financial year ended

December 31 

st

 , 2010 and December 31 

st

 , 2011;

2. To receive and approve the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended December

31 

st

 , 2010 and December 31 

st

 , 2011;

3. To allocate the results of the financial year ended December 31 

st

 , 2010 and December 31 

st

 , 2011;

4. To grant discharge to the Board of Managers and Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates

as at December 31 

st

 , 2010 and as at December 31 

st

 , 2011;

5. To renew the mandates of the Managers and the Statutory auditor until the Annual General Meeting to be held in

2015;

6. Miscellaneous.

The financial statements are available at the registered office of the Company.

Luxembourg, August 9 

th

 , 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A.
T.C.G. Gestion S.A.

Référence de publication: 2012102720/710/25.

BNP Paribas L Fix, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 50.443.

An

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders will be held in Luxembourg on Tuesday <i>September 25, 2012 at 2.30 p.m. at the offices of the manage-

ment company BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Building H2O, Block A, Ground Floor, 33 rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange.

<i>Agenda:

1. To appoint Ernst &amp; Young S.A. as company auditors in place of PriceWaterhouse Coopers S.à r.l.;
In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholders'

Meeting shall be able to validly deliberate only if at least one half of the Company's capital is present or represented.
Decisions shall be taken by at least two-thirds of the votes cast. The votes cast do not include those attached to shares
for which the shareholders have not voted or have abstained or whose vote is blank or invalid.

Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their

shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.

Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon

proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.

The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available

from the bodies listed in the prospectus.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2012111492/755/25.

103203

L

U X E M B O U R G

SEB JINIFE Global Equity Fund 11 - SICAV - FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 133.427.

Einladung zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre die am <i>19. September 2012 um 14:00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfinden wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Lageberichts des Verwaltungsrats und des Berichts des zugelassenen Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses zum 31. März 2012
3. Verwendung des Jahresergebnisses
4. Entlastung aller Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Ausübung ihrer Pflichten für den Zeitraum bis zum 31.

März 2012

5. Statutarische Wahlen
6. Sonstiges

<i>Abstimmung

Beschlüsse werden ohne Anwesenheitsquorum und daher mit einfacher Mehrheit der auf der Hauptversammlung

abgegebenen Stimmen gefasst.

<i>Abstimmungsbedingungen

Jeder Aktionär ist berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. Sollte es Ihnen jedoch nicht möglich sein, an

der ordentlichen Generalversammlung vom 19. September 2012 teilzunehmen, haben Sie die Möglichkeit, sich mittels
privatschriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten zu lassen, die auf Anfrage am Gesellschaftssitz erhältlich ist.

Diese Vollmacht muss vor dem 12. September 2012 ausgefüllt und unterschrieben an den Gesellschaftssitz zurück-

gesendet werden (bitte vorab per Fax +352 2623 2555).

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2012111495/755/29.

Immobilière C.M.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.

R.C.S. Luxembourg B 102.397.

Les actionnaires de la Société sont priés d'assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires qui se tiendra le mardi <i>18 septembre 2012 à 17.00 heures, au siège de la Société, à l'effet de délibérer

sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes de l'exercice social

clos le 31 décembre 2011 et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2011;

2. Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2011;
3. Quitus aux administrateurs et au commissaire;
4. Finalisation de la mise à jour de la situation du capital social;
5. Divers.
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'assemblée ne requièrent aucun quorum et que les

décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration
Claude BAER / Marco DIEDERICH
<i>Administrateur-délégué / Administrateur

Référence de publication: 2012110503/3083/22.

103204

L

U X E M B O U R G

d'Amico International Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 124.790.

The

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company (hereinafter, the "Meeting") will be held at the registered address of the Company,

25C boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>2 October 2012 , at 11.00 a.m., to discuss
and resolve on the following:

<i>Agenda:

1. To reduce, on the basis of a special report by the Board of Directors, the accounting value of each share of the

issued share capital of the Company from its current amount of one dollar of the United States of America (USD
1.-) per share to ten cents of a dollar of the United States of America (USD 0.10) per share without cancellation
of any shares in issue nor repayment on any share; to allocate an amount corresponding to the resulting reduction
of the share capital of an amount of one hundred thirty-four million nine hundred fifty-four thousand nine hundred
sixteen dollars of the United States of America and thirty cents (USD 134,954,916.30) to a special capital account
(apport en capitaux propres non rémunéré par des titres) of an amount of one hundred thirty-four million nine
hundred fifty-four thousand nine hundred sixteen dollars of the United States of America and thirty cents (USD
134,954,916.30), having the same characteristics as the premium account of the Company and the amount of which
(i) can be used in the same way as the amounts allocated to the premium account or (ii) can be reintegrated into
the share capital by means of passing of an appropriate shareholders' resolution adopted in compliance with the
quorum and majority rules for an amendment of the articles of association of the Company; to set the amount of
the issued share capital from its current amount of one hundred forty-nine million nine hundred forty-nine thousand
nine hundred and seven dollars of the United States of America (USD 149,949,907) to the amount of fourteen
million nine hundred ninety-four thousand nine hundred ninety dollars of the United States of America and seventy
cents (USD 14,994,990.70) and to pass resolutions to that effect, including the required amendments of article 5
of the Company's articles of association.

2. To amend, on the basis of a special report by the Board of Directors, the authorised corporate capital from its

present amount of two hundred million dollars of the United States of America (USD 200,000,000.-) divided into
two hundred million (200,000,000) shares with no nominal value to fifty million dollars of the United States of
America (USD 50,000,000.-) divided into five hundred million (500,000,000) shares with no nominal value and to
renew, for a period of five (5) years, the authorisation of the Board of Directors to increase the capital in one or
several tranches within the limits of the amended authorised capital, as well as the authorisation of the Board of
Directors to limit or cancel, in full or partially, the preferential subscription right of existing shareholders and to
pass resolutions to that effect, including the required amendment of article 5 of the Company's articles of associ-
ation.

3. To grant power to the Board of Directors to implement the resolutions passed on the aforementioned items of

the agenda of the meeting.

<i>Quorum and Majority Requirements

The Meeting shall validly deliberate provided a quorum of half of the shares issued and outstanding is reached. If the

quorum is not reached at the first meeting a second meeting may be convened at which no quorum requirement shall
apply. Resolutions shall be adopted by a majority of 2/3 of the votes cast by the shareholders present or represented at
the Meeting.

<i>Declaration of Intention to Participate in the Meeting

Shareholders must notify the Company on the day of the Record Date (as defined hereafter) of their intention to

participate in the Meeting by sending a certificate (the "Certificate") indicating, inter alia, (i) the name and/or corporate
name and the registered address and/or domicile of the shareholder, (ii) a confirmation of participation in the Meeting
and (iii) a confirmation of the number of shares held by the shareholder after closing of the markets on the Record Date
(the "Shareholder's Details"). For shareholders holding their shares through an Intermediary (as defined hereafter), the
Certificate being prepared by the Intermediary with which the shares are held shall be sent to BNP Paribas Securities
Services, Luxembourg branch in its capacity as the duly mandated agent of the Company ("BNP Paribas") with copy to
the Company exclusively through the Euroclear and Clearstream systems. In that respect, Intermediaries are further
requested to compulsorily instruct Euroclear and Clearstream to further confirm to BNP Paribas all Shareholder's Details.

<i>Voting Rights and Record Date

The rights of a shareholder to attend and speak at the Meeting and to vote in respect of his shares shall be determined

with respect to the shares held by the shareholder on 18 September 2012 at 24:00 hours Luxembourg time (the "Record
Date"). Only those who are shareholders on the Record Date shall have the right to participate and vote at the Meeting.

103205

L

U X E M B O U R G

Shareholders present or represented are requested to bring a copy of the Certificate to the Meeting in order to

present it to the board of the Meeting.

<i>Representation by Proxy or Voting by Ballot Paper

Shareholders need not to be present at the Meeting in person. In accordance with the Company's articles of association,

a shareholder on the Record Date may act at the Meeting by appointing another person who needs not to be a shareholder
himself subject to the production of the original of the executed proxy to the Meeting in order to present it to the board
of the Meeting. The proxy holder shall enjoy the same rights to speak and ask questions at the Meeting as those to which
the shareholder thus represented would be entitled. Each shareholder shall only be represented by one proxy holder at
the Meeting except that:

(i) if a shareholder has shares of the Company held in more than one securities account, he may appoint one proxy

holder per securities account at the Meeting;

(ii) a shareholder acting professionally for the account of other natural or legal persons may appoint each of these

natural or legal persons or third parties appointed by them.

A person acting as a proxy holder may hold a proxy from more than one shareholder without limitation as to the

number of shareholders so represented. Where a proxy holder holds proxies from several shareholders, it may cast
votes for a certain shareholder differently from votes cast for another shareholder.

Shareholders shall appoint a proxy holder in writing. Such appointment shall be notified by the shareholders to the

Company in writing by postal services or electronic means at the address of the Company indicated below by no later
than 5:00 p.m. Luxembourg time on 27 September 2012.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners

of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at the Meeting.

Alternatively, in accordance with the Company's articles of association, a shareholder may cast his vote by a ballot

paper ("formulaire") expressed in the English language. Any ballot paper shall be delivered by hand with acknowledgment
of receipt, by registered post, by special courier service using an internationally recognised courier company, by email or
by fax to BNP Paribas with copy to the Company no later than 5:00 p.m. Luxembourg time on 27 September 2012.

Any ballot paper which does not bear the mentions or indications required by the Company's articles of association

is to be considered void and shall be disregarded for quorum purposes. In case a proposed resolution is amended by the
Meeting, the votes expressed on such proposed resolution pursuant to the ballot papers received shall be void.

Shareholders who are not personally registered in the Company's share register may also vote by proxy or by ballot

paper.

To such effect, they must instruct the commercial bank, broker, dealer, custodian, trust company, accountholder,

professional securities depositary, financial institution or other qualified intermediary through which they hold their shares
(hereinafter, the "Intermediary") who handles the management of the Company's shares by using the proxy form or the
ballot paper form.

Intermediaries shall ensure that the signed and dated proxy forms with vote instructions be deposited in writing by

postal services or electronic means at the address of BNP Paribas with copy to the Company by no later than 5:00 p.m.
Luxembourg time on 27 September 2012. Beneficial owners of shares held through an Intermediary are urged to inform
themselves of the deadline for receipt of their proxy forms with vote instructions by such Intermediary to ensure their
onward delivery to BNP Paribas by the relevant deadline.

Shareholders acknowledge that by sending their proxy forms with their voting instructions or their ballot paper form

they will be deemed to consent to having the relevant Intermediary, including but not limited to Euroclear and Clear-
stream, provide all details concerning their identity to BNP Paribas and to the Company.

Relevant proxy forms and/or ballot papers forms may be obtained, free of charge, at the registered office of the

Company,  on  the  Company's  website  www.damicointernationalshipping.com  (hereinafter,  the  "Website")  or  at  BNP
Paribas.

<i>Documentation for the Meeting

In full compliance with the laws and regulations in force and applicable to the Company, the required supporting

documentation, the convening notice, the total number of shares and voting rights, the draft resolutions and the proxy
and ballot papers forms are deposited and available to the public at the Company's registered office, at Borsa Italiana
S.p.A. (Hwww.borsaitaliana.itH) and at Société de la Bourse de Luxembourg S.A. in its quality of OAM, as well as on the
Website.

Shareholders may upon request obtain a copy of the full, unabridged text of the documents to be submitted to the

Meeting of shareholders and draft resolutions proposed to be adopted by the Meeting by electronic means at the address
of the Company indicated below or by postal services at the registered office of the Company.

<i>Right to Put Items on the Agenda and to Table Draft Resolutions

In accordance with the Company's articles of association, shareholders holding individually or collectively at least five

(5)% of the share capital of the Company: (a) have the right to put items on the agenda of the Meeting; and (b) have the
right to table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the Meeting. Those rights shall be

103206

L

U X E M B O U R G

exercised upon requests of the shareholders in writing submitted to the Company by postal services or electronic means
at the addresses of the Company indicated below. The requests shall be accompanied by a justification or a draft resolution
to be adopted in the Meeting and shall include the electronic or mailing address at which the Company can acknowledge
receipt of these requests. The requests from the shareholders must be received by the Company at the latest on 10
September 2012.

<i>Right to Ask Questions

In accordance with the Company's articles of association, shareholders shall have the right to ask questions at the

Meeting related to items on the agenda of the Meeting. The Company shall answer the questions put to it by shareholders.
The right to ask questions and the obligation of the Company to answer are subject to the measures to be taken by the
Company to ensure the identification of shareholders, the good order of general meetings and their preparation as well
as the protection of confidentiality and business interests of the Company.

The contact details of the Company and of the centralising bank mandated by the Company are as follows:
The Company
d'Amico International Shipping S.A.
25 C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: + 352 26 26 24 54, Email: ir@damicointernationalshipping.com
Attention: Mr. Marco FIORI, CEO / Mrs. Anna FRANCHIN, Investor Relations Manager
The details of the centralising bank mandated by the Company are as follows:
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Corporate Trust Services
33 rue de Gasperich, Howald, Hesperange,
L-2085 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel: + 352 2696 2518/2407, Fax: + 352 2696 9757
Email: lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com
Attention: Lux ost domiciliees, Sabrina DEVERSENNE / Rudolf VOIGTLANDER

Luxembourg, 30 August 2012.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2012111493/267/143.

Fidam, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 89.058.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav FIDAM à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(« l'Assemblée ») qui se tiendra le <i>18 septembre 2012 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du

jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 avril 2012
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles auprès du siège social de la Sicav.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq

jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme à
Luxembourg.

Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs

avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 49 924 2501 / e-mail : ifs.fds@bdl.lu) de leur intention
d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2012111494/755/27.

103207

L

U X E M B O U R G

Eucalyptus, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 54.769.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu exceptionnellement le <i>07 septembre 2012 à 14 heures au 163 Rue du Kiem, L-8030

Strassen avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
2. Acceptation de la démission du Commissaire et nomination de son remplaçant.
3. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq

jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 163 Rue du Kiem à Strassen
(Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012106600/18.

UniDynamicFonds: Europa, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 30. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012075864/10.
(120107039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2012.

Tishman Speyer Valentinskamp L.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.014.775,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 113.347.

Tishman Speyer Brienner Strasse G.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 116.067.

Tishman Speyer Valentinskamp G.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 113.348.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of August.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

APPEARED.

1. Tishman Speyer Valentinskamp L.P. S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée),

established and existing under Luxembourg law, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 113347, established pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 14,
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations under number 675 dated April 3, 2006, and
whose bylaws have been last amended by a deed of Maître Francis Kesseler, prenamed, on February 9, 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 1134 dated May 27, 2011, with a subscribed and fully
paid in share capital of twenty-three million fourteen thousand seven hundred seventy-five Euro (EUR 23.014.775,00)
represented by nine hundred twenty thousand five hundred ninety-one (920.591) shares, with a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25,00) each (the Absorbing Company),

103208

L

U X E M B O U R G

here represented by Mr. Richard Fauvel, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue

of a special power of attorney granted by the board of managers of the Absorbing Company dated August 23, 2012
(Resolutions 1);

2. Tishman Speyer Brienner Strasse G.P. S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée),

established and existing under Luxembourg law, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 116067, established pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, on April 21, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 1351
dated July 13, 2006, and whose bylaws have not been amended since, with a subscribed and fully paid in share capital of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of
twenty-five Euro (EUR 25,00) each (the Absorbed Company 1),

here represented by Mr. Richard Fauvel, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue

of a special power of attorney granted by the board of managers of the Absorbed Company dated August 23, 2012
(Resolutions 2);

3. Tishman Speyer Valentinskamp G.P. S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée),

established and existing under Luxembourg law, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 113348, established pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, on December 14, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 673
dated April 1, 2006 and whose bylaws have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on
September 5, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 2130 dated November
15, 2006, with a subscribed and fully paid in share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) repre-
sented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25,00) each (the Absorbed Company
2, together with the Absorbed Company 1 hereinafter referred to as the Absorbed Companies),

here represented by Mr. Richard Fauvel, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue

of a special power of attorney granted by the sole manager of the Absorbed Company dated August 23, 2012 (Resolutions
3);

A copy of the Resolutions 1, the Resolutions 2 and the Resolutions 3 signed ne varietur by the proxyholder of the

appearing persons and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration
authorities.

The Absorbing Company and the Absorbed Companies are hereafter together referred to as the Merging Companies

and are both subject to the Luxembourg law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as subsequently amended

(the Law).

The proxyholder of the appearing persons, acting for the sole manager and the board of managers of the Merging

Companies (the Boards), requested the notary to draw up the merger proposal (the Merger Proposal) related to the
merger between the Absorbing Company and Absorbed Companies (the Merger) in the following way:

MERGER PROPOSAL

The shares of both Merging Companies are held at one hundred percent (100%) by one and the same sole shareholder.
The Boards have decided that the Absorbed Companies shall be merged into the Absorbing Company and for this

purpose, the Absorbed Companies shall contribute all their assets and liabilities (the Assets and Liabilities) to the Ab-
sorbing Company.

The Boards acknowledge that the sole shareholder of the Merging Companies is the only owner holder of voting rights

over the Merging Companies and that it agreed (i) not to appoint an independent expert to the Merger Proposal and to
waive the expert report in accordance with Article 266 (5) of the Law and (ii) to waive the managers' report and the
information referred to in Article 265 (2) of the Law, in accordance with article 265 (3) of the Law.

The Merger is subject to the condition that the sole shareholder of the Absorbing Company and the sole shareholder

of the Absorbed Companies approve the Merger Proposal in separate extraordinary general meetings of the sole sha-
reholder, in compliance with the Law.

The effective date of the Merger shall be the date on which the Merger is approved by the sole shareholder of the

Merging Companies, in accordance with article 272 of the Law (the Effective Date).

Now therefore, it is agreed as follows:
Subject to the approval of the Merger by the sole shareholder of the Merging Companies to be given at separate

extraordinary general meetings of the sole shareholder:

1. On the Effective Date of the Merger, the Absorbed Companies shall, pursuant to articles 257 et seq. of the Law,

contribute to the Absorbing Company all their assets and all their liabilities, without any restriction or limitation.

2. As from the Effective Date of the Merger, all assets and liabilities of the Absorbed Companies shall be deemed

transferred to the Absorbing Company.

103209

L

U X E M B O U R G

The assets and liabilities of the Absorbed Companies, which are all transferred at their book value to the Absorbing

Company on the Effective Date, are evaluated per the financial situation of the Absorbed Companies as at December 31,
2011.

3. In exchange for the said contribution, the Absorbing Company will not issue new shares to the sole shareholder of

the Absorbed Companies, being Tishman Speyer ESOF Holdings (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), established and existing under Luxembourg law, having its registered office at 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one million thirty-seven
thousand five hundred Euro (EUR 1.037.500,00), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 113349 (the Sole Shareholder), but will record an increase of the acquisition cost of the shares of the Absorbed
Companies as an extraordinary reserve of the Absorbing Company and for an amount corresponding to the amount of
the net equity of the Absorbed Companies as of December 31, 2011. There will be no payment in cash.

4. The shares of the Absorbed Companies are free of all liens and charges and not encumbered by any security or

beneficial right or the holder of such lien, charge, security or beneficial right has granted permission for the Merger.

5. As a result of the Merger, the Absorbed Companies shall cease to exist and all their shares in issue shall be cancelled.

The activities of the Absorbed Companies will be continued by the Absorbing Company.

6. Neither Merging Companies have issued to a non-shareholder securities entitling their holders to a right to vote,

therefore no special measures for these persons were proposed or planned.

7. Discharge shall be granted to the managers or sole manager of the Absorbed Companies for the exercise of their

mandate until the Effective Date

8. No particular advantage is granted to the members of the Boards.
9. As the Absorbed Companies do not have any employees, the Merger will not have any effect on employment.
10. The Merger shall further be subject to the following terms and conditions:
a) the Absorbing Company shall acquire the assets contributed by the Absorbed Companies in the state in which they

are on the Effective Date of the Merger, without any right of recourse against the Absorbed Companies or against the
Sole Shareholder on whatever grounds;

b) the Absorbed Companies guarantee to the Absorbing Company the existence of all receivables comprised in the

assets contributed but do not assume any liability as to the solvency of the debtors concerned;

c) the Absorbing Company shall from the Effective Date of the Merger pay all taxes, contributions, duties and levies

whether ordinary or extraordinary, which are due or may become due with respect to the property of the assets con-
tributed;

d) the Absorbing Company shall carry out all agreements and obligations of whatever kind of the Absorbed Companies

such as these agreements and obligations exist on the Effective Date of the Merger;

e) the Absorbing Company shall in particular carry out all agreements existing with the creditors of the Absorbed

Companies and the Absorbing Company shall be subrogated to all rights and obligations resulting therefrom, at its own
risks;

f) the rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Companies shall be transferred to the Absorbing

Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be subro-
gated, without any novation, to all rights, whether in rem or personal, of the Absorbed Companies with respect to all
assets and against all debtors without any exception;

g) the Absorbing Company shall assume all liabilities of any kind of the Absorbed Companies and it shall in particular

assume interest and principal on all debts and liabilities of any kind due by the Absorbed Companies. The Absorbing
Company shall discharge the Absorbed Companies from any shares and claims in relation to obligations and duties thus
assumed by the Absorbing Company;

h) the Absorbing Company hereby formally waives any rights of preference, mortgage and rescission, which it may

have against the Absorbed Companies as a result of the Absorbing Company assuming debts, charges and obligations of
the Absorbed Companies and it explicitly dispenses the keepers of mortgages with making such an entry ex officio upon
registration of this deed.

11. From an accounting point of view, the Merger shall be deemed to be effective as from January 1, 2012, and for the

avoidance of doubt, annual accounts of the Absorbing Company for the period starting on such date should be based on
the annual accounts of both Merging Companies for the period ending on December 31, 2012.

12. The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as are prescribed by

Law, which are necessary or useful to carry into effect the Merger and the transfer and assignment of the assets and
liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company. Insofar as required by Law or deemed necessary or
useful, appropriate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets
and liabilities contributed by the Absorbed Companies to the Absorbing Company.

13. All corporate documents, files and records of the Absorbed Companies shall be kept at the registered office of

the Absorbing Company for so long as the Law prescribes.

103210

L

U X E M B O U R G

14. The Merger Proposal, the accounting statements of the last three years as well as the interim accounts as of June

30, 2012 of the Merging Companies shall be available at the registered office of each one of the Merging Companies for
inspection by their respective sole shareholder one (1) month at least prior to the date of the aforesaid sole shareholder's
meetings.

15. Insofar as not specifically provided herein, the Merging Companies refer to the Law.

<i>Formalities

The Absorbing Company:
- shall carry out all legal and publication formalities relating to the contributions made in relation to the Merger,
- shall take on the statements and necessary formalities relating to all relevant administration matters in order to put

all assets acquired in its name,

- shall carry out any formalities in order to render the transfer of goods and rights that it has received opposable to

third parties.

<i>Delivery of titles

At the definitive realisation of the Merger, the Absorbed Companies will give the Absorbing Company the originals of

all their incorporating documents and amending deeds, as well as the books of account and other accounting documents,
titles of ownership or documentary acts of ownership of any assets, the supporting documents of the operations carried
out, securities and contracts, archives, vouchers and any other documents relating to the assets and rights transferred.

<i>Fees and Duties

Any charges, duties or fees owing as a result of the Merger will be met by the Absorbing Company.
If necessary, the Absorbing Company shall pay the taxes due by the Absorbed Companies on the capital and the profits,

for the fiscal years not yet taxed.

<i>Choice of the domicile

For the execution of the present deed and any subsequent ones or minutes which may arise as a result, and for any

supporting documents or notifications, the registered office of the Absorbing Company is chosen as domicile.

<i>Powers

All the powers are given to the bearer of an original or a copy of the present deed in order to carry out all formalities

and complete all statements, notifications, deposits, publications and other such matters.

In accordance with the provisions of article 271 (2) of the Law, the undersigned notary certifies the legality of the

present merger deed drawn up pursuant to article 261 of the Law.

<i>Costs and Declaration

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Absorbing Company

are estimated at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English text and the French translation, the English version will prevail.

After having read and interpreted the contents to the proxyholder of the appearing persons in a language he knows,

he, known to the Notary by his surname, first name, civil status and residence, has signed the present deed with the
Notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-trois août.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Tishman Speyer Valentinskamp L.P. S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son

siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113347, constituée par acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 14 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 675 en date du 3 avril 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte de Maître Francis Kesseler, prénommé, reçu en date du 9 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 1134 en date du 27 mai 2011, ayant un capital social entièrement libéré de vingt-

103211

L

U X E M B O U R G

trois millions quatorze mille sept cent soixante-quinze Euro (EUR 23.014.775,00), représenté par neuf cent vingt mille
cinq cent quatre-vingt-onze (920.591) parts sociales de vingt-cinq Euro (EUR 25,00) chacune (la Société Absorbante),

ici représentée par M. Richard Fauvel, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg, en vertu d'un mandat spécial accordé par le conseil de gérance de la Société Absorbante en date du 23 août
2012 (les Résolutions 1).

2. Tishman Speyer Brienner Strasse G.P. S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant

son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116067, constituée par acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, reçu en date du 21 avril 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1351 en date du 13 juillet 2006, et dont les statuts n'ont pas
été modifiés depuis, ayant un capital social entièrement libéré de douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,00), représenté
par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq Euro (EUR 25,00) chacune (la Société Absorbée 1),

ici représentée par M. Richard Fauvel, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg, en vertu d'un mandat spécial accordé par le conseil de gérance de la Société Absorbée en date du 23 août 2012
(les Résolutions 2).

3. Tishman Speyer Valentinskamp G.P. S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son

siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113348, constituée par acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, reçu en date du 14 décembre 2005, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 673 du 1 

er

 avril 2006, et dont les statuts ont été modifiés

pour la dernière fois par acte Maître Joseph Elvinger, précité, reçu en date du 5 septembre 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et des Associations numéro 2130 du 15 novembre 2006, ayant un capital social entièrement libéré
de douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq Euro (EUR
25,00) chacune (la Société Absorbée 2, ensemble avec la Société Absorbée 1, les Sociétés Absorbées),

ici représentée par M. Richard Fauvel, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg, en vertu d'un mandat spécial accordé par le gérant unique de la Société Absorbée en date du 23 août 2012 (les
Résolutions 3).

Une copie des Résolutions 1, des Résolutions 2 et des Résolutions 3, signées ne varietur par la personne comparante

et le notaire soussigné resteront annexées au présent acte en vue de leur dépôt auprès des autorités d'enregistrement.

La Société Absorbée 1, la Société Absorbée 2 et la Société Absorbante sont ci-après ensemble désignées comme les

Sociétés Fusionnantes et toutes sont soumises à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée
(la Loi).

Le comparant, agissant pour le gérant unique ou pour les conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes (les Conseils

de Gérance) ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion (le Projet de Fusion) en relation avec la fusion
entre la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées (la Fusion), qui suit:

PROJET DE FUSION

Les parts sociales de chacune des Sociétés Fusionnantes sont détenues à raison de cent pour-cent (100%) par un seul

et même associé.

Les Conseils de Gérance ont décidé de fusionner les Sociétés Absorbées dans la Société Absorbante et, à cet effet,

les  Sociétés  Absorbées  feront  apport  de  tous  leurs  avoirs  et  engagements  (les  Avoirs  et  Engagements)  à  la  Société
Absorbante.

Les Conseils de Gérance, reconnaissent que l'associé unique des Sociétés Fusionnantes est seul porteur des titres

conférant un droit de vote dans les Sociétés Fusionnantes et approuvent la décision de l'associé unique des Sociétés
Fusionnantes approuvant de (i) ne pas désigner un expert indépendant pour examiner le Projet de Fusion et de renoncer
au rapport d'expert, conformément à l'article 266 (5) de la Loi et (ii) de renoncer au rapport de gestion et aux informations
mentionnées à l'article 265 (2) de la Loi, conformément à l'article 265 (3) de la Loi.

La réalisation de la Fusion est conditionnée par l'approbation des assemblées générales extraordinaires respectives de

l'associé unique des Sociétés Fusionnantes du Projet de Fusion, conformément à la Loi.

La Fusion produira ses effets à la date à laquelle la Fusion sera approuvée par l'associé unique des Société Fusionnantes,

conformément à l'article 272 de la Loi (la Date d'Effet).

Est arrêté ce qui suit:
Sous la condition suspensive de l'approbation de la Fusion par les assemblées générales extraordinaires respectives de

l'associé unique des Sociétés Fusionnantes:

1. A la Date d'Effet de la Fusion, les Sociétés Absorbées transmettront de manière universelle et sans limitation ni

restriction tous les éléments actifs et passifs de leur patrimoine à la Société Absorbante, conformément aux articles 257
et suivants de la Loi.

2. A partir de la Date d'Effet, l'universalité des éléments actifs et passifs du patrimoine des Sociétés Absorbées sera

transférée à la Société Absorbante.

103212

L

U X E M B O U R G

L'actif et le passif transférés à valeur comptable à la Société Absorbante à la Date d'Effet sont évalués selon les comptes

annuels des Sociétés Absorbées arrêté au 31 décembre 2011.

3. En contrepartie de la transmission susmentionnée, la Société Absorbante n'émettra pas de parts sociales nouvelles

à l'associé unique des Sociétés Absorbées, nommément Tishman Speyer ESOF Holdings (Luxembourg) S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, un capital social d'un million trente-sept mille cinq cents Euro (EUR 1.037.500,00),
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113349 (l'Associé Uni-
que), mais enregistrera l'augmentation du prix d'acquisition des parts sociales des Sociétés Absorbées comme une réserve
exceptionnelle de la Société Absorbante et pour un montant correspondant au montant de l'actif net des Sociétés Ab-
sorbées au 31 décembre 2011. Il n'y aura pas de paiement en numéraire.

4.  Les  parts  sociales  des  Sociétés  Absorbées  sont  libres  de  toutes  sûretés,  privilèges  et  droit  de  rétention  ou  le

bénéficiaire de tels sûretés, privilèges ou droit de rétention a autorisé la Fusion.

5. Par l'effet de la Fusion, les Sociétés Absorbées cesseront d'exister de plein droit. Les parts sociales des Sociétés

Absorbées seront annulées. Les activités des Sociétés Absorbées seront reprises par la Société Absorbante.

6. Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a émis de titres à des non associés conférant à leur porteur un droit de vote

et donc aucune mesures particulières n'a été proposée ou prévue pour ces personnes.

7. Quitus sera donné aux gérants ou gérant unique des Sociétés Absorbées pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la

Date d'Effet.

8. Aucun avantage particulier n'a été consenti aux membres des Conseils de Gérance.
9. Les Sociétés Absorbées n'ayant pas d'employés, la Fusion restera sans conséquence sur l'emploi.
10. La Fusion sera également soumise aux termes et conditions suivants:
a. la Société Absorbante reprend les actifs transférés par les Sociétés Absorbées en l'état dans lequel ils se trouvent

à la Date d'Effet de la Fusion. La Société Absorbante ne peut émettre aucune prétention, à quelque titre que ce soit,
contre les Sociétés Absorbées ou l'Associé Unique;

b. les Sociétés Absorbées garantissent à la Société Absorbante l'existence de toutes les créances figurant au bilan, mais

n'assumeront aucune responsabilité quant à la solvabilité des débiteurs concernés;

c. à partir de la Date d'Effet de la Fusion, la Société Absorbante payera tous les impôts, taxes et redevances, ordinaires

et extraordinaires dont la Société Absorbante est ou pourra être redevable, eu égard à la propriété des actifs transférés;

d. la Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations et contrats des Sociétés Absorbées, à la condition qu'ils

existent à la Date d'Effet de la Fusion;

e. la Société Absorbante reprend en particulier l'intégralité des contrats existant avec les créanciers des Sociétés

Absorbées. La Société Absorbante sera subrogée dans tous leurs droits et obligations en découlant et ceci à ses propres
risques;

f. Les droits et parts sociales attachés aux actifs transférés par les Sociétés Absorbées seront transférés avec l'intégralité

des sûretés réelles et personnelles à la Société Absorbante. La Société Absorbante sera de ce fait subrogée, sans qu'il n'y
ait novation des contrats, dans tous les droits réels et personnels des Sociétés Absorbées, et ceci sans exception pour
tous les actifs et à l'égard de tous les débiteurs;

g. la Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations des Sociétés Absorbées, et en particulier, la Société

Absorbante sera redevable des intérêts et du capital de toutes dettes et obligations des Sociétés Absorbées. La Société
Absorbante décharge les Sociétés Absorbées de l'intégralité des voix et parts sociales se rapportant à des droits et
obligations possédés jusque-là par les Sociétés Absorbées;

h. la Société Absorbante renonce expressément à tous droits de privilège, d'hypothèque et action résolutoire qu'elle

détient envers les Sociétés Absorbées du fait de la reprise des droits et obligations de ces dernières, et dispense expres-
sément le bureau des hypothèques d'effectuer cette inscription ex officio lors de l'enregistrement du présent acte.

11.  D'un  point  de  vue  comptable,  la  Fusion  produira  ses  effets  à  partir  du  1  janvier  2012,  et  afin  d'éviter  toutes

incertitudes, les comptes annuels de la Société Absorbante pour la période commençant à cette date seront basés sur
les comptes annuels des trois Société Fusionnantes pour la période ayant terminée le 31 décembre 2012.

12. La Société Absorbante peut accomplir toutes formalités, y compris les publications prévues par la Loi, utiles ou

nécessaires à l'entrée en vigueur de la Fusion ou servant la transmission des actifs et passifs. Si prévu par la Loi, ou lorsque
cela peut servir la transmission des actifs et passifs, les actes translatifs seront accomplis par les Sociétés Fusionnantes
afin de garantir la transmission des actifs et passifs des Sociétés Absorbées vers la Société Absorbante.

13. Tout document, acte et registre des Sociétés Absorbées seront conservés au siège social de la Société Absorbante

pendant la durée prévue par la Loi.

14. Le projet de Fusion, les comptes annuels des trois derniers exercices ainsi que les comptes intérimaires au 30 juin

2012 des Sociétés Fusionnantes peuvent être consultés aux sièges sociaux respectifs des Sociétés Fusionnantes pendant
une période d'au moins un (1) mois avant les assemblées susmentionnées.

15. Pour tout point non prévu par les présentes, les parties se réfèrent à la Loi.

103213

L

U X E M B O U R G

<i>Formalités

La Société Absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales et de publication relatives aux apports effectués au titre de la Fusion,
- se chargera de toutes déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations compétentes pour faire

mettre à son nom les éléments d'actif apportés,

- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits reçus.

<i>Remise de titres

Lors de la réalisation définitive de la Fusion, les Sociétés Absorbées remettront à la Société Absorbante les originaux

de tous leurs documents constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables,
les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées,
les valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et
droits apportés.

<i>Frais et Droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.
La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par les Sociétés Absorbées sur le capital et les bénéfices

au titre des exercices non encore imposés définitivement.

<i>Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour

toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la Société Absorbante.

<i>Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et

faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, le notaire soussigné atteste de la légalité du présent

projet de fusion établi en application de l'article 261 de la Loi.

<i>Frais et Déclaration

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société Absorbante et

mis à sa charges à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euro (EUR 1.500,-).

Dont acte, passé à Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre
la version anglaise et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Après lecture faite au mandataire des comparantes et interprétation donnée en une langue de lui connue, le mandataire,

connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Fauvel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 août 2012. Relation: EAC/2012/11227. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de

Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Esch/Alzette, le 27 août 2012.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2012110995/349.
(120149597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

UniEuropaRenta, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 30. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012075865/10.
(120107040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2012.

103214

L

U X E M B O U R G

UniEM Fernost, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 30. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012075866/10.
(120107041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2012.

UniEM Global, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 30. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012075867/10.
(120107042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2012.

UniValueFonds: Global, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 30. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012075868/10.
(120107043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2012.

Lighthouse International Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.548.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-second day of August,
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Has appeared

Me Caroline Taudière, lawyer, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting as a special

attorney in fact of the company Lighthouse International Company S.A. (in administration (Regulation EC 1346/2000)), a
société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

incorporated following a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

of 27 June 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 833 of 13 August 2003 and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 94548 (the "Company").

The articles of association of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned

notary, of 24 July 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

by virtue of the powers conferred on her by the administrators of the Company on 21 August 2012 and as agreed by

resolutions adopted by the board of directors of the Company on 21 August 2012.

An extract of these resolutions having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed and be registered with which it shall be formalised.

The appearing person acting in his afore-mentioned capacity has requested the notary to record the following decla-

rations and facts:

1 That the issued share capital of the Company is presently set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided

into fifteen thousand five hundred (15,500) shares (the "Shares") having a nominal value of two euro (EUR 2.-) each.

103215

L

U X E M B O U R G

2 That pursuant to Article 5 of the Company's articles of association, the authorised share capital of the Company has

been fixed at two hundred million euro (EUR 200,000,000.-) divided into one hundred million (100,000,000) Shares with
a nominal value of two euro (EUR 2.-) each.

3 That the board of directors, in its meeting of 21 August 2012 and in accordance with the authority conferred on it

pursuant to Article 5 of the Company's articles of association, has decided (i) to convert all the one hundred ninety-five
million (195,000,000) convertible bonds having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, issued by the Company and
governed by the terms and conditions dated 21 August 2012 (the "Convertible Notes"), and (ii) to increase the Company's
share capital by an amount of one hundred ninety-five million euro (EUR 195,000,000.-) by the creation of ninety-seven
million five hundred thousand (97,500,000) new shares having a nominal value of two euro (EUR 2.-) each, in connection
with the conversion of all the Convertible Notes which are thus converted (the "Conversion").

4 That the Company has received the report drawn up by Ernst &amp; Young S.A., réviseur d'entreprises agréé, having its

registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and signed by Mr. Bruno
DI BARTOLOMEO on 21 August 2012 (the "Report") wherein the Convertible Notes, including their conversion, is
described and valued. That the conclusion of the Report reads as follows:

"Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the total value of the

contribution as described above which corresponds at least in number and in value to the nominal value of the Convertible
Notes to be issued and the shares into which the Convertible Notes are convertible, assuming a conversion on the date
of this report".

5 That as a consequence, the board of directors, in its meeting dated 21 August 2012 has confirmed the Conversion

and has approved the increase of the share capital of the Company from its current amount of thirty-one thousand euro
(EUR 31,000.-) to one hundred ninety-five million thirty-one thousand euro (EUR 195,031,000.-) by way of issuance of
ninety-seven million five hundred thousand (97,500,000) new shares, having a nominal value of two euro (EUR 2.-) each.

6 That as a consequence of the above mentioned issue of shares, with effect as of 22 August 2012, paragraph one (1)

of Article 5 of the articles of association is therefore amended and shall read as follows:

Art. 5. Share Capital - Authorized Capital. The Company has a share capital of one hundred ninety-five million thirty-

one thousand euro (EUR 195,031,000.-) divided into ninety-seven million five hundred fifteen thousand five hundred
(97,515,500) shares with a par value of two euro (EUR 2.-) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at EUR 6,600.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-deux août,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu

Me Caroline Taudière, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant comme mandataire spécial de la société Lighthouse International Company S.A. (en procédure d'insolvabilité

(Règlement CE 1346/2000)), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 46A, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

constituée suivant acte de Maître Jacques Delvaux, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

le 27 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 833 du 13 août 2003 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94548 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, le 24 juillet 2012, en cours

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

en vertu d'une procuration qui lui a été conférée par les administrateurs de la Société le 21 août 2012 et tel que décidé

par résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 21 août 2012.

Un extrait desdites résolutions, après avoir été signé «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Le comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et consta-

tations suivantes:

103216

L

U X E M B O U R G

1 Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en quinze

mille cinq cents (15.500) actions (les «Actions»), ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

2 Qu'en vertu de l'Article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à deux cents millions

d'euros (EUR 200.000.000,-) divisé en cent millions (100.000.000) d'Actions, ayant une valeur nominale de deux euros
(EUR 2,-) chacune.

3 Que le conseil d'administration, lors de sa réunion en date du 21 août 2012 et conformément au pouvoir qui lui est

conféré par l'Article 5 des statuts de la Société, a décidé (i) de convertir l'ensemble des cent quatre-vingt-quinze millions
(195.000.000) d'obligations convertibles, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, émises par la Société
et régies par les termes et conditions en date du 21 août 2012 (les «Obligations Convertibles»), et (ii) d'augmenter le
capital social de la Société à concurrence de cent quatre-vingt-quinze millions euros (EUR 195.000.000,-) par émission
de quatre-vingt-dix-sept millions cinq cents mille (97.500.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euros
(EUR 2,-) chacune, en rapport avec la conversion de toutes les Obligations Convertibles qui sont ainsi converties (la
«Conversion»).

4 Que la Société a reçu le rapport établi par Ernst &amp; Young S.A., réviseur d'entreprises agréé, ayant son siège social

à 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et signé par M. Bruno DI BARTOLOMEO
le 21 août 2012 (le «Rapport») dans lequel les Obligations Convertibles, y compris leur conversion, sont décrites et
valorisées. Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

«Sur base du travail effectué et décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale de l'apport

tel que décrit ci-dessus qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des Obligations Convertibles à émettre
et aux actions dans lesquelles les Obligations Convertibles sont convertibles, en supposant une conversion à la date du
présent rapport».

5 Qu'en conséquence, le conseil d'administration, lors de sa réunion en date du 21 août 2012 a confirmé la Conversion

et a approuvé l'augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de trente et un mille
euros (EUR 31.000,-) à cent quatre-vingt-quinze millions trente-et-un mille euros (EUR 195.031.000,-) par l'émission de
quatre-vingt-dix-sept millions cinq cents mille (97.500.000) nouvelles actions, ayant une valeur nominale de deux euros
(EUR 2,-) chacune.

6 Que suite à l'émission des actions susvisée, avec effet à compter du 22 août 2012, l'alinéa un (1) de l'Article 5 des

statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Capital Social - Capital Autorisé. La Société a un capital social de cent quatre-vingt-quinze millions trente et

un mille euros (EUR 195.031.000) divisé en quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent quinze mille cinq cents (97.515.500)
actions, ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune."

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués

à EUR 6.600.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; et qu'à la demande du même comparant
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg par le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant a

signé avec le notaire soussigné le présen acte.

Signé: C. Taudière et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 août 2012. LAC/2012/39751. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2012.

Référence de publication: 2012109764/129.
(120148776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2012.

UniValueFonds: Europa, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 30. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

103217

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 2. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012075869/10.
(120107044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2012.

La Paix Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 300.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 171.066.

STATUTS

L'an deux mille douze, le neuf août.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BSSD S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 62, Avenue de la Liberté, ici représentée par son
administrateur unique Madame Isabelle DILLENBOURG.

Lequel comparant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée

qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les comparants une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LA PAIX

IMMOBILIERE S.à r.l. ("la Société"), régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
ultérieurement ("la Loi") ainsi que par les statuts tels qu'établis par acte constitutif et tels que modifiés ultérieurement,
le cas échéant ("les Statuts").

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à la ville de Luxembourg.
Il peut être transféré à toute autre adresse de la même municipalité par simple résolution de la Gérance. Il peut être

transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par l'assemblée générale statuant comme en matière
de modification des statuts.

Art. 3. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition ou la

cession d'immeubles ainsi que la mise en location, l'administration, la gestion, et le développement de ces immeubles.

La Société a également comme objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à la réalisation et au développe-

ment de son objet social. L'énumération qui précède doit être interprétée de la façon la plus large.

La société peut emprunter sous toutes les formes, donner en hypothèque et procéder à l'émission d'obligations, de

reconnaissance de dettes ou tout autre instrument de dette similaire.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. Le décès ou la faillite d'un associé n'entraîne pas la dissolution

de la Société.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR300.000,-) représenté par trois cents (300) parts sociales

sans valeur nominale, libérées intégralement.

Les parts sociales sont et resteront nominatives. Le capital souscrit peut être augmenté ou, le cas échéant, réduit par

l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, respectant les conditions prévues par la Loi.

Art. 6. La gestion de la Société appartient à un ou plusieurs gérant(s) ("la Gérance"), associé(s) ou non, nommé(s) par

l'assemblée générale pour une durée illimitée ou limitée. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par les associés représentant au minimum les trois quarts du capital social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale relèvent de la Gérance.
La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la

signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

La Gérance peut déléguer la représentation de la Société à un ou plusieurs employés ou conférer des mandats spéciaux

ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes de son choix.

Art. 7. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 8. La Gérance établit les comptes annuels tels que prévus par la Loi. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé

cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque
la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale.

103218

L

U X E M B O U R G

Art. 9. La Gérance peut verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des conditions prévues par la Loi.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans
cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

Art. 10. La Société peut être dissoute en observant les conditions requises par la Loi. Lors de la dissolution de la

Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés
par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales ont été souscrites par:

1) BSSD S.A., prénommée, 300 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Total: trois cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de trois cent mille euros

(EUR 300.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la Loi ont été entièrement accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros (EUR
1.900,-).

<i>Résolutions

La comparant prénommée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée,

s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes à

l'unanimité:

1. La Gérance est composée d'un seul gérant (1).
2. Est nommé gérant pour une durée illimitée:
- Madame Isabelle DILLENBOURG, enseignante, née le 08 mars 1967 à Bastogne (Belgique), résidant à B-6700 Arlon,

129, route de Toernich.

- La Société est engagée par la seule signature du gérant unique.
3. L'adresse de la société est fixée au 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé la présente minute avec le notaire.
Signé: I. Dillenbourg et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 août 2012. LAC/2012/38581.Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2012.

Référence de publication: 2012110294/91.
(120149050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

UniDividendenAss, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 30. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012075870/10.
(120107045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2012.

103219

L

U X E M B O U R G

UniProfiAnlage (2015), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012075871/10.
(120107046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2012.

UniProfiAnlage (2027), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012080858/10.
(120113381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

UniProfiAnlage (2025), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012080859/10.
(120113382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

CP Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 250.000,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 170.034.

COMMON DRAFT TERMS OF THE MERGER

THE BOARD OF MANAGERS / BOARD OF DIRECTORS OF:
CP Finance Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company ("Société à responsabilité limitée"), incorporated

under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B170034
("CP Luxembourg"); and

Canadian  Pacific  Hungary  Szolgáltató  Zártköroen  Muködo  Részvénytársaság,  a  private  company  limited  by  shares

("zártköruen muködo részvénytársaság"), having its registered office at 1074 Budapest, Dohány u 12. -, Hungary, registered
with the Budapest Metropolitan Court acting as a Court of Registration under number Cg.01-10-044282 ("CP Hungary");

Hereby agree on the following merger project (the "Project").
CP Luxembourg and CP Hungary are jointly referred to as the "Merging Companies".

WHEREAS:

In accordance with Article 261 and following of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on Commercial Companies,

as amended (the "Luxembourg Law") and in accordance with Article 3 of Act CXL of 2007 on the cross border merger
of limited liability companies (the "Hungarian Cross Border Merger Act") and Article 79(1) of Act IV of 2006 on Business
Associations (the "Hungarian Companies Act") (the Hungarian Cross Border Merger Act and the Hungarian Companies
Act together the "Hungarian Laws"), the management boards of CP Luxembourg and of CP Hungary have together
established the following common terms of the cross-border merger in order to specify the terms and conditions of such
merger and declared that:

- each of CP Hungary and CP Luxembourg has one part-time employee;

103220

L

U X E M B O U R G

- the common draft terms of the merger will be registered with the Luxembourg Trade and Companies Register and

published in the Luxembourg official gazette ("Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations"), in accordance
with Articles 262 and 9 of the Luxembourg Law;

- the common draft terms of the merger will as well be submitted to the Budapest Metropolitan Court acting as a

Court of Registration and published in the Hungarian Companies Gazette in accordance with Article 5(1) of the Hungarian
Cross Border Merger Act and Article 79(5) of the Hungarian Companies Act;

- the financial year of CP Hungary runs from January 1 

st

 up to and including December 31 

st

 and the first financial year

of CP Luxembourg runs from July 5 

th

 , 2012 up to and including December 31 

st

 , 2012;

- in accordance with the Luxembourg Law and the Hungarian Laws, CP Hungary will cease to exist and CP Luxembourg

will acquire all the assets and all the liabilities of CP Hungary under an universal title of succession, under the following
terms and conditions.

1. Title of succession. According to Article 274 and following of the Luxembourg Law and Article 81 of the Hungarian

Companies Act, at the Effective Date (as defined under paragraph 18 below); CP Luxembourg will acquire by operation
of law all assets and liabilities of CP Hungary, being qualified as merger by absorption, such that at the Effective Date:

- all of the assets of CP Hungary shall be vested in CP Luxembourg and shall thereafter be the property of CP Lux-

embourg;

- CP Luxembourg shall be liable for all the obligations of CP Hungary;
- CP Hungary will cease to exist; and
- CP Hungary shall hand over to CP Luxembourg the originals of all its incorporating documents, deeds, amendments,

contracts/agreements and transaction documentation of any kind, as well as the bookkeeping and related archive and any
other accounting documents, titles of ownership or documentary titles of ownership of any assets, the supporting docu-
ments of the operations carried out, securities and contracts, archives, vouchers and any other documents relating to
the assets and rights as existing as at the Effective Date.

2. Form, Corporate denomination and Registered office of the Merging Companies.
2.1 CP Luxembourg
CP Finance Luxembourg S.à r.l. is a private limited liability company ("Société à responsabilité limitée"), having its

registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B170034.

Its issued share capital amounts to two hundred fifty thousand United States Dollars (USD 250,000) and is divided into

two thousand five hundred (2,500) shares having a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100) each.

Its one hundred percent (100%) shareholder is 3939804 Canada Inc., a company duly incorporated and existing under

the Canada Business Corporation Act, having its registered office at Suite 920, 401 - 9 

th

 Avenue, S.W., Calgary AB, T2P

4Z4, Canada and registered under the Company number 393980-4.

2.2 CP Hungary
Canadian Pacific Hungary Szolgáltató Zártköroen Muködo Részvénytársaság is a private company limited by shares,

having its registered office at 1074 Budapest, Dohány u 12., Hungary, registered with the Budapest Metropolitan Court
acting as a Court of Registration under number Cg. 01-10-044282.

It has been incorporated pursuant to a deed of foundation executed on 7 January 2000.
Its currently registered share capital amounts to one hundred and thirty-seven million, four hundred and eighty-eight

thousand nine hundred and six point nine three US Dollars (USD 137,488,906.93) and is divided into

(a) 229,571 registered printed "A" series ordinary shares having a nominal value of USD 298.91 each;
(b) 153 registered printed "B" series ordinary shares having a nominal value of USD 813-84 each;
(c) 24,000 registered printed "C" series shares conferring preferential voting rights having a nominal value of USD

298.91 each; and

(d) 205,980 registered printed "D" series shares conferring preferential dividend rights having a nominal value of USD

298.91 each.

On 25 May 2012 the sole shareholder of CP Hungary resolved to
- decrease the registered capital of CP Hungary by twenty six million five hundred thousand six hundred and eight

point zero two US Dollars (USD 26,500,608.02) to one hundred and ten million nine hundred and eighty-eight thousand
US Dollars (USD 110,988,000); and

- restructure the type, classes and series of the shares issued by CP Hungary by exchanging the Series A, B, C and D

shares for 'A' series shares having a nominal value of USD 1,000 each.

The above changes are under registration.
Its one hundred percent (100%) shareholder is 3939804 Canada Inc., a company duly incorporated and existing under

the Canada Business Corporation Act, having its registered office at Suite 920, 401 - 9 

th

 Avenue, S.W., Calgary AB, T2P

4Z4, Canada and registered under the Company number 393980-4.

103221

L

U X E M B O U R G

2.3 Articles of Association of CP Luxembourg
The articles of association of CP Luxembourg were notarised by a deed of Me Carlo Wersandt, notary, residing in

Luxembourg, dated July 5 

th

 , 2012, under process of publication in the Mémorial.

The current text of, and the proposed amendment to, the articles of association of CP Luxembourg is attached to this

Project according to Article 261 (4) a, of the Luxembourg Law and Article 79(1) d of the Hungarian Companies Act.

The articles of association of CP Luxembourg shall not be amended in connection with the merger between CP Finance

Luxembourg and CP Hungary, except in their article 5 to reflect the change of the issued capital.

3. Motives and Purposes of the merger.
3.1 Reasons for the merger.
The management boards of both CP Luxembourg and CP Hungary consider the merger necessary in order to simplify

the current structure of the group to which they belong while providing greater financial stability in light of the current
Eurozone crisis.

3.2 Expected consequences for the activities.
The business activities of CP Hungary will be continued unchanged by CP Luxembourg.
3.3 Explanation from a legal, economic and social point of view.
By means of the proposed merger CP Hungary will cease to exist and CP Luxembourg will acquire the assets and

liabilities of CP Hungary under a universal title of succession. An important contribution to the realisation of the objects
of the business is expected from the proposed integration of the organisation of CP Hungary and the organisation of CP
Luxembourg. Special consequences for the organisation are not expected.

4. Conditions. In order to fulfill the above-mentioned purposes, this merger shall operate the global transfer of assets

and liabilities of CP Hungary to CP Luxembourg, as follows:

a) CP Luxembourg will become the owner of the assets received from CP Hungary, in the same conditions that they

are at the date of the transfer, and registered for the same amounts as they are registered in the balance sheet of CP
Hungary without any right of claim for any reason against CP Hungary;

b) CP Hungary covenants to CP Luxembourg that the credits assigned through this merger are certain but do not

assume any guarantee concerning the solvency of the assigned debtors;

c) CP Luxembourg will liquidate, from the Effective Date, all the taxes, contributions, income, insurances and any

others duties, ordinary or extraordinary, which are able to burden the assigned assets;

d) CP Luxembourg will perform any agreements and appointments of any nature of CP Hungary existing at the effective

date of the merger;

e) The rights and credits existing in the assets of CP Hungary will be transferred to CP Luxembourg with any related

fixed charges or personal guarantees. CP Luxembourg will be subrogated, without novation, on all personal and rights
"in rem" of CP Hungary related to all assets and against any debtors, without exception, within the terms set forth in the
balance;

f) CP Luxembourg will assume any obligation and debt of any nature of CP Hungary, namely paying the principal and

interest of any debts and obligations of any nature of CP Hungary;

g) The merger is not subject to any conditions or condition subsequent, beyond those that arise from the applicable

Luxembourg and Hungarian laws.

5. Proposed measures in connection with the conversion of the shareholdership.
5.1 Share exchange ratio
As a consequence of the transfer by the operation of the Luxembourg Law of all the assets and liabilities of CP Hungary

by Way of merger to CP Luxembourg, CP Luxembourg will issue to the holders of shares of CP Hungary existing on that
day 1.75 shares of CP Luxembourg for 1 share of CP Hungary (the "Share Exchange Ratio").

As a consequence of this operation on the Effective Date:
- CP Luxembourg shall increase its share capital by an amount of $19,422,900 by the issuance of 194,229 new shares

having a nominal value of $100 USD together with a merger premium corresponding to the remaining of the counterpart
of the assets and liabilities of CP Hungary;

- CP Luxembourg shall allocate to the shareholder of CP Hungary the newly issued shares in accordance with the

applicable Share Exchange Ratio; and

- CP Luxembourg shall amend article 5 of its articles of association to reflect the change of its issued share capital.
5.2 Date as from which the newly issued shares shall carry the rights to participate in the profits
The newly issued shares shall be entitled to any distribution made as of the Effective Date.
5.3 Terms of the delivery of the shares in CP Luxembourg
As a consequence of the merger, CP Hungary will be dissolved without liquidation, and the shares representing its

entire share capital will be extinguished.

103222

L

U X E M B O U R G

Upon the Effective Date, the shareholder of CP Hungary shall automatically receive newly issued shares of CP Lux-

embourg issued according to the Share Exchange Ratio. This new issuance shall then be reflected in the shareholders
register of CP Luxembourg.

The shares of CP Hungary shall be cancelled on the Effective Date.
The valuation of the assets of CP Hungary will be done on the Effective Date.

6. Treatment of special rights. There exist no special rights for the shareholders of CP Luxembourg. In particular, no

special rights will be: granted to individual shareholders in connection with the present merger. There are no special
measures intended, proposed or planned to those persons.

7. Special advantages or benefits. No special benefits will be granted to the auditors, or to members of administrative,

management, supervisory or controlling boards of any of the Merging Companies. In particular, no such benefits will be
granted in connection with the present merger.

8. Repercussions of the cross border merger on employment. There are likely no repercussions of the merger on the

employment of CP Luxembourg since CP Luxembourg will continue in the same conditions the employment contracts
of its sole part-time employee. The services of the sole part-time employee of CP Hungary will no longer be required
once the merger is effected, as referred to in Article 261 (4) b, of the Luxembourg Law and in Article 3(1) c, of the
Hungarian Cross-Border Merger Act.

9. Information on the procedures by which arrangements for the involvement of employees in the definition of their

rights to participation in CP Luxembourg are determined. The information on the procedures, by which arrangements
for the involvement of employees in the definition of their rights to participation in the Merging Companies are determined
as referred to in Article 261 (4) c, of the Luxembourg Law and in Articles 3(1) h and 10(1) the Hungarian Cross-Border
Merger Act, is relevant since each of CP Luxembourg and CP Hungary has one part-time employee. All the procedures
provided by the Luxembourg laws and the Hungarian Laws in relation with the participation of employees in CP Luxem-
bourg will be respected.

10. Information on the valuation of the assets and Liabilities which are transferred to CP Luxembourg. For accounting

purposes, the assets and liabilities of CP Hungary will be booked in the balance sheet of CP Luxembourg at book value
as at the Effective Date, as referred to in Article 261 (4) d, of the Luxembourg Law.

11. Dates of the Merging Companies' accounts of assets and Liabilities used to establish the conditions of the cross

border merger. The conditions of the cross border merger have been determined by reference to:

- the interim account situation as of July 31 

st

 , 2012 (including the balance sheet, the profit and loss statements) of

CP Luxembourg, as per Article 261 (4) e, of the Luxembourg Law;

- the audited situation as of July 31 

st

 , 2012 (including the balance sheet, the profit and loss statements) of CP Hungary

as per Article 73 of the Hungarian Companies Act.

12. Creditors' claims.
12.1  According  to  the  management  boards  of  the  Merging  Companies,  the  creditors  of  CP  Luxembourg  and  CP

Hungary will not be affected by the merger.

12.2 According to Article 268 of the Luxembourg Law, the creditors of the Merging Companies, whose claims predate

the date of publication of the deeds recording the merger may, notwithstanding any agreement to the, contrary, apply
within two months to the competent court to obtain adequate safeguard of collateral for any matured and unmatured
debts, where the merger would make such protection necessary.

12.3 According to Article 76(2) of the Hungarian Companies Act, the creditors of the Merging Companies, whose

claims predate the date of the first publication of the merger in the Hungarian Companies Gazette, may claim security
from the Merging Companies within 30 days of the date of the second publication of the merger in the Hungarian,
Companies Gazette. The Merging Companies agree that the publication of the notices to creditors in the Hungarian
Companies Gazette will be initiated by CP Hungary.

13. Availability of the merger documentation at the registered offices. The documents referred to in Article 267 (1)

a, b, c and d, of the Luxembourg Law and Article 5(3) of the Hungarian Cross-Border Merger Act, in particular:

- the common draft terms of the merger;
- the annual accounts and the management report for the last three financial years (2009, 2010 and 2011) of CP Hungary;
- the interim audited accounts of CP Hungary as at July 31 

st

 , 2012;

- the interim accounts of CP Luxembourg as at July 31 

st

 , 2012; and

- the explanatory reports of the management boards of the Merging Companies;
will be made available for the inspection of the shareholder(s) and employees at the registered offices of the Merging

Companies.

According to Article 266 (5) of the Luxembourg Law and Article 4(5) of the Hungarian Cross-Border Merger Act,

neither an examination of the common draft terms of the merger by independent experts nor an expert report is required

103223

L

U X E M B O U R G

since the shareholders of the Merging Companies have so agreed on August 7 

th

 , 2012 (CP Luxembourg) and August 9

th

 , 2012 (CP Hungary).

14. Intentions involving continuance or termination of activities. The activities of CP Hungary, as referred to in Clause

V of its deed of foundation, will be continued by CP Luxembourg.

15. Intentions with regard to the composition of the management board of CP Luxembourg after the cross border

merger. The present composition of the management board of CP Luxembourg, being as follows:

- M. Patrick Damian WARDE, born in Galway (Ireland), on February 19 

th

 , 1950, residing privately at 22, Siggy vu

Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Mr. Gregpr David DALRYMPLE, born in Edinburgh, on May 16 

th

 , 1960, residing at 18b, rue de la Chapelle, L-8017

Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg; and

- M. Sébastien Jean-Jacques Joseph Ghislain FRANCOIS, born in Libramont-Chevigny (Belgium), on December 4 

th

 ,

1980, with professional address at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

will remain in place unchanged pursuant to the merger.

16. Perfection condition of the common draft terms of the merger. The board of managers / board of directors of the

Merging Companies approved this common draft terms of the merger on August 9 

th

 , 2012 (CP Luxembourg) and August

13 

th

 , 2012 (CP Hungary).

17. Approval of the resolution to effect the cross border merger. The resolution to merge will be adopted by the

general meetings of shareholders of the Merging Companies and is not subject to any approval by another corporate
body of any of the Merging Companies or by any other third party.

18. Effective date of the merger. The merger shall take effect between the Merging Companies on the day on which

the EGM of CP Luxembourg will approve the merger (the "Effective Date").

19. Effective accounting date of the merger. The transactions of CP Hungary are treated, for accounting purposes, as

being those of CP Luxembourg as of the Effective Date.

20. Costs. The costs of the Project and its execution shall be borne by CP Luxembourg. In case the merger will not

become effective, CP Luxembourg shall bear the costs of all parties in connection with the preparation and implementation
of the merger as well as in connection with the Project.

21. Miscellaneous. Should any provision of this Project be or become ineffective, impracticable or unenforceable, the

effectiveness of the other provisions shall remain unaffected. Instead, the parties hereby undertake to replace the inef-
fective, impracticable or unenforceable provision by a provision which comes as close as legally possible to what the
Merging Companies intended from an economic point of view in accordance with the content and purpose of the inef-
fective, impracticable or unenforceable provision. The same shall apply to any omissions.

Exclusive place of jurisdiction for all claims arising from or in connection with this Project shall be the legal seat of CP

Luxembourg to the extent permissible by law.

CP Finance Luxembourg S.à r.l.
Represented by Patrick Damian WARDE / Sébastien FRANCOIS / Gregory DALRYMPLE
<i>Category A Manager / Category B Manager / Category A Manager

On 13.08.2012. Budapest

Canadian Pacific Hungary Szolgáltató Zártköroen Muködo Részvénytársaság
CP Hungary
Represented by Dr. László Csontos / Dr. Kálmán Gyárfás
<i>Member of the Board of Directors / Member of the Board of Directors

Suit la traduction française du texte qui précède:

PROJET COMMUN DE FUSION

LE CONSEIL DE GERANCE / CONSEIL D'ADMINISTRATION DE:
CP Finance Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170034 ("CP Luxembourg"); et

Canadian  Pacific  Hungary  Szolgáltató  Zártköroen  Muködo  Részvénytársaság,  une  société  à  responsabilité  limitée

("zártköruen muködo részvénytársaság"), ayant son siège social au 1074 Budapest, Dohány u 12., Hungary, immatriculée
auprès de la Budapest Metropolitan Court agissant comme Cour de Registre sous le numéro Cg.01-10-044282 ("CP
Hongrie");

Conviennent par la présente du projet de fusion suivant (le "Projet").

103224

L

U X E M B O U R G

CP Luxembourg et CP Hongrie sont dénommées, ci-après, les "Sociétés Fusionnantes".
ENTENDU QUE:
Conformément aux Articles 261 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée (ci-après la "Loi Luxembourgeoise") et conformément à l'Article 3 de l'Act CXL de 2007 sur la fusion trans-
frontalière des sociétés à responsabilité limitée (la "Loi Hongroise sur la fusion transfrontalière") et à l'Article 79(1) de
l'Act  IV  de  2006  sur  les  Associations  d'Affaires  (la  "Loi  Hongroise  sur  les  sociétés")  La  Loi  Hongroise  sur  la  fusion
transfrontalière et la Loi Hongroise sur les sociétés formant ensemble les "Lois Hongroises"), les organes de gestion de
CP Luxembourg et de CP Hongrie ont ensemble rédigé le présent projet de fusion transfrontalière en vue de préciser
les termes et conditions de cette fusion et ont déclaré que:

- CP Luxembourg et CP Hongrie ont chacune un employé à mi-temps;
- le projet commun de fusion sera déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié

dans le journal officiel luxembourgeois ("Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations"), conformément aux
Articles 262 et 9 de la Loi Luxembourgeoise;

- le projet commun de fusion sera également déposé auprès du Budapest Metropolitan Court agissant comme Cour

de Registre et publié dans la Hungarian Companies Gazette, conformément à l'Article 5(1) de la Loi Hongroise sur la
fusion transfrontalière et à l'Article 79(5) de la Loi Hongroise sur les sociétés;

- l'exercice comptable de CP Hongrie court à partir du 1 

er

 Janvier jusqu'au 31 Décembre inclus et le premier exercice

comptable de CP Luxembourg court à partir du 5 Juillet 2012 jusqu'au 31 Décembre 2012 inclus;

- conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux Lois Hongroises, CP Hongrie cessera d'exister et CP Luxembourg

reprendra l'universalité de tous les actifs et passifs de CP Hongrie, selon les termes et conditions qui suivent.

1. Titre de succession. Conformément aux Articles 274 et suivants de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 81 de la

Loi Hongroise sur les sociétés, à la Date d'Effet (telle que définie au paragraphe 18 ci-dessous), CP Luxembourg acquerra
de plein droit l'ensemble du patrimoine actif et passif de CP Hongrie, cette opération étant qualifiée de «fusion par
absorption», de telle sorte qu'à la Date d'Effet:

- l'ensemble des actifs de CP Hongrie sera transmis à CP Luxembourg et deviendra par conséquent la propriété de

CP Luxembourg;

- CP Luxembourg deviendra responsable de toutes les obligations de CP Hongrie;
- CP Hongrie cessera d'exister; et
- CP Hongrie transmettra à CP Luxembourg les originaux de tous les documents de constitution, actes, amendements,

contrats/accords et documents relatifs à toute sorte d'opérations, ainsi que les documents, livres de comptes et tout
autre document comptable; les titre de propriété ou titres documentant la détention d'actifs quelconques; toute docu-
mentation relative aux opérations effectuées, obligations et contrats, archives, reçus et tout autre document relatif aux
actifs et aux droits existants à la Date d'Effet.

2. Forme, Dénomination sociale et Siège social des Sociétés Fusionnantes.
2.1. CP Luxembourg
CP Finance Luxembourg S.à r.l. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grande-Duché de Luxembourg, immatriculé auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous lé numéro B 170034.

Le montant de son capital social s'élève à deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 250.000),

divisé en deux mille cinq cents (2.500) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent dollars (USD 100) chacune.

Son actionnaire unique (100%) est 3939804 Canada Inc., une société valablement constituée et ayant son siège social

Suite 920, 401 - 9 

th

 Avenue, S.W., Calgary AB, T2P 4Z4 Canada, et immatriculée auprès du Canada Business Corporation

Act, sous le numéro 393980-4.

2.2. CP Hongrie
Canadian Pacific Hungary Szolgáltató Zártköroen Muködo Részvénytársaság, une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social au 1074 Budapest, Dohány u 12., Hongrie, immatriculée auprès de la Budapest Metropolitan Court agissant
comme Cour de Registre sous le numéro Cg.01-10-044282.

Elle à été constituée en vertu d'un acte de constitution passé le 7 janvier 2000.
Le montant actuel de son capital social s'élève à cent trente-sept millions quatre-cent quatre-vingt-huit mille neuf cent

six Dollars des Etats-Unis d'Amérique et quatre-vingt-treize cents (USD 137.488.906,93) et est divisé en

(a) deux cent vingt-neuf mille cinq cent soixante-et-onze (229,571) actions ordinaires de classe A, ayant une valeur

nominale  de  deux  cent  quatre-vingt-dix-huit  Dollars  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  quatre-vingt-onze  centimes  (USD
298.91) chacune;

(b) cent cinquante-trois (153) actions ordinaires de classe B, ayant une valeur nominale de huit cent treize Dollars des

Etats-Unis d'Amérique et quatre-vingt-quatre centimes (USD 813.84) chacune;

(c) vingt-quatre mille (24,000) actions préférentielles de classe C, ayant une valeur nominale de deux cent quatre-vingt-

dix-huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique et quatre-vingt-onze centimes (USD 298.91) chacune; et

103225

L

U X E M B O U R G

(d) deux cent cinq mille neuf cent quatre-vingts (205,980) actions préférentielles de classe D, ayant une valeur nominale

de deux cent quatre-vingt-dix-huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique et quatre-vingt-onze centimes (USD 298.91) cha-
cune.

Le 25 mai 2012, l'actionnaire unique de CP Hongrie a décidé de
- réduire le montant du capital social de CP Hongrie de vingt-six millions cinq cent mille six cent huit Dollars des Etats-

Unis d'Amérique et deux cents (USD 26.500.608,02) pour atteindre un montant de capital de cent dix millions neuf cent
quatre-vingt-huit mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 110.988.000); et

- restructurer le type, les classes et les séries d'actions émises par CP Hongrie en échangeant les classes d'actions A,

B, C et D pour une classe 'A' d'actions ayant une valeur nominale de mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.000)
chacune.

Les changements ci-dessus sont en cours d'enregistrement.
Son associé unique (à 100%) est 3939804 Canada Inc., une société en commandite par actions ayant son siège social

Suite 920, 401 - 9 

th

 Avenue, S.W., Calgary AB, T2P 4Z4 Canada et immatriculée auprès du Canada Business Corporation

Act, sous le numéro 393980-4.

2.3. Les statuts de CP Luxembourg
Les statuts de CP Luxembourg ont été consignés dans un acte de Me Carlo Wersandt, notaire, résidant à Luxembourg,

le 5 Juillet 2012, en cours de publication au Mémorial.

La version actuelle des statuts et leur modification proposée se trouvent annexées à ce Projet, conformément à l'Article

261 (4) a, de la Loi luxembourgeoise et à l'Article 79(1) de la Loi Hongroise sur les sociétés.

Les statuts de CP Luxembourg ne seront pas modifiés suite à la fusion entre CP Finance Luxembourg et CP Hungary,

à l'exception de l'article 5 pour refléter le changement du montant de son capital social.

3. Motifs et Objectifs de la fusion.
3.1 Motifs de la fusion
Les organes de gestion de CP Luxembourg et CP Hongrie considèrent la fusion nécessaire à la simplification de la

structure actuelle du groupe auquel elles appartiennent tout en assurant une plus grande stabilité financière dans un
contexte de crise de la zone euro.

3.2 Conséquences attendues pour les activités
Les activités commerciales de CP Hongrie seront poursuivies de manière inchangée par CP Luxembourg.
3.3 Explications d'un point de vue légal, économique et social
Par le biais de la fusion proposée, CP Hongrie cessera d'exister et CP Luxembourg acquerra l'universalité des actifs

et passifs de CP Hongrie. Une contribution importante à là réalisation des objets de l'entreprise est attendue de l'inté-
gration de l'organisation proposée par CP Hongrie et CP Luxembourg. Des conséquences particulières au niveau de
l'organisation ne sont pas attendues.

4. Conditions. Afin de remplir les objectifs susmentionnés, cette fusion doit opérer le transfert de l'ensemble des actifs

et passifs de CP Hongrie à CP Luxembourg, comme suit:

a) CP Luxembourg deviendra la propriétaire des actifs reçus de CP Hongrie, dans les mêmes conditions que celles qui

existaient à la date du transfert, elle les enregistrera à son bilan à la même valeur que celle reflétée dans le bilan de CP
Hongrie, sans possibilité de recours de toute sorte à l'encontre de CP Hongrie;

b) CP Hongrie assurera à CP Luxembourg que les créances transférées suite à cette fusion sont certaines, mais elle

ne donnera aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs transférés;

c) CP Luxembourg prendra en charge, à partir de la Date d'Effet, tous les impôts, cotisations, revenus, assurances et

toute autre obligation, ordinaire ou extraordinaire, qui sont en mesuré de grever les actifs transférés;

d) CP Luxembourg assumera tous les contrats et engagements de toute nature de CP Hongrie existant à la Date d'Effet

de la fusion;

e) Les droits et les créances figurant à l'actif de CP Hongrie seront transférés à CP Luxembourg avec tous les frais

fixes ou garanties personnelles y attachés. CP Luxembourg sera subrogée, sans novation, pour tout droit réel et personnel
"in rem" de CP Hongrie en relation avec tous les actifs et contre tous les débiteurs, sans exception, selon les termes
énoncés dans le bilan;

f) CP Luxembourg assumera toutes les obligations et dettes de toute nature de CP Hongrie, notamment le paiement

du principal et des intérêts de toutes ses dettes et obligations;

g) La fusion n'est soumise à aucune autre condition présente ou future, au-delà de celles prévues par la Loi Luxem-

bourgeoise et les Lois Hongroises.

5. Modalités proposées concernant la conversion de l'actionnariat.
5.1. Rapport d'échange des actions

103226

L

U X E M B O U R G

En conséquence du transfert de plein droit selon la Loi Luxembourgeoise de tous les actifs et passifs de CP Hongrie

à CP Luxembourg, CP Luxembourg émettra en faveur des actionnaires de CP Hongrie existant à ce jour 1,75 action de
CP Luxembourg pour 1 action de CP Hongrie (le «Rapport d'Echange»).

En conséquence de la fusion, à la Date d'Effet:
- CP Luxembourg augmentera son capital social d'un montant de dix-neuf millions quatre-cent vingt-deux mille neuf

cents Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 19.422.900) par l'émission de cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent
vingt-neuf (194.229) nouvelles actions ayant une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100)
chacune, avec une primé de fusion correspondant au resté de la contrepartie des actifs et passifs de CP Hongrie;

- CP Luxembourg allouera à l'actionnaire de CP Hongrie les actions nouvellement émises en accord avec le Rapport

d'Echange applicable; et

- CP Luxembourg modifiera l'article 5 de ses statuts pour refléter le changement du montant de son capital social.
5.2. Date à partir de laquelle les actions nouvellement émises donneront droit à participer aux profits
Les actions nouvellement émises donneront droit à toute distribution faite à compter de la Date d'Effet.
5.3. Conditions de délivrance des actions de CP Luxembourg
En conséquence de la fusion, CP Hongrie sera dissolue sans liquidation et les actions représentant son capital en entier

seront annulées.

A compter de la Date d'Effet, l'actionnaire de CP Hongrie recevra automatiquement des actions nouvellement émises

de CP Luxembourg, émises conformément au Rapport d'Echange. Cette nouvelle émission devra donc être reflétée dans
le registre d'actionnaires de CP Luxembourg.

L'évaluation des actifs de CP Hongrie sera faite à la Date d'Effet.

6. Traitement des droits spéciaux. Les actionnaires de CP Luxembourg ne détiennent pas de droits particuliers. En

particulier, aucun droit spécial ne sera accordé aux actionnaires individuels dans le cadre de la présente fusion. Aucune
mesure spéciale ne leur sera proposée ou planifiée.

7. Avantages spécifiques ou bénéfices.  Aucun  avantage  spécial  ou  bénéfice  ne  sera  accordé  aux  auditeurs  ou  aux

membres des conseils d'administration, de gestion, de supervision ou de contrôle des Sociétés Fusionnantes. En parti-
culier, aucun avantage spécial ou bénéfice ne sera accordé dans le cadre de la présente fusion.

8. Répercussions de la fusion transfrontalière sur l'emploi. La fusion n'aura aucune répercussion sur l'emploi dans les

Sociétés Fusionnantes, CP Luxembourg poursuivant dans les mêmes conditions l'exécution du contrat de travail de son
unique employé à mi-temps. Les services de l'unique employé à mi-temps de CP Hongrie ne seront plus nécessaires une
fois la fusion opérée, conformément à l'Article 261 (4) b, de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 3(1) c, de la Loi
Hongroise sur la fusion transfrontalière.

9. Information sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition

de leurs droits de participation dans CP Luxembourg sont déterminées. L'information sur les procédures selon lesquelles
les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans les Sociétés
Fusionnantes sont déterminés, conformément à l'Article 261 (4) d, de la Loi luxembourgeoise et aux Articles 3(1) h, et
10(1) de la Loi hongroise sur la fusion transfrontalière, est pertinente car les Sociétés Fusionnantes ont chacune un salarié
à mi-temps. Toutes les procédures prévues par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et de la Hongrie relatives à la
participation des salariés dans CP Luxembourg seront respectées.

10. Information sur l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à CP Luxembourg. À des fins comptables, les

actifs et passifs de CP Hongrie seront comptabilisés dans le bilan de CP Luxembourg à leur valeur comptable à la Date
d'Effet, conformément à l'Article 261 (4) d, de la Loi Luxembourgeoise.

11. Dates des comptes d'actif et de passif des Sociétés Fusionnantes utilisés pour définir les conditions de la fusion

transfrontalière. Les conditions de la fusion transfrontalière ont été. déterminées sur la base de:

- la situation comptable intérimaire au 31 juillet 2012 (incluant le bilan, le compte de profits et pertes) de CP Luxem-

bourg, conformément à l'Article 261 (4) e, de la Loi Luxembourgeoise;

- la situation comptable auditée au 31 juillet 2012 (incluant le bilan, le compte de profits et pertes) de CP Hongrie,

conformément à l'Article 73 de la Loi Hongroise sur les sociétés.

12. Recours des créanciers.
12.1. Selon les organes de gestion des Sociétés Fusionnantes, les créanciers de CP Luxembourg et de CP Hongrie ne

seront pas affectés par la fusion.

12.2. Conformément à l'Article 268 de la Loi Luxembourgeoise, les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont les

créances sont antérieures à la date de publication des actes Constatant la fusion, peuvent, nonobstant toute convention
contraire, demander dans les deux mois de cette publication au tribunal compétent la constitution de sûretés et garanties
adéquates pour toutes créances échues ou non échues, dans le cas où la fusion rendrait une telle protection nécessaire.

12.3. Conformément à l'Article 76(2) de la Loi Hongroise sur les sociétés, les créanciers des Sociétés Fusionnantes,

dont les créances sont antérieures à la date de la première publication de la fusion dans la Hungarian Companies Gazette,

103227

L

U X E M B O U R G

peuvent demander des garanties aux Sociétés Fusionnantes dans les 30 jours de la date de la seconde publication de la
fusion dans la Hungarian Companies Gazette. Les Sociétés Fusionnantes sont d'accord sur le fait que la publication des
avis aux créanciers dans la Hungarian Companies Gazette sera faite à l'initiative de CP Hongrie.

13. Disponibilité des documents de fusion aux sièges sociaux. Les documents dont il est fait référence à l'Article 267

(1) a, b, c et d, de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 5(3) de la Loi Hongroise sur la fusion transfrontalière, en particulier:

- le projet commun de fusion;
- les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion de CP Hongrie pour les trois derniers exercices (2009, 2010 et

2011);

- une situation comptable intérimaire auditée de CP Hongrie, arrêtée à la date du 31 juillet 2012;
- une situation comptable intérimaire de CP Luxembourg, arrêtée à la date du 31 juillet 2012; et
- les rapports explicatifs des organes de gestion des Sociétés Fusionnantes;
seront tenus à disposition pour consultation des actionnaire et employés au siège social des Sociétés Fusionnantes.
Conformément à l'Article 266(5) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 4(5) de la Loi Hongroise sur la fusion

transfrontalière, ni un examen du projet commun de fusion par des experts indépendants ni un rapport d'experts ne sont
requis suite à la décision des associés des Sociétés Fusionnantes le 7 août 2012 (CP Luxembourg) et le 9 août 2012 (CP
Hongrie).

14. Intentions sur la continuité ou fin des activités. Les activités de CP Hongrie, telles que visées à la Clause V de son

acte de constitution, seront poursuivies par CP Luxembourg.

15. Intentions concernant la composition du conseil de gérance de CP Luxembourg après la fusion transfrontalière.

La composition actuelle du conseil de gérance de CP Luxembourg, se présentant comme suit:

- Monsieur Patrick Damian WARDE, né à Galway (Irlande), le 19 février 1950, résidant professionnellement au 22,

Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Gregor David DALRYMPLE, né à Edinburgh (Royaume-Uni), le 16 mai 1960, résidant au 18b, rue de la

Chapelle, L-8017 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Sébastien Jean-Jacques Joseph Ghislain FRANÇOIS, né à Libramont-Chevigny (Belgique), le 4 décembre

1980, résidant professionnellement au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

restera en place, inchangée, à la suite de la fusion.

16. Condition de réalisation du projet commun de fusion. Le conseil de gérance / conseil d'administration des Sociétés

Fusionnantes ont approuvé ce projet commun de fusion le 9 août 2012 (CP Luxembourg) et le 13 août 2012 (CP Hongrie).

17. Approbation de la décision de réaliser la fusion transfrontalière. La décision de fusionner sera adoptée par les

assemblées générales des actionnaires des Sociétés Fusionnantes et n'est sujet à aucune approbation par un autre organe
de l'une des Sociétés Fusionnantes ou par toute autre tierce partie.

18. Date d'effet de la Fusion. La fusion deviendra effective entre les Sociétés Fusionnantes à la date de l'assemblée

générale extraordinaire des actionnaires de CP Luxembourg approuvant la fusion (la "Date d'Effet").

19. Date comptable effective de la fusion. Les opérations de CP Hongrie sont traitées comptablement comme étant

celles de CP Luxembourg à partir de la Date d'Effet.

20. Coûts. Les coûts du Projet et de son exécution seront supportés par CP Luxembourg. Dans le cas où la fusion ne

deviendrait pas effective, CP Luxembourg supportera tous les coûts relatifs à la préparation et à la mise en place de la
fusion ainsi que tous ceux relatifs au Projet.

21. Divers. Le fait que l'une des clauses du Projet est ou deviendrait caduque, inapplicable ou non exécutoire, n'affec-

terait en rien les autres clauses. Dans ce cas, les parties s'engagent à remplacer la clause caduque, inapplicable ou non
exécutoire par une clause qui se rapproche le plus d'un point de vue légal de l'intention des Sociétés Fusionnantes d'un
point de vue économique, et conformément au contenu et au but de cette clause caduque, inapplicable ou non exécutoire.
La même règle s'applique en cas d'omission.

La juridiction effective en cas de litige pour toutes les contestations relatives au Projet sera le lieu du siège social de

CP Luxembourg, dans la mesure autorisée par la loi.

CP Finance Luxembourg S.à r.l.
Représentée par Patrick Damian WARDE / Sébastien FRANCOIS / Gregor DALRYMPLE
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B / Gérant de Catégorie A

103228

L

U X E M B O U R G

On 13.08.2012. Budapest

Canadian Pacific Hungary Szolgáltató Zártköroen Muködo Részvénytársaság
CP Hongrie
Représentée par Dr. László Csontos / Dr. Kálmán Gyárfás
<i>Membre du Conseil d'Administration / Membre du Conseil d'Administration

PROJET DE STATUTS COORDONNES

Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object

Art. 1. Form - Name. There is hereby established a company with limited liability ("société á responsabilité limitée ")

governed by Luxembourg law, under the name of CP Finance Luxembourg S.à r.l. (hereinafter referred to as the "Com-
pany").

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred

within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the sole manager or, in case of a plurality of managers, by
resolution of the board of managers of the Company.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal

activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxem-
bourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the
Company.

Art. 4. Corporate Object. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any com-

mercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through
participation, contribution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group of companies the Company
is part of, any assistance of whatever kind including but not limited to financial assistance, loans, advances, securities or
guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,

bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore,
as well as the lending of money;

- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-

marks or other similar interests;

- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and

certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Title II. Capital - Shares

Art. 5. Share Capital. The subscribed corporate capital is set at nineteen million six hundred seventy-two thousand

nine hundred US-Dollars (USD 19,672,900) represented by one hundred ninety-six thousand seven hundred and twenty-
nine (196,729) shares with a par value of one hundred US-Dollars (USD 100) each.

The share capital may be increased or decreased by a decision of the sole shareholder or by a resolution of the

shareholders, as the case may be.

103229

L

U X E M B O U R G

Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of

shares in existence.

A shareholders' register shall be kept by the Company at its registered office. The shareholders' register shall mention

the name, the profession and the address of each shareholder as notified by that shareholder to the Company, the number
of the shares held by each shareholder and, as the case may be, the date and details of any share transfer or conversion.
Each shareholder shall notify in writing to the Company its address and any change thereof.

The ownership of the shares will be evidenced by the inscription in the Shareholders' register.

Art. 6. Transfer of Shares. If the Company has at least two shareholders, the corporate shares are freely transferable

between the shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to non-shareholders is subject to the consent

given in a general meeting of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In case of a sole shareholder, the shares of the Company are freely transferable to non-shareholders.
In the case of the death of a shareholder, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of share-

holders representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving shareholders. In this case,
however, the approval is not required if the shares are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or
to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the

Company.

Art. 7. Redemption of Shares. The Company may redeem its own shares subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholder(s).

Title III. General Meetings of Shareholders

Art. 8. Power of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall rep-

resent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
all acts relating to the activity of the Company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole shareholder

or by a majority of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital. The shareholders may change
the nationality of the Company by a unanimous decision.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be made by written

resolution, the text of which shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by facsimile or e-mail. The
shareholders shall cast their vote by signing the written resolution.

The decisions of the shareholders, as the case may be, are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Art. 9. Vote. Each share entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to such share until one person has been appointed as the sole
owner vis-a-vis the Company.

Art. 10. Single Shareholder. If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the powers

of the general meeting.

The resolutions of the sole shareholder which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes

or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole shareholder and the Company represented by him are recorded

on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered
into under normal conditions.

Art. 11. Annual general meeting. Each year, the annual general meeting of the shareholders or of the sole shareholder,

as the case may be, approving the annual accounts shall be held within six (6) months after the close of the accounting
year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Title IV. Management

Art. 12. Board of managers. The Company is managed by a board of managers composed of at least one (I) A manager

and one (1) B manager, either shareholders or not.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, fix the term

of their office as well as their remuneration. They shall hold office until their successors are elected.

103230

L

U X E M B O U R G

The managers may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting.
In the event of one or more vacancies in the board of managers because of death, retirement or otherwise, the

remaining managers may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.

Art. 13. Meetings. The board of managers may choose from among its shareholders a chairman. It may also choose a

secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of

meeting.

The board of Managers will ordinarily meet semi-annually.
Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least seventy-two

(72) hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature
of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate

notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the board of managers.

Any manager may be represented at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram,

telex, telefax or by e-mail another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex, telefax or by e-mail.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or telefax.

At any meeting of the board of managers the board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority

of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the managers present or represented at such meeting.

Art. 14. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman,

or, in his absence, by the chairman pro tempore, who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 15. Powers. The board of managers or the sole manager, as the case may be, is vested with the broadest powers

to perform all acts of administration and disposition on behalf and in the interest of the Company.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the

board of managers.

The board of managers or the sole manager may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of

the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general
meeting of shareholders, to any manager or managers of the board or to any committee (the shareholders of which need
not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board or the sole manager shall determine.
It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all
officers and employees, and fix their emoluments.

Art. 16. Representation. The Company will be validly bound towards third parties by the joint signatures of either (i)

two (2) A managers or (ii) one (1) A manager plus one (1) B manager or by the signature of the sole manager, as the case
may be.

The Company will be bound by the joint signature of any two (2) persons to whom such signatory power shall have

been delegated by the Board of managers.

Art. 17. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations

of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.

Title V. Accounts

Art. 18. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall

terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year.

Art. 19. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers

or the sole manager as at the end of each financial year and will be at the disposal of the shareholders at the registered
office of the Company.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of shareholders.

103231

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the

expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of shareholders represents the
net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account

of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share
capital of the Company.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of shareholders, which may resolve:
- (i) to pay a dividend to the shareholders proportionally to the shares they hold or
- (ii) to carry them forward or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve, account of the Company.
Notwithstanding the above, the shareholders may resolve to pay interim dividends on the future net profit of the

current financial year provided that:

(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the shareholders;
(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts

showing that sufficient assets are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the shareholders according to the annual general

meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Company towards the shareholders.

The above provisions exist without prejudice to the right of the general meeting of shareholders to distribute at any

moment to the shareholders any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts.

Title VI. Winding up - Liquidation - Miscellaneous

Art. 21. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators (who may be physical persons or legal entities), appointed by the meeting of shareholders resolving such
dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or of one of the shareholders will

not bring the Company to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the shareholders propor-

tionally to the shares they hold in the Company.

Art. 22. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Titel I. Form - Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Form - Name. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), die

dem Luxemburger Recht unterliegt, unter der Bezeichnung CP Finance Luxembourg S.à r.l. (nachstehend die "Gesell-
schaft" genannt), gegründet.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft besteht auf unbeschränkte Zeit.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Er kann innerhalb der Stadt Luxemburg

durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführung
verlegt werden.

Er kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gesellschafterversamm-

lung  verlegt  werden.  Niederlassungen  oder  andere  Büros  können  sowohl  in  Luxemburg  als  auch  im  Ausland  durch
Beschluss der Geschäftsführung gegründet werden.

Sollten sich Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art zugetragen haben oder imminent werden,

welche die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland, wie durch die Geschäftsführung bestimmt, gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend,
bis zur Beendigung dieser anormalen Zustände, ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen be-
einflussen in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des
Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden von der Ge-
schäftsführung ergriffen und allen betroffenen Parteien mitgeteilt.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen, unter welcher Form auch immer, in jedem

kaufmännischen, industriellen, finanziellen oder anderen Luxemburger oder ausländischen Unternehmen zu halten; sämt-
liche Wertpapiere und Rechte durch Beteiligung, Einlage, Optionsrecht oder auf sonstige Art und Weise zu erwerben.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen nutzen, um es in Grundbesitz zu investieren, um ihre Aktiva, wie sie von Zeit zu

Zeit zusammengesetzt sind, nämlich aber nicht beschränkt auf ihr Portfolio von Wertpapieren jeglichen Ursprungs, zu

103232

L

U X E M B O U R G

errichten, verwalten, auszubauen und darüber zu verfügen, um sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von
Unternehmen zu beteiligen, um durch Investition, Zeichnung, Unterzeichnung oder Optionsrecht, Wertpapiere und alle
Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, sie durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder sonstwie zu veräußern, um
Lizenzen für Rechte des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren und den Gesellschaften, oder zum Nutzen
der Gesellschaften, in welchen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung hält, sowie der Gruppe von Gesellschaften
der die Gesellschaft angehört, jede Unterstützung jeglicher Art, einschließend aber nicht beschränkt auf finanzielle Un-
terstützung, Darlehen, Vorschüsse, Sicherheiten oder Garantien zu gewähren.

Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit des Gesellschaftsobjektes, kann die Gesellschaft noch folgendes unterneh-

men:

- der Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Tausch, Übertragung, Handel und Investition in und Abtretung von Anteilen,

Anleihen,  Fonds,  Noten,  Schuldtitel  und  anderen  Wertpapieren,  die  Aufnahme  von  Darlehen  und  die  Ausgabe  von
Schuldscheinen hierfür, sowie Darlehen gewähren;

- der Erwerb von Einkommen als Folge der Verfügung oder Lizenzerteilung von Urheberrechten, Patenten, Mustern,

geheimen Verfahren, eingetragenen Marken oder anderen ähnlichen Interessen;

- die Gewährung von technischer Unterstützung;
- die Beteiligung in und der Geschäftsführung von anderen Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Anleihen, Noten, Wertpapiere, Schuldverschreibungen

und Bescheinigungen privat ausgeben, vorausgesetzt, dass sie nicht frei übertragbar sind und, dass sie nur in eingetragener
Form ausgegeben werden.

Die Gesellschaft kann alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Geschäftsvorgänge, welche unmittelbar oder

mittelbar die oben genannten Bereiche betreffen, durchführen, um die Erfüllung des Gesellschaftszwecks zu vereinfachen.

Allgemein kann die Gesellschaft jede Handlung unternehmen, welche sie für die Erfüllung und die Förderung ihres

Gesellschaftszwecks für nötig erachtet.

Titel II. Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt neunzehn Millionen sechshundertzweiund-

siebzigtausendneunhundert US-Dollar (USD 19.672.900), eingeteilt in einhundertsechsundneunzigtausendsiebenhundert-
neunundzwanzig  (196.729)  Gesellschaftsanteile  mit  einem  Nennwert  von  einhundert  US-Dollar  (USD  100).  Das
Gesellschaftskapital  kann  durch  Beschluss  des  alleinigen  Gesellschafters  oder  durch  Beschluss  der  Gesellschafterver-
sammlung erhöht oder herabgesetzt werden, wie der Fall auch sein mag.

Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur Zuteilung eines Teils der Aktiva und des erzielten Gewinnes der Gesellschaft

im direkten proportionalen Verhältnis zu der Zahl der bestehenden Gesellschaftsanteile.

Die Gesellschaft hat ein Gesellschafterregister an ihrem eingetragenen Sitz zu führen. Das Anteilsregister soll den

Namen, den Beruf und die Adresse eines jeden Gesellschafters gemäß der von diesen zu machenden Angaben beinhalten
sowie die Anzahl der Gesellschaftsanteile, welche von jedem Gesellschafter gehalten werden und gegebenenfalls das
Datum und Details einer jeden Übertragung und Umwandlung eines Gesellschaftsanteils erwähnen. Jedwede Änderung
der oben genannten Angaben ist der Gesellschaft an ihrer Adresse durch den entsprechenden Gesellschafter schriftlich
mitzuteilen.

Das Eigentum an den Gesellschaftsanteilen wird durch die Eintragung in das Gesellschafterregister bescheinigt.

Art. 6. Anteilübertragung. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Gesellschaftsanteile frei

unter den Gesellschaftern übertragbar.

Im Falle mehrerer Gesellschafter, ist die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschaf-

ter abhängig von der in einer Hauptversammlung getätigten Zustimmung der Gesellschafter, die darin mindestens drei
Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Im Falle eines alleinigen Gesellschafters, sind die Gesellschaftsanteile frei zugunsten Nicht-Gesellschafter übertragbar.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Nicht-Gesellschafter von der Zu-

stimmung der Gesellschafter abhängig, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter
vertreten. In diesem Fall jedoch, ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte
oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Ge-

sellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen.

Art. 7. Erwerb der Anteile durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Bedingungen

ihre eigenen Anteile erwerben.

Der Erwerb und die Verfügung durch die Gesellschaft von und über Anteile, die sie in ihrem eigenen Gesellschaftskapital

hält, soll aufgrund eines Beschlusses unter den Fristen und Bedingungen der Gesellschafterversammlung stattfinden.

103233

L

U X E M B O U R G

Titel III. Gesellschafterversammlung

Art. 8. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung wird

die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Hand-
lungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesell-

schafterversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.

Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Bestimmungen gegenwärtiger Satzung können jederzeit durch Beschluss des

alleinigen Gesellschafters oder der Mehrheit, der Gesellschafter, welche mindestens 3/4 des Gesellschaftskapitals ver-
treten,  abgeändert  werden.  Die  Gesellschafter  können  die  Nationalität  der  Gesellschaft  durch  einen  einstimmigen
Beschluss ändern.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.

Soweit die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, können Entscheidungen mittels schrift-

licher Beschlüsse gefasst werden. Der Wortlaut schriftlicher Beschlüsse ist allen Gesellschaftern schriftlich, sei es im
Original oder mittels Fax oder Email, zuzustellen. Die Gesellschafter geben hierbei ihre Stimme durch Unterzeichnung
der schriftlichen Beschlüsse ab.

Die Entscheidungen der Gesellschafter, soweit diese getroffen wurden, sind in Protokollen oder schriftlich aufzusetzen.

Art. 9. Stimmrecht. Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in ordentlichen und außerordentlichen

Gesellschafterversammlungen.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Gesellschaftsanteil anerkennen; falls sich ein Anteil im Besitz

von mehr als einer Person befindet, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Gesell-
schaftsanteils aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen zu der Gesellschaft benannt wurde.

Art. 10. Alleiniger Gesellschafter. Wenn die Gesellschaft nur über einen Gesellschafter verfügt, so übt dieser alleinige

Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.

Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, die im Bereich des ersten Absatzes gefasst werden, werden protokolliert

oder schriftlich niedergelegt.

Ebenfalls werden die Verträge, welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der von ihm vertretenen Gesellschaft

eingegangen werden, protokolliert oder schriftlich niedergelegt. Dennoch ist diese letzte Vorschrift für laufende Ge-
schäfte, die unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden, nicht anwendbar.

Art. 11. Jahreshauptversammlung der Gesellschafter. Jedes Jahr soll die jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter

oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters zur Abnahme der Jahresabschlüsse innerhalb von sechs (6) Monaten
nach Ende des Geschäftsjahres am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen in der Versammlungsein-
ladung genannten Ort abgehalten werden.

Titel IV. Geschäftsführung

Art. 12. Geschäftsführer / Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch eine Geschäftsführung geleitet, die sich aus

mindestens einem (1) A Geschäftsführer und einem (1) B Geschäftsführer, die Gesellschafter sein können, zusammensetzt.

Die Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, die ihre Zahl bestimmt, die

Dauer ihres Amtes, sowie ihre Vergütung festlegt. Sie halten das Amt inne, bis ihre Nachfolger gewählt sind.

Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Begründung (ad nutum), durch Beschluss der Hauptversammlung

ihres Amtes enthoben werden.

Im  Falle  einer  oder  mehrerer  Vakanzen  in  der  Geschäftsführung,  aufgrund  Todes,  Ruhestandes  oder  dergleichen,

können sich die verbleibenden Geschäftsführer entschließen, eine solche Vakanz, in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Gesetzes, zu besetzen. In diesem Fall bestätigt die Hauptversammlung die Wahl im Rahmen seiner folgenden
Sitzung.

Art. 13. Versammlungen. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie kann

weiterhin einen Sekretär ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der für das Anfertigen der Sitzungsprotokolle
der Geschäftsführung und der Gesellschafter verantwortlich ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer an dem

Ort zusammen, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Die Geschäftsführung versammelt sich ordentlich im halbjährigen Turnus.
Schriftliche oder mündliche Einberufungen zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern min-

destens zweiundsiebzig (72) Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden
Fällen, wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in der Einberufung genannt werden muss.

Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durch jeden Geschäftsführer ver-

zichtet werden. Gesonderte Einberufungen sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten

103234

L

U X E M B O U R G

gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbeschluss ge-
nehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Telegramm, Telex,

Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per Kabeltelegramm, Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durchgeführt

werden.

Schriftliche Beschlüsse, welche von allen Geschäftsführern genehmigt und unterschrieben worden sind, haben dieselben

Auswirkungen wie Beschlüsse, welche im Rahmen von Geschäftsführerversammlung getroffen worden sind. Die Unter-
zeichnung kann hierbei auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses erfolgen
und mittels Brief oder Telefax nachgewiesen werden.

Die Geschäftsführung kann im Rahmen einer jeden Geschäftsführerversammlung nur dann wirksam beraten und han-

deln,  wenn  mindestens  eine  Mehrheit  von  Geschäftsführern  bei  der  Sitzung  der  Geschäftsführung  anwesend  oder
vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der, bei einer Sitzung anwesenden oder vertretenen,
Geschäftsführer getroffen.

Art. 14. Protokolle der Sitzungen. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von dem Vorsitzenden

unterzeichnet oder, in dessen Abwesenheit, durch den kommissarischen Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung
übernommen hat.

Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, welche zur Vorlage in Rechtsstreitigkeiten oder in sonstiger Weise

vorgelegt werden können, werden von dem Vorsitzenden und dem Sekretär oder zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 15. Befugnisse. Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer, soweit dies gegeben ist, verfügt über die

weitestgehenden Befugnisse jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft
vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen

in die Zuständigkeit der Geschäftsführung oder des alleinigen Geschäftsführers.

Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer können ihre Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsfüh-

rung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solcher Geschäftsführung
und Angelegenheiten, mit vorherigem Einverständnis der Gesellschafterversammlung an einen oder mehrere Geschäfts-
führer oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen)
übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die von dem alleinigen Geschäftsführer oder von der Ge-
schäftsführung festgelegt werden, beraten und beschließen. Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung kann
ebenfalls jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein
muss, übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und deren Bezüge festsetzen.

Art. 16. Vertretung. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift entweder (i) von zwei (2) A Geschäfts-

führern oder (ii) einem A Geschäftsführer und einem B Geschäftsführer oder des gegebenenfalls vorhandenen alleinigen
Geschäftsführers verpflichtet.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von jeglichen zwei (2) Personen verpflichtet, an die eine

solche Zeichnungsbefugnis durch die Geschäftsführung delegiert wurde.

Art. 17. Haftpflicht. Die Geschäftsführer sind, in Ausübung ihres Mandats, für die Verpflichtungen der Gesellschaft nicht

persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen
obliegenden Pflichten.

Titel V. Abschlüsse

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird am ersten Januar eines jeden Jahres beginnen und am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres enden, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres.

Art. 19. Jahresabschluss. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den alleinigen Geschäftsführer oder die

Geschäftsführung ein Jahresabschluss, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und den Gesellschaftern am Sitz
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Der Jahresabschluss wird anschließend der jährlichen Gesellschafterversammlung vorgelegt.

Art. 20. Gewinne, Rücklagen und Dividenden. Das Guthaben der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der Kosten,

Ausgaben, Tilgungen und Provisionen, so, wie von der jährlichen Gesellschafterversammlung gebilligt, stellt den Reinge-
winn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft zur Bildung der gesetzlichen

Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen Rücklage endet, wenn die Rücklage
einen Betrag erreicht hat, der zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft entspricht.

Die verbleibenden Gewinne werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verwendet, welche beschließen

kann,

- den Gesellschaftern Dividenden entsprechend den von Ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteilen, auszuzahlen oder

103235

L

U X E M B O U R G

- (ii) sie vorzutragen oder
- (iii) sie zu einem anderen verteilbaren Rücklagenkonto der Gesellschaft zu übertragen.
Ungeachtet des oben angeführten, können die Gesellschafter beschließen, Vorschüsse auf Dividenden auf dem komm-

enden Reingewinn des aktuellen Geschäftsjahres auszuzahlen, vorausgesetzt, dass:

(i) der Jahresabschluss des vergangenen Geschäftsjahres ordnungsgemäß durch einen Beschluss der Gesellschafter

gebilligt wurde;

(ii) die Vorschüsse auf Dividenden innerhalb von zwei (2) Monaten nach der Aufstellung des Zwischenabschlusses

durch die Gesellschafter, welches beurkundet, dass genügend Mittel zur Verfügung stehen, ausgezahlt werden;

Wenn die ausgezahlten Vorschüsse auf Dividenden den laut der jährlichen Gesellschafterversammlung endgültig ver-

teilbaren  Betrag  übersteigen,  wird  der  Überschuss  nicht  als  ausgezahlte  Dividende  berücksichtigt,  sondern  als  eine
unverzüglich fällige Forderung der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern.

Die obengenannten Bestimmungen bestehen, unbeschadet des Rechts der Gesellschafterversammlung den Gesell-

schaftern zu jedem Zeitpunkt jeden sich aus den vorigen Geschäftsjahren beziehenden und übertragenen Reingewinn oder
jede, von verteilbaren Rücklagenkonten stammende Beträge auszuzahlen.

Titel VI. Auflösung - Liquidation - Verschiedenes

Art. 21. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator

(en) (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung
ernannt werden, welche über diese Auflösung entscheidet und deren Befugnisse und Vergütungen festlegt.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder

eines der Gesellschafter, werden in keiner Weise die Beendigung der Gesellschaft zur Folge haben. Nach Abschluss der
Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft im Verhältnis, entsprechend den Gesellschaftsanteilen, die sie halten, den
Gesellschaftern zugeteilt.

Art. 22. Verschiedenes. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung geregelt sind, gelten die Bestimmungen

des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

Référence de publication: 2012110016/870.
(120148763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2012.

UniProfiAnlage (2024), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012080860/10.
(120113383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

UniProfiAnlage (2023), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012080861/10.
(120113384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

Cogeco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5810 Hesperange, 43, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 102.047.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit l'adresse du siège social figurant dans l'en-tête des publications de mentions de bilans,

à la page 53280 du Mémorial C n° 1110 du 2 mai 2012, à la page 46304 du Mémorial C n° 965 du 11 mai 2011 et à la
page 92981 du Mémorial C n° 1938 du 5 octobre 2009:

au lieu de: «L-5810 Bettembourg, 43, rue de Bettembourg»,

103236

L

U X E M B O U R G

lire: «L-5810 Hesperange, 43, rue de Bettembourg».
Référence de publication: 2012110504/12.

UniProfiAnlage (2021), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012080862/10.
(120113385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

UniProfiAnlage (2020), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012080863/10.
(120113386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

UniProfiAnlage (2019), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012080864/10.
(120113387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

UniProfiAnlage (2017/6J), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012080865/10.
(120113388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

ACM Bernstein Value Investments, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié concernant le fonds commun de placement ACM Bernstein Value Investments a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2012110030/9.
(120148869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

UniProfiAnlage (2017), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

103237

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 3. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012080866/10.
(120113389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

UniProfiAnlage (2016), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012080867/10.
(120113390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

UniProfiAnlage (2015/II), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 29. Juni 2012 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2012.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012080868/10.
(120113391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2012.

Lighthouse International Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.548.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2012.

Référence de publication: 2012109271/10.
(120147543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.

Lighthouse International Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.548.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2012.

Référence de publication: 2012109765/10.
(120148789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2012.

Centralis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 113.474.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire tenue à Luxembourg le 30 juin 2011

1) L'assemblée a décidé de renouveler jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires devant statuer

sur les comptes au 31 décembre 2011, le mandat des administrateurs suivants:

- Monsieur Laurent GODINEAU, administrateur de sociétés, né à Cholet (France) le 17 juin 1973, demeurant pro-

fessionnellement au L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, en sa qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de
la Société,

103238

L

U X E M B O U R G

- Monsieur François BROUXEL, avocat à la cour, né à Metz (France) le 16 septembre 1966, demeurant profession-

nellement au L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en sa qualité d'administrateur et de président du conseil
d'administrateur de la Société,

- Maître Samia RABIA, avocat à la cour, née à Longwy (France) le 10 février 1974, demeurant professionnellement au

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en sa qualité d'administrateur de la Société,

- Maître Pierre METZLER, avocat à la cour, né à Luxembourg (Luxembourg) le 28 décembre 1969, demeurant pro-

fessionnellement au L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en sa qualité d'administrateur de la Société,

- Maître Michel BULACH, avocat à la cour, né à Metz (France) le 06 avril 1974, demeurant professionnellement au

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en sa qualité d'administrateur de la Société,

2) L'assemblée a décidé de renouveler jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires devant statuer

sur les comptes au 31 décembre 2011, le mandat du réviseur d'entreprises Audit&amp;Compliance.

3) L'assemblée a pris acte de la démission de Maître Georges GUDENBURG de son mandat d'administrateur avec

effet au 1 

er

 septembre 2010, et, a décidé de ne pas le remplacer.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Registre de Commerce

et des Sociétés.

Référence de publication: 2012110502/28.
(110120940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

D.E.H. Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 10.013.517,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 62.815.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012098124/11.

(120134576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Electroengine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1240 Luxembourg, 18, rue Charles Bernhoeft.

R.C.S. Luxembourg B 164.386.

RECTIFICATION

Le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare

par les présentes que dans l'acte de constat d'augmentation de capital reçu par son ministère, en date du 6 juillet 2012,
enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juillet 2012, relation LAC/2012/32327, déposé au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012, référence L120123480 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1836 du 23 juillet 2012, pour compte de la société anonyme "ELECTROENGINE S.A.", établie et
ayant son siège social à L-1240 Luxembourg, 18, rue Charles Bernhoeft, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 164386,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:
IL Y A LIEU DE LIRE:

Version anglaise:

"  Art. 5. (First paragraph).  The  Company  has  an  issued  capital  of  ONE  MILLION  ONE  HUNDRED  SIXTY-ONE

THOUSAND FIVE HUNDRED NINETY-EIGHT EUROS AND TWENTY-FIVE CENTS (1,161,598.25 EUR), divided into
THIRTEEN MILLION SIX HUNDRED AND TWO THOUSAND TWO HUNDRED AND THREE (13,602,203} shares
without designation of the nominal value."

Version française:

Art. 5. (Premier alinéa). La Société a un capital émis d'UN MILLION CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT

QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET VINGT-CINQ CENTS (1.161.598,25 EUR), divisé en TREIZE MILLIONS SIX
CENT DEUX MILLE DEUX CENT TROIS (13.602.203) actions sans désignation de valeur nominale."

AU LIEU DE:

103239

L

U X E M B O U R G

Version anglaise:

"  Art. 5. (First paragraph).  The  Company  has  an  issued  capital  of  ONE  MILLION  ONE  HUNDRED  SIXTY-ONE

THOUSAND FIVE HUNDRED NINETY-EIGHT EUROS AND TWENTY-FIVE CENTS (1,161,598.25 EUR), divided into
THIRTEEN MILLION SIX HUNDRED THIRTY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED AND THREE (13,632,203) shares
without designation of the nominal value."

version française:

Art. 5. (Premier alinéa). La Société a un capital émis d'UN MILLION CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT

QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET VINGT-CINQ CENTS (1.161.598,25 EUR), divisé en TREIZE MILLIONS SIX
CENT TRENTE-DEUX MILLE DEUX CENT TROIS (13.632.203) actions sans désignation de valeur nominale."

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35814. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Carole FRISING.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2012097199/41.
(120134219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2012.

Danaher Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 86.363.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 12 juin 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 12 juillet 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012098126/13.
(120135308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Médecins Sans Frontières, Fondation.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 33, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg G 109.

<i>Bilan 2010

<i>Comptes de Bilan au 31.12.2010

2010

2009

ACTIF
Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

0,00 €

Actif Circulant
Avoir en banques, CCP et caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.371,34 € 2.636,65 €
Compte de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

0,00 €

4.371,34 € 2.636,65 €

Total de l'actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.371,34 € 2.636,65 €
PASSIF
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

0,00 €

Dettes
Dettes fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

0,00 €

Dettes envers MSF a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.770,00 €

0,00 €

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,00 € 2.636,65 €

1.870,00 € 2.636,65 €

Résultat de l'exercise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.501,34 €

0,00 €

Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.371,34 € 2.636,65 €

103240

L

U X E M B O U R G

<i>Compte de résultat 2010

<i>Compte de profits et de pertes au 31.12.2010

2010

2009

COMPTES DE PRODUITS
Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,00 €

0,00 €

Financement de MSF a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,00 €

0,00 €

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 € 1.980,00 €

Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,70 €

0,31 €

Correction de l'actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

0,00 €

1.980,31 €

Total des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.504,70 € 1.980,31 €
COMPTES DE CHARGES
Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 € 1.980,31 €

Frais bancaires et intérêts payés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,36 €

0,00 €

Dévaluation des actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

0,00 €

Résultats de l'exercise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.501,34 €

0,00 €

Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.501,34 € 1.980,31 €

Signatures
<i>Secrétaire / Président

Référence de publication: 2012097484/47.
(120133367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2012.

Speedlingua S.A., Société Anonyme,

(anc. Smart Informatique S.A.).

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 88.696.

L'an deux mille douze, le vingt-deux juin.
Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Marc van HOEK, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de man-

dataire spécial de la Société SPEEDLINGUA S.A., ayant son siège social à L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière, en vertu
d'une résolution du conseil d'administration de la Société prise en réunion en date du 20 janvier 2012.

Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
1. La Société a été constituée initialement sous le nom de «SMART INFORMATIQUE SA" suivant acte notarié du 14

août 2002, publié en date du 15 octobre 2002 dans le au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
1484, les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et la dernière fois par acte reçu par-devant le notaire
instrumentant en date du 6 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2687
du 4 novembre 2011.

2. Le capital social de la Société s'élève actuellement à TROIS CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENT SEIZE

EUROS (351.216.- EUR) représenté par SEPT CENT DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE-DEUX (702.432) actions
existantes de catégorie A ayant une valeur nominale de CINQUANTE CENTIMES (0.50 EUR) chacune.

3. Aux termes de l’alinéa 6 de l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à sept cent seize mille huit

cent trente sept euros (716.837,- EUR) représenté par un million quatre cent trente trois mille six cent soixante quatorze
(1.433.674) actions d’une valeur nominale de cinquante centimes (0.50 EUR) chacune qui pourront consister en différentes
catégories d’actions et l’alinéa 7 de l'article 5 des statuts de la Société autorise le conseil d'administration à augmenter le
capital social de la Société dans les limites du capital autorisé et d’exclure les droits préférentiels de souscription des
actionnaires existants.

4. Lors de sa réunion du 20 janvier 2012, le conseil d'administration a décidé d’augmenter le capital social de la Société

d’un montant de DEUX CENT QUATRE VINGT-HUIT MILLE HUIT CENT DIX-SEPT EUROS (288.817.- EUR) dans les
limites du capital autorisé pour le porter de son montant actuel de TROIS CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX
CENT SEIZE EUROS (351.216.- EUR) à un montant de SIX CENT QUARANTE MILLE TRENTE TROIS EUROS (640.033.-
EUR) par la souscription et l’émission de CINQ CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE SIX CENT TRENTE QUATRE

103241

L

U X E M B O U R G

(577.634) nouvelles actions de catégorie A ayant une valeur nominale de CINQUANTE CENTIMES (0.50 EUR) chacune
avec une prime d’émission d’un montant total de TROIS CENT TRENTE SIX MILLE CENT QUATRE VINGT QUATRE
EUROS (336.184.- EUR).

5. Une liste contenant le nom des souscripteurs, le nombre d’actions souscrites et les versements effectués en nature

et en espèces est jointe au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

6. La libération des nouvelles actions a été réalisée comme suit:
- quatre cent soixante dix-sept mille neuf cent cinquante six (477.956) actions ont été libérées par des versements en

numéraire incluant le paiement d’une prime d’émission d’un montant de deux cent soixante dix huit mille cent soixante
dix  euros  (278.170.-EUR).  Le  montant  total  de  CINQ  CENT  DIX-SEPT  MILLE  CENT  QUARANTE  HUIT  EUROS
(517.148.-EUR) a été mis à la libre disposition de la Société tel que la preuve en a été rapportée au notaire soussigné.

- QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX-HUIT (99.678) actions ont été intégralement libé-

rées incluant le paiement d’une prime d’émission d’un montant de cinquante huit mille quatorze euros (58.014.-EUR) par
un apport en nature consistant en la conversion de deux créances certaines liquides et immédiatement exigibles détenus
respectivement par Monsieur Antoine FATIO à concurrence d’un montant de cinquante sept mille huit cent cinquante
trois euros (EUR 57.853) et par Monsieur Julien PITTON (les «Apporteurs») à concurrence d’un montant de cinquante
mille euros (EUR 50.000) à l’encontre de la société «SPEEDLINGUA S.A.».

L’apport en nature est évalué à un montant total de CENT SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS EUROS

(EUR 107.853);

Les Apporteurs ont déclaré que les créances sont libres de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction

au libre transfert de ces créances à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes
notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de ces créances à la Société.

La preuve de la propriété de l’apport en nature a été rapportée au notaire soussigné.
Conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’existence et la valeur

desdites créances apportées d’un montant total de CENT SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS EUROS (EUR
107.853) a été certifiée par un rapport dressé le 18 juin 2012 par RSM Audit Luxembourg S.à r.l. ayant son siège social à
L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, R.C.S. Luxembourg 113.621 et signé par Monsieur Pierre LEROY, Réviseur d’en-
treprises agrée, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui conclut comme suit:

« 7. Conclusion. Sans remettre en cause notre conclusion, nous attirons votre attention sur le fait que:
- l’actif net de la Société tel qu'il ressort du bilan intérimaire au 30 avril 2012 est négatif;
- nous avons porté ces observations à l’attention des apporteurs et ceux-ci nous ont confirmé par écrit qu'ils en

mesurent et en acceptent pleinement toutes les conséquences et notamment celle de se voir attribuer des actions re-
présentatives du capital d’une société dont l’actif net est négatif.

Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de

l’apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions de SPEEDLINGUA S.A. à émettre en contre-
partie.»

Le dit rapport après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexé aux pré-

sentes pour être enregistrés avec elles.

Le montant de SIX CENT VINGT CINQ MILLE UN EUROS (EUR 625.001) comprenant le montant de la susdite

augmentation du capital social et incluant le paiement de la prime d’émission pour un montant de trois cent seize mille
cent quatre-vingt-quatre Euros (EUR 316.184,-) a été mis à la libre disposition de la Société, tel que démontré au notaire
instrumentant par la présentation des pièces justificatives de libération.

7. En conséquence de l’augmentation de capital qui précède, le premier et le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts

de la Société auront désormais la teneur suivante:

<i>En version anglaise:

«The share capital of the Company is fixed at SIX HUNDRED FORTY THOUSAND THIRTY-THREE EUROS (EUR

640,033), represented by ONE MILLION TWO HUNDRED EIGHTY THOUSAND SIXTY-SIX (1,280,066) category A
shares with a par value of FIFTY CENTS (0,50.- Eur) each.»

«The ONE MILLION TWO HUNDRED EIGHTY THOUSAND SIXTY-SIX (1,280,066) shares with a par value of

FIFTY  CENTS  (0.50.-EUR)  each,  consist  in  ONE  MILLION  TWO  HUNDRED  EIGHTY  THOUSAND  SIXTY-SIX
(1,280,066) fully paid-in ordinary shares (the “category A shares”)»

<i>En version française:

«Le capital social est fixé à SIX CENT QUARANTE MILLE TRENTE TROIS EUROS (640.033.-EUR) représenté par

UN MILLION DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE SOIXANTE SIX (1.280.066) actions existantes de catégorie A ayant
une valeur nominale de CINQUANTE CENTIMES (0.50.- EUR)»

«Les UN MILLION DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE SOIXANTE SIX (1.280.066) actions d’une valeur nominale

de cinquante cents (0,50.EUR) chacune consistent en UN MILLION DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE SOIXANTE
SIX (1.280.066) actions ordinaires intégralement libérées («actions de catégorie A»).»

103242

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare, par application de l’article 32-1 de la Loi sur les Sociétés Commerciales telle que modifiée,

avoir vérifié que les conditions de l’article 26 de la loi précitée ont été remplies.

Le notaire attire l’attention du conseil d’administration ainsi que des actionnaires de la société, sur le contenu de

l’article 32-1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Après que le notaire ait donné lecture de cet article à la
partie comparante, cette dernière déclare bien comprendre le contenu de l’article et déclare en assumer pleinement les
conséquences.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite

au présent acte, est évalué à DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 2.200).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, une partie

de l’acte est rédigée en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. VAN HOEK, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 juin 2012. Relation: LAC/2012/29855. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Référence de publication: 2012098808/115.

(120134633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Dahlia A SICAR S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.081.

Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2012.

Référence de publication: 2012098125/11.

(120135689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Delhaize Distribution Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8281 Kehlen, 51, rue d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 70.512.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELHAIZE DISTRIBUTION LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2012098128/10.

(120134719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

DesCap S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 86.512.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

103243

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012098129/10.

(120134963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Digital Realty (Cressex) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 132.336.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/07/2012.

TMF Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2012098131/12.

(120135645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

DCORP, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 129.495.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice cloturant en 15/12/2011 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2012098139/11.

(120135521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Digital Realty (Manchester) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 132.337.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/07/2012.

TMF Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2012098132/12.

(120135608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Dome 4 0909 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 149.730.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 12 juin 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 12 juillet 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012098133/13.

(120135306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

103244

L

U X E M B O U R G

Dominium Dortmund S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 132.729.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco REIF Services (Lu-

xembourg) SA informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue avec effet le 9 octobre 2007 pour
une durée indéterminée entre les deux sociétés:

Dominium  Dortmund  S.A.,  enregistrée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  Luxembourg  avec  le  numéro

B132729 et ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg jusqu'au 31 juillet 2012, et

Citco (Luxembourg) S.A., qui est devenue Citco REIF Services (Luxembourg) SA, le 1 

er

 juillet 2008, et ayant son siège

social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Et ce avec effet au 31 juillet 2012

Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2012.

Signatures
<i>L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2012098134/17.
(120134775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

DH K S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 365.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 124.642.

Le dépôt rectificatif des comptes consolidés au 31 décembre 2011 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg le 19 juillet 2012, sous la référence L120124258 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2012.

Référence de publication: 2012098144/12.
(120135202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Dominium Palmaille S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 132.730.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco REIF Services (Lu-

xembourg) SA informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue avec effet le 9 décembre 2007 pour
une durée indéterminée entre les deux sociétés:

Dominium Palmaille S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg avec et ayant son siège

social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg jusqu'au 31 juillet 2012, et

Citco (Luxembourg) S.A., qui est devenue Citco REIF Services (Luxembourg) SA, le 1 

er

 juillet 2008, et ayant son siège

social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Et ce avec effet au 31 juillet 2012

Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2012.

Signature
<i>L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2012098135/17.
(120134823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Dominium S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 131.836.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco REIF Services (Lu-

xembourg) SA informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue avec effet le 19 septembre 2007
pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

Dominium S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg avec le numéro B131836 et ayant

son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg jusqu'au 31 juillet 2012, et

103245

L

U X E M B O U R G

Citco (Luxembourg) S.A., qui est devenue Citco REIF Services (Luxembourg) SA, le 1 

er

 juillet 2008, et ayant son siège

social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Et ce avec effet au 31 juillet 2012

Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2012.

Signatures
<i>L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2012098136/17.

(120134774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

MGP Europe AIV (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 122.881.

Suite à l'assemblée générale du 29 juin 2012, les décisions suivantes ont été prises:
- L'assemblée accepte la démission de leur mandat de gérant de:
Madame Julie Mossong, née à Wirksworth, Royaume-Uni, le 30 avril 1965, domiciliée professionnellement 28, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur Thomas Lee, né à Sidney, Australie, le 1 

er

 octobre 1972, domicilié professionnellement 8 Marina View, Asia

Square Tower 1 #27-03, Singapore 018960, Singapour.

Monsieur Laurent Luccioni, né à Paris, France, le 31 juillet 1971, domicilié professionnellement 60 Sloane Avenue,

London SW3 3XB, Royaume-Uni.

- L'assemblée générale nomme à un mandat de gérant, pour une durée indéterminée:
Madame Joanne Fitzgerald, née à Waterford, Irlande, le 11 mars 1979, domiciliée professionnellement 28, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur Steven Willingham, né à Boston, Royaume-Uni, le 7 octobre 1969, domicilié professionnellement 60 Sloane

Avenue, London SW3 3XB, Royaume-Uni.

Référence de publication: 2012098521/20.

(120135094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

DC Systèmes de Sécurité S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 11, Place de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 83.350.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012098138/9.

(120134670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Dekode S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, op der Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 155.797.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012098141/9.

(120135694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Delhaize Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8281 Kehlen, 51, rue d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 97.993.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

103246

L

U X E M B O U R G

DELHAIZE Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012098142/10.
(120134718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

DHC Luxembourg V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.935.345,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.613.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Référence de publication: 2012098145/10.
(120134611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Prodest Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 48.352.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010

et au 31 décembre 2011, tenue en date du 09 juillet 2012 que:

Le siège social de la société est transféré du 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg vers le 412F, route d'Esch, L-1471

Luxembourg.

Il résulte également dudit procès-verbal, que Madame Mireille GEHLEN et que Monsieur Thierry JACOB ont transféré

leur adresse professionnelle du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg vers le 412F, route d'Esch, L-1471 Luxem-
bourg et ceci jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2014.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012098648/16.
(120134512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

DHCT II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.708.379,05.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 146.365.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Référence de publication: 2012098146/10.
(120134609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Difrulux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6238 Breidweiler, 4, rue Hicht.

R.C.S. Luxembourg B 97.813.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Gérard LEUCHTER
4 rue Hicht
L-6238 Breidweiler
<i>Le gérant

Référence de publication: 2012098147/13.
(120134916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

103247

L

U X E M B O U R G

Médecins Sans Frontières, Fondation.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 33, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg G 109.

<i>Bilans 2009

<i>Comptes de bilan au 31.12

2009

2008

ACTIF
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

0,00 €

ACTIF CIRCULANT
Avoir en banques, CCP et caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.636,65 €

656,34 €

Compte de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.636,65 €

656,34 €

Total de l'actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.636,65 €

656,34 €

PASSIF
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

0,00 €

Dettes
Dettes fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

0,00 €

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.636,65 €

656,34 €

2.636,65 €

656,34 €

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

0,00 €

Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.636,65 €

656,34 €

<i>Compte de profits et de pertes au 31.12

2009

2008

COMPTE DE PRODUITS
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.980,00 €

5.013,00 €

Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,31 €

19,48 €

Correction de l'actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 € 73.716,73 €

Total des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.980,31 € 78.749,21 €
COMPTES DE CHARGES
Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.980,31 €

5.032,48 €

Dévolution des actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 € 73.716,73 €

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

0,00 €

Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.980,31 € 78.749,21 €

Signatures.

Référence de publication: 2012097485/38.

(120133368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2012.

EuroPRISA Poland Warehouse S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 134.497.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2012.

TMF Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2012098165/12.

(120135551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

103248


Document Outline

ACM Bernstein Value Investments

ASR Fonds

BNP Paribas L Fix

Centralis S.A.

Cogeco S.à r.l.

CP Finance Luxembourg S.à r.l.

Dahlia A SICAR S.C.A.

d'Amico International Shipping S.A.

Danaher Luxembourg S.à r.l.

DCORP, S. à r.l.

DC Systèmes de Sécurité S.à r.l.

D.E.H. Holdings Sàrl

Dekode S.à r.l.

Delhaize Distribution Luxembourg S.A.

Delhaize Luxembourg S.A.

DesCap S.A.

DHC Luxembourg V S.à r.l.

DHCT II Luxembourg S.à r.l.

DH K S.à r.l.

Difrulux s.à r.l.

Digital Realty (Cressex) S.à r.l.

Digital Realty (Manchester) S.à r.l.

Dome 4 0909 S.à r.l.

Dominium Dortmund S.A.

Dominium Palmaille S.A.

Dominium S.A.

Electroengine S.A.

Eucalyptus

EuroPRISA Poland Warehouse S. à r.l.

Fidam

Immobilière C.M.R. S.A.

La Paix Immobilière S.à r.l.

Lighthouse International Company S.A.

Lighthouse International Company S.A.

Lighthouse International Company S.A.

Médecins Sans Frontières

Médecins Sans Frontières

MGP Europe AIV (Lux) S.à r.l.

Prodest Finance S.A.

SEB JINIFE Global Equity Fund 11 - SICAV - FIS

Smart Informatique S.A.

Speedlingua S.A.

Tishman Speyer Brienner Strasse G.P. S.à r.l.

Tishman Speyer Valentinskamp G.P. S.à r.l.

Tishman Speyer Valentinskamp L.P. S.à r.l.

UniDividendenAss

UniDynamicFonds: Europa

UniEM Fernost

UniEM Global

UniEuropaRenta

UniProfiAnlage (2015)

UniProfiAnlage (2015/II)

UniProfiAnlage (2016)

UniProfiAnlage (2017)

UniProfiAnlage (2017/6J)

UniProfiAnlage (2019)

UniProfiAnlage (2020)

UniProfiAnlage (2021)

UniProfiAnlage (2023)

UniProfiAnlage (2024)

UniProfiAnlage (2025)

UniProfiAnlage (2027)

UniValueFonds: Europa

UniValueFonds: Global

Zellam S.A.