This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2135
28 août 2012
SOMMAIRE
Agave Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102457
Ainvest Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102465
C2Trans Holding S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102457
Capitol Inquiry Services S.A. . . . . . . . . . . . .
102460
CCP III CZ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102449
CCP III Germany Holdings S.à r.l. . . . . . . .
102449
CCP III UK Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
102460
CCP III UK Shopping S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
102450
Ceheca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102449
CFC Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102434
CIR International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102434
Clara Vision S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102434
CMB Immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102449
CMP II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102449
CODUR S.A. (Constructions Durables) . .
102450
Compagnie Immobilière Luxembourgeoi-
se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102461
Comptoir Pharmaceutique Luxembour-
geois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102461
Continental Investissement . . . . . . . . . . . . .
102461
CPI CPEH 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102467
CPS Consulting Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102456
Credipar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102457
Dahlia B SICAR S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
102465
Dana Services Sàr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102466
Daviger S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102467
Déco-Peint Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
102465
Demag Holding, Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102467
Demag Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
102465
Dîon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102464
Distinct Communication, Sàrl . . . . . . . . . . .
102467
Dobry S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102474
Dolomies et Chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102474
Dufouleur Père et Fils, S.à r.l. . . . . . . . . . . .
102479
Dufouleur Père et Fils, S.à r.l. . . . . . . . . . . .
102479
Dufouleur Père et Fils, S.à r.l. . . . . . . . . . . .
102479
Dundee International (Luxembourg) In-
vestments 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102470
Dundee International (Luxembourg) In-
vestments 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102470
Dundee International (Luxembourg) In-
vestments 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102465
D.V.V. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102460
Dynex Energy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102465
Eden 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102479
Element Power Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102479
Encore Plus Lux Co Diamants II S.à r.l. . .
102475
Encore Plus Lux Co Franklin II S.à r.l. . . . .
102475
Encore Plus Lux Co Metzanine II S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102475
Energex Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
102474
Enovos International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
102434
Eurofinance S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102478
Euro Full Media S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102480
Euro Full Media S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102480
Everyone Game Entertainment . . . . . . . . .
102480
Exmar Offshore Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
102480
Exmar Offshore Services S.A. . . . . . . . . . . .
102480
Financière Dolomies et Chaux . . . . . . . . . .
102480
Ingersoll-Rand Lux Clover Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102450
Juniper Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102471
Kuehne + Nagel Investments S.à r.l. . . . . .
102464
Land Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102479
Larus Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102475
Lory S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102478
OME Acquisition S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102470
Stris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102461
Try S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102460
102433
L
U X E M B O U R G
CFC Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 115.321.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096667/10.
(120132376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
CIR International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 15.381.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096671/10.
(120132720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Clara Vision S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 144.265.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096674/10.
(120132754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Enovos International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 11.723.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth of July,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary
general meeting of the shareholders of Enovos International S.A., a public limited liability company (société anonyme),
having its registered office at 66, rue de Luxembourg, L-4221 Eschsur-Alzette, incorporated by a notarial deed on February
5, 1974, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of April 6, 1974, under
number 76 (the “Company”). The articles of association of the Company have been amended for the last time on March
29, 2012 by a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial of April 13, 2012 under number 956.
The meeting was chaired by Mr Marco Hoffmann, professionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary
Mr. Michel Schaus, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Geneviève Schlink, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary
to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Amendments to the Articles of Association of the Company;
2. Acknowledgment of the resignation of Mr. Nico Wietor, Mr. Claude Seywert, and Mr. Fernand Felzinger as directors
of the Company effective on the date of the general meeting of the shareholders of the Company;
3. Decision to appoint Mr. Benoit Gaillochet, Mr. Stephan Illenberger, and Mr. Fernand Felzinger as directors of the
Company effective on the date of the general meeting of the shareholders of the Company, and determination of the
duration of their mandate;
4. Authorization to undertake all necessary actions to file and register the resignations and appointments resulting
from the above resolutions with the Luxembourg Registry of Trade and Companies.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of the shares
held by them are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the
102434
L
U X E M B O U R G
proxy-holders, the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes
with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the
bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
III. It appears from the attendance list that all of the nine hundred nine thousand six hundred twenty-nine (909,629)
shares representing the whole issued share capital of the Company of ninety million nine hundred sixty-two thousand
nine hundred euros (EUR 90,962,900) are represented at this extraordinary general meeting of shareholders.
IV. All the shareholders present or represented declared that they had due notice and full knowledge of the agenda
prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.
V. The meeting is therefore duly constituted and can validly deliberate on the agenda.
VI. After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting
proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the chairman submitted to the vote of the members
of the meeting the following resolutions which were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to amend article 5.4 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
“ 5.4. Any new shares to be paid for in cash or in kind, by incorporation of reserves or any other means, will be offered
by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality of shareholders, such shares will be offered to the
shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. In case one or more
shareholder(s) decide not to exercise his/their preferential subscription right(s), such right(s) shall accrue proportionally
to the other shareholders willing to exercise those rights subject to compliance with article 8.5. The board of directors
shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may
not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing
the opening of the subscription. However, subject to the terms and conditions provided by law and any shareholder
agreement, as may be entered into and amended by the shareholders from time to time (the “Shareholder Agreement”),
the general meeting of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's issued share capital, may limit
or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s). Such resolution to increase the Company's
issued share capital shall be adopted in the manner required for an amendment of these articles of association as set out
under article 5.3. The resolution to limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s)
shall be taken with the unanimous approval of all shareholders of the Company.”
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to amend article 8.5 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
“ 8.5. No shareholder (together with one or more of its Affiliates and/or, but only with respect to AXA Redilion
ManagementCo, with AXA Redilion Transferee as referred to in the second paragraph of article 11) of the Company,
other than the State and/or the SNCI, shall be authorised to hold a shareholding in the Company representing more than
thirty-three (33) percent of the share capital of the Company, except with the prior consent in writing of the shareholders
representing three quarters (3/4) of the share capital of the Company. For the avoidance of doubt, nobody, whether a
natural person or legal entity or others, including, but not limited to, a shareholder (together with one or more of its
Affiliates and/or, but only with respect to AXA Redilion ManagementCo, with AXA Redilion Transferee as referred to
in the second paragraph of article 11) of the Company and/or its Parent(s) and/or its (direct and/or indirect) shareholders,
other than the State and/or the SNCI, shall ever under any circumstances directly and/or indirectly, hold, and/or have an
interest in, and/or have influence on, and/or have control, direction or any other power on an aggregate number of shares
in the Company representing more than thirty three (33) percent of the share capital of the Company, except with the
prior consent in writing of the shareholders representing three quarters (3/4) of the share capital of the Company. The
shareholders agree that they shall take or cause to be taken any necessary actions, resolutions and approvals to be taken
in accordance with applicable law, including by the Company, in that respect.”
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to amend article 10.1.6 of the articles of association of the Company so as to be worded as
follows:
“ 10.1.6. Unless otherwise agreed between the transferring shareholder and the other shareholders, the transferring
shareholder may not send a Shareholder's Notice if the number of shares in the Company to be transferred, together
with the number of shares in the Company already held by one or more Affiliates of the prospective transferee (in case
the prospective transferee is not a shareholder) as well as any person to be taken into consideration in relation to the
(33) percent threshold set out in article 8.5 or by the prospective transferee (together with one or more of its Affiliates
as well as any person to be taken into consideration in relation to the (33) percent threshold set out in article 8.5), would
lead to the exceeding of a thirty-three (33) percent threshold as set out in article 8.5. In the latter case, the transferring
shareholder may opt for the procedure set out in article 10.2.“
102435
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolved to delete article 10.4.2 of the articles of association of the Company, and consequently articles
10.4.3 and 10.4.4 will be renumbered as articles 10.4.2 and 10.4.3 respectively.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolved to amend new article 10.4.2 of the articles of association of the Company so as to be worded
as follows:
“ 10.4.2. In any case, the Buy-Back shall be limited to a maximum of ten (10) percent of the total amount of the share
capital of the Company per period of five (5) years, the first period of five (5) years starting on 18 December 2008.”
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolved to amend new article 10.4.3 of the articles of association of the Company so as to be worded
as follows:
“ 10.4.3. If the Company decides not to perform the Buy-Back, the transferring shareholder may, within a period of
twelve (12) Business Days following such decision:
- either notify the other shareholders that it does not anymore intend to transfer the Offered Shares, it being un-
derstood that it may only accept the Partial Pre-Emption;
- or notify the other shareholders that it shall exercise its right to freely conclude, within a period of six (6) months
following such notification, an agreement with a good faith purchaser in relation to the transfer (including by means of an
asset swap) of part (i.e. the portion of the Offered Shares which have not been pre-empted under the Partial Pre-Emption)
or all (in case no shareholder pre-empted) of the Offered Shares. In case of this second option set out in this paragraph,
the portion of the Offered Shares which have been pre-empted under the Partial Pre-Emption, if any, shall be transferred
to the pre-empting shareholder as soon as reasonably practicable after the transferring shareholder's notice to choose
this second option.”
<i>Seventh resolutioni>
The meeting resolved to amend article 11 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
“ Art. 11. Permitted transfers. The provisions of article 10 will not apply to the transfer by any shareholder (except
AXA Redilion ManagementCo and AXA Redilion Transferee) of its shares in the Company to any of its Affiliates, provided
in each case that the Affiliate adheres in writing to the Shareholder Agreement by executing a deed of adherence and
undertakes to return the shares of the Company to the shareholder-transferor in the event that, and as soon as, it is no
longer an Affiliate. In general, in case of the transfer of a shareholder's shares in the Company to an Affiliate, all rights of
such shareholder under these articles of association and the Shareholder Agreement shall ensure to the benefit of such
Affiliate. For the avoidance of doubt, the State and the SNCI shall be deemed to be Affiliates and in case of the transfer
of the State's shares in the Company to the SNCI, all rights of the State under these articles of association and the
Shareholder Agreement shall inure to the benefit of the SNCI. Other transfers, where provisions of article 10 will not
apply, may be permitted from time to time by the Shareholder Agreement.
Furthermore, AXA Redilion ManagementCo can freely transfer (the “Preempted Shares Transfer”) all the shares in
the Company it may have acquired further to the exercise of its pre-emption rights according to the relevant provisions
of article 10 to one entity (“AXA Redilion Transferee”) managed and directly or indirectly controlled by AXA Investment
Managers Private Equity S.A., in the same way that AXA Redilion ManagementCo is managed and directly or indirectly
controlled by AXA Investment Managers Private Equity S.A., as may be further described in the Shareholder Agreement,
and fulfilling all of the other conditions for there not being a Change of Control in relation to AXA Redilion Transferee
that may be set out in the Shareholder Agreement, provided that it is always the same entity for each Pre-empted Shares
Transfer and that such entity, i.e. AXA Redilion Transferee adheres in writing to the Shareholder Agreement by executing
a deed of adherence, and undertakes to return all of its shares in the Company to AXA Redilion ManagementCo in the
event that, and as soon as, AXA Redilion Transferee is no longer managed and directly or indirectly controlled by AXA
Investment Managers Private Equity S.A. (the “Event”) (and for the avoidance of doubt, AXA Redilion ManagementCo
shall keep the shares it held in the Company prior to the exercise of its pre-emption rights). For the avoidance of doubt
and in addition to other situations of Change of Control in relation to AXA Redilion Transferee, in case of failure by AXA
Redilion Transferee to return forthwith all of the shares in the Company held by AXA Redilion Transferee to AXA
Redilion ManagementCo in case of the Event, there shall be a Change of Control in relation to AXA Redilion Transferee
and article 12 shall apply. AXA Redilion Transferee and AXA Redilion ManagementCo together shall be counted as one
shareholder (i) for the purpose of the determination of their rights to representation at the board of directors of the
Company and the Subsidiaries and at any committee provided for in the Shareholder Agreement, without however
incurring any joint liability by virtue thereof and (ii) for the purpose of the limit of thirty three (33) percent set out in
article 8.5, so that AXA Redilion ManagementCo together with any Affiliate and/or AXA Redilion Transferee shall not
be authorised to hold a shareholding in the Company representing more than thirty three (33) percent of the share capital
102436
L
U X E M B O U R G
of the Company, except with the prior consent in writing of the shareholders representing three quarters (3/4) of the
share capital of the Company.
The transfer of the shares held by AXA Redilion Transferee in accordance with the preceding paragraph shall be made
pursuant to the rules set out in article 10, except that AXA Redilion Transferee is not authorised to transfer a portion
of its shares in the Company representing less than 5% of the share capital of the Company.
If AXA Redilion ManagementCo decides to transfer all of its shares in the Company to a third party acquirer, AXA
Redilion Transferee's shares must be transferred at the same time to the same acquirer, unless otherwise agreed by the
other shareholders.
Unless otherwise agreed by the other shareholders, AXA Redilion ManagementCo must at any time hold a number
of shares in the Company which is at least equal to the number of shares in the Company held by AXA Redilion Trans-
feree.”
<i>Eighth resolutioni>
The meeting resolved to amend article 13 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
“ Art. 13. Parliamentary approval and Municipal Council Approval. The shareholders (other than the State) acknow-
ledge that the State may need to obtain the relevant approvals from parliament in order to be able to exercise the rights
it has pursuant to the various sections of these articles of association. The shareholders (other than the State) agree to
grant the State the time necessary to exercise its rights and, if need be, suspend temporarily the processes provided in
these articles of association during the time of the parliamentary process. The State will use its best efforts to obtain such
parliamentary approval within sixty five (65) Business Days following the determination of the consideration to be paid
for the Offered Shares.
The shareholders (other than VdL) acknowledge that VdL may need to obtain the relevant approvals from the Municipal
Council in order to be able to exercise the rights it has pursuant to the various provisions of these articles of association.
The shareholders (other than VdL) agree to grant VdL the time necessary to exercise its rights and, if need be, suspend
temporarily the processes of the relevant sections of these articles of association during the time of the Municipal Council
process. VdL will use its best efforts to obtain such Municipal Council approval within sixty five (65) Business Days
following the determination of the consideration to be paid for the Offered Shares.”
<i>Ninth resolutioni>
The meeting resolved to amend article 16.4.3 of the articles of association of the Company so as to be worded as
follows:
“ 16.4.3. Unless otherwise provided in these articles of association, at extraordinary general meetings of shareholders,
resolutions shall be passed with a majority of two thirds of the votes validly cast at such general meeting of shareholders
where at least half of the share capital is present or represented on a first call. On a second call, unless otherwise provided
in these articles of association, the resolution shall be passed with a majority of two thirds of the votes validly cast at such
general meeting of shareholders, regardless of the portion of capital present or represented.
Extraordinary general meetings of shareholders shall vote, amongst others, on all amendments to the articles of as-
sociation including increases and decreases of share capital (except in case of authorised capital, if any) and the dissolution
of the Company.”
<i>Tenth resolutioni>
The meeting resolved to delete article 19.5 of the articles of association of the Company.
<i>Eleventh resolutioni>
The meeting resolved to amend article 20.4 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
“ 20.4. In addition to the general powers entrusted by law to the board of directors, the latter shall have the exclusive
power and authority to approve (and shall not delegate such power and authority to the Executive Board) with regard
to the Company and/or Subsidiaries:
a) with regard to the Company, the Grid Company, the Sales Company, and the Major Companies, the presentation
of a mid-term (three years) business plan;
b) all investments, divestments in fixed and financial assets exceeding twenty-five million Euro (EUR 25,000,000) (even
if already covered by the relevant yearly budget or business plan);
c) the incorporation, purchase, sale or closure of major subsidiaries or branches, as well as material amendments
(including capital increases or decreases), of their constitutional documents;
d) the suspension of planned operations, merger, demerger or liquidation;
e) the purchase, sale or encumbrance of real estate as well as lease of real estate for a lease payment (annually) for a
value exceeding five million Euro (EUR 5,000,000);
f) the granting of warranties and guarantees (except for any guarantees already covered by the relevant annual business
plan or yearly budget) for a value exceeding twenty-five million Euro (EUR 25,000,000);
102437
L
U X E M B O U R G
g) the entering into agreements for a value exceeding twenty-five million Euro (EUR 25,000,000) with any of the
shareholders, their Affiliates and the Directors (other than stipulated in the relevant annual business plan or yearly budget);
h) the entering into agreements (including energy sales contracts and energy purchase contracts unless these contracts
fall under the risk policy and limits previously approved by the board of directors) which are not stipulated in the relevant
annual business plan or yearly budget and which exceed an overall value of one hundred million Euro (EUR 100,000,000);
i) the granting or taking of loans or other credits (including bonds or similar securities) exceeding the amount of ten
million Euro (EUR 10,000,000).
To the extent possible and permitted by law, any decision falling within the matters referred to in the list above (other
than set forth under lit a) which are to be taken in relation to a Group Company (other than the Subsidiaries) will be
subject to a report by the Executive Board to the board of directors before such decisions are taken at the level of such
Group Company.”
<i>Twelfth resolutioni>
The meeting resolved to amend article 20.5 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
“ 20.5. With regard to the approvals set forth under 20.4 lit. b, f and h, as well as to the approval of the issuance by
the Grid Company of new shares to other transmission and distribution system operators in exchange for the acquisition
of their infrastructure outside Luxembourg, the approval of the board of directors requires a majority of 3/5 (three fifths)
of the members of the board of directors present or represented at the relevant meeting.”
<i>Thirteenth resolutioni>
The meeting resolved to amend article 20.6 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
“ 20.6. Upon resolution by the board of directors voting with a majority of 2/3rd (two thirds) of its members present
or represented at the relevant meeting, the approvals listed in article 20.4 may be varied and/or supplemented with further
approvals which shall require the approval of the board of directors at a majority of 3/5 (three fifths) of its members
present or represented at the relevant meeting.”
<i>Fourteenth resolutioni>
The meeting resolved to amend article 20.7 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
“ 20.7. The rules set out in articles 20.4, 20.5 and 20.6 shall no longer be applicable in relation to the Grid Company
and its subsidiaries in case of acquisition by the State and/or the SNCI of a majority participation in such Subsidiary.”
<i>Fifteenth resolutioni>
The meeting resolved to amend article 21.1 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:
“ 21.1. The board of directors shall appoint a chairman (the “Chairman”) to be chosen among the Directors appointed
among the candidates submitted by the shareholder (the State and SNCI being in this case counted as one shareholder)
holding the highest number of shares.”
<i>Sixteenth resolutioni>
The meeting resolved to add a section H Grid Company to the articles of association of the Company and consequently
sections H and I will be renumbered as sections I and J respectively, and current article 33 will be renumbered as article
34.
<i>Seventeenth resolutioni>
The meeting resolved to add under section H an article 33 Grid Company to the articles of association of the Company
so as to be worded as follows:
“H. Grid company
Art. 33. Grid Company. The State and/or the SNCI shall obtain at any time upon one or more successive requests
from the State individually or the State and the SNCI jointly, if applicable each time for a portion (and regardless of the
level of participation of the Company in the Subsidiaries) a direct participation and if so requested even a qualified (e.g.
two-third) majority in the share capital of the Grid Company. The shareholders of the Company shall take the necessary
actions, resolutions and approvals to be taken to such effect (including by the Company) and in particular to cause the
resolutions of the shareholders and/or the Subsidiaries of the Company to be taken in order to allow the State and/or
the SNCI to obtain the participation(s) as set forth here above in one or more successive operations. All transactions
necessary in that respect must respect the arm's length principle.
Unless otherwise agreed between the Company and the State and/or the SNCI, as applicable, the purchase price
offered each time for such a participation shall be determined (based on the market value of this participation valued as
a going concern as at the date of the notification (the “Acquisition Notification”) by the State individually or the State
and the SNCI jointly of the intention of the State and/or the SNCI, as applicable, to acquire such participation) by a
102438
L
U X E M B O U R G
Valuator appointed by the acquirer (i.e. the State and/or the SNCI, as applicable) and the Company (acting through its
board of directors and not the Executive Board of the Company). In case of failure to appoint such a Valuator within
twenty (20) Business Days from the receipt of the Acquisition Notification, the Valuator shall be appointed by the Pre-
sident of the District court of the City of Luxembourg (Président du Tribunal d'Arrondissement) upon request of any of
the State or the SNCI, as applicable, or the Company on behalf of the State and/or the SNCI, as applicable, and the
Company. The participation(s) will be acquired on the basis of this price, unless the State and/or the SNCI, as applicable,
refuse(s) to acquire the participation(s) at such a price and notifies thereof the Company within twelve (12) Business
Days of the receipt of the conclusion of the Valuator.
Fifty (50) percent of the fees of the Valuator shall be borne by the Company and fifty (50) percent thereof shall be
borne by the acquirer (i.e. the State and/or the SNCI, as applicable).
The State and/or the SNCI, as applicable, agree not to transfer for commercial reasons, during a period of ten (10)
years, starting at the date of the acquisition of the relevant shares in the Grid Company, all or part of the shares it/they
has/have acquired in the share capital of the Grid Company, subject to what is set out hereafter. It is understood that
the State and/or the SNCI shall be entitled to transfer at any time in any one of the cases set out in article 33.3, (i) to
(iv), even within the above-mentioned period of ten (10) years, all or part of the shares that they own in the Grid Company.
33.1. Subject to the exceptions set out hereafter in article 33.3 and subject to the preceding paragraph, if at any time
the State and/or the SNCI, as applicable, propose(s) to make a transfer of all or part of the shares it/they has/have acquired
in the share capital of the Grid Company, to a prospective transferee(s) other than the Company, then the State and/or
the SNCI, as applicable, shall promptly send to the Company a written notice of the intention to make the transfer (the
“Notice”). The Notice shall include (i) the number of shares of the Grid Company to be transferred (the “Grid Shares”),
(ii) the name(s) and address(es) of the prospective transferee(s), and (iii) the purchase price offered in good faith by such
prospective transferee(s).
The Company shall, within a period of twenty (20) Business Days from the receipt of the Notice, elect to acquire or
elect not to acquire (the failing of the sending of an election notice shall be deemed equivalent to an election not to
acquire) all of the Grid Shares at the price as set forth in the Notice by written notice sent to the State and/or the SNCI,
as applicable.
If the Company does not elect to acquire, as described in the preceding paragraph, the State and/or the SNCI may
freely transfer the Grid Shares to the prospective transferee(s) at the price set forth in the Notice for a period of six (6)
months after the end of the twenty (20) Business Day period, it being understood that, depending on the circumstances,
the conclusion of the transfer agreement may be subject to the obtaining of any required antitrust/competition approval.
33.2. Subject to the exceptions set out hereafter in article 33.3, in case the State and/or the SNCI, as applicable, want
(s) to transfer, without there being a prospective transferee, all or part of the participation it/they has/have acquired in
the share capital of the Grid Company, the Company may elect, within twenty (20) Business Days from the receipt of
the notification by the State and/or the SNCI's intention to transfer such participation, subject to its refusal right after
determination of the price, to acquire the totality of the participation the State and/or the SNCI, as applicable, want(s)
to transfer.
Unless otherwise agreed between the Company and the State and/or the SNCI, as applicable, the purchase price for
the buy-back of this participation shall be determined (based on the market value of this participation valued as a going
concern as at the date of the notification by the Company of its intention to buy-back such participation) by a Valuator
appointed by the State and/or the SNCI, as applicable, and the Company (acting through the board of directors and not
the Executive Board of the Company). In case of failure to do so within twenty (20) Business Days from the notification
by the Company of its intention to buy-back such participation, it shall be appointed by the President of the District court
of the City of Luxembourg (Président du Tribunal d'Arrondissement) upon request of any of the State or the SNCI, as
applicable, or the Company on behalf of the State and/or the SNCI, as applicable, and the Company. The participation
will be bought-back on the basis of this price, unless (i) the Company refuses to acquire the participation at such a price
and notifies thereof the State and/or the SNCI, as applicable within twenty (20) Business Days of the receipt of the
conclusion of the Valuator and/or (ii) unless the State and/or the SNCI, as applicable, refuse(s) to transfer the participation
at such a price and notifies thereof the Company within twelve (12) Business Days of the receipt of the conclusion of the
Valuator.
Fifty (50) percent of the fees of the Valuator shall be borne by the Company and the other fifty (50) percent thereof
shall be borne by the transferor (i.e. the State and/or the SNCI, as applicable).
In case the Company has not elected to acquire or has refused to acquire the totality of the participation that the State
and/or the SNCI, as applicable, want(s) to transfer, the State and/or the SNCI, as applicable, shall be free to transfer this
participation to a transferee other than the Company at a price equalling at least the price as determined by the Valuator.
33.3. The Company shall not benefit from the pre-emption right as detailed herebefore:
(i) in case of a transfer of all or part of such participation between the State and the SNCI, as long as the State is the
majority owner of the SNCI;
(ii) in case the State and/or the SNCI, as applicable, want(s) to transfer all or part of such participation to one or more
municipalities or public bodies or Affiliates of the State and/or the SNCI, subject to the State and/or the SNCI agreeing
with the relevant municipality, public body or Affiliate that the Company shall benefit from a pre-emption right as detailed
102439
L
U X E M B O U R G
here above in articles 33.1 and 33.2 of this article in case of a subsequent transfer to any third party (other than the State
and/or the SNCI and/or any of their respective Affiliates) of any such shares of the Grid Company acquired by such
municipality or public body or Affiliate of the State and/or the SNCI;
(iii) in case the State and/or the SNCI, as applicable, is constrained (in application of any legal or regulatory provisions
or obligations or if required by court order) to transfer all or part of such participation. In such a case, the State and/or
the SNCI, shall be free to transfer all or part of this participation to any transferee other than the Company and/or to
the Company;
(iv) in case the Grid Company is required (in application of any legal or regulatory provisions or obligations) to merge
with one or more other entities.
33.4. Any amendments (including additions) to this article 33 shall require the unanimous consent of all the shareholders
of the Company.”
<i>Eighteenth resolutioni>
The meeting resolved to add the definition of AXA Investment Managers Private Equity S.A. under new section J of
the articles of association of the Company:
“"AXA Investment Managers Private Equity S.A." means AXA Investment Managers Private Equity S.A., a société ano-
nyme incorporated under the laws of France, having its registered office in France and registered with the Trade of
Companies Register of Paris under number 403 081 714;”
<i>Nineteenth resolutioni>
The meeting resolved to add the definition of AXA Redilion ManagementCo under new section J of the articles of
association of the Company:
“"AXA Redilion ManagementCo" means AXA Redilion ManagementCo SCA, a company incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in the Grand Duchy of Luxembourg Luxembourg regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B168843;”
<i>Twentieth resolutioni>
The meeting resolved to add the definition of AXA Redilion Transferee under new section J of the articles of association
of the Company:
“"AXA Redilion Transferee" has the meaning ascribed to it in article 11.”
<i>Twenty-first resolutioni>
The meeting resolved to amend the definition of Change of Control under new section J of the articles of association
of the Company so as to be worded as follows:
““Change of Control” (subject to any terms of the Shareholder Agreement) occurs when:
- a shareholder ceases to be a wholly-owned (direct or indirect) subsidiary of its Parent; or
- the Parent ceases to own (directly or indirectly) (or hold the beneficial ownership of) at least the same percentage
of shares in the shareholder as on 17 July 2012 or in respect of any new shareholder, the date of becoming a shareholder;
- the Parent ceases to have the right to cast more than fifty percent of the votes capable of being cast in the general
meetings of the shareholder; or
- the Parent ceases to have the power to direct the management and policies (whether by way of ownership of shares,
proxy, contract, agency or otherwise) or composition of the board of the shareholder;”
<i>Twenty-second resolutioni>
The meeting resolved to add the definition of Major Companies under new section J of the articles of association of
the Company:
“"Major Companies" means the major subsidiaries of the Grid Company (as long as it is majority owned by the Com-
pany) and the Sales Company, i.e., on 17 July 2012, Enovos Deutschland AG, Creos Deutschland GmbH, Enovos Energie
Deutschland GmbH and Leo (Luxembourg Energy Office) S.A.”
<i>Twenty-third resolutioni>
The meeting resolved to add the definition of Vdl under new section J of the articles of association of the Company:
“”Vdl” means Ville de Luxembourg, acting through its Collège des bourgmestre et échevins currently in place, duly
represented by the Collège Echevinal, having its address at L-2950 Luxembourg.”
<i>Twenty-fourth resolutioni>
The meeting acknowledged the resignation of Mr. Nico Wietor, Mr. Claude Seywert, and Mr. Fernand Felzinger as
directors of the Company effective on the date hereof.
102440
L
U X E M B O U R G
<i>Twenty-fifth resolutioni>
The meeting resolved to appoint as directors of the Company effective on the date hereof and for a term expiring at
the general meeting of shareholders resolving on the accounts for the financial year ending 31 December, 2013:
- Mr. Benoit Gaillochet, Fund manager, born on 4 September 1972 in Senlis (France), having his professional address
at 20, place Vendôme, 75001 Paris, France;
- Mr. Stephan Illenberger, born on 11 April 1959 in Bremen (Germany), having his professional address at c/o Axa
Private Equity Luxembourg S.à.r.l., 24, avenue Emile Reuter, 2420 Luxembourg; and
- Mr. Fernand Felzinger, born on 9 February 1957 in Sarrebourg (France), having his address at 53, avenue de Saint-
Germain, 78600 Maisons-Lafitte, France.
<i>Twenty-sixth resolutioni>
The meeting authorised the undersigned notary to undertake all necessary actions to file and register the resignations
and appointments pursuant to the above resolutions with the Luxembourg Registry of Trade and Companies.
With no other outstanding point on the agenda, and further request for discussion not forthcoming, the meeting was
closed.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with the notary, the present original
deed.
Folgt die Deutsche Fassung:
Im Jahr zweitausendundzwölf, am siebzehnten Juli,
Vor Maître Joëlle Baden, Notar, niedergelassen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, wurde eine außerordent-
liche Hauptversammlung der Aktionäre der Enovos International S. A. abgehalten, einer Aktiengesellschaft (société
anonyme), die ihren eingetragenen Sitz in 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette hat, gegründet durch notarielle
Urkunde am 5. Februar 1974, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das “Mémorial”) des
6. April 1974, unter Nummer 76 (die “Gesellschaft”). Die Satzung der Gesellschaft wurde das letzte Mal am 29. März
2012 geändert, durch notarielle Urkunde des unterzeichnenden Notars veröffentlicht im Mémorial des 13. April 2012
unter Nummer 956.
Die Versammlung wurde geleitet von Herrn Marco Hoffmann, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, welcher als
Schriftführer Herrn Michel Schaus, ernannte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.
Die Versammlung ernannte als Wahlprüfer Frau Geneviève Schlink, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.
Nachdem der Vorstand der Versammlung so errichtet wurde, erklärte der Vorsitzende und bat den unterzeichnenden
Notar festzustellen:
I. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Änderung der Satzung der Gesellschaft.
2. Bestätigung der Rücktritte von Herrn Nico Wietor, Herrn Claude Seywert und Herrn Fernand Felzinger als Ver-
waltungsratsmitglieder der Gesellschaft mit Wirkung am Tag der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft.
3. Entscheidung Herrn Benoit Gaillochet, Herrn Stephan Illenberger und Herrn Fernand Felzinger als Verwaltungs-
ratsmitglieder der Gesellschaft mit Wirkung am Tag der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft zu ernennen
und Bestimmung der Dauer ihres Mandates.
4. Ermächtigung alle notwendigen Handlungen vorzunehmen, um Rücktritte und Ernennungen, die aus den obigen
Beschlüssen resultieren, bei dem luxemburgischen Register für Handel und Gesellschaften einzureichen und einzutragen.
II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Stellvertreter der vertretenen Aktionäre und die Anzahl der von
ihnen gehaltenen Aktien sind in der Anwesenheitsliste aufgeführt; diese Anwesenheitsliste, welche von den anwesenden
Aktionären, den Stellvertretern, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und des unterzeichnenden Notars
unterzeichnet wurden, wird diesem Protokoll dauerhaft angeheftet, und mit diesem eingetragen.
Die Vollmachten, die die vertretenen Aktionäre erteilt haben, nachdem sie ne varietur von den Mitgliedern des Vor-
stands der Versammlung und des unterzeichneten Notars abgezeichnet wurden, werden in gleicher Weise diesem
Protokoll dauerhaft angeheftet.
III. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle der neunhundertneuntausend und sechshundertneunundzwanzig
(909.629) Aktien, die die Gesamtheit des ausgegebenen Aktienkapitals von neunzig Millionen und neunhundertzweiund-
sechzigtausendneunhundert Euro (EUR 90.962.900) darstellen, bei dieser außerordentlichen Hauptversammlung der
Aktionäre vertreten sind.
102441
L
U X E M B O U R G
IV. Alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie rechtzeitig geladen worden sind und dass sie voll-
ständige Kenntnis der Tagesordnung vor dieser Versammlung hatten, und dass sie auf ihr Recht verzichtet hatten, förmlich
geladen zu werden.
V. Die Versammlung ist demnach ordentlich konstituiert und kann wirksam über die Agenda beraten.
VI. Nachdem der Vorsitzende dies vorgebracht hatte und die Mitglieder der Versammlung dies bestätigten, fuhr die
Versammlung mit der Tagesordnung fort. Nachdem die Versammlung die Tagesordnung betrachtet hatte, stellte der
Vorsitzende die folgenden Beschlüsse zur Abstimmung, die einstimmig angenommen wurden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 5.4 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
„ 5.4. Jegliche neuen, in bar oder in Sachleistungen, durch die Aktivierung von Rücklagen oder mit sonstigen Mitteln
zu bezahlenden Aktien werden den Altaktionären bevorzugt angeboten. Gibt es mehrere Altaktionäre, werden diese
Aktien ihnen im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien des Aktienkapitals der Gesellschaft angeboten.
Entscheidet sich ein Aktionär gegen die Ausübung seines Vorzugsbezugsrechtes, wird dieses Recht vorbehaltlich der
Einhaltung von § 8.5 anteilsgemäß denjenigen Aktionären überlassen, die zur Ausübung ihres Vorzugsbezugsrechtes bereit
sind. Der Verwaltungsrat legt die Frist fest, über die dieses Vorzugsbezugsrecht ausgeübt werden kann. Diese Frist beträgt
mindestens dreißig (30) Tage ab dem Tag der Versendung eines an die Aktionäre versandten eingeschriebenen Briefes,
worin die Eröffnung der Zeichnung bekannt gegeben wird. Jedoch kann die Hauptversammlung, die zur Entscheidung über
eine Kapitalerhöhung einberufen worden ist, vorbehaltlich der gesetzlich und des von den Aktionären abgeschlossenen
bzw. von Zeit zu Zeit abgeänderten Aktionärsvertrages (nachstehend „Aktionärsvertrag“) vorgeschriebenen Bedingun-
gen, in einem von ihr geforderten Beschluss zur Erhöhung des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft, das
Vorzugsbezugsrecht der Altaktionäre beschränken oder ganz außer Kraft setzen. Dieser Beschluss über die Erhöhung
des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft wird so gefasst, wie es zur Änderung der vorliegenden Satzung erfor-
derlich und wie in § 5.3 vorgeschrieben ist. Der Beschluss über die Beschränkung bzw. Außerkraftsetzung des Vorzugs-
bezugsrechtes von Altaktionären muss von allen Aktionären der Gesellschaft einstimmig gefasst werden.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 8.5 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
„ 8.5. Kein Aktionär der Gesellschaft, außer dem Staat bzw. der SNCI darf (zusammen mit einem seiner verbundenen
Unternehmen und /oder, jedoch nur bezogen auf AXA Redilion ManagementCo, mit AXA Redilion Übertragungsemp-
fänger wie im zweiten Absatz von § 11 Bezug genommen wird) zum Halten von mehr als dreiunddreißig Prozent (33 %)
des Aktienkapitals der Gesellschaft berechtigt werden, sofern nicht die vorherige schriftliche Zustimmung von Aktionären
vorliegt, die zusammen drei Viertel (3/4) des Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten. Um Missverständnisse auszu-
schließen, darf niemand jemals unter jedweden Umständen, ob eine natürliche Person oder eine juristische Person oder
andere, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, einen Aktionär der Gesellschaft und / oder seiner Muttergesellschaft
und / oder seiner (direkten oder indirekten) Aktionäre, außer dem Staat und / oder der SNCI, (zusammen mit einem
seiner verbundenen Unternehmen und /oder, jedoch nur bezogen auf AXA Redilion ManagementCo, mit AXA Redilion
Übertragungsempfänger wie im zweiten Absatz von § 11 Bezug genommen wird) eine Gesamtzahl von Aktien der Ge-
sellschaft halten, direkt und / oder indirekt, und / oder ein Interesse und / oder Einfluss und / oder Kontrolle, Leitung
oder jedwede andere Befugnis innehaben, die mehr als insgesamt dreiundreißig (33) Prozent des Aktienkapitals der Ge-
sellschaft darstellt, außer es liegt eine vorherige schriftliche Zustimmung der Aktionäre vor, die mindestens drei Viertel
(3/4) des Aktienkapitals der Gesellschaft halten. Die Aktionäre stimmen zu, dass sie im Bezug darauf jede notwendige(n)
Maßnahme, Beschlüsse und Genehmigungen im Einklang mit dem anwendbaren Recht vornehmen oder, einschließlich
durch die Gesellschaft, vornehmen lassen.“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 10.1.6 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
„ 10.1.6. Sofern der übertragende Aktionär und die anderen Aktionäre sich nicht anders einigen, darf der übertragende
Aktionär kein Schreiben an die übrigen Aktionäre senden, wenn die zu übertragende Anzahl der Aktien der Gesellschaft
zusammen mit der Anzahl von Aktien der Gesellschaft, die bereits von verbundenen Unternehmen des voraussichtlichen
Übertragungsempfängers (falls der voraussichtliche Übertragungsempfänger kein Aktionär der Gesellschaft ist) sowie von
irgend einer Person, die berücksichtigt werden muss im Hinblick auf die dreiundreißig (33) Prozent Obergrenze, die in §
8.5 festgesetzt ist, gehalten werden oder von einem voraussichtlichen Übertragungsempfänger (zusammen mit verbun-
denen Unternehmen oder irgend einer Person, die berücksichtigt werden muss im Hinblick auf die dreiundreißig (33)
Prozent Obergrenze, die in § 8.5 festgesetztist), zur Überschreitung der dreiundreißig (33) Prozent Obergrenze, die in
Artikel 8.5 festgesetztist, führen würde. Im letzteren Fall kann der übertragende Aktionär sich für das in § 10.2 dargelegte
Verfahren entscheiden.“
102442
L
U X E M B O U R G
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 10.4.2 der Satzung der Gesellschaft aufzuheben und anschließend die Artikel 10.4.3
und 10.4.4 in der Numerierung zu ändern in jeweils Artikel 10.4.2 und 10.4.3.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 10.4.2 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
„ 10.4.2. Auf jeden Fall ist der Rückkauf für jeweils fünf (5) Jahren auf eine Höchstmenge von zehn Prozent (10 %) des
gesamten Aktienkapitals der Gesellschaft beschränkt, wobei die erste Frist von fünf (5) Jahren am 18. Dezember 2008
beginnt.“
<i>Sechster Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 10.4.3 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
„ 10.4.3. Entscheidet sich die Gesellschaft gegen einen Rückkauf, darf der übertragende Aktionär innerhalb einer Frist
von zwölf (12) Geschäftstagen nach dieser Entscheidung:
- entweder die übrigen Aktionäre darüber unterrichten, dass er nicht mehr plant, die angebotenen Aktien zu über-
tragen, wobei er nur den Teilbezug akzeptieren kann; oder
- die übrigen Aktionäre darüber unterrichten, dass er sein Recht ausübt, innerhalb einer Frist von sechs (6) Monaten
nach dieser Mitteilung frei einen Vertrag über die Übertragung (auch mittels eines Tausches von Vermögenswerten)
sämtlicher angebotener Aktien (falls kein Aktionär sein Vorkaufsrecht ausgeübt hat) oder eines Teiles davon (d. h., des
Teiles, der nicht vom Teilbezug betroffen ist) mit einem in gutem Glauben handelnden Käufer abzuschließen. Wird die
im vorliegenden Absatz dargelegte zweite Möglichkeit gewählt, wird der ggf. unter den Teilbezug fallende Teil der ange-
botenen Aktien so schnell wie praktisch möglich an den sein Vorkaufsrecht ausübenden Aktionär übertragen, nachdem
der übertragende Aktionär mitgeteilt hat, dass er diese zweite Möglichkeit wahrnimmt.“
<i>Siebenter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
„ § 11. Zulässige Übertragungen. Die Bestimmungen von § 10 gelten nicht, wenn ein Aktionär (außer AXA Redilion
ManagementCo und AXA Redilion Übertragungsempfänger) seine Aktien der Gesellschaft an ein mit ihm verbundenes
Unternehmen überträgt, jeweils vorausgesetzt, dass das verbundene Unternehmen schriftlich in einer Beitrittsurkunde
dem Aktionärsvertrag zustimmt und sich verpflichtet, die Aktien der Gesellschaft an den Aktionär-Überträger zurück-
zugeben, sobald es kein verbundenes Unternehmen mehr ist. In der Regel kommen alle Rechte des betreffenden Aktionärs
gemäß der vorliegenden Satzung und dem Aktionärsvertrag dem verbundenen Unternehmen zugute, wenn ein Aktionär
seine Aktien der Gesellschaft an dieses überträgt. Um Missverständnisse auszuschließen: Der Staat und die SNCI gelten
als miteinander verbundene Unternehmen und im Falle der Übertragung der Aktien des Staates an die SNCI kommen
alle Rechte des Staates gemäß der vorliegenden Satzung und dem Aktionärsvertrag der SNCI zugute. Sonstige Übertra-
gungen, für die die Bestimmungen von § 10 nicht gelten, können im Laufe der Zeit vom Aktionärsvertrag gestattet werden.
Des weiteren kann AXA Redilion ManagementCo frei sämtliche Aktien übertragen (die „Übertragung von mittels
Vorkaufsrecht erworbenen Aktien “), die sie an der Gesellschaft erworben hat, in Folge der Ausübung ihrer Vorkaufs-
rechte gemäß den entsprechenden Bestimmungen des § 10, an ein Unternehmen („AXA Redilion Übertragungsempfän-
ger“), das geführt und direkt oder indirekt kontrolliert wird von AXA Investment Managers Private Equity S.A., in der
gleichen Weise wie AXA Redilion ManagementCo geführt und direkt oder indirekt kontrolliert wird von AXA Investment
Managers Private Equity S.A., wie gegebenenfalls weiter im Aktionärsvertrag beschrieben, und das alle weitere Bedin-
gungen erfüllt, damit es keine Änderung der Mehrheitsverhältnisse in Bezug auf AXA Redilion Übertragungsempfänger
gibt, die im Aktionärsvertrag festgelegt sein könnte, sofern es immer das gleiche Unternehmen für jede Übertragung von
mittels Vorkaufsrecht erworbenen Aktien ist, und dass ein solches Unternehmen, i.e. AXA Redilion Übertragungsemp-
fänger, schriftlich in einer Beitrittsurkunde dem Aktionärsvertrag zustimmt, und sich verpflichtet sämtliche seiner Aktien
in der Gesellschaft an die AXA Redilion ManagementCo zurückzugeben für den Fall dass, und sobald wie, AXA Redilion
Übertragungsempfänger nicht länger geführt und direkt oder indirekt von AXA Investment Mangers Private Equity S.A.
kontrolliert wird (das „Geschehen“) (Um Missverständnisse auszuschließen, AXA Redilion ManagementCo wird die Ak-
tien behalten, die sie an der Gesellschaft hielt, bevor sie ihre Vorzugsrechte ausgeübt hat). Um Missverständnisse
auszuschließenund zusätzlich zu anderen Fällen von Änderungen der Mehrheitsverhältnisse in Bezug auf AXA Redilion
Übertragungsempfänger, findet im Fall eines Scheiterns seitens der AXA Redilion Übertragungsempfänger darin alle Ak-
tien, die AXA Redilion Übertragungsempfänger an der Gesellschaft hält, an die AXA Redilion ManagementCo unverzüglich
zurückzugeben bei einem Geschehen, einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse statt in Bezug auf AXA Redilion Über-
tragungsempfänger und § 12 findet Anwendung. AXA Redilion Übertragungsempfänger und AXA Redilion ManagementCo
werden zusammen als ein Aktieninhaber gezählt (i) für den Zweck der Bestimmung ihrer Rechte, im Verwaltungsrat der
Gesellschaft und ihrer Unternehmen vertreten zu sein und in jedwedem Ausschuss, der im Aktionärsvertrag vorgesehen
ist, ohne das jedoch eine gemeinschuldnerische Haftung dadurch begründet wird und (ii) für den Zweck der Begrenzung
auf dreiundreißig (33) Prozent aus § 8.5, so dass AXA Redilion ManagementCo zusammen mit jedwedem verbundenen
102443
L
U X E M B O U R G
Unternehmen und / oder AXA Redilion Übertragungsempfänger nicht das Recht hat, Aktien in der Gesellschaft zu halten,
die mehr als dreiundreißig (33) Prozent des Aktienkapitals der Gesellschaft darstellen, außer es besteht die vorherige
schriftliche Einwilligung von Aktionären, die drei Viertel (3/4) des Aktienkapitals der Gesellschaft halten.
Die Übertragung der Aktien, die AXA Redilion Übertragungsempfänger im Einklang mit dem vorhergehenden Ab-
schnitt hält, geschieht gemäß den Vorschriften des § 10, außer dass es AXA Redilion Übertragungsempfänger nicht
gestattet ist, einen Anteil seiner Aktien an der Gesellschaft zu übertragen, der weniger als 5 % des Aktienkapitals der
Gesellschaft darstellt.
Wenn AXA Redilion ManagementCo entscheidet, alle seine Aktien an der Gesellschaft an einen Dritten als Erwerber
zu übertragen, müssen die Aktien der AXA Redilion Übertragungsempfänger gleichzeitig an denselben Erwerber über-
tragen werden, es sei denn die anderen Aktionäre vereinbaren etwas anderes.
Sofern die Aktionäre sich nicht anderweitig geeinigt haben, muss die AXA Redilion ManagementCo jederzeit eine
Anzahl von Aktien an der Gesellschaft halten, die zumindest der Zahl entspricht, die die AXA Redilion Übertragungs-
empfänger an der Gesellschaft hält.“
<i>Achter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
„ § 13. Parlamentarische Genehmigung und Genehmigung des Stadtrats Die Aktionäre (außer dem Staat) anerkennen,
dass der Staat die jeweils erforderlichen Genehmigungen vom Parlament einholen muss, um die Rechte auszuüben, die
er gemäß den verschiedenen Absätzen der vorliegenden Satzung besitzt. Die Aktionäre (außer dem Staat) verpflichten
sich, dem Staat die notwendige Frist einzuräumen, damit er seine Rechte ausüben kann, und bei Bedarf die in der vorlie-
genden Satzung vorgesehenen Abläufe während des Verlaufs des parlamentarischen Verfahrens zeitweilig außer Kraft zu
setzen. Der Staat bemüht sich nach besten Kräften, die parlamentarische Genehmigung innerhalb von fünfundsechzig (65)
Tagen nach der Festlegung der für die angebotenen Aktien zu zahlenden Gegenleistung zu erlangen.
Die Aktionäre (außer VdL) anerkennen, dass VdL die jeweils erforderlichen Genehmigungen vom Stadtrat einholen
muss, um die Rechte auszuüben, die sie gemäß den verschiedenen Vorschriften der vorliegenden Satzung besitzt. Die
Aktionäre (außer VdL) verpflichten sich, VdL die notwendige Frist einzuräumen, damit sie ihre Rechte ausüben kann, und
bei Bedarf die in den betreffenden Absätzen der vorliegenden Satzung vorgesehenen Abläufe während des Verlaufs des
stadträtlichen Verfahrens zeitweilig außer Kraft zu setzen. VdL bemüht sich nach besten Kräften, die parlamentarische
Genehmigung innerhalb von fünfundsechzig (65) Geschäftstagen nach der Festlegung der für die angebotenen Aktien zu
zahlenden Gegenleistung zu erlangen.“
<i>Neunter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 16.4.3 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
„ 16.4.3. Vorbehaltlich entgegenstehender Regelungen in dieser Satzung werden auf außerordentlichen Hauptver-
sammlungen Beschlüsse mit Zweidrittelmehrheit der auf denjenigen Hauptversammlungen gültig abgegebenen Stimmen
gefasst, auf denen bei der ersten Aufforderung die Inhaber von mindestens der Hälfte des Aktienkapitals anwesend bzw.
vertreten sind. Vorbehaltlich entgegenstehender Regelungen in dieser Satzung werden bei einer zweiten Aufforderung
Beschlüsse mit Zweidrittelmehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig davon, welcher Teil des Kapitals
anwesend bzw. vertreten ist.
Außerordentliche Hauptversammlungen stimmen unter anderem über alle Änderungen der Satzung ab, einschließlich
der Erhöhung und Verringerung des Aktienkapitals (ggf. außer bei genehmigtem Kapital) und der Auflösung der Gesell-
schaft.“
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 19.5 der Satzung der Gesellschaft aufzuheben.
<i>Elfter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 20.4 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
„ 20.4. Neben den gesetzlich dem Verwaltungsrat zugewiesenen Befugnissen besitzt der Verwaltungsrat in Bezug auf
die Gesellschaft bzw. ihre Tochtergesellschaften die ausschließlichen Befugnisse zur Genehmigung von Folgendem (und
darf diese Befugnisse nicht an die Geschäftsführung abtreten):
a) hinsichtlich der Gesellschaft, der Leitungsgesellschaft, der Vertriebsgesellschaft und der Hauptgesellschaften die zum
Halbjahr fällige Vorlage des (dreijährigen) Geschäftsplans
b) alle Beteiligungen und Entflechtungen bezüglich Sach-und Finanzanlagen, die über 25.000.000 EUR (in Worten: fünf-
undzwanzig Millionen Euro) hinausgehen (selbst wenn sie bereits von dem betreffenden jährlichen Budget oder Ge-
schäftsplan gedeckt sind)
c) die Gründung, den Kauf, den Verkauf und die Schließung von wichtigen Tochtergesellschaften und Niederlassungen
sowie wesentliche Änderungen (einschließlich von Kapitalerhöhungen und -verringerungen) ihrer verfassungsgebenden
Urkunden
102444
L
U X E M B O U R G
d) die Außerkraftsetzung von geplanten Geschäftstätigkeiten, Fusionen, Entflechtungen und Abwicklungen
e) den Kauf, den Verkauf und die Belastung von Immobilien sowie das Mieten von Immobilien für eine (jährliche)
Mietzahlung von über 5.000.000 EUR (in Worten: fünf Millionen Euro)
f) die Erteilung von Gewährleistungen und Garantien (außer den bereits im maßgeblichen Jahresgeschäftsplan oder
jährlichen Budget abgedeckten Garantien) in Höhe von über 25.000.000 EUR (in Worten: fünfundzwanzig Millionen Euro)
g) den Abschluss von Verträgen über einen Wert von mehr als 25.000.000 EUR (in Worten: fünfundzwanzig Millionen
Euro) mit Aktionären, deren verbundenen Unternehmen und Verwaltungsratsmitgliedern (außer wenn diese im maßge-
blichen Jahresgeschäftsplan bzw. jährlichen Budget vorgesehen sind)
h) den Abschluss von Verträgen, die nicht im maßgeblichen Jahresgeschäftsplan bzw. jährlichen Budget vorgesehen sind
(einschließlich von Energieverkaufsverträgen und Energieeinkaufsverträgen, sofern diese Verträge nicht unter die Risiko-
politik und Risikobeschränkungen fallen, die vom Verwaltungsrat zuvor genehmigt wurden) und die einen Gesamtwert
von 100.000.000 EUR (in Worten: einhundert Millionen Euro) überschreiten
i) die Gewährung bzw. Aufnahme von Darlehen und sonstigen Krediten (einschließlich von Anleihen und ähnlichen
Wertpapieren) in Höhe von über 10.000.000 EUR (in Worten: zehn Millionen Euro).
Sofern dies gesetzlich erlaubt und möglich ist, wird jede Entscheidung, die einen Bereich in der oben dargestellten Liste
betrifft (außer unter lit. „a)“) und die im Bezug auf eine Konzerngesellschaft (unter Ausschluss der Tochtergesellschaften)
getroffen werden muss, Gegenstand eines Berichts der Geschäftsführung an den Verwaltungsrat sein, bevor solche Ent-
scheidungen auf der Ebene einer solchen Konzerngesellschaft getroffen werden.“
<i>Zwölfter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 20.5 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
" 20.5. Die unter § 20.4 lit. b, f und h dargelegten Genehmigungen sowie die Genehmigung durch die Leitungsgesellschaft
bzgl. der Ausgabe von neuen Aktien an andere Leitungs-und Verteilungssystembetreiber im Gegenzug für den Erwerb
ihrer Infrastruktur außerhalb von Luxemburg, erfordern eine Dreifünftelmehrheit von 3/5 der bei der betreffenden Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrates.“
<i>Dreizehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 20.6 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
" 20.6. Nach der Beschlussfassung seitens des Verwaltungsrates mit den Stimmen der Zweidrittelmehrheit 2/3 seiner
bei der betreffenden Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder, können die in § 20.4 aufgeführten Genehmigungen
mit weiteren Genehmigungen abgeändert und/oder ergänzt werden, die die Genehmigung des Verwaltungsrates mit
Dreifünftelmehrheit 3/5 seiner bei der betreffenden Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder erfordern."
<i>Vierzehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 20.7 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
" 20.7. Die in §§ 20.4, 20.5 und 20.6 dargelegten Vorschriften treffen dann nicht mehr auf die Leitungsgesellschaft und
ihre Tochtergesellschaften zu, falls der Staat bzw. die SNCI eine Mehrheitsbeteiligung an der betreffenden Tochterge-
sellschaft erwirbt."
<i>Fünfzehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 21.1 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut zu ändern:
„ 21.1. Der Verwaltungsrat ernennt einen (1) Vorsitzenden (nachstehend "Vorsitzender"), der aus dem Kreis der
Verwaltungsratsmitglieder ausgewählt wird, die vom Aktionär mit der höchsten Anzahl von Aktien der Gesellschaft (wobei
in diesem Fall der Staat und die SNCI zusammen als ein Aktionär gelten) vorgeschlagen wurden.“
<i>Sechzehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss einen Abschnitt H. Leitungsgesellschaft zur Satzung der Gesellschaft hinzuzufügen. Im
Anschluss werden die Abschnitte H und I jeweils umnummeriertals Abschnitte I und J und der gegenwärtige Artikel 33
wird in Artikel 34 umnummeriert.
<i>Siebzehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, unter Abschnitt H einen Artikel 33 Leitungsgesellschaft zu der Satzung der Gesellschaft
mit folgendem Wortlaut hinzuzufügen:
„H. Leitungsgesellschaft
§ 33. Leitungsgesellschaft. Der Staat und/oder die SNCI müssen zu jederzeit bei einer Anfrage oder bei mehrere
aufeinanderfolgenden Anfragen des Staates alleine oder des Staates gemeinsam mit der SNCI, sofern dies Anwendung
findet, jedes Mal für einen Anteil (und ungeachtet der Ebene der Beteiligung der Gesellschaft in den Tochtergesellschaften)
eine direkte Beteiligung und sofern dies angefordert wird sogar eine qualifizierte (bspw. zweidrittel) Mehrheit in dem
102445
L
U X E M B O U R G
Gesellschaftskapital der Leitungsgesellschaft erhalten. Die Aktionäre der Gesellschaft sollen die erforderlichen Handlun-
gen, Beschlüsse und vorzunehmenden Genehmigungen ergreifen um einen solchen Effekt (einschließlich durch die
Gesellschaft) und im Besonderen solche Beschlüsse der Aktionäre und/oder der Tochtergesellschaften der Gesellschaft
herbeizuführen, die es dem Staat und/oder der SNCI ermöglichen, Beteiligung(en) wie bereits oben dargelegt in einer
oder mehreren aufeinander folgenden Handlungen zu erhalten. Alle in diesem Zusammenhang notwendigen Vorgänge
müssen den Fremdvergleichsgrundsatz («arm's length principle») berücksichtigen.
Soweit nicht anders zwischen der Gesellschaft und dem Staat und/oder der SNCI vereinbart, und sofern dies anwend-
bar ist, muss der gebotene Kaufpreis jedes Mal für eine solche Beteiligung (basierend auf dem Marktwert dieser Beteiligung,
gewertet als ein «going concern» am Tag der Benachrichtigung (der "Erwerbsbenachrichtigung") durch den Staat allein
oder gemeinsam mit der SNCI von der Absicht des Staates und/oder der SNCI, sofern anwendbar, solche Beteiligungen
zu erwerben ) von einem durch den Erwerber (z.B. der Staat und/oder die SNCI, wo anwendbar) und durch die Gesell-
schaft (handelnd durch seine Verwaltungsratsmitglieder and nicht durch die Geschäftsführung) zu ernennenden Schätzer
bestimmt werden. Im Falle des Scheiterns einen solchen Schätzer innerhalb von 20 (zwanzig)Geschäftstagen ab dem
Eingang der Erwerbsbenachrichtigung zu benennen, wird der Schätzer durch den Präsidenten des Bezirksgerichts der
Stadt Luxemburg (Président du Tribunal d'Arrondissement) auf Antrag entweder des Staates und/oder der SNCI, sofern
anwendbar, oder durch die Gesellschaft, stellvertretend für den Staat und/oder die SNCI, sofern anwendbar, oder durch
die Gesellschaft, bestellt werden.
Die Beteiligung(en) wird/werden auf Basis dieses Preisen erworben, es sei denn der Staat und/oder die SNCI, sofern
anwendbar, lehnt oder lehnen es ab, die Beteiligung(en) zu einem solchen Preis zu erwerben und benachrichtigt die
Gesellschaft innerhalb von zwölf (12) Geschäftstagen ab Empfang des Schlussberichts des Schätzers.
Fünfzig (50) Prozent der Gebühren des Schätzers werden von der Gesellschaft und fünfzig (50) Prozent werden von
dem Erwerber (d. h. dem Staat und/oder der SNCI, sofern anwendbar) getragen.
Der Staat und/oder die SNCI, sofern anwendbar, erklären sich einverstanden, nicht aus kommerziellen Gründen für
einen Zeitraum von zehn (10) Jahren, beginnend ab dem Datum des Erwerbs der betreffenden Aktien in der Leitungs-
gesellschaft, alle oder Teile der Aktien, die er/sie in der Leitungsgesellschaft erworben hat/haben, zu verkaufen, vorbe-
haltlich des im Folgenden Gesagten. Es besteht Einigkeit, dass der Staat und/oder die SNCI dazu berechtigt ist / sind, zu
jeder Zeit und in jeder der in § 33.3 genannten Fälle (i) bis (iv), sogar innerhalb des oben genannten Zeitraums von zehn
(10) Jahren, alle oder Teile seiner Aktien, die er/sie in der Leitungsgesellschaft halten, zu verkaufen.
33.1 Vorbehaltlich der hier im Anschluss in § 33.3 genannten Ausnahmen und vorbehaltlich des vorangehenden Para-
graphen, muss der Staat und/oder die SNCI, sofern anwendbar, für den Fall, dass er/sie den Verkauf aller oder Teile der
Aktien, die er/sie aus dem Gesellschaftskapital der Leitungsgesellschaft erworben hat, an einen anderen voraussichtlichen
Übertragungsempfänger, der nicht die Gesellschaft ist, vorschlägt, dann muss der Staat und/ oder die SNCI, sofern an-
wendbar , umgehend eine schriftliche Erklärung mit der Absichtserklärung (die "Absichtserklärung") den Verkauf
durchführen zu wollen, an die Gesellschaft senden. Die Absichtserklärung muss (i) die Anzahl der Aktien der Elektrizi-
tätsgesellschaft, welche übertragen werden sollen (nachfolgend die "Leitungsanteile»), (ii) den (die) Namen und Adresse
(n) des/der interessierten Erwerber(s) und (iii) den von einen/mehreren interessierten Erwerber(n) gutgläubig angebo-
tenen Verkaufspreis, beinhalten Die Gesellschaft muss, innerhalb eines Zeitraums von zwanzig (20) Geschäftstagen nach
Empfang der Absichtserklärung an, wählen, ob sie alle Leitungssanteile zu dem in der Absichtserklärung festgelegten Preis
erwirbt oder nicht erwirbt (das Nichtabsenden einer Kauferklärung wird als Erklärung nicht kaufen zu wollen gewertet)
und eine schriftliche Erklärung an den Staat und/oder die SNCI, sofern anwenbar, senden.
Sollte die Gesellschaft sich entschließen, wie im vorangehenden Paragraphen beschrieben, nicht zu erwerben, kann der
Staat und/oder die SNCI ohne Weiteres die Leitungsanteile an den/die interessierten Erwerber zu dem in der Absicht-
erklärung genannten Preis für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten nach dem Ende der zwanzig (20) Geschäftstage
veräußern, wobei darüber Einigkeit besteht, dass abhängig von den Umständen, der Abschluss der Veräußerungsverein-
barung von der erforderlichen kartell-oder wettbewerbsbezogenen Genehmigung des abhängig sein kann.
33.2 Vorbehaltlich der hier im § 33.3 genannten Ausnahmen, kann die Gesellschaft, für den Fall, dass der Staat und/
oder die SNCI, sofern anwendbar, alle oder Teile seiner/ihrer Beteiligungen, die er/sie aus dem Gesellschaftskapital der
Leitungsgesellschaft erworben hat/haben veräußern möchte, ohne dass ein interessierter Erwerber existiert, innerhalb
von zwanzig (20) Geschäftstagen nach Empfang der Benachrichtigung der Absicht durch den Staat und/oder die SNCI eine
solche Beteiligung zu veräußern, und vorbehaltlich seines Ablehnungsrechtes nach der Bestimmung des Preises, entschei-
den, die Gesamtheit der Beteiligung des Staates und/oder der SNCI, sofern anwendbar, die er/sie veräußern wollte, zu
erwerben.
Soweit nichts anders zwischen der Gesellschaft und dem Staat und/oder der SNCI, sofern anwendbar, vereinbart
wurde, wird der Kaufpreis für den Rückkauf dieser Beteiligung (basierend auf dem Marktwert dieser Beteiligung, gewertet
als ein«going concern» am Tag der Benachrichtigung durch die Gesellschaft von seiner Absicht eine solche Beteiligung
zurückkaufen zu wollen) von einem durch den Staat und/oder der SNCI, sofern anwendbar, und der Gesellschaft (handelnd
durch seine Verwaltungsratsmitglieder und nicht durch die Geschäftsführung) zu ernennenden Schätzer bestimmt werden.
Im Falle des Scheiterns einen solchen Schätzer innerhalb von 20 (zwanzig) Geschäftstagen ab dem Eingang der Er-
werbsbenachrichtigung zu benennen, soll der Schätzer durch den Präsidenten des Bezirksgerichts der Stadt Luxemburg
(Président du Tribunal d'Arrondissement) auf Antrag entweder des Staates und/oder der SNCI, sofern anwendbar, oder
102446
L
U X E M B O U R G
durch die Gesellschaft, stellvertretend für den Staat und/oder die SNCI, sofern anwendbar, oder durch die Gesellschaft,
bestellt werden. Die Beteiligung wird auf der Basis dieses Preises zurück gekauft, es sei denn (i) die Gesellschaft lehnt es
ab, eine die Beteiligung zu einem solchen Preis zu erwerben und benachrichtigt sodann den Staat und/oder die SNCI, wo
anwendbar, innerhalb von zwanzig (20) Geschäftstagen ab dem Eingang des Schlussberichts des Schätzers und/oder (ii)
es sei denn der Staat und/oder die SNCI, wo anwendbar, lehnen es ab, die Beteiligung zu einem solchen Preis zu veräußern
und benachrichtigen so dann die Gesellschaft innerhalb von zwölf (12) Geschäftstagen nach Empfang des Schlussberichts
des Schätzers.
Fünfzig (50) Prozent der Gebühren des Schätzers werden von der Gesellschaft und fünfzig (50) Prozent werden von
dem Erwerber (d.h. dem Staat und/oder der SNCI,wo anwendbar) getragen.
Für den Fall, dass die Gesellschaft sich nicht entschlossen hat oder es abgelehnt hat, die Gesamtheit der Beteiligung,
die der Staat und/oder die SNCI, wo anwendbar, veräußern wollte, zu erwerben, kann der Staat und/oder die SNCI diese
Beteiligung ohne Weiteres an einen anderen Erwerber als die Gesellschaft veräußern und zwar zum selben Preis, welcher
zuletzt vom Schätzer bestimmt wurde.
33.3 Die Gesellschaft darf nicht vom Vorkaufsrechtwie zuvor beschrieben profitieren:
(i) Im Falle einer Veräußerung aller oder Teile einer solchen Beteiligung zwischen dem Staat und der SNCI, solange
der Staat der Mehrheitseigentümer der SNCI ist;
(ii) Im Falle, dass der Staat und/oder SNCI, sofern anwendbar, alle oder Teile einer solchen Beteiligung an eine oder
mehrere Gemeinden oder öffentliche Einrichtungen oder Tochtergesellschaften des Staates und/oder der SNCI veräußern
möchte, vorausgesetzt der Staat und / oder SNCI einigen sich mit der jeweiligen Gemeinde, öffentlichen Einrichtungen
oder Tochtergesellschaft darüber, dass die Gesellschaft von einem Bezugsrecht wie in den oben beschriebenen §§ 33.1
und 33.2 dieses Artikels für den Fall einer späteren Veräußerung an eine andere dritte Partei ( andere als der Staat und/
oder die SNCI und/oder einer ihrer Tochtergesellschaften) von jeglichen Aktien der Leitungsgesellschaft durch eine solche
Gemeinde oder öffentliche Einrichtung oder einer Tochtergesellschaft des Staates und/oder der SNCI profitiert;
(iii) Im Falle, dass der Staat und/oder die SNCI, sofern anwendbar, eingeschränkt ist (aufgrund der Anwendung von
Rechts-oder Verwaltungsvorschriften oder Verpflichtungen oder gegebenenfalls durch Gerichtsentscheidung) alle oder
Teile einer solchen Beteiligung zu veräußern. In einem solchen Fall sind der Staat und/oder die SNCI ungehindert, alle
oder Teile seiner/ihrer Aktien an jeden Erwerber, anderen als die Gesellschaft selbst und/oder an die Gesellschaft zu
veräußern;
(iv) Im Falle, dass die Leitungsgesellschaft (aufgrund der Anwendung von Rechts-oder Verwaltungsvorschriften oder
Verpflichtungen) gehalten ist, sich mit einer oder mehreren Unternehmen zu verschmelzen.
33.4 Jede Änderung (einschließlich Zusätze) zu diesem § 33 bedarf der einstimmigen Zustimmung durch alle Aktien-
inhaber dieser Gesellschaft."
<i>Achtzehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss eine Definition für AXA Investment Managers Private Equity S.A. unter dem neuenAb-
schnitt J der Satzung der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut einzufügen:
"AXA Investment Managers Private Equity S.A." steht für AXA Investment Managers Private Equity S.A., einer nach
französischem Recht gegründete Société Anonyme, die ihren satzungsmäßigen Sitz in Frankreich hat und im Register für
Handel und Gesellschaften in Paris unter der Nummer 403 081 714 registriert ist.
<i>Neunzehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss eine Definition für AXA Redilion ManagementCo unter dem neuenAbschnitt J der Satzung
der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut einzufügen:
"AXA Redilion ManagementCo" steht für AXA Redilion ManagementCo SCA, einer nach dem Großherzogtum Lu-
xemburg geltendem Recht gegründeten Gesellschaft, die ihren satzungsmäßigen Sitz im Großherzogtum Luxemburg hat
und im Register für Handel und Gesellschaften in Luxemburg unter der Nummer B168843 registriert ist.
<i>Zwangzigster Beschlussi>
Die Versammlung beschloss eine Definition für AXA Redilion Empfänger unter dem neuenAbschnitt J der Satzung der
Gesellschaft mit folgendem Wortlaut einzufügen:
"AXA Redilion Übertragungsempfänger" hat die Bedeutung wie in § 11 beschrieben.
<i>Einundzwanzigster Beschlussi>
Die Versammlung beschloss die Definition für Änderung der Mehrheitsverhältnisse unter dem neuen Abschnitt J der
Satzung der Gesellschaft umzuändern mit folgendem Wortlaut:
Eine "Änderung der Mehrheitsverhältnisse" (vorbehaltlich jeglicher Bestimmungen des Aktionärsvertrages) tritt dann
ein, wenn:
- ein Aktionär nicht mehr (mittelbar oder unmittelbar) eine vollumfänglich im Eigentum seiner Muttergesellschaft
befindliche Tochtergesellschaft ist; oder
102447
L
U X E M B O U R G
- die Muttergesellschaft am 17. Juli 2012 bzw. im Fall neuer Aktionäre an dem Tag, an dem diese zum Aktionär wurden,
nicht mehr (mittelbar oder unmittelbar) mindestens den gleichen Anteil von Aktien am Aktionär hält (oder nicht mehr
Nießbrauchsberechtigter von diesen ist);
- die Muttergesellschaft das Recht verliert, mehr als fünfzig Prozent (50 %) der Stimmen abzugeben, die in der Haupt-
versammlung abgegeben werden können;
- die Muttergesellschaft die Befugnis verliert, die Geschäftsführung und die Unternehmenspolitik (ob im Wege des
Aktieneigentums, der Stellvertretung, eines Vertrages, einer Beauftragung oder anderweitig) oder die Zusammensetzung
des Verwaltungsrates zu lenken.“
<i>Zweiundzwanzigster Beschlussi>
Die Versammlung beschloss die Definition für Hauptgesellschaften unter dem neuen Abschnitt J der Satzung der Ge-
sellschaft mit folgendem Wortlaut einzufügen:
"Hauptgesellschaften" steht für die Haupt-Tochtergesellschaften der Leitungsgesellschaft (solange die Gesellschaft die
Mehrheit an diese hält) und der Vertriebsgesellschaft, d.h. am 17. Juli 2012, Enovos Deutschland AG, Creos Deutschland
GmbH, Enovos Energie Deutschland GmbH und Leo (Luxembourg Energy Office) S.A.
<i>Dreiundzwanzigster Beschlussi>
Die Versammlung beschloss eine Definition für Vdl unter dem neuen Abschnitt J der Satzung der Gesellschaft mit
folgendem Wortlaut einzufügen: "Vdl" steht für Ville de Luxembourg, handelnd durch das Kollegium seiner aktuell im Amt
vertretenen Bürgermeister und der Beigeordneten, ordnungsgemäß vertreten durch das Beigordnetenkollegium (Collège
Echevinal), mit der Adresse in L-2950 Luxembourg.
<i>Vierundzwanzigster Beschlussi>
Die Versammlung bestätigte die Rücktritte der HerrenNico Wietor, Claude Seywert und Fernand Felzinger als Mit-
glieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit Wirkung von heutigem Tage.
<i>Fünfundzwanzigster Beschlussi>
Die Versammlung ernannte als Mitglieder des Verwaltungsratesder Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Datum
und für einen Zeitraum, der endet wenn die Hauptversammlung der Aktionäre die Entlastung für die Konten des Finanz-
jahres endend am 31 Dezember 2013, erteilt:
- Herrn Benoit Gaillochet, Fondsmanager, geboren am 4. September 1972 in Senlis (Frankreich), berufliche Adresse
in 20, place Vendôme, 75001 Paris, Frankreich;
- Herrn Stephan Illenberger, geboren am 11. April 1959 in Bremen (Deutschland), berufliche Adresse in c/o Axa Private
Equity Luxembourg S.à r.l., 24, avenue Emile Reuter, 2420 Luxemburg; und
- Herrn Fernand Felzinger, geboren am 9. Februar 1957 in Saarbourg (Frankreich), berufliche Adresse in 53, avenue
de Saint-Germain, 78600 Maisons-Lafitte, Frankreich.
<i>Sechsundzwanzigster Beschlussi>
Die Versammlung ermächtigte den unterzeichnenden Notar alle notwendigen Handlungen vorzunehmen, um Rück-
tritte und Ernennungen, die aus den obigen Beschlüssen resultieren, bei dem luxemburgischen Register für Handel und
Gesellschaften einzureichen und einzutragen.
Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung austehend waren, und keine weiteren Anträge zur Diskussion an-
standen, wurde die Versammlung beendet. Die vorliegende notarialle Urkunde wurde in L-1445 Strassen, 2, rue Thomas
Edison, hierüber verfasst, an dem Tag, der zu Anfang dieses Dokuments benannt ist.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, beurkundet hiermit auf Antrag der
erschienenen Parteien, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Version; auf Antrag der selben erschienenen Parteien ist im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text die englische Fassung maßgebend.
Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, haben diese erschienenen Personen diese
Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: M. HOFFMANN, M. SCHAUS, G. SCHLINK und J. BADEN
Enregistré à Luxembourg A. C., le 18 juillet 2012. LAC / 2012 / 34126. Reçu soixante-quinze euros € 75,
<i>Le Receveuri> (signé): THILL Irène.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 30. Juli 2012.
Référence de publication: 2012095061/796.
(120131049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.
102448
L
U X E M B O U R G
CCP III CZ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 162.462.
Les comptes annuels pour la période du 19 juillet 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096659/11.
(120132534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
CCP III Germany Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 164.772.
Les comptes annuels pour la période du 4 novembre 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096662/11.
(120132530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
CMP II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 135.328.
Par résolutions prises en date du 20 juillet 2012 l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Christopher Finn, avec adresse au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
de son mandat de Gérant de catégorie A, avec effet au 20 juillet 2012.
2. Nomination de David Pearson, avec adresse au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, 20004-2505
Washington D.C., Etats-Unis, au mandat de Gérant de catégorie A, avec effet au 20 juillet 2012 et pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096678/16.
(120131948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Ceheca S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8371 Hobscheid, 7, rue de Hiehl.
R.C.S. Luxembourg B 98.743.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012096666/11.
(120132226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
CMB Immobilière, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 152, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 158.358.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
102449
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AREND & PARTNERS S.à r.l.
12, rue de la Gare
L-7535 MERSCH
Signature
Référence de publication: 2012096676/13.
(120133206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
CCP III UK Shopping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 161.351.
Les comptes annuels pour la période du 3 juin 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096664/11.
(120132535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
CODUR S.A. (Constructions Durables), Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 89.984.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012096679/11.
(120132130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Ingersoll-Rand Lux Clover Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 170.402.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the sixth day of July.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Ingersoll-Rand Global Holding Company Limited, a company formed in the Islands of Bermuda, having its office address
at Canon's Court, 22 Victoria Street, Box HM 1179, Hamiton HM EX Bermuda, registered with Bermuda Registrar of
Companies of under Registration number 31860,
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/
Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal.
Said power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):
Art. 1. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares
hereafter issued a private limited liability company under the name “Ingersoll-Rand Lux Clover Holding S.à r.l.” which will
be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the Company), and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association
(hereafter the Articles).
102450
L
U X E M B O U R G
Art. 2. The Company is established for an indefinite duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution
of the shareholder(s) adopted in the manner required for amendment of these Articles as prescribed in Article 10 hereof.
Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any
companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may
in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may participate in the creation, development and management of portfolio of patents, know how,
trademarks and any other intellectual or industrial property rights of any nature or origin, without any limitation what-
soever, and may receive and pay royalties and license fees.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities, or of equity, to its subsidiaries, affiliated
companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to
secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may
further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and use any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credits,
currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Company may engage in any intra-group factoring activities and may further develop and carry out either in
Luxembourg or abroad in a branch office or otherwise any headquarter type activities.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.
Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices may
be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager(s).
In the event that the manager(s) determine(s) that extraordinary, political, economic, or social developments have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a
Luxembourg company.
Art. 5. The Company's share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) represented by
twenty thousand (20,000) shares, in registered form, of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully
paid-up.
The share capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the Law.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
Company's decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one
hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share
capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 6. Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to non shareholders is subject
to the consent expressed in a shareholders' meeting of at least seventy-five per cent of the Company's share capital. In
the case of the death of a shareholder, the share transfer shall be made pursuant to applicable legal provisions.
Art. 7. The Company is managed by a board of managers composed of one or several A manager(s) and one or several
B manager(s). Neither the A manager(s) nor the B manager(s) need to be shareholders. The A manager(s) and the B
manager(s) are appointed and dismissed by the general meeting of shareholders acting on the votes of a majority of share
capital, which determines their powers and the duration of their mandates. The A manager(s) and the B manager(s) may
be re-elected and may be revoked ad nutum with or without cause at any time.
Towards third parties, the A manager(s) and the B manager(s), acting jointly, have the most extensive powers for the
ordinary administration of the Company. The A manager(s) and the B manager(s), acting jointly, may execute any act
without exception (other than these acts for which a general meeting is required by the Law) which are deemed appro-
priate with regard to the object of the Company. The Company will be bound by the joint signature of at least two
managers, of which one must be a B manager and one a A manager.
102451
L
U X E M B O U R G
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax
or telex, another manager of the same category as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of
managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the
meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting. Meetings may further be held by way of conference call only.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by
ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.
A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content.
Art. 8. In carrying out their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company,
they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 9. 1. If the Company is composed of a simple shareholder, the latter exercises the powers granted by the Law to
the general meeting of the shareholders.
Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.
2. If the Company is composed of several shareholders, collective decisions are taken by ordinary general or extraor-
dinary general meetings. The convening of general meetings is not necessary for as long as the Company has less than 25
shareholders. In this case, collective decisions may be taken by circular resolutions.
Every shareholder may take part in the collective decisions. His number of votes is equal to the number of shares
which he owns and he may validly act at the meeting either in person or through a special proxy. If the Company has
more than 25 shareholders, a general meeting must be held at least once a year during a time period determined by the
articles. Extraordinary general meetings may be held under circumstances required by the Law.
Art. 10. Collective decisions are only valid if the votes in their favour represent more than half of the share capital.
However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital, and must be recorded by a notarial deed, as required by the Law.
Art. 11. The Company's accounting year begins on 1
st
January and ends on 31
st
December of each year.
Art. 12. Every year the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 13. The financial statements are at the disposal of the shareholder(s) at the registered office of the Company.
Art. 14. Five per cent (5%) out of the net profit shall be placed into a legal reserve account.
This deduction ceases to be compulsory when this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the share capital of the
Company.
The balance is at the disposal of the shareholder(s).
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by at least one A manager and one B manager;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by an
extraordinary general meeting of the shareholders;
4. The payment is made once the sole shareholder, or in the case of a plurality of shareholders, the extraordinary
general meeting of the shareholders, has stated that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
Art. 15. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of any of the shareholders.
The liquidation of the Company, if any, may occur according to provisions of the Law.
Art. 16. In the case that the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who
need not be shareholders and who are appointed by the shareholders who will specify the powers and remuneration of
the liquidators.
Art. 17. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single
shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the Law. In this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the
Law are applicable.
Art. 18. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 December 2013.
102452
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Ingersoll-Rand Global Holding Company Limited, represented as stated above, declares to subscribe to
the whole share capital of the Company, i.e. twenty thousand (20,000) shares, in registered form, of one United States
Dollar (USD 1.-) each, and to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twenty thousand United States
Dollars (USD 20,000.-).
The amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) is forthwith at the disposal of the Company,
evidence thereof has been given to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euro (€
1.500,-).
<i>Resolutions of the sole shareholder of the Companyi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, represented as stated above, resolved to
set at three (3) the number of managers of the Company and further resolved to appoint the following persons as A
managers and B managers for an undetermined period:
1) The following persons are appointed as managers for an undetermined period:
<i>A managers:i>
- Mr Jan OVERSTEYNS, Director International Taxation, born on April 11, 1964 in Knokke, Belgium, residing at c/o
Ingersoll-Rand International Limited, Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium; and
- Mr. Olivier Patrick Henry Pierre Marie CAREMANS, Vice President and General Counsel Europe, Middle East, Africa
& India of Ingersoll Rand, born on 9 August 1971 in Wilrijk, Belgium, residing at c/o Ingersoll-Rand International Limited,
Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium.
<i>B manager:i>
- Ms Agnes Csorgo, company director, born on 27 July 1978 in Hatvan, Hungary, with professional address at 16,
avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2) The Company shall have its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the proxyholder of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrepancies between
the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le sixième jour de juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Ingersoll-Rand Global Holding Company Limited, une société (limited company) établie selon les lois des Bermudes,
dont le siège social est situé au Canon's Court, 22 Victoria Street, Box HM 1179, Hamilton HM EX Bermuda, immatriculée
auprès du Registre de Commerce des Bermudes sous le numéro 31860,
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence professionnelle à Esch/
Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le représentant de la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des
statuts d'une société à responsabilité limitée comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre le(s) souscripteur(s) et tous ceux qui deviendraient détenteurs des parts sociales émises
ci-après, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de “Ingersoll-Rand Lux Clover Holding S.à r.l.” régie
par les lois applicables à une telle entité (ci-après la Société) et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts).
102453
L
U X E M B O U R G
Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. La Société peut être dissoute à tout moment sur décision
des associés, statuant comme en matière de modification des statuts dans les conditions édictées à l'Article 10 ci-après.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés
ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations.
La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres,
actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou
instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement,
la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra participer à la création, développement et gestion de portefeuille de brevets, licences, marques
déposées, savoir-faire et/ou autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle de n'importe quelle nature ou origine,
et pourra recevoir ou payer des redevances et droits de licence.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par
voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créan-
ces. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société pourra effectuer toutes les activités d'affacturages intra-groupe et pourra développer au Luxembourg ou à
l'étranger tout type d'activité de siège ou de succursale ou autrement.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Des succursales ou bureaux tant dans le
Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger peuvent être créés sur simple décision du/des gérant(s).
Au cas où le/les gérant(s) estimeraient que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social
de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000.-) représenté par vingt mille
(20.000) parts sociales, sous forme nominative, d'une valeur nominale de un Dollar Américain (USD 1.-) chacune, toutes
souscrites et intégralement libérées.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment conformément à l'article 199 de la Loi.
La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne pourra être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables suffisantes sont disponibles au regard du surplus du prix d'achat.
La décision de la Société de racheter ses parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent (100%) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et entraînera une réduction du capital
social par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Un transfert de parts sociales entre vifs à un ou
plusieurs non associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée des associés représentant au moins
soixante quinze pour cent du capital social. En cas de décès d'un associé, le transfert des parts sociales sera réalisé
conformément aux dispositions légales applicables.
Art. 7. La Société est administrée par un conseil de gérance composé de un ou plusieurs gérants A et un ou plusieurs
gérants B. Ni les gérants A, ni les gérants B, ne doivent être associés. Le(s) gérant(s) A et le(s) gérant(s) B sont nommés
et révoqués par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité du capital social, cette dernière déterminant leurs
pouvoirs et la durée de leurs mandats. Le(s) gérant(s) A et le(s) gérant(s) B peuvent être réélus et peuvent être révoqués
ad nutum à tout moment avec ou sans motif.
Le(s) gérant(s) A et le(s) gérant(s) B, agissant conjointement, ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour
assurer l'administration ordinaire de la Société. Le(s) gérant(s) A et le(s) gérant(s) B agissant conjointement peuvent
exécuter tous actes, sans exception (autres que les actes pour lesquels la Loi requiert une assemblée générale), qui
102454
L
U X E M B O U R G
semblent appropriés au regard de l'objet de la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de deux gérants
au moins, dont un doit être un gérant de catégorie A et un doit être de catégorie B.
Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, par télécopie ou câble, télé-
gramme, fax ou télex, un autre gérant comme son fondé de pouvoir. Chaque gérant peut assister à une réunion du conseil
de gérance par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication qui permette à tous les participants
à la réunion de s'entendre et de se parler, et la participation à une réunion par de tels moyens sera assimilée à une
présence physique à une telle réunion. Les réunions peuvent aussi être tenues par simple conférence téléphonique.
Les résolutions approuvées par écrit et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions adoptées
lors des réunions des gérants.
Dans ces cas, de telles résolutions ou décisions peuvent être prises expressément, soit en étant formulées dans une
résolution circulaire, ou transmise par courrier ordinaire, courrier électronique ou télécopieur, ou par téléphone, télé-
conférence ou par tout autre moyen de télécommunication approprié.
Pareille résolution écrite pourra être prise dans un seul ou plusieurs documents séparés ayant tous le même contenu.
Art. 8. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune responsabilité personnelle. Comme simples
mandataires de la Société, ils ne sont responsables que de l'exécution correcte de leurs mandats.
Art. 9.
1. Si la Société est composée d'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale
des associés.
Les articles 194 à 196 et 199 de la Loi ne sont pas applicables dans une telle hypothèse.
2. Si la Société est composée de plusieurs associés, les décisions collectives sont prises par assemblées générales
ordinaires ou extraordinaires. La convocation des assemblées générales n'est pas nécessaire, si la Société a moins de 25
associés. Dans ce cas, les décisions collectives peuvent être prises par résolution circulaire.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il
possède et peut valablement agir en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire spécial. Si la Société a plus de 25
associés, une assemblée générale devra au minimum être tenue une fois par an à la date déterminée par les Statuts. Des
assemblées générales extraordinaires pourront être tenues dans les circonstances requises par la Loi.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les votes en leur faveur représentent
plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts, ne pourront être
prises que si les votes exprimés en leur faveur représentent au moins les trois quarts du capital social et devront être
enregistrés par acte notarié, comme requis par la Loi.
Art. 11. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année, les gérants établissent les comptes annuels.
Art. 13. Les comptes annuels sont à la disposition de(s) l'associé(s) au siège social de la Société.
Art. 14. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net pour la constitution d'un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire à partir du moment où la réserve légale atteint dix pourcent (10%) du capital
social de la Société.
Le solde est à la disposition des associés.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par au moins un gérant A et un gérant B,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes,
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après que l'Associé Unique ou en cas de pluralité des associés, l'assemblée
générale des associés ait obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.
Art. 15. La Société ne sera pas dissoute par la mort, l'interdiction, la banqueroute ou l'insolvabilité d'un des associés.
La liquidation de la Société, le cas échéant, sera faite conformément aux dispositions de la Loi.
Art. 16. Dans l'hypothèse d'une dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui détermineront les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.
Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société
est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres,
de la Loi sont applicables.
Art. 18. Pour tous les points qui ne sont pas réglés par les présents Statuts, il sera fait référence à la Loi.
102455
L
U X E M B O U R G
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits, Ingersoll-Rand Global Holding Company Limited, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare souscrire à la totalité du capital social de la Société, soit vingt mille Dollars Américains (USD 20.000.-) parts
sociales, sous forme nominative, de un Dollar Américain (USD 1.-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire d'un montant de vingt mille Dollars Américains (USD 20.000.-).
Le montant de vingt mille Dollars Américains (USD 20.000.-) est dès à présent à la disposition de la Société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s'élèvent à environ mille cinq cents euros (€ 1.500,-).
<i>Résolutions de l'associé unique de la Sociétéi>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représenté comme ci-dessus, a décidé de fixer le
nombre de gérants de la Société à trois (3) et ainsi de nommer les personnes suivantes comme gérants A et gérants B
pour une durée indéterminée:
1) Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants pour une durée illimitée:
<i>Gérants A:i>
- M. Jan Oversteyns, Directeur International Fiscalité, né le 11 avril 1964 à Knokke, Belgique, résidant à c/o Ingersoll-
Rand International Limited, Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgique; et
- M. Olivier Patrick Henry Pierre Marie CAREMANS, Vice President et Conseil Général, Centre Est, Afrique & Inde
de Ingersoll Rand, né le 9 aout 1971 à Wilrijk, Belgique, résidant à c/o Ingersoll-Rand International Limited, Lenneke
Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgique.
<i>Gérant B:i>
- Mme Agnes Csorgo, administrateur de sociétés, née le 27 juillet 1978 à Hatvan, Hongrie, résidant professionnellement
au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2) Le siège social de la Société est fixé au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la requête du mandataire de la partie comparante
les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française et en cas de divergence entre le texte anglais
et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9162. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012095822/332.
(120132491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
CPS Consulting Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 116.558.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012096696/10.
(120133469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
102456
L
U X E M B O U R G
Credipar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 134.385.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096697/10.
(120133118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
C2Trans Holding S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 35, Parc d'activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 153.607.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 6 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096700/10.
(120133178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Agave Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 148.755.
In the year two thousand and twelve.
On the eighteenth day of June.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Mr. Juan Francisco BECKMANN VIDAL, entrepreneur, born in Mexico City, Mexico, on February 9, 1940, with pro-
fessional address at Guillermo Gonzalez Camarena 800-Piso 4, Col. Zedec Santa Fe, C.P. 01210, Mexico, D.F., Mexico,
here represented by Mr. Max MAYER, private employee, residing professionally at Junglinster, by virtue of a proxy
given under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr. Max MAYER, pre-named, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole shareholder of the private limited company (société à responsabilité limitée) "Agave
Luxco S.à r.l." (hereinafter referred to as “the Company”), having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 148755, incorporated on October 7, 2009 pursuant
to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the
Mémorial C number 2193 of November 10, 2009, and whose articles of association have been amended for the last time
pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, pre-named, acting on behalf of the undersigned notary, on March 5,
2012, published in the Mémorial C number 1291 of May 24, 2012,
and that the appearing party has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Article 8.3 (i) of the article of association is amended and will have henceforth the following wording:
" 8.3. (i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of two (2) class A
managers and two (2) class B managers or (ii) the single signature of any manager but only for transactions up to an
amount of ten thousand Euro (EUR 10,000) on a per transaction basis.".
<i>Second resolutioni>
The corporate capital is increased to the extent of thirty four million US Dollars (USD 34,000,000.-) in order to raise
it from the amount of one hundred eighty four million seven hundred fifty thousand eight hundred and seventy one US
Dollars (USD 184,750,871.-) to two hundred eighteen million seven hundred fifty thousand eight hundred and seventy
one US Dollars (USD 218,750,871.-) by the issuance of three million and four hundred thousand (3,400,000) new class
A shares, three million and four hundred thousand (3,400,000) new class B shares, three million and four hundred thousand
(3,400,000) new class C shares, three million and four hundred thousand (3,400,000) new class D shares, three million
102457
L
U X E M B O U R G
and four hundred thousand (3,400,000) new class E shares, three million and four hundred thousand (3,400,000) new
class F shares, three million and four hundred thousand (3,400,000) new class G shares, three million and four hundred
thousand (3,400,000) new class H shares, three million and four hundred thousand (3,400,000) new class I shares and
three million and four hundred thousand (3,400,000) new class J shares, with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-)
each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription and Paymenti>
The three million and four hundred thousand (3,400,000) new class A shares, three million and four hundred thousand
(3,400,000) new class B shares, three million and four hundred thousand (3,400,000) new class C shares, three million
and four hundred thousand (3,400,000) new class D shares, three million and four hundred thousand (3,400,000) new
class E shares, three million and four hundred thousand (3,400,000) new class F shares, three million and four hundred
thousand (3,400,000) new class G shares, three million and four hundred thousand (3,400,000) new class H shares, three
million and four hundred thousand (3,400,000) new class I shares and three million and four hundred thousand (3,400,000)
new class J shares, with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, are subscribed by the appearing party and are
fully paid up by the latter by contribution in cash of thirty four million US Dollars (USD 34,000,000.-).
The contribution in cash amounting to thirty four million US Dollars (USD 34,000,000.-).has been proved to the
undersigned notary by a bank certificate. This amount is now at the free disposal of the Company.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of such increase of capital article 5.1 of the articles of association is amended so that it reads
henceforth as follows:
" 5.1. The issued corporate capital is set at two hundred eighteen million seven hundred fifty thousand eight hundred
and seventy one US Dollars (USD 218,750,871.-) represented by twenty-one million eight hundred ninety thousand one
hundred and ninety (21,890,190) class A shares, twenty one million eight hundred seventy three thousand four hundred
and nine (21,873,409) class B shares, twenty one million eight hundred seventy three thousand four hundred and nine
(21,873,409) class C shares, twenty one million eight hundred seventy three thousand four hundred and nine (21,873,409)
class D shares, twenty one million eight hundred seventy three thousand four hundred and nine (21,873,409) class E
shares, twenty one million eight hundred seventy three thousand four hundred and nine (21,873,409) class F shares,
twenty one million eight hundred seventy three thousand four hundred and nine (21,873,409) class G shares, twenty one
million eight hundred seventy three thousand four hundred and nine (21,873,409) class H shares, twenty one million eight
hundred seventy three thousand four hundred and nine (21,873,409) class I shares and twenty one million eight hundred
seventy three thousand four hundred and nine (21,873,409) class J shares.
Each share has a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) and with such rights and obligations as set out in the present
articles of association."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately EUR 6,800.-. .
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Monsieur Juan Francisco BECKMANN VIDAL, entrepreneur, né à Mexico City, Mexique, le 9 février 1940, demeurant
professionnellement à Guillermo Gonzalez Camarena, 800-Piso 4, Col. Zedec Santa Fe, C.P. 01210, Mexico, D.F., Mexique,
ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
102458
L
U X E M B O U R G
Lequel comparant, représenté par Monsieur Max MAYER, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce
qui suit:
Que le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée "Agave Luxco S.à r.l." (ci-après «la Société»),
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 148755, constituée en date du 7 octobre 2009 par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 2193 du 10 novembre 2009, et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Joseph ELVINGER, pré-nommé, agissant pour le compte du
notaire instrumentant, en date du 5 mars 2012, publié au Mémorial C numéro 1291 du 24 mai 2012 et que le comparant
a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’article 8.3 (i) des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
" 8.3. (i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par (i) les signatures conjointes de deux (2)
gérants de classe A et de deux (2) gérants de classe B ou (ii) la signature individuelle d'un gérant mais seulement pour
des transactions jusqu'à un montant de dix mille euros (EUR 10.000) par transaction.".
<i>Seconde résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de trente-quatre millions de Dollars US (USD 34.000.000,-) pour le porter
de son montant de cent quatre-vingt-quatre millions sept cent cinquante mille huit cent soixante et onze Dollars US (USD
184.750.871,-) à deux cent dix-huit millions sept cent cinquante mille huit cent soixante et onze Dollars US (USD
218.750.871,-) par l’émission de trois millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de classe A, trois
millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de classe B, trois millions quatre cent mille (3.400.000)
nouvelles parts sociales de classe C, trois millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de classe D, trois
millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de classe E, trois millions quatre cent mille (3.400.000)
nouvelles parts sociales de classe F, trois millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de classe G, trois
millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de classe H, trois millions quatre cent mille (3.400.000)
nouvelles parts sociales de classe I et trois millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de classe J, d’une
valeur nominale d’un Dollar US (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
Les trois millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de classe A, trois millions quatre cent mille
(3.400.000) nouvelles parts sociales de classe B, trois millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de
classe C, trois millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de classe D, trois millions quatre cent mille
(3.400.000) nouvelles parts sociales de classe E, trois millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de
classe F, trois millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de classe G, trois millions quatre cent mille
(3.400.000) nouvelles parts sociales de classe H, trois millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de
classe I et trois millions quatre cent mille (3.400.000) nouvelles parts sociales de classe J, d’une valeur nominale d’un US
Dollar (USD 1,-) chacune, sont souscrites par le comparant et sont intégralement libérées par ce dernier par l’apport en
espèces de trente-quatre millions de Dollars US (USD 34.000.000,-).
L’apport en espèces d’un montant de trente-quatre millions de Dollars US (USD 34.000.000,-) a été prouvé au notaire
instrumentaire par un certificat bancaire. Ce montant est dès à présent à la libre disposition de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article 5.1 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
" 5.1. Le capital émis de la Société est fixé à deux cent dix-huit millions sept cent cinquante mille huit cent soixante et
onze Dollars US (USD 218.750.871,-) représenté par vingt et un millions huit cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-
vingt-dix (21.890.190) parts sociales de classe A, vingt et un millions huit cent soixante-treize mille quatre cent neuf
(21.873.409) parts sociales de classe B, vingt et un millions huit cent soixante-treize mille quatre cent neuf (21.873.409)
parts sociales de classe C, vingt et un millions huit cent soixante-treize mille quatre cent neuf (21.873.409) parts sociales
de classe D, vingt et un millions huit cent soixante-treize mille quatre cent neuf (21.873.409) parts sociales de classe E,
vingt et un millions huit cent soixante-treize mille quatre cent neuf (21.873.409) parts sociales de classe F, vingt et un
millions huit cent soixante-treize mille quatre cent neuf (21.873.409) parts sociales de classe G, vingt et un millions huit
cent soixante-treize mille quatre cent neuf (21.873.409) parts sociales de classe H, vingt et un millions huit cent soixante-
treize mille quatre cent neuf (21.873.409) parts sociales de classe I et vingt et un millions huit cent soixante-treize mille
quatre cent neuf (21.873.409) parts sociales de classe J.
Chaque part sociale a une valeur nominale d’un Dollar US (USD 1,-) avec les droits et obligations énoncés dans les
présents statuts.".
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la Société à raison des présentes sont évalués à la somme de 6.800,- EUR.
102459
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 juin 2012. Relation GRE/2012/2176. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096408/158.
(120133048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
D.V.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 110.192.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012096701/10.
(120133434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Capitol Inquiry Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 144.315.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012096656/9.
(120132672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Try S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 55.377.
Par la présente, je remets avec effet immédiat ma démission en tant qu'administrateur de votre estimée société.
Mondercange, le 19 juillet 2012.
Roger CAURLA.
Référence de publication: 2012096318/9.
(120132896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
CCP III UK Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 46.231,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 160.971.
Les comptes annuels pour la période du 17 mai 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096663/11.
(120132540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
102460
L
U X E M B O U R G
Compagnie Immobilière Luxembourgeoise, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 29.696.
<i>Extrait du procès-verbal par voie circulaire des résolutions du conseil d'administrationi>
Le conseil décide de proroger le mandat du président du conseil d'administration, Monsieur Gaëtan Piret né le 8 juillet
1958 à Uccle (Belgique) demeurant à B-1180 Uccle, Avenue Hamoir, 24i.
Son mandat commencera le 29 juin 2012 et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2015.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012096684/13.
(120132860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 5.735.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 27 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096685/11.
(120132262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Continental Investissement, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 41.177.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CONTINENTAL INVESTISSEMENT
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012096688/11.
(120132110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Stris S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 7.442.000,00.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 73.045.
In the year two thousand and twelve, on the twenty second of June.
Before Maître Kesseler Francis, notary residing in Esch/Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of Stris S.A., a public limited liability company (société
anonyme), incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, rue du Laboratoire, L-1911
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 73.045 (the "Company").
The Company has been incorporated pursuant to a deed received by the notary Maître Reginald Neuman residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C number 117 of 3 February 2000.
The articles of association were amended for the last time by a deed of the notary Maître Jacques Delvaux residing in
Luxembourg, on 5 November 2007, published in the Mémorial C number 54 dated 9 January 2008.
The Meeting was opened at 8.00 a.m. and was presided by Maître Sabine Hinz, lawyer, residing professionally in Howald
(Grand Duchy of Luxembourg), appointed as chairman pro tempore in compliance with article 10 of the articles of
association of the Company.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Maître Nathalie Houllé, lawyer, residing professionally in Howald
(Grand Duchy of Luxembourg).
These individuals constitute the bureau of the Meeting.
102461
L
U X E M B O U R G
Having thus been constituted, the bureau of the Meeting drew up the attendance list, which, after having been signed
"ne varietur" by the proxy holder representing any shareholder, by the members of the bureau of the Meeting and the
public notary, will remain attached to the present minutes together with any proxy and will be filed together with the
present deed, with the registration authorities.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The Meeting has been convened by notice sent out on 14 June 2012 and all shareholders of the Company had
knowledge of the Meeting and of its agenda as required by the Luxembourg company law dated 10 August 1915 as amended
(the "Company Law").
II. The share capital of the Company is set at EUR 7,442,000.- (seven million four hundred forty two thousand Euros),
represented by 7,442 (seven thousand four hundred forty two) shares with a par value of EUR 1,000.- (one thousand
Euros) each, all in registered form, which have been entirely paid in.
III. The agenda of the Meeting was the following:
1. Decision to put the Company into voluntary liquidation and to receive advance on liquidation proceeds to be
instructed and paid in cash and/or in kind by the liquidator subject to the fulfilment of the conditions required by the
Company Law and the commitment of the shareholders, in accordance with the Luxembourg applicable laws, to complete
any future obligation;
2. Decision to appoint BDO Tax & Accounting, société anonyme incorporated in Luxembourg as liquidator;
3. Determination of the powers and the remuneration of the liquidator;
4. Granting power to the liquidator and/or to any lawyer of the law firm Bonn Steichen & Partners to carry out any
required step relating to the resolutions to be taken on the basis of the present agenda;
5. Any other business.
IV. The bureau of the Meeting, after having considered itself as duly composed, and given its approval with respect to
the explanations of the chairman, deliberated and passed by unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolved to put the Company into voluntary liquidation and to receive advance on liquidation proceeds
to be instructed and paid in cash and/or in kind by the liquidator subject to the fulfilment of the conditions required by
the Company Law and the commitment of the shareholders, in accordance with the Luxembourg applicable laws, to
complete any future obligation.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to appoint BDO Tax & Accounting, société anonyme having its registered office at 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 147.571 to assume the role as liquidator of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to confer to the liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Company Law.
The liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Company Law, without prior consent of the general meeting of the Company.
The liquidator is exempted from the obligation of drawing-up an inventory, and may in this respect fully rely on the
books of the Company. The liquidator may, under its own responsibility and regarding special or specific operations,
delegate such part of its powers and for such duration as it may deem fit, to one (1) or several representatives.
The liquidator shall also be authorised to make advance payments in cash and/or in kind of any liquidation proceeds
of the Company to the shareholders of the Company as it deems fit.
The Meeting resolved that the liquidator shall be remunerated according to the standard practice.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved to grant powers to the liquidator and/or to any lawyer of the law firm Bonn Steichen & Partners,
to carry out any required step relating to the resolutions taken at the present Meeting.
<i>Estimated costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Howald (Grand Duchy of Luxembourg) on the date mentioned
at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing persons, known to the notary by surname, first name, civil status and
residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
102462
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons,
the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Follows the French version:
L'an deux mille douze, le vingt-deux juin,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette (Grand Duché de Luxembourg), s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire Assemblée») de Stris S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les
lois de Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.045 et
ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, (la «Société»).
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 3 février 2000, numéro 117.
Les statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, du 5
novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 janvier 2008, numéro 54.
L'Assemblée a été ouverte à 8.00 heures et présidée par Maître Sabine Hinz, avocat à la Cour, demeurant profes-
sionnellement à Howald (Grand Duché de Luxembourg), nommée comme président pro tempore conformément à
l'article 10 des statuts de la Société.
Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur Maître Nathalie Houllé, avocat à la Cour, demeurant profes-
sionnellement à Howald (Grand Duché de Luxembourg).
Ces personnes constituent le bureau de l'Assemblée.
Ainsi constitué, le bureau de l'Assemblée établit la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par le
mandataire représentant tout actionnaire, les membres du bureau et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte avec les procurations, aux fins d'enregistrement.
Le président a demandé au notaire instrumentant de déclarer:
I. L'Assemblée a été convoquée par avis envoyé le 14 juin 2012 et tous les actionnaires de la Société ont eu connaissance
de l'Assemblée et de son ordre du jour tel que prescrit par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10
août 1915, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).
II. Le capital social est fixé à EUR 7.442.000,- (sept million quatre cent quarante-deux mille euros), représenté par
7.442 (sept mille quatre cent quarante-deux) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, toutes
nominatives et entièrement libérées.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée était le suivant:
1. Décision de mettre la Société en liquidation volontaire et d'obtenir une avance sur le produit de liquidation qui sera
accordée, en espèces ou en nature, par le liquidateur sous condition de l'accomplissement des modalités requises par la
Loi sur les Sociétés Commerciales et de l'engagement des actionnaires, conformément au droit luxembourgeois applicable,
de remplir toutes obligations futures;
2. Décision de nommer BDO Tax & Accounting, société anonyme constituée au Luxembourg en tant que liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur;
4. Délégation de pouvoirs en faveur du liquidateur et/ou de tout avocat de l'étude Bonn Steichen & Partners de passer
tout acte pouvant s'avérer être nécessaire en relation avec les résolutions prises sur base du présent ordre du jour;
5. Divers.
IV. Le bureau de l'Assemblée, après avoir considéré être dûment constitué et ayant accepté les explications données
par le président, ont délibéré et adopté à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée a décidé de mettre la Société en liquidation volontaire et d'obtenir une avance sur le produit de liquidation
qui sera accordée, en espèces ou en nature, par le liquidateur sous condition de l'accomplissement des modalités requises
par la Loi sur les Sociétés Commerciales et de l'engagement des actionnaires, conformément au droit luxembourgeois
applicable, de remplir toutes obligations futures.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée a décidé de nommer BDO Tax & Accounting, société anonyme ayant son siège social au 2, Avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 147.571, en tant que liquidateur de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée a décidé d'accorder au liquidateur les pouvoirs tels que prévus aux articles 144 et suivants de la Loi sur
les Sociétés Commerciales.
Le liquidateur est autorisé à adopter tout acte et à procéder à toute opération, y compris ceux cités à l'article 145 de
la Loi sur les Sociétés Commerciales, sans approbation préalable de l'assemblée générale de la Société.
102463
L
U X E M B O U R G
Le liquidateur est exonéré de l'obligation de dresser un inventaire et peut en conséquence entièrement se référer aux
comptes de la Société.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et concernant des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer une
partie de ses pouvoirs et pour la durée qu'il estime nécessaire, à un (1) ou plusieurs mandataires.
Le liquidateur est également autorisé à faire des paiements anticipés, en espèces ou en nature, de tout produit de
liquidation de la Société aux actionnaires de la Société, tel qu'il l'estime approprié.
L'Assemblée décide que la rémunération du liquidateur se fera selon les pratiques courantes.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée a décidé la délégation de pouvoirs au liquidateur et/ou à tout avocat de l'étude Bonn Steichen & Partners,
afin de faire toute démarche pouvant s'avérer être nécessaire en relation avec les résolutions prises par la présente
Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui devra y être imputé en relation avec le présent acte, s'élève à approximativement mille trois cent euros (€ 1.300,-).
Dont acte, passé à Howald (Grand Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénoms
usuels, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue française, précédé d'une version anglaise. À la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Signé: Hinz, Houlle, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 juin 2012. Relation: EAC/2012/8422. Reçu douze euros 12,00€
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012096275/154.
(120132729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Kuehne + Nagel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 103.753.
<i>Auszug der Beschlussfassung der außerordentlichen Generalversammlung, weiche am Sitz der Gesellschaft in Contern, 1 rue Ed-i>
<i>mond Reuter, am 26. Juli 2012 abgehalten wurde.i>
Die Versammlung beschließt, jeweils einstimmig, wie folgt:
Die Wohnadresse des Geschäftsführers Michael Stoll ist wie folgt im Register de Commerce zu ändern.
Von: Degnerstrasse 132, 13053 Berlin, Deutschland
Zu: Albert-Schweitzer-Strasse 60B, 54329 Konz, Deutschland
Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 17.15 Uhr geschlossen.
Th. Kroyer / I. Konter / I. Konter
<i>Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähleri>
Référence de publication: 2012095909/16.
(120132901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Dîon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 133.314.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice cloturant en date du
31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2012096703/11.
(120132884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
102464
L
U X E M B O U R G
Dahlia B SICAR S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.080.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096704/11.
(120133113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Demag Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 88.830.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012096705/10.
(120132111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Déco-Peint Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3835 Schifflange, 13, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 137.004.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DECO-PEINT LUXEMBOURG SARLi>
Référence de publication: 2012096702/10.
(120132303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Dynex Energy S.A., Société Anonyme,
(anc. Ainvest Finance S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 164.435.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 juillet 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012096713/12.
(120132413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Dundee International (Luxembourg) Investments 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 162.422.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Dundee International (Luxembourg) Investments 6 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012096712/11.
(120133300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
102465
L
U X E M B O U R G
Dana Services Sàr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7540 Lintgen, 9, rue de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 71.643.
L'an deux mille douze, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Dieter KUNDLER, comptable, né à Schweinfurt, (Allemagne), le 7 octobre 1940, demeurant à L-7540
Lintgen, 9, rue de Diekirch, et
2.- Monsieur Antonin KUNDLER, employé, né à Bruxelles, (Belgique), le 37 août 1974, demeurant à L-7540 Lintgen,
9, rue de Diekirch, et
tous deux (2) ici représentées aux fins des présentes par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnel-
lement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui substituée, laquelle, après
avoir été signée «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux
présentes pour être enregistrée avec elles.
Lesquels comparants ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "Dana Services S.à r.l.", avec siège social à L-7565 Mersch, 37, rue Emmanuel
Servais, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 71.643, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 20 août 1999,
publié au Mémorial C numéro 895 du 26 novembre 1999,
que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Gérard Lecuit en date du 2 mars 2000, publié au
Mémorial C numéro 507 du 17 juillet 2000,
et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du:
- 20 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 1020 du 4 juillet 2002, et
- 31 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 411 du 17 avril 2002.
- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire et ont pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée constate qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 7 février 2011, Madame
Julia KUNDLER a cédé ses cent vingt-cinq (125) parts sociales, à Monsieur Dieter KUNDLER, préqualifié.
Cette cession de parts est approuvée conformément à l'article sept (7) des statuts et l'associé unique la considère
comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Le cessionnaire susdit, est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social vers L-7540 Lintgen, 9, rue de Diekirch et en conséquence
de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts comme suit:
" Art. 3. (premier alinéa).
Art. 3. Le siège social est établi dans la Commune de Lintgen."
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de reformuler l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée constate que l'adresse des associés et gérant(s) est actuellement: L-7540 Lintgen, 9, rue de Diekirch.
<i>Évaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 850,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
102466
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 juillet 2012. Relation GRE/2012/2787. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPÉDITION CONFORME.
Junglinster, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012096714/61.
(120132412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Daviger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 160.213.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012096715/11.
(120133025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Demag Holding, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 88.342.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012096717/10.
(120132112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Distinct Communication, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7307 Steinsel, 42, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 146.463.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DISTINCT COMMUNICATION, SARLi>
Référence de publication: 2012096720/10.
(120132304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
CPI CPEH 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 118.036.
In the year two thousand twelve, on the eighteenth of July.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. CPI Capital Partners Europe, L.P., an English limited partnership having its registered office at 9 West 57
th
Street,
New York, NY 10019, United States of America, registered with the Companies Register of England and Wales under
number LP 11071;
2. CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P., an English limited partnership, having its registered office at 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, United States of America, registered with the Companies Register of England and Wales
under number LP11169;
102467
L
U X E M B O U R G
both represented by Annick Braquet, private employee, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue
Cents, by virtue of two proxies given under private seal.
Said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing parties, represented as thereabove mentioned, have requested the undersigned notary to enact the
following:
- that they are the actual partners of CPI CPEH 2 S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office
in L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy, incorporated by a deed of the undersigned notary, then residing in
Mersch, on July 3, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1861 on 4
October 2006 (the "Company"). The Company's Articles of Incorporation have last been amended pursuant to a deed
of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, on January 20, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations under number 559 of March 13, 2009.
- that the partners have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners decides to create two new classes of shares: class H and class I shares.
<i>Second resolutioni>
The partners decides to increase the share capital of the Company by an amount of FORTY-ONE THOUSAND AND
TWO HUNDRED EUROS (EUR 41,200.-) in order to bring it from its present amount of THIRTY-TWO MILLION
EIGHT HUNDRED FIFTY-SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED AND SEVENTY-FIVE EURO (EUR 32,857,175.-) re-
presented by ONE MILLION THREE HUNDRED AND FORTY THOUSAND TWO HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN
(1,314,287) shares having a nominal value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each, to THIRTY-TWO MILLION EIGHT
HUNDRED AND NINETY-EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED AND SEVENTY-FIVE EUROS (EUR 32,898,375.-)
by way of the issue of ONE THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY-EIGHT (1,648) new shares, of which nine
hundred and twenty-three (923) class H shares and seven hundred and twenty-five (725) class I shares, with a nominal
value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
1. CPI Capital Partners Europe, L.P., prenamed, represented as thereabove mentioned,
declares to subscribe to 923 class H shares and to pay up them in cash,
2. CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P., prenamed, represented as thereabove mentioned,
declares to subscribe to 725 class I shares and to pay up them in cash,
so that the total amount of FORTY-ONE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (EUR 41,200) is at the disposal of
the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The partner decides to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth
have the following wording:
“The share capital is set at thirty two million eight hundred and ninetyeight thousand three hundred and seventy-five
Euros (EUR 32,898,375.-) , divided into one million three hundred and fifteen thousand nine hundred and thirty-five
(1,315,935) shares, of which five hundred (500) ordinary shares, one thousand seventy-four (1,074) Class C Shares, four
hundred fifty-nine thousand nine hundred ninety-nine (459,999) Class D Shares, two hundred thirty thousand four hun-
dred thirty-nine (230,439) Class E shares, three hundred forty-seven thousand two hundred ninety-one (347,291) Class
F Shares, two hundred seventy-four thousand nine hundred eightyfour (274,984) Class G Shares, nine hundred and twenty-
three (923) Class H Shares and seven hundred and twenty-five (725) Class I Shares, with a nominal value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each."
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,700.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said proxyholder signed together
with the notary the present original deed.
102468
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. CPI Capital Partners Europe, L.P., un limited partnership, constitué selon les lois de l'Angleterre, ayant son siège
social à 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, Etats-Unis d'Amérique, enregistré auprès du Registre des Sociétés
de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro LP 11071;
2. CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P., un limited partnership, constitué selon les lois de l'Angleterre, ayant son
siège social à 9 West 57
th
Street, New York, NY 10019, Etats-Unis d'Amérique, enregistré auprès du Registre des
Sociétés de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro LP11169;
les deux ici représentés par Annick Braquet, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu de deux procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls associés actuels de la société CPI CPEH 2 S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors résidant à Mersch, en date du 3 juillet 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1861 le 4 octobre 2006 (la "Société"). Les statuts de la Société ont
été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 20
janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 559 du 13 mars 2009.
- Qu'ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de créer 2 nouvelles catégories de parts sociales: parts sociales de Catégorie H et de Catégorie
I.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de QUARANTE ET UN
MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 41.200.-), afin de porter le capital de son montant actuel de TRENTE-DEUX MIL-
LIONS HUIT CENT CINQUANTE-SEPT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (EUR 32.857.175.-) représenté par
UN MILLION TROIS CENT QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT SEPT (1.314.287) parts sociales d’une
valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25.-) chacune, à TRENTE-DEUX MILLIONS HUIT CENT QUATRE-
VINGT DIX-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (EUR 32.898.375.-) par l’émission de MILLE SIX
CENT QUARANTE-HUIT (1.648) parts sociales nouvelles, dont neuf cent vingt-trois (923) parts sociales de Catégorie
H et sept cent vingt-cinq (725) parts sociales de Catégorie I, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Sont alors intervenus aux présentes:
1. CPI Capital Partners Europe, L.P., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant,
déclare souscrire à neuf cent vingt-trois (923) parts sociales nouvelles de Catégorie H et les libérer intégralement en
espèces.
2. CPI Capital Partners Europe (NFR), L.P., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire à sept
cent vingt-cinq (725) parts sociales nouvelles de Catégorie I et les libérer intégralement en espèces,
de sorte que le montant total de QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 41.200.-) a été mise à la
disposition de la Société. Preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à trente-deux millions huit cent quatre-vingt dix-huit mille trois cent soixante quinze euros
(EUR 32.898.375.-), représenté par un million trois cent quinze mille neuf cent trente-cinq (1.315.935) parts sociales,
représentées par cinq cents (500) parts sociales ordinaires, mille soixante-quatorze (1.074) Parts Sociales de Catégorie
C, quatre cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (459.999) Parts Sociales de Catégorie D, deux cent
trente mille quatre cent trente-neuf (230.439) Parts Sociales de Catégorie E, trois cent quarante-sept mille deux cent
quatre-vingt-onze (347.291) Parts Sociales de Catégorie F, deux cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-
quatre (274.984) Parts Sociales de Catégorie G, neuf cent vingt-trois (923) Parts Sociales de Catégorie H et sept cent
vingt-cinq (725) Parts Sociales de Catégorie I, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
102469
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ EUR 1.700.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 juillet 2012. Relation: LAC/2012/34821. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096695/139.
(120132595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Dundee International (Luxembourg) Investments 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 162.359.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Dundee International (Luxembourg) Investments 1 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012096707/11.
(120133056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
OME Acquisition S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 141.861.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg de manière extraordinaire en date du 23 juilleti>
<i>2012i>
L'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de la société KPMG AUDIT, R.C.S Luxembourg B 103.590, aux
fonctions de réviseur d'entreprises agréé.
L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société KPMG Luxembourg S.à r.l., R.C.S Luxembourg B 149.133
ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé jusqu'à
l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2012.
Pour extrait conforme
OME S.A.
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2012096088/17.
(120132880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Dundee International (Luxembourg) Investments 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 162.385.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
102470
L
U X E M B O U R G
<i>Pour Dundee International (Luxembourg) Investments 5 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012096711/11.
(120133261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Juniper Investment S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 25.175.272,61.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 52.852.
In the year two thousand and twelve, on the twenty second of June.
Before Maître Kesseler Francis, notary residing in Esch/Alzette, (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of Juniper Investment S.A., a public limited liability company
(société anonyme), incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, rue du Laboratoire,
L-1911 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 52.852 (the
“Company”).
The Company has been incorporated pursuant to a deed received by the notary Maître Reginald Neuman residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C number 26 of 15 January 1996.
The articles of association were amended for the last time by a deed of the notary Maître Jacques Delvaux residing in
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on 5 November 2007, published in the Mémorial C number 54 dated 9
January 2008.
The Meeting was opened at 8.30 a.m. and was presided by Maître Sabine Hinz, lawyer, residing professionally in Howald
(Grand Duchy of Luxembourg), appointed as chairman pro tempore in compliance with article 10 of the articles of
association of the Company.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Maître Nathalie Houllé, lawyer, residing professionally in Howald.
These individuals constitute the bureau of the Meeting.
Having thus been constituted, the bureau of the Meeting drew up the attendance list, which, after having been signed
“ne varietur” by the proxy holder representing any shareholder, by the members of the bureau of the Meeting and the
public notary, will remain attached to the present minutes together with any proxy and will be filed together with the
present deed, with the registration authorities.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The Meeting has been convened by notice sent out on 14 June 2012 and all shareholders of the Company had
knowledge of the Meeting and of its agenda as required by the Luxembourg company law dated 10 August 1915 as amended
(the “Company Law”).
II. The share capital of the Company is set at EUR 25,175,272.61 (twenty five million one hundred seventy five thousand
two hundred seventy two Euros sixty one cents), represented by 55.479 (fifty five thousand four hundred seventy nine)
shares without par value, all in registered form, which have been entirely paid in.
III. The agenda of the Meeting was the following:
1. Decision to put the Company into voluntary liquidation and to receive advance on liquidation proceeds to be
instructed and paid in cash and/or in kind by the liquidator subject to the fulfilment of the conditions required by the
Company Law and the commitment of the shareholders, in accordance with the Luxembourg applicable laws, to complete
any future obligation;
2. Decision to appoint BDO Tax & Accounting, société anonyme incorporated in Luxembourg as liquidator;
3. Determination of the powers and the remuneration of the liquidator;
4. Granting power to the liquidator and/or to any lawyer of the law firm Bonn Steichen & Partners to carry out any
required step relating to the resolutions to be taken on the basis of the present agenda;
5. Any other business.
IV. The bureau of the Meeting, after having considered itself as duly composed, and given its approval with respect to
the explanations of the chairman, deliberated and passed by unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolved to put the Company into voluntary liquidation and to receive advance on liquidation proceeds
to be instructed and paid in cash and/or in kind by the liquidator subject to the fulfilment of the conditions required by
the Company Law and the commitment of the shareholders, in accordance with the Luxembourg applicable laws, to
complete any future obligation.
102471
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to appoint BDO Tax & Accounting, société anonyme having its registered office at 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 147.571 to assume the role as liquidator of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to confer to the liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Company Law.
The liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Company Law, without prior consent of the general meeting of the Company.
The liquidator is exempted from the obligation of drawing-up an inventory, and may in this respect fully rely on the
books of the Company.
The liquidator may, under its own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of its
powers and for such duration as it may deem fit, to one (1) or several representatives.
The liquidator shall also be authorised to make advance payments in cash and/or in kind of any liquidation proceeds
of the Company to the shareholders of the Company as it deems fit.
The Meeting resolved that the liquidator shall be remunerated according to the standard practice.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved to grant powers to the liquidator and/or to any lawyer of the law firm Bonn Steichen & Partners,
to carry out any required step relating to the resolutions taken at the present Meeting.
<i>Estimated costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Howald (Grand Duchy of Luxembourg) on the date mentioned
at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing persons, known to the notary by surname, first name, civil status and
residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons,
the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Follows the French version:
L'an deux mille douze, le vingt-deux juin,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette (Grand Duché de Luxembourg), s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'”Assemblée”) de Juniper Investment S.A., une société anonyme, constituée et
existant selon les lois de Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 52.852 et ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, (la “Société”).
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 janvier 1996, numéro 26.
Les statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, du 5
novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 janvier 2008, numéro 54.
L'Assemblée a été ouverte à 8.30 heures et présidée par Maître Sabine Hinz, avocat à la Cour, demeurant profes-
sionnellement à Howald (Grand Duché de Luxembourg), nommée comme président pro tempore conformément à
l'article 10 des statuts de la Société.
Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur Maître Nathalie Houllé, avocat à la Cour, demeurant profes-
sionnellement à Howald (Grand Duché de Luxembourg).
Ces personnes constituent le bureau de l'Assemblée.
Ainsi constitué, le bureau de l'Assemblée établit la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par le
mandataire représentant tout actionnaire, les membres du bureau et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte avec les procurations, aux fins d'enregistrement.
Le président a demandé au notaire instrumentant de déclarer:
I. L'Assemblée a été convoquée par avis envoyé le 14 juin 2012 et tous les actionnaires de la Société ont eu connaissance
de l'Assemblée et de son ordre du jour tel que prescrit par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10
août 1915, telle que modifiée (la “Loi sur les Sociétés Commerciales”).
II. Le capital social est fixé à EUR 25.175.272,61 (vingt-cinq million cent soixante-quinze mille deux cent soixante-douze
euros soixante-et-un cents), représenté par 55.479 (cinquante-cinq mille quatre cent soixante-dix-neuf) actions sans
désignation de valeur nominale, toutes nominatives et entièrement libérées.
102472
L
U X E M B O U R G
III. L'ordre du jour de l'Assemblée était le suivant:
1. Décision de mettre la Société en liquidation volontaire et d'obtenir une avance sur le produit de liquidation qui sera
accordée, en espèces ou en nature, par le liquidateur sous condition de l'accomplissement des modalités requises par la
Loi sur les Sociétés Commerciales et de l'engagement des actionnaires, conformément au droit luxembourgeois applicable,
de remplir toutes obligations futures;
2. Décision de nommer BDO Tax & Accounting, société anonyme constituée au Luxembourg en tant que liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur;
4. Délégation de pouvoirs en faveur du liquidateur et/ou de tout avocat de l'étude Bonn Steichen & Partners de passer
tout acte pouvant s'avérer être nécessaire en relation avec les résolutions prises sur base du présent ordre du jour;
5. Divers.
IV. Le bureau de l'Assemblée, après avoir considéré être dûment constitué et ayant accepté les explications données
par le président, ont délibéré et adopté à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée a décidé de mettre la Société en liquidation volontaire et d'obtenir une avance sur le produit de liquidation
qui sera accordée, en espèces ou en nature, par le liquidateur sous condition de l'accomplissement des modalités requises
par la Loi sur les Sociétés Commerciales et de l'engagement des actionnaires, conformément au droit luxembourgeois
applicable, de remplir toutes obligations futures.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée a décidé de nommer BDO Tax & Accounting, société anonyme ayant son siège social au 2, Avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 147.571, en tant que liquidateur de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée a décidé d'accorder au liquidateur les pouvoirs tels que prévus aux articles 144 et suivants de la Loi sur
les Sociétés Commerciales.
Le liquidateur est autorisé à adopter tout acte et à procéder à toute opération, y compris ceux cités à l'article 145 de
la Loi sur les Sociétés Commerciales, sans approbation préalable de l'assemblée générale de la Société.
Le liquidateur est exonéré de l'obligation de dresser un inventaire et peut en conséquence entièrement se référer aux
comptes de la Société.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et concernant des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer une
partie de ses pouvoirs et pour la durée qu'il estime nécessaire, à un (1) ou plusieurs mandataires.
Le liquidateur est également autorisé à faire des paiements anticipés, en espèces ou en nature, de tout produit de
liquidation de la Société aux actionnaires de la Société, tel qu'il l'estime approprié.
L'Assemblée décide que la rémunération du liquidateur se fera selon les pratiques courantes.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée a décidé la délégation de pouvoirs au liquidateur et/ou à tout avocat de l'étude Bonn Steichen & Partners,
afin de faire toute démarche pouvant s'avérer être nécessaire en relation avec les résolutions prises par la présente
Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui devra y être imputé en relation avec le présent acte, s'élève à approximativement mille trois cents euros (€ 1.300,-).
Dont acte, passé à Howald (Grand Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénoms
usuels, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue française, précédé d'une version anglaise. À la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Signé: Hinz, Houlle, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 juin 2012. Relation: EAC/2012/8424. Reçu douze euros 12,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012095881/156.
(120132731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
102473
L
U X E M B O U R G
Dobry S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1842 Howald, 37, avenue Grand-Duc Jean.
R.C.S. Luxembourg B 153.628.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DOBRY S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012096721/10.
(120132305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Dolomies et Chaux, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 58.523.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2011 de sa société
mère, LHOIST S.A. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096722/12.
(120132538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Energex Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 30.245.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 21 mars 1989,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 195 du 15 juillet 1989.
Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de la société ENERGEX ENGINEERING S.A., tenue en date du 12
juin 2012, que la décision suivante a été prise:
- suite à la démission des administrateurs, en date du 16 mars 2011, sont nommés au poste d'administrateur les sociétés
suivantes en remplacement des administrateurs démissionnaires:
* F.T.E. Luxembourg S.A., constituée en date du 14 mars 2003, inscrite au RCS sous le numéro B-92.629, ayant son
siège social au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, et dont le représentant permanent est Monsieur Bonaldi
Aido, né le 09/06/1959 en Italie, demeurant 1, rue du Tenao - MC-98000 Monte Carlo; et
* ALEM S.à r.l., constituée en date du 18 novembre 2008, inscrite au registre de commerce de Tunis sous le numéro
B2480492008, ayant son siège social à la Résidence Le Rosier-Appartement B13, Jardins du Luc, Tunis - Tunisie, et dont
le représentant permanent est Monsieur Zucchini Claudio, né le 16/04/1974 en Italie, demeurant Résidence les Rosiers,
Appartement B13, Jardins du Lac, Tunis-Tunisie.
Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de la société ENERGEX ENGINEERING S.A., tenue en date du 12
juin 2012, que le mandat de Monsieur Aldo BONALDI a été renouvelé.
Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de la société ENERGEX ENGINEERING S.A., tenue en date du 12
juin 2012, que Monsieur Aldo BONALDI a également été nommé président du conseil d'administration.
Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.
Luxembourg, le 17 juillet 2012.
<i>Pour la société ENERGEX ENGINEERING S.A.i>
Référence de publication: 2012096773/27.
(120132077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
102474
L
U X E M B O U R G
Encore Plus Lux Co Diamants II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 322.400,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 129.645.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 23 mars 2012 que le siège social des associés, Encore
Plus Lux Co Diamants I S.à r.l., a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1
er
avril 2012.
A Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096741/13.
(120132447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Encore Plus Lux Co Franklin II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 290.900,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 131.623.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 20 mars 2012 que le siège social des associés, Encore
Plus Lux Co Franklin I S.à r.l., a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1
er
avril 2012.
A Luxembourg, le 26 Juillet 2012.
Référence de publication: 2012096742/13.
(120132211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Encore Plus Lux Co Metzanine II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 126.700,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 131.606.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 20 mars 2012 que le siège social des associés, Encore
Plus Lux Co Metzanine I S.à r.l., a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1
er
avril 2012.
A Luxembourg, le 26 Juillet 2012.
Référence de publication: 2012096744/13.
(120132212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Larus Holding S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 7.442.000,00.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 73.028.
In the year two thousand and twelve, on the twenty second of June.
Before Maître Kesseler Francis, notary residing in Esch/Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of Larus Holding S.A., a public limited liability company
(société anonyme), incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, rue du Laboratoire,
L-1911 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 73.028 (the
"Company").
The Company has been incorporated pursuant to a deed received by the notary Maître Reginald Neuman residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C number 101 of 29 January 2000.
The articles of association were amended for the last time by a deed of the notary Maître Jacques Delvaux residing in
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on 5 November 2007, published in the Mémorial C number 54 dated 9
January 2008.
102475
L
U X E M B O U R G
The Meeting was opened at 8.15 a.m. and was presided by Maître Sabine Hinz, lawyer, residing professionally in Howald
(Grand Duchy of Luxembourg), appointed as chairman pro tempore in compliance with article 10 of the articles of
association of the Company.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Maître Nathalie Houllé, lawyer, residing professionally in Howald.
These individuals constitute the bureau of the Meeting.
Having thus been constituted, the bureau of the Meeting drew up the attendance list, which, after having been signed
"ne varietur" by the proxy holder representing any shareholder, by the members of the bureau of the Meeting and the
public notary, will remain attached to the present minutes together with any proxy and will be filed together with the
present deed, with the registration authorities.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The Meeting has been convened by notice sent out on 14 June 2012 and all shareholders of the Company had
knowledge of the Meeting and of its agenda as required by the Luxembourg company law dated 10 August 1915 as amended
(the "Company Law").
II. The share capital of the Company is set at EUR 7,442,000.- (seven million four hundred forty two thousand Euros),
represented by 7,442 (seven thousand four hundred forty two) shares with a par value of EUR 1,000.- (one thousand
Euros) each, all in registered form, which have been entirely paid in.
III. The agenda of the Meeting was the following:
1. Decision to put the Company into voluntary liquidation and to receive advance on liquidation proceeds to be
instructed and paid in cash and/or in kind by the liquidator subject to the fulfilment of the conditions required by the
Company Law and the commitment of the shareholders, in accordance with the Luxembourg applicable laws, to complete
any future obligation;
2. Decision to appoint BDO Tax & Accounting, société anonyme incorporated in Luxembourg as liquidator;
3. Determination of the powers and the remuneration of the liquidator;
4. Granting power to the liquidator and/or to any lawyer of the law firm Bonn Steichen & Partners to carry out any
required step relating to the resolutions to be taken on the basis of the present agenda;
5. Any other business.
IV. The bureau of the Meeting, after having considered itself as duly composed, and given its approval with respect to
the explanations of the chairman, deliberated and passed by unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolved to put the Company into voluntary liquidation and to receive advance on liquidation proceeds
to be instructed and paid in cash and/or in kind by the liquidator subject to the fulfilment of the conditions required by
the Company Law and the commitment of the shareholders, in accordance with the Luxembourg applicable laws, to
complete any future obligation.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to appoint BDO Tax & Accounting, société anonyme having its registered office at 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 147.571 to assume the role as liquidator of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to confer to the liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Company Law.
The liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Company Law, without prior consent of the general meeting of the Company.
The liquidator is exempted from the obligation of drawing-up an inventory, and may in this respect fully rely on the
books of the Company.
The liquidator may, under its own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of its
powers and for such duration as it may deem fit, to one (1) or several representatives.
The liquidator shall also be authorised to make advance payments in cash and/or in kind of any liquidation proceeds
of the Company to the shareholders of the Company as it deems fit.
The Meeting resolved that the liquidator shall be remunerated according to the standard practice.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved to grant powers to the liquidator and/or to any lawyer of the law firm Bonn Steichen & Partners,
to carry out any required step relating to the resolutions taken at the present Meeting.
<i>Estimated costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).
102476
L
U X E M B O U R G
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Howald (Grand Duchy of Luxembourg) on the date mentioned
at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing persons, known to the notary by surname, first name, civil status and
residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons,
the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Follows the French version:
L'an deux mille douze, le vingt-deux juin,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette (Grand Duché de Luxembourg), s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire Assemblée») de Larus Holding S.A., une société anonyme, constituée et existant
selon les lois de Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
73.028 et ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, (la «Société»).
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 janvier 2000, numéro 101.
Les statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, du 5
novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 janvier 2008, numéro 54.
L'Assemblée a été ouverte à 8.15 heures et présidée par Maître Sabine Hinz, avocat à la Cour, demeurant profes-
sionnellement à Howald (Grand Duché de Luxembourg), nommée comme président pro tempore conformément à
l'article 10 des statuts de la Société.
Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur Maître Nathalie Houllé, avocat à la Cour, demeurant profes-
sionnellement à Howald (Grand Duché de Luxembourg).
Ces personnes constituent le bureau de l'Assemblée.
Ainsi constitué, le bureau de l'Assemblée établit la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par le
mandataire représentant tout actionnaire, les membres du bureau et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte avec les procurations, aux fins d'enregistrement.
Le président a demandé au notaire instrumentant de déclarer:
I. L'Assemblée a été convoquée par avis envoyé le 14 juin 2012 et tous les actionnaires de la Société ont eu connaissance
de l'Assemblée et de son ordre du jour tel que prescrit par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10
août 1915, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).
II. Le capital social est fixé à EUR 7.442.000,- (sept million quatre cent quarante-deux mille euros), représenté par
7.442 (sept mille quatre cent quarante-deux) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, toutes
nominatives et entièrement libérées.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée était le suivant:
1. Décision de mettre la Société en liquidation volontaire et d'obtenir une avance sur le produit de liquidation qui sera
accordée, en espèces ou en nature, par le liquidateur sous condition de l'accomplissement des modalités requises par la
Loi sur les Sociétés Commerciales et de l'engagement des actionnaires, conformément au droit luxembourgeois applicable,
de remplir toutes obligations futures;
2. Décision de nommer BDO Tax & Accounting, société anonyme constituée au Luxembourg en tant que liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur;
4. Délégation de pouvoirs en faveur du liquidateur et/ou de tout avocat de l'étude Bonn Steichen & Partners de passer
tout acte pouvant s'avérer être nécessaire en relation avec les résolutions prises sur base du présent ordre du jour;
5. Divers.
IV. Le bureau de l'Assemblée, après avoir considéré être dûment constitué et ayant accepté les explications données
par le président, ont délibéré et adopté à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée a décidé de mettre la Société en liquidation volontaire et d'obtenir une avance sur le produit de liquidation
qui sera accordée, en espèces ou en nature, par le liquidateur sous condition de l'accomplissement des modalités requises
par la Loi sur les Sociétés Commerciales et de l'engagement des actionnaires, conformément au droit luxembourgeois
applicable, de remplir toutes obligations futures.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée a décidé de nommer BDO Tax & Accounting, société anonyme ayant son siège social au 2, Avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 147.571, en tant que liquidateur de la Société.
102477
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée a décidé d'accorder au liquidateur les pouvoirs tels que prévus aux articles 144 et suivants de la Loi sur
les Sociétés Commerciales.
Le liquidateur est autorisé à adopter tout acte et à procéder à toute opération, y compris ceux cités à l'article 145 de
la Loi sur les Sociétés Commerciales, sans approbation préalable de l'assemblée générale de la Société.
Le liquidateur est exonéré de l'obligation de dresser un inventaire et peut en conséquence entièrement se référer aux
comptes de la Société.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et concernant des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer une
partie de ses pouvoirs et pour la durée qu'il estime nécessaire, à un (1) ou plusieurs mandataires.
Le liquidateur est également autorisé à faire des paiements anticipés, en espèces ou en nature, de tout produit de
liquidation de la Société aux actionnaires de la Société, tel qu'il l'estime approprié.
L'Assemblée décide que la rémunération du liquidateur se fera selon les pratiques courantes.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée a décidé la délégation de pouvoirs au liquidateur et/ou à tout avocat de l'étude Bonn Steichen & Partners,
afin de faire toute démarche pouvant s'avérer être nécessaire en relation avec les résolutions prises par la présente
Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui devra y être imputé en relation avec le présent acte, s'élève à approximativement mille trois cents euros (€ 1.300,-).
Dont acte, passé à Howald (Grand Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénoms
usuels, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue française, précédé d'une version anglaise. À la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Signé: Hinz, Houlle, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 juin 2012. Relation: EAC/2012/8420. Reçu douze euros 12,00€
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012095938/156.
(120132730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Lory S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 56.010.
Par la présente, je remets avec effet immédiat ma démission en tant qu'administrateur de votre estimée société.
Mondercange, le 19 juillet 2012.
Roger CAURLA.
Référence de publication: 2012095954/9.
(120132895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Eurofinance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 54.520.
Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale
ordinaire du 19 juillet 2012 a nommé comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Administrateur, Madame
Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012096791/12.
(120132929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
102478
L
U X E M B O U R G
Dufouleur Père et Fils, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 22.052.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012096726/9.
(120132583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Dufouleur Père et Fils, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 22.052.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012096727/9.
(120132584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Eden 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 137.730.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012096735/9.
(120132792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Element Power Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 163.057.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012096737/9.
(120133029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Dufouleur Père et Fils, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 22.052.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012096725/9.
(120132582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Land Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 62.225.
Par la présente, je remets avec effet immédiat ma démission en tant qu'administrateur de votre estimée société.
Mondercange, le 19 juillet 2012.
Roger CAURLA.
Référence de publication: 2012095936/9.
(120132894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
102479
L
U X E M B O U R G
Financière Dolomies et Chaux, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R.C.S. Luxembourg B 163.549.
Les comptes annuels pour la période du 15 septembre 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096799/11.
(120132751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Everyone Game Entertainment, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 169.235.
EXTRAIT
Depuis le 16 juillet 2012, Monsieur George BRYAN-ORR, né le 10 octobre 1970 à North York, Canada, avec adresse
professionnelle à 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, assure la fonction de représentant permanent de la société à
responsabilité limitée TITAN pour ses fonctions d'administrateur unique de la société anonyme EVERYONE GAME
ENTERTAINMENT.
Pour Extrait
La société
Référence de publication: 2012096794/14.
(120132207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Exmar Offshore Services S.A., Société Anonyme,
(anc. Exmar Offshore Lux S.A.).
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 65.505.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012096795/11.
(120132972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
E.F.M. S.A., Euro Full Media S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire.
R.C.S. Luxembourg B 63.498.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012096790/9.
(120132271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Euro Full Media S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire.
R.C.S. Luxembourg B 63.498.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012096789/9.
(120132270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
102480
Agave Luxco S.à r.l.
Ainvest Finance S.A.
C2Trans Holding S.A
Capitol Inquiry Services S.A.
CCP III CZ S.à r.l.
CCP III Germany Holdings S.à r.l.
CCP III UK Holdings S.à r.l.
CCP III UK Shopping S.à r.l.
Ceheca S.A.
CFC Finance
CIR International S.A.
Clara Vision S.A.
CMB Immobilière
CMP II S.à r.l.
CODUR S.A. (Constructions Durables)
Compagnie Immobilière Luxembourgeoise
Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois S.A.
Continental Investissement
CPI CPEH 2 S.à r.l.
CPS Consulting Sàrl
Credipar S.A.
Dahlia B SICAR S.C.A.
Dana Services Sàr.l.
Daviger S.à r.l.
Déco-Peint Luxembourg S.à r.l.
Demag Holding, Sàrl
Demag Investments S.à r.l.
Dîon S.A.
Distinct Communication, Sàrl
Dobry S. à r.l.
Dolomies et Chaux
Dufouleur Père et Fils, S.à r.l.
Dufouleur Père et Fils, S.à r.l.
Dufouleur Père et Fils, S.à r.l.
Dundee International (Luxembourg) Investments 1 S.à r.l.
Dundee International (Luxembourg) Investments 5 S.à r.l.
Dundee International (Luxembourg) Investments 6 S.à r.l.
D.V.V. S.A.
Dynex Energy S.A.
Eden 2 S.à r.l.
Element Power Sàrl
Encore Plus Lux Co Diamants II S.à r.l.
Encore Plus Lux Co Franklin II S.à r.l.
Encore Plus Lux Co Metzanine II S.à r.l.
Energex Engineering S.A.
Enovos International S.A.
Eurofinance S.A. SPF
Euro Full Media S.A.
Euro Full Media S.A.
Everyone Game Entertainment
Exmar Offshore Lux S.A.
Exmar Offshore Services S.A.
Financière Dolomies et Chaux
Ingersoll-Rand Lux Clover Holding S.à r.l.
Juniper Investment S.A.
Kuehne + Nagel Investments S.à r.l.
Land Investments S.A.
Larus Holding S.A.
Lory S.A.
OME Acquisition S.C.A.
Stris S.A.
Try S.A.