logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2088

23 août 2012

SOMMAIRE

Achte PMB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100218

Alain Afflelou International S.A.  . . . . . . . . .

100209

Amelia Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100219

ArcelorMittal Sourcing  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100220

Aviva Investors Structured Funds  . . . . . . .

100202

Blue Water Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

100217

BOC Frankfurt GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

100203

CF Industries International Holdings Lu-

xembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100208

David Brown Systems S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

100209

Ets. Hoffmann - Neu Combustibles S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100215

Euro Pro Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

100202

Fascolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100203

FedEx Luxembourg S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

100218

Financial Resources  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100224

Fondations Capital I S.C.A., SICAR  . . . . . .

100218

Gemstone 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100204

Gemstone 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100204

Getin International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

100220

GT Satellite Systems S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

100204

Halesia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100219

Halit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100205

HBP Muelheim S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100214

High Gate Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100219

Ilyx S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100223

Immoffice S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100206

Industrielle Pensions Beteiligungsgesell-

schaft S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100207

Infrastrukturelle Beteiligungsgesellschaft

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100216

Itaú SIF Fund of Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100214

Itavy Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100205

Lisac s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100206

Luxe Editions, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100206

LX Alpha Phi S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100207

Lyreco Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100207

Majerus-Parmentier Constructions Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100208

Manacor (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . .

100206

Medinvest International (Invecom Manage-

ment) S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100208

Meyket Locations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

100208

Mobilized Media S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100207

Molson Coors Lux 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100208

Novimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100209

Oddo Services Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

100209

Paloma International II  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100212

Participation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100220

PAS Luxembourg, S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

100213

Plansee Group Service S.A.  . . . . . . . . . . . . .

100212

Promotions Tavares & Fils, s.à r.l.  . . . . . . .

100213

Queensgate Investments I S.à r.l.  . . . . . . . .

100213

R&H Fund Services (Luxembourg) Limited

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100214

Sashey Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

100212

S Asia III Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

100214

Siemens Enterprise Communications S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100215

Siliwa S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100217

SilverStreet Management S.àr.l.  . . . . . . . . .

100216

SJ (Luxembourg) Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100217

SL Investment General Partners Fund

SCA, SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100217

SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.  . . .

100218

SMBC Nikko Investment Fund Manage-

ment Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100218

Square Holdings (CDE) S.àr.l.  . . . . . . . . . . .

100216

Square Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100216

Terra Industries International Holdings Lu-

xembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100208

Vintners Propco S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100204

Violine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100178

100177

L

U X E M B O U R G

Violine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 158.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 113.812.

O.K.N. Amsterdam B.V.
Société à responsabilité limitée
Herikerbergweg 238, Luna Arena,
1101 CM, Amsterdam Zuidoost
R.C.S. Néerlandais 33209694
Capital Social: EUR 2.000.000

CONDITIONS COMMUNES DE FUSION TRANSFRONTALIERE

Conformément à la Section 2:309 et suivants du Code civil néerlandais ("DCC") et aux Articles 261 et suivants de la

Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales (la "Loi Luxembourgeoise"),

(1) le conseil d'administration de "O.K.N. Amsterdam B.V.", société à responsabilité limitée de droit néerlandais dont

le siège social est à 1101 CM, Amsterdam Zuidoost, Herikerbergweg 238, Luna Arena, immatriculée au Registre de
Commerce Néerlandais sous le numéro 33209694, ayant un capital émis de deux millions d'euros (EUR 2,000,000.00)
représenté par deux mille (2,000) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1,000) chacune (la "Société Absor-
bante") et

(2) le conseil d'administration de "Violine S.à r.l.", société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le

siège social est à (L-2086) Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, 412F, Route d'Esch, constituée par acte de Maître
Paul Bettingen, résidant à Senningerberg, le vingt-sept décembre deux mille cinq, publié dans le "Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C", C N° 837 du 26 avril 2006, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la
Ville de Luxembourg dans la section B et sous le numéro 113812, ayant un capital émis de cent cinquante-huit mille cinq
cents euros (EUR 158,500) représenté par six mille trois cent quarante (6,340) actions d'une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25) chacune (la "Société Absorbée", dénommée conjointement avec la Société Absorbante les "Sociétés
Fusionnantes"),

ont  défini  ensemble  les  conditions  communes  suivantes  de  la  fusion  transfrontalière  par  absorption  de  la  Société

Absorbée par la Société Absorbante (le "Projet de Fusion") afin de préciser les conditions de la dite fusion et ont déclaré
que:

- les actions de la Société Absorbante sont détenues par l'actionnaire unique, Onward Holdings Co. Ltd, société de

droit japonais;

- les actions de la Société Absorbée sont détenues par les actionnaires, Onward Holdings Co. Ltd, société de droit

japonais (91.10%) et la Société Absorbante (8,90%);

- aucune des Sociétés Fusionnantes n'a de conseil de surveillance;
- aucune des Sociétés Fusionnantes n'a de comité d'entreprise ("ondernemingsraad") ou de syndicat ayant parmi ses

membres des employés de l'une des Sociétés Fusionnantes ou de l'une de ses filiales;

- aucune des Sociétés Fusionnantes n'a été dissoute ou déclarée en faillite ou n'a été déclarée en cessation de paiement;
- aucune des Sociétés Fusionnantes n'a d'employés;
- la fusion susmentionnée est motivée par des raisons de restructuration et de rationalisation de la structure et des

activités des Sociétés Fusionnantes, et du groupe dont elles font partie, y compris en particulier la réduction du nombre
de sociétés du groupe et la simplification organisationnelle et administrative. La Fusion par absorption de la Société
Absorbée par la Société Absorbante néerlandaise vise aussi à renforcer la présence et les activités du groupe dont les
Sociétés Fusionnantes font partie, aux Pays-Bas;

- les renseignements requis conformément à la Section 2:333e DCC seront publiés au Journal officiel des Pays-Bas

("Staatscourant") et il sera publié dans un journal à diffusion nationale aux Pays-Bas que les documents de la Fusion ont
été déposés conformément à la Section 2:314 DCC,

- le Projet de Fusion sera enregistré dans le Registre du Commerce et des Sociétés de la Ville de Luxembourg et publié

dans le "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C" conformément aux Articles 262 et 9 de la Loi Luxembour-
geoise.

- la fusion transfrontalière de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la ' "Fusion") devra se conformer à la

fois aux dispositions légales néerlandaises et luxembourgeoises. Tout cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit:

Art. 1 

er

 . Transfert universel de tous les actifs et passifs.  Aux termes, notamment des Sections 2:309 et suivantes

DCC et des Articles 261 et suivants de la Loi Luxembourgeoise relatives aux fusions par acquisition, et ce à la Date de
prise d'effet (telle que définie à l'Article 4 ci-dessous), la Société Absorbée transférera la totalité de ses actifs et passifs

100178

L

U X E M B O U R G

(connus et inconnus), de plein droit à la Société Absorbante, de telle sorte qu'à la Date de prise d'effet (telle que définie
ci-dessous):

a) tous les actifs de la Société Absorbée deviendront propriété de la Société Absorbante;
b) la Société Absorbante répondra de toutes les obligations de la Société Absorbée, étant entendu, toutefois, que

nonobstant les dispositions ci-dessus, les montants dus entre la Société Absorbée et la Société Absorbante seront com-
pensés sans contrepartie;

c) la Société Absorbée cessera d'exister;
d) la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de tous ses documents de constitution, actes,

avenants, contrats et transactions de toute nature, ainsi que la comptabilité et les archives et tous autres documents
comptables, titres de propriété et titres attestant la propriété de tous actifs, les documents de support des opérations
effectués, les titres et contrats, et tous autres documents relatifs aux actifs et droits cédés à la Date de prise d'effet (telle
que définie à l'Article 4 ci-dessous).

Art. 2. Données à mentionner aux termes de la Section 2:312 paragraphe 2 et 2:333d DCC et de l'Article 261 de la

Loi Luxembourgeoise. Les données suivantes doivent être mentionnées aux termes des Sections 2:312 paragraphe 2 et
2:333d DCC et de l'Article 261 de la Loi Luxembourgeoise:

I. Type d'entité juridique, nom et siège social des Sociétés Fusionnantes (Section 2:312 paragraphe 2, sous-paragraphe

a. et Section 2:333d, sub a. DCC ainsi qu'Article 261 paragraphe 2 a) de la Loi Luxembourgeoise).

(i) la société à responsabilité limitée ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"):
"O.K.N. Amsterdam B.V.", société à responsabilité limitée de droit néerlandais, 1101 CM, Amsterdam Zuidoost, He-

rikerbergweg 238, Luna Arena, immatriculée au Registre de Commerce Néerlandais sous le numéro 33209694, ayant un
capital émis de deux millions d'euros (EUR 2,000,000.00) représenté par deux mille (2,000) actions d'une valeur nominale
de mille euros (EUR 1,000) chacune,

(ii) la société anonyme:
"Violine S.à r.l.", société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à (L-2086) Luxembourg,

Grand-Duché du Luxembourg, 412F, Route d'Esch, constituée par acte de Maître Paul Bettingen, résidant à Senningerberg,
le vingt-sept décembre deux mille cinq, publiée au "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", numéro C N° 837
du 26 avril 2012, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Ville de Luxembourg, section B et numéro
113812, ayant un capital émis de cent cinquante-huit mille cinq cent euros (EUR 158,500) représenté par six mille trois
cent quarante (6,340) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

II. Rapport d'échange des actions ou parts, et le cas échéant, montant de tout paiement en numéraire (Section 3:326

DCC ainsi qu'Article 261 paragraphe 2 b) de la Loi Luxembourgeoise).

Les actionnaires de la Société Absorbée recevront deux actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1,000)

chacune de la Société Absorbante en échange de toutes leurs actions dans le capital de la Société Absorbée. Il n'y aura
pas de soulte en numéraire.

III. Conditions de livraison des actions ou parts de la Société Absorbante (Section 2:312 paragraphe 2, sous-paragraphe

g. DCC ainsi qu'Article 261 paragraphe 2 c) de la Loi Luxembourgeoise).

Les actions à émettre conformément au rapport d'échange des actions sont des actions nominatives. Après la Fusion,

les nouvelles actions seront enregistrées dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante, ce qui constitue
seulement une formalité et non pas une condition nécessaire à la création de ces actions. Les mêmes dispositions s'ap-
pliquent à l'enregistrement de cette augmentation de capital de la Société Absorbante auprès du Registre de Commerce
Néerlandais.

IV. Date à compter de laquelle ces actions ou parts auront le droit de participer aux bénéfices et toute condition

spéciale concernant ce droit (Section 2:326 DCC ainsi que Article 261 paragraphe 2 d) de la Loi Luxembourgeoise).

Les actions participeront aux bénéfices de la Société Absorbante à compter du 1 

er

 décembre 2011. Aucune condition

spéciale ne s'appliquera à la dite participation aux bénéfices de la Société Absorbante.

V.  Statuts  de  la  Société  Absorbante  (Section  2:312,  paragraphe  2,  sous-paragraphe  b.  DCC  ainsi  que  Article  261

paragraphe 4 a) de la Loi Luxembourgeoise).

Les Statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés en relation avec la Fusion.
Les Statuts de la Société Absorbante ont été adoptés par acte de constitution le 28 avril 1989. Les Statuts ont été

modifiés pour la dernière fois, par acte signé le 2 juillet 2007 par devant A.A. Voorneman, notaire à Amsterdam, Pays-
Bas. Les Statuts de la Société n'ont pas - selon les informations du Registre de Commerce Néerlandais - été modifiés
depuis. Le texte actuel des Statuts est joint au présent Projet de Fusion pour être présenté en même temps aux autorités
d'enregistrement, et fera partie intégrante du présent Projet de Fusion et sera publié conjointement au présent Projet
de Fusion.

VI. Droits conférés et contreparties à payer à charge de la Société Absorbante (Section 2:312, paragraphe 2, sous-

paragraphe c. DCC ainsi qu'Article 261 paragraphe 2 f) de la Loi Luxembourgeoise).

100179

L

U X E M B O U R G

Aucun droit spécial à rencontre de la Société Absorbée n'ayant été accordé à aucune autre personne, autre que

l'actionnaire de la Société, aucun droit spécial ne sera conféré et aucune contrepartie ne sera payée à qui que ce soit par
la Société Absorbante.

VII. Avantages à accorder aux membres du Conseil d'administration ou du Conseil de supervision des Sociétés Fu-

sionnantes ou à des tiers en relation avec la Fusion (Section 2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe d. DCC ainsi qu'Article
261 paragraphe 2 g) de la Loi Luxembourgeoise).

Néant.
VIII. Intentions concernant la composition du conseil d'administration de la Société Absorbante après la Fusion (Section

2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe e. DCC).

Il n'y a pas d'intention de modifier la composition du Conseil d'administration de la Société Absorbante après la Fusion.
La composition actuelle est la suivante:

<i>Conseil d'administration:

- Eiji TONO, Administrateur A;
- Hirokazu YOSHIZATO, Administrateur A;
- Paul Jozef SCHMITZ, Administrateur B;
- Jacob Cornelis Willem VAN BURG, Administrateur B;
- Michiel Merijn BERNARDUS, Administrateur B.
IX. Date pour laquelle les données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels

de la Société Absorbante (Section 2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe f. DCC et Article 261 paragraphe 2 e) de la Loi
Luxembourgeoise).

Les données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absor-

bante avec effet rétroactif au 1 

er

 décembre 2011 (la "Date Comptable"). Le dernier exercice de la Société Absorbée se

clôt donc à la date précédant immédiatement la Date Comptable.

X. Mesures proposées en relation avec une transmission de l'actionnariat de la Société Absorbée (Section 2:312,

paragraphe 2, sous-paragraphe g. DCC).

Il n'y aura pas de transmission de l'actionnariat de la Société Absorbée; par conséquent aucune mesure ne sera requise.
XI. Intentions concernant la continuation ou la cessation d'activités (Section 2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe h.

DCC).

En plus des conséquences juridiques de la prise d'effet de la Fusion indiquées à l'Article 4 ci-dessous, les activités de

la Société Absorbée seront continuées par la Société Absorbante. Précisons à toutes fins utiles que la présente fusion
transfrontalière n'impliquera ni n'entraînera la cessation d'activités des Sociétés Fusionnantes.

XII. Approbation de la résolution concernant la Fusion (Section 2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe i. DCC ainsi

qu'Article 263 et suivants de la Loi Luxembourgeoise).

Les résolutions concernant la Fusion seront adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absor-

bante et par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée.

XIII. Effets de la Fusion sur le goodwill et les réserves distribuâmes de la Société Absorbante (Section 2:312, paragraphe

4, alinéa final DCC).

Il n'y aura pas d'effet de la Fusion sur le goodwill et les réserves distribuables de la Société Absorbante.
XIV. Conséquences probables de la Fusion pour l'emploi (Section 2:333d, sub b. DCC ainsi qu'Article 261 paragraphe

4 b) de la Loi Luxembourgeoise).

Il n'y a pas de conséquences probables de la Fusion pour l'emploi, vu que les Sociétés Fusionnantes n'ont pas d'employés.
XV. Procédures pour la participation des employés (Section 2:333d, sub c. DCC ainsi qu'Article 261 paragraphe 4 c)

de la Loi Luxembourgeoise).

Vu que les Sociétés Fusionnantes n'ont pas d'employés et qu'aucune des Sociétés Fusionnantes n'est soumise à des

dispositions concernant la participation des employés, aucune mesure concernant la participation des employés ne doit
être adoptée.

XVI. Informations sur l'évaluation des actifs et passifs de la Société Absorbée à acquérir par la Société Absorbante

(Section 2:333d, sub d. DCC ainsi qu'Article 261 paragraphe 4 d) de la Loi Luxembourgeoise).

L'évaluation des actifs et passifs significatifs de la Société Absorbée qui seront transférés à la Société Absorbante a été

effectuée sur la base de la valeur comptable telle que reprise dans ses comptes intermédiaires au 31 mai 2012.

XVII. Date des derniers comptes annuels approuvés utilisés pour définir les conditions de la Fusion (Section 2:33d, sub

e. DCC ainsi que Article 261 paragraphe 4 e) de la Loi Luxembourgeoise).

Les comptes annuels de la Société Absorbante pour l'exercice clos au 30 novembre 2011 ont été adoptés le 30 juillet

2012 pour la Société Absorbante et les comptes annuels de la Société Absorbée clos au 30 novembre 2011 ont été
adoptés le 9 juillet 2012 pour la Société Absorbée.

100180

L

U X E M B O U R G

XVIII. Proposition pour le niveau de compensation des actionnaires de la Société Absorbée (Section 2:333d, sub f.

DCC).

Il n'y aura pas de compensation pour les actionnaires de la Société Absorbée votant contre la Fusion. En outre, la

Société Absorbée renonce par les présentes à tout droit qu'elle pourrait avoir concernant une compensation de ce genre.

Art. 3. Evaluation des actifs et Passifs de la Société Absorbée. Sur base des comptes intérimaires de la Société Absorbée

au 31.05.2012, la valeur comptable des actifs nets de la Société Absorbée s'élève à 62.298.898,88 euros (soixante deux
millions deux cent quatre vingt dix huit mille huit cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt huit centimes).

Après la Fusion, les actifs et passifs de la Société Absorbée seront inscrits au bilan de la Société Absorbante à leur

valeur comptable à la Date Comptable.

Art. 4. Date de prise d'effet - Approbation de la Société Absorbante.  La  Fusion  prendra  effet  entre  les  Sociétés

Fusionnantes et envers les tiers à compter du lendemain de la signature de l'acte notarié de fusion par devant un notaire
néerlandais (I' "Acte de Fusion").

Art. 5. Obligations concernant les formalités de la Société Absorbante. La Société Absorbante devra accomplir toutes

les formalités légales requises par la loi et nécessaires ou utiles pour réaliser la Fusion et permettre à la Société Absorbante
d'acquérir tous les actifs et passifs de la Société Absorbée.

Art. 6. Disponibilité de la Documentation relative à la fusion au siège social. Les documents visés à la Section 2:314

paragraphes 1 et 2 DCC et à l'Article 267 paragraphe 1 a), b), c) et d) de la Loi Luxembourgeoise, en particulier:

a) le Projet de Fusion;
b) les comptes annuels des Sociétés Fusionnantes pour les trois derniers exercices;
c) comptes intermédiaires des Sociétés Fusionnantes au 31.05.2012;
d) les rapports explicatifs des Conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée;
e) le cas échéant, les rapports visés à l'Article 266 de la Loi Luxembourgeoise,
seront mis à disposition à compter de la date indiquée ci-dessus pour inspection au siège social des Sociétés Fusion-

nantes, en plus de leur présentation au Registre de Commerce Néerlandais.

Art. 7. Droits des créanciers. Les créanciers des Sociétés Fusionnantes bénéficieront de toutes les protections et

recours prévus par le droit néerlandais et la Loi Luxembourgeoise, à savoir:

a) aux termes de la Section 2:316 DCC, chaque créancier pourra s'opposer au Projet de Fusion par une demande au

tribunal précisant la sûreté requise jusqu'à un (1) mois à compter du jour où les Sociétés Fusionnantes ont annoncé que
le Projet de Fusion et les autres documents requis ont été déposés conformément aux dispositions applicables du DCC;

b) aux termes de la Loi Luxembourgeoise, les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont les créances sont antérieures

à la date de publication de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbée qui devra se tenir par devant un
notaire luxembourgeois pour approuver la Fusion pourront, malgré tout accord contraire, demander dans un délai de
deux (2) mois au tribunal compétent d'acquérir une sauvegarde adéquate de collatéral pour toutes dettes échues ou non
échues, si la Fusion rend cette protection nécessaire.

A ce titre, les créanciers pourront obtenir des informations supplémentaires au siège social de la Société Absorbante,

1101 CM Amsterdam Zuidoost, Pays-Bas, Herikerbergweg 238, Luna Arena et de la Société Absorbée, (L-2086) Luxem-
bourg, Grand-Duché du Luxembourg, 412F, Route d'Esch.

Art. 8. Intentions concernant la continuation ou la cessation des activités. Les activités de la Société Absorbée seront

continuées par la Société Absorbante de la même manière.

Art. 9. Effets de l'absorption. L'absorption entraîne les effets de l'article 274 de la loi luxembourgeoise.
Par effet de l'absorption, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation et les actions de la Société Absorbée seront

annulées.

Les mandats des administrateurs de la Société Absorbée prendront fin à la date de prise d'effet, quitus sera donné aux

administrateurs des sociétés absorbées.

La Société Absorbante sera propriétaire des actifs appartenant à la Société Absorbée à la date de prise d'effet, sans

appel à rencontre de la Société Absorbée pour quelque motif que ce soit. La Société Absorbée garantit à la Société
Absorbante que les créances transférées dans le cadre de l'absorption sont certaines mais ne garantit pas la solvabilité
des débiteurs.

La Société Absorbante assume la responsabilité de tous les droits et obligations attachés à la Société Absorbée.
La Société Absorbante règle, à la date de prise d'effet toutes les taxes, droits, assurances et autres, tant ordinaires

qu'extraordinaires, grevant ou pouvant grever la propriété de tous les actifs transférés.

La Société Absorbante signera tous les contrats et engagements de quelque nature que ce soit de la Société Absorbée,

tels que les dits contrats et engagements existent à la date de prise d'effet.

La Société Absorbante accomplira toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à l'absorption et au

transfert de tous les actifs et obligations de la Société Absorbée.

100181

L

U X E M B O U R G

Les documents d'entreprise de la Société Absorbée seront déposés et conservés pendant le délai légal du siège social

de la Société Absorbante.

Violine S.à r.l. / Violine S.à r.l. / Violine S.à r.l. / O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V. /
O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V.
F. Pèné / P. Wagner / D. Alves / E. Tono / H. Yoshizato / P.J. Schmitz / J.C.W. van Burg / M.M. Bernardus
<i>Administrateur A / Administrateur B / Administrateur B / Administrateur A / Administrateur B / Administrateur B /
Administrateur B

COMMON TERMS OF CROSS-BORDER MERGER

In accordance with Section 2:309 and following of the Dutch Civil Code ("DCC") and Article 261 and following of the

Luxembourg law of 10 August 1915 on Commercial Companies (the "Luxembourg Law"),

(1) the management board of "O.K.N. Amsterdam B.V.", a private limited liability company, under the laws of the

Netherlands, with registered office in 1101 CM, Amsterdam Zuidoost, Herikerbergweg 238, Luna Arena, registered with
the Dutch Trade Register under number 33209694, with an issued share capital of two million Euro (EUR 2,000,000.00)
represented by two thousand (2,000) shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000) each (the "Absorbing
Company") and

(2) the board of directors of "Violine S.à r.l.", a limited liability company, under the laws of Luxembourg, with registered

office in (L-2086) Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 412F, Route d'Esch, incorporated by deed of notary Maitre
Paul Bettingen, residing in Senningerberg, on the twenty-seventh day of December two thousand five, published in the
"Memorial, Recueil des Sociétés et Associations C", C N° 837 of 26 april 2006, registered at the Trade and Companies'
Register in Luxembourg-City under section B and number 113812, with an issued share capital of one hundred fifty-eight
thousand five hundred Euro (EUR 158,500) represented by six thousand three hundred forty (6,340) shares with a nominal
value of twenty-five Euro (EUR 25) each (the "Absorbed Company", together with the Absorbing Company referred to
as the "Merging Companies"),

have together established the following common terms of the cross-border merger by absorption of the Absorbed

Company by the Absorbing Company (the "Merger Project") in order to specify the terms and conditions of such merger
and declared that:

- the shares of the Absorbing Company are held by the sole shareholder, Onward Holdings Co. Ltd, a company duly

incorporated under the laws of Japan;

- the shares of the Absorbed Company are held by the shareholders, Onward Holdings Co. Ltd, a company duly

incorporated under the laws of Japan (91.10%) and the Absorbing Company (8,90%);

- neither of the Merging Companies has a supervisory board;
- neither of the Merging Companies have a Works Council ("ondernemingsraad") or a trade union that has among its

members employees of one of the Merging Companies or any of their subsidiaries;

- neither of the Merging Companies have been dissolved or declared bankrupt, nor has a suspension of payment been

declared;

- none of the Merging Companies has any employees;
- the aforementioned merger is motivated by reasons of restructuring and rationalization of the structure and activities

of the Merging Companies, and the group of which they form part, including particularly reduction of the number of group
companies and organizational and administrative simplification. The merger by absorption of the Absorbed Company by
the Dutch Absorbing Company also aims at strengthening the presence and activities of the group of which the Merging
Companies form part, in the Netherlands;

- the details required pursuant to Section 2:333e DCC will be published in the State Gazette of the Netherlands

( "Staatscourant"), it will be announced in a nationally distributed newspaper in the Netherlands that the merger docu-
ments have been deposited in accordance with Section 2:314 DCC,

- the Merger Project will be registered with the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City and published in

the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C" in accordance with Articles 262 and 9 of the Luxembourg Law.

- the cross-border merger of the Absorbed Company into the Absorbing Company (the "Merger") shall comply with

both Dutch and Luxembourg legal provisions.

Thereupon, the following has been agreed:

Art. 1. Universal transfer of assets and liabilities. According to notably Section 2:309 and following DCC and Article

261 and following of the Luxembourg Law dealing with merger by acquisition, at the Effective Date (as defined in Art. 4
below) the Absorbing Company will acquire the entirety of the assets and liabilities of the Absorbed Company (known
and unknown), by operation of law, such that at the Effective Date (as defined below):

a) all of the assets of the Absorbed Company shall be vested in the Absorbing Company and shall thereafter be the

property of the Absorbing Company;

100182

L

U X E M B O U R G

b) the Absorbing Company shall be liable for all the obligations of the Absorbed Company, provided, however, that

notwithstanding the foregoing, amounts owing between the Absorbed Company and the Absorbing Company shall be
cancelled for no consideration;

c) the Absorbed Company will cease to exist;
d) the Absorbed Company shall hand over to the Absorbing Company the originals of all its incorporating documents,

deeds, amendments, contracts/agreements and transaction of any kind, as well as the bookkeeping and related archive
and any other accounting documents, titles of ownership or documentary titles of ownership of any assets, the supporting
documents of the operations carried out, securities and contracts, archives, vouchers and any other documents relating
to the assets and rights given at the Effective Date (as defined in Art. 4 below).

Art. 2. Data to be mentioned pursuant to Section 2:312 paragraph 2 and 2:333d DCC and Article 261 of the Luxem-

bourg Law. The following data need to be mentioned pursuant to Sections 2:312 paragraph 2 and 2:333d DCC and Article
261 of the Luxembourg Law:

I. Type of legal entity, name and official seat/registered office of the merging companies (Section 2:312 paragraph 2,

subparagraph a. and Section 2:333d, sub a. DCC as well as Article 261 paragraph 2 a) of the Luxembourg Law).

(i) the private limited liability company ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"):
"O.K.N. Amsterdam B.V.", a private limited liability company, under the laws of the Netherlands, 1101 CM, Amsterdam

Zuidoost, Herikerbergweg 238, Luna Arena, registered with the Dutch Trade Register under number 33209694, with an
issued share capital of two million Euro (EUR 2,000,000.00) represented by two thousand (2,000) shares with a nominal
value of one thousand Euro (EUR 1,000) each,

(ii) the limited company ("société anonyme"):
"Violine S.à r.l.", a public limited liability company, under the laws of Luxembourg, with registered office in (L-2086)

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 412F, Route d'Esch incorporated by deed of notary Maître Paul Bettingen,
residing in Senningerberg, on the twenty-seventh day of December two thousand five, published in the "Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C", number C N° 837 of 26 April 2012, registered at the Trade and Companies' Register in
Luxembourg-City under section B and number 113812, with an issued share capital of one hundred fifty-eight thousand
five hundred Euro (EUR 158,500) represented by six thousand three hundred forty (6,340) shares with a nominal value
of twenty-five Euro (EUR 25) each.

II. Share or corporate unit exchange ratio and, where appropriate, the amount of any cash payment (Section 3:326

DCC as well as Article 261 paragraph 2 b) of the Luxembourg Law).

The shareholders of the Absorbed Company shall receive two shares, with a nominal value of one thousand Euro

(EUR 1,000) each, in the capital of the Absorbing Company in exchange for all of its shares in the capital of the Absorbed
Company. There will be no cash payments in connection with this share exchange rate.

III. Terms for the delivery of the shares or corporate units in the Absorbing Company (Section 2:312 paragraph 2,

subparagraph g. DCC as well as Article 261 paragraph 2 c) of the Luxembourg Law).

The shares to be issued pursuant to the share exchange rate are registered shares. After the merger is effected, the

new shares will be registered in the shareholders' register of the Absorbing Company, which is a formality only and not
a constitutive requirement for the coming into existence of those shares. The same applies to the registration of this
share capital increase of the Absorbing Company with the Dutch Trade Register.

IV. Date as from which those shares or corporate units shall carry the right to participate in the profits and any special

condition regarding that right (Section 2:326 DCC as well as Article 261 paragraph 2 d) of the Luxembourg Law).

The shares shall participate in the profits of the Absorbing Company as of 1 December 2011. No special conditions

apply to such participation in the profits of the Absorbing Company.

V. Articles of Association of the Absorbing Company (Section 2:312, paragraph 2, subparagraph b. DCC as well as

Article 261 paragraph 4 a) of the Luxembourg Law).

The Articles of Association of the Absorbing Company shall not be amended in connection with the Merger.
These Articles of Association of the Absorbing Company were drawn up by deed of incorporation on 28 April 1989.

The Articles of Association were last amended, by a deed, executed on 2 July 2007 before A.A. Voorneman, civil law
notary in Amsterdam, the Netherlands. The Articles of Association of the Company have -according to information from
the Dutch Trade Register - not been amended since. The current text of the Articles of Association, is attached to this
Merger Project to be filed at the same time with the registration authorities, shall form an integrated part of this Merger
Project and shall be published together with this Merger Project.

VI. Rights given and compensations to be paid, chargeable, to the Absorbing Company (Section 2:312, paragraph 2,

subparagraph c. DCC as well as Article 261 paragraph 2 f) of the Luxembourg Law).

As there are no persons who, in any other capacity than as shareholder, have special rights against the Absorbed

Company, no special rights will be given to and no compensations will be paid to anyone by the Absorbing Company.

VII. Benefits to be granted to the members of the management board or of the supervisory board of the Merging

Companies or to third parties in connection with the Merger (Section 2:312, paragraph 2, subparagraph d. DCC as well
as Article 261 paragraph 2 g) of the Luxembourg Law).

100183

L

U X E M B O U R G

None.
VIII. Intentions with regard to the composition of the management board of the Absorbing Company after the Merger

(Section 2:312, paragraph 2, subparagraph e. DCC).

There is no intention to change the composition of the management board of the Absorbing Company after the Merger.
The present composition is as follows:

<i>Management board:

- Eiji TONO, with title director A;
- Hirokazu YOSHIZATO, with title director A;
- Paul Jozef SCHMITZ, with title director B;
- Jacob Cornelis Willem VAN BURG, with title director B;
- Michiel Merijn BERNARDUS, with title director B.
IX. Date per which the financial data of the Absorbed Company will be accounted for in the annual accounts of the

Absorbing Company (Section 2:312, paragraph 2, subparagraph f. DCC and Article 261 paragraph 2 e) of the Luxembourg
Law).

The financial data of the Absorbed Company will be accounted for in the annual accounts of the Absorbing Company

with retroactive effect as per 1 December 2011 (the "Accounting Date"). The last financial year of the Absorbed Company
therefore ends on the date immediately preceding the Accounting Date.

X. Proposed measures in connection with a transmission of the shareholdership of the Absorbed Company (Section

2:312, paragraph 2, subparagraph g. DCC).

There will be no transmission of the shareholdership of the Absorbed Company; therefore measures will not be

required.

XI. Intentions involving continuance or termination of activities (Section 2:312, paragraph 2, subparagraph h. DCC).
In addition to the legal consequences further to effectiveness of the Merger as stated in Art. 4 below, the activities of

the Absorbed Company will be continued by the Absorbing Company. For the avoidance of doubt, this cross-border
merger will not imply or provoke any termination of activities of the Merging Companies.

XII. Approval of the resolution to effect the Merger (Section 2:312, paragraph 2, subparagraph i. DCC as well as Article

263 and following of the Luxembourg Law).

The  resolutions  to  effect  the  Merger  will  be  taken  by  the  general  meeting  of  the  shareholders  of  the  Absorbing

Company and by the general meeting of shareholders of the Absorbed Company.

XIII. Effects of the Merger on the goodwill and the distributable reserves of the Absorbing Company (Section 2:312,

paragraph 4, final sentence DCC).

There will be no effects of the Merger on the goodwill and the distributable reserves of the Absorbing Company.
XIV. Probable consequences of the Merger for the employment (Section 2:333d, sub b. DCC as well as Article 261

paragraph 4 b) of the Luxembourg Law).

There are no probable consequences of the Merger for employment, as the Merging Companies have no employees.
XV. Procedures for employee participation (Section 2:333d, sub c. DCC as well as Article 261 paragraph 4 c) of the

Luxembourg Law).

As the Merging Companies do not have employees and none of the Merging Companies is subject to regulations dealing

with employee participation, no arrangements with respect to employee participation have to be made.

XVI. Information on the valuation of assets and liabilities of the Absorbed Company to be acquired by the Absorbing

Company (Section 2:333d, sub d. DCC as well as Article 261 paragraph 4 d) of the Luxembourg Law).

The valuation of the relevant assets and liabilities of the Absorbed Company to be acquired by the Absorbing Company

was done on the basis of the book value in accordance with its interim accounts as at 31 

st

 May 2012.

XVII. Date of the most recently adopted annual accounts used to establish the terms of the Merger (Section 2:33d,

sub e. DCC as well as Article 261 paragraph 4 e) of the Luxembourg Law).

The annual accounts of the Absorbing Company for the financial year having ended as at 30 November 2011 were

adopted on 30 

th

 July 2012 for the Absorbing Company and the annual accounts of the Absorbed Company ended as at

30 November 2011 were adopted on 9 

th

 July 2012 for the Absorbed Company.

XVIII. Proposal for the level of compensation of shareholders of the Absorbed Company (Section 2:333d, sub f. DCC).
There will be no compensation for shareholders of the Absorbed Company which vote against the Merger. In addition,

the Absorbed Company hereby waives any claim it may have to such compensation.

Art. 3. Valuation of assets and Liabilities of the Absorbed Company. On the basis of their book value the net assets

of the Absorbed Company amount to 62.298.898,88 Euro (sixty-two million two hundred ninety-eight thousand eight
hundred ninety-eight Euro and eighty eight euro cents) according to its interim accounts as at 31 

th

 May 2012.

100184

L

U X E M B O U R G

Further to the Merger, the assets and liabilities of the Absorbed Company will be booked in the balance sheet of the

Absorbing Company at book value as at the Accounting Date.

Art. 4. Effective Date - Approval of the Absorbing Company. The Merger shall become effective between the Merging

Companies and towards third parties as of the day after the day the notarial deed of merger has been executed before
a Dutch civil law notary (the "Deed of Merger").

Art. 5. Obligations concerning formalities of the Absorbing Company. The Absorbing Company shall carry out all the

legal formalities required by law and being necessary or useful to achieve the Merger and to have the Absorbing Company
acquire all the assets and liabilities of the Absorbed Company.

Art. 6. Availability of the Merger documentation at registered offices. The documents referred to Section 2:314 para-

graphs 1 and 2 DCC and in Article 267 paragraph 1 a), b), c) and d) of the Luxembourg Law, in particular:

a) the Merger Project;
b) the annual accounts of the Merging Companies for the last three financial years;
c) interim accounts of the Merging Companies as at 31.05 2012;
d) the explanatory reports of the management body of the Absorbing Company and of the board of directors of the

Absorbed Company;

e) where applicable, the reports referred to in Article 266 of the Luxembourg Law,
will be made available as from the date hereof for inspection at the registered offices of the Merging Companies, in

addition to their filing with the Dutch Trade Register.

Art. 7. Creditors' claims. The creditors of the Merging Companies will benefit from all the protections and recourses

as provided for by Dutch law and the Luxembourg Law, i.e.:

a) according to Section 2:316 DCC, each creditor may oppose the Merger Project by a petition to the court specifying

the requested security up to one (1) month after the day, on which the Merging Companies have announced that the
Merger Project and other required documents have been deposited in accordance with the applicable provisions of the
DCC;

b) according to Luxembourg Law, the creditors of the Merging Companies, whose claims predate the date of publication

of the extraordinary general meeting of the Absorbed Company to be held before a Luxembourg notary approving the
Merger may, notwithstanding any agreement to the contrary, apply within two (2) months to the competent court to
obtain  adequate  safeguard  of  collateral  for  any  matured  and  unmatured  debts,  where  the  Merger  would  make  such
protection necessary.

In this respect, the creditors may obtain additional information at the registered offices of the Absorbing Company,

i.e. 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands, Herikerbergweg 238, Luna Arena and of the Absorbed Company,
i.e. at (L-2086) Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 412F, Route d'Esch. Signature page follows.

Art. 8. Intentions regarding continuation or winding up of activities. The activities of the Absorbed Company shall be

continued by the Absorbing Company in the same manner.

Art. 9. Effects of the absorption. The absorption involves the effects of the article 274 of the LSC.
By effect of the absorption, the absorbed company will be dissolved without liquidation and the shares of the absorbed

company will be cancelled.

The mandates of the directors and the legal auditor of the absorbed company will be ended on the effective date, the

disclaimer will be granting to the directors and the legal auditor of the absorbed companies.

The absorbing company will be the owner of the assets belonging to the absorbed company on the effective date,

without  appeal  against  the  absorbed  company  for  any  reason  whatsoever.  The  absorbed  company  guarantee  to  the
absorbing company that the transferred claims in the framework of the absorption are certain but not guarantee the
solvency of debtors.

The absorbing company takes the responsibility all rights and obligations attached to the absorbed company.
The absorbing company settle, on the effective date all the taxes, fees, insurances and others, so ordinary as extraor-

dinary, which will burden or can burden the property of all transferred assets.

The absorbing company will execute all agreements and commitments of whatever nature of the absorbed company,

such as these agreements and commitments exist in the effective date.

The absorbing company will proceed to all the necessary or useful formalities to give effect to the absorption and the

transfer of all the assets and obligations of the absorbed company.

The corporate documents of the absorbed company will be deposited and kept during the legal period of the corporate

seat of the absorbing company.

100185

L

U X E M B O U R G

24/07/2012.

Violine S.à r.l. / Violine S.à r.l. / Violine S.à r.l. / O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V. /
O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V.
F. Pèné / S. Crugnola / D. Alves / E. Tono / H. Yoshizato / P.J. Schmitz / J.C.W. van Burg / M.M. Bernardus
<i>Director A / Director B / Director B / Director A / Director A / Director B / Director B / Director B

Luxembourg, on 30 July 2012.

Violine S.à r.l. / Violine S.à r.l. / Violine S.à r.l. / O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V. /
O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V.
F. Pèné / P. Wagner / D. Alves / E. Tono / H. Yoshizato / P.J. Schmitz / J.C.W. van Burg / M.M. Bernardus
<i>Director A / Director B / Director B / Director A / Director A / Director B / Director B / Director B

24/07/2012 / 30/07/2012 / 2 August 2012.

Violine S.à r.l. / Violine S.à r.l. / Violine S.à r.l. / O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V. /
O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V. / O.K.N. Amsterdam B.V.
F. Pèné / S. Crugnola / D. Alves / E. Tono / H. Yoshizato / P.J. Schmitz / J.C.W. van Burg / M.M. Bernardus
<i>Director A / Director B / Director B / Director A / Director A / Director B / Director B / Director B

MODIFICATION DE STATUTS

Le deux juillet deux mille sept, par-devant Nous.
Anton Arnaud Voorneman. notaire à Amsterdam,

a comparu:

Monsieur Hugo Meilink. dont le bureau est situé à 1083 GV Amsterdam. Areni Janszoon -Ernststraat 199, né à Har-

denberg le trois décembre mil neuf cent septante-sept.

Le comparant a déclaré ce qui suit:
L'actionnaire unique d'O.K..N. Amsterdam B.V.. une société privée à responsabilité limitée, ayant son siège statutaire

à Amsterdam et son siège social à 1077 ZX Amsterdam. Strawinskylaan 3105 7e étage, inscrite au registre du commerce
sous le numéro 33209694 (la «société»). a décidé, le dix-huit juin deux mille sept de modifier et de refixer l'ensemble
des statuts de la société ainsi que de mandater le comparant pour passer le présente acte. Il ressort de cette résolution
une décision d'actionnaire qui est jointe au présent acte.

Les statuts de la société ont été partiellement modifiés en dernier lieu par acte de modification de statuts, passé le

vingt-cinq mai deux mille quatre devant Me Renatus iViartinus Rieter, notaire à 's Gravenhage, et une déclaration minis-
térielle de non-objection a été délivrée en conséquence, le treize mai deux mille quatre sous le numéro BV 357202.

En exécution de la décision de changement de statuts susmentionnée, les statuts de la société sont modulés par la

présente et refixés dans leur ensemble comme suit.

STATUTS:

1. Définitions.
1.1 Dans les présents statuts, les termes suivants s'entendent comme suit:
«action»: une action dans le capital de la société:
«actionnaire»: le détenteur d'une ou plusieurs actions:
«assemblée générale» ou «assemblée générale des actionnaires»: l'organe social qui est constitué par les actionnaires

ou une réunion d'actionnaires (ou de leurs représentants) et d'autres personnes avec droits d'assemblée:

«directeur A»: un directeur A de la société:
«directeur B»: un directeur B de la société:
«direction»: la gestion de la société:
«par écrit»: par lettre, télécopie ou courrier électronique ou tout autre moyen de communication électronique, à

condition que le message soit lisible et reproductible:

«capitaux propres pouvant être distribués»: la partie des capitaux propres de la société qui excède le capital souscrit

majoré des réserves qui doivent être maintenues en venu de la loi:

«société»: la société dont l'organisation interne est régie par les présents statuts.
1.2 Sauf disposition contraire expresse, les renvois aux articles sont des renvois aux articles des présents statuts.

2. Dénomination et Siège.
2.1 La société est dénommée comme suit: O.K.N. Amsterdam B.V.
2.2 La société est établie à Amsterdam.

100186

L

U X E M B O U R G

3. Objet. La société a pour objet:
a) la création de la participation de quelque façon que ce soit à la gestion et la surveillance d'entreprises et de sociétés:
b) le financement d'entreprises et de sociétés;
c) le prêt et la mobilisation de ressources, en ce compris l'émission d'obligations ou autres titres, ainsi que la conclusion

des conventions connexes:

d) la fourniture d'avis et la prestation de services aux entreprises et sociétés auxquelles la société est liée dans un

groupe ainsi qu'aux tiers:

e) la fourniture de garanties, l'engagement de la société et la mise en gage d'actifs de la société au profit d'entreprises

et de sociétés avec lesquelles la société est liée dans un groupe ainsi qu'au profit de tiers:

f) l'obtention, la gestion, l'exploitation et l'aliénation de biens enregistrés et de valeurs en général:
g) la négociation de devises, d'effets et de valeurs en général:
h) l'exploitation et la négociation de brevets, de droits de marques, d'autorisations, de savoir-faire, de droits d'auteur,

de banques de données et autres doits de propriété intellectuelle:

i) l'exécution de tout type d'activités industrielles, financières et commerciales:
et tout ce qui a un rapport avec les activités précitées ou qui peuvent en favoriser l'accomplissement, le tout au sens

le plus large du terme.

4. Capital social.
4.1 Le capital social de la société s'élève à sept millions d'euros (7.000.000 EUR).
4.2 Le capital social est divisé en sept mille (7.000) actions ayant une valeur nominale de mille euros (1.000 EUR)

chacune.

4.3 Toutes les actions sont nominatives. Des certificats d'action ne sont pas émis.

5. Registre des actionnaires.
5.1 La direction lient un registre des actionnaires dans lequel sont repris les noms et adresses de tous les actionnaires.
5.2 Les dispositions de l'article 2.194 du Code civil sont applicables au registre des actionnaires.

6. Émission d'actions.
6.1 Une émission d'actions a lieu par suite d'une décision de l'assemblée générale. L'assemblée générale peut transférer

sa compétence à cet égard à un autre organe social et peut révoquer ce transfert.

6.2 Le prix de l'émission et les autres conditions d'émission sont fixés lors de la décision d'émettre des actions.
6.3 Pour l'émission d'une action, un acte passé à cet effet par-devant un notaire de résidence aux Pays-Bas et auquel

les intéressés sont parties est en outre exigé.

6.4 Lors de l'émission des actions, chaque actionnaire dispose d'un droit préférentiel de souscription proportionnel-

lement au montant nominal total de ses actions, sous réserve des limitations légales a cet effet et des dispositions de
l'article 6.5.

6.5 Le droit préférentiel peut chaque fois, pour une émission unique, être limité ou exclu par décision de l'organe

social compétent pour les émissions.

6.6 L'intégralité du montant nominal doit être versée lors de la souscription de toute action.
6.7 La direction est compétente pour conclure les actes juridiques concernant un apport autre qu'en numéraire sur

les actions ainsi que les autres actes juridiques \isés à l'article 2.204 du Code civil, sans l'approbation préalable de l'as-
semblée générale.

7. Actions propres: Réduction du capital souscrit.
7.1 La société et ses filiales peuvent acquérir des actions entièrement libérées ou les certificats de ces dernières, sous

réserve des limitations légales à cet égard.

7.2 La société et ses filiales ne peuvent accorder de prêts en vue de la souscription ou de l'acquisition d'actions ou de

leurs certificats qu'à concurrence de la limite la plus élevée des réserves distribuables de la société.

7.3 L'assemblée générale peut décider d'une réduction du capital souscrit sous réserve des dispositions prévues à cet

effet par la loi.

8. Livraison des actions.
8.1 Pour la livraison d'une action, un acte passé à cet effet par-devant un notaire de résidence aux Pays-Bas et auquel

les intéressés sont parties est exigé.

8.2 Sauf dans le cas où la société est elle-même partie à l'acte juridique, les droits liés à l'action peuvent cire exercés

pour la première fois après que la société a reconnu l'acte ou après que l'acte lui est signifié, conformément aux dispo-
sitions de la loi à cet égard.

100187

L

U X E M B O U R G

9. Règle de blocage (offre à des coactionnaires).
9.1 Les dispositions prévues ci-après au présent article 9 sont applicables au transfert d'une ou de plusieurs actions,

sauf si i) tous les actionnaires ont donné leur accord par écrit au transfert précité, lequel accord est valable pour une
période de trois mois, ou si ii) l'actionnaire concerné est légalement tenu par la loi de transférer ses actions à un précédent
actionnaire.

9.2 Le transfert d'une ou plusieurs actions ne peut a\oir lieu que lorsque la vente de celles-ci a d'abord été proposée

aux coactionnaires. L'actionnaire en question (l'actionnaire «offrant») en fait I"offre au moyen d'une communication écrite
à la direction, en indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite transférer et la personne ou les personnes auxquelles il
souhaite transférer ces actions. La direction porte l'offre à la connaissance des coactionnaires. Les coactionnaires qui ...
l'achat d'une ou plusieurs des actions proposées (les «candidats acquéreurs») doivent le signaler à la direction. Si la société
est elle-même un coactionnaire, elle ne peut intervenir en tant que candidat acquéreur qu'avec l'accord de l'actionnaire
offrant.

9.3 Le prix auquel les actions proposées peuvent être achetées par les candidats acquéreurs est fixé par l'actionnaire

offrant et les candidats acquéreurs en concertation mutuelle ou par des experts à désigner par eux. Si un accord sur le
prix ne peut être obtenu par eux ou par l'expert (les experts), le prix est fixé par un ou plusieurs experts indépendants
qui seront désignés, à la demande d'une ou plusieurs parties concernées, par le président de la Chambre du commerce
et de l'industrie dans le registre de laquelle la société est inscrite.

9.4 Dans un délai d'un mois après que le prix fixé leur a été communiqué, les candidats acquéreurs doivent commu-

niquer à la direction le nombre d'actions offertes qu'ils souhaitent acheter. Après la communication telle que visée dans
la phrase précédente, un candidat acquéreur ne peut se retirer qu'avec l'accord des autres candidats acquéreurs.

9.5 Si les candidats acquéreurs souhaitent, au total, acheter davantage d'actions que celles qui sont proposées, les

actions proposées seront réparties entre eux. La répartition est fixée en concertation mutuelle par les candidats acqué-
reurs. Si les candidats acquéreurs ne parviennent pas à un accord sur la répartition, celle-ci est fixée par la direction, et
ce,  de  façon  aussi  proportionnelle  que  possible  au  montant  nominal  total  des  actions  dont  dispose  chaque  candidat
acquéreur au moment de la répartition. Il ne peut être attribué davantage d'actions proposées à un candidat acquéreur
qu'il ne souhaite en acquérir.

9.6 L'actionnaire offrant est habilité à retirer son offre pendant un délai d'un mois à compter du jour où il a connaissance

du ou des candidat(s) acquéreur(s) au(x)quel(s) il peut vendre toutes ses actions proposées et à quel prix.

9.7 S'il s'avère qu'aucun des coactionnaires n'est candidat acquéreur ou que toutes les actions proposées ne seront

pas achetées moyennant un paiement au comptant par un ou plusieurs candidats acquéreurs, l'actionnaire offrant peut,
après un délai de trois mois, transférer librement les actions en question, et non une partie seulement de celles-ci. à la
personne ou aux personnes désignées à cet effet dans l'offre.

10. Nantissement et Usufruit sur les actions.
10.1 Les dispositions de l'article S s'appliquent par analogie à la constitution d'un nantissement sur les actions et à la

constitution d'un usufruit sur les actions.

10.2 Lors de la constitution d'un nantissement ou d'un usufruit sur une action, le droit de vote ne peut être accordé

au détenteur du nantissement ou de l'usufruit.

11. Certificats d'actions.

12. Directeurs.
12.1 La direction se compose d'un ou plusieurs directeurs A et d'un ou plusieurs directeurs B. Tant des personnes

physiques que morales peuvent être directeurs. L'assemblée générale fixe le nombre de directeurs A et B.

12.2 Les directeurs A et B sont nommés par l'assemblée générale.
12.3 Chaque directeur peut être suspendu et révoqué à tout moment pal l'assemblée générale.

13. Gestion, Résolution et Répartition des tâches.
13.1 La direction est chargée de la gestion de la société.
13.2 La direction peut fixer les règles concernant le processus décisionnel et opérationnel de la direction. Dans ce

cadre,  la  direction  peut  notamment  déterminer  de  quelle  tâche  chaque  directeur  sera  plus  particulièrement  chargé.
L'assemblée générale peut déterminer que ces règles et cette répartition des lâches doivent être établies par écrit et
soumises à son approbation.

13.3 Les décisions de la direction peuvent être prises par écrit à tout moment, à condition que la proposition en

question soit présentée à tous les directeurs en fonction et qu'aucun d'eux ne s'oppose à ce processus décisionnel.

14. Représentation: conflits d'intérêts.
14.1 La direction est compétente pour représenter la société. Le pouvoir de représentation revient à un directeur A

et un directeur B agissant conjointement.

14.2 La direction peut désigner des agents disposant d'un pouvoir de représentation général ou limité. Chacun d'eux

représente la société dans le respect des limites fixées à leur compétence. Les titres et qualités de ces agents sont

100188

L

U X E M B O U R G

déterminés par la direction. Le pouvoir de représentation d'un agent ainsi nommé ne peut s'étendre aux cas où la société
présente un conflit d'intérêts avec l'agent en question ou avec un ou plusieurs directeurs.

14.3 Dans tous les cas où la société présente un conflit d'intérêts avec un ou plusieurs directeurs, les dispositions de

l'article 14.1 restent pleinement applicables sauf si l'assemblée générale a désigné une ou plusieurs autres personnes pour
représenter la société dans le cas en question ou dans des cas semblables. Une décision de la direction pour l'accom-
plissement d'un acte juridique qui concerne un conflit d'intérêts avec un ou plusieurs directeurs en privé est soumise à
l'approbation de l'assemblée générale mais l'absence d'une telle approbation n'affecte pas le pouvoir de représentation
de la direction ou des directeurs.

15. Approbation des décisions de la direction.
15.1 L'assemblée générale a le pouvoir de soumettre les décisions de la direction à son approbation. Ces décisions

doivent être clairement décrites et communiquées par écrit à la direction.

15.2 L'absence d'approbation de lu part de l'assemblée générale sur une décision telle que visée au présent article 15

n'affecte pas le pouvoir de représentation de la direction ou des directeurs.

16. Absence ou Empêchement. En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les autres directeurs sont tem-

porairement chargés de la gestion de la société, à condition qu'il n'existe pas d'absence ou d'empêchement en ce qui
concerne au moins un directeur A et un directeur B. En cas d'absence ou d'empêchement de tous les directeurs ou en
cas d'absence ou d'empêchement de tous les directeurs A et de tous les directeurs B, la personne nommée à cet effet
par l'assemblée générale est chargée de la gestion de la société.

17. Exercice et Comptes annuels.
17.1 L'exercice de la société s'étend du premier décembre au trente novembre de l'année suivante.
17.2 Chaque année, dans un délai de cinq mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai d'au

maximum six mois par l'assemblée générale en raison de circonstances particulières, la direction établit les comptes
annuels et les met à la disposition des actionnaires au siège de la société.

17.3 Au cours de ce délai, la direction met également le rapport annuel à la disposition des actionnaires, sauf si l'article

2.396. paragraphe 6, ou l'article 2.403 du Code civil des sociétés s'applique.

17.4 Les comptes annuels se composent d'un bilan, d'un compte de résultat et de notes explicatives.
17.5 Les comptes annuels sont signés par les directeurs. En l'absence de la signature de l'un ou de plusieurs d'entre

eux, il en est fait mention en indiquant le motif.

17.6 La société peut donner mission, et en cas d'obligation légale, donnera mission à un comptable d'examiner les

comptes annuels. L'assemblée générale est compétente pour confier cette mission.

17.7 L'assemblée générale établit les comptes annuels.
17.8 Lors de l'assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle il est décidé d'établir les comptes annuels, il

est spécialement mis à l'ordre du jour une proposition concernant l'octroi de la décharge aux directeurs sur la gestion,
pour l'exercice de leurs tâches, telle qu'elle résulte des comptes annuels ou des informations autrement communiquées
à l'assemblée générale préalablement à l'établissement des comptes annuels.

18. Bénéfices et Versements.
18.1 Les bénéfices enregistrés au cours d'un exercice sont mis à la disposition de l'assemblée générale.
18.2 La distribution des bénéfices s'effectue après l'établissement des comptes annuels desquels il ressort qu'elle est

permise.

18.3 L'assemblée générale peut décider de procéder à des distributions intérimaires et/ou à des distributions à charge

d'une réserve de la société.

18.4 Les distributions sur les actions ne peuvent avoir lieu qu'à concurrence du montant des capitaux propres distri-

buâmes.

19. Assemblées générales des actionnaires.
19.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tient dans un délai de six mois à compter de la clôture de

l'exercice.

19.2 D'autres assemblées générales des actionnaires se tiennent aussi souvent que la direction le juge nécessaire.
19.3 Les actionnaires représentant conjointement au moins un dixième du capital souscrit de la société ont le droit

de demander à la direction de convoquer une assemblée générale des actionnaires, en précisant les sujets à traiter. Si la
direction n'a pas procédé à la convocation dans un délai de quatre semaines, de façon à ce que l'assemblée puisse se tenir
clans un délai de six semaines à compter de la demande, les demandeurs sont habilités à procéder eux-mêmes à la
convocation.

20. Convocation, Ordre du jour et Lieu des assemblées.
20.1 Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par la direction, sous réserve des dispositions de

l'article 19.3.

100189

L

U X E M B O U R G

20.2 La convocation ne peut avoir lieu plus tard que le cinquième jour précédant celui de l'assemblée.
20.3 Lors sujets à traiter sont mentionnés dans la convocation. Les sujets qui ne sont pas mentionnés dans la convo-

cation peuvent être précisés dans le délai visé à l'article 20.2.

20.4 Un sujet dont le traitement a été demandé par écrit par un ou plusieurs actionnaires qui, seuls ou conjointement,

représentent au moins un centième du capital souscrit, est repris dans la convocation ou annoncée de la même façon si
la société n'a pas reçu la demande moins de trente jours avant la tenue de l'assemblée et à condition qu'aucun intérêt
majeur de ma société ne s'y oppose.

20.5 La convocation a lieu au moyen d'avis de convocation envoyés aux adresses des actionnaires telles que mention-

nées dans le registre des actionnaires.

20.6 Les assemblées générales des actionnaires se tiennent dans la commune où la société est établie conformément

aux statuts ou à Schiphol (commune de Haarlemmermeer). Les assemblées générales des actionnaires peuvent également
se tenir ailleurs mais dans ce cas, les décisions de l'assemblée générale ne peuvent être valablement prises que si l'ensemble
du capital souscrit de la société est représenté.

21. Accès et Droits d'assemblée.
21.1 Chaque actionnaire est habilité à assister aux assemblées générales des actionnaires, y intervenir et exercer son

droit de vote. Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée au moyen d'une procuration écrite.

21.2 Chaque actionnaire avec droit de vote qui est présent à l'assemblée doit signer la liste des présences. Le président

de l'assemblée peut déterminer que la liste des présences doit également être signée par les autres personnes qui sont
présentes à l'assemblée.

21.3 Les directeurs ont, en cette qualité, une voix consultative lors des assemblées générales des actionnaires.
21.4 Le président de l'assemblée décide d'autoriser la présence d'autres personnes.

22. Président et Rédacteur du procès-verbal de l'assemblée.
22.1 Le président d'une assemblée générale des actionnaires est désigné par les actionnaires ayant droit de vote qui

sont présents à l'assemblée, à la majorité des votes émis.

22.2 Le président de l'assemblée désigne le rédacteur du procès-verbal pour l'assemblée.

23. Procès-verbaux: Mention des décisions des actionnaires.
23.1 Le rédacteur du procès-verbal établit un compte-rendu des questions traitées lors de l'assemblée générale des

actionnaires. Les procès-verbaux sont établis par le président et le rédacteur de l'assemblée et sont attestés par leur
signature.

23.2 La direction prend note de toutes les décisions prises par l'assemblée générale. Si la direction n'est pas représentée

à  l'assemblée,  une  copie  des  décisions  prises  est  envoyée  à  la  direction  dans  les  plus  brefs  délais  après  la  tenue  de
l'assemblée par ou au nom du président de l'assemblée. Ces indications sont mises à la disposition des actionnaires au
siège de la société. Une copie ou un extrait de ces indications est envoyé à chacun d'eux sur demande.

24. Prise de décision en assemblée.
24.1 Chaque action donne droit à une voix.
24.2 Sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises

à la majorité absolue des voix émises, sans qu'un quorum soit nécessaire.

24.3 En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
24.4 S'il n'est pas tenu compte des prescriptions données par la loi ou les présents statuts pour la convocation et la

tenue des assemblées générales des actionnaires, des décisions de l'assemblée ne peuvent être valablement prises lors
de l'assemblée que si la totalité du capital souscrit de la société est représentée et à l'unanimité.

25. Prise de décision hors assemblée.
25.1 Les actionnaires peuvent prendre les décisions de l'assemblée générale par écrit et non en assemblée, moyennant

l'unanimité de tous les actionnaires avant droit de vote. Les dispositions de l'article 21.3 s'appliquent par analogie.

25.2 Chaque actionnaire est tenu de veiller à ce que les décisions ainsi prises soient communiquées par écrit à la

direction dans les plus brefs délais. I.a direction prend note des décisions prises et ajoute ces indications à celles visées à
l'article 23.2.

26. Modification des statuts. L'assemblée générale est habilitée à modifier les présents statuts. Lorsqu'une proposition

de modification des statuts doit être faite à l'assemblée générale, celle-ci doit toujours être mentionnée dans la convo-
cation de l'assemblée générale. Dans le même temps, une copie de la proposition, dans laquelle la modification proposée
est littéralement reprise, est mise à la disposition des actionnaires au siège de la société, jusqu'à la fin de l'assemblée.

27. Dissolution et Liquidation.
27.1 La société peut être dissoute par décision une décision de l'assemblée générale prise à cet effet. Lorsqu'une

proposition de dissolution de la société doit être soumise à l'assemblée générale, elle doit être mentionnée dans l'avis de
convocation à l'assemblée générale.

100190

L

U X E M B O U R G

27.2 En cas de dissolution de la société en vertu d'une décision de l'assemblée générale, les directeurs sont les liqui-

dateurs du patrimoine de la société dissoute, sauf si l'assemblée générale décide de nommer une ou plusieurs autres
personnes.

27.3 Pendant la dissolution, les dispositions des présents statuts restent autant que possible en vigueur.
27.4 Le solde restant après l'extinction des créances de la société dissoute est transféré aux actionnaires, propor-

tionnellement au montant nominal total des actions de chacun.

27.5 Les dispositions pertinentes du Livre 2. Titre I, du Code civil s'appliquent en outre à la liquidation.

28. Dispositions transitoires.
28.1 L'exercice de la société qui a débuté le premier janvier deux mille sept prend fin le trente novembre deux mille

sept.

28.2 L'article 28, y compris l'intitulé, s'éteint à l'échéance de l'exercice prenant fin le trente novembre deux mille sept.
Enfin, le comparant a déclaré:
Déclaration de non-objection
Aux fins de la modification de statuts susmentionnée, une déclaration ministérielle de non-objection a été délivrée en

conséquence, le vingt-neuf juin deux mille sept sous le numéro BV 357202, de laquelle il ressort une déclaration écrite
du Ministère de la Justice qui est jointe au présent acte.

<i>Dispositions finales

Le comparant est connu de Nous, notaire.

Dont acte, passé à Amsterdam, à la date mentionnée en tète du présent acte.
Avant de donner lecture, le contenu du présent acte a été remis et expliqué en substance au comparant. Le comparant

a ensuite déclaré avoir pris connaissance du contenu du présent acte, y donner son accord et ne pas tenir à sa lecture
intégrale. Immédiatement après une lecture limitée du présent acte, ce dernier a été signé par le comparant ainsi que par
Nous, notaire,

Signé: H. Meilink. A.A. Voorneman.

POUR COPIE
Signature

AMENDMENT ARTICLES OF ASSOCIATION

On the second day of July two thousand seven appeared before me,
Anton Amaud Voorneman, civil law notary in Amsterdam:
Mr Hugo Meilink, with office address at 1083 GV Amsterdam, Arent Janszoon Emststraat 199, born in Hardenberg on

the third day of December nineteen hundred seventy-seven,

The person appearing declared the following:

The sole shareholder of O.K.N. Amsterdam B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met

beperhe aansprakelijkheid), incorporated under the laws of the Netherlands, having its corporate seat (statutaire zetel)
at Amsterdam, and its office at Strawinskylaan 3105 7 

th

 floor, 1077 ZX Amsterdam, registered with the Dutch Trade

Register of the Chambers of Commerce under number 33209694 (the "Company") has resolved on the eighteenth day
of June day two thousand and seven to amend and completely readopt the articles of association of the Company, as well
as to authorise the person appearing to have this deed executed. The adoption of such resolutions is evidenced by a
shareholder's resolution attached to this deed. The articles of association of the Company were last partially amended
by a deed of amendment of the articles of association, executed on the twenty-fifth day of May two thousand and four
before Renatus Martinus Rieter, at the time civil law notary in The Hague, with respect to which a ministerial statement
of no objections was granted on the thirteenth day of May two thousand and four, under number BV 357202.

In implementing the aforementioned resolution, the articles of association of the Company are hereby amended and

completely readopted as follows.

ARTICLES OF ASSOCIATION:

1. Definitions.
1.1 In these articles of association, the following terms shall have the following meanings:
"Share": a share in the capital of the Company.
"Shareholder": a holder of one or more Shares.
"General Meeting" or "General Meeting of Shareholders": the body of the Company consisting of the Shareholders or

(as the case may be) a meeting of Shareholders (or their representatives) and other persons entitled to attend such
meetings.

"Managing Director A": a managing director A of the Company;
"Managing Director B": a managing director B of the Company

100191

L

U X E M B O U R G

"Management Board": the management board of the Company.
"in writing": transmitted by letter, telecopier or e-mail, or any other electronic means of communication, provided the

relevant message is legible and reproducible.

"Distributable Equity": the part of the Company's equity which exceeds the aggregate of the issued capital and the

reserves which must be maintained pursuant to the law.

"Company": the company the internal organisation of which is governed by these Articles of Association.
1.2 References to "Articles" refer to articles which are part of these Articles of Association, except where expressly

indicated otherwise.

2. Name and Official Seat.
2.1 The Company's name is: O.K.N. Amsterdam B.V.
2.2 The official seat of the Company is in Amsterdam.

3. Objects. The objects of the Company are:
(a) to incorporate, to participate in any way whatsoever in, to manage, to supervise businesses and companies;
(b) to finance businesses and companies;
(c) to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence

of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with aforementioned activities;

(d) to render advice and services to businesses and companies with which the Company forms a group and to third

parties;

(e) to grant guarantees, to bind the Company and to pledge its assets for obligations of businesses and companies with

which it forms a group and on behalf of third parties;

(f) to acquire, alienate, manage and exploit registered property and items of property in general;
(g) to trade in currencies, securities and items of property in general;
(h) to develop and trade in patents, trade marks, licenses, know-how, copyrights, data base rights and other intellectual

property rights;

(i) to perform any and all activities of an industrial, financial or commercial nature; and to do all that is connected

therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.

4. Authorised Capital.
4.1 The authorised capital of the Company is seven million euro (EUR 7,000.000).
4.2 The authorised capital of the Company is divided into seven thousand (7,000) Shares with a nominal value of one

thousand euro (EUR 1,000) each.

4.3 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued.

5. Register of Shareholders.
5.1 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and addresses of all Shareholders

are recorded.

5.2 Section 2:194 of the Dutch Civil Code applies to the register of Shareholders.

6. Issuance of Shares.
6.1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the General Meeting. The General Meeting may transfer this

authority to another body of the Company and may also revoke such transfer.

6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.
6.3 The issue of a Share shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law

notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties.

6.4 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre emption in proportion to the aggregate nominal

value of his Shares, subject to the relevant limitations prescribed by law and the provisions of Article 6.5.

6.5 Prior to each single issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the body of the

Company competent to issue such Shares.

6.6 The full nominal value of each Share must be paid upon subscription.
6.7 The Management Board shall be authorised to perform legal acts relating to non¬cash contributions on Shares and

other legal acts mentioned in Section 2:204 of the Dutch Civil Code, without prior approval of the General Meeting.

7. Own Shares: Reduction of the Issued Capital.
7.1 The Company and its subsidiaries may acquire fully paid in Shares or depositary receipts thereof, with due ob-

servance of the limitations prescribed by law.

7.2 The Company and its subsidiaries may grant loans with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or

depositary receipts thereof, but not in excess of the amount of the Company's distributable reserves.

100192

L

U X E M B O U R G

7.3 The General Meeting may resolve to reduce the Company's issued capital in accordance with the relevant provisions

prescribed by law.

8. Transfer of Shares.
8.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary

registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.

8.2 Unless the Company itself is party to the transfer, the rights attributable to the Share can only be exercised after

the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it, in accordance with the relevant
provisions of the law.

9. Share Transfer Restrictions (Offer to co-Shareholders).
9.1 The provisions of this Article 9 below are applicable to a transfer of one or more Shares, unless (i) all Shareholders

have granted permission for the intended transfer in writing, which permission shall then be valid for a period of three
months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by law to transfer his Shares to a former Shareholder.

9.2 A transfer of one or more Shares can only be effected after the Shares have been offered for sale to the co-

Shareholders first The relevant Shareholder (the "Offeror") shall make the offer by means of a written notification to the
Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer and the person or persons to whom he wishes
to transfer the Shares. The Management Board shall give notice of the offer to the co-Shareholders. Co-Shareholders
interested in purchasing one or more of the offered Shares (the "Interested Parties") must notify the Management Board
of their interest. If the Company itself is a co-Shareholder, it shall only be entitled to act as an Interested Party with the
consent of the Offeror.

9.3 The price for which the offered Shares can be purchased by the Interested Parties shall be set by the Offeror and

the Interested Parties in joint consultation or by one or more experts designated by them. If an agreement on the price
or on the expert or experts, as the case may be, is not reached, the price shall be set by one or more independent experts
to be designated, at the request of one or more of the parties concerned, by the chairperson of the Chamber of Commerce
and Factories where the Company is registered in the Trade Register.

9.4 Within one month of the set price having been notified to them, the Interested Parties must give notice to the

Management  Board  of  the  number  of  the  offered  Shares  they  wish  to  purchase.  Once  the  notice  mentioned  in  the
preceding sentence has been given, an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.

9.5 If the Interested Parties together wish to purchase more Shares than have been offered the offered Shares shall

be distributed among them. The Interested Parties shall decide together upon the distribution. If an agreement on the
distribution is not reached, the Management Board shall determine the distribution, as far as possible in proportion to
the total nominal value of the Shares held by each Interested Party at the time of the distribution. The number of offered
Shares allocated to an Interested Party cannot exceed the number of Shares he wishes to purchase.

9.6 The Offeror may withdraw his offer up to one month from the day on which he is informed of the Interested Party

or Parties to whom he can sell all offered Shares and at what price.

9.7 If it becomes apparent that none of the co-Shareholders is an Interested Party or that not all offered Shares will

be purchased against payment in cash by one or more Interested Parties, the Offeror may, within a period of three months,
freely transfer all the offered Shares, but not part thereof, to the person or persons listed in the offer.

10. Pledging of Shares and Usufruct in Shares.
10.1 The provisions of Article 8 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a

usufruct in Shares.

10.2 If a Share is pledged or if a usufruct is created in a Share, the voting rights attributable to such Share may not be

assigned to the pledgee or usufructuary.

11. Depositary Receipts for Shares. The Company shall not cooperate in the issuance of depositary receipts for Shares.

12. Managing Directors.
12.1 The Management Board shall consist of one or more Managing Directors A and one or more Managing Directors

B. Both individuals and legal entities can be Managing Directors. The General Meeting shall determine the number of
Managing Directors A and B.

12.2 Managing Directors A and B are appointed by the General Meeting.
12.3 A Managing Director may be suspended or removed by the General Meeting at anytime.
12.4 The authority to establish remuneration and other conditions of employment for Managing Directors is vested

in the General Meeting.

13. Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties.
13.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company.
13.2 The Management Board may establish rules regarding its decision-making process and working methods. In this

context, the Management Board may also determine the duties which each Managing Director shall be particularly re-

100193

L

U X E M B O U R G

sponsible for. The General Meeting may resolve that such rules and allocation of duties must be put in writing and that
such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.

13.3 Management Board resolutions at all times may be adopted in writing, provided the proposal concerned is sub-

mitted to all Managing Directors then in office and none of them objects to this manner of adopting resolutions.

14. Representation: Conflicts of Interest.
14.1 The Company shall be represented by the Management Board. A Managing Director A and a Managing Director

B acting jointly shall also be authorised to represent the Company.

14.2 The Management Board may appoint officers with general or limited power to represent the Company. Each

officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management Board
shall determine each officer's title. The authority of an officer thus appointed may not extend to any transaction where
the Company has a conflict of interest with the officer concerned or with one or more Managing Directors.

14.3 In the event of a conflict of interest between the Company and a Managing Director, the provisions of Article

14.1 shall continue to apply unimpaired unless the General Meeting has appointed one or more other persons to represent
the Company in the case at hand or in general in the event of such a conflict. A resolution of the Management Board with
respect to a matter involving a conflict of interest with a Managing Director in a private capacity shall be subject to the
approval of the General Meeting, but the absence of such approval shall not affect the authority of the Management Board
or the Managing Directors to represent the Company.

15. Approval of Management Board Resolutions.
15.1 The General Meeting may require Management Board resolutions to be subject to its approval. The Management

Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified.

15.2 The absence of approval by the General Meeting of a resolution referred to in this Article 15 shall not affect the

authority of the Management Board or the Managing Directors to represent the Company.

16. Vacancy or Inability to Act. If a seat on the Management Board is vacant (ontstentenis) or a Managing Director is

unable to perform his duties (belet), the remaining Managing Directors shall be temporarily entrusted with the manage-
ment of the Company, provided that at all times at least one Managing Director A and one Managing Director B are in
office and able to perform their duties. If all seats on the Management Board are vacant or all Managing Directors are
unable to perform their duties, or if no Managing Director A and/or no Managing Director B is in office and able to
perform its duties, the management of the Company shall be temporarily entrusted to the person designated for that
purpose by the General Meeting.

17. Financial Year and Annual Accounts.
17.1 The Company's financial year shall run from the first day of December up to and including the thirtieth day of

November of the following calendar year.

17.2 Annually, not later than five months after the end of the financial year, save where this period is extended by the

General Meeting by not more than six months by reason of special circumstances, the Management Board shall prepare
annual accounts, and shall deposit the same for inspection by the Shareholders at the Company's office.

17.3 Within the same period, the Management Board shall also deposit the annual report for inspection by the Share-

holders, unless Section 2:396, subsection 6, or Section 2:403 of the Dutch Civil Code applies to the Company.

17.4 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.
17.5 The annual accounts shall be signed by the Managing Directors. If the signature of one or more of them is missing,

this shall be stated and reasons for this omission shall be given.

17.6 The Company may, and if the law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such

appointment shall be made by the General Meeting.

17.7 The General Meeting shall adopt the annual accounts.
17.8 At the General Meeting of Shareholders at which it is resolved to adopt the annual accounts, a proposal concerning

release of the Managing Directors from liability for the management pursued, insofar as the exercise of their duties is
reflected in the annual accounts or otherwise disclosed to the General Meeting prior to the adoption of the annual
accounts, shall be brought up separately for discussion.

18. Profits and Distributions.
18.1 The allocation of profits accrued in a financial year shall be determined by the General Meeting.
18.2 Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the law given the

contents of the annual accounts.

18.3 The General Meeting may resolve to make interim distributions and/or to make distributions at the expense of

any reserve of the Company.

18.4 Distributions may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the Distributable Equity.

19. General Meetings of Shareholders.
19.1 The annual General Meeting of Shareholders shall be held within six months after the end of the financial year.

100194

L

U X E M B O U R G

19.2 Other General Meetings of Shareholders shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
19.3 Shareholders representing in the aggregate at least one-tenth of the Company's issued capital may request the

Management Board to convene a General Meeting of Shareholders, stating specifically the business to be discussed. If the
Management Board has not given proper notice of a General Meeting of Shareholders within four weeks following receipt
of such request such that the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be
authorised to convene a meeting themselves.

20. Notice, Agenda and Venue of Meetings.
20.1 Notice of General Meetings of Shareholders shall be given by the Management Board, without prejudice to the

provisions of Article 19.3.

20.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
20.3 The notice convening the meeting shall specify the business to be discussed. Other business not specified in such

notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 20.2.

20.4 Items, for which a written request has been filed to discuss them, by one or more holders of Shares, alone or

jointly representing at least one hundredth of the issued capital, shall be included in the notice or announced in the same
manner, provided that the Company received the request no later than on the thirtieth day before the date of the meeting
and provided that no important interests of the Company dictate otherwise.

20.5 The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the Shareholders shown in the register of Shareholders.
20.6 General Meetings of Shareholders are held in the municipality in which, according to these Articles of Association,

the Company has its official seat or at Schiphol (municipality Haarlemmermeer). General Meetings of Shareholders may
also be held elsewhere, in which case valid resolutions of the General Meeting may only be adopted if all of the Company's
issued capital is represented.

21. Admittance and Rights at Meetings.
21.1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings of Shareholders, to address the meeting and

to exercise his voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorised in writing.

21.2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meeting

may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.

21.3 The Managing Directors shall have the right to give advice in the General Meetings of Shareholders.
21.4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.

22. Chairperson and Secretary of the Meeting.
22.1 The chairperson of a General Meeting of Shareholders shall be appointed by a majority of the votes cast by the

persons with voting rights present at the meeting.

22.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.

23. Minutes: Recording of Shareholders' Resolutions.
23.1 The secretary of a General Meeting of Shareholders shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The

minutes shall be adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by
them.

23.2 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting. If the Management

Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Management Board is provided
with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records shall be deposited at the
Company's office for inspection by the Shareholders. On application, each of them shall be provided with a copy of or
an extract from the records.

24. Adoption of Resolutions in a Meeting.
24.1 Each Share confers the right to cast one vote.
24.2 To the extent that the law or these Articles of Association do not provide otherwise, all resolutions of the General

Meeting shall be adopted by a simple majority of the votes cast, without a quorum being required.

24.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
24.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings of Shareholders, as prescribed by law or these

Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions of the General Meeting may only be adopted in a
meeting, if in such meeting all of the Company's issued capital is represented and such resolution is carried by unanimous
vote.

25. Adoption of Resolutions without holding Meetings.
25.1 Shareholders may adopt resolutions of the General Meeting in writing without holding a meeting, provided they

are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The provisions of Article 21.3 shall apply by
analogy.

100195

L

U X E M B O U R G

25.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon

as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records
to those referred to in Article 23.2.

26. Amendment of the Articles of Association. The General Meeting may resolve to amend these Articles of Associ-

ation. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made to the General Meeting, the notice convening
the General Meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall be deposited and
kept available at the Company's office for inspection by the Shareholders, until the conclusion of the meeting.

27. Dissolution and Liquidation.
27.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting. When a proposal

to dissolve the Company is to be made to the General Meeting, this must be stated in the notice convening the General
Meeting.

27.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting, the Managing Directors shall become

liquidators of the dissolved Company's property, unless the General Meeting resolves to appoint one or more other
persons as liquidator.

27.3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible.
27.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Share-

holders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.

27.5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of Book 2, Title 1, of the Dutch Civil Code.

28. Transitory Provision.
28.1 The Company's financial year which started on the first day of January two thousand and seven shall end on the

thirtieth day of November two thousand and seven.

28.2  This  Article  28,  including  its  heading,  expires  at  the  end  of  the  financial  year  ending  on  the  thirtieth  day  of

November two thousand and seven.

Finally, the person appearing has declared:
Statement of No Objections
With respect to the foregoing amendment of the articles of association, a ministerial statement of no objections was

granted on the twenty ninth day of June two thousand and seven, under number BV 357202, which is evidenced by a
written statement from the Dutch Ministry of Justice attached to this deed.

<i>Close

The person appearing is known to me, civil law notary.
This deed was executed in Amsterdam on the date first above written. Before reading out, a concise summary and an

explanation of the contents of this deed were given to the person appearing. The person appearing then declared that
she had taken note of and agreed to the contents of this deed and did not want the complete deed to be read to her.
Thereupon, after limited reading, this deed was signed by the person appearing and by me, civil law notary,

(w.s) H. Meilink, A.A. Voorneman.

STATUTENWIJZIGING

Op twee juli tweeduizend zeven is voor mij,
mr. Anton Arnaud Voomeman, notaris te Amsterdam, versehenen:
de heer mr. Hugo Meilink, met kantooradres 1083 GV Amsterdam, Arent Janszoon Emststraat 199, geboren te Har-

denberg op drie december negentienhonderd zevenenzeventig,

<i>De comparant heeft het volgende verklaard:

De enig aandeelhouder van O.K.N. Amsterdam B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met

statutaire zetel te Amsterdam en kantoorhoudende te 1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105 7e etage, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 33209694 (de "vennootschap") heeft op achttien
juni tweeduizend zeven besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede
om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een aandeelhoudersbesluit
dat aan deze akte is gehecht.

De Statuten van de vennootschap zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging op vijfentwintig mei

tweeduizend vier verleden voor mr. Renatus Martinus Rieter, destijds notaris te 's-Gravenhage, terzake waarvan een
ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend op dertien mei tweeduizend vier, onder nummer BV 357202.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de Statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd

en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.

100196

L

U X E M B O U R G

STATUTEN

1. Begripsbepalingen.
1.1 In deze Statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
"aandeel": een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.
"aandeelhouder": een houder van een of meer aandelen.
"algemene vergadering" of "algemene vergadering van aandeelhouders": het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd

door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen
met vergaderrechten.

"directeur A": een directeur A van de vennootschap;
"directeur B": een directeur B van de vennootschap;
"directie": het bestuur van de vennootschap.
"schriftelijk": bij brief, telefax of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en

reproduceerbaar is.

"uitkeerbare eigen vermögen": het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal

vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

"vennootschap": de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.
1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze Statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Naam en zetel.
2.1 De naam van de vennootschap is:
O.K.N. Amsterdam B.V.
2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.
3 Doel
De vennootschap heeft ten doel:
(a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het -toezicht houden op ondememingen

en vennootschappen;

(b) het financieren van ondememingen en vennootschappen;
(c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of

andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

(d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondememingen -en vennootschappen waarmee de

vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

(e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap

ten  behoeve  van  ondememingen  en  vennootschappen  waarmee  de  vennootschap  in  een  groep  is  verbonden  en  ten
behoeve van derden;

(f) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het alge-

meen;

(g) het verhandeln van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
(h) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, know how, auteursrechten, databanken

en andere intellectuele eigendomsrechten;

(i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; en al hetgeen met vorenstaande

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

4. Maatschappelijk kapitaal.
4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen euro (EUR 7.000.000).
4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in zevenduizend (7.000) aandelen met -een nominaal bedrag van eenduizend

euro (EUR 1.000) elk.

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

5. Register van aandeelhouders.
5.1 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden

opgenomen.

5.2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:194 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Uitgifte van aandelen.
6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.

6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

100197

L

U X E M B O U R G

6.3 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats

hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

6.4 ledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke

nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikel 6.5.

6.5 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot

uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.

6.6 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
6.7 De directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld

en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goed-
keuring van de algemene vergadering.

7. Eigen aandelen: vermindering van het geplagtste kapitaal.
7.1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mögen volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen,

met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake.

7.2 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of certificaten daarvan mögen de vennootschap en

haar dochtermaatschappijen slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves van de ven-
nootschap.

7.3 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, met

inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

8. Levering van aandelen.
8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe besterade ten overstaan van een in Nederland standplaats

hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel ver-

bonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar
is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald.

9. Blokkerinesregeling (aanbieding aan mede-aandeelhouders).
9.1 Op een overdracht van een of meer aandelen is het hierna in dit artikel 9 bepaalde van toepassing, tenzij (i) alle

aandeelhouders schriftelijk toestemming hebben verleend tot de voorgenomen overdracht, welke toestemming alsdan
voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht
van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

9.2 Een overdracht van een of meer aandelen kan slechts plaatsvinden nadat deze eerst te koop zijn aangeboden aan

de mede-aandeelhouders. De desbetreffende aandeelhouder (de "Aanbieder") doet het aanbod door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de persoon
of personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. De directie brengt het aanbod ter kennis van de mede-
aandeelhouders. Mede-aandeelhouders die geïteresseerd zijn één of meer van de aangeboden aandelen te kopen (de
"Gegadigden") dienen dat op te geven aan de directie. Indien de vennootschap zelf mede-aandeelhouder is, kan zij alleen
met mstemming van de Aanbieder als Gegadigde optreden.

9.3 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de Gegadigden kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door

de Aanbieder en de Gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij
over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onaf-
hankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister.

9.4 Binnen één maand nadat de vastgestelde prijs aan hen bekend wordt, dienen de Gegadigden aan de directie op te

geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te kopen. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een
Gegadigde zieh slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere Gegadigden.

9.5 Indien de Gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen

tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de Gegadigden vastgesteld. Indien de Gega-
digden geen overeenstemming bereiken over de verdeling, wordt deze vastgesteld door de directie, en wel zoveel mogelijk
naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van de aandelen die iedere Gegadigde ten tijde van de verdeling
houdt. Aan een Gegadigde kunnen niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen.

9.6 De Aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken tot één maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke

Gegadigde of Gegadigden hij alle aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.

9.7 Indien komt vast te staan dat geen van de mede-aandeelhouders Gegadigde is of dat niet alle aangeboden aandelen

tegen contante betaling door één of meer Gegadigden worden gekocht, mag de Aanbieder tot drie maanden nadien de
desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe
in het aanbod waren genoemd.

100198

L

U X E M B O U R G

10. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.
10.1 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en

op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.

10.2 Bij de vestiging van een pandrecht of vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder of

vruchtgebruiker worden toegekend.

11. Certificaten van aandelen. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aan-

delen.

12. Directeuren.
12.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren A en één of meer directeuren B. Zowel natuurlijke personen als

rechtspersonen kunnen directeur zijn. De algemene vergadering steh het aantal directeuren A en B vast.

12.2 Directeuren A en B worden benoemd door de algemene vergadering.
12.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
12.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe

aan de algemene vergadering.

13. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.
13.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
13.2 De directie kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader kan de

directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene verga-
dering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling
aan haar goedkeuring onderwerpen.

13.3 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan

alle in functie zünde directeuren is voorgelegd en geen van hen zieh tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

14. Vertegenwoordiging: tegenstriidie belang.
14.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt

mede aan een directeur A en een directeur B gezamenlijk handelend toe.

14.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van

hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur
van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde
functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbe-
treffende functionaris of met één of meer directeuren.

14.3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één -of meer directeuren, blijft het

bepaalde in artikel 14.1 onverkort van kracht tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen heeft aange-
wezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van
de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé
betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

15. Goedkeuring van directiebesluiten.
15.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze bes-

luiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.

15.2 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 15 tast de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

16. Ontstentenis of belet. In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren tijdelijk

met het bestuur van de vennootschap belast, mits ten aanzien van ten minste één directeur A en één directeur B geen
ontstentenis of belet bestaat. In geval van ontstentenis of belet van aile directeuren of in geval van ontstentenis of belet
van aile directeuren A en/of alle directeuren B, is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd,
tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.

17. Boekiaar en iaarrekening.
17.1 Het boekjaar van de vennootschap loopt van één december tot en met dertig november in het daaropvolgende

jaar.

17.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste

zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening
op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

17.3 Binnen deze termijn legt de directie iook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396

lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

17.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.

100199

L

U X E M B O U R G

17.5De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen,

dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

17.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot on-

derzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.

17.7 De algemene vergadering steh de jaarrekening vast.
17.8 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt

afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de directeuren voor het gevoerde bestuur,
voor zover van nun taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling
van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

18. Winst en uitkerineen.
18.1 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering.
18.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
18.3 De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve

van de vennootschap.

18.4 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen

vermögen.

19. Algemene vereaderingen van aandeelhouders.
19.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het

boekjaar.

19.2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht.
19.3 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van

de vennootschap hebben het recht aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te
roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot
oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden ge-
houden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

20 Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.
20.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie, onverminderd het be-

paalde in artikel 19.3.

20.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
20.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn

vermeid, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 20.2 bedoelde termijn.

20.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen

of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in
de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag
voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

20.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals

deze zijn vermeid in het register van aandeelhouders.

20.6 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens

deze Statuten gevestigd is of te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer). Algemene vergaderingen van aandeelhouders
kunnen ook eiders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden
genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

21. Toeeang en vergaderrechten.
21.1 ledere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord

te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zieh ter vergadering doen vertegenwoordigen door
een schriftelijk gevolmachtigde.

21.2 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de

vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering
aanwezig zijn.

21.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.
21.4 0mtrent toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering.

22. Voorzitter en notulist van de vergadering.
22.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen door de ter vergadering aan

wezige stemgerechtigden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

22.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

100200

L

U X E M B O U R G

23. Notulen: aantekening van aandeelhoudersbesluiten.
23.1 Van het verhandele in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist

van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke
daarvan door hen ondertekend.

23.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet

ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen
besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de
vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit
de aantekeningen verstrekt.

24. Besluitvorming in vergadering.
24.1 Elk aandeel geeft recht opéén stem.
24.2 Voor zover de wet of deze Statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering

genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.

24.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
24.4 Indien de door de wet of deze Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene

vergaderingen  van aandeelhouders niet  in  acht  zijn  genomen,  kunnen ter  vergadering  alleen geldige  besluiten van de
algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd
en met algemene stemmen.

25. Besluitvorming buiten vergadering.
25.1 De aandeelhouders kunnen besluiten van de algemene vergadering in plaats van in een vergadering schriftelijk

nemen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 21.3 is van ove-
reenkomstige toepassing.

25.2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk

schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt
deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 23.2.

26. Statutenwiiziging. De algemene vergadering is bevoegd deze Statuten te wijzigen. Wanneer aan de algemene ver-

gadering  een  voorstel  tot  statutenwijziging  zal  worden  gedaan,  moet  zulks  steeds  bij  de  oproeping  tot  de  algemene
vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woor-
delijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop
van de vergadering.

27. Ontbinding en vereffening.
27.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet dat
bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

27.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren

vereffenaars van het vermögen van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering besluit £en of meer
andere personen tot vereffenaar te benoemen.

27.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zo veel mogelijk van kracht.
27.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen

aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.

27.5 0p de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk

Wetboek.

28. Overeangsbepaling.
28.1 Het boekjaar van de vennootschap dat is begonnen op één januari tweeduizend zeven, zal eindigen op dertig

november tweeduizend zeven.

28.2 Dit artikel 28, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het boekjaar eindigend op dertig november tweeduizend

zeven.

Ten slotte heeft de comparant verklaard:
Verklaring van geen bezwaar
Terzake van bovenstaande statutenwijziging is een ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op negenentwintig

juni tweeduizend zeven, onder nummer BV 357202, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van
Justitie die aan deze akte is gehecht.

<i>Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

100201

L

U X E M B O U R G

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is

overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daama
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te steoimen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na bepencte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris,
ondirtekend.

(w.g.) H. Meilink, A.A. Voorneman.

VOOR AFSCHRIFT
Signature

The undersigned,
Anton Arnaud Voomeman,
civil law notary in Amsterdam,
certifies that the attached document is a fair English translation of the deed of amendment and the articles of association

of the private company with limited liability:

O.K.N. Amsterdam B.V.
with statutory seat in Amsterdam
In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity.

Inevitably, differences may occur in translation, and if so the Dutch text will by law govern.

Amsterdam, the 3 

rd

 day of July 2007.

Signature.

Référence de publication: 2012107190/1324.
(120145975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.

Aviva Investors Structured Funds, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 148.660.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l´Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société qui a eu lieu le Mercredi 25

<i>Avril 2012

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale de la Société que:

- M. Timothy LUCAS, ayant son adresse professionnelle au N 

o

 1 Poultry EC2R 8EJ Londres, Royaume-Uni, a été

nommé en tant qu’administrateur de la Société en remplacement de M. Stéphane ROUGIER, ayant son adresse profes-
sionnelle au No 1 Poultry EC2R 8EJ Londres, Royaume-Uni, avec effet au 25 Avril 2012 jusqu'à la prochaine assemblée
générale qui se tiendra en 2013.

Au 25 Avril 2012, le Conseil d’Administration se compose comme suit jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se

tiendra en 2013:

- M. William GILSON, Président et Administrateur, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon,

L-1249 Luxembourg;

- M. Mark PHILLIPS, Administrateur, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg;
- M. Timothy LUCAS, Administrateur
L´Assemblée Générale a élu PriceWaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1014

Luxembourg, en tant que Réviseur d´Entreprises jusqu´à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui se tiendra en 2013.

A Luxembourg, le 26 Juillet 2012.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012093057/26.
(120130617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Euro Pro Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 93.723.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

100202

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092474/10.
(120128906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Fascolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 168.121.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue de façon exceptionnelle en date du 19 juillet 2012

<i>1 

<i>ère

<i> Résolution:

L'Assemblée accepte la démission des Administrateurs, Messieurs Emmanuel Cukrowicz, Marcel Genadry, Walter

Symons et Dirk Vercruyssen, avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de ne pas pourvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires.

<i>2 

<i>ème

<i> Résolution:

L'Assemblée constate que la société n'a plus qu'un actionnaire unique, et conformément à l'article 6 des statuts de la

société, décide de nommer Madame Johanna Schadeck, née le 22 février 1979 à Messancy, avec adresse professionnelle
au rue Astrid, 15, L-1143 Luxembourg, comme Administrateur Unique de la société jusqu'à l'Assemblée Générale ordi-
naire constatant l'existence de plus d'un actionnaire.

La société sera engagée par sa seule signature, conformément à l'article 12 des statuts de la société.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Administrateur Unique

Référence de publication: 2012092500/22.
(120128909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

BOC Frankfurt GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 112.643.

Veuillez noter que l’adresse professionnelle des gérants suivant a changé:
Monsieur Richard Crombie
25 Bank Street
Canary Wharf
London, E14 5JP
Monsieur Karl McCathern
25 Bank Street
Canary Wharf
London, E14 5JP
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

<i>Pour la Société
TMF Luxembourg S.A.
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2012093149/22.
(120130633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

100203

L

U X E M B O U R G

Gemstone 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.275.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 06 juillet 2012

Est nommé gérant pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Guy HORNICK, gérant démissionnaire:
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 juillet 2010.

Référence de publication: 2012092543/14.
(120129012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Gemstone 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 462.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.419.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 06 juillet 2012

Est nommé gérant pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Guy HORNICK, gérant démissionnaire:
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092545/14.
(120129087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

GT Satellite Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 104.868.

EXTRAIT

L'Actionnaire unique a pris en date du 25 juin 2012 la résolution suivante:
Le mandat du réviseur de la Société PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à.r.l. est reconduit à compter de ce jour et

viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2012.

Référence de publication: 2012092566/13.
(120128958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Vintners Propco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 636.925,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 129.506.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 24 Juillet 2012

L'associé unique de la Société a décidé en date du 24 Juillet 2012 comme suit:
- D'accepter la démission de Monsieur Jeffrey Goldberger de son mandat de gérant A et ce avec effet au 24 Juillet

2012;

- D'accepter la démission de Monsieur Andrew B Cohen de son mandat de gérant A et ce avec effet au 24 Juillet 2012;
- D'accepter la démission de Monsieur Marcel Stephany de son mandat de gérant B et ce avec effet au 24 Juillet 2012;
- D'accepter la démission de Monsieur Luc Sunnen de son mandat de gérant B et ce avec effet au 24 Juillet 2012;
- D'accepter la démission d'ALCANJANE S.à r.l. de son mandat de gérant A et ce avec effet au 24 Juillet 2012;

100204

L

U X E M B O U R G

- De nommer Monsieur Jan Willem Overheul, né le 4 Janvier 1982, à Neerijnen, Pays-Bas ayant t'adresse professionnelle

suivante: 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, en tant que gérant A de la Société avec effet au 24 Juillet 2012, et ce
pour une durée indéterminée;

- De nommer Luxembourg Corporation Company SA, une société anonyme ayant l'adresse professionnelle suivante:

20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B37974 en tant que gérant A de la Société avec effet au 24 Juillet 2012, et ce pour une durée indéterminée;

- De nommer Monsieur Kenneth Gaw, né le 22 Septembre 1970, à Bangkok, Thaïlande ayant l'adresse professionnelle

suivante: 3/F, Block F, Repuise Bay Towers, 119A Repuise Bay Road, Hong Kong, en tant que gérant B de la Société avec
effet au 24 Juillet 2012, et ce pour une durée indéterminée.

- De nommer Monsieur Jeffrey Schwartz, né le 22 Janvier 1959, à Redwood City, Etats Unis d'Amérique ayant l'adresse

professionnelle suivante: 35a Maximilianstrasse, 80539 Munich, Allemagne en tant que gérant B de la Société avec effet
au 24 Juillet 2012, et ce pour une durée indéterminée.

- De nommer Monsieur Jean-Seok Oh, né le 20 Septembre 1975, à Séoui, République de Corée ayant l'adresse pro-

fessionnelle suivante: 101-904 Ssangyong APT, Hanganro 3-ga, Yongan-gu, Seoul, République de Corée en tant que gérant
B de la Société avec effet au 24 Juillet 2012, et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

<i>Gérant A;

- Monsieur Jorrit Crompvoets
- Monsieur Jan Willem Overheul
- Luxembourg Corporation Company S.A

<i>Gérant B:

- Kenneth Gaw
- Jeffrey Schwartz
- Jean-Seok Oh

Luxembourg, le 26 Juillet 2012.

Jorrit Crompvoets.

Référence de publication: 2012093842/41.
(120130719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Halit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 170.114.

EXTRAIT

Il résulte de résolutions de l'associé unique en date du 2 juillet 2012 que:
- Monsieur Dariusz OLCZYK, administrateur de sociétés, né à Czestochowa (Pologne) le 4 mars 1967, demeurant à

Rekreacyjna 2, 55-040 SLEZA, Pologne, a été nommé à la fonction de gérant de catégorie A.

- Ont été nommés aux fonctions de gérants de catégorie B pour une durée indéterminée:
* Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fes (Maroc) le 18 décembre 1970, demeurant profes-

sionnellement à L-1118 Luxembourg, 23 rue Aldringen.

* Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, née à Fes (Maroc) le 22 octobre 1966, demeurant pro-

fessionnellement à L-1118 Luxembourg, 23 rue Aldringen.

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012092578/18.
(120128992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Itavy Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 168.323.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 24 juillet 2012 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg)

S.A. et Col Hunt Holdco B Limited, les 1,250,000 de la Société sont désormais réparties comme suit:

- Col Hunt Holdco B Limited détient 1,250,000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100205

L

U X E M B O U R G

<i>Pour Itavy Holdings S.à r.l.
Représentée par Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant Unique

Référence de publication: 2012092603/14.
(120129016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Immoffice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 156.002.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2012092611/12.
(120128982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Lisac s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6136 Junglinster, 20C, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 120.676.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 25 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092693/10.
(120129621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Manacor (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 9.098.

<i>Extrait rectificatif concernant la publication du 28/05/2003

Un extrait référencé sous le numéro L030025650 a été déposé le 28 mai 2003 en vue de la publication au Mémorial

de l'élection de l'administrateur Marcus Jacobus DIJKERMAN.

Cet extrait est rectifié comme suit:
Marcus Jacobus DIJKERMAN, administrateur, a son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

<i>Pour la Société
Robert van 't Hoeft
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012092713/18.
(120129111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Luxe Editions, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5720 Aspelt, 1, Um Klaeppchen.

R.C.S. Luxembourg B 169.431.

<i>Extrait de la décision de l'associé unique prise en date du 11 juillet 2012

<i>Résolution unique

L'associé unique accepte la démission de Mr Pierre Thomas en tant que gérant.

100206

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012092703/11.
(120128994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

LX Alpha Phi S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 155.583.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2012092707/12.
(120128790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Lyreco Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Jean Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 38.924.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 25 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092708/10.
(120129333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Industrielle Pensions Beteiligungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.708.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société que:
- Monsieur Philip Godley, né le 21/03/1974 à Sheffield, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 51 Avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

- Monsieur Peter Dickinson, né le 01/03/1966 à Nuneaton, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 51

Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

- Madame Geneviève Blauen-Arendt, née le 28/09/1962 à Arlon, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 231

Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg

Ont été élus administrateurs de la société à partir du 25 juillet 2012 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en

l'année 2018

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012093450/21.
(120130647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Mobilized Media S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 155.384.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 21 juin 2012.

Référence de publication: 2012092724/10.
(120128970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

100207

L

U X E M B O U R G

Majerus-Parmentier Constructions Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 36, Wämperweeg.

R.C.S. Luxembourg B 150.200.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 3 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092742/10.
(120129038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Medinvest International (Invecom Management) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 76.357.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 16 mars 2012.

Référence de publication: 2012092755/10.
(120128972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Meyket Locations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9766 Munshausen, 4B, Maarnicherwee.

R.C.S. Luxembourg B 145.146.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092762/10.
(120128971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

CF Industries International Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Terra Industries International Holdings Luxembourg S.à r.l.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 142.667.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 13 juin 2012, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 juillet 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012093008/14.
(120128934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Molson Coors Lux 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 548.620.713,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 168.684.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092776/11.
(120129338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

100208

L

U X E M B O U R G

Alain Afflelou International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 58.334.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 30 décembre 2011 au 9-11 rue du

<i>Prince à Genève (Suisse):

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
* La société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR S.A.S., ayant son siège social au 45, avenue Kleber 75016 Paris (France);
* Monsieur Lionel Afflelou, directeur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 9-11 rue du Prince CH-1204

Genève (Suisse);

* Monsieur Didier Pascual, directeur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 45, avenue Kleber 75016 Paris

(France).

Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 juillet 2012.
- L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Lionel Afflelou, directeur de

sociétés, ayant son adresse professionnelle au 9-11 rue du Prince CH-1204 Genève (Suisse);

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos

au 31 juillet 2012.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de C.G. Consulting, société anonyme,

ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos

au 31 juillet 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012093079/25.
(120130685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Novimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3616 Kayl, 18, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 86.963.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2012092803/11.
(120128719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Oddo Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 158.637.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092808/10.
(120128721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

David Brown Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 140.251.

In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of June.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
David Brown Systems (Holdings) S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its

registered office (siège social) at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under the number B 140252 (the "Sole Member"),

100209

L

U X E M B O U R G

here represented by Me Carmine REHO, residing at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, by virtue of a

power of attorney delivered to him.

Said power will remain attached to the present deed, after being signed “ne varietur” by the attorney and the under-

signed notary.

The appearing, acting in his capacity as duly appointed attorney of the Sole Member, in its capacity as Sole Member of

David  Brown  Systems  S.à  r.l.  (hereafter  the  "Company")  a  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité
limitée), having its registered office (siège social) at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 140251, incorporated originally under the name of Bond Subco III
S.à r.l., by a deed drawn up by Me Paul FRIEDERS, then notary residing in Luxembourg, on the 4 

th

 of July 2008, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1939 of the 7 

th

 of August 2008. The by-laws were

amended several times and for the last time by a deed of the officiating notary, on the 28 

th

 of July 2009, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1747 on the 10 

th

 of September 2009.

The Sole Member took, in the extraordinary general meeting and, in the best interest of the Company, the following

resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member of the Company resolved to increase the corporate capital of the Company by way of contribution

in kind of One Pound Sterling (GBP 1) so as to bring it from its present amount of Nine Hundred and Forty Nine Thousand
Four Hundred and Seventy Two Pounds Sterling (GBP 949.472) to an amount of Nine Hundred and Forty Nine Thousand
Four Hundred and Seventy Three Pounds Sterling Pounds Sterling (GBP 949.473) represented by Nine Hundred and
Forty Nine Thousand Four Hundred and Seventy Three (949.473) corporate units, each corporate unit with a nominal
value of one Pound Sterling (GBP 1) and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the
Company together with a share premium amounting to Twenty Million One Hundred and Four Thousand Thirty Six
Pounds Sterling (GBP 20,104,036).

<i>Second resolution

<i>Subscription and payment

Further appeared said Me Carmine REHO, prenamed, acting in his said capacity as duly appointed attorney of the Sole

Member declared to subscribe respectively in the name and on behalf of the Sole Member, prenamed, One (1) corporate
unit having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) with such rights and obligations as set out in the articles of
association of the Company and in consideration of a contribution in kind consisting of Twenty Million One Hundred and
Four Thousand Thirty Seven (20,104,037) interest free preferred equity certificates having a nominal value of one Pound
Sterling (GBP 1) (“IFPECs”) for an aggregate amount of Twenty Million One Hundred and Four Thousand Thirty Seven
Pounds Sterling (GBP 20,104,037) representing a share premium in relation to this subscription amounting to Twenty
Million One Hundred and Four Thousand Thirty Six Pounds Sterling (GBP 20,104,036).

The valuation of the contribution is made under the responsibility of the board of managers of the Company and it is

recorded in the minutes of the board meeting dated 15 June 2012.

A copy of the minutes of the said board meeting is provided, as evidence, to the notary for his comfort, and will remain

attached hereto to be submitted together with the present deed to the registrations authorities.

Thereupon the general meeting resolved to accept the said subscription and payment and to issue and allocate One

(1) corporate unit to the Sole Member.

<i>Third resolution

The Sole Member of the Company resolved to amend article 5, paragraph 1 of the articles association of the Company

so as to give it the following wording:

“ Art. 5. Corporate Capital. The subscribed share capital is set at Nine Hundred and Forty Nine Thousand Four

Hundred and Seventy Three Pounds Sterling (GBP 949.473) represented by Nine Hundred and Forty Nine Thousand
Four Hundred and Seventy Three (949.473) Corporate Units, each with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1)
with such rights and obligations as set out in the present articles of association."

<i>Fourth resolution

The Sole Member of the Company resolved to grant authorization to any one manager of the Company or to any

lawyer of the law firm WILDGEN, Luxembourg, to carry out any action necessary or incidental in relation to the above
resolutions.

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

deed is estimated at EUR 6,800.-.

<i>Evaluation

The amount of the capital increase with share premium is valued at EUR 24,803,000,-.

100210

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person and
in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

WHEREOF the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the officiating notary, by name, surname, civil

status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le quinze juin.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
David Brown Systems (Holdings) S.à.r.l, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 37, rue d'Anvers,

L-1130 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 140252 (l'«Associé
Unique»),

ici  représentée  par  Me  Carmine  REHO,  demeurant  professionnellement  au  69,  Boulevard  de  la  Pétrusse,  L-2320

Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et
le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Le Comparant agissant en sa qualité de mandataire de l'Associé Unique dûment nommé, en sa qualité d'Associé Unique

de David Brown Systems S.à r.l, (la «Société») société à responsabilité limitée, ayant son siège social, ayant son siège social
au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 140251, constituée originairement sous la dénomination de Bond Subco III S.à r.l., suivant acte reçu par
Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1939 du 7 août 2008. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1747 du 10 septembre 2009.

L'associée unique, a pris en assemblée générale extraordinaire, et dans le meilleur intérêt de la Société, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique de la Société a décidé d'augmenter le capital social de la Société par apport en nature d'une Livre

Sterling (GBP 1) pour le porter de son montant actuel de neuf cent quarante-neuf mille quatre cent soixante- douze Livres
Sterling (GBP 949.472) au montant de neuf cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-treize Livres Sterling (GBP
949.473) représenté par neuf cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-treize (949.473) parts sociales ayant une
valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) et avec les mêmes droits et obligations tels que prévus dans les statuts de
la Société, ensemble avec une prime d'émission d'un montant de vingt millions cent quatre mille trente- six Livres Sterling
(GBP 20.104,036).

<i>Deuxième résolution

<i>Souscription et paiement

Ensuite a comparu Monsieur Carmine REHO, prénommé, en sa dite qualité de mandataire de l'Associé Unique, a

déclaré souscrire au nom et pour le compte de l'Associé Unique:

Une (1) part sociale ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) ayant les mêmes droits et obligations tels

qu'énoncés dans les statuts de la Société et en considération d'un apport en nature consistant en vingt millions cent quatre
mille trente-sept (20.104.037) interest free preferred equity certificates ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling
(GBP 1) («IFPECs»), pour un montant de vingt millions cent quatre mille trente-sept Livres Sterling (20.104.037), repré-
sentant une prime d'émission en relation à cette souscription d'un montant de vingt millions cent quatre mille trente-six
Livres Sterling (GBP 20.104.036).

L'évaluation de l'apport est faite sous la responsabilité du conseil de gérance de la Société et est enregistrée dans le

procès-verbal de la réunion du conseil du 15 Juin 2012.

Une copie du procès-verbal dudit conseil de gérance est remise au notaire instrumentant pour son confort, et restera

attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités en charge de l'enregistrement.

Sur ce, les associés décident d'approuver la souscription et le paiement pré-mentionnés et d'émettre et allouer Une

(1) part sociale à l'Associé Unique.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5, paragraphe 1 des statuts de la Société qui sera dorénavant libellé comme

suit:

« Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à neuf cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-treize

Livres Sterling (GBP 949.473) représenté par neuf cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-treize (949.473) parts

100211

L

U X E M B O U R G

sociales, ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP1) chacune avec les mêmes droits et obligations tels qu'énon-
cés dans les présents statuts de la Société».

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'autoriser tout gérant de la Société ou tout avocat de l'étude WILDGEN, Luxembourg, de

prendre les mesures nécessaires ou incidentes en exécution des résolutions prises sur base des présentes résolutions

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à 6.800,- EUR.

<i>Evaluation

Le montant de l'augmentation de capital avec la prime d'émission est évalué à 24.803.000,- EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la demande du comparant que le présent acte est libellé

en anglais suivi de la traduction française et qu'à la demande du comparant et en cas de divergence entre la version anglaise
et française du texte, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture à la personne comparante, connue du notaire instrumentant, par nom, prénom, état et demeure, ladite

personne a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Carmine REHO, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 juin 2012. Relation GRE/2012/2167. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012093261/141.
(120130071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Paloma International II, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 164.010.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092826/11.
(120129385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Plansee Group Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R.C.S. Luxembourg B 110.469.

<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société en date du 14 juin 2012

Les actionnaires de la Société ont décidé de renouveler le mandat de Grant Thornton Lux Audit S.A. en tant que

réviseur d'entreprises de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Plansee Group Service S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012092833/13.
(120128944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Sashey Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 168.468.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 25 Juillet 2012 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg)

S.A. et First State Infrastructure S.à r.l., les 1,250,000 parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

- First State Infrastructure S.à r.l. détient 1,250,000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0.01

100212

L

U X E M B O U R G

En date du 24 juillet 2012, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Démission de Manacor (Luxembourg) S.A. de sa fonction de gérant unique avec effet au 24 juillet 2012.
2. Nomination à la fonction de gérant de catégorie A, avec effet au 24 Juillet 2012 et pour une durée indéterminée de

Inderdip Singh Syan, né le 8 Octobre 1976 à Londres, Royaume-Uni, ayant pour adresse 34 Craven Avenue, Ealing, W5
2SX Royaume-Uni;

3. Nomination à la fonction de gérant de catégorie B, avec effet au 24 Juillet 2012 et pour une durée indéterminée de

Robert van 't Hoeft, né le 13 Janvier 1958 à Schiedam, Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg;

4. Nomination à la fonction de gérant de catégorie B, avec effet au 24 Juillet 2012 et pour une durée indéterminée de

Gwenaelle B.A.D. Cousin, né le 3 Avril 1973 à Rennes, France, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg.

A dater du 24 Juillet 2012, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

<i>Gérant de catégorie A:

Inderdip Singh Syan

<i>Gérant de catégorie B:

Gwenaelle B.A.D. Cousin
Robert van 't Hoeft
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Robert van 't Hoeft
<i>Représentée par Gérant B

Référence de publication: 2012093719/30.
(120130665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

PAS Luxembourg, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 31.776.803,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 125.564.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092845/11.
(120129317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Promotions Tavares &amp; Fils, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3616 Kayl, 18, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 111.104.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2012092866/11.
(120128764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Queensgate Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 167.580.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 3 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092874/10.
(120129040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

100213

L

U X E M B O U R G

HBP Muelheim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 114.748.

Veuillez noter que l’adresse professionnelle des gérants suivant a changé:
Monsieur Richard Crombie
25 Bank Street
Canary Wharf
London, E14 5JP
Monsieur Karl McCathern
25 Bank Street
Canary Wharf
London, E14 5JP
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

<i>Pour la Société
TMF Luxembourg S.A.
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2012093440/22.
(120130634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

R&amp;H Fund Services (Luxembourg) Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 150.293.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 29 juin 2012

Le siège social de la société a été transféré du 22, Rue Goethe à L-1637 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163

Luxembourg.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012092883/13.
(120129009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

S Asia III Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 164.641.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2012092926/12.
(120128755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Itaú SIF Fund of Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 162.832.

- L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue extraordinairement le 13 juillet 2012, a pris note

de la fin des mandats de Mr. Roberto Nishikawa et de Mr. Don George Linford, avec effet au jour de l'assemblée.

- L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de nommer en tant qu'administrateurs:

100214

L

U X E M B O U R G

Mr. Shee Wah Chang
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira,
707, torre Eudoro Villela 11, 04344-902 Sao Paulo /SP
Brézil
Mr. Marcelo de Lima Fatio,
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira,
707, torre Eudoro Villela 11, 04344-902 Sao Paulo /SP
Brézil
pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2013.
- L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de renouveler le mandat de Mr. Justin Egan, Carne Global Financial Services

(Luxembourg) S.à r.l. 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2013.

- L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, 400,

route d'Esch L-1471 Luxembourg, en qualité de Réviseur, pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2013.

<i>Pour ITAÚ SIF FUND OF FUNDS
Société d'Investissement à Capital Variable Fond d'investissement spécialisé
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société anonyme

Référence de publication: 2012093485/29.
(120130301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Ets. Hoffmann - Neu Combustibles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 30, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 42.186.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 juillet 2012 tenue au siège social de la société

Il résulte de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire que:
- Le mandat de Monsieur Hoffmann Guy - domicilié 30A route de Wasserbillig L-6686 Mertert - administrateur est

prolongé pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

- Le mandat de Madame Putz Viviane - domiciliée 25 rue des marais L-6634 Wasserbillig - administrateur est prolongé

pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018

- Le mandat de Monsieur Hoffmann Jean - domicilié 25 rue des marais L-6634 Wasserbillig - administrateur est prolongé

pour une durée de 6 ans, jusqu'à rassemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

- Le mandat de Madame Theato Marlies - domiciliée 25 rue des marais L-6634 Wasserbillig - administrateur est prolongé

pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

- Le mandat de Monsieur Hoffmann Guy - domicilié 30A route de Wasserbillig L-6686 Mertert - administrateur délégué

à la gestion journalière est prolongé pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

- La Fiduciaire Générale de Luxembourg S.à r.l., avec siège social à 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg est

nommée comme commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Référence de publication: 2012095086/26.
(120130785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.

Siemens Enterprise Communications S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 145.611.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

100215

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092942/10.
(120128741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

SilverStreet Management S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 153.488.

<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaire de la Société, tenue le 19 juillet 2012

L'actionnaire accepte la nomination de Simon Morgan en tant que gérant de la Société, né le 17 mars 1965 à Harare

au Zimbabwe et domicilié au Robinswood, 6 Fairmile Park Copse, Cobham, Surrey, KT112PQ, le Royaume-Uni.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092943/12.
(120129130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Square Holdings (CDE) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 116.492.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2012092950/11.
(120129383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Infrastrukturelle Beteiligungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.886.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société que:
- Monsieur Philip Godley, né le 21/03/1974 à Sheffield, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 51 Avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

- Monsieur Peter Dickinson, né le 01/03/1966 à Nuneaton, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 51

Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

- Madame Geneviève Blauen-Arendt, née le 28/09/1962 à Arlon, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 231

Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg

Ont été élus administrateurs de la société à partir du 25 juillet 2012 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en

l'année 2018

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012093451/21.
(120130649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Square Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 115.481.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100216

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2012092951/11.
(120129384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Siliwa S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 154.267.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092978/10.
(120129081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

SJ (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.238.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 3 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092980/10.
(120129039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

SL Investment General Partners Fund SCA, SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 163.833.

<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire en date du 20 juillet 2012

En date du 20 juillet 2012, le Conseil d'Administration a décidé:
- de nommer, avec effet au 23 septembre 2011, Deloitte Audit SARL, 560, rue de Neudorf, L - 2220 Luxembourg en

qualité de Réviseur d'Entreprise jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SL Investment General Partners Fund SCA Sicav SIF
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012092983/16.
(120129004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Blue Water Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 166.221.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 13 juin 2012, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 juillet 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012093006/13.
(120128945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

100217

L

U X E M B O U R G

SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 11.809.

STATUTS COORDONNES déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092986/10.
(120128954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 39.615.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Référence de publication: 2012092987/10.
(120128977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

FedEx Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 152.468.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 13 juin 2012, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 juillet 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012093009/13.
(120128942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Achte PMB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.354.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 27 juillet 2011

L'assemblée générale des associés du 27 juillet 2011 avait noté la fin du mandat du réviseur d'entreprises agréé, à savoir

PricewaterhouseCoopers AG, avec effet au 1 

er

 octobre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Signature
<i>Gérance

Référence de publication: 2012093039/15.
(120129796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Fondations Capital I S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 129.317.

Statuts coordonnés, suite à une constatation d'augmentation de capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire

de résidence à Esch/Alzette, en date du 13 juin 2012, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

100218

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 juillet 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012093010/14.
(120128933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

High Gate Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 166.217.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 13 juin 2012, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 juillet 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012093011/13.
(120128947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Amelia Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 54.081.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25 juillet 2012

<i>Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:
1. L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg au 241, Route

de Longwy L-1941 Luxembourg avec effet immédiat.

2. L'assemblée générale accepte les démissions suivantes:
- Monsieur Christophe BLONDEAU, administrateur
- Monsieur Romain THILLENS, administrateur
- Madame Cornelia METTLEN, administrateur
- La société H.R.T. Révision SA, commissaire aux comptes
3. L'Assemblée décide de nommer en remplacement jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2018:
- Monsieur Pascal HENNUY demeurant professionnellement au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg au poste

d'administrateur et administrateur délégué

- Monsieur François DIFFERDANGE demeurant professionnellement au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg

au poste d'administrateur

- Monsieur Tom DONOVAN demeurant professionnellement Glenvara Park 79 Knocklyon Dublin 16 Irlande au poste

d'administrateur

- La société JAWER CONSULTING S.A. immatriculée au RCS Luxembourg B 54 164, ayant son siège social au 241,

Route de Longwy L-1941 Luxembourg au poste de Commissaire aux Comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012093087/27.
(120130736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Halesia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 120.806.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 14 juin 2012, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100219

L

U X E M B O U R G

Esch/Alzette, le 13 juillet 2012.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012093012/13.
(120128948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Participation, Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 142.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2012093046/10.
(120129812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

ArcelorMittal Sourcing, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 59.577.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012093048/9.
(120130158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Getin International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.142.825,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 122.395.

In the year two thousand and twelve, on the thirteenth of July.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

APPEARED:

"GETIN INTERNATIONAL S.A.", a company incorporated under Polish law, having its registered address at ul. Pows-

tancôw Sl. 2-4, 53-333 Wroclaw, Poland,

here represented by Mr. Raymond THILL, private employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 22 

nd

 June, 2012

Which power of attorney, after being signed by the parties and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party has requested the notary to enact the following:
- That the 'société à responsabilité limitée' GETIN INTERNATIONAL S. à r. l, a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on November 20 

th

 , 2006,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 115, dated February 5 

th

 , 2007 (the Company).

The articles of incorporation of the Company have been lastly amended by a deed of Maître Martine SCHAEFFER,

notary residing in Luxembourg, on October 6 

th

 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

number 2543, dated November 23 

th

 , 2010.

That the share capital of the Company amounts to thirty one million forty-two thousand eight hundred and twenty-

five euro (EUR 31,042,825.-), represented by one million two hundred forty-one thousand seven hundred and thirteen
(1,241,713) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

- That the appearing party represents 100% of the share capital.
- That the appearing party fixed the agenda as follows:

<i>Agenda

1. Increase of the Company's subscribed share capital by an amount of EUR 100,000.- (one hundred thousand euro),

in order to increase it from its current amount of EUR 31,042,825.- (thirty-one million forty-two thousand and eight

100220

L

U X E M B O U R G

hundred and twenty-five euro) up to EUR 31,142,825.- (thirty-one million one hundred and forty-two thousand eight
hundred and twenty-five euro) through the issue of 4,000 (four thousand) new shares, with a par value of EUR 25.-
(twenty-five euro) each;

2. Subscription and payment;
3. Amendment of Article 6 of the Articles of Association further to the above resolutions;
4. Miscellaneous.
With respect to the foregoing, the Sole Partner took the following resolutions:

<i>First resolution

It is decided to increase the Company's subscribed share capital by an amount of one hundred thousand euro (EUR

100,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one million forty-two thousand eight hundred and twenty-
five euro (EUR 31,042,825.-) to thirty-one million one hundred and forty-two thousand eight hundred and twenty-five
euro (EUR 31,142,825.-) by the issue of four thousand (4,000) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each.

<i>Second resolution

<i>Intervention - Subscription - Payment

GETIN INTERNATIONAL S.A., here represented by Mr. Raymond THILL, declares to subscribe to four thousand

(4,000) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and fully paid up in cash so that the total amount
of thirty-one million one hundred and forty-two thousand and eight hundred twenty-five euro (EUR 31,142,825.-) is at
the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 6 of the Articles of Association to read

as follows:

Art. 6. The Company's capital is set at thirty-one million one hundred and forty-two thousand eight hundred and

twenty-five euro (EUR 31,142,825.-), represented by one million two hundred and forty-five thousand seven hundred
and thirteen (1,245,713) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the mandatory of the person appearing, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le treize juillet.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

GETIN INTERNATIONAL S.A., société de droit polonais, avec son siège social à ul. Powstahców Slaskich 2-4, 53-333

Wroclaw, Pologne,

Ici représentée par Monsieur Raymond THILL, employé privé, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée le 22 Juin 2012.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée GETIN INTERNATIONAL S. à r. l., société à responsabilité limitée, ayant son

siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVIN-
GER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 115 du 5 février 2007 (la Société).

- Les statuts de la Société ont été amendés pour la dernière fois par un acte notarié reçu par Maître Martine SCHAEF-

FER,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  daté  du  6  octobre  2010,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations numéro 2543 du 23 novembre 2010.

100221

L

U X E M B O U R G

- Que le capital social de la Société s'élève à trente et un millions quarante-deux mille huit cent vingt-cinq euros (EUR

31.042.825,-), représenté par un million deux cent quarante et un mille sept cent treize (1.241.713) parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuelle de la Société.
- Que le comparant a fixé l'ordre du jour comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence d'un montant de EUR 100.000,- (cent mille euros) pour

le porter de son montant actuel de EUR 31.042.825,- (trente et un millions quarante-deux mille huit cent vingt-cinq euros)
à EUR 31.142.825,- (trente et un millions cent-quarante-deux mille huit cent vingt-cinq euros) par l'émission de 4.000
(quatre mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune.

2. Souscription et libération.
3. Modification afférente de l'article 6 des statuts suite aux résolutions qui précèdent.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000,-) pour le porter de son

montant actuel de trente et un millions quarante-deux mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 31.042.825,-) à trente et un
millions cent-quarante-deux mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 31.142.825,-) par l'émission de quatre mille (4.000)
parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

<i>Intervention - Souscription - Libération

GETIN INTERNATIONAL S.A., représentée par Monsieur Raymond THILL a déclaré souscrire quatre mille (4.000)

parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et les libérer intégralement en numéraire,
de sorte que le montant de cent mille euros (EUR 100.000,-) est à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 6 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un millions cent quarante-deux mille huit cent vingt-cinq euros (EUR

31.142.825,-) divisé en un million deux cent quarante-cinq mille sept cent treize (1.245.713) parts sociales de vingt- cinq
euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la comparante le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juillet 2012. LAC/2012/34029. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Référence de publication: 2012093381/130.
(120129785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

100222

L

U X E M B O U R G

Ilyx S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 95.985.

DISSOLUTION

In the year two thousand twelve, on the thirteenth July.
Before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared the following:

Björn Isaksson Förvaltning AB, registration number 556639-3517, with registered address at Primusgatan 65, SE-112

67 Stockholm hereby represented by Mr. Laurent BARNICH, employee, professionally residing in Luxembourg (Grand-
Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy delivered to him, which, after having been signed ne varietur by the appearing
party and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that:
I. ILYX S.A., a limited company ("société anonyme") incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of

Luxembourg, having its registered office at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg') under the number B 95.985, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Alphonse Lentz, then notary residing in Remich, on the 19 

th

 September 2003,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1100 of the 22 

nd

 October 2003,

II. the capital of the Company is fixed at thirty two thousand euro (32,000.-EUR) represented by one thousand (1,000)

shares without nominal value all shares fully paid up;

III. the appearing party is the sole shareholder of the Company;
IV. the appearing party has decided to dissolve the Company with immediate effect as the business activity of the

Company has ceased;

V. the appearing party, being the sole owner of the shares and liquidator of the Company, declares:
- that all assets have been realised;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid;
- that it irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company and other potential

liabilities presently unknown to the Company and therefore not paid to date.

VI. as a result of the above, the liquidation of the Company is to be considered closed;
VII. full discharge is granted to the directors and to the statutory auditor of the Company for the exercise of their

mandate;

VIII. the books and documents of the Company shall be kept during a period of five years at L-1720 Luxembourg, 6,

rue Heine (Grand-Duchy of Luxembourg) or any other address that will be chosen by the shareholder.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this deed are estimated at approximately nine hundred fifty Euro (950.- EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above person,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by his surname,

first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le treize juillet.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Björn Isaksson Förvaltning AB, numéro d'enregistrement 556639-3517, ayant son adresse Primusgatan 65, SE-112 67

Stockholm, représentée par Mr. Laurent BARNICH, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-
Duché  de  Luxembourg),  en  vertu  d'une  procuration  lui  délivrée,  laquelle,  après  avoir  été  signée  ne  varietur  par  la
mandataire et le notaire soussigné, sera annexée au présente acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. la société ILYX S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège

social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, enregistrée auprès du Registre de commerce et de sociétés de Luxembourg

100223

L

U X E M B O U R G

sous le numéro B 95.985, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Alphonse LENTZ, alors notaire de
résidence à Remich, en date du 19 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1100 du 22 octobre 2003;

II. le capital social de la Société a été fixé à trente-deux mille euros (32.000,-EUR) représenté par mille (1.000) actions

sans valeur nominale, chacune entièrement libérées;

III. la comparante est l'actionnaire unique de la Société;
IV. la comparante a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat, étant donné que la Société a cessé toute

activité;

V. la comparante, étant l'unique associée de la Société et agissant comme liquidatrice de la Société déclare:
- que tous les actifs ont été réalisés;
- que, sous réserve de ce qui suit, tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été entièrement réglés;
- qu'il déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société tous éventuels autres passifs

actuellement inconnus de la Société et dès lors impayés à cette date;

VI. la liquidation de la Société est dès lors à considérer comme clôturée;
VII. décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour

l'exercice de leur mandat;

VIII. les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-1720 Luxembourg, 6,

rue Heine ou à n'importe quelle adresse choisie par les associés.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte,

sont évalués approximativement à neuf cents cinquante euros (950.- EUR).

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire

du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant

par ses noms, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé Barnich,Grethen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2012. Relation: LAC/2012/33506. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Référence de publication: 2012095205/88.
(120130712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2012.

Financial Resources, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 42.296.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 14 juin 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le juge-commissaire Anita LECUIT en son rapport oral,
le liquidateur et le Ministère Public en ses conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation
de la société anonyme FINANCIAL RESOURCES S.A., ayant eu son siège social à L-2021 Luxembourg, 31, Grand-Rue.

Pour extrait conforme
Maître Erwin SOTIRI
70, Grand-Rue
L-1660 Luxembourg
<i>Le liquidateur / Avocat à la Cour

Référence de publication: 2012093364/17.
(120130754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

100224


Document Outline

Achte PMB S.à r.l.

Alain Afflelou International S.A.

Amelia Invest S.A.

ArcelorMittal Sourcing

Aviva Investors Structured Funds

Blue Water Holding S.A.

BOC Frankfurt GP S.à r.l.

CF Industries International Holdings Luxembourg S.à r.l.

David Brown Systems S.à r.l.

Ets. Hoffmann - Neu Combustibles S.A.

Euro Pro Services S.à r.l.

Fascolux S.A.

FedEx Luxembourg S. à r.l.

Financial Resources

Fondations Capital I S.C.A., SICAR

Gemstone 2 S.à r.l.

Gemstone 3 S.à r.l.

Getin International S.à r.l.

GT Satellite Systems S.A.

Halesia S.A.

Halit S.à r.l.

HBP Muelheim S.à r.l.

High Gate Holding S.A.

Ilyx S.A.

Immoffice S.A.

Industrielle Pensions Beteiligungsgesellschaft S.A.

Infrastrukturelle Beteiligungsgesellschaft S.A.

Itaú SIF Fund of Funds

Itavy Holdings S.à r.l.

Lisac s.à r.l.

Luxe Editions, S.à r.l.

LX Alpha Phi S.C.A.

Lyreco Luxembourg

Majerus-Parmentier Constructions Sàrl

Manacor (Luxembourg) S.A.

Medinvest International (Invecom Management) S.C.A.

Meyket Locations S.à r.l.

Mobilized Media S.A.

Molson Coors Lux 2

Novimmo S.A.

Oddo Services Luxembourg S.A.

Paloma International II

Participation

PAS Luxembourg, S.à.r.l.

Plansee Group Service S.A.

Promotions Tavares &amp; Fils, s.à r.l.

Queensgate Investments I S.à r.l.

R&amp;H Fund Services (Luxembourg) Limited

Sashey Investment S.à r.l.

S Asia III Luxembourg S.à r.l.

Siemens Enterprise Communications S.A.

Siliwa S.A. - SPF

SilverStreet Management S.àr.l.

SJ (Luxembourg) Sàrl

SL Investment General Partners Fund SCA, SICAV-SIF

SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.

SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.

Square Holdings (CDE) S.àr.l.

Square Holdings S.àr.l.

Terra Industries International Holdings Luxembourg S.à r.l.

Vintners Propco S.à.r.l.

Violine S.à r.l.