logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2075

22 août 2012

SOMMAIRE

Alysea Luxembourg Les Soins S.A  . . . . . . .

99579

Antarex International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

99580

Biocera S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99599

Cape Cod SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99581

Champagne Invest, SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

99587

Châteaux Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99584

Comptoir Pharmaceutique Luxembour-

geois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99587

Concept Live S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99587

Cordouan Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

99588

CVIC Lux Securities Trading  . . . . . . . . . . . .

99582

CVIC Lux Securities Trading S.à r.l.  . . . . .

99582

Danube SCA SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99588

Diapason Investissements S.A.  . . . . . . . . . .

99589

Dininvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99591

Dorn Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99592

Edison Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

99593

Elizabeth Verwaltung S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

99594

Energies Van Kasteren S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

99576

Energies Van Kasteren S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

99595

Energy Investments Lux S.A. . . . . . . . . . . . .

99595

Ets. Bourgeois S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99595

Eurofins Pharma Services France LUX

Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99589

Euro-Zone Office Investments S.A.  . . . . . .

99586

Extenso Int. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99596

Facette S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99596

Faduval Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99597

Familiar S.A., SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . .

99597

FDG Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99597

Fibaco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99598

Financière Express Holding 2001 S.A.  . . . .

99598

Financière Palladio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

99588

Finanmag S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99599

GCVMBB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99599

Gentiane S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99600

Gift Productions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99575

Global Fund House Management S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99600

Gruppo Coin International S.A.  . . . . . . . . .

99596

Heirens Constructions S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

99579

Heron Optique et Audition S.A.  . . . . . . . . .

99581

InfraTaf Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

99567

Intekbio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99585

Intelprop S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99595

Kalispera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99598

Luxembourg Food & Beverage S.à r.l. . . . .

99587

Luxpromo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99582

Presse Européenne S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

99586

Princess Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99592

PSMA Luxco GP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99600

Ravago Production S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

99577

Saxon Energy Services Holdings Sàrl . . . . .

99594

Saxon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99584

Société Luxembourgeoise des Mines . . . . .

99591

Steffen Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99597

Syndex Umbrella SICAV . . . . . . . . . . . . . . . .

99554

Teknimed International S.A.  . . . . . . . . . . . .

99585

Telenet Finance IV Luxembourg S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99592

TETRA Kayser Associés S.A.  . . . . . . . . . . . .

99594

TREVOR & Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99578

Universal Premium Holding SA  . . . . . . . . .

99589

99553

L

U X E M B O U R G

Syndex Umbrella SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécia-

lisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 170.918.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of the month of August.
Before us Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Syndex Capital Management AG, a "public liability company" organised and existing under the laws of Switzerland,

having its registered office at Felsenstrasse 4, 8832 Wollerau, Switzerland, registered with the Swiss trade and companies
register under number CH-130.3.013.509-4,

represented by Laura Macri, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given on August 8

th

 2012.

The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to

this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, in its capacity, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a

"société anonyme" named " Syndex Umbrella SICAV" and qualifying as a "a société d'investissement à capital variable -
fonds d'investissement spécialisé" ("SICAV-FIS") which it intends to incorporate in Luxembourg.

Title I. Denomination, Duration, Object, Registered office

Art. 1. Name. There exists among the subscriber and all those who may become holders of shares of the Company

hereafter issued, a company in the form of a société anonyme (public limited company) qualifying as a société d'investis-
sement  à  capital  variable  -  fonds  d'investissement  spécialisé  (investment  company  with  variable  capital  -  specialised
investment fund) under the name of Syndex Umbrella SICAV (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved by a resolution

of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the "Articles").

Art. 3. Object. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of

any kind and other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the
results of the management of its portfolio.

The Company is subject to the provisions of the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as

amended (the "Law") and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accom-
plishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, in the Grand

Duchy of Luxembourg.

Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

resolution of the board of directors of the Company (the "Board").

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board may transfer the

registered office of the Company within the municipality of Luxembourg and, to the extent it is allowed by the law, to
any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg.

The registered office may also be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means

of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for any amend-
ment to the Articles or, if permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, by the
Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economical, social or military events have occurred

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company.

Title II. Share capital - Shares - Net asset value

Art. 5. Share Capital. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time

be equal to the net assets of the Company as defined in Article 12 hereof.

99554

L

U X E M B O U R G

The initial subscribed capital is fifty thousand US Dollars (USD [50,000]) divided into fifty [50] fully paid up shares

which may be entirely redeemed at their initial value of one thousand US Dollars (USD[1,000]) by the launch date of the
first sub-fund.

The minimum capital of the Company shall be the minimum capital required by Luxembourg law and must be reached

within twelve (12) months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund
under the Law.

The Board may, at any time, as it deems appropriate, decide to create one or more compartments or sub-funds within

the meaning of article 71(1) of the Law, (each such compartment or sub-fund, a "Sub-Fund"). The Company constitutes
a single legal entity, but the assets of each Sub-Fund shall be invested for the exclusive benefit of the shareholders of the
corresponding Sub-Fund and the assets of a specific Sub-Fund are solely accountable for the liabilities, commitments and
obligations of that Sub-Fund.

The shares to be issued in a Sub-Fund may, as the Board shall determine, be of one or more different classes (each

such class, a "Class"), the features, terms and conditions of which shall be established by the Board.

The Board may create each Sub-Fund for an unlimited or a limited period of time.
The proceeds from the issuance of shares of any Class within a Sub¬Fund shall be invested pursuant to Article 17

hereof in securities of any kind or other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or
monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities or assets or with such other specific features, as
the Board shall from time to time determine in respect of the relevant Sub-Fund.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class shall, if not

expressed in USD, be converted into USD and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes.

The general meeting of shareholders of a Sub-Fund or Class, deciding with simple majority, or the Board may conso-

lidate ("reverse split") or split the shares of such Sub-Fund or Class.

Art. 6. Issue of shares.  The  Board  is  authorized  without  limitation  to  issue  further  partly  or  fully  paid  shares,  as

determined  by  the  Board,  at  any  time,  in  accordance  with  the  procedures  and  subject  to  the  terms  and  conditions
determined by the Board and disclosed in the sales documents, without reserving to the existing shareholders preferential
or pre-emptive rights to subscription of the shares to be issued.

Investors shall have either to commit to subscribe to shares or may directly subscribe to shares, as determined by the

Board and disclosed in the sales documents.

In case the Board decides that investors have to commit to subscribe shares, investors will be required to execute a

subscription agreement and indicate therein their total committed capital (the "Commitment" or "Commitments"), subject
to any minimum Commitment as may be decided by the Board.

The procedures relating to Commitments and drawdown of Commitments will be disclosed in the sales documents

and the subscription agreement.

Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents, the issue price shall be based on to the

Net Asset Value for the relevant Class as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof plus a
subscription charge, if any, as the sales documents may provide. The Board may also make such adjustment to the issue
price as it may consider appropriate to ensure fairness between the shareholders. For the avoidance of doubt, the issue
price may among others also be based at any time on the initial subscription price for the relevant Sub-Fund or Class,
plus a subscription charge, if any, as the sales documents may provide.

In addition, a dilution levy may be imposed on subscriptions requests for shares of a Sub-Fund as specified in the sales

documents. Such dilution levy should not exceed such percentage of the Net Asset Value per share, as may be decided
in the discretion of the Board and disclosed in the sales documents.

Shares of the Company are restricted to institutional investors, professional investors or any other well-informed

investors (investisseurs avertis) within the meaning of the Law ("Eligible Investors").The Board may delegate to any duly
authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duty of accepting subscriptions
and/or delivering and receiving payment for such new shares, remaining always within the limits imposed by the Law.

The Board is further authorised to determine the conditions of any such issue and to make any such issue subject to

payment at the time of issue of the shares.

The issue of shares shall be suspended if the calculation of the Net Asset Value is suspended pursuant to Article 11

hereof.

The Board may decide to issue shares against contribution in kind in accordance with Luxembourg law. To the extent

required by the applicable laws and regulations, the contributed assets shall be valued in a report issued by the auditor
of the Company. Any costs incurred in connection with a contribution in kind shall be borne by the relevant shareholder,
unless the Board considers that the subscription in kind is in the interest of the Company in which case such costs may
be borne in all or in part by the Company.

The Board may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares until such time as the

Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Eligible Investor and is not precluded from
holding shares in the Company.

99555

L

U X E M B O U R G

In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Eligible Investor or any

shareholder precluded from holding shares in the Company (including for the avoidance of doubt any person precluded
from holding shares in the Company by virtue of Article 9 hereof), and who holds shares in the Company, shall hold
harmless and indemnify the Company, the Board, the other shareholders and the Company's agents for any damages,
losses expenses and liabilities (including inter alia tax liabilities deriving from the Foreign Account Tax Compliance Act
("FATCA") requirements or breach thereof) resulting from or connected to such holding in circumstances where the
relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representa-
tions to wrongfully establish its status as an eligible investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.

Art. 7. Form of shares. The Company will in principle issue shares in registered form only. The Company reserves the

right to issue bearer shares to the extent that it is in a position to check at all times the status of Eligible Investor of the
holders of the bearer shares.

All issued registered shares of the Company shall be inscribed in the register of shareholders (the "Register"), which

shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company. The Register shall
contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile as notified to the Company and
the number and Class(es) of shares held by him.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements

from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register. In the event of joint holders of shares, only
one address will be inserted and any notices will be sent to that address only.

In the event that a shareholder does not provide such address, or such notices and announcements are returned as

undeliverable to such address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register and the
shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so
entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder.
The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register by means of a written notification to the
Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the Register as full owner of the

shares. The Company shall be entitled to consider any right, interest or claim of any other person in or upon such shares
to be non-existing, provided that the foregoing shall deprive no person of any right which he might properly have to
request a change in the registration of his shares.

The Company will recognise only one holder per share. In the event of joint ownership the Company may suspend

the exercise of any right deriving from the relevant share(s) until one person shall have been designated to represent the
joint owners vis-à-vis the Company.

In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or

other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint
holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.

Fractions of shares up to the number of decimal places to be decided by the Board will be issued if so decided by the

Board. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets and any
distributions attributable to the relevant Class on a pro rata basis.

The Company shall decide whether share certificates shall be delivered to the shareholders and under which conditions

or whether the shareholders shall receive a written confirmation of their shareholding.

Any share certificates shall be signed by two (2) directors or by a director and an official duly authorized by the Board

for such purpose. Signatures of the directors may be either manual, or printed, or by facsimile. The signature of the
authorized official shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board may
from time to time determine.

Transfer of registered shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register to be made by the Company

upon delivery of the certificate or certificates, if any, representing such shares, to the Company along with appropriate
document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee and such other documentation as the
Company may require.

The Company will refuse to give effect to any transfer of shares and refuse any transfer of shares to be entered in the

Register in circumstances where such transfer would result in shares being held by any person not qualifying as an Eligible
Investor or by any person precluded from holding shares in the Company.

Art. 8. Mutilation of shares. If share certificates are issued and if any shareholder can prove to the satisfaction of the

Company that his/her/its share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his/her/its request, a duplicate
share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company
but without restriction thereto, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which
it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall
become void.

The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and

all  reasonable  expenses  undergone  by  the  Company  in  connection  with  the  issuance  and  registration  thereof,  or  in
connection with the annulment of the original share certificate.

99556

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Restrictions on the ownership of shares. The Board shall have power to impose such restrictions as it may

think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by or for the account
of (a) any person not qualifying as an Eligible Investor, (b) any US Person (as defined the case being in the sales documents
of the Company) (c) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental authority or (d)
any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability or
taxation (including inter alia any liability that might derive from any FATCA requirements or any breach thereof) or
suffering any pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered. More specifically,
the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body
(including for the avoidance of doubt any persons in breach of FATCA requirements).

For such purposes the Company may:
a) decline to issue any share or to register any transfer of any share where it appears to it that such registry would or

might result in such share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the
Company;

b) at any time require any person whose name is entered in the Register to furnish it with any information, supported

by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such
shareholder's share rests or will rest in a person who is precluded from holding shares in the Company;

c) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of

shareholders of the Company; and

d) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares or a certain proportion

of the shares in the Company or whom the Company reasonably believes to be precluded from holding shares in the
Company, either alone or in conjunction with any other person is beneficial owner of shares, (i) direct such shareholder
to (a) transfer his shares to a person qualified to own such shares, or (b) request the Company to redeem his shares, or
(ii) compulsorily redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "Redemption Notice") upon the shareholder holding such

shares or appearing in the Register as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as
aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect of such share is
payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope
addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said share-
holder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates (if issued)
representing the shares specified in the Redemption Notice. Immediately after the close of business on the date specified
in the Redemption Notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held or owned by
him shall be cancelled;

2) The price at which the shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the "Redemption

Price") shall be an amount equal to the Net Asset Value of the relevant shares, determined in accordance with Article
12 hereof less any service charge (if any). Where it appears that, due to the situation of the shareholder, payment of the
redemption price by the Company, any of its agents and/or any other intermediary may result in either the Company,
any of its agents and/or any other intermediary to be liable to a foreign authority for the payment of taxes or other
administrative charges, the Company may further withhold or retain, or allow any of its agents and/or other intermediary
to withhold or retain, from the Redemption Price an amount sufficient to cover such potential liability until such time
that the shareholder provide the Company, any of its agents and/or any other intermediary with sufficient comfort that
their liability shall not be engaged, it being understood (i) that in some cases the amount so withheld or retained may
have to be paid to the relevant foreign authority, in which case such amount may no longer be claimed by the shareholder,
and (ii) that potential liability to be covered may extend to any damage that the Company, any of its agents and/or any
other intermediary may suffer as a result of their obligation to abide by confidentiality rules;

3) Payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency

of denomination for the relevant Class and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere
(as specified in the Redemption Notice) for payment to such person but only, if a share certificate shall have been issued,
upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice. Upon deposit of
such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such Redemption Notice shall have any further
interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right
of the shareholder appearing as the thereof owner to receive the price so deposited (without interest) from such bank
as aforesaid.

4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any

case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith.

Art. 10. Redemption and Conversion of Shares. As is more specifically prescribed herein below the Company has the

power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by law.

Unless otherwise provided for a specific Sub-Fund or Class in the sales documents, any shareholder may request the

redemption of all or part of his/her/its shares by the Company under the terms, conditions and limits set forth by the

99557

L

U X E M B O U R G

Board in the sales documents and within the limits provided by law and these Articles. Any redemption request must be
filed by such shareholder in written form, subject to the conditions set out in the sales documents of the Company, at
the registered office of the Company or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for
redemption of shares, together with the delivery of the certificate(s) for such shares in proper form (if issued).

Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents, the redemption price shall be based on

to the Net Asset Value for the relevant Class as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof less
any redemption charge, if any, as the sales documents may provide. This price may be rounded up or down, as the Board
may determine, and such rounding may accrue to the benefit of the Company, as the case may be. From the redemption
price there may further be deducted any deferred sales charge if such shares form part of a Class in respect of which a
deferred sales charge has been contemplated in the sales documents. The redemption price per share shall be paid within
a period as determined by the Board provided that the share certificates, if issued, and any requested documents have
been received by the Company, subject to Article 11 hereof.

The Board may determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of any specific Class

or Classes. The specific period for payment of the redemption proceeds of any Class of the Company and any applicable
notice period as well as the circumstances of its application will be published in the sales documents relating to the sale
of such shares.

The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised

person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.

The Board may (subject to the principle of equal treatment of shareholders and, if required by the applicable laws and

regulations, the consent of the shareholder(s) concerned) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by
allocating to the redeeming shareholders investments from the portfolio in value equal to the applicable redemption price
attributable to the shares to be redeemed as described in the sales documents. If required by the applicable laws and
regulations, such redemption will be subject to a special audit report by the auditor of the Company.

The specific costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, will have to be borne

by the shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless
the Board considers that the redemption in kind is in the interest of the Company or made to protect the interests of
the Company.

Any request for redemption is revocable under the conditions determined by the Board and disclosed in the sales

documents, if any, and in the event of suspension of redemption pursuant to Article 11 hereof. In the absence of revocation,
redemption will occur as further detailed in the sales documents of the Company.

Unless otherwise provided for in the sales documents, any shareholder may request conversion of whole or part of

his shares of one Class of a Sub-Fund into shares of another Class of that or another Sub-Fund at the respective Net
Asset Values of the shares of the relevant Classes under the terms, conditions and limits set forth by the Board in the
sales documents. The Board may notably impose restrictions between Classes of shares as disclosed in the sales docu-
ments as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversions subject to payment of a charge as specified
in the sales documents.

The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the shares to be converted has

been fully settled by such shareholder.

If on any given redemption or conversion day (as defined in the sales documents), redemption requests and/or con-

version requests exceed a certain level determined by the Board and set forth in the sales documents, the Board may
decide that the processing of part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred or that part or
all the payment of the relevant redemption requests will be deferred for such period and in a manner that the Board
considers to be in the best interest of the relevant Sub-Fund or Class and of the Company. On the next redemption or
conversion day (as applicable) following that period, the redemption and conversion requests the processing of which
has been deferred will be met in priority to a later request, subject to the same limitation as above.

The Board may refuse redemptions (or conversions) for an amount less than the minimum redemption (or conversion)

amount as determined (if any) by the Board and disclosed in the sales documents, or any other amount the Board would
determine in its sole discretion.

If a redemption (or conversion) would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one Sub-

Fund or Class below the minimum holding amount as the Board shall determine from time to time, then such shareholder
may be deemed to have requested the conversion of his/her/its shares into shares of the Class of the same Sub-Fund with
a lower minimum holding or the redemption of all his/her/its shares of such Sub-Fund or Class as further detailed in the
sales documents of the Company.

The Board may in its absolute discretion compulsory redeem or convert any holding with a value of less than the

minimum holding amount to be determined from time to time by the Board and to be published in the sales documents
of the Company.

The Board may also compulsorily redeem shares if it becomes aware that a shareholder has failed to provide any

information or declaration required by the Board within the deadline fixed by the Board.

99558

L

U X E M B O U R G

The Board or any duly appointed agent may further decide to compulsorily redeem shares the subscription of which

would not be made in accordance with the sales documents of the Company or whose wired subscription amounts would
be insufficient to cover the relevant subscription price (including, for the avoidance of doubt, any applicable subscription
charge). Such redemption will be carried out under the most favourable conditions for the Company, including among
other the possibility for the Company to keep the difference between the redemption price and the subscription price
when the latter is lower than the former or claim to the relevant investor that difference when the latter is higher than
the former.

In exceptional circumstances relating to a lack of liquidity of certain investments made by certain Sub-Funds and the

related difficulties in determining the Net Asset Value of the shares of certain Sub-Funds, the treatment of redemption
requests may be deferred and/or the issue, redemptions and conversions of shares suspended by the Board.

In the same circumstances, the Board may consider the creation of side-pockets via any means and to the largest extent

authorised pursuant to applicable Luxembourg laws and regulations and, as the case may be, subject to prior clearance
from the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

In addition to the foregoing, the Board may decide to temporarily suspend the redemption of shares if exceptional

circumstances as set forth in Article 11, so warrant.

The Board may suspend the redemption rights of any shareholder if the Board deems it necessary to comply with anti-

money laundering laws and regulations or any other legal requirement applicable to the Company, its investment manager,
the administrative agent and their respective affiliates or any other service provider to the Company. The Board may also
suspend the redemption rights of any shareholder if in its opinion the effect of such redemptions would be to seriously
impair the Company's (or any Sub-Fund's) ability to operate or to jeopardise its tax status.

In addition, a dilution levy may be imposed on any redemption or conversion requests for shares of a Sub-Fund. Such

dilution levy should not exceed such percentage of the Net Asset Value per share, as may be decided in the discretion
of the Board and disclosed in the sales documents.

Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.

Art. 11. Frequency of the calculation of the NAV. The Net Asset Value of shares shall, for the purpose of the re-

demption, conversion or issue of shares, be determined by the Company or any agent appointed thereto, under the
responsibility of the Board, from time to time, but in no instance less than once per year, as the Board may determine
(every such day or time for determination of net asset value being referred to herein as a "Valuation Day").

The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value of one or more Sub-Fund(s) and

consequently the issue, redemption and conversion of shares of such Sub-Fund(s), it being understood that where the
context so requires "Sub-Fund" may also be read as "Class", during:

(a) any period when any of the stock exchanges or other principal markets on which a substantial portion of the assets

of the such Sub-Fund(s), from time to time, is quoted or dealt in, is closed (otherwise than for ordinary holidays) or during
which dealings therein are restricted or suspended provided that such restriction or suspension affects the valuation of
the investments of the Company attributable to such Sub-Fund(s) quoted thereon; or

(b) any period when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the

control, responsibility and power of the Board, or the existence of any state of affairs which constitutes an emergency
in the opinion of the Board, disposal or valuation of assets held by the Company attributable to such Sub-Fund(s) is not
reasonably practical without this being detrimental to the interests of shareholders, or if in the opinion of the Board, the
issue and, if applicable, redemption prices cannot fairly be calculated; or

(c) any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price or

value of any of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund(s) or the current prices or values on any
stock exchange or other market in respect of the assets attributable to such Sub-Fund(s); or

(d) during any period when dealing the units/shares of an investment vehicle in which the concerned Sub-Fund(s) may

be invested is restricted or suspended; or, more generally, during any period when remittance of monies which will or
may be involved in the realisation of, or in the payment for any of the concerned Sub-Fund(s)' investments is not possible;
or

(e) any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption

of shares of such Sub-Fund(s) or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments
or payments due on redemption of shares of the Company cannot in the opinion of the Board, be effected at normal
rates of exchange; or

(f) from the time of publication of a notice convening an extraordinary general meeting of shareholders for the purpose

of winding up the Company or any Sub-Fund(s), or merging the Company or any Sub-Fund(s), or informing the share-
holders of the decision of the Board to terminate or merge any Sub-Fund(s); or

(g) when for any other reason, the prices of any investments owned by the Company, attributable to the concerned

Sub-Fund cannot be promptly or accurately ascertained; or

(h) during any other circumstance where a failure to do so might result in the Company, any of its Sub-Funds or its

shareholders incurring any liability, pecuniary disadvantages or any other detriment which the Company the Sub-Fund or
its shareholders might so otherwise not have suffered.

99559

L

U X E M B O U R G

If there have been created within a Sub-Fund several Classes, the above shall apply at the level of a Class, if relevant.
Notice of the beginning of any period of suspension shall be given by the Company to all the shareholders affected,

i.e. having made an application for subscription, redemption or conversion of shares for which the determination of the
Net Asset Value has been suspended.

In case of suspension of the calculation of the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund or Class shareholders may

give notice that they wish to withdraw their application. If no such notice is received by the Company, such application
will be dealt with as further detailed in the sales documents of the Company.

Art. 12. Valuation regulations. Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents, the Net

Asset Value of shares of each Class within each Sub-Fund (the "Net Asset Value") shall be expressed in the reference
currency of the relevant Class (and/or in such other currencies as the Board shall from time to time determine) as a per
share figure. It shall be determined as at any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to the
relevant Class, being the value of the assets of the Company attributable to such Class less the liabilities attributable to
such Class as at such Valuation Day, by the number of shares of the relevant Class then outstanding, in accordance with
the rules set forth below.

The Net Asset Value per share may be rounded up or down as the Board shall determine.
If, since the time of determination of the Net Asset Value on the relevant Valuation Day, there has been a material

change in the valuations of the investments attributable to the relevant Sub-Fund, the Company may, in order to safeguard
the interests of the shareholders and of the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

A. The assets of the Company shall be deemed to include (without limitation):
(1) All cash at hand and on deposit, including interest accrued thereon.
(2) All bills and demand notes payable and accounts receivable (including the proceeds of securities sold but not

delivered).

(3) All bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights,

warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company.

(4) All stock dividends, cash dividends and cash distributions declared receivable by the Company to the extent in-

formation thereon is reasonably available to the Company.

(5) All interest accrued on any interest-bearing asset owned by the Company except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of such asset.

(6) The preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,

insofar as they have not been amortised.

(7) The liquidating value of all futures and forward contracts and all call and put options the Company has an open

position in.

(8) All other assets of any kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable (including any rebates

on fees and expenses payable by any investment fund), prepaid expenses, cash dividends declared and interest accrued
and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or
received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as the Board may consider
appropriate in such case to reflect the true value thereof.

2) The value of securities (including shares or units of closed-ended investment funds) which are quoted, traded or

dealt in on any stock exchange shall be based on the last closing prices or, if appropriate, on the average price on the
stock exchange which is normally the principal market of such securities, and each security traded on any other regulated
market shall be valued in a manner as similar as possible to that provided for quoted securities;

3) For non-quoted securities or securities not traded or dealt in on any stock exchange or other regulated market,

as well as quoted or non-quoted securities on such other market for which no valuation price is available, or securities
for which the quoted prices are, in the opinion of the Board, not representative of the fair market value, the value thereof
shall be determined prudently and in good faith by the Board on the basis of foreseeable sales prices;

4) Liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an

amortised cost basis;

5) Futures and options are valued by reference to the last available closing price on the relevant market; the market

prices used are the futures exchanges settlement prices;

6) Swaps are valued at fair value based on the last available closing price of the underlying security.
7) Investments in open-ended investment funds will be taken at their latest official net assets values or at their latest

unofficial net asset values (i.e. which are not generally used for the purposes of subscription and redemption of shares of
the underlying investment funds) as provided by the relevant administrators or investment managers if more recent than
their official net asset values and for which there is sufficient assurance that the valuation method used by the relevant
administrator for said unofficial net asset values is coherent as compared to the official one.

99560

L

U X E M B O U R G

If events have occurred which may have resulted in a material change of the net asset value of such shares or units in

other investment funds since the day on which the latest official net asset value was calculated, the value of such shares
or units may be adjusted in order to reflect, in the reasonable opinion of the Board, such change of value.

8) All other securities and assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures

established by the Board.

The Board, or any appointed agent, at its discretion, may permit some other method of valuation to be used, if it

considers that such valuation better reflects the fair value and is in accordance with good accounting practice.

For the purpose of determining the value of the Company's assets, the administrative agent, having due regards to the

standard of care and due diligence in this respect, may, when calculating the Net Asset Value, completely and exclusively
rely, unless there is manifest error or negligence on its part, upon the valuations provided (i) by various pricing sources
available on the market such as pricing agencies or fund administrators, (ii) by brokers, or (iii) by a specialist duly authorized
to that effect by the Board. Finally, in the cases no prices are found or when the valuation may not correctly be assessed,
the administrative agent may rely upon the valuation of the Board.

In circumstances where (i) one or more pricing sources fail(s) to provide valuations to the administrative agent, which

could have a significant impact on the Net Asset Value, or where (ii) the value of any asset(s) may not be determined as
rapidly and accurately as required, the administrative agent is authorized to postpone the Net Asset Value calculation
and as a result may be unable to determine subscription, redemption and conversion prices. The Board shall be informed
immediately by the administrative agent should the situation arise. The Board may then decide to suspend the calculation
of the Net Asset Value.

For the avoidance of doubt, the provisions of this Article 12 are rules for determining Net Asset Value per share and

are not intended to affect the treatment for accounting or legal purposes of the assets and liabilities of the Company or
any securities issued by the Company.

B. The liabilities of the Company shall be deemed to include (without limitation):
(1) All loans, bills and accounts payable.
(2) All accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans).
(3) All accrued or payable fees and expenses (including administrative expenses, management fees, including incentive

fees, custodian fees, central administration agent's fees and registrar and transfer agent's fees).

(4) All known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments in cash or in

kind, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company.

(5) An appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from

time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board, as well as such amount
(if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company.

(6) All other liabilities of the Company, of whatever kind and nature reflected in accordance with generally accepted

accounting principles. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses
payable by the Company, including, without any limitation, the incorporation expenses and costs for subsequent amend-
ments to the constitutional documents, all translation costs, fees and expenses payable to the investment manager(s)/
advisor(s), including performance fees, if any, the custodian and its correspondent agents, the administrative agent, do-
miciliary and corporate agent, the registrar and transfer agent, listing agent, any paying agent, any distributor or other
agents and employees of the Company, as well as any permanent representatives of the Company in countries where it
is subject to registration, the costs and expenses for legal, accounting and auditing services, any fees and expenses involved
in registering and maintaining the registration of the Company with any government agencies or stock exchanges in the
Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing,
printing, advertising and distributing prospectuses, explanatory memoranda, periodical reports or registration statements,
the cost of printing share certificates, if any, and the costs of any reports to the shareholders, expenses incurred in
determining the Company's Net Asset Value, the cost of convening and holding shareholders' and directors' meetings,
reasonable travelling expenses of directors, directors' fees, all taxes and duties charged by governmental or similar au-
thorities and stock exchanges, the costs of publishing the issue and repurchase prices as well as any other operating costs,
including the costs of buying and selling assets, finder fees, financial, banking and brokerage expenses and all other admi-
nistrative costs as well as interest, bank charges, currency conversion costs, postage, telephone and telex, insurance costs,
including insurance costs for the directors, employees and agents of the Company, costs and expenses related to legal,
notarial and /or administrative proceedings and indemnifications resulting from such proceedings, involving, directly or
indirectly, the Company, directors, employees and agents of the Company as well as legal, to the extent as permitted by
law, notarial and/or administrative proceedings and indemnifications resulting from such proceedings, related, directly or
indirectly to former or existing shareholders.

In assessing the amount of such liabilities, the Company shall take into account pro rata temporis any expenses or

other costs, administrative and other, that occur regularly or periodically.

C. There shall be established a separate pool of assets and liabilities in respect of each Sub-Fund in the following manner:

99561

L

U X E M B O U R G

(1) Proceeds resulting from the issue of shares in different Sub-Funds shall be allocated in the Company's books to

the pool of assets of that Sub-Fund and the assets, liabilities, commitments, revenues and expenses relating to that Sub-
Fund shall be allocated to the corresponding pool in compliance with the provisions below.

(2) When an income or asset is derived from another asset, such income or asset will be recorded in the Company's

books under the same Sub-Fund holding the asset from which it derived, and, on each revaluation of the asset, the increase
or decrease in value shall be allocated to the corresponding Sub-Fund.

(3) When the Company incurs a liability attributable to a specific asset in a given pool of assets or to a transaction

performed in relation to the assets of a given Sub-Fund, this liability shall be allocated to that Sub-Fund.

(4) If an asset or a liability of the Company cannot be allocated to a given Sub-Fund, this asset or liability shall be

allocated to all Sub-Funds pro rata to their respective Net Asset Values or in any other manner the directors may decide
in good faith.

(5) Following a dividend distribution to shareholders of a Sub-Fund, the Net Asset Value of that Sub-Fund shall be

reduced by the amount of such distribution.

If there have been created within a Sub-Fund two or more Classes, the allocation rules set above shall apply, mutatis

mutandis, to such Classes.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted

accounting principles.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken

by the Board or by any agent which the Board may appoint for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be
final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

D. For the purpose of valuation under this Article:
(a) each of the Company's shares subject to a redemption request shall be considered as a share issued and outstanding

until the close of business on the Valuation Day on which it is redeemed and its price shall be considered a liability of the
Company from the close of business on such Valuation Day until the price has been paid;

(b) each share of the Company in respect of which subscription has been accepted but payment has not been received

shall be deemed to be existing as from the close of business on the Valuation Day on which it has been allotted and the
price thereof, until received by the Company shall be deemed a debt due to the Company;

(c) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the reference

currency in which the Net Asset Value per share of the relevant Class is calculated shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant
Class; and

(d) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for the Company on

such Valuation Day to the extent practicable.

Art. 13. Co-management. The Board may authorise investment and management of all or any part of the portfolio of

assets established for two or more Sub-Funds on a pooled basis, or of all or any part of the portfolio of assets of the
Company on a co-managed or cloned basis with assets belonging to other Luxembourg collective investment schemes,
all subject to compliance with applicable regulations.

Title III. Administration and Supervision

Art. 14. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three

members; members of the Board need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period determined by such meeting in

compliance with the law, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at
any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director appointed by a general meeting of shareholders, because of death,

retirement or otherwise, the remaining directors so appointed may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy
until the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Meeting of the Board. The Board will choose from among its members a chairman, and may choose from

among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall
be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon
call by the chairman or by any two (2) directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the shareholders or

the Board may appoint any authorised person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram,
telex, telefax or any other electronic means capable of evidencing such waiver of each director. Separate notice shall not

99562

L

U X E M B O U R G

be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of
the Board.

Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex, telefax message

or any electronic means capable of evidencing such appointment, another director as his proxy. Any director may attend
a meeting of the Board using teleconference or videoconference means provided that (i) the director attending the
meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission
is performed on an ongoing basis and (iv) the directors can properly deliberate. The participation in a meeting by such
means shall constitute presence in person at the meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office
of the Company. Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram, telex, telefax message or any other
electronic means capable of evidencing such vote.

The directors may only act at duly convened meetings of the Board. directors may not bind the Company by their

individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.

The Board can deliberate or act validly only if at least two directors are present or represented by another director

as proxy at a meeting of the Board.

Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event

that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have
a casting vote.

Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms in the form of one

or several documents in writing signed by all the directors or by telex, cable, telegram, telefax message or by telephone
provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The Board from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, a secretary, and any

assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operations and manage-
ment of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be directors
or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the
powers and duties given to them by the Board.

The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to

carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any com-
mittee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit, provided
that the majority of the members of the committee are directors and that no meeting of the committee shall be quorate
for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are directors
of the Company.

Art. 16. Minutes. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman, as the case may be, pro

tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

such chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 17. Powers of the Board. The Board shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine

the corporate and investment policy and the course of conduct of management and business affairs of the Company.

The Board shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the

Company.

Art. 18. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business, shall not, by reason of such connection and/or relationship with such other company or firm, be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted

for approval to the Board conflicting with that of the Company, such director or officer shall make known to the Board
such conflict and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction shall be reported to the next
succeeding meeting of shareholders.

The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board or by the single director relates to current

operations entered into under normal conditions.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in

any matter, position or transaction involving any entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or such other
company or entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion, provided that this personal
interest is not considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations.

Art. 19. Indemnification of directors. The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to

99563

L

U X E M B O U R G

which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be
indemnified. Such person shall be indemnified in all circumstances except in relation to matters as to which he shall be
finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a
settlement, any indemnity shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which
the Company is advised by its counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The
foregoing right of indemnity shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 20. Signatory power. The Company will be bound by the joint signature of any two directors or by the joint or

single signature(s) of any other person(s) to whom such authority has been delegated by the Board.

Art. 21. Auditor. The Company shall appoint a réviseur d'entreprises agréé (independent auditor) who shall carry out

the duties prescribed by of the Law. The auditor shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for
a period determined by such meeting and until its successor is elected.

Title IV. General meetings - Accounting year - Distribution

Art. 22. General meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the
Company regardless of the Class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company.

Shareholders will meet upon call by the Board or upon the written request of shareholders representing at least one

tenth of the share capital of the Company, pursuant to a notice setting forth the agenda, sent at least 8 days prior to the
meeting to each shareholder at the shareholder's address in the Register.

Art. 23. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Lu-

xembourg law, at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the
notice of meeting, on the 15 

th

 of the month of May at 11.30 a.m. (Luxembourg time). If such day is not a bank business

day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general
meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

If permitted by and at the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of

shareholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, which date, time
or place are to be decided by the Board.

Other meetings of shareholders or of holders of shares of any specific Sub-Fund or Class may, where required or

appropriate, be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 24. Quorum and Voting. The quorum and notice periods required by law shall govern the conduct of the meetings

of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

If permitted by and at the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting

of shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by
reference to the shares issued and in circulation at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record
Date"), whereas the right of a shareholder to participate at a general meeting of shareholders and to exercise the voting
right attached to his/its/her shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record
Date.

Each share of whatever Class and regardless of the Net Asset Value per share within the Class, is entitled to one vote,

subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing
another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex, telefax message or any other electronic means
capable of evidencing such proxy. Such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened
shareholders' meeting. A company may execute a proxy under the hand of a duly authorized officer.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of votes cast. The Board may determine all other conditions that must be
fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If and to the extent permitted by the Board for a specific meeting of shareholders, each shareholder may vote through

voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening
notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least (i) the name,
address or registered office of the relevant shareholder, (ii) the total number of shares held by the relevant shareholder
and, if applicable, the number of shares of each Class or sub-class held by the relevant shareholder, (iii) the place, date
and time of the general meeting, (iv) the agenda of the general meeting, (v) the proposal submitted for decision of the
general meeting, as well as (vi) for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour, against or abstain
from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms, which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention shall be void. The

Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders to which they
relate.

99564

L

U X E M B O U R G

Art. 25. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on first day of January and shall terminate

on the last day of December of the same year.

Art. 26. Distributions. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board, shall determine how

the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare dividends from time to time. Interim dividends
may be distributed upon decision of the Board.

No distribution of dividends may be made if, as a result thereof, the capital of the Company became less than the

minimum prescribed by the Law.

A dividend declared but not paid on a share during five (5) years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Title V. Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or more

liquidators appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.
The net proceeds may be distributed in kind to the holders of shares.

Art. 28. Liquidation and Amalgamation. If the net assets of any Sub-Fund or Class fall below or do not reach an amount

determined by the Board to be the minimum level for such Sub-Fund or Class to be operated in an economically efficient
manner or if a change in the economic, monetary or political situation relating to the Sub-Fund or Class concerned justifies
it or in order to proceed to an economic rationalisation, the Board has the discretionary power to liquidate such Sub-
Fund or Class by compulsory redemption of shares of such Sub-Fund or Class at the Net Asset Value per share (but
taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) determined as at the Valuation Day
at which such a decision shall become effective. The decision of the liquidation will be published by the Company prior
to  the  effective  date  of  the  liquidation  and  the  publication  will  indicate  the  reasons  for,  and  the  procedures  of,  the
liquidation operations. Unless the Board decides otherwise in the interests of, or in order to ensure equal treatment of,
the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or Class concerned may continue to request redemption or con-
version of their shares free of redemption or conversion charges (but taking into account actual realisation prices of
investments and realisation expenses).

Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, a general meeting of shareholders

of any Sub-Fund or Class may, upon proposal from the Board and with its approval, redeem all the shares of such Sub-
Fund or Class and refund to the shareholders the Net Asset Value of their shares (taking into account actual realisation
prices of investments and realisation expenses) determined as at the Valuation Day at which such decision shall take
effect. There shall be no quorum requirements for such a general meeting of shareholders at which resolutions shall be
adopted by simple majority of the votes cast.

Assets which could not be distributed to the relevant shareholders upon the close of the liquidation of a Sub-Fund or

Class will be deposited with the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the relevant shareholders. Amounts
not claimed will be forfeited in accordance with Luxembourg law.

Upon the circumstances provided for above, the Board may decide to allocate the assets of any Sub-Fund to those of

another existing Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment ("UCI"), or to another
sub-fund within such other UCI (the "new Sub¬Fund") and to re-designate the shares of the Sub-Fund concerned as shares
of the new Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to
any fractional entitlement to shareholders)". Such decision will be notified to the shareholders concerned (together with
information in relation to the new Sub-Fund), one month before the date on which the amalgamation becomes effective
in order to enable shareholders to request redemption or conversion of their shares, free of charge, during such period.
After such period, the decision commits the entirety of shareholders who have not used this possibility, provided however
that, if the amalgamation is to be implemented with a Luxembourg UCI of the contractual type ("fonds commun de
placement") or a foreign based undertaking for collective investment, such decision shall be binding only on the share-
holders who are in favour of such amalgamation.

Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, a contribution of the assets and

liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund of the Company, to another UCI or to another sub-fund
within that UCI may be decided upon by a general meeting of the shareholders, upon proposal from the Board and with
its approval, of the contributing Sub-Fund for which there shall be no quorum requirements and which shall decide upon
such an amalgamation by resolution adopted by simple majority of the votes cast, except when such amalgamation is to
be implemented with a Luxembourg UCI of the contractual type ("fonds commun de placement") or a foreign based UCI,
in which case resolutions shall be binding only on the shareholders of the contributing Sub-Fund who have voted in favour
of such amalgamation.

For the purpose of this article, where the context so requires, the term "Sub-Fund" shall also be read as "Class".

99565

L

U X E M B O U R G

Title VI. Final provisions

Art. 29. Custodian. The Company shall enter into a custodian agreement with a bank, which shall satisfy the require-

ments of the Luxembourg laws and the Law (the "Custodian").

In case of withdrawal, whether voluntarily or not, of the Custodian, the Custodian will remain in function until the

appointment, which must happen within two months, of another eligible credit institution.

Art. 30. Amendment of the Articles. These Articles may be amended from time to time by a general meeting of

shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 31. Name of the Company. The Company shall enter into an investment management agreement with one or

more companies of, or affiliated to, the Syndex group (hereafter collectively the "Manager"), under which agreement such
Manager will advise upon and manage the portfolio investments of the Company. In the event of the termination of the
investment management agreement in any manner whatsoever, the Company will at the request of the Manager change
its name forthwith to a name not resembling the one specified in Article 1 hereof, specifically not including the word
"Syndex " or any similar word in any part thereof, and no further usage of the Syndex name or brand shall be used by the
Company without the express consent of the entity holding the intellectual rights over the name "Syndex " (the "Syndex
Owner"). The Company shall indemnify the Syndex Owner and hold it harmless from and against all liabilities, damages,
losses, claims, causes of action, costs, expenses (including, without limitation, legal fees and court costs) and/or procee-
dings (including without limitation indirect, consequential, special, incidental, or punitive damages arising out of or in
connection with the use of the name "Syndex " in any way from the effective termination date of the investment mana-
gement agreement functions of the appointed Manager).

Art. 32. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the laws

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto (the "1915 Law") and the Law.

<i>Transitional dispositions

1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2013.
2) The first annual general meeting shall be held in 2014.

<i>Subscription and Payment

The subscriber has subscribed for fifty [50] shares and has paid in cash fifty thousand USD (USD.-50,000).
Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred and sixty euro [EUR.-1160]

<i>Statements

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26, 26-3 and 26-5 of the 1915

Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Extraordinary general meeting

The appearing person has forthwith taken immediately the following resolutions:

<i>First resolution

The registered office of the Company is set at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

<i>Second resolution

The following persons are appointed directors for a period ending at the first annual general meeting which will be

held in [2014]

- Hans Christoph SCHMIDHUBER, born in Munich, on 24 April 1964, and professionally residing at Felsenstrasse 4,

CH-8832 Wollerau, Switzerland;

- Lucien EULER, born in Ettelbruck, on 13 April 1952, and professionally residing at 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Thomas NUMMER, born in Trier, on 24 April 1969, professionally residing at 2B, Boulevard Royal, L-2444 Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

PricewaterhouseCoopers, having its registered office at 400, Route d'Esch, L-1014 Luxembourg, has been appointed

as independent auditor of the Company for a period ending at the first annual general meeting.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English.

99566

L

U X E M B O U R G

WHEREOF, the notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by the surname, Christian name, civil

status and residence, said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.

Signé: L.MACRI, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 août 2012. Relation: LAC/2012/38927. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, Délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 17 août 2012.

Référence de publication: 2012106520/750.
(120145070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2012.

InfraTaf Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 170.908.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the ninth day of the month of August.
Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

«InfraMed Infrastructure», a French company with registered office at 19, Avenue de l'Opéra, Paris 75001, France,

registered with the Company and Trade Register of Paris under number 522.811.413.

Here represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg (Grand-Duchy of

Luxembourg),

By virtue of a proxy given under private seal, dated 2 

nd

 , August 2012;

The proxy signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary will remain

attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which the prenamed party hereby
declares to form among himself as follows:

Art. 1. Form. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended (the

“1915 Law”), by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorpora-
tion").

The Company is initially composed of one shareholder, owner of all the shares.
The Company may however at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) share-

holders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign

undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as

the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also utilize its funds to invest in real estate and, provided such investment is ancillary to or related

to the acquisition, holding, administration, development and management of the undertaking forming part of the group
of the Company, the Company may invest in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in
any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. Name. The name of the Company is "InfraTaf Holding S.à r.l.".

Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg).

99567

L

U X E M B O U R G

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders'

meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board as defined under Article 12 may also establish branches and subsidiaries,

whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In the event that the Manager or, as the case may be, the Board should determine that extraordinary political, economic

or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any inter-
ested parties by the Manager or, as the case may be, the Board of the Company.

Art. 6. Capital. The issued capital of the Company is set at Twenty Thousand US Dollars (USD 20,000.-) divided into

two million (2,000,000) shares with a nominal value of one US Dollar Cent (USD 0.01) each which are fully paid-up.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single shareholder or

by a resolution of the general meeting of shareholders as the case may be.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.

If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by the 1915

Law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the single

shareholder or the general meeting of shareholders.

The creditors or successors of any of the shareholders may in no event, for whatever reason, request that seals be

affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the
exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single shareholder or of the general
meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.
Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst

them or not.

Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of one single shareholder, said single shareholder may transfer

freely its shares.

If the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders.
In this same scenario, the shares may only be transferred to non shareholders with the authorisation of the general

meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital by application of the requirements of articles
189 and 190 of the 1915 Law.

Art. 11. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other

similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 12. Management of the Company. The Company is managed by one or several Managers who need not be sha-

reholders.

They are appointed and removed from office by a decision of the single shareholder or, as the case may be, by a simple

majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates.
If no term is indicated the Managers are appointed for an undetermined period.

The Managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any

time.

In the case of more than one Manager, the Managers constitute a board of Managers (the “Board”).
Any Manager may participate in any meeting of the Board by conference call or by other similar means of communi-

cation allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting
or the holding of a meeting in person.

Managers may be represented at meetings of the Board by another Manager without limitation as to the number of

proxies which a Manager may accept and vote, it being understood that at least two Managers must be present in person
or by conference call.

Written notice of any meeting of the Board must be given to the Managers twenty four (24) hours at least in advance

of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice.

99568

L

U X E M B O U R G

This notice may be omitted in case of assent of each Manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile,

or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a Board meeting to be
held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board.

The sole shareholder or as the case may be the general meeting of shareholders may decide appointing Managers of

two different classes, being class A Managers and class B Managers. Any such classification of Managers shall be duly
recorded in the minutes of the relevant meeting and the Managers be identified with respect to the class they belong.

The Board can only act or deliberate validly if a majority of the Managers in office are present or represented.
Decisions of the Board are validly taken by the approval of the majority of the Managers of the Company (including

by way of representation). In the event however the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of
shareholders has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) any resolutions
of the Board may only be validly taken if approved by the majority of Managers including at least one class A and one class
B Manager.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed any two Managers present at such meeting.
The Board may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will
form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
Manager.

Art. 13. Events affecting the Managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

a Manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a Manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 14. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in

relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole

Manager, and in the case of a Board by the joint signature of two Managers, provided however that in the event the single
shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed different classes of Managers
(namely class A Managers and class B Managers), the Company will only be validly bound by the joint signature of one
class A Manager and one class B Manager (including by way of representation).

In any event, the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory

powers shall have been delegated by the Manager; or by two Managers in case of Board; or, in the event of classes of
Managers, by one class A and one class B Manager acting together (including by way of representation).

Art. 16. General meetings of shareholders. As long as the Company is composed of one (1) single shareholder, the

latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.

Articles 194 to 196 and 199 of the 1915 Law are not applicable to that situation.
In case the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general

meeting of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
management to the shareholders by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt

of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually within six (6) months

after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified
in the notice of the meeting.

Art. 17. Decisions of the shareholders. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more

than half of the capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles of Incorporation may only be adopted by
the majority (in number) of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's shares, subject to any
other provision of the 1915 Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The decisions of the single shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders are documented

in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.

The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

Art. 18. Financial year. The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day

of December of the next year.

99569

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Annual accounts. At the end of each financial year, the Company's annual accounts are established by the

Manager or, as the case may be, the Board and the Manager or, as the case may be, the Board prepares a general inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the Company's registered office com-

munication of the said inventory and balance sheet.

Art. 20. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of

overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital.

The remaining profit is allocated by resolution of the shareholder(s), as the case may be.
Notwithstanding the preceding provisions, the Manager or, as the case may be, the Board may decide to pay interim

dividends to the shareholder(s) before the end of the year on the basis of a statement of accounts showing (i) that sufficient
funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed where applicable,
realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law
or these Articles of Incorporation (ii) and that any such distributed sums which do not correspond to profits actually
earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Art. 21. Dissolution, Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single shareholder or one of the shareholders.

The liquidation of the Company shall be decided by the single shareholder or by shareholders' meeting in accordance

with the applicable legal provisions.

In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but

need not be shareholders, appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, who shall
determine their powers and their compensation.

Art. 22. Matters not provided. All matters not specifically governed by these Articles of Incorporation shall be deter-

mined in accordance with the 1915 Law.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the

number of shares and has paid in cash the amount mentioned hereafter:

Shareholder

Subscribed

capital
(USD)

Number

of shares

Amount

paid-in

(USD)

InfraMed Infrastructure prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,000.- 2,000,000 20,000.-

Total:

20,000.- 2,000,000 20,000.-

All the shares have been fully subscribed and totally paid up by the above named shareholder so that the amount of

twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) is from this day on at the free disposal of the company.

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the 1915 Law, have been observed.

<i>Transitory provision

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2012.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholder resolved to set at two (2) the number of Managers and further resolved to appoint the followings as

Managers for an unlimited duration, with the powers set forth in Article 12 of the Articles of Incorporation:

- Mr. Frédéric Gilbert Ottavy, born on 24 May 1965, in Nice, France, with professional address at le 19 avenue de

l'Opéra, 75001 Paris;

- Mr. Alain Peigneux, born on 27 February 1968, in Huy, Belgium, with professional address at 283, route d'Arlon,

L-8011 Strassen.

99570

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The registered office shall be at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxy holder, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, first

name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le neuf août.
Pardevant Nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire des présentes.

A comparu:

«InfraMed Infrastructure», une société française ayant son siège social au 19, Avenue de l'Opéra, Paris 75001, France,

immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 522.811.413,

ici représentée par M. Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-duché

de Luxembourg),

en vertu d'une procuration donnée sous seing privée, datée du 2 août 2012.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser

l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les lois

du Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi de 1915»), par l'article 1832 du Code Civil ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé, propriétaire de la totalité des parts sociales.
La Société peut cependant, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés,

par suite notamment, de cession de parts sociales ou d'émission de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, y compris des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut également utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier et, à condition qu'un tel investissement

soit accessoire ou connexe à l'acquisition, la détention, l'administration, le développement et la gestion d'une société qui
fait partie du même groupe de sociétés que la Société, la Société peut investir dans des droits de propriété intellectuelle
ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette

similaires.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination de "InfraTaf Holding S.à r.l.".

Art. 4. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

des associés.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil, comme défini à l'Article 12, peut pareillement établir des succursales et des

filiales aussi bien au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,

économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication
aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement
le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxem-

99571

L

U X E M B O U R G

bourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le Gérant ou, le cas échéant,
le Conseil de la Société.

Art. 6. Capital. Le capital émis de la Société est fixé à vingt mille US Dollars (USD 20.000,-) divisé en deux millions

(2.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de US Dollar (USD 0,01) chacune, celles-ci étant en-
tièrement libérées.

Art. 7. Modification du capital. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant une résolution de

l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres parts sociales.

Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi de 1915 et les

Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de

la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d'un associé unique, ledit associé unique peut librement céder

ses parts.

Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément

donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, par application des
prescriptions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

Art. 11. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évé-

nement similaire de l'associé unique ou l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 12. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise par l'associé unique ou le cas échéant par une décision prise à

la majorité par l‘assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun
terme n'est indiqué, les Gérants sont élus pour une durée indéterminée.

Les Gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout

moment.

Au cas où il y aurait plus d'un Gérant, les Gérants constituent un conseil de Gérance (le «Conseil»).
Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de com-

munication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une
participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne.

Les Gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil par un autre Gérant, sans limitation quant au nombre

de procurations qu'un Gérant peut accepter et voter, étant entendu qu'au moins deux Gérants soient présents en per-
sonne ou par conférence téléphonique.

Une convocation écrite à toute réunion du Conseil devra être donnée aux Gérants au moins vingt-quatre (24) heures

à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de l'urgence
devront être mentionnées dans la convocation.

La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque Gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-

mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire
pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l‘heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par
le Conseil.

L'associé unique ou le cas échéant l'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des Gérants de deux

classes différentes, les Gérants de classe A et les Gérants de classe B. Une telle classification de Gérants devra être dûment
enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Gérants devront être identifiés en ce qui concerne la
classe à laquelle ils appartiennent.

Le Conseil ne peut agir ou délibérer validement que si une majorité des Gérants en fonction sont présents ou repré-

sentés.

99572

L

U X E M B O U R G

Les décisions du Conseil sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des Gérants de la Société (y

inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'associé unique ou l'assemblée générale des associés aurait
nommé différentes classes de gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B), toute résolution du
Conseil ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des Gérants, y inclus au moins un
Gérant de classe A et un Gérant de classe B.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil devront être signés par deux Gérants présents à cette réunion.
Le Conseil pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dument signés l'existence de la résolution. Les
résolutions des Gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous
la signature individuelle de tout Gérant.

Art. 13. Evénements affectant les Gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout autre événement

similaire affectant le Gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un Gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 14. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de
son mandat.

Art. 15. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle en cas de Gérant unique,

et en cas d'un Conseil, par la signature conjointe de deux Gérants, étant entendu cependant que si l'associé unique ou
l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de Gérants (à savoir les Gérants de classe A et les Gérants
de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant
de classe B (y inclus par voie de représentation).

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

de signature ont été délégués soit par le gérant; ou soit par deux Gérants en cas d'un Conseil ou encore; en cas de classes
de Gérants, par un Gérant de classe A et un Gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).

Art. 16. Assemblée générale des associés. Tant que la Société ne comporte qu'un (1) associé unique, celui-ci exerce

les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de
la Loi de 1915 ne sont pas applicables.

Lorsque  la  Société  est  composée  de  plusieurs  associés,  les  décisions  collectives  sont  prises  lors  d'une  assemblée

générale des associés ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux
associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote par écrit et de l'envoyer à la Société, dans un

délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle

se tiendra dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social au siège social de la Société ou en tout autre lieu à spécifier
dans la convocation de cette l'assemblée.

Art. 17. Décisions des associés. Les décisions collectives ne sont valablement prises pour autant que les associés

possédant plus que la moitié du capital les adoptent. Cependant, les décisions ayant pour objet une modification des
Statuts ne peuvent être adoptées qu'à la majorité (en nombre) des associés possédant au moins les trois quarts des parts
sociales de la Société, sauf dispositions contraires de la Loi de 1915. Le changement de la nationalité de la Société requiert
l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés lors d'une assemblée des associés, et s'ils déclarent connaître l'ordre

du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, seront établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social de la Société.

Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

Art. 18. Année sociale. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre

de l'année suivante.

Art. 19. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes annuels de la Société sont établis

par le Gérant ou, le cas échéant, par le Conseil et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil dresse un inventaire général
comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite peut prendre connaissance desdits inventaires et

bilans au siège social de la Société.

99573

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des

frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil peut décider de payer à l'associé unique ou, le cas échéant, aux

associés des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir
que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas
excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi de 1915
ou des Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés
seront remboursées par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.

Art. 21. Dissolution, Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l'insolvabilité ou de la faillite d'un des associés.

La liquidation de la Société sera décidée par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée des associés en con-

formité avec les dispositions légales applicables.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

selon le cas par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Disposition générale. Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents Statuts seraient régies

conformément à la Loi de 1915.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en

numéraire les montants ci après énoncés:

Associé

Capital

souscrit

(USD)

Nombre

de parts

sociales

Libération

(USD)

InfraMed Infrastructure prénommée; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,- 2.000.000

20.000,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,- 2.000.000

20.000,-

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées de sorte que la somme de vingt

mille US Dollars (USD 20.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la société

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l'article 183 de la Loi de 1915, ont été respectées.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2012.

<i>Evaluations des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à mille cinq cents Euros (1.500.-EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique prénommé, par le mandataire susnommé, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire

et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de fixer à deux (2) le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que

Gérants pour une période indéterminée, avec les pouvoirs prévus à l'article 12 des Statuts:

- Monsieur Frédéric Gilbert Ottavy, né le 24 mai 1965 à Nice, France, résidant professionnellement au le 19 avenue

de l'Opéra, 75001 Paris;

- Monsieur Alain Peigneux, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, résidant professionnellement au 283, route d'Arlon,

L-8011 Strassen;

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

99574

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la partie comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même partie et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite par le mandataire de la partie comparante, connu par le notaire par son nom, prénom, état et

demeure, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. GALIOTTO et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 août 2012. Relation: LAC/2012/38424. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 août 2012.

Référence de publication: 2012106299/431.
(120144873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2012.

Gift Productions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 124.587.

L'an deux mille douze, le onze juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «GIFT PRODUCTIONS

S.A.», ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 8 février 2007, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 719 du 26 avril 2007.

L'assemblée est présidée par Madame Lidia KEISER-LOGUTOVA, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

qui assume également la fonction de scrutateur.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée

générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Emile WIRTZ, consultant, avec adresse professionnelle à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, né à

Luxembourg, le 27 septembre 1963.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

99575

L

U X E M B O U R G

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. KEISER-LOGUTOVA, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juillet 2012. Relation: LAC/2012/33161. Reçu douze euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090784/54.
(120127954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Energies Van Kasteren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 163.307.

L'an deux mille douze, le vingt-neuf juin,
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

A comparu

l'associé unique (l'Associé) de la société à responsabilité limité de droit luxembourgeois "Energies Van Kasteren S.à

r.l.", ayant son siège social au 209 rue des Romains, L-8041 Bertrange, au capital social de EUR 100.000.-, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.307, constituée suivant acte de Maître Henri
BECK, notaire résident à Echternach (Grand-Duché du Luxembourg), le 2 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N° 2633 du 28 octobre 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés
depuis leur publication:

La société M Energies, une société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social au 96 Impasse Pierre

et Marie Curie, F-54170 Ludres, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le n° B 449.469.113,

ici  représenté  par  Gabrielle  DE  CARRERE,  avocate,  domiciliée  professionnellement  à  Luxembourg  (le  «Fondé  de

Pouvoir»), en vertu d'une procuration sous seing privé du 28 juin 2012.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné

restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée.

La partie comparante, telle que représentée ci-dessus, déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. les cent mille (100.000.-) parts sociales d'une valeur nominale de un euro ( EUR 1.-) chacune représentant l'entièreté

du capital votant de la Société de cent mille euros (EUR 100.000.-) sont dûment représentées à l'assemblée qui est par
conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour reproduit ci-après.

II. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle au 4, rue des Joncs, hall n°3, L-1818 Hesperange et

modification subséquente de l'article 4 des Statuts;

2. Suppression de classe C de gérants, modification des pouvoirs des gérants et modification subséquente de l'article

8 des Statuts; et

4. Divers.
Après délibération, l'Associé a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 4, rue des Joncs, hall n°3, L-1818

Howald (Hesperange), avec effet à la date des présentes. En conséquence l'Associé décide de modifier l'article 2.1 des
Statuts comme suit:

« Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la

commune de Hesperange par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut
être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.»

<i>Deuxième résolution

L'Associé décide de supprimer la classe C de gérants et modifier les pouvoirs des gérants.

99576

L

U X E M B O U R G

En conséquence, l'Associé décide de modifier le paragraphe 1 de l'article 8 des Statuts comme suit:

« Art. 8. Conseil de gérance Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil),

composé de gérant(s) de classe A et de gérant(s) de classe B. Toute référence dans les Statuts aux gérants, sans mention
de leur classe, désignera les gérants de toute classe.»

L'Associé décide de modifier l'article 8.1. paragraphe (ii) des Statuts comme suit:
«(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques par

(i) un gérant de classe A ou (ii) un gérant de classe A conjointement avec un gérant de classe B ou (iii) le Conseil.»

L'Associé décide de modifier l'article 8.2. paragraphe (v) des Statuts comme suit:
«(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que (i) si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et (ii) si au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil
sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, au cas où la majorité n'est pas
atteinte, la voix du ou des gérants de classe A est prépondérante. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents
ou représentés.»

L'Associé décide de modifier l'article 8.3. des Statuts comme suit:

« Art. 8.3. Représentation. La Société est engagée vis-à-vis des tiers:
(i) par la seule signature d'un gérant de classe A;
(ii) jusqu'à concurrence d'un montant de dix mille euros (EUR 10.000.-) par la seule signature d'un gérant de classe B;
(iii) pour tout montant supérieur à dix mille euros (EUR 10.000.-), par (i) la seule signature d'un gérant de classe A ou

(ii) par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B;

(iv) par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués en vertu de l'article 8.1.; et
(v) Pour tout montant supérieur à cinquante mille euros (EUR 50.000.-), les gérants de classe A et B devront être

préalablement informés.»

<i>Troisème résolution

Le siège social est établi au 4, rue des Joncs,hall n°6, L-1818 Howald (Hesperange).
Plus rien n'étant à l'odre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société au titre

du présent acte, est estimé à six cent soixante-cinq euros (EUR 665.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: DE CARRERE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2012. Relation: LAC/2012/30545. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090712/81.
(120127979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Ravago Production S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 136.281.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu par voie circulaire

Les Administrateurs élisent en leur sein, conformément aux dispositions de l’article 64 (2) de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, un Président en la société Ravago Management S.à R.L., représentée par Mme
Gunhilde VAN GORP, Représentant Permanent. La société assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Certifié sincère et conforme
RAVAGO PRODUCTION S.A.
Benoît PARMENTIER / Leo CAERS
<i>Administrateur / Administrateur

99577

L

U X E M B O U R G

<i>Extract of the resolutions of the circular Board of Directors

According to the article 64 (2) of the law dated August 10 

th

 , 1915 relating to commercial companies, the Directors

decide to appoint Ravago Management S.à R.L., represented by Mrs. Gunhilde VAN GORP, Permanent Representative,
as Chairman of the Board. The company acts as Chairman for the whole period of his mandate.

Luxembourg, July 13 

th

 , 2012.

For true copy
RAVAGO PRODUCTION S.A.
Benoît PARMENTIER / Leo CAERS
<i>Director / Director

Référence de publication: 2012091036/25.
(120128300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

TREVOR &amp; Company, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg E 4.837.

STATUTS

L'an deux mille douze, le premier juillet.

Ont comparu:

1)  -  Monsieur  James  SEINE,  né  le  19  mars  1963  à  NEUILLY  SUR  SEINE  (France),  avec  adresse  professionnelle  à

Luxembourg (L-2530). 6, rue Henri Schnadt

2) - B.E.S.Trading limited Luxembourg, enregistrée au Grand Duché du Luxembourg sous le numéro B134923 en date

du 11/01/2008, avec adresse à Luxembourg (L-2530). 6, rue Henri Schnadt, valablement représentée par son Directeur.

Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société civile, qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'exploitation d'immeubles à acquérir

exclusivement pour son propre compte, tant au Luxembourg qu'à l'étranger. La société sera habilitée à procéder à toute
division ou le remembrement de parcelles ainsi que la vente d'immeubles lut appartenant. La société est autorisée à se
porter caution au profit de ses associés. Elle pourra réaliser toutes opérations pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social.

Art. 2. La société prend la dénomination de TREVOR &amp;. Company.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par anticipation par décision

de l'assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité des voix et des participants.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Art. 5. Le capital social est fixé à mille euro (EUR 1.000.-), représenté par cent (100) parts d'une valeur nominale de

dix euro (EUR 10,-) chacune, réparties comme suit:

Parts

a) Monsieur James SEINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

b) B.E.S.Trading limited Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de mille euro

(EUR l .000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 6. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l'article 1690 du

Code Civil. Sous réserve de conventions particulières entre associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Sous réserve de conventions particulières entre associés, elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu'avec
l'agrément des associés décidant à l'unanimité.

Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés. L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la
déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société qui continuera entre les autres associés, à
l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture. Chaque part
est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire
représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte
de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

99578

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre de parts existantes.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés

à la majorité des parts sociales.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

Art. 11. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se réunissent en assemblée générale et prennent, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le nombre de gérant est fixé à un ( l ). Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur James SEINE, prénommé.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances à l'égard des tiers par la signature individuelle du

gérant. Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

2) Le siège social de la société est établi à Luxembourg (L-2530) 6, rue Henri Schnadt Luxembourg,

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Monsieur James SEINE / B.E.S.Trading limited Luxembourg
- / Signature

Référence de publication: 2012091154/61.
(120127694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Alysea Luxembourg Les Soins S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 159.837.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 13 avril 2012

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 avril 2012 que:
1. Administrateur, démissionnaire avec effet au 4 avril 2012:
Madame Claude Hemmer
7, place du Château
F-57330 Roussy Le Bour
2. Administratrice-déléguée, démissionnaire, avec effet au 4 avril 2012:
Madame Claude Hemmer
7, place du Château
F-57330 Roussy Le Bour
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090552/20.
(120128332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Heirens Constructions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7738 Colmar-Berg, Zone Industrielle, route de Cruchten.

R.C.S. Luxembourg B 102.858.

<i>Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société HEIRENS CONSTRUCTIONS SARL tenue le 15/06/2012 au

<i>siège social à L-7738 Colmar-Pont, Zone Industrielle, route de Cruchten

<i>Résolutions:

<i>Cession de parts

En date du 15 juin 2012, Madame Liette REISCH, née à Luxembourg le 21 février 1951, demeurant à L-7593 Beringen,

17, rue Wenzel, propriétaire de 270 (deux cent soixante-dix) parts sociales dans la Société, a déclaré céder 140 (cent
quarante) parts sociales à Madame Tanja HEIRENS, née à Luxembourg le 13 décembre 1973, demeurant à L-7594 Be-
ringen, 9, rue des Noyers, ainsi que de céder 30 (trente) parts sociales à Monsieur Robert HEIRENS, né à Ettelbruck le
15 mai 1947, demeurant à L-7593 Beringen, 17, rue Wenzel.

99579

L

U X E M B O U R G

Les cessionnaires sont propriétaires des parts cédées dès ce jour et ils en auront la jouissance et seront subrogés dans

tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

<i>Acceptation

Tous les associés ainsi que le gérant de la société Monsieur Frank SCHULLER consentent aux cessions de parts ci-

avant mentionnées, conformément à l'article 1690 du Code Civil, tant en nom personnel qu'au nom et pour compte de
la société et les tiennent pour valablement signifiées à la société et à eux-mêmes.

Depuis cette date, les parts sociales de la Société sont distribuées comme suit:

Monsieur Frank Schuller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 parts sociales
Monsieur Robert Heirens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 parts sociales
Madame Tanja Heirens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
Madame Liette Reisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 parts sociales

approuvé par la signature des associés.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la réunion est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par les associés.

Frank SCHULLER / Robert HEIRENS / Tanja HEIRENS / Liette REISCH
9, rue des Noyers / 17, rue Wenzel / 9, rue des Noyers / 17, rue Wenzel
L-7594 BERINGEN / L-7593 BERINGEN / L-7594 BERINGEN / L-7593 BERINGEN
380 parts sociales / 270 parts sociales / 250 parts sociales / 100 parts sociales

Référence de publication: 2012090813/34.
(120128486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Antarex International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 52.257.

<i>Décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 juin 2012.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2014 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

<i>Administrateurs de catégorie A:

Mme  Manuela  D'Amore,  résidant  professionnellement  au  19-21  Boulevard  du  Prince  Henri,  L-1724  Luxembourg,

administrateur;

M. Giovanni Spasiano, résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, ad-

ministrateur et président;

<i>Administrateur de catégorie B:

MM Alfio Riciputo, demeurant professionnellement 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, adminis-

trateur;

Leonardo Miocchi, demeurant professionnellement 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, adminis-

trateur;

Marco Gostoli, demeurant professionnellement 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 68 Rue de Koerich, L-8437 Steinfort.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2012090580/29.
(120127917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

99580

L

U X E M B O U R G

Heron Optique et Audition S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 146.870.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 18 juillet 2012 tenue au siège de la société

Le mandat du Commissaire aux Comptes, à savoir la Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie Sàrl, ayant son siège au 63-65

rue de Merl, est reconduit jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>HERON OPTIQUE ET AUDITION S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012090816/15.
(120128068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Cape Cod SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 69.000,00.

Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 84.461.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2011 a décidé:
- L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de M. Christian SCHMIDT, né le 26 novembre 1964 à

METZ (France), administrateurs de sociétés, demeurant à L-8227 MAMER (Luxembourg), 2, Rue des Eglantiers pour une
période venant à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31
décembre 2013,

Ce renouvellement de mandat est fait à titre rétroactif à compter du 31/12/2007 pour une durée de 6 ans,
- L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de M. PERINO Christophe, né le 12 septembre 1966 à

BRIEY (France), gérant de société, demeurant à F-57935 LUTTANGE (France), 9, Rue de Metz, pour une période venant
à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2013.

Ce renouvellement de mandat est fait à titre rétroactif à compter du 31/12/2007 pour une durée de 6 ans.
- L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de M. LAURENT Lionel, né le 13 décembre 1952 à

ROCQUIGNY (France), administrateur de sociétés, demeurant à F-57580 ANCERVILLE (France), 48, Rue Saint Michel
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant
le 31 décembre 2013.

Ce renouvellement de mandat est fait à titre rétroactif à compter du 31/12/2007 pour une durée de 6 ans.
- L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de M GRAFF Cyril, né le 6 avril 1973 employé, demeurant

à F-54700 MONTAUVILLE, 400 av Général Eisenhower, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2013.

Ce renouvellement de mandat est fait à titre rétroactif à compter du 31/12/2007 pour une durée de 6 ans.
- L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur délégué de M. PERINO Christophe, né le 12 septembre

1966 à BRIEY (France), gérant de société, demeurant à F-57935 LUTTANGE (France), 9, Rue de Metz, pour une période
venant à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre
2013.

Ce renouvellement de mandat est fait à titre rétroactif à compter du 31/12/2007 pour une durée de 6 ans.
- L'assemblée générale donne le mandat de commissaire aux comptes à Madame Anne-Flora JARDEL, née le 10/08/1971

à Denain (France), demeurant 32, rue Mangin 57000 METZ

Cette nomination au mandat de commissaire aux comptes est faite à titre rétroactif à compter du 31/12/2007 pour

une durée de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Dudelange, le 6 février 2012.

<i>Pour CAPE COD SA
Lionel LAURENT / Cyril GRAFF / Christophe PERINO

Référence de publication: 2012090652/41.
(120128220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

99581

L

U X E M B O U R G

Luxpromo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 49.917.

La société KAPPWEILER S.C.I. dénonce, avec effet immédiat, le siège social de la société LUXPROMO S.à.r.l., imma-

triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 49 917.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012090911/13.
(120128425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

CVIC Lux Securities Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CVIC Lux Securities Trading).

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 164.812.

In the year two thousand and twelve, on the fourth day of July.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) CVIC Lux Master, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg trade and companies' register under number B 164.791 (Lux Master), duly represented by one of its A managers
Mrs Cécile GADISSEUR; and

2) CVIC Lux Finance, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg  trade  and  companies'  register  under  number  B  164.800  (Lux  Finance  and,  together  with  Lux  Master,  the
Shareholders), duly represented by one of its managers Mrs. Cécile GADISSEUR.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that:
I. Lux Master and Lux Finance are the shareholders of CVIC Lux Securities Trading, a société à responsabilité limitée

having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies' register under number B 164.812 incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing
in Junglinster, on October 28 

th

 , 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on December

29 

th

 , 2011, number 3205 (the "Company"). The articles of association have not yet been amended since.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Amendment to the name of the Company from "CVIC Lux Securities Trading" to "CVIC Lux Securities Trading S.à

r.l.";

2. Amendment to article 4 of the Articles.
Now, therefore, the appearing parties have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into "CVIC Lux Securities Trading S.à r.l." with

effect as of June 29 

th

 , 2012.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the articles of asso-

ciation, which will henceforth have the following wording:

Art. 4. The Company will have the name CVIC Lux Securities Trading S.à r.l.."

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present, is approximately one thousand two hundred euro (EUR
1,200).

99582

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and
the German text, the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendzwölf, am vierten Juli.
Vor der unterzeichneten Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amssitz in Luxembourg.

SIND ERSCHIENEN:

1) CVIC Lux Master, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 11-13,

boulevard  de  la  Foire,  L-1528  Luxembourg,  eingetragen  im  luxemburgischen  Handelsregister  unter  der  Nummer  B
164.791 (Lux Master), hier rechtsmäßig vertreten durch einer ihrer Geschäftsführer der Kategorie A Frau Cécile GA-
DISSEUR; und

2) CVIC Lux Finance, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 11-13,

boulevard  de  la  Foire,  L-1528  Luxembourg,  eingetragen  im  luxemburgischen  Handelsregister  unter  der  Nummer  B
164.800 (Lux Finance), hier rechtsmäßig vertreten durch einer ihrer Geschäftsführer Frau Cécile GADISSEUR.

Die Gesellschafter haben den unterzeichneten Notar ersucht, folgendes festzuhalten:
I. Lux Master und Lux Finance sind die Gesellschafter von CVIC Lux Securities Trading, einer "société à responsabilité

limitée" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-1528 Luxemburg, 11-13,
boulevard de la Foire ("die Gesellschaft") eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Num-
mer B 164.812, gegründet am 28. Oktober 2012 gemäss einer Urkunde der Notar Maître Jean Seckler, mit Amtssitz in
Junglinster, veröffentlicht am 29. Dezember 2012 im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, unter Nummer
3205. Die Satzung der Gesellschaft wurde seither noch nicht abgeändert.

II. Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt:
1. Änderung des Namens der Gesellschaft von CVIC Lux Securities Trading in CVIC Lux Securities Trading S.à r.l.;
2. Änderung vom Artikel 4 der Satzung.
Heute haben die Erschienenen Parteien den unterzeichneten Notar ersucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den Firmennamen der Gesellschaft in "CVIC Lux Securities Trading S.à r.l." zu ändern

rückwirkend zum 29. Juni 2012.

<i>Zweiter Beschluss

Als Resultat des obigen Beschlusses, beschließen die Gesellschafter Artikel 4 der Satzung wie folgt zu ändern:

Art. 4. Die Gesellschaft wird den Firmennamen CVIC Lux Securities Trading S.à r.l. tragen."

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben und Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft entstehen oder ihr in Zusammenhang mit der

vorliegenden Urkunde in Rechnung gestellt werden, belaufen sich auf ungefähr eintausendzweihundert Euro (1.200.- EUR).

Da es keine weiteren Tagesordnungspunkte zu besprechen gibt, wird die Versammlung geschlossen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht, bestätigt, dass auf Verlangen der erscheinenden Partei,

die Urkunde auf englisch verfasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle von Diskrepanzen die
englische Version bindend sein soll.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichen  Vornamen,  sowie  Stand  und  Wohnort  bekannten,  haben  dieselben  mit  dem  Notar  gegenwärtige  Urkunde
unterschrieben.

Signé: C. Gadisseur et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juillet 2012. LAC/2012/31715. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

99583

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 25 juillet 2012.

Référence de publication: 2012093252/93.
(120129681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Châteaux Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3598 Dudelange, 12A, route de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg B 82.498.

<i>Extrait du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 17 juillet 2012

<i>pour statuer sur les comptes au 31 décembre 2011

L’Assemblée Générale constate que les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance et décide de renouveler

les mandats de Madame Eve CLAUSSE, Monsieur Pascal CLAUSSE et Monsieur Marc LOEFFLER pour une durée de 6
ans. Les mandats des administrateurs prendront fin en 2018, à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

L’Assemblée Générale constate que le mandat du commissaire aux comptes arrive à échéance et décide de renouveler

le mandat de la société MGI FISOGEST S.àr.l. pour une durée de 6 ans. Le mandat du commissaire aux comptes prendra
fin en 2018, à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 17 juillet 2012

Les membres du Conseil d’Administration décident de renouveler le mandat de Président du Conseil d’Administration

de Monsieur Pascal CLAUSSE, préqualifié, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2018 et se
prononcera sur l’exercice clôturé le 31 décembre 2017.

Les membres du Conseil d’Administration décident de renouveler le mandat d’administrateurdélégué de Monsieur

Clausse PASCAL, préqualifié, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2018 et se prononcera
sur l’exercice clôturé le 31 décembre 2017.

Référence de publication: 2012090665/23.
(120128347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Saxon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 152.145.

EXTRAIT

1. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2012 que:
- Les démissions de Madame Florence Rao et de Monsieur Jorge Pérez Lozano ont été acceptées et prennent effet au

9 juillet 2012.

- Ont été élus gérants de la Société à compter du 9 juillet 2012 et pour une durée indéterminée:
* Monsieur Philip Godley, né le 21 mars 1974 à Sheffield (Royaume Uni), résidant professionnellement au 51, avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

* Monsieur Peter Dickinson, né le 1 

er

 mars 1966 à Nuneaton (Royaume Uni), résidant professionnellement au 51,

avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

* Madame Geneviève Blauen-Arendt, née le 28 septembre 1962 à Arlon (Belgique), résidant professionnellement au

231, val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg;

* Monsieur Marc Schmit, né le 13 mai 1959 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), résidant professionnelle-

ment au 231, val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

2. Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 juillet 2012, que le conseil d’administration

a décidé à l’unanimité et avec effet rétroactif:

- Que le siège social de la société est transféré au 51 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à compter du 9

juillet 2012

- Le siège social de l’associé unique, STICHTING ASTERIX a été transféré au 88 Spoorhaven, 2651AV Berkel En

Rodenrijs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

99584

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A

Référence de publication: 2012091080/31.
(120128058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Teknimed International S.A., Société Anonyme,

(anc. Intekbio S.A.).

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 90.675.

L'an deux mille douze, le onze juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société INTEKBIO S.A., établie et ayant son

siège social à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 90.675, constituée suivant
acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23
décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 162 du 15 février 2003. Les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Lu-
xembourg, en date du 21 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 638 du 21
juin 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Annick BRAQUET, demeurant professionnellement à L-1319

Luxembourg, 101, rue Cents.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, demeurant professionnellement à

L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, demeurant professionnel-

lement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille cent

actions sans désignation de valeur nominale, constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros, sont
dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté
de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés restera annexée au

présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la dénomination sociale.
2. Divers.
L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement consti-

tuée et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en TEKNIMED INTERNATIONAL S.A. de sorte

que le premier alinéa de l’article 1 

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

“Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TEKNIMED INTERNATIONAL S.A.”
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.
Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, P. CHANTEREAU et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juillet 2012. Relation: LAC/2012/33166. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090833/49.
(120127997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

99585

L

U X E M B O U R G

Presse Européenne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1615 Luxembourg, 2, rue Alcide de Gaspéri.

R.C.S. Luxembourg B 157.388.

L’an deux mil douze, le dix-septième jour de juillet.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

Madame Francesca MAGALDI, commerçante, née à Lanciano (Italie), le 21 juin 1954, demeurant à F-57270 Richemont,

15 rue de Bévange, (l’«Associé unique»);

Laquelle comparante déclare être l’associé unique de la société «Presse Européenne S.à r.l.», ayant son siège social à

L-6660 Born, 8, Sauergaass, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le
numéro 157.388, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12
novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 241 en date du 5 février 2011.

L’associé unique a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de L-6660 Born, 8, Sauergaass à L-1615 Luxembourg, 2, rue Alcide

de Gaspéri, Bâtiment Jean Monnet.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’associé unique décide de modifier l'article 5 (alinéa 1 

er

 ) des statuts:

Art. 5. (Alinéa 1 

er

 ).  "Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg".

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire

soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Francesca Magaldi, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 juillet 2012. LAC / 2012 / 34013. Reçu 75.-

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012093652/37.
(120129692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Euro-Zone Office Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 104.157.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 28 juin 2012 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur

les comptes de l'exercice 2012, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de Groote, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxem-

bourg, Président du Conseil;

- Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Willem Hopman, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 111 Jachthavenweg, NL-1081 KM Ams-

terdam, Pays-Bas.

99586

L

U X E M B O U R G

A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur

les comptes de l'exercice 2011:

- Ernst &amp; Young S.A., ayant son siège social au 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activités Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
Référence de publication: 2012090737/19.
(120127885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Luxembourg Food &amp; Beverage S.à r.l., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 68.452.

<i>Résolution prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 13 avril 2012:

L'Assemblée prend note du changement d'adresse de l'associé et gérant Monsieur Alain DUTOURNIER, domicilié

professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AKELYS EUROPEAN SCORE
20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012090908/14.
(120128135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Champagne Invest, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

R.C.S. Luxembourg B 66.467.

FIDUCIS S.à r.l. dénonce le siège social de CHAMPAGNE INVEST SPF, Société anonyme (R.C.S. Luxembourg B 66.467)

situé 12, route d’Arlon à 1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090666/9.
(120128436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 5.735.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Maître Léonie Grethen
<i>Notaire

Référence de publication: 2012090678/12.
(120128108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Concept Live S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 13, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 120.394.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2012090679/12.
(120128488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

99587

L

U X E M B O U R G

Financière Palladio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 89.682.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

La clôture de la liquidation de la Société a été prononcée par l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date

du 29 juin 2012, au siège social de la société.

Il résulte de cette Assemblée que:
Tous les livres et des documents sociaux seront déposés et conservés au siège social, au 1, rue des Glacis, L-1628

Luxembourg, durant la période de 5 années à compter de la date de publication de l’Assemblée Générale statuant sur la
clôture de la liquidation.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Le liquidateur

Référence de publication: 2012090747/21.
(120127809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Cordouan Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 59.672.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 17 juillet 2012 les décisions suivantes

ont été prises:

1) La démission de Monsieur Horst SCHNEIDER de ses fonctions d'Administrateur-Délégué et d'Administrateur est

acceptée.

2) Est nommé jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les Comptes Annuels clôturant au 31 décembre 2012:
- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale

ordinaire du 17 juillet 2012 a nommé comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Administrateur, Madame
Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2012090681/18.
(120127892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Danube SCA SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 149.983.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire Gérant Commandité Danube Management S.A.R.L. le 15 juin 2012

Il résulte d'une décision prise par l'Actionnaire Gérant Commandité que, avec effet au 7 juillet 2012, la Société a

transféré son siège du 46a avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Il est à noter que l'Actionnaire Gérant Commandité Danube Management S.A.R.L. a également changé d'adresse et

est à présent domicilié au 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

99588

L

U X E M B O U R G

Signé à Luxembourg, le 24 juillet 2012.

<i>Pour Danube SCA SICAR
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012090686/18.
(120128452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Eurofins Pharma Services France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 165.605.

Il est constaté que la société «Eurofins France Holding», une société par actions simplifiée de droit français avec siège

social à F-67700 Saverne, 20, rue de Kochersberg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Saverne sous le
numéro 528 643 000, détentrice de l’intégralité des parts sociales représentatives du capital de la société à responsabilité
limitée «Eurofins Pharma Services France LUX Holding», avec siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M.
Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B165605, a transféré en date
du 14 décembre 2011, son siège social à l’adresse suivante: site de la Géraudière, rue Pierre Adolphe Bobierre F-44300
Nantes, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro TI 528 643 000 (Dépôt de l’acte au
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 1937).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2012090718/18.
(120128448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Diapason Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 163.245.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090697/10.
(120128244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Universal Premium Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.538.

In the year two thousand and twelve, on the twelfth of July
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, was held an extraordinary general meeting of the

sole shareholder of Universal Premium Holding S.A. (the "Company"), with registered office at 21 rue des Près, L-8147
Bridel, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 148.538, incorporated by a deed of
Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, on September 30, 2009, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C number 2129 dated October 30, 2009.

The general meeting is opened at 5:00 pm and Yannick Deschamps, Lawyer, residing professionally in Luxembourg is

elected chairman of the meeting.

Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg is appointed secretary and scrutineer.
The chairman then declared and requested the notary to state the following:
I.- The sole shareholder is represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be annexed
to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the shares in issue are represented at the present extraordinary general

meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholder declares having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the present meeting is the following:

99589

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

Decision to transfer the registered office of the Company to 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and to modify

the first sentence of article 4 of the articles of incorporation as follows:

"The registered office is established in Luxembourg in the Grand Duchy of Luxembourg."
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company to 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

and to modify the first sentence of article 4 of the articles of incorporation as follows:

"The registered office is established in Luxembourg in the Grand Duchy of Luxembourg."
There being no further business, the Meeting is closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present

deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons, appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le douze juillet.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire

de l'actionnaire unique de Universal Premium Holding S.A. (la «Société») ayant son siège social au 21, rue des Près, L-8147
Bridel dûment enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro B. 148.538 et constituée suivant acte notarié de
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 septembre 2009 et publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 2129 daté du 30 octobre 2009.

L'assemblée est ouverte à 17h00 et Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, est élu

président de l'assemblée.

Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg est nommée secrétaire et

scrutateur.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:
I.- Que l'actionnaire unique est représenté et le nombre d'actions détenues par lui sont indiqués sur une liste de

présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que la procuration
seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les actions émises sont représentées à la présente assemblée

générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour dont l'actionnaire déclare avoir parfaite connaissance.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

Décision de transférer le siège social de la Société au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et de modifier la

première phrase de l'article 4 des statuts comme suit:

"Le siège social est établi à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg."
Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et de modifier

la première phrase de l'article 4 des statuts comme suit:

"Le siège social est établi à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg.."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi de la version française, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la
version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y. DESCHAMPS, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juillet 2012. Relation: LAC/2012/33176. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

99590

L

U X E M B O U R G

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012091158/79.
(120128281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Société Luxembourgeoise des Mines, Société Anonyme,

(anc. Dininvest S.A.).

Enseigne commerciale: SOLUMINES.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 60.774.

L'an deux mille douze, le onze juillet.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société DININVEST S.A., établie et ayant son

siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 60.774, constituée
suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 5 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 696 du 11 décembre 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Annick BRAQUET, demeurant professionnellement à L-1319

Luxembourg, 101, rue Cents.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, demeurant professionnellement à

L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, demeurant professionnel-

lement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille cent

actions sans désignation de valeur nominale, constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros, sont
dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté
de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés restera annexée au

présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la dénomination sociale et ajout d’une enseigne commerciale.
2. Divers.
L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement consti-

tuée et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée  décide  de  changer  la  dénomination  sociale  de  la  société  en  Société  Luxembourgeoise  des  Mines,  et

d’ajouter une enseigne commerciale de sorte que la première phrase de l’article 1 

er

 des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de Société Luxembourgeoise des Mines. Elle aura également

pour enseigne commerciale: SOLUMINES.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.
Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, P. CHANTEREAU et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juillet 2012. Relation: LAC/2012/33164. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090699/48.
(120127986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

99591

L

U X E M B O U R G

Dorn Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 118.967.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de notre société, tenue en date du 30 mai 2012 que:
- Décision a été prise de renouveler les mandats d’administrateurs de:
* Monsieur Roger GREDEN, né le 28.10.1953 à Arlon (Belgique), demeurant à L-2273 Luxembourg, 4A rue de l’Ouest,
* Monsieur Pierre-Paul BOEGEN, né le 20.10.1948 à Arlon (Belgique), demeurant B-6700 Arlon, 65 rue de Freylange,
* Madame Nelly NOEL, née le 26.10.1946 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-2440 Luxembourg, 121 rue de Rollin-

gergrund.

- Décision a été prise de renouveler le mandat du commissaire aux comptes EP INTERNATIONAL SA, avec siège

social au 20, rue Michel Rodange à L-2430 Luxembourg, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
sous le numéro B130232.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société

Référence de publication: 2012090704/20.
(120128501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Telenet Finance IV Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 161.083.

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires en date du 20 juillet 2012

1. Monsieur Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de membre du conseil de surveillance.
2. Monsieur Jonathan LEPAGE a démissionné de son mandat de membre du conseil de surveillance.
3. Monsieur Pietro LONGO a démissionné de son mandat de membre du conseil de surveillance.
4. M. Alexandre TRUTT, administrateur de sociétés, né le 11 juin 1967 à Paris (France), avec adresse professionnelle

à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, a été nommé comme membre du conseil de surveillance jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de 2017.

5. M. Frank PRZYGODDA, administrateur de sociétés, né le 28 février 1968 à Bochum (Allemagne), avec adresse

professionnelle à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, a été nommé comme membre du conseil de surveillance
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2017.

6. M. Christophe DAVEZAC, administrateur de sociétés, né le 14 février 1964 à Cahors (France), avec adresse pro-

fessionnelle à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, a été nommé comme membre du conseil de surveillance jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2017.

7. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1882 Luxem-

bourg, 5, rue Guillaume Kroll.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Telenet Finance IV Luxembourg S.C.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012091121/26.
(120127945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Princess Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 62.055.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 juillet 2012.

En date du 20 juillet 2012, l'assemblée générale des actionnaires approuve la nomination de Monsieur Patrick WIL-

WERT, né le 30.07.1977 à Luxembourg, demeurant professionnellement 36, rue Emile Mayrisch à L-4240 ESCH-SUR-
ALZETTE, au poste d'administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

99592

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012091022/13.
(120127942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Edison Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 152.810.

DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le vingt juillet.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme «Edison Investissements SPF S.A.», établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 102,

Boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151773,

ici représentée par Madame Isabelle SCHAEFER, employée privée, demeurant professionnellement à L-2763 Luxem-

bourg, 12, rue Sainte Zithe, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à elle,

laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il

suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "Edison Participations SARL", établie et ayant son siège social à L-2320

Luxembourg, 102, Boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 152810, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 20 avril 2010, publié au Mémorial C numéro 1235 du 14 juin 2010.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "Edison Participations SARL", pré-qualifiée, s'élève ac-

tuellement à QUINZE MILLE EUROS (€ 15.000,-), représenté par CENT CINQUANTE (150) parts sociales d'une valeur
nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la comparante en sa qualité d'associé unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation

financière de la susdite société "Edison Participations SARL".

IV.- Que la comparante est propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique

elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que la comparante déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'elle prend à sa charge tous les

actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est
achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2320 Luxembourg,

102, Boulevard de la Pétrusse.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Schaefer, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9802. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090707/47.
(120127965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

99593

L

U X E M B O U R G

TETRA Kayser Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 158.880.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TETRA Kayser Associés S.A.

Référence de publication: 2012093815/2.
(120130075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2012.

Saxon Energy Services Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.447.874,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.595.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 4 juillet 2012.

En date du 4 juillet 2012 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Johan Dejans, en tant que gérant de Classe B de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Hille-Paul Schut, salarié, né le 29 septembre 1977 à 's-Gravenhage aux Pays-Bas, demeurant profession-

nellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de Classe B de la Société pour une
durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

<i>Gérant de Classe A:

- Jim McKee

<i>Gérants de Classe B:

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Hille-Paul Schut
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Hille-Paul Schut
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012091060/24.
(120128236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Elizabeth Verwaltung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 152.587.

<i>Extrait du procès verbal d'une réunion du Conseil de gérance tenue le 6 juillet 2012

Il résulte d'une décision prise par le conseil de gérance que, avec effet au 7 juillet 2012, la Société a transféré son siège

du 46a avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Il est à noter que l'adresse professionnelle des gérants de catégorie A Cliff Langford et Renaud Labye, et du gérant de

catégorie B Stephen Burnett, se trouve à présent au 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

L'associé unique Red Shield Management S.A. a également transféré son siège social du 46a avenue John F Kennedy,

L-1855 Luxembourg au 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

<i>Pour Elizabeth Verwaltung S.à r.l.
Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2012090709/20.
(120127805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

99594

L

U X E M B O U R G

Energies Van Kasteren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 163.307.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2012090713/11.
(120128472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Intelprop S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 52.253.

<i>I. Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale tenue le 08 juin 2012

<i>4 

<i>ème

<i> Résolution:

Le mandat de deux Administrateurs et du Commissaire étant arrivé à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur de Monsieur Christophe
BLONDEAU (Président du Conseil d'Administration) jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se
tiendra en 2017.

L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de Madame Cornelia METTLEN et

décide de la remplacer par Madame Michèle DETAILLE demeurant professionnellement au Zone d'Activités Salzbaach,
L-9559 Wiltz, Luxembourg jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2017.

L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat du Commissaire Lauren Business Limited et décide de

nommer comme nouveau Commissaire,Madame Annette MICHELS demeurant au 13, route de Peppange, L-3378 LI-
VANGE, avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2017.

Le mandat d'Administrateur de Monsieur Dominique Ransquin est renouvelé avec effet au 19 septembre 2011 jusqu'à

l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour INTELPROP S.A.

Référence de publication: 2012090835/23.
(120128318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Energy Investments Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 57.675.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090715/10.
(120128499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Ets. Bourgeois S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 40.176.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2012090717/12.
(120128489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

99595

L

U X E M B O U R G

Extenso Int. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 45.873.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 juin 2012 que:
Madame Giulia Garzotto, née le 18 juin 1991 à Aoste en Italie, demeurant à CZ-110 00 Prague, Korunni 96 est nommée

administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de 2017.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012090742/12.
(120127971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Gruppo Coin International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 19.508.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 juillet 2012

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 janvier 2013.

- Monsieur Nicola SCATTOLIN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement Via Terraglio 17, Venezia-

Mestre, Italie, Président.

- Monsieur Luca ZEILANTE, responsable financier, demeurant 62 VIA Ghetto I-31021 Mogliano Veneto, Italie.
- Monsieur Nicola PERIN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement Via Terraglio 17, Venezia-Mes-

tre, Italie.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 janvier 2013:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090798/20.
(120128444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Facette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 49.600,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 42.272.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 28 juin 2012 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les

comptes de l'exercice 2012, le Conseil de Gérance se compose de:

- Michel de Groote, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxem-

bourg;

- Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur

les comptes de l'exercice 2012:

- Ernst &amp; Young S.A., ayant son siège social à 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
Référence de publication: 2012090749/18.
(120127886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

99596

L

U X E M B O U R G

Familiar S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 160.547.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090744/11.
(120127895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Faduval Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 150.627.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2012090750/12.
(120128215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Steffen Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 8, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.156.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2012.

<i>Première résolution

L'assemblée  générale  accepte  la  démission  de  Madame  Prasopnetr  Prapaipit,  épouse  Steffen,  demeurant  à  L-8410

Steinfort 8 route d'Arlon comme administrateur.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décidé dé nommer comme nouvel administrateur de la société Monsieur Debargue Reynald

demeurant à F-57570 Boust 8 le Hellberg.

Suite à Cette résolution le Conseil d'Administration se compte comme suit:
1. Monsieur Steffen Frank, administrateur, demeurant à L-8410 Steinfort 8 route d'Arlon.
2. Monsieur Steffen Tom, administrateur, demeurant à L-8410 Steinfort 10 route d'Arlon.
3. Monsieur Debargue Reynald, administrateur, demeurant à F-57570 Boust 8 le Hellberg,
Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

STEFFEN Frank / STEFFEN Tom / DEBARGUE Reynald.

Référence de publication: 2012091112/21.
(120128482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

FDG Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.459.006,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 147.182.

<i>Extrait des résolutions prises en date du 12 juillet 2012

Conformément aux résolutions prises en date du 12 juillet 2012, il a été décidé:
1/ D'accepter la démission de Monsieur Andreas PAULKE en tant que Gérant de catégorie A avec effet immédiat.
2/ De pourvoir au poste de gérant A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, la personne suivante:

99597

L

U X E M B O U R G

- Madame Patricia ROTHACKER, née le 9 April 1990 à Bad Homburg (Allemagne), demeurant au Brönnerstrasse 23,

60313 Frankfurt am Main (Allemagne).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

<i>Pour FDG Holding S.à r.l.
SGG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2012090753/19.
(120127941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Fibaco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 22.178.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 2 juillet 2012 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur

les comptes de l'exercice 2012, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de Groote, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxem-

bourg, Président du Conseil;

- Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Hermann Bissig, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 10 Grafenauweg, CH-6300 Zug, Suisse.
A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur

les comptes de l'exercice 2012:

- Ernst &amp; Young S.A., ayant son siège social au 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activités Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
Référence de publication: 2012090754/18.
(120127888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Kalispera, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 76.399.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012090866/9.
(120128095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Financière Express Holding 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 84.420.

Il résulte de lettres adressées à la société en date du 23 juillet 2012 que Monsieur Riccardo MORALDI, demeurant

professionnellement, 40 Avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg et Monsieur Andrea DE MARIA, demeurant pro-
fessionnellement 40 Avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg, ont démissionné de leurs postes d’administrateurs de
la société avec effet au 23 juillet 2012.

Il résulte également d’une lettre adressée à la société en date du 23 juillet 2012 que Ser.Com Sàrl, ayant son siège

social à Luxembourg, 3, rue de Belle Vue L-1227, a démissionné de son poste de commissaire aux comptes de la société
avec effet au 23 juillet 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090759/16.
(120128142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

99598

L

U X E M B O U R G

Finanmag S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 47.951.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090760/10.
(120128268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Biocera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 88.269.

<i>Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenu au siège de la Société en date du 6 juillet 2012

Tous les Actionnaires sont présents.
Les Actionnaires ont pris les décisions suivantes:
Les Actionnaires décident:
- De révoquer Mme LEVY Fabienne, demeurant à 1, Rue Mazagran F-54000 NANCY en tant que qu'administrateur et

administrateur délégué,

- De nominer Mme DETALLE Anne, demeurant à 30, Rue du Général Leclerc F-54320 MAXEVILLE en tant que nouvel

administrateur. Mme DETALLE Anne est également nommée administrateur délégué avec pouvoir de signature indivi-
duelle pour une période qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017,

- De révoquer M. LELOUP Raynald, demeurant à 12, Rue des Loups F-57590 ABONCOURT-SUR-SEILLE en tant

qu'administrateur,

- De nominer M. WILHELM Jean, demeurant à 90, Rue des Cottages F-54600 VILLERS LES NANCY en tant que nouvel

administrateur, pour une période qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017,

- De révoquer Mme THIBAUT Marie-Aude, demeurant à 1, Rue Keup L-1860 Luxembourg en tant qu'administrateur,
- De nominer M. COLLINOT Jean-Aldric, demeurant à 1, Rue Mazagran F-54000 NANCY en tant que nouvel admi-

nistrateur, pour une période qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.

Les décisions ont été admises à l'unanimité.
Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

BIOCERA S.A.
Mme DETALLE Anne / M. WILHELM Jean / M. COLLINOT Jean-Aldric
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012092082/28.
(120128525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

GCVMBB, Société Civile.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

R.C.S. Luxembourg E 4.344.

<i>Résolution prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 20 mars 2012:

L'Assemblée prend note du changement d'adresse des deux associés et gérants:
- Madame Sonia, Julie HANNOUN, épouse HERTZOG, associée et gérante, domiciliée 44 Lennox Gardens SW1X0DJ

London, United Kingdom,

- Monsieur Bernard, René, Jacques HERTZOG, associé et gérant, domicilié 44 Lennox Gardens SW1X0DJ London,

United Kingdom.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AKELYS EUROPEAN SCORE
20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012090782/17.
(120128147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

99599

L

U X E M B O U R G

Gentiane S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 74.063.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090783/10.
(120128255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Global Fund House Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 141.046.

<i>Extrait du procès verbal d'une réunion du Conseil de Gérance tenue le 28 juin 2012

Il résulte d'une décision prise par le Conseil de Gérance que, avec effet au 7 juillet 2012, la Société a transféré son

siège du 46a avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé à Luxembourg, le 24 juillet 2012.

<i>Pour Global Fund House Management S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012090787/16.
(120128451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

PSMA Luxco GP, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 168.701.

EXTRAIT

En date du 9 juillet 2012 l'associé unique de la Société a approuvé les transferts suivants ont été effectués:
- PSMA Holdco S.àr.l. a transféré 1.442 parts sociales qu'elle détenait de la Société à AXA LBO Fund IV F.C.P.R., une

société de fonds commun de placement à risque, constituée en France, ayant son siège social au 20, Place Vendôme,
75001 Paris, France, représenté par sa société de gestion AXA Investment Managers Private Equity Europe, une société
anonyme, constituée en France, ayant son siège social au 20, Place Vendôme, 75001 Paris, France et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 403 201 882;

- PSMA Holdco S.àr.l. a transféré 433 parts sociales qu'elle détenait de la Société à AXA LBO Fund IV Supplementary

F.C.P.R., une société de fonds commun de placement à risque, constituée en France, ayant son siège social au 20, Place
Vendôme, 75001 Paris, France, représenté par sa société de gestion AXA Investment Managers Private Equity Europe,
une société anonyme, constituée en France, ayant son siège social au 20, Place Vendôme, 75001 Paris, France et imma-
triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 403 201 882.

Suite à ces transferts PSMA Holdco S.àr.l. détient 10.625 parts sociales de la Société.
L'associé unique de la Société a décidé de nommer M. Caspar von Meiborn, en tant que gérant, né le 17 décembre

1970 à Düsseldorf, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à An der Welle 4, 60322 Frankfurt, Allemagne, avec
effet au 9 juillet 2012 et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2012.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2012092116/28.
(120128437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

99600


Document Outline

Alysea Luxembourg Les Soins S.A

Antarex International S.A.

Biocera S.A.

Cape Cod SA

Champagne Invest, SPF

Châteaux Lux S.A.

Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois S.A.

Concept Live S.A.

Cordouan Holding S.A.

CVIC Lux Securities Trading

CVIC Lux Securities Trading S.à r.l.

Danube SCA SICAR

Diapason Investissements S.A.

Dininvest S.A.

Dorn Immo S.A.

Edison Participations S.à r.l.

Elizabeth Verwaltung S.à r.l.

Energies Van Kasteren S.à r.l.

Energies Van Kasteren S.à r.l.

Energy Investments Lux S.A.

Ets. Bourgeois S.à.r.l.

Eurofins Pharma Services France LUX Holding

Euro-Zone Office Investments S.A.

Extenso Int. S.A.

Facette S.à r.l.

Faduval Capital S.à r.l.

Familiar S.A., SICAV-SIF

FDG Holding S.à r.l.

Fibaco S.A.

Financière Express Holding 2001 S.A.

Financière Palladio S.à r.l.

Finanmag S.A. - SPF

GCVMBB

Gentiane S.A.

Gift Productions S.A.

Global Fund House Management S.à r.l.

Gruppo Coin International S.A.

Heirens Constructions S.àr.l.

Heron Optique et Audition S.A.

InfraTaf Holding S.à r.l.

Intekbio S.A.

Intelprop S.A.

Kalispera

Luxembourg Food &amp; Beverage S.à r.l.

Luxpromo S.à r.l.

Presse Européenne S.à r.l.

Princess Holding S.A.

PSMA Luxco GP

Ravago Production S.A.

Saxon Energy Services Holdings Sàrl

Saxon S.à r.l.

Société Luxembourgeoise des Mines

Steffen Immo S.A.

Syndex Umbrella SICAV

Teknimed International S.A.

Telenet Finance IV Luxembourg S.C.A.

TETRA Kayser Associés S.A.

TREVOR &amp; Company

Universal Premium Holding SA