logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2041

17 août 2012

SOMMAIRE

Afrimedia International . . . . . . . . . . . . . . . . .

97929

Arelux 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97947

Arelux France S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97930

ARGO IMMOBILIERE société à responsa-

bilité limitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97947

Arlene S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97947

Auberge du Lac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97947

Avanza Beta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97948

Avanza S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97948

Avencor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97948

Avencor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97950

Axis Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97954

Ayocco's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97957

Bairlinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97964

Becton Dickinson Luxembourg Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97957

Becton Dickinson Management S.à r.l.  . . .

97958

Bellevue Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97960

Bell Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97964

Belux-Automobile S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

97965

Bering GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97963

Biminvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97965

Bio Chemical Luxembourg Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97966

Bluehill Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

97963

BlueOrchard Loans for Development S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97949

Bluestar Elkem International Co., Ltd. S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97963

Bodycote Luxembourg Finance S.à r.l.  . . .

97924

Bodycote Luxembourg Holdings Sàrl  . . . .

97950

Boxtel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97966

Boxtel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97966

Bridon SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97954

Brillen Boutique Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97966

B&S Holding S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97930

Bubbles S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97967

Business Investor Market  . . . . . . . . . . . . . . .

97967

Business Market Energy S.à r.l.  . . . . . . . . . .

97964

BWPE - FTL S.C.A. SICAR  . . . . . . . . . . . . .

97967

BWPE - FTL S.C.A. SICAR  . . . . . . . . . . . . .

97966

Canam Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

97968

CAP Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97954

C&C Media S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97968

Central Investments DBI  . . . . . . . . . . . . . . .

97949

Central Investments DBI  . . . . . . . . . . . . . . .

97950

C.K. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97968

Compagnie Européenne de Financement

C.E.F. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97959

Creche Mini-Snoopy S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

97949

Cynthia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97930

CYNTHIA, Société de Gestion de Patri-

moine Familial, SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97930

First Animation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97959

Grand City Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . .

97922

Healthcare Promise Investment Partners

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97963

Jones Lang LaSalle Luxembourg Star S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97948

LSRC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97968

Medicis Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97964

Ontex III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97959

PM Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97954

Sopalux Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97965

Vadimont S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97967

97921

L

U X E M B O U R G

Grand City Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 165.560.

In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of July.

Before M 

e

 Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

- Mr Eyal GRUMBERG, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as the representative of the board of

directors of the public limited company " Grand City Properties S.A.", with registered office in L-1430 Luxembourg, 6,
boulevard Pierre Dupong, registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg (“Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg), section B, number 165.560, pursuant to a power given by the board of directors of the
said company in their meetings of July 4 

th

 , 12 

th

 and 19 

th

 , 2012.

The copies of the minutes of this meetings, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the

notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing person, acting as said before, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:

1. The company "Grand City Properties S.A." has been incorporated by deed of M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing

in Luxembourg, on the 16 

th

 of December 2011, published in the Mémorial C number 287 on the 2 

nd

 of February 2012.

2. The subscribed capital of the company is fixed five million Euro (5,000,000.- EUR), represented by fifty million

(50,000,000) shares of a par value of ten Cents (0.10 EUR) each.

3. Pursuant to article 5 of the articles of association, the authorized capital is set at twenty million euro (20.000.000.-

EUR).

The board of directors is authorized to increase in one or several times the subscribed capital in the limits of the

authorized capital at the terms and conditions which he will fix and to suppress or limit the preferential subscription right
of the existing shareholder.

4. In its meetings of July 4 

th

 , 12 

th

 and 19 

th

 , 2012, the board of directors of the said company has decided to increase

the capital by five hundred fifty thousand Euro (550,000.- EUR), so as to raise the capital from its present amount of five
million Euro (5,000,000.- EUR) to five million five hundred fifty thousand Euro (5,550,000.- EUR) by the creation and the
issue of five million five hundred thousand (5,500,000) new shares with a par value of ten Cents (0.10 EUR) each.

5. That the subscription and full payment of the five million five hundred thousand (5,500,000) new shares has been

made as detailed in the subscription sheet of the Board of Directors, of which a copy shall remain attached hereto.

<i>Payment

The new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of fifteen million one hundred twenty-five thousand

Euro (15,125,000.- EUR) is at the disposal of the company, of which five hundred fifty thousand Euro (550,000.- EUR),
are allotted to the corporate share capital and the balance of fourteen million five hundred seventy-five thousand Euro
(14,575,000.- EUR) is allotted to the share premium account, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

6. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the articles of association is amended

and now reads as follows:

Art. 5. (First paragraph). The subscribed capital of the Company is fixed at five million five hundred fifty thousand Euro

(5,550,000.- EUR), represented by fifty-five million five hundred thousand (55,500,000) shares of a par value of ten Cents
(0.10 EUR) each."

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at EUR 6,000.-.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that at the request of the

appearing person the present deed is worded in English, followed by an French version; at the request of the same
appearing person, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

97922

L

U X E M B O U R G

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix-neuf juillet.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

- Me Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire

spécial au nom et pour compte du conseil d’administration de la société anonyme "Grand City Properties S.A.", avec siège
social à L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B numéro 165.560, en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le conseil d’administration de
ladite société en ses réunion du 4, 12 et 19 juillet 2012.

Copies des procès-verbaux de ces réunions, après avoir été signées “ne varietur” par le comparant et le notaire,

resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations

comme suit:

1. La société anonyme " Grand City Properties S.A." a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT,

notaire de résidence à Luxembourg en date du 16 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 287 du 2 février 2012.

2. le capital souscrit de la société est fixé à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR), représenté par cinquante millions

(50.000.000) actions d'une valeur nominale de dix Cents (0,10 EUR) chacune.

3. Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à vingt millions d'euros (20.000.000,- EUR).
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites

du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription
des anciens actionnaires.

4. En ses réunions du 4, 12 et 19 juillet 2012, le conseil d’administration de ladite société a décidé d’augmenter le

capital social à concurrence de cinq cent cinquante mille euros (550.000,- EUR), pour porter le capital social ainsi de son
montant actuel de cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) à cinq millions cinq cent cinquante mille euros (5.550.000,-
EUR) par la création et l’émission de cinq millions cinq cents mille (5.500.000) actions nouvelles d'une valeur nominale
de dix Cents (0,10 EUR) chacune.

5. Que la souscription et la libération intégrale des cinq millions cinq cents mille (5.500.000) actions nouvelles s’est

faite, tel que détaillé dans les procès-verbaux du Conseil d’administration.

<i>Libération

Les actions nouvelles ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de quinze millions cent vingt-

cinq mille euros (15.125.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, dont cent cinquante mille euros (550.000,-
EUR)  sont  alloués  au  compte  capital  social  et  le  solde  de  quatorze  millions  cinq  cent  soixante-quinze  mille  euros
(14.575.000,- EUR) sont alloués au compte prime d’émission, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.

6. En conséquence de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

Art. 5. (Premier alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à cinq millions cinq cent cinquante mille euros

(5.550.000,- EUR), représenté par cinquante-cinq millions cinq cent mille (55.500.000) actions d'une valeur nominale de
dix Cents (0,10 EUR) chacune."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à 6.000,- EUR.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du com-

parant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Eyal GRUMBERG, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juillet 2012. Relation GRE/2012/2673. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

97923

L

U X E M B O U R G

Junglinster, le 19 juillet 2012.

Référence de publication: 2012089176/108.
(120125533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Bodycote Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.880,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 89.603.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of June at four p.m.
Before Us, Me Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grandduchy of Luxembourg,

There appeared:

BODYCOTE LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L., a société à responsabilité limitée (private limited liability company)

duly incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Muns-
bach, Luxembourg, and registered with the Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg (Luxembourg Trade
and Companies Register) under number B. 89602 (the “Sole Shareholder”),

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at, 101 rue de Cents, L-1319 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. That the appearing party, aforementioned, is currently the sole shareholder of the société à responsabilité limitée

(private limited liability company) existing in Luxembourg under the name of BODYCOTE LUXEMBOURG FINANCE
S.À R.L., having its registered office at 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register)
under number B 89.603 (the “Company”), and, incorporated by a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Lu-
xembourg, on October 18, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1708,
on November 29, 2002, page 81947, and which articles of association (the “Articles”) have been amended for the last
time on June 25, 2012 by a deed of Maître Carlo Wersandt, not yet published.

II. The Company's share capital currently amounts to fourteen thousand eight hundred eighty Euro (EUR 14,880)

represented by six (6) common shares having a nominal value of two thousand four hundred and eighty Euro (EUR 2,480)
each.

III. That the Sole Shareholder declares that it has full knowledge of the agenda prior to the present meeting and agrees

to waive the notice requirements, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV. That the agenda of the meeting is the following:
1. Conversion of common shares into “ordinary shares”;
2. Consider to create “mandatory redeemable preferred shares”, vested with the rights and obligations described in

the amended articles of association of the Company to be approved as per item 4 below;

3. Consider the conversion of one (1) ordinary share into one (1) mandatory redeemable preferred share for an

aggregate amount of two thousand four hundred eighty Euro (EUR 2,480), together with a share premium attached to
such mandatory redeemable preferred share for a global amount of one hundred sixty-four million nine hundred twenty-
three thousand two hundred thirty-eight Euro (EUR 164,923,238);

4. Consider the subsequent amendment of articles 7, 8, 14 and 15 of the articles of association of the Company;
5. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved, the Sole Shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to convert the existing common shares into ordinary shares (the “Ordinary Shares”).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to create mandatory redeemable preferred share(s) (the “MRPS”), having the rights

and obligations described in the amended articles of association of the Company as per the fourth resolution.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to convert one (1) Ordinary Share into one (1) MRPS having a nominal value of two

thousand four hundred eighty Euro (EUR 2,480), together with a share premium attached to such MRPS for a global
amount of one hundred sixty-four million nine hundred twenty-three thousand two hundred thirty-eight Euro (EUR
164,923,238).

97924

L

U X E M B O U R G

The global share premium attached to the MRPS shall be allocated as follows:
- up to an amount of two hundred forty-eight Euro (EUR 248) to a non distributable item of the balance sheet of the

Company as legal reserve; and

- up to an amount of one hundred sixty-four million nine hundred twenty-two thousand nine hundred ninety Euro

(EUR 164,922,990) to a distributable item of the balance sheet of the Company as share premium.

<i>Fourth resolution

Pursuant to the amendments to the share capital of the Company, the Sole Shareholder resolved to amend the articles

7, 8, 14 and 15 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 7. The subscribed capital is fixed at fourteen thousand eight hundred and eighty Euro (EUR 14,880) represented

by five (5) ordinary shares (the “Ordinary Share(s)”) and one (1) mandatory redeemable preferred share (“MRPS”) of
two thousand four hundred and eighty Euro (EUR 2,480) each fully paid up. The corporate capital may be increased by
the issuance of new Ordinary Shares and MRPS. For the sake of clarity, “shares” in the present Articles shall include
Ordinary Shares and MRPS. As long as all the shares are held by only one shareholder, the company is a sole shareholder
company.

Ordinary Shares and MRPS (together referred to as the «classes» of shares and each referred to as a «class» of shares)

can be issued with or without a share premium, subject to legal requirements and the provisions of the present Articles.
Any amount of share premium which has been paid in addition to the nominal value of the Ordinary Shares (the “Ordinary
Share Premium”) shall remain attached to the Ordinary Shares and shall be designated as the “Ordinary Share Premium
Account”. Any amount of share premium which has been paid in addition to the nominal value of the MRPS (the “MRPS
Premium”) shall remain attached to the MRPS and shall be designated as the “MRPS Premium Account”.

The aggregate amount of said premium accounts is at the free disposal of the shareholder(s).
As long as the Company has a sole shareholder, a portion of MRPS Premium equal to ten per cent (10%) of the share

capital (represented by both Ordinary Shares and MRPS) should be allocated to the legal reserve.”

“ Art. 8. The company may to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own ordinary shares.

Such repurchase shall be subject to the following conditions:

- any repurchase of parts made by the company may only be made out of the company's distributable retained profits

and free reserves.

- the repurchased parts will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance

with the legal requirements.

MRPS are redeemable (partially or in full) at any time until maturity at the option of the company (an “Early Redemption

Date”). The company shall redeem the MRPS at the latest ten (10) years after their issuance (the “Maturity Date”). The
MRPS shall be redeemed for an amount corresponding to the sum of (i) the aggregate nominal value of the redeemed
MRPS, (ii) the MRPS Premium attached to the redeemed MRPS, including the amount allocated from the MRPS Premium
Account to the legal reserve provided that the legal reserve remains at a level of ten percent (10%) of the new share
capital after the redemption, and (iii) any preferred dividend accrued but not yet declared (the “Redemption Price”).
Nonetheless, the MRPS shall only be redeemed at the Maturity Date if the company has sufficient available funds to do
so on the concerned date (the “Available Funds”). In case the company dispose of funds available for distribution in
accordance with article 72-1 of the Law to pay the Redemption Price but has no sufficient cash available at the Maturity
Date, it may, at its sole discretion, pay the Redemption Price in kind (partially or in full). In case the company has Available
Funds to pay the Redemption Price in cash, the Redemption Price can nonetheless be paid in kind (either at the Maturity
Date or an Earlier Redemption Date), if the MRPS holder(s) so agree. Irrespective of whether the Company has Available
Funds to pay the Redemption Price in cash or not, the Company may discharge the Redemption Price (either at the
Maturity Date or an Early Redemption Date) by transferring to the holder(s) of MRPS to be redeemed any receivable(s)
owing to the Company by any person, to be valued for these purposes at a value not lower than their nominal amount.
The Company may perform early repayments without penalty.

MRPS redeemed by the company shall be immediately cancelled and the amount of share capital shall be reduced

accordingly, to the extent that the minimum amount of share capital required by the law is maintained. In addition, the
MRPS Premium Account shall be reduced accordingly.

“ Art. 14. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well

as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the pro-

visions and taxation constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.

97925

L

U X E M B O U R G

For every financial year of the company, and for the first time at the occasion of its first financial year, the holders of

MRPS are entitled to a preferred fixed cumulative return of zero point one per cent (0.1%) a year, computed on the
nominal amount of the MRPS and the MRPS Premium Account, including the amount allocated from the MRPS Premium
Account to the legal reserve (the “Preferred Dividend”).

Preferred Dividends will accrue on a daily basis and may be payable in cash or in kind each year to the extent the

company has sufficient distributable profits available. If the current year's Preferred Dividends may not be declared (due
to a lack of distributable profits), they shall be cumulated and can be declared in the next financial year, or the first following
year in which there is sufficient profit to distribute.

The holders of the Ordinary Shares are entitled to the remainder of the company's profit for any given financial year

(“Ordinary Dividend”), but no dividends will be paid to the holders of the Ordinary Shares until all rights to Preferred
Dividends of the holders of MRPS of the current year and the prior years have been paid.

The above Preferred Dividends do not have any impact on the obligation for each shareholder to participate to the

losses under the sequence described in article 15 of the Articles.

The board of managers may resolve to pay one or more interim dividends with respect to the MRPS (“Preferred

Interim Dividend”) and Ordinary Shares (“Ordinary Interim Dividend”), including during the first financial year, subject
to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. The declaration of
Preferred Interim Dividends shall be limited to the Preferred Dividends accumulated on the MRPS as at the day this
decision is taken. The Ordinary Interim Dividend shall be limited to the distributable profits that are in excess of the
profits necessary to declare the Preferred Interim Dividend. The total amount to be distributed may not exceed total
distributable profits since the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available
reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or
of the Articles.

“Title VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 15. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need

not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of
August  10 

th

  ,  1915  and  of  its  modifying  laws.  The  liquidator(s)  shall  be  invested  with  the  broadest  powers  for  the

realization of the assets and payment of the liabilities.

Upon winding-up of the company, subject the prior payment of the company's creditors and to the availability of funds,

the holders of the MRPS have a preferred right to the repayment of their contributions compared to the holders of
Ordinary Shares (i.e., MRPS and MRPS Premium Account) and Preferred Dividend accrued or declared but not yet paid
at that time.

The holders of the Ordinary Shares are not entitled to the repayment of their contribution (i.e., Ordinary Shares,

Ordinary Share Premium) until all rights to repayment of the holders of MRPS have been discharged. Should there be
insufficient funds to pay entirely the preferred repayment right of MRPS, available funds will be allocated to the holders
of MRPS pro rata their repayment rights. Holders of the Ordinary Shares are entitled to the entire liquidation proceeds
of the company after the holders of MRPS have received their preferred rights to repayment. Holders of MRPS are thus
excluded from any liquidation surplus of the Company after they have received their preferred right to repayment.

In case of liquidation losses, such losses will be supported firstly by the holders of the Ordinary Shares, and then by

the holders of the MRPS when necessary, but before creditors.”

There being no further business, the meeting was terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at one thousand five hundred Euros (1,500.-EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the persons appearing, they signed together with the notary

the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-cinq juin à seize heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

A comparu:

BODYCOTE LUXEMBOURG HOLDINGS S.A R.L., une société à responsabilité limitée, dûment constituée sous les

lois du Luxembourg, ayant son siège social au 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-duché de Luxembourg,

97926

L

U X E M B O U R G

et enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 89602 (l'«Associé
Unique»),

Représentée par Régis Galiotto clerc de notaire, ayant sont adresse professionnelle au 101 rue de Cents, L-1319

Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que le comparant, précité, est l'associé unique de la société à responsabilité limitée existant au Luxembourg sous

le nom de BODYCOTE LUXEMBOURG FINANCE SARL, ayant son siège social situé au 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand-duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 89603 (la «Société»), et, constituée par un acte de Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Lu-
xembourg, le 18 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1708, le 29
novembre 2002, page 81947, et dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le 25 juin 2012 par
un acte de Maître Carlo Wersandt, non encore publié.

II. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à quatorze mille huit cent quatre-vingt euros (EUR 14,880)

représentés par six (6) parts sociales ayant une valeur nominale de deux mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR 2,480)
chacune.

III. Que l'Associé Unique déclare avoir eu connaissance complète de l'agenda avant la présente assemblée et accepte

de renoncer aux formalités de convocation afin que l'assemblée puisse délibérer valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour.

IV. Que l'agenda de l'assemblée est le suivant:
1. Conversion des parts sociales communes en «parts sociales ordinaires»;
2. Considérer la création de «parts préférentielles avec obligations de rachat» ayant les mêmes droits et obligations

décrits dans les statuts modifiés de la Société tels qu'approuvée au point 4 de l'agenda ci-dessous;

3. Considérer la conversion d'une (1) part sociale ordinaire en une (1) part préférentielle avec obligation de rachat

pour un montant de deux mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR 2.480), ensemble avec une prime d'émission attachée
à cette part préférentielle avec obligation de rachat pour un montant global de cent soixante-quatre millions neuf cent
vingt-trois mille deux cent trente-huit euros (EUR 164.923.238);

4. Considérer les modifications subséquentes des articles 7, 8, 14 and 15 des statuts de la Société
5. Divers.
Après l'approbation de ce qui précède, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé de convertir les parts sociales communes existantes en parts sociales ordinaires (les «Parts

Sociales Ordinaires»).

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé de créer des parts (s) préférentielle(s) avec obligations de rachat («MRPS») ayant les mêmes

droits et obligations que ceux décrits dans les statuts modifiés de la Société tels que prévus à la quatrième résolution.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé de convertir une (1) Part Sociale Ordinaire en une (1) MRPS ayant une valeur nominale de

deux mille quatre cent quatre-vingts euros (EUR 2.480), ensemble avec une prime d'émission attachée au MRPS pour un
montant global de cent soixante-quatre millions neuf cent vingt-trois mille deux cent trente-huit euros (EUR 164.923.238).

Le montant global de la prime d'émission attachée au MRPS sera alloué comme suit:
- un montant de deux cent quarante-huit euros (EUR 248) à un élément non distribuable du bilan de la Société en tant

que réserve légale; et

-  un  montant  de  cent  soixante  quatre  million  neuf-cent  vingt-deux  mille  neuf  cent  quatre-vingt-dix  euros  (EUR

164.922.990) à un élément distribuable du bilan de la Société en tant que compte de prime d'émission.

<i>Quatrième résolution

Suite aux modifications du capital social de la Société ci-dessus, l'Associé Unique a décidé de modifier les articles 7, 8,

14, et 15 des Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

« Art. 7. Le capital social souscrit est fixé à quatorze mille huit cent quatre-vingt euros (EUR 14,880) représentés par

cinq (5) parts sociales ordinaires («Part(s) Sociale(s) Ordinaires(s)») et une (1) part préférentielle avec obligation de rachat
(«MRPS») de deux mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR 2.480) chacune entièrement libérée. Le capital social peut
être augmenté par l'émission de nouvelles Parts Sociales Ordinaires et MRPS. Dans un souci de clarté, les «parts» dans
les présents statuts comprennent les Parts Sociales Ordinaires et les MRPS. Aussi longtemps que toutes les parts sont
détenues par un seul associé, la société est une société unipersonnelle.

97927

L

U X E M B O U R G

Les Parts Sociales Ordinaires et les MRPS (appelées collectivement les «classes» de parts et individuellement appelée

«classe» de parts) peuvent être émises avec ou sans prime d'émission, soumises aux obligations légales et aux dispositions
des présents statuts. Tout montant de prime d'émission qui a été payé en supplément de la valeur nominale des Parts
Sociales Ordinaires (la «Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires») restera attaché aux Parts Sociales Ordinaires
et sera dénommé «Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires». Tout montant de prime d'émission qui
a été payé en supplément de la valeur nominale des MRPS (la «Prime d'Emission des MRPS») restera attaché aux MRPS
et sera dénommé «Compte de Prime d'Emission des MRPS».

Le montant total desdits comptes de prime d'émission est à la libre disposition de/des associé(s).
Tant que la société a un associé unique, une partie des Primes d'Emission des MRPS s'élevant à dix pourcent (10%) du

capital social (représenté par les Parts Sociales Ordinaires et les MRPS) devra être allouée à la réserve légale.

« Art. 8. La société peut, dans la mesure et sous les conditions permises par la loi, acquérir ses propres Parts Sociales

Ordinaires. Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts par la société sera fait uniquement à partir des profits retenus distribuable et des réserves

disponibles.

- Les parts rachetées seront immédiatement annulées et le capital social de la Société réduit en conséquence confor-

mément aux exigences légales.

Les MRPS sont rachetables (partiellement ou entièrement) à tout moment jusqu'à maturité à l'option de la société (la

«Date de Rachat Anticipé»). La société doit racheter les MRPS au plus tard dix (10) ans après leur émission (la «Date
d'Exigibilité»). Les MRPS doivent être rachetées pour un montant correspondant à la somme de (i) la valeur nominale
totale des MRPS rachetées, (ii) la Prime d'Emission des MRPS attachée aux MRPS rachetées, comprenant le montant alloué
du Compte de Prime d'Emission des MRPS à la réserve légale pour autant que la réserve légale reste égale à dix pourcent
(10%) du nouveau capital social après rachat, et (iii) tout dividende préférentiel accumulé mais non encore déclaré (le
«Prix de Rachat»). Néanmoins, les MRPS seront rachetées à la Date d'Exigibilité uniquement si la société a suffisamment
de fonds disponibles pour la distribution à cette date (les «Fonds Disponibles»). Dans le cas où la société disposerait des
fonds disponibles pour une distribution conformément à l'article 72-1 de la Loi pour payer le Prix de Rachat mais ne
dispose pas d'assez de numéraire disponible à la Date d'Exigibilité, elle pourra, à sa seule discrétion, payer le Prix de
Rachat en nature (partiellement ou totalement). Dans le cas où la société disposerait des Fonds Disponibles pour payer
le Prix de Rachat en numéraire, le Prix de Rachat pourra toutefois être payé en nature (soit à la Date d'Exigibilité soit à
une Date de Rachat Anticipée), si le/les détenteur(s) de MRPS y sont favorables(s). Indépendamment de la question de
savoir si la société dispose des Fonds Disponibles pour payer le Prix de Rachat en espèce ou pas, la Société pourra se
décharger du Prix de Rachat (soit à la Date d'Exigibilité ou Date de Rachat Anticipé) en transférant au(x) détenteur(s)
des MRPS toute(s) dette(s) due(s) à la société par toute personne, devant être évaluée dans cet objectif à une valeur qui
ne peut être inférieure à leur valeur nominale. La Société peut procéder à tous repaiements anticipés sans pénalité.

Les  MRPS  rachetées  par  la  société  sont  immédiatement  annulées  et  le  montant  du  capital  social  doit  être  réduit

corrélativement. En outre, le compte de Prime d'Emission des MRPS doit être réduit en conséquence.

« Art. 14. Chaque année le dernier jour de décembre un inventaire des tous les actifs et passifs de la Société ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes seront dressés.

Les revenus de la société, déduction faite des dépenses générales et des charges, des dépréciations, des provisions et

des impôts, devront constitués le profit net.

Cinq pour cent (5%) des profits nets seront alloué à la réserve légale; la déduction cesse d'être obligatoire dès que la

réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital de la société, mais cela doit être réduit jusqu'à ce que la réserve soit
entièrement reconstituée si, à tout moment, et pour toute raison que ce soit, cela a été modifié. Le bilan est à la disposition
de l'assemblée générale des participants.

Pour chaque année comptable de la société, et pour la première fois lors de sa première année comptable, les déten-

teurs de MRPS ont droit à (i) un dividende préférentiel fixe cumulé de zéro virgule un pourcent (0,1%) par an, calculé sur
la valeur nominale des MRPS et du Compte de la Prime d'Emission des MRPS, incluant le montant alloué au Compte de
Prime d'Emission des MRPS à la réserve légale (le «Dividende Préférentiel»).

Les Dividendes Préférentiels sont cumulés sur une base journalière et payés en numéraire ou en nature chaque année

pour autant que la société ait suffisamment de profits distribuables disponibles. Si les Dividendes Préférentiels de l'année
ne sont pas distribués (à cause d'un manque de profits distribuables), ils sont cumulés et peuvent être distribués durant
l'année comptable suivante, ou la première année où il y a un profit suffisant à distribuer.

Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires ont droit, chaque année comptable, aux profits restants de la Société (le

«Dividende Ordinaire»), mais aucun dividende ne sera payé aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires tant que tous
les droits des Dividendes Préférentiels des détenteurs des MRPS de l'année en court et des années précédentes n'ont
pas été acquittés.

Les Dividendes Préférentiels ci-dessus n'ont aucune influence sur l'obligation de chaque associé de participer aux pertes

décrites à l'article 15 des présents statuts.

Le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement d'un ou de plusieurs acomptes sur dividendes concernant

les MRPS («Acompte sur Dividendes Préférentiels») et les Parts Sociales Ordinaires («Acompte sur Dividendes Ordi-

97928

L

U X E M B O U R G

naires»), y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution. La déclaration d'Acompte sur Dividende Préférentiels doit être limitée
aux Dividendes Préférentiels accumulés sur les MRPS au jour où la décision de distribuer un tel dividende est prise.
L'Acompte sur Dividendes Ordinaires se limite aux profits distribuables excédant le profit nécessaire à l'Acompte sur
Dividendes Préférentiels. Le montant total distribué ne doit pas excéder le montant total des profits distribuables réalisés
depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et
diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.»

«Titre VI. - Liquidation-Dissolution

Art. 15. En cas de liquidation de la société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non,  nommés  par  l'assemblée  des  associés  à  la  majorité  définie  à  l'article  142  de  la  loi  du  10  août  1915  et  ses  lois
modificatives. Le ou les liquidateur(s) devront être investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et
le règlement du passif.

Suivant la dissolution de la société, sous réserve du paiement des créanciers de la société et de la disponibilité des

fonds, les détenteurs des MRPS ont un droit préférentiel au remboursement de leur apport par rapport aux détenteurs
de Parts Sociales Ordinaires (comprenant notamment MRPS et le Compte de Prime d'Emission des MRPS) et du Dividende
Préférentiel cumulé ou déclaré mais non encore payé.

Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires n'ont pas de droit préférentiel au remboursement de leur apport (les Parts

Sociales Ordinaires, le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires) tant que tous les droits de rembour-
sement des détenteurs des MRPS n'ont pas été exécutés. S'il n'y a pas de fonds suffisants pour payer entièrement le droit
préférentiel de remboursement des MRPS, les fonds disponibles seront alloués aux détenteurs de MRPS au prorata des
droits de remboursement. Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires ont droit à l'entièreté du boni de liquidation de
la Société après que les détenteurs des MRPS aient obtenu le payement de leur droit préférentiel au remboursement.
Les détenteurs de MRPS sont donc exclus de tout excédant de liquidation de la société après obtention du payement de
leur droit préférentiel au remboursement.

En cas de pertes, ces pertes sont supportées premièrement par les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, et ensuite,

si nécessaire, par les détenteurs des MRPS, mais avant les créanciers.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500.-EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31240. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088119/320.
(120125068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Afrimedia International, Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 140.632.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 11 juillet 2012

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Martin Belinga Eboutou, né à Nkilzok, République du Cameroun le 17 février

1940, demeurant à Yaoundé, République du Cameroun en qualité de nouvel administrateur de la Société.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

97929

L

U X E M B O U R G

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012088937/14.
(120126171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Arelux France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 160.433.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088961/10.
(120125963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de

Patrimoine Familial,

(anc. Cynthia).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 58.839.

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en

date du 2 avril 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 390 du 21 juillet 1997. Le capital
social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée
générale du 20 décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 761 du 18
mai 2002. Les statuts ont été modifiés, ainsi que la dénomination sociale qui a été changée en CYNTHIA, Société
de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, suivant acte reçu par le même notaire en date du 30 décembre 2010, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 424 du 4 mars 2011.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2012089882/21.
(120126753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

B&amp;S Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.237.875,00.

Siège social: L-7610 Larochette, 18, place Bleech.

R.C.S. Luxembourg B 135.944.

In the year two thousand and twelve, on the fourth day of July,
before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of B&amp;S Holding S.à r.l., a Luxembourg

private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 18, place Bleech, L-7610 Laro-
chette, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (RCS)
under the number B 135.944 with a statutory capital of EUR 5,000,000.- (the Company). The Company has been incor-
porated on December 30, 2007 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 534 of March 4, 2008.
The articles have been amended for the last time on January 13, 2010 pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
N° - 557 of March 16, 2010.

There appeared:

1. Sarabel Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered

office at 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under
number B 166.130, with a statutory capital of EUR 12,501,-;

97930

L

U X E M B O U R G

hereby represented by Mr. Jérémie HOUET, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal;

2. Sarabel B.V./S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with principal establishment

and place of effective management at 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the RCS under number B 136.083, with a statutory capital of EUR 18,000.-;

hereby represented by Mr. Jérémie HOUET, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal; and,

3. Lebaras Belgium B.V.B.A., a company incorporated and organized under the laws of Belgium, having its registered

office at 179, Ter Borcht, B-2930 Brasschaat, Belgium, registered with the Register für juristische Personen von Antwerpen
under number BE 0985104716;

hereby represented by Mr. Jeremie HOUET, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The proxies from the shareholders, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the

appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities.

The shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the shareholders own all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Creation of class P preferred shares (the Shares P) having such rights and features as set out in the articles of

association of the Company as they are proposed to be amended and restated pursuant to item 6. of the agenda (the
Articles);

3. Waiver of the pre-emptive right;
4. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred thirty-seven thousand eight hundred

seventy-five euro (EUR 237,875.-) in order to bring the share capital from its present amount of five million euro (EUR
5,000,000.-) represented by one hundred forty-six thousand six hundred and sixty (146,660) Shares S, and fifty-three
thousand three hundred and forty (53,340) Shares L in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each, to an amount of five million two hundred thirty-seven thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 5,237,875.-)
by way of the issuance of nine thousand five hundred and fifteen (9,515) new Shares P, having a par value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each in the share capital of the Company;

5. Subscription for and payment of the share capital increase set out in item 4;
6. Subsequent full restatement of the articles of association;
7. Amendment to the shareholder's register of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly
issued shares in the shareholder's register of the Company; and

8. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Meeting, the following resolutions have been unanimously taken:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the shareholders waive the con-

vening notices, considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has
been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to create Shares P in the share capital of the Company, having the rights and obligations described

in the restated articles of association of the Company mentioned in the sixth resolution below.

<i>Third resolution

The two shareholders Sarabel Luxembourg S.à r.l. and Sarabel B.V./S.à r.l., waive their pre-emptive right according to

article 7 of the Articles.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred thirty-seven thousand

eight hundred seventy-five euro (EUR 237,875.-)

in order to bring the share capital from its present amount of five million euro (EUR 5,000,000.-) represented by one

hundred forty-six thousand six hundred and sixty (146,660) Shares S, and fifty-three thousand three hundred and forty
(53,340) Shares L in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to an amount of five million
two hundred thirty-seven thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 5,237,875.-)

97931

L

U X E M B O U R G

by way of the issuance of nine thousand five hundred and fifteen (9,515) new Shares P, having a par value of twenty-

five euro (EUR 25.-) each in the share capital of the Company.

The Meeting approves and accepts the subscription and payment for the nine thousand five hundred and fifteen (9,515)

new Shares P having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, as set out below:

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Subscription - Payment

The above party, Lebaras Belgium B.V.B.A., declares to subscribe for the nine thousand five hundred and fifteen (9,515)

new Shares P, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to have fully paid them by way of a contribution
in cash in an aggregate amount of two hundred thirty-seven thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 237,875.-)
to be entirely allocated to the share capital of the Company.

Therefore, the amount of two hundred thirty-seven thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 237,875.-) is as

now at the disposal of the Company and proof of which has been duly given to the undersigned notary who expressly
acknowledges it.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to fully restate the Articles of the Company,

which shall henceforth be worded as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

B&amp;S HOLDING S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Larochette, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred within the boundaries of the municipality by a resolution of by the Board of Managers. The registered office may
further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single
shareholder or the General Meeting adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the Board of Managers. Where the Board of Managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

97932

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at five million two hundred thirty-seven thousand eight hundred seventy-

five euro (EUR 5,237,875.-) divided into one hundred and forty-six thousand six hundred and sixty (146,660) Shares S,
fifty-three thousand three hundred and forty (53,340) Shares L, and nine thousand five hundred and fifteen (9,515) Shares
P, each in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-), all subscribed and fully paid-up.

5.2. The Board of Managers may number the various types of Shares consecutively, beginning with 1 (L1, S1 and P1).

With due observance of the provisions of the preceding sentence, the Board of Managers may change the numbering of
the various types of Shares.

5.3 Any share premium paid in respect of any Shares S upon their issuance shall be allocated to a share premium

reserve account (the S Share Premium Reserve Account and the S Share Premium Reserve Account II) of the Company.
Any share premium paid in respect of any Shares L upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve
account (the L Share Premium Reserve Account and the L Share Premium Reserve Account II) of the Company. Any
share premium paid in respect of any Shares P upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account
(the P Share Premium Reserve Account) of the Company.

5.4. The S Share Premium Reserve Account, the L Share Premium Reserve Account and the P Share Premium Reserve

Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of Shares S, Shares L, and Shares
P respectively, subject to the Articles.

Art. 6. Issuance of Shares.
6.1 With the Supervisory Board's prior approval, the General Meeting will have the right by a unanimous vote to

resolve to issue Shares, including the determination of the price of issue and the other conditions, which may include the
payment on Shares in a foreign currency, at a meeting at which at least two-thirds of the issued capital is represented.

6.2 The provisions of Article 6.1 will apply accordingly to the granting of rights to purchase Shares, but will not apply

to the issue of Shares to a natural person or legal entity exercising a right to acquire Shares previously granted, with due
observance of the provisions of Article 6.1.

6.3 The issue of Shares will require a deed intended for that purpose and executed before a civil-law notary officiating

in Luxembourg, to which deed the Company and each natural person or legal entity to which Shares are issued must be
parties.

6.4 The Company may not purchase any Shares upon their issue.
6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

Art. 7. Pre-emptive right upon issue.
7.1 Each shareholder will have a pre-emptive right upon the issue of Shares pro rata to the total value of his Shares

on the day on which the resolution to issue Shares is adopted.

7.2 If a shareholder does not exercise his pre-emptive right or does not do so in time or in full, the pre-emptive right

in respect of the Shares thus released will vest in the other shareholders, in the ratio described in Article 7.1.

7.3 The General Meeting may resolve, each time in respect of one single issue, to limit or exclude the pre-emptive

right to purchase Shares, provided that such a resolution is adopted at the same time as the resolution to issue Shares.

7.4 The Company must announce the issue of Shares subject to a pre-emptive right and the period within that right

may be exercised to all the shareholders. The pre-emptive right can be exercised during the period to be determined by
the General Meeting, which must be at least four weeks, as from the day following the day of the dispatch of the an-
nouncement.

7.5 The above provisions of this Article will apply accordingly to the granting of rights to purchase Shares.

Art. 8. Reduction of the share capital.
8.1 The General Meeting may resolve to reduce the issued capital by withdrawing Shares or by reducing the value of

the Shares by amendment to these Articles.

8.2 A resolution to withdraw Shares may relate only to Shares held by the Company itself.
8.3 If the General Meeting resolves to reduce the value of the Shares by amendment to these Articles - irrespective

of whether that is done without repayment or with partial repayment on the Shares or with or without exemption from
the obligation to make payment - the reduction must take place proportionally in respect of all the Shares. The propor-
tionality requirement may be departed from with the approval of all the shareholders.

97933

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Shares.
9.1. Subject to the provisions of Article 19, each Share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and

profits of the Company in direct proportion to the number of Shares in existence.

9.2. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

9.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

Inter vivos, the transfer of Shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the General Meeting representing
at least three quarters of the share capital of the Company. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased
shareholder to new shareholders is subject to the approval given by the other shareholders in a General Meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. Such approval is however not required if, in the event of death, the Shares
are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse. A Share transfer will only be binding upon the
Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of
the civil code. For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

9.4 Shares may be pledged. If it was provided upon the creation of the pledge that the voting right vests in the pledgee,

he will have that right only if the granting of the voting right to the pledge and - upon transfer or transmission of the
pledge - the passing of the voting right has been approved by the General Meeting by a unanimous vote. If another party
succeeds to the pledgee's rights, he will have the voting right only if the General Meeting approves the passing of the
voting right by a unanimous vote, at a meeting at which at least two-thirds of the issued capital is represented.

9.5. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

III. Management - Representation - Supervisory Board

Art. 10. Board of Managers and Supervisory Board.
10.1 The Company will be managed by a Board of Managers, consisting of one or more general managers (the General

Managers) and one or more ordinary managers (the Ordinary Managers). The Company will have a Supervisory Board
consisting of one or more members. The number of managers and their titles, as well as the number of Supervisory
Directors, will be determined by the General Meeting.

10.2 Both natural persons and legal entities may be appointed as members of the Board of Managers. Only natural

persons may be appointed as Supervisory Directors.

10.3 The General Meeting will appoint the members of the Board of Managers as General or Ordinary Manager and

will appoint the Supervisory Directors.

10.4 Upon a nomination for appointment as a Supervisory Director, the candidate's age, his profession, the value of

the Shares held by him in the Company and the positions that he holds or has held insofar as relevant to the performance
of the task of a Supervisory Director will be stated. It will also be stated with what legal entities he is already affiliated as
a Supervisory Director; if they include companies that belong to one and the same group, the name of that group will
suffice. The reasons for the nomination must be stated and the nomination must be made by the Chairman of the Su-
pervisory Board.

10.5 Members of the Board of Managers and members of the Supervisory Board may be suspended or removed from

office by the General Meeting at any time. The person in question will be given the opportunity to render account at the
General Meeting at which the suspension or removal from office will be addressed. He may be represented by counsel
at that meeting.

10.6 Resolutions of the General Meeting to appoint, suspend or remove from office members of the Board of Managers

and members of the Supervisory Board may be adopted only at a General Meeting at which at least more than one half
of the issued capital is represented and only by a majority of two-thirds of the votes cast. If the requisite capital is not
represented at that meeting, a second meeting can be convened, to be held on a date to be determined by the first
meeting, which must be at least three weeks after the date of the first meeting, at which the aforesaid resolutions can be
adopted by the aforesaid majority of the votes, irrespective of the size of the capital represented. The notices convening
the new meeting must state that and why a resolution can be adopted irrespective of the part of the capital represented
at the meeting. No new proposals will be addressed at that second meeting.

Art. 11. Powers of the Board of Managers.
11.1. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the General Meeting fall within the competence

of the Board of Managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with
the Company's object.

11.2 The Board of Managers will require the approval of the Supervisory Board for resolutions of the Board of Managers

involving an amount of more than two million five hundred thousand euro (EUR 2,500,000):

a. to acquire, encumber, transfer, lease or let real property and other registered property;
b. to encumber movable property and property rights;
c. to enter into financial loans issued by the Company;

97934

L

U X E M B O U R G

d. to grant financial loans;
e. to render the Company liable for debts of other parties, either by means of suretyship or otherwise;
f. to enter into agreements;
g. to conduct proceedings - both as the plaintiff as and as the defendant - before an ordinary court, by way of arbitration

or in order to obtain binding advice, with the exception, however, of taking such legal measures as brook no delay or
that are purely of a protective nature, and furthermore with the exception of taking measures to collect financial claims
on the grounds of goods delivered or services provided by the Company;

h. to extend the Company's activities to include a new line of business and to shut down the Company's business or

any part thereof, including a transfer of ownership or enjoyment;

i. to participate in and otherwise take an interest in other businesses, and to terminate or change such participation

or interest;

j. to enter into, terminate and amend cooperation agreements and pooling agreements;
k. to acquire, encumber and transfer intellectual property rights, including in particular industrial ownership and co-

pyrights, as well as to grant and obtain licences and sublicenses;

l. to purchase fixed assets; and
m. to perform any and all other legal acts, insofar as they are not already covered by one of the preceding letters.
11.3 The Board of Managers will also require the approval of the Supervisory Board for a resolution of the Board of

Managers to appoint or dismiss employees with an annual salary of more than two hundred thousand euro (EUR 200,000.-)
or to give an assignment to a legal entity to perform work for the Company for an annual fee of more than two hundred
thousand euro (EUR 200,000.-).

11.4 The approval referred to in Articles 11.2 and 11.3 above will not be required if it relates to redeployment or

renewal under the same conditions as existing agreements.

11.5 In addition to the resolutions described in Article 11.2 for which the Supervisory Board's prior approval is re-

quired, the Supervisory Board will be authorised to submit other resolutions of the Board of Managers to its approval,
provided that the Supervisory Board accurately describes such resolutions and notifies them to the Board of Managers.

11.6 If no agreement can be reached among the shareholders regarding the resolutions in respect of which the General

Meeting is authorised, the Supervisory Board will decide on request, which decision must be made by an absolute majority.
If the vote is equally divided, the Chairman of the Supervisory Board will have a decisive vote.

11.7 The absence of approval by the Supervisory Board for a resolution as referred to in this Article 11 shall not affect

the authority of the Board of Managers or its members to represent the Company.

11.8. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by any two managers of the Company.

Art. 12. Procedure.
12.1 The Board of Managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

12.2 Written notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

12.3 No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

12.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

12.5 The Board of Managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the Board of Managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

12.6 Any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

12.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 13. Representation. The Company shall be bound towards third parties (a) in all matters (i) by the joint signature

of any General Manager and any Ordinary Manager or (ii) by the single signature of the General Manager, (b) by the single
signature of any Ordinary Manager in respect of commercial matters up to an amount of five thousand euro (EUR 5,000.-)

97935

L

U X E M B O U R G

or  (c)  by  the  joint  or  single  signatures  of  any  persons  to  whom such  signatory  power  has been  validly delegated  in
accordance with article 11.8 of these Articles.

Art. 14. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Art. 15. Tasks and Powers of the Supervisory Board.
15.1 The tasks of the Supervisory Board will be:
a. to supervise the policy of the Board of Managers and the general affairs within the Company and the business affiliated

with it; and

b. to advise the Board of Managers.
15.2 In the performance of their tasks, the Supervisory Directors will focus on the interest of the Company and the

business affiliated with it.

15.2 If invited to do so, the members of the Board of Managers will be required to attend the meetings of the Super-

visory Board. The Supervisory Board will meet at least four times a year, whereby at least fifteen working days before
the next financial year the Board of Managers will present the budget and the investment budget to the Supervisory Board
for its approval. The Supervisory Board must furthermore meet no later than six months after the end of the preceding
financial year in order to discuss the annual accounts with the Board of Managers.

15.3 If there are one or more vacancies on the Supervisory Board, it will remain authorised to fulfil its statutory tasks

and its tasks under these Articles.

15.4 If and as long as only one Supervisory Director is in office, he or she will exercise the Supervisory Board's statutory

powers and obligations and its powers and obligations under these Articles.

15.5 The Supervisory Board will elect a chairman and the vice-chairman from its midst. The meetings of the Supervisory

Board will be chaired by its chairman and, in his absence, by the vice-chairman or, in the absence of the latter person, by
another person to be appointed for that purpose at the meeting in question.

IV. General Meetings of Shareholders

Art. 16. Powers and Voting Rights.
16.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the General Meeting.
16.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
16.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e¬mail, to represent him at the General Meetings.

Art. 17. Form - Quorum - Majority.
17.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

17.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

17.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual Accounts - Allocation of Profits

Art. 18. Accounting Year.
18.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December of each year.

18.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

18.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 19. Allocation of Profits.
19.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

19.2 Upon the allocation to the statutory reserve mentioned in Article 19.1, the remaining profit will be available to

the General Meeting, with due observance of the following provisions.

97936

L

U X E M B O U R G

19.3 The Company will have a retained surplus account S, a retained surplus account L and a retained surplus account

P. The holders of Shares S will be entitled only to the retained surplus account S. The holders of Shares L will be entitled
only to the retained surplus account L. The holders of Shares P will be entitled only to the retained surplus account P.

19.4 The General Meeting will decide with due observance of the provisions of the paragraphs set out below what

part of the profit will be carried to reserve, what part will be distributed and what part will be carried to the retained
surplus accounts or, in the event of a loss, will be withdrawn from the retained surplus accounts.

19.5 With due observance of the provisions of Article 19, (i) primarily and in so far as possible, a preferred dividend

is paid and added to the retained surplus account P on each Share P in the amount equal to the return made on the par
value of each Share P, and (ii) secondly, after application of the first sentence, a fixed percentage of three percent (3%)
of the distributable profit will be added to the retained surplus accounts S and L. That percentage will be calculated on
the basis of the status (i) in the retained surplus accounts S and L before profit distribution and (ii) in the S Share Premium
Reserve Account II and L Share Premium Reserve Account II. If a retained surplus account has a negative balance, interest
at a rate of three percent (3%) will be charged.

19.6 If any profit remains after the addition of interest referred to in Article 19.5, that profit will be carried to the

retained surplus accounts S, and L, pro rata to the nominal shareholdings of the Shares S and L, respectively.

19.7 If any loss remains after the addition of interest referred to in Article 19.5 above, that loss will be deducted from

the retained surplus accounts S and L, pro rata to the nominal shareholdings of the Shares S and L, respectively.

19.8 The Company may make interim additions to the surplus accounts if all the shareholders so decide by a unanimous

vote at a meeting under the following conditions:

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the Board of Managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Art. 20. Profit distribution.
20.1 The Company may make distributions from the distributable profit to the shareholders, only insofar as its equity

exceeds the capital increased by the reserves that must be maintained by law.

20.2 Profit will be distributed after adoption of the annual accounts evidencing that such distribution is permitted.
20.3 In calculating the profit distribution, the Shares held by the Company in its own capital will not be counted, unless

those Shares are encumbered with a pledge and the pledgee is entitled to the profit.

20.4 Distributions out of a retained surplus account can be made only to holders of Shares of the type in question.

Distributions may be made at any time, provided that the provisions of Article 20.1 are observed. A distribution can be
made only by resolution of the General Meeting.

20.5 The Company may make interim distributions only if the requirements of Article 20.1 have been met.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 21. Dissolution - Liquidation.
21.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

21.2 Out of the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company

shall (i) firstly, and in so far as possible, be paid on each Share P an amount equal to the par value of a Share P, and (ii)
secondly, the balance remaining after application of the first sentence shall be paid to the shareholder or, in the case of
a plurality of shareholders, the shareholders holding Shares S and L in proportion to the shares held by each such sha-
reholder in the Company.

VII. Definitions

22. In these Articles, the terms listed below have the following meaning:
Board of Managers means the board managers of the Company from time to time.
General Meeting means the general meeting of shareholders of the Company.
L Share Premium Account shall have the meaning set out in article 5.3. of the Articles.
L Share Premium Account II shall have the meaning set out in article 5.3. of the Articles.
P Share Premium Account shall have the meaning set out in article 5.3. of the Articles.
S Share Premium Account shall have the meaning set out in article 5.3. of the Articles.
S Share Premium Account II shall have the meaning set out in article 5.3. of the Articles.

97937

L

U X E M B O U R G

Shares means the shares of any class whatsoever with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) in the share capital

of the Company.

Supervisory Board means the supervisory board of the Company from time to time.
Supervisory Directors means the members of the Supervisory Board from time to time.

VIII. General Provision

23. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend the shareholder's register of the Company in order to reflect the above changes with

power and authority given to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of
the newly issued shares in the shareholder's register of the Company.

<i>Estimated costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 2,200.-.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties and signed together with us, the notary,

the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorherstehenden Textes:

Im Jahr zweitausend zwölf, am vierten Juli,
vor mir, Maître Martine Schaeffer, Notar mit Wohnsitz in Luxemburg,

fand eine außerordentliche Jahreshauptversammlung (die Versammlung) der Gesellschafter der B&amp;S Holding S.à r.l.

statt, einer privaten Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit eingetra-
genem Sitz in 18, place Bleech, L-7610 Larochette, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxem-
burg (HR) unter der Nummer B 135.944 mit einem gesetzlichen Stammkapital von EUR 5.000.000,- (die Gesellschaft).
Die Gesellschaft wurde am 30. Dezember 2007 gegründet gemäß einer Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit
Wohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, N° - 534 vom 4. März 2008. Die Satzung der Gesellschaft wurde letztmalig am 13. Januar 2010 durch einen Akt
von Maître Paul Decker, Notar mit Wohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welcher im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N° - 557 vom 16. März 2010 veröffentlicht wurde, geändert.

Es erschienen:

1. Sarabel Luxembourg S.à.r.l., eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit

eingetragenem Sitz in 10-12, rue Medernach, L-7619 Larochette, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im HR unter
der Nummer B 166.130 mit einem gesetzlichen Stammkapital von EUR 12.501,-;

hiermit vertreten durch Herrn Jérémie HOUET, berufsansässig in Luxemburg kraft einer privatschriftlich erteilten

Vollmacht;

2. Sarabel B.V. / S.à r.l, eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Haupt-

niederlassung  und  tatsächlichem  Verwaltungssitz  in  10-12,  rue  de  Medernach,  L-7619  Larochette,  Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im HR unter der Nummer B 136.083 mit einem gesetzlichen Stammkapital von EUR 18.000,-;

hiermit vertreten durch Herrn Jérémie HOUET, berufsansässig in Luxemburg kraft einer privatschriftlich erteilten

Vollmacht;

3. Lebaras Belgium B.V.B.A., eine nach belgischem Recht gegründete und organiserte Gesellschaft mit eingetragenem

Sitz in Ter Borcht 179, B-2930 Brasschaat, Belgien, eingetragen im Register für juristische Personen von Antwerpen unter
der MwSt.-Nummer BE 0985.104.716;

hiermit vertreten durch Herrn Jérémie HOUET, berufsansässig in Luxemburg kraft einer privatschriftlich erteilten

Vollmacht.

Die Vollmachten der Gesellschafter, nachdem sie ne varietur unterzeichnet wurden, durch den Bevollmächtigten, der

für die erscheinenden Parteien handelt und durch den unterzeichneten Notar sollen der vorliegenden und bei den Zu-
lassungsbehörden einzureichenden Urkunde angeheftet bleiben.

Die Gesellschafter haben den unterzeichneten Notar gebeten, Folgendes schriftlich niederzulegen:

97938

L

U X E M B O U R G

I. Dass die Gesellschafter Eigentümer aller Geschäftsanteile des Stammkapitals der Gesellschaft sind.
II. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
1. Verzicht auf die Einberufungsbekanntmachungen;
2. Schaffung von Klasse P Vorzugsanteilen (die P Anteile) mit solchen Rechten und Eigenschaften wie in der Satzung

der Gesellschaft dargelegt und wie sie zur Abänderung und Neufassung gemäß Punkt 6 der Tagesordnung vorgeschlagen
werden (die Satzung);

3. Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts;
4. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um zweihundertsiebenunddreißigtausend achthundertfünfundsiebzig

Euro (EUR 237.875,-), um das Stammkapital von seinem gegenwärtigen Betrag von fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-),
vertreten durch einhundertsechsundvierzigtausendsechshundertsechzig (146.660) S Anteile, und dreiundfünfzigtausendd-
reihundertvierzig (53.340) L Anteile in Form von Stammanteilen, mit einem Nominalbetrag von jeweils fünfundzwanzig
Euro (EUR 25,-) auf einen Betrag von fünf Millionen zweihundertsiebenunddreissigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro
(EUR 5.237.875,-) durch Emission von neuntausendfünfhundertfünfzehn (9.515) neuen P Anteilen mit einem Nominalbe-
trag von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) im Stammkapital der Gesellschaft zu erhöhen;

5. Zeichnung des und Zahlung für die Kapitalerhöhung wie in Punkt 4 beschrieben;
6. Nachfolgende Neufassung der Satzung;
7. Änderung des Gesellschafterregisters der Gesellschaft, um die oben genannten Änderungen widerzuspiegeln, wobei

jedem Geschäftsführer der Gesellschaft, die Vollmacht zukommen soll, für die Gesellschaft die Eintragung der neu emit-
tierten Geschäftsanteile in dem Register der Gesellschafter der Gesellschaft zu vollziehen;

8. Verschiedenes.
Nach Genehmigung des Vorausgehenden durch die Versammlung, wurden die folgenden Beschlüsse einstimmig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Da die Gesamtheit des Stammkapitals der Gesellschaft bei der Versammlung vertreten ist, verzichten die Gesellschafter

auf die Einberufungsbekanntmachungen, betrachten sich ferner als ordnungsgemäß einberufen und erklären, dass sie bes-
tens über die Tagesordnung, welche ihnen im Voraus mitgeteilt wurde, in Kenntnis gesetzt sind.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt Klasse P Anteile, mit solchen Rechten und Eigenschaften im Stammkapital der Gesellschaft

zu schaffen, wie sie in der neugefassten Satzung der Gesellschaft, wie sie im sechsten Beschluss unten Erwähnung findet,
dargelegt sind.

<i>Dritter Beschluss

Die  beiden  Gesellschafter  Sarabel  Luxembourg  S.à  r.l.  und  Sarabel  B.V.  /  S.à  r.l.  verzichten  auf  die  Ausübung  des

Vorkaufsrechts gemäß Artikel 7 der Satzung.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft um zweihundertsiebenunddreißigtausend achthun-

dertfünfundsiebzig Euro (EUR 237.875,-) zu erhöhen,

um das Stammkapital von seinem gegenwärtigen Betrag von fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-), vertreten durch

einhundertsechsund-vierzigtausendsechshundertsechzig (146.660) S Anteile, und dreiundfünfzigtausenddreihundertvier-
zig (53.340) L Anteile in Form von Stammanteilen, mit einem Nominalbetrag von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-)
auf  einen  Betrag  von  fünf  Millionen  zweihundertsieben-unddreissigtausendachthundertfünfundsiebzig  Euro  (EUR
5.237.875,-)

durch Emission von neuntausendfünfhundertfünfzehn (9.515) neuen P Anteilen mit einem Nominalbetrag von jeweils

fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) im Stammkapital der Gesellschaft zu erhöhen.

Die Versammlung genehmigt und akzeptiert die Zeichnung der und Zahlung für die neuntausendfünfhundertfünfzehn

(9.515) neuen P Anteile mit einem Nominalbetrag von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), wie unten dargelegt:

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt die folgende Zeichnung und volle Zahlung der Stammkapitalerhöhung wie folgt zu ak-

zeptieren und festzuhalten:

<i>Zeichnung - Zahlung

Die oben genannte Partei, Lebaras Belgium B.V.B.A., erklärt neuntausendfünfhundertfünfzehn (9.515) neue P Anteile

mit einem Nominalbetrag von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu zeichnen und sie voll bezahlt zu haben durch
Bareinlage  eines  Gesamtbetrages  von  zweihundertsiebenunddreißigtausendachthundertfünfundsiebzig  Euro  (EUR
237.875,-), welcher komplett dem Stammkapital der Gesellschaft zugeteilt werden soll.

97939

L

U X E M B O U R G

Daher ist der Betrag von zweihundertsiebenunddreißigtausend achthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 237.875,-) jetzt

im Besitz der Gesellschaft und ein Beleg dafür wurde dem unterzeichneten Notar rechtmäßig gegeben, welcher diesen
ausdrücklich anerkennt.

<i>Sechster Beschluss

Als Folge der vorangehenden Beschlüsse, beschließt die Versammlung die Satzung der Gesellschaft komplett neuzu-

fassen, welche nunmehr wie folgt lauten soll:

I. Firma - Eingetragener Sitz - Gegenstand - Dauer

Art. 1. Firma. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wird gegründet in Firma B&amp;S

HOLDING S.à r.l. (die Gesellschaft) und ist eine Gesellschaft nach dem Recht von Luxemburg, insbesondere dem Gesetz
vom 10. August 1915 für Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung (das Gesetz), sowie der vorliegenden
Satzung (die Satzung).

Art. 2. Eingetragener Geschäftssitz.
2.1. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in Larochette, Großherzogtum Luxemburg. Dieser

Sitz kann innerhalb der Stadtgrenzen durch Beschluss oder durch Entscheidung der Geschäftsführung verlegt werden.
Außerdem kann der eingetragene Geschäftssitz anhand eines Beschlusses des einzigen Gesellschafters oder der Haupt-
versammlung,  der  gemäß  der  in  der  Satzung  vorgesehenen  Weise  zu  verabschieden  ist,  an  einen  anderen  Ort  im
Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.2. Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder sonstige Geschäftsstellen können entweder im Großherzogtum Luxem-

burg oder im Ausland durch Beschluss des Vorstands eingerichtet werden. Wenn nach Ansicht der Geschäftsführung
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Zwischenfälle vorliegen, eingetreten sind oder unmit-
telbar bevorstehen und diese Entwicklungen oder Zwischenfälle die üblichen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft an
ihrem eingetragenen Geschäftssitz oder die Kommunikation zwischen diesem Geschäftssitz und Personen im Ausland
behindern, kann der eingetragene Geschäftssitz vorübergehend in das Ausland verlegt werden, bis die außergewöhnlichen
Umstände vollständig beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität
der Gesellschaft, die ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres eingetragenen Geschäftssitzes eine Gesellschaft
nach luxemburgischem Recht bleibt.

Art. 3. Zweck.
3.1. Die Gesellschaft befasst sich in Luxemburg oder im Ausland mit dem Erwerb von Beteiligungen an anderen Ge-

sellschaften oder Unternehmen jedweder Form sowie dem Management solcher Beteiligungen. Die Gesellschaft kann
diese Erwerbungen insbesondere durch Zeichnung oder Kauf von oder Tauschgeschäfte oder sonstige Transaktionen mit
Aktien, Anteilen oder sonstigen Anteilssicherheiten, Obligationen, Schuldverschreibungen, Depotscheinen oder sonstigen
Schuldurkunden und im allgemeinen jeglichen Sicherheiten und Finanzinstrumenten vornehmen, die von einer öffentlichen
oder privaten Organisation ausgegeben werden. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, dem Management und der
Kontrolle jeglicher Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen. Darüber hinaus kann sie in den Erwerb und das Ma-
nagement eines Portfolios von Patenten oder sonstigen geistigen Eigentumsrechten jeglicher Art und jeglichen Ursprungs
investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann in jeglicher Form, außer im Wege öffentlicher Zeichnungsangebote, Gelder aufnehmen.

Anteile können nur im Wege privater Platzierungen von Schuldverschreibungen und Obligationen und jeglicher Formen
von Verschuldungen und/oder Dividendenpapieren ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann Gelder verleihen, ein-
schließlich aber nicht beschränkt auf die Erlöse aus Geldaufnahmen und/oder der Ausgabe von Schuldverschreibungen an
ihre Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und/oder sonstige Gesellschaften. Sie kann außerdem Bürgschaf-
ten und bindende Versprechen abgeben, Sicherheiten bezüglich aller oder einiger ihrer Vermögenswerte übertragen,
belasten oder anderweitig bestellen und gewähren, um ihre eigenen Verpflichtungen und Zusagen und/oder Verpflich-
tungen und Zusagen anderer Gesellschaften und im allgemeinen zu ihrem eigenen Nutzen und/oder zum Nutzen anderer
Gesellschaften oder Personen zu gewährleisten bzw. zu sichern.

3.3. Die Gesellschaft kann jegliche Verfahren und Instrumente in Bezug auf ihre Investitionen zum Zwecke von deren

effizientem Management anwenden, einschließlich Verfahren und Instrumente, die dem Schutz der Gesellschaft gegenüber
Krediten, Wechselkursen, Zinssatzrisiken und sonstigen Risiken dienen.

3.4. Die Gesellschaft kann jegliche kommerziellen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten und jegliche Transaktionen

im Hinblick auf Immobilien oder bewegliches Vermögen vornehmen, die ihrem Zweck mittelbar oder unmittelbar dienen
oder damit zusammenhängen.

Art. 4. Dauer.
4.1 Die Gesellschaft wird für einen unbefristeten Zeitraum gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht wegen Tod, Aussetzung der Bürgerrechte, Arbeits/Geschäfts/Erwerbsunfähigkeit, In-

solvenz, Konkurs oder dementsprechende Vorfälle, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen, beendet.

97940

L

U X E M B O U R G

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Kapital der Gesellschaft wird auf fünf Millionen zweihundertsiebenunddreissigtausendachthundertfünfund-

siebzig Euro festgesetzt (EUR 5.237.875), aufgeteilt in hundertsechsundvierzigtausendsechshundertundsechzig (146.660)
S-Geschäftsanteile,  dreiundfünzigtausenddreihundertundvierzig  (53.340)  L-Geschäftsanteile,  und  neuntausendfünfhun-
dertfünfzehn (9.515) P Geschäftsanteile, jeder in registrierter Form mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR
25,-), wobei alle Geschäftsanteile gezeichnet und voll einbezahlt sind.

5.2. Die Geschäftsführung kann die verschiedenen Arten von Geschäftsanteilen fortlaufend nummerieren, beginnend

mit 1 (L1, S1 und P1). Unter gebührender Beachtung der Bestimmungen des vorstehenden Satzes, kann die Geschäfts-
führung die Nummerierung der verschiedenen Arten von Geschäftsanteilen ändern.

5.3 Jedes Emissionsagio, das hinsichtlich eines S-Geschäftsanteils bei seiner Ausgabe gezahlt wurde, soll einem Agio-

Rücklagenkonto der Gesellschaft zugewiesen werden (das S-Geschäftsanteil Agio-Rücklagenkonto und das S-Geschäfts-
anteil  Agio-  Rücklagenkonto  II)  und  jedes  Emissionsagio,  das  hinsichtlich  eines  L-Geschäftsanteils  bei  seiner  Ausgabe
gezahlt wurde soll einem Agio-Rücklagenkonto zugewiesen werden (das L-Geschäftsanteil Agio-Rücklagenkonto und das
L-Geschäftsanteil  Agio-Rücklagenkonto  II).  Jedes  hinsichtlich  jeglicher  P  Geschäftsanteile  bei  ihrer  Emission  gezahlte
Emissionsagio soll dem Agio-Rücklagenkonto (das P Geschäftsanteile Agio-Rücklagenkonto der Gesellschaft) zugewiesen
werden.

5.4. Das S-Geschäftsanteil Agio-Rücklagenkonto, das L-Geschäftsanteil Agio-Rücklagenkonto und das P Geschäftsan-

teile Agio-Rücklagenkonto können in das Grundkapital der Gesellschaft eingegliedert werden, gegen Ausgabe von S-
Geschäftsanteilen, L-Geschäftsanteilen und P Geschäftsanteilen, jeweils vorbehaltlich der Satzung.

Art. 6. Ausgabe von Geschäftsanteilen..
6.1 Mit der vorherigen Genehmigung des Aufsichtsrats kann die Generalversammlung im Rahmen einer Sitzung, bei

der mindestens zwei Drittel des ausgegebenen Kapitals vertreten sind, einstimmig die Ausgabe von Geschäftsanteilen
beschließen und den Ausgabepreis sowie die weiteren Bedingungen festlegen, wozu auch die Einzahlung in Form aus-
ländischer Währungen gehören kann.

6.2 Die Bestimmungen des Artikels 6.1 finden entsprechende Anwendung auf die Gewährung von Rechten zum Erwerb

von Anteilen, aber nicht für die Ausgabe von Anteilen an eine natürliche oder juristische Person bei deren Wahrnehmung
eines vorher gewährten Rechts auf Erwerb der Anteile gemäß den Bestimmungen des Artikels 6.1.

6.3 Die Ausgabe von Geschäftsanteilen bedarf der Ausstellung einer Urkunde vor einem Notar mit Sitz in Luxemburg,

die von der Gesellschaft und jeder natürlichen oder juristischen Person, die die betreffenden Geschäftsanteile erhält, als
Parteien zu unterzeichnen ist.

6.4 Die Gesellschaft ist bei Ausgabe von Geschäftsanteilen nicht zum Kauf berechtigt.

Art. 7. Vorkaufsrechte bei Ausgaben.
7.1 Bei Ausgabe von Geschäftsanteilen steht jedem Gesellschafter anteilmäßig zu dem Gesamtwert der von ihm am

Tag des Beschlusses über die Ausgabe von Anteilen gehaltenen Geschäftsanteile ein Vorkaufsrecht zu.

7.2 Nimmt ein Gesellschafter sein Vorkaufsrecht nicht wahr oder nicht fristgemäß oder nicht vollständig wahr, fällt

sein Vorkaufsrecht bzw. das Recht auf die verbleibenden Anteile in dem im Artikel 7.1 genannten Verhältnis den anderen
Gesellschaftern zu.

7.3 Die Generalversammlung kann in Bezug auf jede einzelne Ausgabe bestehende Vorkaufsrechte einschränken oder

ausschließen, vorausgesetzt, dies ist gleichzeitig mit der Verabschiedung des Beschlusses über die Ausgabe von Geschäfts-
anteilen beschlossen worden.

7.4  Die  Gesellschaft  ist  verpflichtet,  die  Ausgabe  von  Geschäftsanteilen,  bei  der  Vorkaufsrechte  ausgeübt  werden

können, sowie die von sämtlichen Gesellschaftern für die Wahrnehmung dieser Rechte einzuhaltende Frist bekannt zu
geben. Vorkaufsrechte können innerhalb der von der Generalversammlung bestimmten Frist wahrgenommen werden,
die ab dem Datum des Versands der Mitteilung mindestens vier Wochen beträgt.

7.5 Die vorstehenden Bestimmungen in diesem Artikel finden auf die Gewährung von Rechten zum Erwerb von Ge-

schäftsanteilen dementsprechende Anwendung.

Art. 8. Reduzierung des Stammkapitals.
8.1 Die Generalversammlung kann die Reduzierung des ausgegebenen Kapitals durch Rücknahme von Geschäftsanteilen

oder Reduzierung des Werts der einzelnen Anteile bei Änderung dieser Satzung beschließen.

8.2 Ein Beschluss über die Wiedereinziehung von Anteilen darf sich nur auf die von der Gesellschaft selbst gehaltenen

Geschäftsanteile beziehen.

8.3 Wenn die Generalversammlung eines Reduzierung des Werts der Geschäftsanteile bei Änderung dieser Satzung

beschließt, muss diese Reduzierung anteilmäßig unter Berücksichtigung sämtlicher Anteile vorgenommen werden, unab-
hängig davon, ob diese Reduzierung ohne Rückzahlungen oder mit Teilrückzahlungen auf die Anteile oder mit oder ohne
Freistellung von Zahlungsverpflichtungen erfolgt. Von dieser Vorschrift der Verhältnismäßigkeit kann mit Genehmigung
sämtlicher Gesellschafter abgewichen werden.

97941

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Geschäftsanteile.
9.1. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 19 erhält ein Gesellschafter mit jedem Geschäftsanteil einen Anteil

an den Vermögenswerten und Ergebnissen der Gesellschaft in direkter Proportion zu der bestehenden Gesamtanzahl
der Geschäftsanteile.

9.2. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind im Verhältnis zu der Gesellschaft nicht teilbar, sondern pro Anteil ist

nur ein Inhaber zugelassen. Gemeinschaftsinhaber sind zur Bestellung einer einzigen Person als ihrem Vertreter gegenüber
der Gesellschaft verpflichtet.

9.3 Die Geschäftsanteile können im Kreis der Gesellschafter oder, wenn nur ein einziger Gesellschafter besteht, an

Dritte abgetreten werden. Eine Abtretung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Personen, die nicht bereits Gesell-
schafter  sind,  unterliegt  der  vorherigen  Zustimmung  der  Generalversammlung,  bei  der  mindestens  drei  Viertel  des
Gesellschaftskapitals vertreten sein müssen. Im Todesfall unterliegt die Abtretung der Anteile des verstorbenen Gesell-
schafters an neue Gesellschafter der Zustimmung einer Dreiviertel-Mehrheit der anderen Gesellschafter im Rahmen einer
Generalversammlung. Diese Zustimmung ist allerdings nicht erforderlich, wenn Geschäftsanteile wegen Tod an die Eltern,
Abkömmlinge oder den überlebenden Ehegatten des Verstorbenen abgetreten werden. Eine Abtretung von Geschäfts-
anteilen  ist  für  die  Gesellschaft  bzw.  für  Dritte  nur  dann  verbindlich,  wenn  gemäß  Artikel  1690  des  Bürgerlichen
Gesetzbuchs eine Benachrichtigung an die Gesellschaft ergangen ist oder die Gesellschaft die Abtretung dementsprechend
anerkannt hat. Im Hinblick auf alle weiteren Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes verwiesen.

9.4 Geschäftsanteile können mit Pfandrechten versehen werden. Wenn bei Bestellung eines Pfandrechts vorgesehen

wird, dass der Pfandinhaber das Stimmrecht erhalten soll, steht ihm dieses Recht nur dann zu, wenn die Gewährung des
mit dem Pfandrecht verbundenen Stimmrechts und - bei Abtretung oder Übertragung des Pfandrechts - der dement-
sprechende Übergang des Stimmrechts - von der Generalversammlung einstimmig genehmigt worden ist. Wenn eine
andere Partei in die Rechte des Pfandinhabers eintritt, steht dieser Partei das Stimmrecht nur dann zu, wenn die Gene-
ralversammlung diesen Rechtseintritt im Rahmen einer Sitzung, bei der mindestens zwei Drittel des ausgegebenen Kapitals
vertreten sind, einstimmig genehmigt hat.

9.5. Die Gesellschaft unterhält an ihrem eingetragenen Geschäftssitz ein Gesellschafterregister gemäß den Bestim-

mungen des Gesetzes, dass von jedem Gesellschafter auf Wunsch eingesehen werden kann.

III. Geschäftsführung - Vertretung - Aufsichtsrat

Art. 10. Geschäftsführung und Aufsichtsrat.
10.1 Die Gesellschaft steht unter der Leitung einer Geschäftsführung, die aus einem oder mehreren Hauptgeschäfts-

führern (General Manager) und einem oder mehreren weiteren Geschäftsführern der Gesellschaft (Manager) besteht.
Weiterhin hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus einem oder mehreren Mitgliedern besteht. Die Anzahl der
Geschäftsführer und deren Titel bzw. Positionen sowie die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder werden von der General-
versammlung festgelegt.

10.2 Zu Mitgliedern der Geschäftsführung können sowohl natürliche als auch juristische Personen bestellt werden. In

den Geschäftsführungsrat können nur natürliche Personen bestellt werden.

10.3 Die Jahreshauptversammlung bestellt die Mitglieder der Geschäftsführung zu Hauptgeschäftsführern oder Ge-

schäftsführern und außerdem die Aufsichtsratsmitglieder.

10.4 Wird ein Kandidat für die Position eines Aufsichtsratsmitglieds vorgeschlagen, sind Alter, Beruf, der Wert der

von diesem Kandidaten an der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile sowie weitere für die Aufgabe eines Aufsichts-
ratsmitglieds sachdienlichen Positionen anzugeben, die dieser Kandidat besetzt oder besetzt hat. Weiterhin ist anzugeben,
mit  welchen  rechtlichen  Organisationen  der  Kandidat  bereits  als  Aufsichtsratsmitglied  verbunden  ist.  Gehören  diese
Organisation zu ein und demselben Konzern, reicht die Angabe des Konzerns aus. Darüber hinaus sind die Gründe für
die Nominierung anzugeben, und die Nominierung selbst ist vom Aufsichtsratsvorsitzenden vorzunehmen.

10.5 Die Mitglieder der Geschäftsführung und die Mitglieder des Aufsichtsrats können jederzeit von der Generalver-

sammlung von ihren Aufgaben suspendiert bzw. aus ihrem Amt enthoben werden. Der betreffenden Person wird dabei
die Gelegenheit erteilt, der Generalversammlung, die sich mit der Suspendierung bzw. Amtsenthebung befasst, Rechen-
schaft zu erteilen. Bei dieser Sitzung muss die betreffende Person von einem Rechtsberater vertreten werden.

10.6 Beschlüsse der Generalversammlung zur Bestellung, Suspendierung oder Amtsenthebung von Mitgliedern der

Geschäftsführung und des Aufsichtsrats dürfen nur bei Generalversammlungen verabschiedet werden, bei der mindestens
die Hälfte des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft vertreten ist und eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stim-
men dem betreffenden Beschluss zustimmt. Ist die erforderliche Beschlussfähigkeit bei einer Sitzung nicht gegeben, kann
eine zweite Sitzung anberaumt werden, die an einem bei der ersten Sitzung festzulegenden Datum innerhalb von min-
destens drei Wochen nach der ersten Sitzung stattfindet und bei der die betreffenden Beschlüsse unabhängig von der
Höhe des vertretenen Kapitals mit der vorgenannten Mehrheit verabschiedet werden können. In den Einladungen für die
neue Versammlung ist anzugeben, dass und aus welchen Gründen ein Beschluss unabhängig von der Höhe des vertretenen
Kapitals verabschiedet werden kann. Bei dieser zweiten Sitzung werden keine weiteren Angelegenheiten behandelt.

97942

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Vollmachten der Geschäftsführung.
11.1. Sämtliche Aufgaben, die kraft Gesetz oder dieser Satzung nicht ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten

sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Geschäftsführung, die sämtliche Vollmachten innehat, um alle Handlungen
und Geschäftstätigkeiten durchzuführen und zu genehmigen, die im Rahmen des Gesellschaftszwecks liegen.

11.2 Die folgenden Beschlüsse der Geschäftsführung bedürfen dann, wenn ein Betrag von über zwei Millionen fünf-

hunderttausend Euro (EUR 2.500.000,-) involviert ist, der Zustimmung des Aufsichtsrats:

a. Erwerb, Belastung, Abtretung, Leasing oder anderweitige Überlassung von Grundeigentum oder sonstigem regist-

riertem Eigentum;

b. Belastung von beweglichem Vermögen und Eigentumsrechten;
c. Eintritt in von der Gesellschaft ausgestellte finanzielle Darlehensverträge;
d. Gewährung von finanziellen Darlehen;
e. Haftbarmachung der Gesellschaft für Verschuldungen anderer Parteien im Wege von Bürgschaften oder anderweitig;
f. Abschluss von Verträgen;
g.  Führung  von  Gerichtsverhandlungen  -  als  Kläger  oder  Beklagter  -  vor  einem  ordentlichen  Gericht,  vor  einem

Schiedsgericht oder zwecks Einholung eines verbindlichen Rats, aber mit Ausnahme der Fälle, in denen diese rechtlichen
Schritte zur Unterbindung etwaiger Verzüge oder aus reinen Schutzgründen oder zur Beitreibung finanzieller Forderungen
aus gelieferten Waren bzw. erbrachten Dienstleistungen der Gesellschaft ergriffen werden;

h. Ausweitung der Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft zwecks Aufnahme einer neuen Geschäftslinie sowie Stilllegung

des Geschäfts der Gesellschaft oder Teilen davon, einschließlich einer Eigentums- oder Benutzungsrechtsübertragung;

i. Beteiligung oder anderweitige Übernahme von Anteilen an anderen Geschäftsbetrieben und die Beendigung oder

Änderung solcher Beteiligungen oder Anteile;

j. Abschluss, Kündigung und Änderung von Kooperations- und Poolingverträgen;
k. Erwerb, Belastung und Abtretung von geistigen Eigentumsrechten, einschließlich insbesondere gewerblichen Eigen-

tumsrechten und Urheberrechten, sowie Gewährung und Entgegennahme von Lizenzen und Unterlizenzen;

l. Erwerb von Anlagevermögen; und
m. Durchführung jeglicher Rechtshandlungen, soweit sie nicht bereits Gegenstand einer eine der vorstehenden Ziffern

sind.

11.3 Die Geschäftsführung ist darüber hinaus zur Einholung der Genehmigung des Aufsichtsrats verpflichtet, wenn die

Anstellung oder Entlassung von Mitarbeitern, die ein Jahresgehalt von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-)
beziehen, oder die Inanspruchnahme einer juristischen Person für Tätigkeiten der Gesellschaft gegen ein Jahreshonorar
von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-) beschlossen werden sollen.

11.4 Die in den Artikeln 11.2 und 11.3 oben genannten Genehmigungen sind im Falle von Wiederanstellungen oder

Erneuerungen bzw. Verlängerungen unter den gleichen Bedingungen wie denen bereits bestehender Verträge nicht er-
forderlich.

11.5  Außer  den  im  Artikel  11.2  dargelegten  Beschlüssen,  die  vorab  vom  Aufsichtsrat  zu  genehmigen  sind,  ist  der

Aufsichtsrat befugt, auch andere Beschlüsse der Geschäftsführung seiner Genehmigung zu unterwerfen, vorausgesetzt,
der Aufsichtsrat legt der Geschäftsführung eine genaue Beschreibung solcher Beschlüsse vor.

11.6 Können die Gesellschaft in Zusammenhang mit Beschlüssen, zu denen sie bevollmächtigt sind, keine Einigung

erzielen, entscheidet der Aufsichtsrat bei entsprechender Aufforderung, welche Beschlüsse der absoluten Mehrheit un-
terworfen sind. Bei Stimmengleichheit hat der Aufsichtsratsvorsitzende eine ausschlaggebende Stimme.

11.7 Genehmigt der Aufsichtsrat einen in diesem Artikel 11 genannten Beschluss nicht, hat dies keine Auswirkungen

auf die Befugnisse der Geschäftsführung oder ihrer Mitglieder auf Vertretung der Gesellschaft.

11.8. Für bestimmte Angelegenheiten können ein oder mehrere Handlungsbevollmächtigte unabhängig davon, ob sie

Gesellschafter sind oder nicht, besondere und beschränkte Vollmachten von einem oder, soweit die Geschäftsführung
aus mehr als einem Mitglied besteht, von zwei Geschäftsführern erhalten.

Art. 12. Verfahren.
12.1 Die Geschäftsführung hält ihre Sitzungen so oft ab, wie die Interessen der Gesellschaft es erforderlich machen

oder wann immer ein Mitglied der Geschäftsführung eine Sitzung einberuft; diese Sitzungen werden an dem in der Einla-
dung genannten Ort abgehalten.

12.2 Schriftliche Einladungen zu Sitzungen der Geschäftsführung sind allen Geschäftsführern mindestens 23 (vierund-

zwanzig) Stunden vor dem für eine Sitzung anberaumten Datum zu erteilen, außer in Notfällen, in denen die betreffenden
Umstände in der Einladung zu der Sitzung der Geschäftsführung zu benennen sind.

12.3 Eine derartige Einladung ist nicht erforderlich, wenn sämtliche Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft

bei einer Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung vollständig informiert sind
und Kenntnis erhalten haben. Auf die Einladung kann durch schriftliche Erklärung eines jeden einzelnen Geschäftsführers,
zu versenden im Original, per Telegramm, Telex, Faksimile oder E-Mail, verzichtet werden.

97943

L

U X E M B O U R G

12.4 Jeder Geschäftsführer kann sich bei Sitzungen der Geschäftsführung anhand einer schriftlichen Erklärung von

einem anderen Geschäftsführer vertreten lassen.

12.5 Die Geschäftsführung ist nur dann beratungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend

oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung bedürfen zwecks Gültigkeit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Diese Beschlüsse werden in einem Protokoll niedergelegt, das von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen
Mitgliedern zu unterzeichnen ist.

12.6 Jeder Geschäftsführer kann an den Sitzungen per Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder anhand dement-

sprechender Kommunikationsmittel teilnehmen, die es ermöglichen, dass alle Teilnehmer sich gegenseitig hören und
zueinander sprechen können. Eine Teilnahme an einer Sitzung anhand dieser Mittel gilt als persönliche Anwesenheit bei
der Sitzung.

12.7 In Rundschreiben niedergelegte Beschlüsse, die von allen Mitgliedern der Geschäftsführung unterzeichnet wurden,

sind genauso gültig und verbindlich wie Beschlüsse, die bei ordnungsgemäß abgehaltenen Sitzungen verabschiedet werden.
Die entsprechenden Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf unterschiedlichen Ausfertigungen ein
und desselben Beschlusses abgegeben werden; Unterschriften per Brief oder Fax sind gültig.

Art. 13. Vertretung. Gegenüber Dritten kann die Gesellschaft gebunden werden (a) in sämtlichen Angelegenheiten (i)

durch die gemeinsame Unterzeichnung von einem Hauptgeschäftsführer der Gesellschaft und von einem Geschäftsführer
oder (ii) durch die alleinige Unterschrift des Hauptgeschäftsführers, oder (b) durch die alleinige Unterschrift eines Ge-
schäftsführers bei geschäftlichen Angelegenheiten mit einem Wert bis zu fünftausend Euro (EUR 5.000,-) oder (c) durch
die gemeinsame oder einzelne Unterzeichnung der Personen, die gemäß Artikel 11.8 dieser Satzung eine gültige Zeich-
nungsvollmacht für eine Angelegenheit erhalten haben.

Art. 14. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer übernehmen im Rahmen ihrer Aufgaben keine persönliche

Haftung für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, vorausgesetzt, die Verpflichtungen
werden gemäß dieser Satzung und den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes übernommen.

Art. 15. Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats.
15.1 Der Aufsichtsrat hat die folgenden Aufgaben:
a. Beaufsichtigung der Politik der Geschäftsführung und der allgemeinen Angelegenheiten innerhalb der Gesellschaft

sowie der mit ihr verbundenen Geschäftsbetriebe; und

b. Beratung der Geschäftsführung.
15.2 Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stellen die Aufsichtsratsmitglieder die Interessen der Gesellschaft und der mit

ihr verbundenen Geschäftsbetriebe in den Vordergrund.

15.2  Bei Erhalt  einer  entsprechenden  Aufforderung  sind die  Geschäftsführer zur  Teilnahme an  den Sitzungen  des

Aufsichtsrats verpflichtet. Der Aufsichtsrat hält seine Sitzungen mindestens vier Mal pro Jahr ab, wobei die Geschäfts-
führung dem Aufsichtsrat mindestens fünfzehn Werktage vor Beginn des nächsten Geschäftsjahrs den Budget und den
Investitionsbudget zur Genehmigung vorzulegen hat. Der Aufsichtsrat muss außerdem spätestens sechs Monate nach
Ablauf des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahrs eine Sitzung abhalten, um den Jahresabschluss mit der Geschäftsfüh-
rung zu besprechen.

15.3 Sind im Aufsichtsrat eine oder mehrere Positionen unbesetzt, ist der Aufsichtsrat dennoch befugt, seine gesetz-

lichen und laut Satzung vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen.

15.4 Wenn und solange der Aufsichtsrat der Gesellschaft nur aus einem Mitglied besteht, wird dieses Mitglied die

gesetzlichen Vollmachten und Verpflichtungen des Aufsichtsrats wahrnehmen und erfüllen und dabei nach Maßgabe dieser
Satzung handeln.

15.5 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Den Vorsitz

der Aufsichtsratssitzungen hat der Aufsichtsratsvorsitzende oder im Falle von dessen Abwesenheit der stellvertretende
Vorsitzende; ist letztgenannter ebenfalls abwesend, wird der Vorsitzende bei der betreffenden Sitzung von den Anwe-
senden bestellt.

IV. Generalversammlungen

Art. 16. Vollmachten und Stimmrechte.
16.1 Der einzige Gesellschafter übernimmt sämtliche Vollmachten, die der Generalversammlung kraft Gesetz obliegen.
16.2 Jeder Gesellschafter hat die Stimmrechte, die ihm durch die von ihm gehaltenen Geschäftsanteile zustehen.
16.3 Jeder Gesellschafter kann sich anhand einer schriftlichen Stimmrechtsbevollmächtigung, die per Brief, Telegramm,

Telex, Faksimile oder E-Mail erteilt werden kann, bei Generalversammlungen von einer beliebigen Person oder Organi-
sation vertreten lassen.

Art. 17. Form - Beschlussfähigkeit - Mehrheit.
17.1 Soweit die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, können Entscheidungen der Gesell-

schafter  per  Rundschreiben  getroffen  werden,  dessen  Text  schriftlich  allen  Gesellschaftern  im  Original  oder  per
Telegramm,  Telex,  Faksimile  oder  E-Mail  zuzustellen  ist.  Die  Gesellschafter  geben  in  diesem  Fall  ihre  Stimme  durch

97944

L

U X E M B O U R G

Unterzeichnung des in dem Rundschreiben schriftlich verfassten Beschlusses ab. Diese Unterschriften können auf einem
einzigen Dokument oder auf unterschiedlichen Ausfertigungen ein und desselben Beschlusses abgegeben werden; Un-
terschriften per Brief oder Faksimile sind gültig.

17.2 Gemeinschaftliche Beschlüsse sind nur dann gültig, wenn sie von einer Anzahl von Gesellschaftern angenommen

werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten.

17.3 Beschlüsse über die Änderung der Satzung oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft bedürfen allerdings

der mehrheitlichen Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft ver-
treten.

V. Jahresabschlüsse - Zuweisung der Ergebnisse

Art. 18. Geschäftsjahr.
18.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines

jeden Jahres.

18.2 Die Abschlüsse der Gesellschaft sind in jedem Jahr zum Ende des Geschäftsjahres zu erstellen, und der Ge-

schäftsführer oder, soweit die Gesellschafter mehrere Geschäftsführer hat, die Geschäftsführung hat eine Bestandsliste
mit Angabe des Wertes der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu diesem Stichtag aufzustellen.

18.3 Jeder Gesellschafter hat das Recht, die vorgenannte Bestandsliste und die Bilanz am eingetragenen Geschäftssitz

der Gesellschaft einzusehen.

Art. 19. Zuweisung der Ergebnisse.
19.1 Die im Jahresabschluss angegebenen Brutto-Gewinne der Gesellschaft, nach Abzug der allgemeinen Kosten, Ab-

schreibungen und Aufwendungen stellen den Nettogewinn dar. Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettoge-
winns der Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage zugewiesen, bis diese Rücklage sich auf zehn Prozent (10%) des
nominalen Stammkapitals der Gesellschaft beläuft.

19.2 Nach der in Artikel 19.1 erwähnten Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage, steht der restliche Gewinn der Ver-

sammlung zur Verfügung, unter Beachtung der folgenden Bestimmungen.

19.3 Die Gesellschaft wird ein Gewinnkonto S, ein Gewinnkonto L und ein Gewinnkonto P haben. Die Inhaber von S-

Geschäftsanteilen werden nur ein Anrecht auf das Gewinnkonto S haben. Die Inhaber von L-Geschäftsanteilen werden
nur ein Anrecht auf das Gewinnkonto L haben. Die Inhaber von P-Geschäftsanteilen werden nur ein Anrecht auf das
Gewinnkonto P haben.

19.4 Die Versammlung wird unter gebührender Beachtung der Bestimmungen aus den nachfolgenden Absätzen ent-

scheiden, welcher Teil des Gewinns rückgestellt werden soll, welcher Teil verteilt werden soll und welcher Teil den
Gewinnkonten zugeteilt oder im Falle von Verlusten von den Gewinnkonten abgezogen wird.

19.5 Unter gebührender Beachtung der Bestimmungen des Artikels 19, (i) wird in erster Linie und sofern möglich eine

Vorzugsdividende gezahlt und für jeden P-Geschäftsanteil dem Gewinnkonto P in der Höhe der bezüglich jeden P-Ge-
schäftsanteils gemachten Rendite zum Nominalwert zugeführt und (ii) zweitens, nach Anwendung des ersten Satzes, wird
ein fester Prozentsatz von drei Prozent (3%) des verteilbaren Gewinns den Gewinnkonten S und L zugefügt. Dieser
Prozentsatz wird auf der Grundlage des Status (i) in den Gewinnkonten S und L vor Gewinnverteilung und (ii) in dem S
Agio-Rücklagenkonto II und dem L Agio-Rücklagenkonto II berechnet werden. Wenn ein Gewinnkonto ein negatives
Saldo aufweist werden Zinsen in Höhe von drei Prozent (3%) berechnet.

19.6 Wenn nach Zufügung der in Artikel 19.5 erwähnten Zinsen ein Gewinn bleibt, dann wird dieser Gewinn den

Gewinnkonten S und L proratarisch nach den nominalen Beteiligungen der jeweiligen S- und L-Geschäftsanteile zugeteilt.

19.7 Wenn nach Zufügung der oben in Artikel 19.5 erwähnten Zinsen ein Verlust bleibt, dann wird dieser Verlust von

den  Gewinnkonten  S  und  L  proratarisch  nach  den  nominalen  Beteiligungen  der  jeweiligen  S-  und  L-Geschäftsanteile
abgezogen.

19.8 Die Gesellschaft kann zwischenzeitige Ergänzungen zu den Gewinnkonten machen, wenn alle Gesellschafter dies

durch ein einstimmiges Votum bei einem Treffen unter den folgenden Bedingungen beschliessen:

(i) Ein Rechenschaftsbericht oder eine Bestandsliste oder ein Bericht wird durch die Geschäftsführung verfasst;
(ii) Dieser Rechenschaftsbericht oder diese Bestandsliste oder dieser Bericht zeigt, dass ausreichende Mittel zur Ver-

teilung zur Verfügung stehen, wobei es das Verständnis aller sein soll, dass der zu verteilende Betrag den seit dem Ende
des letzten Geschäftsjahres realisierten Gewinn, erhöht um den Gewinnvortrag und verteilbare Rückstellungen aber
gemindert um den Verlustvortrag und die Summen, die der gesetzlichen Rücklage zuzuteilen sind, nicht überschreiten
soll;

(iii) Es wurde Sicherheit erlangt, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind.

Art. 20. Gewinnausschüttung.
20.1  Die  Gesellschaft  kann  aus  den  ausschüttbaren  Gewinnen  Ausschüttungen  an  die  Gesellschafter  nur  insoweit

vornehmen, wie ihr Eigenkapital den Betrag des Kapitals, erhöht um die kraft Gesetz zu unterhaltenden Rücklagen, über-
schreitet.

97945

L

U X E M B O U R G

20.2 Der Gewinn wird nach Feststellung des Jahresabschlusses und des Nachweises, dass die Ausschüttung zulässig ist,

ausgeschüttet.

20.3 Bei der Berechnung der Gewinnausschüttung werden die von der Gesellschaft als deren eigenes Kapital gehaltenen

Geschäftsanteile nicht mitgezählt, es sei denn, diese Anteile sind mit Pfandrechten belastet und der Pfandinhaber hat
Anspruch auf Gewinne.

20.4 Ausschüttungen aus einem Gewinnkonto dürfen nur an die Inhaber der Geschäftsanteile der zugehörigen Klasse

vorgenommen werden. Ausschüttungen können jederzeit durchgeführt werden, vorausgesetzt, die Bestimmungen des
Artikels 20.1 werden eingehalten. Eine Ausschüttung bedarf eines Beschlusses der Generalversammlung.

20.5 Die Gesellschaft kann nur dann Zwischenausschüttungen vornehmen, wenn die Voraussetzungen des Artikels

20.1 erfüllt sind.

VI. Auflösung - Liquidation

Art. 21. Auflösung - Liquidation.
21.1 Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Abwicklern durchgeführt,

der/die nicht Gesellschafter sein muss/müssen und durch Beschluss des einzigen Gesellschafters oder der Generalver-
sammlung bestellt wird/werden, der/die auch die Vollmachten und Vergütungen für den/die Abwickler festlegt. Soweit in
dem Beschluss des/der Gesellschafter/s oder kraft Gesetz nicht anderweitig vorgesehen, werden die Abwickler mit den
weitestgehenden Vollmachten für die Flüssigmachung der Vermögenswerte und Zahlung der Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft ausgestattet.

21.2 Aus dem nach Flüssigmachung der Vermögenswerte und Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ver-

bleibenden  Überschuss  soll  (i)  erst  und  sofern  möglich,  hinsichtlich  jeden  P-Geschäftsanteils  ein  Betrag  der  dem
Nominalwert des P-Geschäftsanteils entspricht eine Vorzugsdividende gezahlt werden, und (ii) zweitens, der nach An-
wendung des ersten Satzes verbleibende Restbetrag an die Gesellschaft oder, soweit mehrere Gesellschafter vorhanden
sind, an die Inhaber der Geschäftsanteile der Klassen S und L in Proportion zu den von jedem einzelnen Gesellschafter
gehaltenen Anteilen gezahlt werden.

VII. Definitionen

22. In dieser Satzung haben die nachfolgend aufgeführten Begriffe die ihnen hier zugeordneten Bedeutungen:
Geschäftsführung sind die von Zeit zu Zeit bestehenden Geschäftsführer der Gesellschaft.
Hauptversammlung ist die Hauptversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft.
L Agio-Rücklagenkonto hat die Bedeutung wie in Artikel 5.3 der Satzung festgesetzt.
L Agio-Rücklagenkonto II hat die Bedeutung wie in Artikel 5.3 der Satzung festgesetzt.
P Agio-Rücklagenkonto II hat die Bedeutung wie in Artikel 5.3 der Satzung festgesetzt.
S Agio-Rücklagenkonto hat die Bedeutung wie in Artikel 5.3 der Satzung festgesetzt.
S Agio-Rücklagenkonto II hat die Bedeutung wie in Artikel 5.3 der Satzung festgesetzt.
Geschäftsanteile sind die Geschäftsanteile der jeweiligen Klassen im Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) am

Stammkapital der Gesellschaft.

Aufsichtsrat ist der von Zeit zu Zeit bestehende Aufsichtsrat der Gesellschaft.
Aufsichtsratsdirektoren meint die Mitglieder des Aufsichtsrates von Zeit zu Zeit.

VIII. Allgemeine Bestimmungen

23. Für sämtliche Angelegenheiten, die in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes

verwiesen.

<i>Siebter Beschluss

Die Versammlung beschließt das Gesellschafterregister der Gesellschaft zu ändern, um die oben genannten Änderun-

gen widerzuspiegeln, wobei jedem Geschäftsführer der Gesellschaft, die vollumfängliche Vollmacht zukommen soll, für
die Gesellschaft die Eintragung der neu emittierten Geschäftsanteile in dem Register der Gesellschafter der Gesellschaft
zu vollziehen.

<i>Kostenschätzung

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Abgaben jeglicher Art, welche von der Gesellschaft als Folge der vorlie-

genden Urkunde getragen werden müssen, werden auf EUR 2.200,- geschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten

Parteien die vorliegende Urkunde auf Englisch formuliert ist, gefolgt von einer deutschen Version, und auf Bitte der
gleichen erscheinenden Parteien, dass im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem deutschen Text
die englische Version Vorrang hat.

97946

L

U X E M B O U R G

Womit die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg erstellt ist, im Jahr und am Tage wie oben beschrieben.
Das Dokument wurde den Bevollmächtigten der erscheinenden Parteien verlesen, die Bevollmächtigten der erschein-

enden Parteien haben zusammen mit mir, dem Notar, die vorliegende Original-Urkunde unterzeichnet.

Signé: J. Houet et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2012. LAC/2012/31514. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signée): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087379/912.
(120124101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Arlene S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 81.517.

Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco C&amp;T (Luxembourg)

SA informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 10 juillet, 2001 pour une durée indéterminée
entre les deux sociétés:

Arlene SA, ayant son siège social au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS B 81517 et Citco C&amp;T

(Luxembourg) SA ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg, avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Christelle Ferry / Fabio Spadoni.

Référence de publication: 2012088964/12.
(120125631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Arelux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 159.737.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 19 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088962/10.
(120125962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

ARGO IMMOBILIERE société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3961 Ehlange, 35B, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 110.969.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012088963/10.
(120126251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Auberge du Lac, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6841 Machtum, 77, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 19.140.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012088968/9.
(120125488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

97947

L

U X E M B O U R G

Jones Lang LaSalle Luxembourg Star S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 74.327.025,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 41, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 105.309.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 1 

<i>er

<i> décembre 2011

Jones Lang LaSalle Global Finance Luxembourg S.à r.l. et Jones Lang LaSalle Finance Luxembourg S.à r.l., les associés

de la Société (les Associés):

(i) ont noté et accepté la démission de M. Olivier BASTIN de son mandat de gérant de la Société avec effet au 31

octobre 2011 et;

(ii) ont décidé de nommer M. Romain MULLER, dont l’adresse est située au 48, rue de la Gare, L-8325 Capellen,

Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 31 octobre 2011 et pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jones Lang LaSalle Luxembourg Star S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012089263/19.
(120125738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Avanza Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.812.178,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.809.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088969/10.
(120125793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Avanza S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 544.252,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.744.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088970/10.
(120125798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Avencor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 54.930.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012088971/9.
(120125918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

97948

L

U X E M B O U R G

Creche Mini-Snoopy S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 62, rue de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 141.343.

<i>Extrait des résolutions l'assemblée générale extraordinaire du 05 juillet 2012.

L'assemblée a pris acte de la cession de parts sociales intervenue en date du 05 Juillet 2012:
Madame Vasilica PANICAN-MAGDALINOIU, née le 06 Juillet 1963 à Bucarest (Roumanie),
demeurant à B-6780 Messancy, 68 rue Emile KIRSCH
Cède 25 parts sociales de la société à responsabilité limitée «Crèche Mini-Snoopy Sàrl» à
Madame Susana PEREIRA CARDOSO, née le 18 novembre 1982 à Luxembourg,
demeurant L-4026 ESCH SUR ALZETTE, 173 rue de Belvaux
A la suite de cette cession, les parts sociales représentant l'intégralité du capital
de la société à responsabilité limité sont détenues à
75 % par Madame Vasilica PANICAN-MAGDALINOIU
25% par Madame Susana PEREIRA CARDOSO
L'assemblée a décidé de nommer au poste de gérante technique:
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée,
Madame Susana PEREIRA CARDOSO,
née le 18 novembre 1982 à Luxembourg,
demeurant L-4026 ESCH SUR ALZETTE, 173 rue de Belvaux
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089072/25.
(120125675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Central Investments DBI, Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 82.386.

<i>Rectificatif du dépôt numéroté L090135852 en date du 28 aout 2009

Les comptes annuels consolidés de la société au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012089018/13.
(120125536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

BlueOrchard Loans for Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 127.644.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 3 juillet 2012

Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de BDO Audit, ayant son siège social au 2, avenue Charles

De Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 147 570 au Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société concernant l'audit des comptes annuels se clôturant le 31 dé-
cembre 2012.

A Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2012088983/16.
(120125579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

97949

L

U X E M B O U R G

Avencor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 54.930.

AUSZUG

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche am 25. Juni 2012
abgehalten wurde, geht folgendes hervor:
1. Die Ämter der Verwaltungsräte:
- Dieter GROZINGER DE ROSNAY, wohnhaft in L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix
- Marco FRITSCH, wohnhaft in L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix,
- Sonja HERMES, mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix werden bis zur ordentlichen Ge-

neralversammlung des Jahres 2018 verlängert.

2. Das Amt der Rechnungsprüferin Frau Sylvie PORTENSEIGNE, mit Geschäftsadresse in L-1331 Luxemburg, 57,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, wird bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018 verlängert.

Luxemburg, den 20. Juli 2012.

Référence de publication: 2012088972/18.
(120125943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Central Investments DBI, Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 82.386.

<i>Rectificatif du dépôt numéroté L090135853 en date du 28 aout 2009

Les comptes annuels consolidés de la société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012089019/13.
(120126051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Bodycote Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.885.600,00.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 89.602.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth of June at 4:30 p.m.
Before Us Maître Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BODYCOTE INTERNATIONAL LIMITED, a private limited liability company duly incorporated and validly existing

under the laws of England and Wales, having its registered office at Springwood Court, Springwood Close, GB-SK102XF
Macclesfield Cheshire, United Kingdom, and registered with the Companies House under number 01036959 (the "Sole
Shareholder"),

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. That the appearing party, aforementioned, is currently the sole shareholder of the société à responsabilité limitée

(private limited liability company) existing in Luxembourg under the name of BODYCOTE LUXEMBOURG HOLDINGS
S.A R.L., having its registered office at 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register)
under number B 89.602 (the "Company"), and, incorporated by a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Lu-
xembourg, on October 18, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1706,
on November 29, 2002, page 81873, and which articles of association (the "Articles") have been amended for the last

97950

L

U X E M B O U R G

time on December 17, 2010 by a deed of Maître Paul Frieders, aforementioned, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations under number 613, on April 1 

st

 , 2011, page 29414.

II. That the Company's share capital amounts to four million eight hundred eighty-five thousand six hundred Euros

(EUR 4,885,600) represented by one thousand nine hundred seventy (1,970) shares of two thousand four hundred eighty
Euro (EUR 2,480) each.

III. That the Sole Shareholder declares that it has full knowledge of the agenda prior to the present meeting and agrees

to waive the notice requirements, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV. That the agenda of the meeting is the following:
1) Approval of the transfer of the registered office and effective place of management and control from Luxembourg

to Jersey (the "Migration"), with effective date as at the date when the formalities to register the Company in Jersey have
been duly fulfilled (the "Effective Date") and effect the transfer of the registered office of the Company from 6c, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg to 13 Castle Street, JE4 5UT St. Helier, Jersey, Channel
Islands;

2) Adoption of the new bylaws of the Company;
3) Acknowledgment of the resignations of the existing managers of the Company and granting them full discharge for

the execution of their mandate;

4) Appointment of new managers of the Company;
5) Granting of powers of attorney to any member of the new management of the Company appointed hereto, so that

any of them by his own signature is entitled, acting on behalf of the Company, to execute any actions and steps which
may be necessary for its registration in Jersey;

6) Miscellaneous;
V. That, on basis of the agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the Migration. The registered office, place of effective management and

central place of administration of the Company shall be set at 13 Castle Street, JE4 5UT St. Helier, Jersey, Channel Islands.

Pursuant to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and Jersey, the Migration from the Grand Duchy of Luxem-

bourg to Jersey does not affect the legal continuance of the Company.

<i>Second resolution

As a result of the Migration and under the condition (condition suspensive) of the registration of the present deed

with the Jersey Financial Services Commission, the Company shall operate in Jersey under the same name for the time
being.

The Sole Shareholder resolves to proceed to the amendment of the Articles so as to ensure that they comply with

the requirements of Jersey law.

This resolution is subject to the execution, filing and enactment of all legal formalities under Jersey law.
A copy of the amended Articles shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authority.

<i>Third resolution

Subject to the approval of the Migration by the relevant Jersey authority, the Sole Shareholder acknowledges the

resignation of the following managers, as of the Effective Date, of and resolves to grant discharge to them for the execution
of their mandate:

- Mr. Christophe Gaul with professional address at 17 rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg;

- Mr. Jorg Stinshoff, with professional address at Robert-Bosch-Str. 2a, D-50354 Hürth, Germany;
- Mr. Wolfgang Plech, with professional address at Buchwiesen 6, D-73061 Ebersbach, Germany;
- Mr. Franz Karl Strick, with professional address at 13, Pingsdorferstrasse, D-50321 Bruehl,

<i>Fourth resolution

Subject to the approval of the Migration by the relevant Jersey authority, the Sole Shareholder resolves to appoint, as

of the Effective Date, the following persons as new managers of the Company:

- Mr. David Smaller, born on October 1, 1961 in Appleton, Cheshire, United Kingdom, with professional address at

13, Castle Street St Helier, Jersey, Channel Islands JE4 5UT,

- Mr. Carl Andrew Pollard, born on September 1, 1966 in Coventry, United Kingdom, with professional address at

13, Castle Street St Helier, Jersey, Channel Islands JE4 5UT,

- Mr. Franz Karl Strick, with professional address at 13, Pingsdorferstrasse, D-50321 Bruehl,
As a result, subject to the approval of the Migration by the relevant Jersey authority, the managers of the Company

shall be the following persons as of the Effective Date:

97951

L

U X E M B O U R G

- Mr. David Smaller;
- Mr. Carl Andrew Pollard;
- Mr. Franz Karl Strick.

<i>Fifth resolution

Subject to the approval of the Migration by the relevant Jersey authority, the Sole Shareholder resolves to grant powers

of attorney to any member of the new management of the Company appointed hereto, acting individually to carry out
any action necessary or incidental in relation to the above taken resolutions and particularly to perform any action or
deed necessary for the registration of the Company in Jersey.

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately at two thousand EURO (EUR 2,000.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the person appearing, she signed together with the notary the present

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-cinq juin, à seize heures trente.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

A comparu:

BODYCOTE INTERNATIONAL LIMITED, une société à responsabilité limitée, dûment constituée sous les lois d'An-

gleterre et du Pays de Galle, ayant son siège social à Springwood Court, Springwood Close, GB-SK102XF Macclesfield
Cheshire, Royaume-Uni, et enregistrée auprès du registre des sociétés («Companies House») sous le numéro 01036959
Associé Unique»),

Représentée par Mr. Régis Galliotto, clerc de notaire, ayant sont adresse professionnelle au 101, rue de Cents, L-1319

Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que le comparant, précité, est l'associé unique de la société à responsabilité limitée existant au Luxembourg sous

le nom de BODYCOTE LUXEMBOURG HOLDING SARL, ayant son siège social situé au 6c, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand-duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 89602 (la «Société»), et, constituée par un acte de Maître Paul Frieders, notaire de résidence
à Luxembourg, le 18 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1706, le
29 novembre 2002, page 81873, et dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le 17 décembre
2010 par un acte de Maître Paul Fieders, précité, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le
numéro 613, le 1 

er

 avril 2011, page 29414.

II. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille six cents

euros (EUR 4.885.600) représentés par mille neuf cent soixante-dix (1.970) parts sociales ayant une valeur nominale de
deux mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR 2.480) chacune.

III. Que l'Associé Unique déclare avoir eu connaissance complète de l'agenda avant la présente assemblée et accepte

de renoncer aux formalités de convocation afin que l'assemblée puisse délibérer valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour.

IV. Que l'agenda de l'assemblée est le suivant:
1) Approbation du transfert du siège social et du lieu de direction et de contrôle effectif de Luxembourg à Jersey (la

«Migration»), effectif à la date à laquelle les formalités d'enregistrement de la Société à Jersey seront remplies (la «Date
Effective») et effectuer le transfert du siège social de la Société du 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-
duché de Luxembourg au 13 Castle Street, JE4 5UT St. Helier, Jersey, Channel Islands;

2) Adoption des nouveaux statuts de la Société;
3) Reconnaissance des démissions des gérants actuels de la Société et décharge pleine et entière pour l'exécution de

leur mandat;

4) Nomination des nouveaux gérants de la Société;

97952

L

U X E M B O U R G

5) Pouvoir donner à tout membre du nouvel organe de gestion de la Société nommé, afin que chacun des membres

soit autorisé par sa signature à prendre, au nom de la Société, les actions et décisions nécessaires à l'enregistrement de
la Société à Jersey;

6) Divers.
V. Sur base de l'ordre du jour, l'Associé Unique prend les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'approuver la Migration. Le siège social, le lieu de direction et de contrôle et la place centrale

d'administration de la Société seront situés au 13, Castle Street, JE4 5UT St. Helier, Jersey, Channel Islands.

Conformément aux lois du Grand-duché de Luxembourg et de Jersey, la Migration du Grand-duché de Luxembourg

à Jersey n'affecte pas la continuité de la personnalité juridique de la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la Migration et sous la condition (condition suspensive) de l'enregistrement du présent acte auprès

de la Commission des Services Financier de Jersey (Jersey Financial Services Commission), la Société opérera à Jersey
sous la même dénomination qu'actuellement.

L'Associé Unique décide de procéder à la modification des Statuts afin de s'assurer qu'ils soient conformes aux exi-

gences du droit de Jersey.

Cette résolution est sujette à l'exécution, au dépôt, et la promulgation de toutes les formalités juridiques du droit de

Jersey.

Une copie des Statuts modifiés devront rester joints au présent acte afin d'être déposée auprès de l'autorité d'enre-

gistrement.

<i>Troisième résolution

Sous la condition de l'approbation de la Migration par l'autorité compétente de Jersey, l'Associé Unique accepte la

démission des gérants suivants, à la Date Effective, et décide de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution
de leur mandat:

- M. Christophe Gaul résidant professionnellement au 17 rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, Grand-duché de

Luxembourg;

- M. Jorg Stinshoff, résidant professionnellement au Robert-Bosch-Str. 2a, D-50354 Hürth, Allemagne;
- M. Franz Karl Strick, residant professionnellement au 13, Pingsdorferstrasse, D-50321 Bruehl,
- M. Wolfgang Plech, résidant professionnellement au Buchwiesen 6, D-73061 Ebersbach, Allemagne.

<i>Quatrième résolution

Sous la condition de l'approbation de la Migration par l'autorité compétente de Jersey, l'Associé Unique décide de

nommer, à la Date Effective, les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société:

- M. David Smaller, né le 1 

er

 octobre 1961 à Appleton, Cheshire, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au

13, Castle Street St Helier, Jersey, Channel Islands JE4 5UT,

- M. Carl Andrew Pollard, né le 1 

er

 septembre 1966 à Coventry, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au

13, Castle Street St Helier, Jersey, Channel Islands JE4 5UT,

- M. Franz Karl Strick, residant professionnellement au 13, Pingsdorferstrasse, D-50321 Bruehl,
En conséquent, sous la condition de l'approbation de la Migration par l'autorité compétente de Jersey, les gérants de

la Société seront les personnes suivantes à partir de la Date Effective:

- M. David Smaller;
- M. Carl Andrew Pollard;
- M. Franz Karl Strick.

<i>Cinquième résolution

Sous la condition de l'approbation de la Migration par l'autorité compétente de Jersey, l'Associé Unique décide de

donner procurations à tout membre du nouvel organe de gestion de la Société nommé par la présente assemblée, agissant
individuellement afin de prendre toute action nécessaire ou accessoire en relation avec les résolutions ci-dessus et en
particulier pour procéder à toute action ou acte nécessaire à l'enregistrement de la Société à Jersey.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ deux mille Euros (2.000.- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

97953

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataires des comparants, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31241. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088120/196.
(120125119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Bridon SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 165.653.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société en date du 25 mai

<i>2012

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. d'accepter la démission de la société SV SERVICES Sàrl de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société.
2. de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société ACCOUNTIS S.A, ayant son

siège son social au 4, Rue Jean-Pierre Probst à L-2352 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le n° B146381. Sa mission commencera par la revue des comptes arrêtés au 31 décembre 2011 et
son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme

Clemency, le 17 juillet 2012.

Référence de publication: 2012089005/17.
(120125513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Axis Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.670.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012088973/9.
(120126261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

CAP Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PM Group S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 163.128.

In the year two thousand and twelve, on the eleventh of July.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PM GROUP, a Luxembourg limited

liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 12, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 163.128 (the Company). The
Company has been incorporated on August 19 

th

 , 2011 pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing

in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2562
of October 21 

st

 , 2011. The articles of association (the Articles) of the Company have been amended latest on May 16

th

 2012 pursuant to a deed of Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1599 of June 26 

th

 2012.

The Meeting is chaired by Mr Lorenzo Barcaglioni, private employee, professionally residing at 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Mrs Mia Voss, private employee, professionally residing at the same address, as secretary of

the Meeting (the Secretary).

97954

L

U X E M B O U R G

The Meeting elects Mr Jean Barret, private employee, professionally residing at the same address, as scrutineer of the

Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The shareholders of the Company represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on

an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of
the shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders of the Company represented at the Meeting, after having been signed ne varietur

by the proxyholder and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.

The Bureau having thus been validly constituted, the Chairman requests the notary to record:
I. that it appears from the attendance list that all of the 116,500,000 (one hundred and sixteen million five hundred

thousand ) shares, having a nominal value of one Penny (GBP 0,01) each, representing the entire subscribed share capital
of the Company are present or duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly
deliberate on all the items on the agenda hereinafter reproduced, the shareholders represented at the Meeting having
agreed to meet after examination of the agenda.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Change of the name of the Company from "PM GROUP S.a r.l." to "CAP Group S.a r.l.";
2. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting unanimously waives

the convening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change the name of the Company from "PM GROUP S.a r.l." to "CAP Group S.a r.l.".

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 1 of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of «CAP Group S.à r.l.».»

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

There being no further business on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of the present

deed.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names

and residences, the said persons signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le onze juillet.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de PM GROUP S.à r.l., une société à

responsabilité de droit luxembourgeois ayant son siège social sis 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.163.128 (la Société). La Société a
été constituée le 19 août 2011 par un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, publié dans le Memorial C du Recueil des Sociétés et Associations n°2562 du 21 octobre 2011.
Les statuts de la société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Marc LOESCH,

97955

L

U X E M B O U R G

notaire  de  résidence  à  Mondorf-les-Bains,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  publié  dans  le  Memorial  C  du  Recueil  des
Sociétés et Associations n°1599 du 26 juin 2012.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lorenzo Barcaglioni, employé privé, demeurant professionnel-

lement à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Mia Voss, employée privée, demeurant professionnellement à la même.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Barret, employé privé, demeurant professionnellement à la

même adresse.

Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau.
Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux ressortent d'une liste

de présence, signée par les associés et/ou les mandataires des associés représentés en vertu de procurations émises par
ces derniers et les membres du Bureau. Cette liste de présence ainsi que les procurations, après avoir été signées ne
varietur par les mandataires des associés représentés et par le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes
minutes.

Le Bureau étant ainsi constitué, le président prie le notaire d'acter que:
I. qu'il apparaît d'après la liste de présence que l'ensemble des 116.500.000 (cent seize millions cinq cent mille) actions

ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0.01) chacune, représentant la totalité du capital social souscrit de la Société,
est dûment représenté à l'Assemblée qui est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les
points de l'ordre du jour produit ci-dessous, les associés représentés à l'Assemblée ayant accepté de tenir l'Assemblée
après examen de l'ordre du jour. Cette liste de présence ainsi que les procurations, après avoir été signées ne varietur
par les mandataires des associés représentés et par le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes minutes.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Changement du nom de la Société «PM GROUP S.à r.l.» pour devenir «CAP Group S.à r.l.»;
2. Divers.
III. que l'Assemblée à décider de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités

de convocation, les associés représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir une
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier le nom de la Société à de "PM GROUP S.à r.l. " en "CAP Group S.à r.l.".

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 1 

er

 des statuts de la Société en vue de refléter la première résolution ci-

dessous, de sorte que l'article 1 aura la teneur suivante-

«  Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»)

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un Associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs Associés, dans

la limite de quarante (40) Associés.

La Société existe sous la dénomination «CAP Group S.à r.l.».»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, dont les noms, prénoms et domiciles sont connus par le notaire,

celles-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Barcaglioni, M. Voss, J. Barret et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 juillet 2012. LAC/2012/32780. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

97956

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088643/129.
(120125125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 622.576.031,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 163.035.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088976/11.
(120126147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Ayocco's, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4990 Sanem, 100, rue de Niederkorn.

R.C.S. Luxembourg B 170.231.

STATUTS

L'an deux mille douze, le treize juillet.
Par devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

ont comparu:

Les époux Monsieur Shahram GHARIBI, salarié, né à Téhéran (Iran) le 5 juin 1977(matr. 1977 06 05 833),
et Madame Zeinab BAKHSHI VARZEGHANI, née à Mianeh (Iran) le 1 juillet 1976 (matr. 1976 07 01 061), demeurant

ensemble à L-4990 Sanem, 100, rue de Niederkorn,

lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté

les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de «AYOCCO'S».

Art. 2. Le siège social est fixé dans la commune de Sanem, il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un snackbar avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques et

petite restauration.

La société pourra en outre accomplir tous les actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques, de

nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière se rattachant directement ou indirectement à l'objet
précédent ou à tous les objets similaires suceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement, pour compte
propre, de tiers ou en participation tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros. (12.500,00 €), divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (125 €) chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

En cas de décès de l'associé unique ou de l'un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l'associé

unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivants. La société ne reconnaît cependant qu'un
seul propriétaire par part social et les copropriétaires d'une part sociale devront désigner l'un d'eux pour les représenter
à regard de la société.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

97957

L

U X E M B O U R G

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumettent

à la législation en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre de l'an deux mil douze.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

M. Shahram GHARIBI, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 parts
Mme Zeinab BAKHSHI VARZEGHANI, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 parts

Toutes les parts sociales ont été souscrites tel que décrit ci-dessus et libérées entièrement par les souscripteurs prédits

moyennant un versement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,00 €) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les

bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Evaluation des frais

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de huit cents euros (800,00 €).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, les comparants susnommés, représentant l'intégralité du capital social de la société, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-4990 Sanem, 100, rue de Niederkorn.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant unique, pour une durée illimitée:
Monsieur Shahram GHARIBI, prénommé;
- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Shahram GHARIBI, Zeinab BAKHSHI VARZEGHANI, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 13 juillet 2012. Relation: DIE/2012/8451. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 20 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088974/80.
(120125980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Becton Dickinson Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.143.619,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 163.006.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088978/11.
(120126125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

97958

L

U X E M B O U R G

Compagnie Européenne de Financement C.E.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 1.860.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Une  erreur  matérielle  a  été  commise  dans  la  déclaration  effectuée  en  date  du  11  juin  2012  sous  la  référence

L120095877 (la Déclaration). En effet, lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui s'est tenue le 6 juin 2012,
les actionnaires de la Société ont décidé de renommer DELOITTE S.A. en tant que réviseur d'entreprises agréé de la
Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2013 et non pas en 2016 comme indiqué
dans la Déclaration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Compagnie Européenne de Financement C.E.F. S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012089064/17.
(120125495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

First Animation, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 99.854.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 5 juillet 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société

FIRST ANIMATION S.A. dont le siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, a été dénoncé en date du

20 novembre 2009, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99854;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, premier juge au Tribunal d'Arrondissement

de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Laetitia LA VECCHIA, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 26 juillet 2012 au greffe de la sixième

Chambre de ce Tribunal.

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Pour extrait conforme
Maître Laetitia LA VECCHIA
1, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2012089157/23.
(120125873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Ontex III S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.244.708,67.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 153.348.

L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 25 mai 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Nicole Gôtz en qualité d'administrateur de classe A de la Société avec effet au 25 mai 2012.
- la nomination avec effet au 25 mai 2012 et jusqu'au 28 juin 2016, en qualité d'administrateur de classe A de la Société

de Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2,
rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration sera, à partir du 25 mai 2012, composé comme suit:
- Martin DAVIDSON, administrateur de classe B
- Dominique LE GAL, administrateur de classe A
- Michael FURTH, administrateur de classe A

97959

L

U X E M B O U R G

- Pedro FERNANDES DAS NEVES, administrateur de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Dominique Le Gal
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012089425/22.
(120125766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Bellevue Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 170.223.

STATUTS

L'an deux mille douze, le seize juillet.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- Mr Alex DE WITTE, promoteur immobilier, domicilié à B-9051 GENT, Schoonzichtstraat 6,
- Mme Isabelle VERRAES épouse DE WITTE, gérante de société, domicilié à B-9051 GENT, Schoonzichtstraat, 6,
tous deux ici représentés par Madame Stéphanie MORGESE, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrées en date du 11 juillet 2012.

Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité

limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet:
1. La prestation de services et la consultance à des personnes et sociétés en matières juridiques, fiscales, financières

et commerciales, en ce compris le conseil immobilier, la gestion de patrimoine, la politique d'investissement, l'analyse
financière et le financement d'entreprise, la comptabilité, l'administration, l'informatique et les ressources humaines;

2. Tout ce qui se rapporte, de manière directe ou indirecte, à la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, comme

notamment l'achat et la vente ainsi que la location de biens immeubles, toutes les activités qui relèvent de la législation
relatives aux agents immobiliers, la construction et la promotion de biens immeubles;

3. L'exercice de fonctions ou mandats d'administrateur, gestionnaire, directeur, commissaire ou liquidateur dans d'au-

tres sociétés, associations ou entreprises ou la création de structures à cet effet;

4. L'octroi de prêts, avances, crédits et suretés à ou en faveur de tiers, tant actionnaires, administrateurs que simples

tiers et la souscription à tout instrument financier;

5. La prise d'intérêt, soit par l'acquisition, l'apport ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, entreprises, accords

de coopération, associations professionnelles ou groupements, existants ou à constituer, tant au Grand Duché de Lu-
xembourg qu'à l'étranger, quel que soit son objet. Elle peut agir pour compte propre comme société d'investissement
ou comme holding;

6. La réalisation de tous biens pour compte propre ou pour compte de tiers et tout ce qui s'y rapporte directement

ou indirectement.

Cette énumération n'est pas limitative et doit être interprétée dans le sens le plus large du terme. La société peut

procéder à toutes opérations civiles, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont direc-
tement ou indirectement liées aux activités précitées et qui sont de nature à en favoriser ou étendre la réalisation, et qui
y sont nécessaires, utiles ou même seulement favorables. La société peut réaliser son objet, tant en Grand Duché de
Luxembourg qu'à l'étranger, de toutes manières qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: "BELLEVUE INVEST S.à r.l.".

97960

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut-être transféré en tout autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l' assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme
en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENT EUROS (12.500.- EUR) représenté par CENT (100)

parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.  Dans  l'hypothèse  où  il  y  a  plusieurs  associés,  les  parts  sociales  détenues  par  chacun  d'entre  eux  ne  sont
transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg. Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et
statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des
documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax
ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

97961

L

U X E M B O U R G

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2012.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions
suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Mr Alex DE WITTE, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Mme Isabelle VERRAES, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ SEPT CENT VINGT EUROS
(720.- EUR).

<i>Décision de l'associé unique

1 ) Est nommé gérant pour une durée illimitée:
- Mr Alex DE WITTE, promoteur immobilier, domicilié à B-9051 GENT, Schoonzichtstraat, 6,
2) L'adresse de la Société est fixée à L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: MORGESE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2012. Relation: LAC/2012/33432. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088993/148.
(120125452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

97962

L

U X E M B O U R G

Bering GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 138.291.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012088979/9.
(120125444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Bluehill Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 152.300.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012088980/9.
(120125906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Bluestar Elkem International Co., Ltd. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 130.000.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 159.902.

Les comptes annuels pour la période du 16 mars 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088981/11.
(120125792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Healthcare Promise Investment Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 162.694.

<i>Extrait des résolutions prises par l’actionnaire unique en date du 11 juillet 2012

<i>Résolutions

L’actionnaire unique décide de réélire Monsieur Nabil Gharios, administrateur et président du conseil d’administration,

Monsieur Olivier Bohuon, administrateur, Monsieur Jacques Chatain, administrateur, Monsieur Georges Fadlallah, admi-
nistrateur,  Monsieur  Pascal  Lagarde,  administrateur  et  PricewaterhouseCoopers  sàrl,  Luxembourg  comme  Réviseur
d’Entreprises, jusqu’à la prochaine assemblée clôturant les comptes au 31 décembre 2012.

L’actionnaire unique décide d’entériner l’acceptation par le conseil d’administration de la démission de Monsieur André

Garcia avec effet au 20 Décembre 2011.

<i>Conseil d’administration:

Monsieur Nabil Gharios
Monsieur Olivier Bohuon
Monsieur Jacques Chatain
Monsieur Georges Fadlallah
Monsieur Pascal Lagarde

<i>Réviseur d’Entreprises

PricewaterhouseCoopers sàrl, Luxembourg.

Eurobank FG Private Bank Luxembourg S.A.
<i>Banque Domiciliataire

Référence de publication: 2012089197/25.
(120125695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

97963

L

U X E M B O U R G

Business Market Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 150.304.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2012088987/12.
(120125543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Bairlinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 94.272.

<i>Dépôt complémentaire des comptes annuels au 31.12.2011 déposés en date du 12/04/2012 n°L120058824

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2012088988/14.
(120126183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Medicis Finance S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 120.070.

<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire

<i>unique en date du 29 décembre 2011

Démission d'un administrateur unique
- Monsieur Dominique DELABY

Nomination d'un nouvel administrateur unique
- Monsieur Yvon HELL
Né le 30 juin 1957 à Strasbourg (F)
Demeurant professionnellement 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg

Le mandat de l'administrateur unique ainsi nommé prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2017.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089375/19.
(120126123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Bell Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 106.018.

<i>Dépôt complémentaire des comptes annuels au 31.12.2011 déposés en date du 09/05/2012 n°L120075360

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

97964

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2012088992/15.
(120126180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Belux-Automobile S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4235 Esch-sur-Alzette, 6, rue Saint Martin.

R.C.S. Luxembourg B 74.198.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BELUX-AUTOMOBILE
N. CHEDID
<i>Gérant Unique

Référence de publication: 2012088994/12.
(120125613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Sopalux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 25.173.

EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration tenu en date du 16 juillet 2012 que le siège social de la société a été transféré du

47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes est désormais:
- M. Matthijs BOGERS, administrateur, au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- M. Stéphane HEPINEUZE, administrateur, au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le siège social de la société, European Trust Services (Luxembourg) S.à r.l., Commissaire, est également désormais

situé au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Mombaya KIMBULU
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012089566/19.
(120125609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Biminvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 95.821.

<i>Dépôt complémentaire des comptes annuels au 31.12.2011 déposés en date du 29/05/2012 n°L120087023

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2012088996/15.
(120126054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

97965

L

U X E M B O U R G

Bio Chemical Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 2, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 152.564.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20/07/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2012088997/12.
(120126120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Boxtel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.009.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Assemblée tenue le 19 juillet 2012.

<i>Résolution:

L'assemblée nomme Mme Sarah Lobo, Master of Commerce, demeurant professionnellement à 31, Boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, nouvel administrateur, en remplacement de Mme Carole Farine. Elle terminera
le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Référence de publication: 2012089002/15.
(120126172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

BWPE - FTL S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investis-

sement en Capital à Risque.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 158.629.

Die Aktionäre beschliessen einstimmig BDO Audit S.A. als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen General-

versammlung der Aktionäre im Jahr 2013 wiederzuwählen.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Référence de publication: 2012089011/12.
(120126025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Boxtel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.009.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089003/9.
(120126173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Brillen Boutique Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 8, Letzebuergerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 165.167.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

97966

L

U X E M B O U R G

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089006/9.
(120125781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Bubbles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4108 Esch-sur-Alzette, 173, route d'Ehlerange.

R.C.S. Luxembourg B 163.038.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089007/9.
(120125427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Business Investor Market, Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 147.647.

<i>Dépôt complémentaire des comptes annuels au 31.12.2011 déposés en date du 20/04/2012 n°L120063808

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2012089008/14.
(120126275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Vadimont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 111.802.

EXTRAIT

1. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 juin 2012 que:
Les mandats d'administrateur de:
- Monsieur Dieter GROZINGER DE ROSNAY, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix,
- Monsieur Marco FRITSCH, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix,
- Madame Sylvie PORTENSEIGNE, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte,

sont renouvelés pour une période de six ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en

2018.

Le mandat de commissaire aux comptes de Madame Sonja HERMES, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxem-

bourg, 105, Val Ste Croix, est renouvelé pour une période de six ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2018.

2. En date du 25 juin 2012, le Conseil d'Administration a confirmé Monsieur Dieter GROZINGER DE ROSNAY,

précité, dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2018.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Référence de publication: 2012089617/22.
(120125944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

BWPE - FTL S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investis-

sement en Capital à Risque.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 158.629.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

97967

L

U X E M B O U R G

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Référence de publication: 2012089010/11.
(120126002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

C.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 55, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 17.312.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089013/9.
(120126203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

C&amp;C Media S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 140.987.

Les  comptes  annuels,  les  comptes  de  Profits  et  Pertes  ainsi  que  les  Annexes  de  l'exercice  cloturant  en  date  du

31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2012089014/11.
(120126204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

LSRC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 118.838.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 29 juin 2012

Le mandat des cinq gérants:
- Mr. Behzad KHOSROWSHAHI, né le 24 Juin 1969 à Téhéran (Iran), demeurant au 105, Poplar Plains Road, Toronto,

Ontario M4V 2N1, Canada;

- Mr. Ali HEDAYAT, né le 8 février 1975 à Téhéran (Iran), demeurant à Clarendon House, 5 

th

 Floor, 11-12 Clifford

Street, Londres W1S 2LL.

- Mr. Ali SEIRAFI, né le 16 Janvier 1940 à Téhéran (Iran), demeurant au 13 Chemin de la Rochette, 1202 Genève,

Suisse;

- Mr. Sinan SAR, né le 5 Juin, 1980 à Luxembourg, demeurant au 5 avenue Gaston Diderich, L-1420, Luxembourg;
- Mr. Gérard MATHEIS, né le 4 Décembre 1962 à Luxembourg, demeurant au 5 avenue Gaston Diderich, L-1420,

Luxembourg

est renouvelé jusqu'au 21 Septembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LSRC S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2012089329/23.
(120126003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Canam Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 151.475.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012089015/9.
(120125531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

97968


Document Outline

Afrimedia International

Arelux 1 S.à r.l.

Arelux France S.à r.l.

ARGO IMMOBILIERE société à responsabilité limitée

Arlene S.A.

Auberge du Lac

Avanza Beta S.à r.l.

Avanza S.à r.l.

Avencor S.A.

Avencor S.A.

Axis Investments S.A.

Ayocco's

Bairlinvest S.A.

Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l.

Becton Dickinson Management S.à r.l.

Bellevue Invest S.à r.l.

Bell Investments S.A.

Belux-Automobile S.à r.l.

Bering GmbH

Biminvest S.A.

Bio Chemical Luxembourg Holding S.A.

Bluehill Participations S.à r.l.

BlueOrchard Loans for Development S.A.

Bluestar Elkem International Co., Ltd. S.à r.l.

Bodycote Luxembourg Finance S.à r.l.

Bodycote Luxembourg Holdings Sàrl

Boxtel S.A.

Boxtel S.A.

Bridon SA

Brillen Boutique Sàrl

B&amp;S Holding S.àr.l.

Bubbles S.à r.l.

Business Investor Market

Business Market Energy S.à r.l.

BWPE - FTL S.C.A. SICAR

BWPE - FTL S.C.A. SICAR

Canam Luxembourg Sàrl

CAP Group S.à r.l.

C&amp;C Media S.A.

Central Investments DBI

Central Investments DBI

C.K. S.A.

Compagnie Européenne de Financement C.E.F. S.A.

Creche Mini-Snoopy S. à r.l.

Cynthia

CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF

First Animation

Grand City Properties S.A.

Healthcare Promise Investment Partners S.A.

Jones Lang LaSalle Luxembourg Star S.àr.l.

LSRC S.à r.l.

Medicis Finance S.A.

Ontex III S.A.

PM Group S.à r.l.

Sopalux Holding S.A.

Vadimont S.A.