logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1997

10 août 2012

SOMMAIRE

Allianz Investments I Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95852

Alpina Real Estate Company II SCA  . . . . .

95833

Alpina Real Estate Company S.C.A.  . . . . .

95835

Athmosphera Golf & Wellness Resort S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95852

Balmoral Land Luxembourg Sàrl  . . . . . . . .

95844

BALTHASAR FinPar SA  . . . . . . . . . . . . . . . .

95834

BG Holdings I Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95851

Brufinol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95834

Campus West S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95844

Carrelages Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95832

Centre d'Echelles et de Matériel S.àr.l. . . .

95844

Clearstream Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95845

CMS Management Services S.A. . . . . . . . . .

95845

Diaverum Pooling GP & Co., SCA  . . . . . . .

95856

Dreamco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95856

Duferco Long Products S.A. . . . . . . . . . . . . .

95832

Entreprise de Peinture MASSEN S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95856

Eurasian Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

95853

Expert Resource Exchange and Consulting

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95833

Foruminvest Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

95834

Gaichel Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95830

Genes Technologies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95830

Good Energies Investments 2 (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95830

GP Leasing S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95831

GP Worldwide Investments (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95810

Harmon Europe Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

95853

ImmoFinRe II SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . . .

95811

InfraRev Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95826

Intelicom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95855

Japoma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95851

Kredietbank Informatique GIE  . . . . . . . . . .

95834

LAI SICAV-SIF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95851

La Serine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95810

Linea Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

95817

LogiCor Topco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95845

Lux-Edjar Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . .

95833

Melvic Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95855

Menolly Investments 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

95856

OI-Clothing S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95852

PAH SBSS Lux Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . .

95835

Palcor International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

95815

Palcor International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

95817

Palcor International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

95815

Palcor International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

95817

Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95831

PL Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95844

Rock Ridge RE 37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95837

Rock Ridge RE 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95815

Salinger S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95829

Sarabel Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

95811

Simon Pierre S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95828

Sphinx Private Equity Management Inter-

national S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95824

SVL-LuxInvest SCS SICAF-SIF  . . . . . . . . . .

95824

Tempyr S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95828

Titan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95829

Toubkal Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95825

Trican Well Service Ltd., Luxembourg

Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95825

TWS - Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95825

Ultima Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95829

Xtravel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95831

ZapFi International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

95831

ZapFi Networks International S.A.  . . . . . .

95832

ZapFunding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95833

ZapHolding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95833

95809

L

U X E M B O U R G

GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 711.850,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 99.512.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Lors du dépôt numéro L120108449 en date du 28 juin 2012, une erreur matérielle s'est produite. Cette nouvelle

donnée remplace la précédente.

Le siège social de la Société est situé au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et non au 20, rue Eugène Ruppert,

L-2053 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 13 juillet 2012.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2012085215/22.
(120120674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

La Serine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 117.644.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SChlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 6 juillet

2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1712 du 13 septembre 2006.

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de la société LA SERINE S.A., tenue en date du 8 juin 2012, que les

mandats ci-dessous sont renouvelés.

<i>aux postes d'administrateurs:

- Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG,

15, boulevard Roosevelt. Son mandat de président du conseil d'administration est également renouvelé.

- Mademoiselle Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15, boule-

vard Roosevelt.

- Mademoiselle Nadia PRINTZ, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15, bou-

levard Roosevelt.

<i>au poste de commissaire aux comptes:

- REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-25.549.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

Luxembourg, le 11 juin 2012.

Fiduciaire Fernand Faber

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SChlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 6 juillet

2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1712 du 13 septembre 2006.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

"REVILUX S.A.", ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, Val Ste Croix, 223, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 25.549, tenue en date du 25 janvier 2011 que son siège a été
transféré vers L-2450 Luxembourg, boulevard Roosevelt, 17.

Luxembourg, le 11 juin 2012.

Fiduciaire Fernand Faber

Référence de publication: 2012085323/32.
(120120743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

95810

L

U X E M B O U R G

ImmoFinRe II SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 153.670.

<i>Cet extrait rectificatif remplace la version déposée antérieurement le 4 juillet 2012 sous le N: L120113014

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue le 20 juin 2012

Est nommé réviseur d’entreprises agréé, en remplacemnet du mandat de commissaire aux comptes, son mandat pren-

ant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012:

- Ernst &amp; Young S.A., 7, rue Gabriel Lippman, Parc d’Activité Syrdall, 2, L-5365 Munsbach
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2012.

Référence de publication: 2012085251/15.
(120120770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Sarabel Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 166.130.

In the year two thousand twelve, the third day of July before Me Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Sarabel Luxembourg S.à r.l., a

Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 166.130
(the Company). The Company has been incorporated on January 6, 2012 pursuant to a deed of Me Schaeffer, notary
residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 478 dated February 23, 2012.
The articles have not been amended since then.

There appeared

Stichting Administratiekantoor Sarabel, a Foundation under Dutch law, having its official seat in Delfzijl, the Nether-

lands, and its office address at Rondeboslaan 35, 9936 BJ Farmsum, the Netherlands (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr. Jérémie HOUET, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1) in order to bring the share capital

of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12.500), represented by twelve
thousand five hundred (12.500) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each to twelve
thousand five hundred and one euro (EUR 12.501), by way of the issue of one (1) new share of the Company having a
par value of one euro (EUR 1 ).

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.
3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the increase of the share capital adopted under item 1. above.

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the regis-
tration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of

one euro (EUR 1 ),

95811

L

U X E M B O U R G

in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12.500), represented by twelve thousand five hundred (12.500) shares in registered form, having a nominal value
of one euro (EUR 1) each to twelve thousand five hundred and one euro (EUR 12.501),

by way of the issue of one (1) new share of the Company having a par value of one euro (EUR 1).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

Mr. Willem Adriaan Blijdorp, Dutch citizen, residing at bâtiment Villa Eugenie, Residence Azur 16, 1898 St Gingolph,

Switzerland (the New Shareholder) declares to subscribe to one (1) new share having a par value of one euro (EUR 1)
and to fully pay up such share by a contribution in kind consisting of ninety-six thousand three hundred ninety-five (96.395)
shares S (the Shares) he holds in the share capital of B&amp;S Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its regis-
tered  office  at  18,  place  Bleech,  L-7610  Larochette,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 135.944 (B&amp;S), such Shares having an aggregate fair market value
in an amount of sixty-nine million nine hundred fifty-seven thousand seven hundred twenty euro and eighty-five cents
(EUR 69.957.720,85).

The contribution in kind of the Shares to the Company, in an aggregate amount of sixty-nine million nine hundred fifty-

seven thousand seven hundred twenty euro and eighty-five cents (EUR 69.957.720,85) is to be allocated as follows:

- in an amount of one euro (EUR 1) to be allocated to the nominal share capital account of the Company;
- in an amount of sixty-nine million nine hundred fifty-seven thousand seven hundred nineteen euro and eighty-five

cents (EUR 69.957.719,85) to be allocated to the share premium account of the Company.

The value of the contribution of the Shares to the Company has been certified to the undersigned notary by a valuation

certificate dated June 29, 2012 issued by the management of B&amp;S and the New Shareholder which states in essence that:

1. "the New Shareholder is the sole owner of the Shares;
2. the Shares are fully paid up;
3. the New Shareholder is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or

usufruct thereon and none of the Shares are subject to any attachment;

5. There exists no pre-emption rights nor any other rights pursuant to which any person may request that the Shares

be transferred to it;

6. The Shares are freely transferable;
7. All formalities required in Luxembourg in relation to the contribution in kind of the Shares to the Company, have

been effected or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution
in kind; and

8. Based on general accepted accounting principles, the Shares are valued at their fair market value, at sixty-nine million

nine hundred fifty-seven thousand seven hundred twenty euro and eighty-five cents (EUR 69.957.720,85), and since the
valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the
Company."

The said certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The Sole Shareholder and the New Shareholder are hereinafter referred to as the Shareholders.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles in order

to reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:

5.1. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred and one euro (EUR 12.501), represented

by twelve thousand five hundred and one (12.501) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR
1 ) each."

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and empowers and authorizes any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with
the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

95812

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 6.600.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le troisième jour du mois de juillet, par devant Me Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Sarabel Luxembourg S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Luxembourg avec siège social au 10-12, rue de Medernach,
L-7619 Larochette, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 166.130 (la Société). La Société a été constituée le 6 janvier 2012 suivant un acte de Me Schaeffer,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 478 en date du 23 février
2012. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

A comparu:

Stichting Administratiekantoor Sarabel, une fondation organisée sous le droit néerlandais, ayant son siège social à

Delfzijl, les Pays-Bas, et son établissement à Rondeboslaan 35, 9936 BJ Farmsum, les Pays-Bas (l'Associé Unique),

représentée par Monsieur Jérémie HOUET, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de un euro (EUR 1) de sorte de porter le capital social

de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, à douze mille cinq cent un euros (EUR
12.501), par l'émission de une (1) nouvelle part sociale de la Société ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1).

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social spécifiée au point 1. ci-dessus.
3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation du

capital social adoptées aux points 1. ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité

à tout gérant de la Société, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts
sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

5. Divers.
III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de un

euro (EUR 1),

de sorte de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500)

représenté par douze mille cinq cent (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, à
douze mille cinq cent un euro (EUR 12.501),

par l'émission de une (1) nouvelle part sociale de la Société ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1).

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation

de capital comme suit:

<i>Souscription - Libération

Mr. Willem Adriaan Blijdorp, citoyen néerlandais, résidant à bâtiment Villa Eugenie, Résidence Azur 16, 1898 St Gin-

golph, Suisse (le Nouvel Associé) déclare souscrire à une (1) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale de un euro

95813

L

U X E M B O U R G

(EUR 1) et de la libérer par un apport en nature se composant de quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-quinze
(96.395) parts sociales S (les Parts Sociales) détenues par lui dans le capital social de la société B&amp;S Holding S.à r.l., une
société à responsabilité limitée constituée et organisée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 18, place
Bleech, L-7610 Larochette, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 135.944 (B&amp;S), les Parts Sociales ayant une valeur totale de soixante-neuf millions neuf
cent cinquante-sept mille sept cent vingt euros et quatre-vingt-cinq centimes (EUR 69.957.720,85).

Cet apport en nature des Parts Sociales à la Société d'un montant total de soixante-neuf millions neuf cent cinquante-

sept mille sept cent vingt euros et quatre-vingt-cinq centimes (EUR 69.957.720,85) sera affecté comme suit:

- un montant de un euro (EUR 1) sera affecté sur le compte capital social nominal de la Société;
- un montant de soixante-neuf millions neuf cent cinquante-sept mille sept cent dix-neuf euros et quatre-vingt-cinq

centimes (EUR 69.957.719,85) sera affecté sur le compte de prime d'émission de la Société.

La valeur de l'apport des Parts Sociales à la Société a été certifiée au notaire instrumentant au moyen d'une attestation

datée du 29 juin 2012 délivrée par la gérance de B&amp;S et du Nouvel Associé qui atteste que:

«1. Le Nouvel Associé est le seul propriétaire des Parts Sociales.
2. Les Parts Sociales sont entièrement libérées.
3. Le Nouvel Associé est le seul titulaire des Parts Sociales et possède le droit d'en disposer.
4. Aucune des Parts Sociales n'est grevée d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un

nantissement ou un usufruit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales n'est sujette à une telle opération.

5. Il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que

les Parts Sociales lui soient cédées.

6. Les Parts Sociales sont librement cessibles.
7. Toutes les formalités requises à Luxembourg consécutives à l'apport en nature des Parts Sociales à la Société seront

effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant cet apport en nature.

8. Se basant sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur des Parts Sociales est évaluée, à la juste

valeur du marché, à soixante-neuf millions neuf cent cinquante-sept mille sept cent vingt euros et quatre-vingt-cinq cen-
times (EUR 69.957.720,85), et depuis cette évaluation, il n'y a pas eu de changements matériels qui auraient déprécié la
valeur de l'apport fait à la Société.»

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique et le Nouvel Associé sont ci-après référés comme les Associés.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter

les modifications ci-dessus de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent un euro (EUR 12.501), représenté par douze mille cinq cent un

(12.501) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.»

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et

donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la
Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-

mativement à la somme de 6.600.- euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: J. Houet et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2012. LAC/2012/31511. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

95814

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085499/201.
(120120936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Palcor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.772.

Par la présente, je vous remets ma démission comme administrateur de votre société avec effet à la date de ce jour.

Luxembourg, le 29 juin 2012.

Claude SCHMITZ.

Référence de publication: 2012085435/9.
(120120755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Palcor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.772.

Par la présente, je vous remets ma démission comme administrateur et président du Conseil d'Administration de votre

société avec effet à la date de ce jour.

Luxembourg, le 29 juin 2012.

Reno Maurizio TONELLI.

Référence de publication: 2012085436/10.
(120120755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Rock Ridge RE 6, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 124.532.

In the year two thousand twelve, on the seventh of June.
Before Us, MaTtre Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Field Point IV S.à r.l, a société à responsbilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having  its  registered  at  22,  Grand-rue,  L-1660  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies
Register under number B 119.324 (the "Sole Shareholder"), here represented by Mrs Claire GUILBERT, lawyer, profes-
sionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on June 6 

th

 , 2012.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy¬holder and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Rock Ridge RE 6, a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on January 10 

th

 , 2007 and published

with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 717 of April 26 

th

 , 2007, pursuant to a deed of Maître

Henri HELLINCKX, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thou-
sand five hundred euro (EUR 12,500), having its registered office at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 124.532 (the "Company").

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<i>First resolution

In accordance with articles 141 to 151 of the Law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended, the

Sole Shareholder decides to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into liquidation.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to grant full discharge to the managers of

the Company for the exercise of their mandate.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint AIM Services S.à r.l., a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office

95815

L

U X E M B O U R G

at 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 74.676, as liquidator (the "Liquidator").

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and

liabilities, that the Liquidator will have the broadest powers to perform its duties and that the Company will be bound
towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that, on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and, in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder representing the appearing party, said proxy-holder signed to-

gether with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le sept juin.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Field Point IV S.à r.l, une société à responsabilité limitée organisée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social

au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 119.324 (l'«Associé Unique»), ici représentée par Mademoiselle Claire GUILBERT, juriste, résidant professionnellement
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée à Luxembourg le 6 juin 2012.

Laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante

et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregis-
trement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de Rock Ridge RE 6, une société à responsabilité limitée constituée

sous les lois du Grand Duché de Luxembourg le 10 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 717 du 26 avril 2007, par acte notarié de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), ayant son siège social au 22, Grand-rue, L-1660
Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.532 (la
«Société»).

L'Associé Unique, représentant la totalité du capital social de la Société, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée, l'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge aux gérants

de la Société pour l'exercice de leur mandat.

<i>Troisième Résolution

L'Associé Unique décide de nommer AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois

du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.676, en tant que liquidateur (le «Liquidateur»).

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide que le Liquidateur préparera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société, que le

Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer sa mission et que la Société sera engagée envers les
tiers par la signature individuelle du Liquidateur.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que, sur requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec le notaire, le présent acte

en original.

Signé: C. Guilbert et M. Schaeffer.

95816

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 juin 2012. LAC/2012/26714. Reçu douze euros EUR 12,-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085474/89.
(120121018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Palcor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.772.

Par la présente, je vous remets ma démission comme administrateur de votre société avec effet à la date de ce jour.

Luxembourg, le 29 juin 2012.

Pierre LENTZ.

Référence de publication: 2012085434/9.
(120120755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Palcor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.772.

Par la présente, nous vous remettons notre démission en tant que commissaire aux comptes de votre société avec

effet à la date de ce jour.

Luxembourg, le 29 juin 2012.

AUDIEX S.A.
Signature

Référence de publication: 2012085433/12.
(120120755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Linea Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 170.059.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twenty-second June.
Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Maître René FALTZ, lawyer, residing professionally in L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine ,
represented by Mrs. Monique Drauth, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

2) Maître Tom FELGEN, lawyer, residing professionally in L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine ,
represented by Mrs. Monique Drauth, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
The two prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organise among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby established by the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued, a company in the form of a public limited company ("société anonyme"), under the name of "Linea Investments
S.A." (hereafter the "Company").

Art. 2. The registered office is in the municipality of Luxembourg.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other

95817

L

U X E M B O U R G

place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders'
meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into thousand

(1.000) shares with a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a
general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors
may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than
one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented. Proxies

between directors are permitted; with the restriction that one director can only represent one of the members of the
board of directors.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors'

meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August
10 

th

 , 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the com-

petence of the board of directors.

95818

L

U X E M B O U R G

Art. 11. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of

the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other
agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution
of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board
of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 12. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed
of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed
by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the third Monday of the month of April at 11.30. a.m..

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing ten percent of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognise only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1 

st

 and ends on December 31 of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2012.
The first annual general meeting shall be held in 2013.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

95819

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed to as follows:

Subscribers

Number

of shares

Amount

subscribed

to and paid-up

Maître René FALTZ, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

15,500.- EUR

Maître Tom FELGEN, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

15,500.- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000

31,000.- EUR

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty-

one thousand euro (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10 

th

 , 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilments.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to elect three directors.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the accounts as at 31 December 2017.

- Maître René FALTZ, lawyer, residing professionally in L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine ,
- Maître Tom FELGEN, lawyer, residing professionally in L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine;
- Monsieur Laurent BARNICH, companys' director, residing professionally in L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine
Maître René FALTZ, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general

meeting.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the accounts as at 31 December 2017,

- LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., LOMAC S.A. for short, a «société anonyme» with

registered office at L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 22.206.

<i>Third resolution

The company's registered office is located at L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-deux juin.
Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Maître René FALTZ, avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine,
ici représenté par Madame Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé;

2. Maître Tom FELGEN, avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine,

95820

L

U X E M B O U R G

ici représenté par Madame Monique Drauth, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps avec lui aux formalités de l'en-
registrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d'une société anonyme, qui prend la dénomination sociale de «Linea Investments S.A.» (la «So-
ciété»).

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Commune de Luxembourg
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La Société a en outre pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

La Société pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute

société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou

réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de trente et un euro (EUR 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

95821

L

U X E M B O U R G

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage, la voix de celui

qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion

pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose
au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 12. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième lundi du mois d'avril à Luxembourg à 11.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

95822

L

U X E M B O U R G

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des action-

naires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs

Nombre

d'actions

Libération

Maître René FALTZ, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

15,500.- EUR

Maître Tom FELGEN, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

15,500.- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000

31,000.- EUR

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente-et-un

mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cent euros (EUR

1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes au

31 décembre 2017:

- Maître René FALTZ, avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine,
- Maître Tom FELGEN, avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine,
- Monsieur Laurent BARNICH, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, Rue

Heine.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Maître René FALTZ, préqualifié, aux fonctions de président du conseil

d'administration.

95823

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes au 31 décembre 2017:

- La société anonyme LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., en abrégé LOMAC S.A., avec

siège social à L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 22.206.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1720 Luxembourg, 6, Rue Heine.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire des comparants prémentionnés a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé Drauth, GRETHEN5 juin 2012.
Relation: LAC/2012/29273. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

<i>Le Receveur

 (signé): THILL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085313/357.
(120120666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Sphinx Private Equity Management International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 143.846.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2012

En date du 29 juin 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Madame Marianne Ghali, de Monsieur Hisham El Khazindar et de Monsieur Ahmed

Heikal en qualité de Gérants, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013.

Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Sphinx Private Equity Management International S.à.r.l.
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012085512/15.
(120120738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

SVL-LuxInvest SCS SICAF-SIF, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 164.951.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18. November 2011

Am 18. November 2011 um 11:00 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Gesellschafter obiger Gesellschaft zusammen.
Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Infolge der obengenannten Beschlüsse beschließen die Gesellschafter, den ersten Absatz des Artikels 6 Absatz 2 der

Satzung wie folgt abzuändern:

„Das Kapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausendein Euro (EUR 500.001,00) und ist in einen (1) Komplemen-

täranteil, der durch den Komplementär gehalten wird, sowie fünfhunderttausend (500.000) Kommanditanteile von jeweils
einem Euro (EUR 1,00) eingeteilt. Die Kommanditanteile sowie der Anteil des Komplementärs wurden vollständig ein-
gezahlt."

95824

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 13. Juli 2012.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2012085558/20.
(120120787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Toubkal Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 114.067.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 29 juin 2012 à 16.30 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'entreprises viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de M. Joseph WINANDY, M. Koen LOZIE,

COSAFIN S.A., représentée par M. Jacques BORDET, ATLAS FOOD HOLDING S.A., Administrateurs sortants.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer FIDEWA-CLAR, 2-4 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange,

Réviseur d'Entreprises, en remplacement de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DES AUDITEURS REUNIS (CLAR)
S.A.

Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'entreprises viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale

qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2012.

Pour copie certifiée conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012085584/19.
(120120857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Trican Well Service Ltd., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 153.136.

EXTRAIT

- Monsieur David L. CHARLTON a démissionné de son poste d’administrateur de la société, Trican Well Services

Ltd., en date du 31 décembre 2011;

- Monsieur Gary L. WARREN a démissionné de son poste d’administrateur de la société, Trican Well Services Ltd.,

en date du 10 mai 2011;

- Monsieur Alexander J. POURBAIX, né le 29 juillet 1965 à Edmonton, Alberta (Canada), résidant professionnellement

au 2900/645 7th! Avenue S.W., T2P 4G8 Calgary, Canada, a été nommé administrateur de la société, Trican Well Services
Ltd., avec effet au 9 mai 2012 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TRICAN WELL SERVICES LTD., LUXEMBOURG BRANCH

Référence de publication: 2012085588/17.
(120120749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

TWS - Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 145.050.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire

L'Assemblée a décidé de nommer Monsieur Thierry Casier , commerçant ,né 14 september 1967à Diets (B) le de-

meurant professionnellement au diesterstraat 164/1 B-3980 Tessenderlo. comme Administrateur avec effet le 30 Juin
2012

POUR COPIE CONFORME

Fait à Luxembourg, le 30 Juin 2012.

Référence de publication: 2012085593/13.
(120120781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

95825

L

U X E M B O U R G

InfraRev Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.020.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 168.171.

In the year two thousand and twelve, on the eighth day of June.
Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

InfraMed Infrastructure, a French company with registered office at 19, Avenue de l'Opéra, Paris 75001, France, re-

gistered with the Company and Trade Register of Paris under number 522.811.413 (the “Sole Shareholder”),

Here represented by Mr. Regis Galiotto, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxem-

bourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

By virtue of a proxy given under private seal, dated 25 May, 2012;
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that InfraMed Infrastructure is the Sole Shareholder of InfraRev Holding S.à r.l., a private limited liability company

(“société à responsabilité limitée”), having its registered office set at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 168.171, incorporated
by a deed of Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on March 27, 2012, in progress
of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter referred to as the “Company”).

II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according

to the agenda below:

<i>Agenda:

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of USD 1,000,000.- (one million) US Dollars by the

issuance of 100,000,000 (one hundred million) shares with a value of USD 0.01- (one Cent US Dollar) each;

2. Subscription and payment of all additional issued shares by the Sole Shareholder, by contribution in cash;
3. Approval of the amendment of the Company's articles of association to reflect the issuance of new shares and the

amendment of any relevant provisions of the Company's articles of association (the “Articles”) in that respect; and

4. Miscellaneous.
Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder DECIDES to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 1,000,000.-

(one million US Dollars) by the issuance of 100,000,000 (one hundred million) shares with a value of USD 0.01 (one Cent
US Dollar) each.

<i>Intervention - Subscription - Payment

There now appeared Mr. Regis Galiotto, acting in his capacity as duly appointed special attorney of the Sole Shareholder

by virtue of a proxy given on 25 May, 2012 which will remain attached to the present deed.

The appearing person declared to subscribe for and fully pay 100,000,000 (one hundred million) shares with a value

of USD 0.01 (one Cent US Dollar) each, for a total amount of USD 1,000,000.- (one million US Dollars) together with a
share premium amounting to USD 99,000,000 (ninety-nine million US Dollars) by a contribution in cash so that the amount
of USD 100,000,000.- (one hundred million US Dollars) is from now at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.

As a consequence, the corporate capital of the Company is equal to an amount of USD 1,020,000.- (one million twenty

thousand US Dollars) represented by 102,000,000 (one hundred and two million) shares with a value of USD 0.01 (one
Cent US Dollar) each.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder DECIDES to amend Article 6 of

the Articles to read as follows:

Art. 6. “The issued capital of the Company is set at USD 1,020,000.- (one million twenty thousand US Dollars) re-

presented by 102,000,000 (one hundred and two million) shares with a value of USD 0.01 (one Cent US Dollar) each
which are fully paid-up.”

95826

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.- EUR).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is

closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary

by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary,
the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le huit juin.
Pardevant Nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire des présentes.

A comparu:

InfraMed Infrastructure, une société française ayant pour siège sociale le 19, Avenue de l'Opéra, Paris, 75001, inscrite

au registre des sociétés et du commerce de Paris sous le numéro 522.811.413 (l'«Associé Unique»),

Dûment représenté par Mr. Regis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319

Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 mai 2012.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte du comparant et

par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en qualité ci-dessus indiquée, déclare et demande au notaire:
I. d'acter que InfraMed Infrastructure est l'Associé Unique de la Société à responsabilité limitée InfraRev Holding S.à

r.l. ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.171, constituée suivant acte reçu par Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg le 27 mars 2012, en cours de publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-

dessous:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de USD 1.000.000,- (un million de Dollars

Américains) par l'émission de 100.000.000 (cents millions) de parts sociales d'une valeur nominale de USD 0,01 (Un cent
de Dollar Américain) chacune;

2. Souscription et libération de toutes les nouvelles parts sociales par l'Associé Unique, par un apport en numéraire;
3. Approbation de la modification des statuts pour refléter l'émission de nouvelles parts sociales et la modification de

toute disposition des statuts de la Société (les «Statuts») à cet égard; et

4. Divers.

<i>Première résolution

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 1.000.000 (un million de

Dollars Américains) par l'émission de 100.000.000 (cent millions) de parts sociales d'une valeur nominale de USD 0,01
(Un cent de Dollar Américain) chacune.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Est alors intervenu aux présentes, Mr. Regis Galiotto, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Unique,

en vertu d'une procuration donnée le 25 mai 2012 qui restera annexée aux présentes.

Le comparant a déclaré souscrire et payer en totalité les 100.000.000 (cent millions) de parts sociales d'une valeur

nominale de USD 0,01 (Un cent de Dollar Américain) chacune pour un montant total de USD 1.000.000,- (un million de
Dollars Américains) ensemble avec une prime d'émission s'élevant à USD 99.000.000,- (quatre-vingt-dix-neuf millions de
Dollars Américains) par paiement en numéraire de sorte que la somme USD 100.000.000,- (cent millions de Dollars
Américains) se trouvent dès à présent à la libre disposition de la Société, la preuve ayant été fournie au notaire instru-
mentant, par certificat bancaire.

95827

L

U X E M B O U R G

Par conséquent, le capital social de la Société est égal à un montant de USD 1.020.000,- (un million vingt mille Dollars

Américains) représenté par 102.000.000 (cent et deux millions) de parts sociales d'une valeur nominale de USD 0,01 (un
cent de Dollar Américain) chacune.

<i>Deuxième résolution

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 6

des statuts afin de le lire comme suit:

Art. 6. «Le capital émis de la Société est fixé à un million vingt mille US Dollars (USD 1.020.000,-) divisé en cent deux

millions (102.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de US Dollar (USD 0,01) chacune, celles-ci
étant entièrement libérées.»

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunération et charges, de quelque forme que ce soit, incombant à la société suite à cet acte

sont estimés approximativement à sept mille Euros (7.000.- EUR).

L'ordre du jour étant épuisait, et sans question complémentaire, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare qu'à la requête des membres du bureau et des comparants,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre les deux versions,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, dont le nom, le nom de baptême, l'état civil et l'adresse

sont connu du notaire, celui-ci a signé le présent acte avec Notaire.

Signé: R. GALIOTTO et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juin 2012. Relation: LAC/2012/28050. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085252/132.
(120120748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Simon Pierre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1623 Luxembourg, 4, rue Génistre.

R.C.S. Luxembourg B 53.875.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2012

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monseigneur Mathias Schiltz, comme président et administrateur

du conseil d'administration.

L'assemblée générale décide d'élire Monseigneur Erny Gillen, vicaire générale, né le 29 janvier 1960 à Differdange,

demeurant à 52, rue Jules Wilhelm, L-2728 Luxembourg, comme administrateur et nouveau président du conseil d'ad-
ministration, en remplacement de Monseigneur Mathias Schiltz.

Le mandat de Monseigneur Erny Gillen prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
Le mandat du commissaire aux comptes, Mademoiselle Martine Oehmen, venant à terme, l'assemblée générale décide

de renouveler son mandat pour une nouvelle période de 3 ans. Le mandat de Mademoiselle Martine Oehmen prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 30 mars 2012.

Egon SEYWERT
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2012085506/21.
(120120719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Tempyr S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 123.803.

<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration du 12 Juillet 2012

Il résulte des décisions prises par le conseil d'administration lors de sa réunion du 12 Juillet 2012 que:

95828

L

U X E M B O U R G

- l'adresse de la société Tempyr S.à r.l. sera transférée au 39, avenue Monterey L-2163 Luxembourg avec effet au 6

Juillet 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012085579/12.
(120120695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Salinger S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 166.391.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société du 31 mai 2012

<i>Quatrième résolution

Nomination de 3 Administrateurs.
L'Assemblée Générale décide de nommer les 3 administrateurs suivants qui l'acceptent:
- Monsieur Marc AUGIER, employé privé, demeurant professionnellement 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxem-

bourg;

- Madame Anne-Lyse GILLES, employé privé, demeurant professionnellement 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Lu-

xembourg;

- Monsieur Jean-Patrick TRAN-PHAT, employé privé, demeurant professionnellement 11 avenue Emile Reuter, L-2420

Luxembourg;

Leurs mandats prennent effet à compter de ce jour et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

SALINGER SA

Référence de publication: 2012085493/21.
(120120660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Titan, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 164.838.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 14 mai 2012 que la société à responsabilité limitée

MAZE, avec siège social à L-8308 Capellen, 75, parc d'activités, Grand Duché du Luxembourg, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110554, a cédé 100 (cent) parts sociales qu'elle détenait
dans la société à responsabilité limitée TITAN à la société anonyme FIDOMES ayant son siège social à L-8308 Capellen,
75, parc d'activités, Grand Duché du Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 95765.

Pour extrait
La société

Référence de publication: 2012085583/16.
(120120686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Ultima Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 143.834.

EXTRAIT

La Société prend acte que le siège social de Réviconsult S.à r.l., commissaire de la Société, a été transféré du 16, rue

Jean l’Aveugle L-1148 Luxembourg au 12, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, et ce avec effet au 25 février
2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

95829

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085597/14.
(120120875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Good Energies Investments 2 (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 130.919.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 25 juin 2012 au siège social que:
Suite à l'élection de Mr Louis BRENNINKMEIJER et à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se

terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2012, le Conseil de Gérance se compose de:

- Michel de GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxem-

bourg;

- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;

- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 1 

st

 Floor, 2-5 Old Bond

Street, Londres, W1S 4PD, Angleterre;

- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Grafenauweg, 10, CH-6300 Zug, Suisse
- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Jean Monnetlaan, B-1804 Vilvoorde, Belgique;

- Louis BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 4 

th

 Floor,

2-5 Old Bond Street, Londres, W1S 4PD, Angleterre.

A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur

les comptes de l'exercice 2012:

- Ernst &amp; Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
Référence de publication: 2012085191/24.
(120120825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Gaichel Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 49.403.

<i>Extrait de Conseil d’Administration tenu le 13 juillet 2012

Le Conseil d’Administration constate que la dénomination sociale de son commissaire aux comptes MAZARS, enre-

gistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B56248, a été modifiée en FIDUO avec
effet au 1 

er

 juillet 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012085193/12.
(120120862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Genes Technologies, Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 167.811.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64569 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012085199/10.
(120120767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

95830

L

U X E M B O U R G

GP Leasing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 278.174.950,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 118.041.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Lors du dépôt numéro L120108451 en date du 28 juin 2012, une erreur matérielle s'est produite. Cette nouvelle

donnée remplace la précédente.

Le siège social de la Société est situé au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et non au 20, rue Eugène Ruppert,

L-2053 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 13 juillet 2012.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2012085214/22.
(120120675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 132.987.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085420/10.
(120120788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Xtravel S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 143.387.

GLOBAL TRUST ADVISORS S.A a dénoncé tout office de domiciliation de la société XTRAVEL S.A., domiciliée 26/28

Rives de Clausen Luxembourg (RCSL B 143387), avec effet au 9 juillet 2012.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

GLOBAL TRUST ADVISORS S.A

Référence de publication: 2012085622/10.
(120120685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

ZapFi International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7432 Gosseldange, 79, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 163.788.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085625/10.
(120120790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

95831

L

U X E M B O U R G

ZapFi Networks International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7432 Gosseldange, 79, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 167.818.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085627/10.

(120120789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Carrelages Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4920 Bascharage, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 168.837.

L'associé unique de la société Carrelages Lux Sàrl a pris le 27 juin 2012 les décisions suivantes:

<i>1 

<i>ère

<i> Résolution

L'associé unique , Monsieur Emanuel De Jesus Valentim Chéu, né le 13 juin 1969 à Lisbonne (Portugal), domicilié à

L-4620 Differdange, 19 rue Emile Mark, démissionne avec effet immédiat comme gérant technique de Carrelages Lux
S.àr.l.

<i>2 

<i>ème

<i> Résolution

L'associé unique décide de nommer Monsieur José Da Silva Santos, né le 27.02.1952 à ARcozelo, Vila Nova De Gaia

(Portugal), domicilié à F-57390 Russange, 6 rue des Dahlias, pour une durée indéterminée au poste de gérant technique
de la société Carrelages Lux S.àr.l.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant

administratif avec pouvoir de déléguation réciproque.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 27 juin 2012.

Signature
<i>Associé unique
José Valentim / Martine Bredemus / Claude Karp
<i>Président du bureau / Secrétaire du bureau / Scrutateur du bureau

Référence de publication: 2012085015/24.

(120120759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Duferco Long Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 159.896.

EXTRAIT

La Société prend acte que le siège social de Réviconsult S.à r.l., commissaire de la Société, a été transféré du 16, rue

Jean l’Aveugle L-1148 Luxembourg au 12, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, et ce avec effet au 25 février
2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085078/14.

(120120874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

95832

L

U X E M B O U R G

Expert Resource Exchange and Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 65.951.

<i>Extrait procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement des actionnaires du 07.10.2011

<i>Résolutions

1. Le Mandat d'administrateur de Monsieur Kris Deroo est reconduit jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en 2016.
2. Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Kris Deroo est reconduit jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en

2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kris Deroo / Luc Lesire / Koen Van Huynegem
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2012085085/15.
(120120718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Alpina Real Estate Company II SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 150.694.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Référence de publication: 2012086593/10.
(120122709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Lux-Edjar Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 150.947.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 3.03.2010

EXTRAIT

Suite aux résolutions prises par l’associé unique en date du 15 mars 2012, il résulte que:
- Le mandat des gérants de catégorie A Daniel CHIM et Tony CHIU et le mandat des gérants de catégorie B Emmanuel

REVEILLAUD, Philippe TOUSSAINT et Emanuele GRIPPO ont été renouvelé avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LUX-EDJAR Luxembourg Sàrl,

Référence de publication: 2012085319/15.
(120120752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

ZapHolding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7432 Gosseldange, 79, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 162.278.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085631/10.
(120120791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

ZapFunding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7432 Gosseldange, 79, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 162.221.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

95833

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085629/10.
(120120792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Kredietbank Informatique GIE, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg C 2.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée des Membres du 26 juin 2012

L'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. L'assemblée des membres acte la fin de la fonction de gérant de M. John PERKS.
2. L'assemblée procède à la nomination à partir de ce jour de Monsieur Philippe AUQUIER, KBL, professionnellement

domicilié au 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, comme nouveau gérant de Kredietbank Informatique GIE, en
remplacement de M. John PERKS.

<i>Pour KredietBank Informatique G.I.E.

Référence de publication: 2012085662/14.
(120120828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Foruminvest Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 225.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 93.529.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 7 juin 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Walterus J. Kuppens, avec adresse professionnelle au 5, Schoutenbosje 1251 LE Laren,

Pays-Bas, de son mandat de Gérant de type B, avec effet au 9 mai 2012

- nomination de Rob Baris, avec adresse professionnelle au 5, Schoutenbosje, 1251 LE Laren, Pays-Bas, au mandat de

Gérant de type B, avec effet au 9 mai 2012 et pour une durée indéterminée

- nomination de David Ermia, avec adresse professionnelle au 5, Schoutenbosje, 1251 LE Laren, Pays-Bas, au mandat

de Gérant de type B, avec effet au 7 juin 2012 et pour une durée indéterminée

- renouvellement de DELOITTE S.A., avec siège social au 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg en tant que

commissaire aux comptes, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085156/20.
(120120724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Brufinol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R.C.S. Luxembourg B 157.456.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BRUFINOL S.A.
Signature

Référence de publication: 2012086657/11.
(120123074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

BALTHASAR FinPar SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 29.441.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

95834

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

BALTHASAR FinPar S.A.

Référence de publication: 2012086665/12.
(120122622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Alpina Real Estate Company S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 131.697.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2012.

Référence de publication: 2012086594/10.
(120122697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

PAH SBSS Lux Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 167.311.

In the year two thousand and twelve, on the second day of July.
Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

THERE APPEARED:

PFIZER LUXEMBOURG SARL having its registered office at 51, Ave JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on 3 

rd

 October 2001, registered at the Register of

commerce of Luxembourg section B number 84.125,

represented by Me Cécile JAGER, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg,

on July 2, 2012.

Which proxy shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity PFIZER LUXEMBOURG SARL, is the sole part holder in PAH SBSS LUX HOLDING SARL,

incorporated on March 5, 2012 by deed of Me Paul BETTINGEN, with registered office at 51, avenue JF Kennedy, L-1885
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 167.311, published in the
Mémorial C number 1005 of April 18, 2012 (the “Company”) and the Company's articles have been amended by deed
of the undersigned notary on July 2, 2012, not yet published in the Mémorial C.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The sole part holder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ONE MILLION TWO

HUNDRED AND TWENTY-FIVE THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 1,225,000.-) to bring it from its present amount
of TWENTY-FIVE THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 25,000.-) to the amount of ONE MILLION TWO HUNDRED
FIFTY THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 1,250,000.-) by the creation and the issue of ONE MILLION TWO HUNDRED
AND TWENTY-FIVE THOUSAND (1,225,000) new shares having a par value of ONE U.S. DOLLARS (USD 1.-) each
(the “New Shares”), having the same rights and obligations as the existing shares, together with total issue premium of
TEN MILLION NINE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY-TWO U.S. DOLLARS
THIRTY-ONE CENTS (USD 10,925,892.31.-).

The aggregate contribution of TWELVE MILLION ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND NINE HUNDRED NINETY-

TWO U.S. DOLLARS AND THIRTY-ONE CENTS (USD 12,150,892.31.-) in relation to the New Shares is allocated as
follows: (i) ONE MILLION TWO HUNDRED AND TWENTY-FIVE THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 1,225,000.-) to
the share capital of the Company and (ii) TEN MILLION NINE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND EIGHT HUN-
DRED NINETY-TWO U.S. DOLLARS THIRTY-ONE CENTS (USD 10,925,892.31.-) to the share premium account of
the Company.

<i>Subscription

PFIZER LUXEMBOURG SARL, prenamed, represented as stated hereabove has declared to subscribe for the ONE

MILLION TWO HUNDRED AND TWENTY-FIVE THOUSAND (1,225,000) New Shares, and to pay them a total price
of ONE MILLION TWO HUNDRED AND TWENTY-FIVE THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 1,225,000.-) together
with total issue premium of TEN MILLION NINE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND EIGHT HUNDRED NINE-

95835

L

U X E M B O U R G

TY-TWO  U.S.  DOLLARS  THIRTY-ONE  CENTS  (USD  10,925,892.31.-)  by  a  contribution  in  kind  consisting  in  the
contribution of a claim in its favour against the Company.

The above contribution in kind has been dealt with in a statement issued by the management of the Company, based

on accounts of the Company as at July 2, 2012 which certifies the existence and the total value of the claim contributed.

<i>Second resolution

The sole partner resolves to amend the first paragraph of article 7 of the by-laws of the Company in order to reflect

such increase of capital, which now reads as follows:

Art. 7. First paragraph. “The corporate capital of the company is set at ONE MILLION TWO HUNDRED FIFTY

THOUSAND  US  DOLLARS  (USD  1,250,000.-)  divided  into  ONE  MILLION  TWO  HUNDRED  FIFTY  THOUSAND
(1,250,000.-) shares having a par value of ONE US DOLLAR (USD 1.00) each.”

<i>Valuation - Costs

For the sake of the present deed, the share capital is estimated at EUR 8,658,970 (exchange rate (median price) on

July 2, 2012: USD 1.-= EUR 0.79252).

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at EUR 4,500 (four thousand five hundred euros).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby

grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign
any deed rectifying the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le deuxième jour de juillet.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

PFIZER LUXEMBOURG SARL constituée suivant acte reçu par acte du notaire instrumentant en date du 3 octobre

2001, ayant son siège au 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 84.125,

représentée par Mme Cécile JAGER, maître en droit, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée en Luxembourg le 2 juillet 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la personne représentant la partie comparante susnom-

mée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée, PFIZER LUXEMBOURG SARL, est l'associé unique de PAH SBSS LUX HOLDING SARL,

constituée suivant acte reçu par acte du notaire instrumentant en date du 5 mars 2012, ayant son siège au 51, avenue JF
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg sous le numéro B 167.311, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1005
du 18 avril 2012 (la «Société») et dont les statuts on été modifiés par acte du notaire soussigné e date du 2 juillet 2012,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Laquelle personne comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société par un montant de UN MILLION DEUX CENT

VINGT-CINQ MILLE DOLLARS AMERICAINS (USD 1.225.000,-) pour le porter de son montant actuel de VINGT-CINQ
MILLE DOLLARS AMERICAINS (USD 25.000,-) à un montant de UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE
DOLLARS  AMERICAINS  (USD  1.250.000,-)  par  l'émission  de  UN  MILLION  DEUX  CENT  VINGT-CINQ  MILLE
(1.225.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur D'UN U.S. DOLLAR (USD 1,00) chacune (les «Nouvelles Parts
Sociales»), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission
de DIX MILLIONS NEUF CENT VINGT-CINQ MILLE HUIT CENT QUATREVINGT-DOUZE DOLLARS AMERICAINS
ET TRENTE ET UN CENTS (USD 10.925.892,31.-).

95836

L

U X E M B O U R G

L'apport total de DOUZE MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE DOLLARS

AMERICAINS ET TRENTE ET UN CENTS (USD 12.150.892,31,-) relativement aux Nouvelles Parts Sociales est alloué
comme suit: (i) UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS AMERICAINS (USD 1.250.000,-) au capital
social de la Société et (ii) DIX MILLIONS NEUF CENT VINGT-CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE
DOLLARS AMERICAINS ET TRENTE ET UN CENTS (USD 10.925.892,31.-) au compte de prime d'émission de la Société.

<i>Souscription

PFIZER  LUXEMBOURG  SARL,  a  déclaré  souscrire  toutes  les  UN  MILLION  DEUX  CENT  VINGT-CINQ  MILLE

(1.225.000) nouvelles parts sociales et les libérer pour un prix total de UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE
DOLLARS  AMERICAINS  (USD  1.250.000,-)  ensemble  avec  une  prime  d'émission  de  DIX  MILLIONS  NEUF  CENT
VINGT-CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE DOLLARS AMERICAINS ET TRENTE ET UN CENTS
(USD 10.925.892,31.-), par un apport par l'apport en nature d'une créance en sa faveur et à l'encontre de la Société.

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'une confirmation de l'existence et de la valeur émise par les gérants de la

Société, sur base d'un bilan de la Société daté du 2 juillet 2012, qui certifient la valeur totale de l'apport en nature.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide alors de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société pour refléter

l'augmentation de capital, lequel article sera comme suit:

Art. 7. Premier paragraphe. « Le capital social de la société est fixé à UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE

DOLLARS AMERICAINS (EUR 1.250.000,-) divisé en UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE (1.250.000) parts
sociales ayant une valeur nominale de 1 DOLLAR AMERICAIN (USD 1.00) chacune.»

<i>Frais

Pour les besoins du présent acte, le capital social est évalué à EUR 8.658.970 (taux de change (median price) du 2 juillet

2012: USD 1,-= EUR 0,79252).

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte, sont évalués à EUR 4.500 (quatre mille cinq cents euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à

tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête e la personne compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état

et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Cécile Jager, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 6 juillet 2012. LAC / 2012 / 31752. Reçu 75.- €.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme  délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085432/134.
(120120750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Rock Ridge RE 37, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 170.064.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the seventh day of June.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg

There appeared:

Field Point IV S.à r.l, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with

registered office at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register
under number B 119.324,

95837

L

U X E M B O U R G

duly represented by Ms. Claire Guilbert, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on the 1st of June 2012.

This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has requested the undersigned notary to enact the

following articles of association of a société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company") is hereby established

by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the law of
10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of association (the "Articles of
Association").

Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may in addition acquire, dispose of and invest in loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances,

warrants and other debt instruments and securities secured by real estate.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company and may also acquire, hold
and dispose of stock and other equity interests in such companies.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of "Rock Ridge RE 37".

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a resolution of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only
be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general
meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares
are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers, who need not necessarily be

shareholders. The board shall be composed of at least one manager A and at least one manager B.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one manager A and one manager

B.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

95838

L

U X E M B O U R G

The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime).

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board
of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire
set of such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at

least three quarters of the share capital.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

95839

L

U X E M B O U R G

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by Field Point IV S.a r.l for a total subscription price of twelve

thousand five hundred Euro (EUR 12,500).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now at the free disposal of the Company, as it has been justified to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2012.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1200.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxem-

bourg.

2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr. Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, born on 28 November 1957 in Oxford, England, with professional

address at 5, Savile Row, W1S 3PD London, United Kingdom;

- Mr. Lewis Schwartz, Manager A, born on 12 January 1966 in New Jersey, United States of America, with professional

address at 100, West Putnam Avenue 06830 Connecticut, Greenwich, United States of America;

- Mr. Julien Goffin, Manager B, born on 27 March 1980 in Verviers, Belgium, with professional address at 22, Grand-

rue, L-1660 Luxembourg;

- Mr. Pierre Beissel, Manager B, born on 25 April 1973 in Luxembourg, with professional address at 14, rue Erasme,

L-2010 Luxembourg; and

- Mr. Christoph Tschepe, Manager B, born on 6 April 1979 in Trier, Germany, with professional address at 22, Grand-

rue, L-1660 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, the said person appearing signed together

with the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendzwölf, den siebten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Field Point IV S.à r.l, eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzog-

tums Luxemburg, mit Sitz in 22, Grand-rrue, L-1660 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg unter der Nummer B 119.324,

hier vertreten durch Claire Guilbert, maître en droit, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 1. Juni 2012.

95840

L

U X E M B O U R G

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  „Gesell-
schaft") gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb and Verkauf von Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland,

sowie die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Beteiligungen in
luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Ver-
kauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf und die Beteiligung an Darlehen, Anleihen, Schuldscheinen,

Obligationen, Scheinen, Krediten, Optionsscheinen und anderen Schuldinstrumenten und Wertpapieren, die durch Im-
mobilienvermögen abgesichert sind.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen. Die Gesellschaft kann auch Aktien und andere Kapitalbeteiligungen in solchen Gesellschaften erwerben,
halten und veräussern.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Rock Ridge RE 37".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Haupt-

versammlung  der  Gesellschafter  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Großherzogtum  Luxemburg  verlegt  werden.  Innerhalb
derselben Gemeinde kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführerrats verlegt werden. Die Gesellschaft
kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft endet nicht mit dem Tod, dem Verlust der Bürgerrechte, dem Konkurs oder der Zahlungs-

unfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder

Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt, die die Dauer seines/ihres Mandates fest-

legt.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet, der aus min-

destens einem A Geschäftsführer und mindestens einem B Geschäftsführer besteht.

95841

L

U X E M B O U R G

In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von einem A Geschäftsführer und

einem B Geschäftsführer verpflichtet.

Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der je-
weiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund

auch immer, aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens

drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

95842

L

U X E M B O U R G

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 23. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines

von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von Field Point IV S.ä r.l., vorgenannt, für einen Gesamtpreis von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde, der es bestätigt
hat.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

EUR 1200 geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich  nach  Gesellschaftsgründung  hat  der  Gesellschafter,  der  das  gesamte  gezeichnete  Gesellschaftskapital

vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, Großher-

zogtum Luxemburg.

2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Geschäftsführer A, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, mit

beruflicher Adresse in 5, Savile Row, W1S 3PD London, Grossbritannien;

- Herr Lewis Schwartz, Geschäftsführer A, geboren am 12. Januar 1966 in New Jersey, Vereinigten Staaten, mit be-

ruflicher Adresse in 100, West Putnam Avenue 06830 Connecticut, Greenwich, Vereinigten Staaten;

- Herr Julien Goffin, Geschäftsführer B, geboren am 27. März 1980 in Verviers, Belgien, mit beruflicher Adresse in 22,

Grand-rue, L-1660 Luxemburg;

- Herr Pierre Beissel, Geschäftsführer B, geboren am 25. April 1973 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse in 14, rue

Erasme, L-2010 Luxemburg; und

- Herr Christoph Tschepe, Geschäftsführer B, geboren am 6. April 1979 in Trier, Deutschland, mit beruflicher Adresse

in 822, Grand-rue, L-1660 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

95843

L

U X E M B O U R G

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigen hat dieser mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Guilbert et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 juin 2012. LAC/2012/26717. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085473/342.
(120121012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

PL Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 151.047.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64562 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012085445/10.
(120120771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Balmoral Land Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 139.210.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BALMORAL LAND LUXEMBOUR Sàrl

Référence de publication: 2012086664/10.
(120122585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Campus West S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.873.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2012086694/11.
(120123202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Centre d'Echelles et de Matériel S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, route de Kayl.

R.C.S. Luxembourg B 55.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2012086717/10.
(120122269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

95844

L

U X E M B O U R G

Clearstream Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 60.911.

Le Bilan de Clearstream Services au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012086725/12.
(120123038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

CMS Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 81.525.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christelle Ferry
<i>Director

Référence de publication: 2012086726/11.
(120122284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

LogiCor Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 170.062.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the fourth day of July.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

BRE/Europe 6Q S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg

and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies under number B 164012,

here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

under private seal in Luxembourg, on 2 July 2012.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of association of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the “Company”)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

95845

L

U X E M B O U R G

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of “LogiCor Topco S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time subject to the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognise only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
rights owned by the survivors. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of its sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be

shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board
of managers. The managers may be dismissed freely at any time.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

Art. 12. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate
or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

95846

L

U X E M B O U R G

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 18. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by BRE/Europe 6Q S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) entirely allocated to the share capital is as of now available to the Company, as it has been justified to the
undersigned notary.

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2012.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

95847

L

U X E M B O U R G

<i>Sole shareholder resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the sole shareholder, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L1273 Luxembourg,
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its

registered office at 19, rue de Bitbourg, L1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register
under the number B 164777 is appointed as manager of the Company for an indefinite period.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and

residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le quatre juillet,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

BRE/Europe 6Q S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant

son siège social au 19, rue de Bitbourg, L1273 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 164012,

ici représentée par Mademoiselle Carole Noblet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 juillet 2012.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de son objet.

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l'assistance de conseillers
extérieurs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «LogiCor Topco S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Au sein de la même municipalité, le siège social
peut  être  transféré  par  simple  décision  du  gérant  ou  du  conseil  de  gérance.  La  Société  peut  ouvrir  des  agences  ou
succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

95848

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la Société

sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gérants sont
librement et à tout moment révocables.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 12. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou

par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

95849

L

U X E M B O U R G

D. Décisions de l'associé unique  Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 18. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 19. Le nombre d'associés de la Société ne pourra jamais dépasser trente (30). Une personne physique ne pourra

jamais prétendre au statut d'associé de la Société.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net est réservé à la création d'une réserve statutaire jusqu'à ce que cette

réserve s'élève à dix pour cent (10%) du capital social. Le solde pourra être librement utilisé par le ou les actionnaire(s).
Des dividendes intérimaires pourront être distribués conformément aux termes et conditions prévus par la loi.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par BRE/Europe 6Q S.à r.l., préqualifiée.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200,-.

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., une société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège

social au 19, rue de Bitbourg, L1273 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 164777, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. NOBLET - H. HELLINCKX.

95850

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 juillet 2012. Relation:LAC/2012/31489. Reçu soixante-quinze euro 75,00

EUR

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le treize juillet de l'an deux mille douze.

Référence de publication: 2012085316/300.
(120120952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

LAI SICAV-SIF S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

R.C.S. Luxembourg B 133.036.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung 08. März 2012

Am 08. März 2012 um 11 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.
Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft, BDO Audit, S.A., wird um ein Jahr und damit bis zum Ablauf der

im Jahr 2013 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung verlängert.

Luxemburg, den 10. Juli 2012.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2012085324/14.
(120120740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Japoma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 90.410.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 31 mars 2012.

<i>Pour JAPOMA S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2012085277/13.
(120120746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

BG Holdings I Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 126.082.

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 2 mars 2012 sous seing prive que;
M Felix Bauer, administrateur de sociétés, né le 5 juin 1975 à Marktredwitz (Allemagne), demeurant à 14-18 Heddon

Street, W1B 4DA Londres (Grande Bretagne) a cédé l'intégralité des 500 parts sociales de la Société à Dr. Michael Bauer,
dentiste, né le 9 mai 1966 à Waldsassen (Allemagne), demeurant à Landsberger Str. 155, D-80687 Munich (Allemagne).

Suite à ce transfert le capital social est désormais reparti comme suit:

Dr. Michael Bauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2012084950/18.
(120120669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

95851

L

U X E M B O U R G

Allianz Investments I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 325.000.000,00.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 112.841.

AUSZUG

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von

Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2012086588/13.
(120122404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Athmosphera Golf &amp; Wellness Resort S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 162.297.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ATHMOSPHERA GOLF &amp; WELLNESS RESORT S.A.
SGG S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012086641/13.
(120122771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

OI-Clothing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.717.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée tenue le 13 juillet 2012

<i>Résolution

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décidé de renouveler le mandat de Ernst &amp;

Young S.A., avec siège social à 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, jusqu'au l'assemblée
qui se tiendra en 2013.

L'assemblée décide de recomposer le conseil d'administration avec les personnes suivantes:
- Mrs. Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, demeurant professionnellement à 31, Boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg;

-  Mrs.  Virginie  Derains,  employée,  demeurant  professionnellement  à  31,  Boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,

L-1331 Luxembourg;

- Mrs. Sarah Lobo, Master of Commerce, demeurant professionnellement à 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg;

Leur mandat viendra à échéance a l'assemblée qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085409/23.
(120120689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

95852

L

U X E M B O U R G

Harmon Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.002,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 143.562.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Lors du dépôt numéro L120108450 en date du 28 juin 2012, une erreur matérielle s'est produite. Cette nouvelle

donnée remplace la précédente.

Le siège social de la Société est situé au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et non au 20, rue Eugène Ruppert,

L-2053 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 13 juillet 2012.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2012085227/22.
(120120673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Eurasian Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 135.511.

In the year two thousand twelve, on the 11 

th

 of July.

Before us, Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held an Extraordinary general meeting of the shareholders of "EURASIAN CONSULTING S.à r.l.", duly incor-

porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-8010 Strassen
206-210, route d'Arlon (Grand-Duchy of Luxembourg) and registered at the Register of Trade and Companies of Lu-
xembourg under number B 135511, incorporated on January 22 

nd

 , 2008 before the notary Maître Blanche MOUTRIER,

residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), deed published in Memorial Recueil Special des Sociétés et
Associations C number 1488 of June 17 

th

 , 2008, deed last time modified on September 9 

th

 , 2010 before the notary

Maître Blanche MOUTRIER, prenamed, deed published in Memorial recueil des Sociétés et Associations C number 2279
of October 10 

th

 , 2010 (hereafter the "Company).

The General Meeting is presided by Mr. Hervé PONCIN, manager, with professional address in L-2419 Luxembourg,

3, rue du Fort Rheinsheim.

The chairman appointed as secretary Mr. Charles DURO, lawyer, with professional address in L-1325 Luxembourg,

3, rue de la Chapelle.

The General Meeting elected as scrutineer Mr. Lionel BONIFAZZI, lawyer, with professional address in L-1325 Lu-

xembourg, 3, rue de la Chapelle.

The meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Transfer of the registered office from L-8010 Strassen 206-210, route d'Arlon (Grand-Duchy of Luxembourg) to

L-1114 Luxembourg 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duchy of Luxembourg);

2. Amendment of first paragraph 1 of article 5 of the by-laws of the Company so as to reflect the decision taken;
3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the office of the meeting and the undersigned notary will remain attached to the present deed,

95853

L

U X E M B O U R G

together with the proxies of the represented shareholders signed "ne varietur" by the office of the meeting and the
undersigned notary.

III. It appears from said attendance list that all the shares issued are present or represented. Consequently, the general

meeting is regularly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda aforementioned, all
the shareholders hereby stating that they have been informed of the agenda of the meeting, prior to the holding of the
meeting.

IV. After having approved the foregoing and after deliberation, the general meeting unanimously took the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to transfer the registered office of the Company from L-8010 Strassen 206-210, route

d'Arlon (Grand-Duchy of Luxembourg) to L-1114 Luxembourg 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duchy of Luxembourg)
with effect as of June 1 

st

 2012.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, paragraph 1 of article 5 of the by-laws has been amended and will now

be read as follows:

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg."
Nothing further being on the agenda and nobody asking to speak, the meeting was terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation; upon request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française

L'an deux mille douze, le onze juillet.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg).
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois «EURASIAN CONSULTING S.à r.l.», ayant son siège social à L-8010 Strassen 206-210, route d'Arlon (Grand-Duché
de Luxembourg) et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135511, con-
stituée le 22 janvier 2008 par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché
de Luxembourg), acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1488 du 17 juin 2008
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 16 septembre 2010, par devant Maître Blanche MOUTRIER,
prénommée, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2279 du 26 octobre 2010 (ci-après
«la Société»).

L'assemblée est présidée par M. Hervé PONCIN, manager, demeurant professionnellement à L-2419 Luxembourg, 3,

rue du Fort Rheinsheim.

Le président a désigné comme secrétaire Me Charles DURO, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Lu-

xembourg, 3, rue de la Chapelle.

L'assemblée  a  choisi  comme  scrutateur  Me  Lionel  BONIFAZZI,  avocat,  demeurant  professionnellement  à  L-1325

Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1.  Transfert  du  siège  social  de  L-8010  Strassen  206-210,  route  d'Arlon  (Grand-Duché  de  Luxembourg)  à  L-1114

Luxembourg 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Luxembourg);

2. Modification de l'article 5, alinéa premier des statuts de la Société afin de refléter la décision prise;
3. Divers.
II- Il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents et/ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent; cette liste de présence, signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et
le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par les membres
du bureau et le notaire instrumentant.

III- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées. Dès lors, l'as-

semblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points de l'ordre du jour

95854

L

U X E M B O U R G

précité, dont les associés ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée. Tous les associés déclarent avoir été informés
de l'ordre du jour de l'assemblée avant la tenue de l'assemblée.

IV- Après avoir approuvé ce qui précède et après délibérations, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unani-

mité:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de L-8010 Strassen 206-210, route d'Arlon (Grand-Duché de Lu-

xembourg) à L-1114 Luxembourg 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet au 1 

er

 Juin 2012.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 5, alinéa premier des statuts de la Société a été modifié et a dorénavant la

teneur suivante:

Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. "
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; sur demande des mêmes requérants et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: H. Poncin, C. Duro, L. Bonifazzi, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9241. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085132/111.
(120120254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Intelicom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 100.834.

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de la Société tenue en date du 13 juillet 2012

que les administrateurs suivants, M. Fernand HEIM, Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT et M. Marc SCHMIT, ainsi que
le commissaire aux comptes, M. Marco RIES, se sont démis de leurs fonctions respectives avec effet immédiat.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2012085271/12.
(120120786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Melvic Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 100.833.

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de la Société tenue en date du 13 juillet 2012

que les administrateurs suivants, M. Fernand HEIM, Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT et M. Marc SCHMIT, ainsi que
le commissaire aux comptes, M. Marco RIES, se sont démis de leurs fonctions respectives avec effet immédiat.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2012085371/12.
(120120785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

95855

L

U X E M B O U R G

Entreprise de Peinture MASSEN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3259 Bettembourg, 23, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 25.663.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le gérant

Référence de publication: 2012086784/10.
(120123164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Diaverum Pooling GP &amp; Co., SCA, Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 1.970.080,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.608.

Les Comptes Annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2012.

<i>Pour la Société
Jana Oleksy
<i>Gérante

Référence de publication: 2012086756/13.
(120122341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Dreamco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 158.356.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

le 25 avril 2012 sous la référence L120066480

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012086759/13.
(120122975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Menolly Investments 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.158.

Par résolutions prises en date du 3 mai 2012 l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Marie-Catherine Brunner, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg de son mandat de Gérant B, avec effet immédiat

2. Nomination de Sara Speed, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de Gérant B,

avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Référence de publication: 2012085356/15.
(120120726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

95856


Document Outline

Allianz Investments I Luxembourg S.à r.l.

Alpina Real Estate Company II SCA

Alpina Real Estate Company S.C.A.

Athmosphera Golf &amp; Wellness Resort S.A.

Balmoral Land Luxembourg Sàrl

BALTHASAR FinPar SA

BG Holdings I Sàrl

Brufinol S.A.

Campus West S.à r.l.

Carrelages Lux S.à r.l.

Centre d'Echelles et de Matériel S.àr.l.

Clearstream Services

CMS Management Services S.A.

Diaverum Pooling GP &amp; Co., SCA

Dreamco S.à r.l.

Duferco Long Products S.A.

Entreprise de Peinture MASSEN S.à r.l.

Eurasian Consulting S.à r.l.

Expert Resource Exchange and Consulting S.A.

Foruminvest Luxembourg S.à r.l.

Gaichel Invest S.A.

Genes Technologies

Good Energies Investments 2 (Luxembourg) S.à r.l.

GP Leasing S.à r.l.

GP Worldwide Investments (Luxembourg) S.à r.l.

Harmon Europe Holding S.à r.l.

ImmoFinRe II SICAV-FIS

InfraRev Holding

Intelicom S.A.

Japoma S.A.

Kredietbank Informatique GIE

LAI SICAV-SIF S.A.

La Serine S.A.

Linea Investments S.A.

LogiCor Topco S.à r.l.

Lux-Edjar Luxembourg Sàrl

Melvic Group S.A.

Menolly Investments 2 S.à r.l.

OI-Clothing S.A.

PAH SBSS Lux Holding Sàrl

Palcor International S.A.

Palcor International S.A.

Palcor International S.A.

Palcor International S.A.

Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l.

PL Holdings S.à r.l.

Rock Ridge RE 37

Rock Ridge RE 6

Salinger S.A.

Sarabel Luxembourg S.à r.l.

Simon Pierre S.A.

Sphinx Private Equity Management International S.à r.l.

SVL-LuxInvest SCS SICAF-SIF

Tempyr S.à r.l.

Titan

Toubkal Holding S.A.

Trican Well Service Ltd., Luxembourg Branch

TWS - Europe S.A.

Ultima Holding S.A.

Xtravel S.A.

ZapFi International S.A.

ZapFi Networks International S.A.

ZapFunding S.à r.l.

ZapHolding S.A.