logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1703

6 juillet 2012

SOMMAIRE

Automat' Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81734

Baden Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81724

Black Tie Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

81726

Boom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81738

Café Belle époque S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

81718

Château de Beggen Participations S.A. . . .

81741

Criali Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81743

DenTheater.lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81731

E.P.F. European Property Foundation

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81721

Ermitage Japan Absolute Fund  . . . . . . . . . .

81738

Hereford Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81721

Imperiale Lounge Bar  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81718

Indufin Capital Partners S.A., SICAR  . . . .

81735

LF Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81698

Lunon A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81722

Majerus-Parmentier Constructions Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81721

Meco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81723

Medic Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

81725

MEIF4 Luxembourg B Holdings S.à. r.l.  . .

81734

MGG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81724

Microcap 08/09 - FTL S.C.A., SICAR  . . . . .

81716

Microcap 08/09 - ITM S.C.A., SICAR  . . . . .

81716

Mirabaud Asset Management (Europe)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81721

Mit Holding S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81726

ML Ray Investor S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

81728

MOTO24H S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81728

Motor Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81728

New La Rosière S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81724

NIFE Carlo Seccomandi  . . . . . . . . . . . . . . . .

81711

Nowa Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81722

NS Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81724

Pan European Ventures S.A.  . . . . . . . . . . . .

81728

Panev S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81729

PEME 09 - FTL S.C.A, SICAR  . . . . . . . . . . .

81714

PEME 09 - ITM S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . .

81714

Prologis Fund Management S.à r.l. . . . . . . .

81730

Promotions Schmit & Klein S.à r.l. . . . . . . .

81730

Prorech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81734

Prorech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81730

Q Build  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81734

Quadro Capital Management S.à r.l.  . . . . .

81734

Quant Solutions Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81735

Racine Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .

81737

Rafferty 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81729

Ramsac S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81737

Regus Enterprises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81739

Renda S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81737

Renimax S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81738

Research Invest Protocol S.A.  . . . . . . . . . . .

81735

Rich Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

81739

Risk Dynamics S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81741

Risk Dynamics S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81742

Risk & Insurance Services S.A. (Luxem-

bourg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81741

Rollins Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81742

Ronndriesch 123 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81743

Roosevelt International S.à r.l.  . . . . . . . . . .

81743

S.M. Tuyauteries Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81744

Structor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81729

Taranis International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

81731

Triton III No. 10 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

81742

Triton III No. 11 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

81730

WP2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81743

81697

L

U X E M B O U R G

LF Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 169.735.

STATUTES

In the year two thousand and twelve; on the twentieth day of June;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

LF Finance (Suisse) S.A., with registered office at 86 rue du Rhône, CH-1200 Geneva, Switzerland,
here represented by Me David HEINEN, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg,
pursuant to a proxy under private seal given on 15 June 2012.
The proxy, signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to draw up the following

articles of incorporation of a société anonyme which it declares to organize:

Art. 1. Denomination. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of

shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme qualifying as “société d'investissement à capital
variable - fonds d'investissement spécialisé” under the name of “LF Funds” (hereinafter the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved by a resolution

of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the “Articles of
Incorporation”).

Art. 3. Object. The object of the Company is to place the funds available to it in securities of all types (including units

or shares of other undertakings for collective investment), and other permitted assets, directly or through one or several
wholly owned subsidiaries, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of
the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 13 February 2007 on specialised investment
funds, as amended (the “Law of 2007”).

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy

of Luxembourg.

The registered office of the Company may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of

the board of directors of the Company (the “Board of Directors”).

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board

of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military events have occurred or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company.

Art. 5. Capital - Shares - Classes and Sub-Funds. The capital of the Company shall be represented by shares of no par

value (the “Shares” and each a “Share”) and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined
in Article 23 hereof.

The initial share capital of the Company amounts to forty-five thousand U.S. Dollars (USD 45,000.-) divided into four

hundred fifty (450) fully paid Shares of no par value.

The  subscribed capital  of  the  Company, increased  by  the share premiums,  shall  amount  at least  to  the minimum

prescribed by Luxembourg law and must be reached within a period of twelve months from the authorisation of the
Company in Luxembourg.

The Board of Directors is authorised without limitation to issue fully paid Shares and/or partly paid Shares (as permitted

by the Law of 2007) at any time in accordance with article 6 at a price based on the Net Asset Value (as defined below)
per Share without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscription of the Shares to be issued.

The Board of Directors may also decide to issue Shares with a share premium.
The Board of Directors may delegate to any of its members (the “Directors”, each individually a “Director”) or to

any officer of the Company or to any duly authorised person, the duty to accept subscriptions and receive payment for
such new Shares and to deliver these, remaining always within the provisions of the Law of 2007.

81698

L

U X E M B O U R G

As the Board of Directors shall determine, the capital of the Company, which has an umbrella structure, may be divided

into different portfolios of securities and other assets permitted by law with specific investment objectives and various
risk or other characteristics (the “Sub-Funds” and each a “Sub-Fund”). The Sub-Funds may be denominated in different
currencies as the Board of Directors shall determine. With regard to third parties, there is no cross liability between
Sub-Funds and each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities reasonably attributable to it. Within each
Sub-Fund, the Board of Directors may decide to issue different classes of Shares (the “Classes” and each a “Class”) which
may differ, inter alia, with respect to their charging structure, dividend policies, hedging policies, investment minima,
currency of denomination or other specific features, as the Board of Directors may decide to issue. The Board of Directors
may decide if and from what date Shares of any such Classes shall be offered for sale, those Shares to be issued on the
terms and conditions as shall be decided by the Board of Directors. Where the context so requires, references in these
Articles of Incorporation to “Sub-Fund(s)” shall be references to “Class(es)”.

The Company is an umbrella structure as provided for in article 71 of the Law of 2007. The assets of a specific Sub-

Fund are exclusively available to satisfy the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation,
the operation or the liquidation of that Sub-Fund.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not

denominated in USD, be converted into USD and the capital shall be the aggregate of the net assets of all the Sub-Funds.
The Company shall prepare consolidated accounts in USD or such other currency as the Board of Directors may de-
termine.

Art. 6. Issue of Shares. The Company may elect to issue Shares in both registered or bearer form. The Company shall

issue statements of account to certify holdings of shareholders, which shall constitute extracts of the register of share-
holders (the “Register”).

If bearer Shares are issued, certificates will be issued in such denominations as the Board of Directors shall decide. If

a bearer shareholder requests the exchange of his certificates for certificates in other denominations, he will be charged
the cost of such exchange. Bearer share certificates shall be signed by two Directors. Both such signatures may be either
manual, or printed, or by facsimile. However, one of such signatures may be by a person delegated to this effect by the
Board of Directors. In such latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such
form as the Board of Directors may from time to time determine.

Unless otherwise provided for in the offering document of the Company as the same may be amended from time to

time (the “Offering Document”), Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and after receipt of the
purchase price. The subscriber will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase
price and any other document required by the Company or its duly appointed agent as disclosed in the Offering Document,
receive title to the Shares purchased by him and upon application obtain delivery of definitive share certificates in bearer
form or a confirmation of his shareholding.

Holders  of  bearer  Shares  may  at  any  time  request  conversion  of  their  Shares  into  registered  Shares.  Holders  of

registered Shares may only request conversion of their Shares into bearer Shares if permitted by the Board of Directors
and disclosed in the Offering Document.

Payments of dividends will be made by bank transfer to shareholders, in respect of registered Shares, at their address

in the Register or to designated third parties and, in respect of bearer Shares, in the manner determined by the Board
of Directors from time to time in accordance with Luxembourg law.

A dividend declared but not paid on a Share during six years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share,

shall be forfeited by the holder of such Share, and shall revert to the Company. All issued Shares of the Company, other
than bearer Shares, shall be inscribed in the Register, which shall be kept by the Company or by one or more persons
designated therefor by the Company and such Register shall contain the name of each holder of registered Shares, his
residence or elected domicile and the number of Shares held by him. Every transfer of a registered Share shall be entered
in the Register.

Transfer of bearer Shares shall be effected by delivery of the relevant bearer share certificates and in accordance with

the Offering Document.

Transfer of registered Shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the Register, dated

and signed by the transferor and if so requested by the Company, at its discretion, also signed by the transferee, or by
persons holding suitable powers of attorney to act therefor.

In case of bearer Shares the Company may consider the bearer, and in the case of registered Shares the Company

shall consider the person in whose name the Shares are registered in the Register, as full owner of the Shares.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements

from the Company may be sent. Such address will also be entered in the Register.

In the event that such shareholder does not provide such an address, the Company may permit a notice to this effect

to be entered in the Register and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company,
or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided
to the Company by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register

81699

L

U X E M B O U R G

by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the
Company from time to time.

If payment made by any subscriber results in the issue of a Share fraction, the person entitled to such fraction shall

not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine as to the calculation of fractions, be entitled
to dividends or other distributions on a pro rata basis. In the case of bearer Shares, only certificates evidencing full Shares
will be issued.

The Company will recognise only one holder in respect of a Share in the Company unless otherwise determined by

the Board of Directors and disclosed in the Offering Document. In the event of joint ownership or bare ownership and
usufruct, the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant Share or Shares until one person
shall have been designated to represent the joint owners or bear owners and usufructaries vis-à-vis the Company.

In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or

other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint
holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.

Art. 7. Lost and Damaged Certificates. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share

certificate has been mislaid or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such
conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the
Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate,
the original share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated certificates shall

be delivered to the Company and shall be annulled immediately.

The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate and all reasonable expenses

undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the annulment
of the old share certificates.

Art. 8. Restrictions on Shareholding. Shares of the Company may only be subscribed by well-informed investors, as

defined in article 2 of the Law of 2007 (“Well-Informed Investors”) and the Board of Directors has full power to accept
and reject subscriptions. However, the Board of Directors shall have power to impose or relax restrictions on any Shares
or Sub-Fund (other than any restrictions on transfer of Shares, but including the requirement that Shares be issued only
in registered form), but not necessarily on all Shares within the same Sub-Fund, as it may think necessary for the purpose
of ensuring that no Shares in the Company or no Shares of any Sub-Fund in the Company are acquired or held by or on
behalf of:

(a) any person in breach of the law or requirements of any country or governmental or regulatory authority (if the

Board of Directors shall have determined that any of them, the Company, any manager of the Company's assets, any of
the Company's investment managers or advisers or any Connected Person (as defined in Article 17) would suffer any
disadvantage as a result of such breach),

(b) any person in circumstances which in the opinion of the Board of Directors might result in the Company or its

shareholders incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which they might not other-
wise have incurred or suffered, including a requirement to register under any securities or investment or similar laws or
requirements of any country or authority, or market timing and/or late trading practices; or

(c) any person who, in the opinion of the Board of Directors, does not qualify as a Well-Informed Investor.
The Directors shall have the power to compulsorily redeem Shares in the circumstances under (a), (b) and (c) above.
The Board of Directors is also entitled to compulsorily redeem all Shares of a shareholder where:
(1) a shareholder has transferred or attempted to transfer any portion of its Shares in violation of the Offering Do-

cument and/or of these Articles of Incorporation; or

(2) any of the representations or warranties made by a shareholder in connection with the acquisition of Shares was

not true when made or has ceased to be true; or

(3) a shareholder (i) has filed a voluntary petition in bankruptcy; (ii) has been adjudicated bankrupt or insolvent, or has

had entered against it an order for relief, in any bankruptcy or insolvency proceeding; (iii) has filed a petition or answer
seeking any reorganization, arrangement, composition, readjustment, liquidation, dissolution or similar relief under any
statute, law or regulation; (iv) has filed an answer or other pleading admitting or failing to contest the material allegations
of a petition filed against him in any proceeding of this nature; or (v) has sought, consented to or acquiesced in the
appointment of a trustee, receiver or liquidator of such shareholder or of all or any substantial part of the shareholder's
properties; or

(4) in any other circumstances in which the Board of Directors determines in its absolute discretion that such com-

pulsory redemption would avoid material legal, pecuniary, tax, economic, proprietary, administrative or other disadvan-
tages to the Company.

More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm

or corporate body, and, without limitation, by any U.S. Person (as defined in the Offering Document).

For such purpose, the Company may:

81700

L

U X E M B O U R G

(a) decline to issue any Share where it appears to it that such registration would or might result in such Share being

directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding Shares in the Company (the “Precluded Per-
son”);

(b)  at  any  time  require  any  person  whose  name  is  entered  in  the  register  of  shareholders  to  furnish  it  with  any

information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not
beneficial ownership of such shareholder's Shares rests in a Precluded Person; and

(c) where it appears to the Company that any person, who is a Precluded Person, either alone or in conjunction with

any other person is a beneficial or registered owner of Shares, compulsorily redeem from any such shareholder all Shares
held by such shareholder in the following manner:

(i) The Company shall serve a notice (hereinafter called the “Redemption Notice”) upon the shareholder bearing such

Shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to
be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the Redemption Price (as hereafter
defined) in respect of such Shares is payable. Any such Redemption Notice may be served upon such shareholder by
posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing
in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the
Share certificate or certificates (if issued) representing the Shares specified in the Redemption Notice. Immediately after
the close of business on the date specified in the Redemption Notice, such shareholder shall cease to be a shareholder
and the Shares previously held by him shall be cancelled;

(ii) the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (the “Redemption Price”) shall

be an amount equal to the Net Asset Value of Shares of the relevant Sub-Fund and Classes, determined in accordance
with Article 23, less any redemption charge payable in respect thereof;

(iii) payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency

of denomination of the relevant Sub-Fund or Class and will be deposited by the Company in Luxembourg or elsewhere
(as specified in the Redemption Notice) for payment to, such person but only, if a Share certificate shall have been issued,
upon surrender of the Share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice. The Redemption
Price which may not be distributed to the shareholders upon the implementation of the redemption will be deposited
with the custodian for a period of six months and after such period, the Redemption Price will be deposited in escrow
with the Luxembourg Caisse de Consignation on behalf of the shareholders entitled thereto. Upon deposit of such price
as aforesaid no person interested in the Shares specified in such Redemption Notice shall have any further interest in
such Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the
shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest);

(iv) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in

any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true
ownership of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided
that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith;

(d) decline to accept the vote of any Precluded Person at any general meeting of shareholders of the Company; and
(e) if it appears at any time that a shareholder is not a Well-Informed Investor, in addition to any liability under applicable

law, the relevant shareholder shall hold harmless and indemnify the Company, the Board of Directors, the other share-
holders of the relevant Sub-Fund and the Company's agents and affiliates for any damages, losses and expenses resulting
from or connected to such holding circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue
documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as a Well-Informed
Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.

Art. 9. Powers of the General Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of the shareholders

of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all
shareholders of the Company regardless of the Sub-Fund and Classes of Shares held by them. It shall have the broadest
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 10. General Meetings. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg

law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of the registered
office as may be specified, on the first Friday of the month of June at 2 p.m. (Luxembourg time). If such day is not a bank
business day in Luxembourg (a “Business Day”), the general meeting will take place on the following Business Day. The
annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional
circumstances so require.

Other general meetings of shareholders or Sub-Fund or Class meetings may be held at such place and time as may be

specified in the respective notices of meeting. Sub-Fund or Class meetings may be held to decide on any matters, which
relate exclusively to such Sub-Fund or Class. Two or several Sub-Funds or Classes may be treated as one single Sub-Fund
or Class if such Sub-Funds or Classes are affected in the same way by the proposals requiring the approval of shareholders
of the relevant Sub-Funds or Classes.

Art. 11. Notices, Quorum and Votes. The quorum and notice periods required by law shall govern the conduct of the

meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

81701

L

U X E M B O U R G

Each Share of whatever Sub-Fund and regardless of the Net Asset Value per Share within its Class, is entitled to one

vote subject to the restrictions contained in these Articles of Incorporation. A shareholder may act at any meeting of
shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram or telex or facsimile. Such
proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders' meeting.

Shareholders may also vote by means of a dated and duly completed form which must include the information as set

out herein. The Board of Directors may in its absolute discretion indicate in the convening notice that the form must
include information in addition to the following information: the name of the Company, the name of the shareholder as
it appears in the Register; with respect to bearer Shares, the identification number of the certificate that was issued to
the shareholder; the place, date and time of the meeting; the agenda of the meeting; an indication as to how the shareholder
has voted.

In order for the votes expressed by such form to be taken into consideration for the determination of the quorum,

the form must be received by the Company or its appointed agent at least three Business Days before the meeting or
any other period as may be indicated in the convening notice by the Board of Directors.

If so decided by the Board of Directors at its discretion and disclosed in the convening notice for the relevant meeting,

shareholders may take part in a meeting by way of videoconference or by any other means of telecommunication which
allow them to be properly identified and in such case will be considered as present for the quorum and majority deter-
mination.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 12. Convening Notice. Shareholders will meet pursuant to notice in the manner provided for by Luxembourg law.

Art. 13. The Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than

three members. Members of the Board of Directors need not be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise the remaining Directors

may meet and may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 14. Proceedings of the Board of Directors. The Board of Directors shall choose from among its members a

chairman and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who
need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and
of the shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two Directors, at the place
indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and at the Board of Directors, in his absence the shareholders

or the Board of Directors shall appoint any person as chairman pro tempore.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by email, cable, telegram,
telex or telefax of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by email, cable or telegram

or telex or telefax message another Director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by cable,
telegram, telex or telefax.

Meetings of the Board of Directors may be held by way of conference call, video conference or by any similar means

of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

The meeting held at a distance by way of such means of communication shall be deemed to have taken place at the

registered office of the Company.

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors.
Directors may not bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the

Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least two Directors are present at a meeting of the Board

of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman or, in his
absence, the chairman pro tempore shall have a casting vote.

Resolutions of the Board of Directors may also be passed in the form of consent resolution in identical terms which

may be signed on one or more counterparts by all the Directors.

81702

L

U X E M B O U R G

The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a

secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the ope-
ration and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors.
Officers need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given them by the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its

powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities
which need not be members of the board. The board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to
any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the board or not) as it thinks
fit.

Art. 15. Minutes of Board of Directors Meetings. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed

by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, the secretary or by any two Directors.

Art. 16. Determination of the Investment Policies. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading

of risks, have power to determine the corporate and investment policy and the course of conduct of the management
and business affairs of the Company and shall set forth in the Offering Document the investment objectives, policies and
restrictions of the Company in accordance with the Law of 2007.

The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more

Classes or Sub-Funds on a pooled basis, as described in Article 24, where it is appropriate to do so.

Art. 17. Director's Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate officer or employee of such other company or firm (a “Connected Person”). Any Director
or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such an affiliation with such other company or firm
but subject as hereinafter provided, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transactions and such Director's or officer's interest therein, shall be reported to the next
succeeding meeting of shareholders.

The term “personal interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in

any matter, position or transaction involving LF Finance (Suisse) S.A. or Banque Libano-Francaise SAL or any subsidiary
or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors.

Art. 18. Indemnity. Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been a Director

or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and
against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which
he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Director or officer and against
amounts paid or incurred by him in the settlement thereof.

The words “claim”, “actions”, “suit”, or “proceeding”, shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil,

criminal or other including appeals), actual or threatened, and the words “liability” and “expenses” shall include, without
limitation, attorney's fees, costs, judgments, amounts paid in settlement, fines, penalties and other liabilities.

No indemnification shall be provided hereunder to a Director or officer:
A.- against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

B.- with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated not to have acted in good faith and in

the reasonable belief that his action was in the best interests of the Company;

C.- in the event of a settlement, unless there has been a determination that such Director or officer did not engage

in wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office:

1) by a court or other body approving the settlement; or
2) by vote of two thirds (2/3) of those members of the Board of Directors of the Company constituting at least a

majority of the Board of Directors who are not themselves involved in the claim, action, suit or proceeding; or

3) by written opinion of independent counsel.
The right of indemnification herein provided may be insured against by policies maintained by the Company, shall be

severable, shall not affect any other rights to which any Director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue
as to a person who has ceased to be such Director or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and

81703

L

U X E M B O U R G

administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate
personnel other than Directors and officers may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this Article may be advanced by the Company, prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or Director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.

Art. 19. Administration. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or

single signature of any Director or officer to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 20. Auditor. The Company shall appoint an independent auditor who shall carry out the duties prescribed by the

Law of 2007. The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and serve until its
successor shall have been elected.

Art. 21. Redemption and Conversion of Shares. As is more specifically prescribed herein below the Company has the

power to redeem its own Shares at any time within the sole limitations set forth by law.

Any shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company provided that:
(i) in the case of a request for redemption of part of his Shares, the Company may, if compliance with such request

would result in a holding of Shares of any one Sub-Fund with an aggregate Net Asset Value of less than such amount or
number of Shares as determined by the Board of Directors and disclosed in the Offering Document from time to time,
redeem all the remaining Shares held by such shareholder; and

(ii) the Company may limit the total number of Shares of any Sub-Fund which may be redeemed on a Valuation Day

(as defined in Article 22) to a number representing a percentage (as set out in the Offering Document) of the net assets
of a same Sub-Fund or a percentage (as set out in the Offering Document) of the net assets of Classes related to a single
pool of assets in the Company.

In case of deferral of redemption, the relevant Shares shall be redeemed at the Share price based on the Net Asset

Value per Share prevailing at the date on which the redemption is effected, less any redemption charge in respect thereof.

The redemption price shall be paid normally, within a period as determined by the Board of Directors and disclosed

in the Offering Document from time to time, following the receipt of the redemption request by the Company and shall
be  based  on  the  Share  price  for  the  relevant  Class  of  the  relevant  Sub-Fund  as  determined  in  accordance  with  the
provisions of Article 23 hereof, less any redemption charge in respect thereof determined by the Board of Directors, as
further disclosed in the Offering Document, including to whom it shall be payable. If in exceptional circumstances the
liquidity of the portfolio of assets maintained in respect of the Shares being redeemed is not sufficient to enable the
payment to be made within such a period, such payment shall be made as soon as reasonably practicable thereafter but
without interest.

Any such request must be filed or confirmed by such shareholder in written form at the registered office of the

Company in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of
Shares. The certificate or certificates for such Shares in proper form and accompanied by proper evidence of transfer or
assignment must be received by the Company or its agent appointed for that purpose before the redemption price may
be paid.

The Company shall have the right, if the Board of Directors so determines, to satisfy payment of the redemption price

to any shareholder requesting redemption of any of his Shares (but subject to the consent of the shareholder) in specie
by allocating to the holder investments from the portfolio of the relevant Sub-Fund equal in value (calculated in the manner
described in Article 23 hereof) to the value of the holding to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred
in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders
of Shares in the relevant Sub-Fund and the valuation used shall be confirmed by a special report of an independent auditor.

Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
Unless otherwise determined by the Board of Directors and disclosed in the Offering Document, any shareholder may

request switching of the whole or part of his Shares of one Class of a Sub-Fund into Shares of a Class of another Sub-
Fund or in another Class of the same Sub-Fund based on a switching formula as determined from time to time by the
Board of Directors and disclosed in the Offering Document provided that the Board of Directors may impose such
restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make switching subject to payment of such charge, as it
shall determine and disclose in the Offering Document.

Art. 22. Valuations and Suspension of Valuations. The Net Asset Value shall be determined as to the Shares of each

Class of each Sub-Fund by the Company from time to time, as the Board of Directors by regulation may direct (every
such day or time of determination thereof being referred to herein as a “Valuation Day”).

The Company may suspend the issue and allocation and the redemption and repurchase of Shares relating to any Sub-

Fund as well as the right to convert Shares relating to a Sub-Fund into those relating to another Sub-Fund and the
calculation of the Net Asset Values per Share relating to any Sub-Fund:

81704

L

U X E M B O U R G

a) during any period when any market or stock exchange, which is the principal market or stock exchange on which

a material part of the investments of the relevant Sub-Fund for the time being are quoted or dealt in, is closed, other than
for legal holidays or during which dealings are substantially restricted or suspended;

(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which, in the opinion of

the Board of Directors, disposal or valuation of investments of the relevant Sub-Fund by the Company would be im-
practicable;

(c) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price

or value of any of the relevant Sub-Fund's investments or the current price or value on any market or stock exchange;

(d) if the Company is being or may be wound up or merged, from the date on which notice is given of a general meeting

of shareholders at which a resolution to wind up or merge the Company is to be proposed or if a Sub-Fund is being
liquidated or merged, from the date on which the relevant notice is given;

(e) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to a Sub-Fund cannot

promptly or accurately be ascertained or estimated (including the suspension of the calculation of the net asset value of
an underlying undertaking for collective investment or sub-fund thereof);

(f) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of any Class of Shares of a Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or
acquisition of investments or payments due on redemption of any Class of Shares cannot, in the opinion of the Board of
Directors, be effected at normal rates of exchange;

(g) when the Company has knowledge that the valuation of certain of its investments which it had previously received

and used to calculate the Net Asset Value per Share of any Class was incorrect in any material respect which, in the
opinion of the Board of Directors, justifies the recalculation of such Net Asset Value (provided, however, that in no
circumstances will the Board of Directors be bound to revise or recalculate a previously calculated Net Asset Value on
the basis of which subscriptions, switchings or redemptions may have been effected);

(h) any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Company or the shareholders

incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or other detriment which the Company or
the shareholders might not otherwise have suffered;

i) in case of a proposed or decided liquidation or merger of the Company or of a Sub-Fund, if the Board deems this

to be necessary and in the best interest of shareholders; or

(j) any other circumstances beyond the control of the Board of Directors or during any period which the Board of

Directors determines in good faith that there exist any circumstances that render impracticable or undesirable the cal-
culation of the Net Asset Value, the acceptance of subscriptions, redemptions or switches of Shares, or the payment of
the redemption price.

The Board of Directors may, in any of the cases listed above, suspend the issue and/or redemption and/or switching

of Shares without suspending the calculation of the Net Asset Value.

If required by law or otherwise determined by the Board of Directors, a notice of the beginning and of the end of any

period of suspension will be sent to the shareholders or published in a newspaper.

Such suspension as to any Sub-Fund will have no effect on the calculation of the Net Asset Value per Share, the issue,

redemption and conversion of the Shares of any other Sub-Fund.

Art. 23. Determination of Net Asset Value. The net asset value (the “Net Asset Value”) per Share shall be determined

by dividing the net assets of the Company being the value of the assets of the Company corresponding to the relevant
Sub-Fund less the liabilities attributable to such Sub-Fund, by the number of outstanding Shares of the relevant Sub-Fund
adjusted to reflect any dealing charges, dilution levies or fiscal charges which the Board of Directors feels it is appropriate
to take into account in respect of that Sub-Fund and by rounding the resulting sum as provided in the sales documents
of the Company.

The Net Asset Value per Share of a Sub-Fund is expressed in a currency selected by the Board of Directors for each

Sub-Fund.

The Net Asset Value of the Company is expressed in USD or such other currency as the Board of Directors may

determine.

A. The assets of the Company shall include without limitation
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares (including units or shares in undertakings for collective invest-

ment), stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial instru-
ments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments
in a manner not inconsistent with paragraph (a) below with regards to fluctuations in the market value of securities caused
by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);

4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions received by the Company to the extent information thereon

is reasonably available to the Company;

81705

L

U X E M B O U R G

5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of such asset;

6) the liquidation value of all forward contracts and all call or put options the Company has an open position in;
7) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,

insofar as the same have not been written off; and

8) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of the assets of the Company shall be determined as follows:
(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable (including any rebates

on fees and expenses payable by any underlying fund), prepaid expenses, cash dividends declared and interest accrued,
and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or
received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as the Board of Directors
may consider appropriate to reflect the true value thereof;

(b) the value of securities and/or financial derivative instruments which are quoted, traded or dealt in on any stock

exchange shall be based on the latest available price or, if appropriate, on the average price on the stock exchange which
is normally the principal market of such securities, and each security traded on any other regulated market shall be valued
in a manner as similar as possible to that provided for quoted securities;

(c) for non-quoted securities or securities or financial derivative instruments not traded or dealt in on any stock

exchange or other regulated market (including non-quoted securities of closed-ended underlying funds), as well as quoted
or non-quoted securities or financial derivative instruments on such other market for which no valuation price is available,
or securities for which the quoted prices are, in the opinion of the Board of Directors, not representative of the fair
market value, the value thereof shall be determined prudently and in good faith by the Board of Directors on the basis
of foreseeable sales prices;

(d) securities issued by any open-ended underlying funds shall be valued at their last available price or net asset value,

as reported or provided by the underlying funds, their investment managers or their agents;

(e) liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an

amortised cost basis; and

(f) all other securities and assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures

established by the Board of Directors.

The Board of Directors may, in its absolute discretion, use different valuation methods than those set out above. In

any case, the valuation methods will be disclosed in the Offering Document.

The value of assets denominated in a currency other than the reference currency of a Sub-Fund or Class shall be

determined by taking into account the rate of exchange prevailing at the time of the determination of the Net Asset Value.

B. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, management fees, incentive fees, custodian fees,

and corporate agents' fees);

4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;

5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from

time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board of Directors, as well as
such amount (if any) as the Board of Directors may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent
liabilities of the Company;

6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted

accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses
payable by the Company which may comprise formation and launching expenses, fees payable to its investment manager,
investment adviser (if any), fees and expenses payable to its auditors and accountants, custodian and its correspondents,
domiciliary and corporate agent, registrar and transfer agent, listing agent (if any), any paying agent, any permanent re-
presentatives in places of registration, as well as any other agent employed by the Company, the remuneration (if any)
of the directors and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, and reasonable travelling costs in
connection with board meetings, fees and expenses for legal and auditing services, distribution fees (if any), any fees and
expenses involved in registering and maintaining the registration of the Company with any governmental agencies or stock
exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses, including the
cost of preparing, printing, advertising (to the extent such advertising costs are permitted to be charged to a Sub-Fund
pursuant to applicable regulations in the jurisdictions where such Sub-Fund is distributed) and distributing prospectuses,
explanatory memoranda, periodical reports or registration statements, and the costs of any reports to shareholders, all
taxes, duties, governmental and similar charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling
assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may accrue administrative and
other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount rateably for yearly or other periods.

81706

L

U X E M B O U R G

In varying its policies in respect of each Sub-Fund, the Board of Directors may permit the application of different rules

of valuation if this appears to be appropriate in light of the investments made, provided that one set of rules shall be
applied to the valuation of all assets allocated to a specific Sub-Fund.

The proportion of the net assets allocable to a Sub-Fund shall be determined on the basis of the issue and redemption

of the Shares concerned, the change in value of the assets held on behalf of the Sub-Fund and the liabilities allocable
thereto, as well as by taking into account distributions made to holders of the Shares concerned.

For these purposes, Shares of the relevant Sub-Fund to be redeemed on the relevant Valuation Day will be included

in the Shares of the relevant Sub-Fund in issue while Shares of each Sub-Fund to be issued on the relevant Valuation Day
will be excluded from the Shares of the relevant Sub-Fund in issue.

C. The Board of Directors shall establish a portfolio of assets for each Sub-Fund, and if applicable, for each Class of in

the following manner:

(a) if a Sub-Fund issues two or more Classes of Shares, the assets attributable to such Classes shall be invested in

common pursuant to the specific investment objective, policy and restrictions of the Sub-Fund concerned;

(b) within any Sub-Fund, the Directors may determine to issue Classes subject to different terms and conditions,

including, without limitation, Classes subject to (i) a specific distribution policy entitling the holders thereof to dividends
or no distributions, (ii) specific subscription and redemption charges, (iii) a specific fee structure and/or (iv) other distinct
features;

(c) the net proceeds from the issue of Shares of a Class in relation to a specific Sub-Fund are to be applied in the books

of the Company to that Class and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto are applied
to such Class subject to the provisions set forth below;

(d) where any income or asset is derived from another asset, such income or asset is applied in the books of the

Company to the same Sub-Fund or Class as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the
increase or diminution in value is applied to the relevant Sub-Fund or Class;

(e) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or Class or to any action

taken in connection with an asset of a particular Sub-Fund or Class, such liability is allocated to the relevant Sub-Fund or
Class;

(f) if any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Sub-Fund or Class,

such asset or liability will be allocated to all the Sub-Funds or Classes pro rata to their respective Net Asset Values, or
in such other manner as the Directors, acting in good faith, may decide; and

(g) upon the payment of distributions to the holders of any Class of Shares, the Net Asset Value of such Class shall

be reduced by the amount of such distributions.

D. Each pool of assets and liabilities shall consist of a portfolio of securities and other assets in which the Company is

authorised to invest, and the entitlement of each Share Class which is issued by the Company in relation with a same
pool will change in accordance with the rules set out below.

In addition there may be held within each pool on behalf of one specific Share Class or several specific Share Classes,

assets which are class specific and kept separate from the portfolio which is common to all Share Classes related to such
pool and there may be assumed on behalf of such class or Share Classes specific liabilities.

The proportion of the portfolio which shall be common to each of the Share Classes related to a same pool which

shall be allocable to each class of shares shall be determined by taking into account issues, redemptions, distributions, as
well as payments of class specific expenses or contributions of income or realisation proceeds derived from class specific
assets, whereby the valuation rules set out below shall be applied mutatis mutandis.

The percentage of the Net Asset Value of the common portfolio of any such pool to be allocated to each class of

shares shall be determined as follows:

1) initially the percentage of the net assets of the common portfolio to be allocated to each Share Class shall be in

proportion to the respective number of the shares of each class at the time of the first issuance of shares of a new class;

2) the issue price received upon the issue of shares of a specific class shall be allocated to the common portfolio and

result in an increase of the proportion of the common portfolio attributable to the relevant Share Class;

3) if in respect of one Share Class the Company acquires specific assets or pays class specific expenses (including any

portion  of  expenses  in  excess  of  those  payable  by  other  Share  Classes)  or  makes  specific  distributions  or  pays  the
redemption price in respect of shares of a specific class, the proportion of the common portfolio attributable to such
class shall be reduced by the acquisition cost of such class specific assets, the specific expenses paid on behalf of such
class, the distributions made on the shares of such class or the redemption price paid upon redemption of shares of such
class;

4) the value of class specific assets and the amount of class specific liabilities are attributed only to the Share Class or

Classes to which such assets or liabilities relate and this shall increase or decrease the Net Asset Value per share of such
specific Share Class or Classes.

E. For the purposes of this Article and unless otherwise provided for in the Offering Document:

81707

L

U X E M B O U R G

a) shares shall only be issued once the subscription has been accepted and the payment thereof has been received and

the price therefor, until received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;

b) Shares of the Company to be redeemed under Article 21 hereof shall be treated as existing and taken into account

until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from such time and until
paid the price therefor shall be deemed to be a liability of the Company;

c) all investments, cash balances and other assets of the Company not expressed in the currency in which the Net

Asset Value of any Sub-Fund is denominated, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange
in force at the date and time for determination of the asset value of shares and

d) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company

on such Valuation Day, to the extent practicable.

If the Board of Directors so determines, the Net Asset Value of the Shares of each Sub-Fund may be converted at the

middle market rate into such other currencies than the currency of denomination of the relevant class, referred to above,
and in such case the issue and redemption price per Share of such Sub-Fund may also be determined in such currency
based upon the result of such conversion.

Art. 24. Pooling.
1. The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for each Sub-Fund

(hereafter referred to as “Participating Funds”) on a pooled basis where it is applicable with regard to their respective
investment sectors to do so. Any such enlarged asset pool (“Enlarged Asset Pool”) shall first be formed by transferring
to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter
the Board of Directors may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. It may also transfer
assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating
Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are appropriate to
the investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned.

2. A Participating Fund's participation in an Enlarged Asset Pool shall be measured by reference to notional units

(“Units”) of equal value in the Enlarged Asset Pool. On the formation of an Enlarged Asset Pool the Board of Directors
shall in its discretion determine the initial value of a Unit which shall be expressed in such currency as the Board of
Directors considers appropriate, and shall allocate to each Participating Fund Units having an aggregate value equal to the
amount of cash (or to the value of other assets) contributed. Fractions of Units, calculated to four decimal places, may
be allocated as required. Thereafter the value of a Unit shall be determined by dividing the net asset value of the Enlarged
Asset Pool (calculated as provided below) by the number of Units subsisting.

3. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Enlarged Asset Pool, the allocation of

Units  of  the  Participating  Fund  concerned  will  be  increased  or  reduced  (as  the  case  may  be)  by  a  number  of  Units
determined by dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a Unit.
Where a contribution is made in cash it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which
the Board of Directors considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be
incurred in investing the cash concerned; in the case of a cash withdrawal a corresponding addition may be made to reflect
costs which may be incurred in realising securities or other assets of the Enlarged Asset Pool.

4. The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Enlarged Asset Pool at any time and the

net asset value of the Enlarged Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of
Article 23 provided that the value of the assets referred to above shall be determined on the day of such contribution
or withdrawal.

5. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged

Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective entitlements to the
assets in the Enlarged Asset Pool at the time of receipt.

Art. 25. Issue of Shares. Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such

Shares shall be offered and sold, shall be based on the Share price for the relevant Class of the relevant Sub-Fund. The
Company may levy an initial sales charge of up to 5.5% of the Net Asset Value per Share. Such initial sales charge, if any,
shall be disclosed in the Offering Document and it shall also be disclosed therein to whom it shall be payable. The price
so determined shall be payable within a period, as determined by the Board of Directors and disclosed in the Offering
Document from time to time. The Share price (not including the sales commission) may, upon approval of the Board of
Directors, and subject to all applicable laws, namely with respect to a special audit report confirming the value of any
assets contributed in specie, be paid by contributing to the Company securities acceptable to the Board of Directors
consistent with the investment policy and investment restrictions of the Company.

Art. 26. Distributors. The Board of Directors may permit any company or other person appointed for the purpose

of distributing Shares of the Company to charge any applicant for Shares a sales commission of such amount as may be
disclosed in the Offering Document.

Art. 27. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and shall terminate

on 31 December of the same year. The accounts of the Company shall be expressed in USD or such other currency as

81708

L

U X E M B O U R G

the Board of Directors may determine. Where there shall be different Sub-Funds as provided for in Article 5 hereof, and
if the accounts within such Sub-Funds are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into USD,
or such other currency as the Board of Directors may determine, and added together for the purpose of determination
of the accounts of the Company.

Art. 28. Custodian. The Company shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the require-

ments of the Law of 2007 (the “Custodian”) and which shall assume the responsibilities provided by law in respect of the
Company and its shareholders.

In the event of the Custodian desiring to retire, the Board of Directors shall use their best endeavours to find within

two months a corporation to act as custodian and upon doing so the Board of Directors shall appoint such corporation
to be custodian in place of the retiring Custodian. The Board of Directors may terminate the appointment of the Custodian
but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with
this provision to act in the place thereof.

Art. 29. Investment Manager. The Company or its management company, if any, shall enter into an investment mana-

gement agreement with LF Finance (Suisse) S.A. or any affiliated or associated companies (the “Investment Manager”) for
the management of the assets of the Company or any Sub-Fund and assistance with respect to its portfolio selection. The
Board of Directors or its management company, if any, may authorise the Investment Manager to delegate from time to
time the power to implement the investment policy and manage the assets of the Company to any third party working
under the supervision and responsibility of the Investment Manager. In the event of termination of said agreement in any
manner  whatsoever,  the  Company  will,  if  applicable,  change  its  name  forthwith  upon  the  request  of  the  Investment
Manager to another name not resembling the one specified in Article 1 hereof.

Art. 30. Liquidation of a Sub-Fund or of the Company and Mergers. In the event of a dissolution of the Company,

liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the
meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The
net proceeds of liquidation corresponding to each Class shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares
of each Class of each Sub-Fund in proportion of their holding of Shares in such category of such Class. Any funds to which
shareholders are entitled upon the liquidation of the Company and which are not claimed by those entitled thereto prior
to the close of the liquidation process shall be deposited for the persons entitled thereto to the Caisse de Consignation
in Luxembourg in accordance with the Law of 2007.

A Sub-Fund or a Class may be terminated by resolution of the Board of Directors if the Net Asset Value of a Sub-

Fund or a Class is below such amount as determined by the Board of Directors and disclosed in the Offering Document
from time to time or in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military
emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including
conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund or a Class to operate in an economically efficient manner,
and with due regard to the best interests of shareholders, that a Sub-Fund or a Class should be terminated. In such event,
the assets of the Sub-Fund or the Class shall be realized, the liabilities discharged and the net proceeds of realization
distributed to shareholders in proportion to their holding of Shares in that Sub-Fund or Class and such other evidence
of discharge as the Board of Directors may reasonably require. This decision will be notified to shareholders as required.
No Shares shall be redeemed after the date of the decision to liquidate the Sub-Fund or a Class. Assets, which could not
be distributed to shareholders upon the close of the liquidation of the Sub-Fund concerned, will be deposited with the
custodian of the Company for a period of six months after the close of liquidation. After this time, the assets will be
deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg on behalf of their beneficiaries.

A Sub-Fund or a Class may merge with one or more other Sub-Funds or Classes by resolution of the Board of Directors

if the Net Asset Value of a Sub-Fund or a Class is below such amount as determined by the Board of Directors and
disclosed in the Offering Document from time to time or in the event of special circumstances beyond its control, such
as political, economic, or military emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market
or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund or a Class to operate in an
economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Sub-Fund or a Class
should be merged. This decision will be notified to shareholders as required. Each shareholder of the relevant Sub-Fund
or a Class shall be given the option, within a period to be determined by the Board of Directors, but not being less than
one month, and specified in said notice, to request free of any redemption charge either the repurchase of its Shares or
the  exchange  of  its  Shares  against  Shares  of  any  Sub-Fund  or  a  Class  not  concerned  by  the  merger.  Any  applicable
contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges and shall therefore be due.

A Sub-Fund may be contributed to another Luxembourg investment fund by resolution of the Board of Directors in

the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the Board
of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely
affect the ability of a Sub-Fund to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests
of shareholders, that a Sub-Fund should be contributed to another fund. This decision will be notified to shareholders as
required. Each shareholder of the relevant Sub-Fund shall be given the possibility within a period to be determined by
the Board of Directors, but not being less than one month, and specified in said notice, to request, free of any redemption
charge, the repurchase of its Shares. Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as re-

81709

L

U X E M B O U R G

demption  charges  and  shall  therefore  be  due.  At  the  close  of  such  period,  the  contribution  shall  be  binding  for  all
shareholders who did not request a redemption. In the case of a contribution to an unincorporated investment fund,
however, the contribution will be binding only on shareholders who expressly agreed to the contribution. When a Sub-
Fund is contributed to another investment fund, the valuation of the Sub-Fund's assets shall be verified by an auditor who
shall  issue  a  written  report  at  the  time  of  the  contribution.  A  Sub-Fund  may  be  contributed  to  a  non  Luxembourg
investment fund only when the relevant Sub-Fund's shareholders have unanimously approved the contribution or on the
condition that only the shareholders who have approved such contribution are effectively transferred to that foreign fund.

If the Board of Directors determines that it is in the interests of the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class

or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund or Class concerned has occurred which
would justify it, the reorganisation of one Sub-Fund or Class, by means of a division into two or more Sub-Funds or
Classes, may take place. This decision will be notified to shareholders as required. The notification will also contain
information about the two or more new Sub-Funds or Classes. The notification will be made at least one month before
the date on which the reorganization becomes effective in order to enable the shareholders to request the sale of their
Shares, free of charge, before the operation involving division into two or more Sub-Funds or Classes becomes effective.
Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges and shall therefore be
due.

Art. 31. Amendment of Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to time

by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg.

Any amendment affecting the rights of the holders of Shares of any Class or Sub-Fund vis-à-vis those of any other Class

or Sub-Fund shall be subject, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant Class or
Sub-Fund.

Art. 32. General. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with

the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the Law of 2007.

<i>Transitory provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2012.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held on 7 June 2013.

<i>Subscription and Payment

The subscriber subscribes for the number of Shares of LF Funds - LF Total Return Bond Fund and pays in cash the

amounts as mentioned hereafter:

LF Finance (Suisse) S.A., prenamed, 450 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 45,000.-

The Shares are all paid up to the extent of one hundred per cent (100 %) by payment in cash, so that the amount of

forty-five thousand U.S. Dollars (USD 45,000.-) is from now on at the free disposal of the Company, evidence of which
is given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of 10 August 1915 on commercial

companies, as amended, have been observed.

<i>Extraordinary general meeting

<i>Decisions taken by the sole shareholder

The above named party, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, immediately

proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it is regularly constituted, it passed the following resolutions.

<i>First resolution

The following persons are appointed Directors until the next annual general meeting:
a) Mr Thomas Nummer, born in Trier, Germany, on 24 April 1969 with professional address at 25 B, Boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg;

b) Mr Raphael Walid, born in Dlebta, Lebanon, on 2 October 1971, with professional address at Liberty Plaza, 5, Rome

Street, Hamra, Lebanon;

c) Mr Georges Khoury, born in Beirut, Lebanon, on 26 October 1958, with professional address at 7 

th

 Floor, Com-

merce et Finance Building, Kantari, Beirut, Lebanon.

81710

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The following is appointed auditor until the next annual general meeting:
Deloitte Audit, 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The registered office of the Company is fixed at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with the

notary the present original deed.

Signé: D. HEINEN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juin 2012. LAC/2012/28930. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 28 juin 2012

Référence de publication: 2012077943/762.
(120110427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.

NIFE Carlo Seccomandi, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 69.397.

In the year two thousand and twelve, the twenty-fifth of June.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NIFE CARLO SECCOMANDI, a société en com-

mandite simple, having its registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B. 69397, incorporated by a notarial deed on March 22, 1999, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 486 of June 25, 1999. The articles of Incorporation have
been amended at several times and for the last time by a notarial deed on May 11, 2004, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations number 738 of July 19, 2004.

The meeting was opened with Mr Giacomo DI BARI, private employee, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Christine RACOT, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Christelle HERMANT-DOMANGE, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the issuance of a certified independent auditor's report in accordance with Article 266(1) of

the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law");

2. Acknowledgement of the fulfilment of the obligations resulting from article 267 of the Law;
3. Approval of the common draft terms of merger;
4. Dissolution of the Company and cancellation of all the shares issued by the Company;
5. Full and complete discharge granted to the general partner of the Company for the performance of his mandate;
6. Keeping of the legal files;
7. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an

attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital are present or

represented at this meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the
agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda. After deliberation, the meeting adopts unanimously the following resolutions:

81711

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The general meeting acknowledges the certified independent auditor's report in accordance with Article 266(1) of the

Law, issued on 15 May 2012, by "GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.", having its registered office in 83, Pafebruch,
L-8308 Capellen, which contains the following conclusion:

<i>Conclusion:

"Based on our diligences, no fact came to our attention that makes us believe that:
- the exchange ratio determined in the merger project is not relevant and reasonable,
- the valuation methods adopted to determine the exchange ratio are not adequate and their application is not ap-

propriate to the context.

In addition, we have considered all the information included in the merger project in order to identify the significant

incoherencies with the information related to the exchange ration and the methods used to determine it. Our aim was
to report inaccurate information identified on the basis of our general knowledge of the merging companies acquired
during our mission.

In the context we have no comments on the information included in the merger project."
Such report, after signature "ne varietur" by the members of the board and the notary will remain attached to the

present deed in order to be formalised.

<i>Second resolution

The general meeting acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law have been deposited at

the registered office of the Company for inspection by the shareholders of the Company at least one month before the
date of the present general meeting.

<i>Third resolution

The general meeting having duly considered the common draft merger terms (the "Proposal") approved by the general

partner in its meeting dated February 22, 2012 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1223 on May 16, 2012, and the report of the general partner of the Corporation explaining and justifying the
Proposal prescribed by article 266 of the law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended, and concerning
the examination inter alia of the exchange ratio, its fairness and its adequacy, has resolved to approve the reverse merger.

Further to the approval of the merger by the Absorbing Company, the general meeting acknowledges the realisation

of the merger on the date of the present general meeting approving the merger, notwithstanding the provisions of article
273 of the Law.

The general meeting notes that, for accounting purposes, the operations of the Absorbed Company shall be treated

as being carried out on behalf of the Company as of January 1 

st

 , 2012.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the general meeting resolves to dissolve the Company and to cancel

all the shares issued by the Company.

<i>Fifth resolution

The general meeting further notes that the mandate of the general partner of Company will end on the effective date

of the merger.

The general meeting resolves to grant full and complete discharge to the general partner of the Company for the

execution of his mandate until the effective date of the merger.

<i>Sixth resolution

The general meeting decides that all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five

years at the registered office of the surviving company.

<i>Declaration

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and

legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the merger proposal.

There being no further business, the meeting is closed.

WHEREOF, this deed is drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

This deed having been read and translated to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder signed

together with the notary this original deed.

81712

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, Notaire de residence à SANEM, Grand Duché de Luxembourg.
S'est  tenue  l'assemblée  générale extraordinaire  des actionnaires de la société NIFE CARLO SECCOMANDI,  une

société en commandite simple, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, enregistrée au Registre
de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 69397, constituée suivant acte notarié en date du 22
mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 486 du 25 juin 1999. Les statuts ont été
modifiés à maintes reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 11 mai 2004, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 738 du 19 juillet 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Giacomo DI BARI, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Christine RACOT, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée  choisit  comme  scrutatrice  Madame  Christelle  HERMANT-DOMANGE,  employée  privée,  demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constituée, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de l'émission du rapport d'un réviseur d'entreprises indépendant, conformément à l'article 266(1) de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi");

2. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la Loi;
3. Approbation du projet commun de fusion inversée;
4. Dissolution de la société et annulation pure et simple de toutes les actions émises par la Société;
5. Pleine et entière décharge accordée au general partner de la Société pour l'exécution de son mandat;
6. Conservation des livres de la Société;
7. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires prend connaissance du rapport émis, le 15 mai 2012, par le réviseur d'entreprises

indépendant agréé «GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.», ayant son siège social au 83, Pafebruch, L-8308 Capellen,
conformément à l'article 266(1) de la Loi.

La conclusion (en version anglaise) de ce rapport est la suivante:

<i>Conclusion:

"Based on our diligences, no fact came to our attention that makes us believe that:
- the exchange ratio determined in the merger project is not relevant and reasonable,
- the valuation methods adopted to determine the exchange ratio are not adequate and their application is not ap-

propriate to the context.

In addition, we have considered all the information included in the merger project in order to identify the significant

incoherencies with the information related to the exchange ration and the methods used to determine it. Our aim was
to report inaccurate information identified on the basis of our general knowledge of the merging companies acquired
during our mission.

In the context we have no comments on the information included in the merger project."
Ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

81713

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale déclare que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été tenus à la disposition

des actionnaires de la Société, au siège social de la Société, au moins un mois avant la date de la présente assemblée.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale ayant dûment considéré le projet commun de fusion inversée (la "Proposition") approuvé par le

general partner de la Société lors de sa réunion du 22 février 2012 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1223 du 16 mai 2012, le rapport du general partner de la Société expliquant et justifiant la Propo-
sition et le rapport prévu par l'article 266 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, concernant
l'examen, entre autres, du rapport d'échange, de sa justesse et de son caractère adéquat, décide d'approuver la fusion
inversée.

Vu l'approbation de la fusion par la Société absorbante, l'assemblée générale constate la réalisation de la fusion à la

date de la tenue de la présente assemblée approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi.

L'assemblée générale constate que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme

accomplies pour le compte de la Société, à compter du 1 

er

 janvier 2012.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de dissoudre la Société et d'annuler pu-

rement et simplement toutes les actions émises par la Société.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale constate par ailleurs que le mandat du general partner de la Société prendra fin à la date à laquelle

la fusion deviendra effective.

L'assemblée générale donne pleine et entière décharge au general partner de la Société pour l'exécution de son mandat

jusqu'à la date à laquelle la fusion deviendra effective.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée légale de

cinq ans au siège social de la société absorbante.

<i>Déclaration

Le Notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi, l'existence et la légalité des

actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. DI BARI, C. RACOT, C. HERMANT-DOMANGE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 juin 2012. Relation: EAC/2012/8374. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012078039/180.
(120110385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.

PEME 09 - FTL S.C.A, SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Inves-

tissement en Capital à Risque,

(anc. PEME 09 - ITM S.C.A., SICAR).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 152.466.

Im Jahre zweitausendzwölf, am einunddreißigsten Mai.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,
sind die Aktionäre der PEME 09 - ITM S.C.A., SICAR (die "Gesellschaft") mit Sitz in 18, Boulevard de la Foire, L-1528

Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 152466, zu einer außerordentlichen
Generalversammlung (die „Außerordentliche Generalversammlung") zusammengetreten.

81714

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft wurde am 31. März 2010 gemäß notarieller Urkunde von Maître Carlo Wersandt, Notar mit dem

Amtssitz in Luxemburg, gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
vom 28. April 2010 veröffentlicht. Die Satzung wurde seitdem nicht geändert.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Francis Kass, Rechtsanwalt, ansässig in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Jennifer Burr, Rechtsanwältin, ansässig in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Anika Ratzmann, Rechtsanwältin, ansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Kenntnisnahme der Umstrukturierung des Komplementärs, „Institutional Trust Management Company S.à r.l.", von

einer Société à responsabilité limitée (S.à r.l.) in eine Société anonyme (S.A.) und Namensänderung des Komplementärs
von „Institutional Trust Management Company S.à r.l." in „Feri Trust (Luxembourg) S.A.".

2. Mit Punkt 1 einhergehende Namensänderung der Gesellschaft von „PEME 09 - ITM S.C.A., SICAR" in „PEME 09 -

FTL S.C.A., SICAR".

3. Als Folge der vorhergehenden Punkte, Änderung der folgenden Artikel der Satzung:
- Artikel 1 Absatz 1 (Name): Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft.
- Artikel 5 Absatz 1 (Haftung): Änderung der Bezeichnung des Komplementärs.
- Artikel 15 Absatz 1 und 2 (Komplementär): Änderung der Bezeichnung des Komplementärs.
II. Gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915") ist

die Außerordentliche Generalversammlung nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten ist. Ferner sind nach dieser Vorschrift Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der Stimmen
der anwesenden oder vertretenen Aktionäre zu fassen.

III. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien

gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertre-
tern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten
Vertretern und dem amtierenden Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigefügt,
um mit ihr zusammen registriert zu werden.

IV. Da ausschließlich Namensaktien im Umlauf sind, erfolgte die Einberufung zu dieser Außerordentlichen General-

versammlung am 24. April 2012 per Einschreiben an alle Aktionäre.

V. Aus der Anwesenheitsliste und dem Auszug aus dem Aktionärsregister geht hervor, dass von den 44.222,181 Aktien,

die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, 41.222,181 Aktien in dieser Außerordentlichen Generalver-
sammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.

VI. Demnach wurde das für eine Satzungsänderung gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes von 1915 gesetzlich vorges-

chriebene Anwesenheitsquorum von 50% des Gesellschaftskapitals erreicht, die Außerordentliche Generalversammlung
der Gesellschaft ist daher beschlussfähig und kann über die vorhandene Tagesordnung beraten und beschließen.

Nach Beratung fasst die Außerordentliche Generalversammlung folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung nimmt die Umstrukturierung des Komplementärs der Gesellschaft „Ins-

titutional Trust Management Company S.à r.l." von einer Société à responsabilité limitée (S.à r.l.) in eine Société anonyme
(S.A.) und die Namensänderung des Komplementärs von „Institutional Trust Management Company S.à r.l." in „Feri Trust
(Luxembourg) S.A." zur Kenntnis.

<i>Zweiter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, als Folge des vorhergehenden Beschlusses, den Namen der

Gesellschaft von „PEME 09 - ITM S.C.A., SICAR" in „PEME 09 - FTL S.C.A., SICAR" zu ändern.

<i>Dritter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, als Folge der vorhergehenden Beschlüsse, Artikel 1 Absatz 1,

Artikel 5 Absatz 1 sowie Artikel 15 Absatz 1 und 2 der Satzung zu ändern. Die zuvor genannten neugefassten Artikel der
Satzung lauten wie folgt:

Art. 1. (Absatz 1). Name. Hiermit wird zwischen vorbenannten Parteien und denjenigen, die in Zukunft Inhaber aus-

zugebender Aktien (die „Aktien") werden, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in der Form einer Investment-
gesellschaft zur Anlage in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque, SICAR) unter dem Namen PEME 09
- FTL S.C.A., SICAR (die „Gesellschaft") gegründet.

Art. 5. (Absatz 1). Haftung. Die Feri Trust (Luxembourg) S.A. ist Komplementär der Gesellschaft (der „Komplemen-

tär"). Als solches ist er Geschäftsführer (gérant) und Aktionär der Gesellschaft. Er hält eine Aktie - die „Komplementär-

81715

L

U X E M B O U R G

saktie" -, die nicht übertragbar ist und weder zu Dividendenzahlungen noch zu Kapitalrückführungen berechtigt. Der
Komplementär haftet persönlich und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht aus deren Ver-
mögen bezahlt werden können.

Art. 15. (Absatz 1 und 2). Komplementär. Die Gesellschaft wird von der Feri Trust (Luxembourg) S.A. als Komple-

mentär geführt.

Der Komplementär ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach Luxemburger Recht. Der Komplementär besitzt

die umfassende Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, soweit das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Gesellschaft
nicht ausdrücklich bestimmte Befugnisse der Hauptversammlung vorbehält.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. KASS, J. BURR, A. RATZMANN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juin 2012. Relation: LAC/2012/25801. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 25. Juni 2012.

Référence de publication: 2012075117/85.
(120106398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2012.

Microcap 08/09 - FTL S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque,

(anc. Microcap 08/09 - ITM S.C.A., SICAR).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 139.630.

Im Jahre zweitausendzwölf, am einunddreißigsten Mai.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,
sind die Aktionäre der Microcap 08/09 – ITM S.C.A., SICAR (die "Gesellschaft") mit Sitz in 18, Boulevard de la Foire,

L-1528 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 139630, zu einer außeror-
dentlichen Generalversammlung (die „Außerordentliche Generalversammlung") zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde am 18. Juni 2008 gemäß notarieller Urkunde von dem Notar Maître Henri Hellinckx, mit dem

Amtssitz in Luxemburg, gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
vom 30. Juli 2008 veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt am 28. Dezember 2010, in der berichtigten Fassung vom 11.
Mai 2011, geändert und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 6. Juni 2011 veröffentlicht.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Francis Kass, Rechtsanwalt, ansässig in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Jennifer Burr, Rechtsanwältin, ansässig in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Anika Ratzmann, Rechtsanwältin, ansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Kenntnisnahme der Umstrukturierung des Komplementärs, „Institutional Trust Management Company S.à r.l.", von

einer Société à responsabilité limitée (S.à r.l.) in eine Société anonyme (S.A.) und Namensänderung des Komplementärs
von „Institutional Trust Management Company S.à r.l." in „Feri Trust (Luxembourg) S.A.".

2. Mit Punkt 1 einhergehende Namensänderung der Gesellschaft von „Microcap 08/09 – ITM S.C.A., SICAR" in „Mi-

crocap 08/09 – FTL S.C.A., SICAR".

3. Als Folge der vorhergehenden Punkte, Änderung der folgenden Artikel der Satzung:
- Artikel 1 Absatz 1 (Name): Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft.
- Artikel 5 Absatz 1 (Haftung): Änderung der Bezeichnung des Komplementärs.
- Artikel 16 Absatz 1 und 2 (Komplementär): Änderung der Bezeichnung des Komplementärs.
II. Gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915") ist

die Außerordentliche Generalversammlung nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten ist. Ferner sind nach dieser Vorschrift Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der Stimmen
der anwesenden oder vertretenen Aktionäre zu fassen.

81716

L

U X E M B O U R G

III. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien

gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertre-
tern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten
Vertretern und dem amtierenden Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigefügt,
um mit ihr zusammen registriert zu werden.

IV. Da ausschließlich Namensaktien im Umlauf sind, erfolgte die Einberufung zu dieser Außerordentlichen General-

versammlung am 24. April 2012 per Einschreiben an alle Aktionäre.

V. Aus der Anwesenheitsliste und dem Auszug aus dem Aktionärsregister geht hervor, dass von den 26.781 Aktien,

die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, 22.381 Aktien in dieser Außerordentlichen Generalversammlung
anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.

VI. Demnach wurde das für eine Satzungsänderung gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes von 1915 gesetzlich vorges-

chriebene Anwesenheitsquorum von 50% des Gesellschaftskapitals erreicht, die Außerordentliche Generalversammlung
der Gesellschaft ist daher beschlussfähig und kann über die vorhandene Tagesordnung beraten und beschließen.

Nach Beratung fasst die Außerordentliche Generalversammlung folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung nimmt die Umstrukturierung des Komplementärs der Gesellschaft „Ins-

titutional Trust Management Company S.à r.l." von einer Société à responsabilité limitée (S.à r.l.) in eine Société anonyme
(S.A.) und die Namensänderung des Komplementärs von „Institutional Trust Management Company S.à r.l." in „Feri Trust
(Luxembourg) S.A." zur Kenntnis.

<i>Zweiter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, als Folge des vorhergehenden Beschlusses, den Namen der

Gesellschaft von „Microcap 08/09 – ITM S.C.A., SICAR" in „Microcap 08/09 – FTL S.C.A., SICAR" zu ändern.

<i>Dritter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, als Folge der vorhergehenden Beschlüsse, Artikel 1 Absatz 1,

Artikel 5 Absatz 1 sowie Artikel 16 Absatz 1 und 2 der Satzung zu ändern. Die zuvor genannten neugefassten Artikel der
Satzung lauten wie folgt:

Art. 1. (Absatz 1) - Name. Hiermit wird zwischen vorbenannten Parteien und denjenigen, die in Zukunft Inhaber

auszugebender Aktien (die „Aktien") werden, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in der Form einer Invest-
mentgesellschaft  zur  Anlage  in  Risikokapital  (société  d'investissement  en  capital  à  risque,  SICAR)  unter  dem  Namen
Microcap 08/09 - FTL S.C.A., SICAR (die „Gesellschaft") gegründet.

Art. 5. (Absatz 1) – Haftung. Die Feri Trust (Luxembourg) S.A. ist Komplementär der Gesellschaft (der „Komple-

mentär"). Als solches ist er Geschäftsführer (gérant) und Aktionär der Gesellschaft. Er hält eine Aktie - die „Komple-
mentärsaktie" -, die nicht übertragbar ist und weder zu Dividendenzahlungen noch zu Kapitalrückführungen berechtigt.
Der Komplementär haftet persönlich und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht aus deren
Vermögen bezahlt werden können.

Art. 16. (Absatz 1 und 2) - Komplementär. Die Gesellschaft wird von der Feri Trust (Luxembourg) S.A. als Komple-

mentär geführt.

Der Komplementär ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach Luxemburger Recht. Der Komplementär besitzt

die umfassende Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, soweit das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Gesellschaft
nicht ausdrücklich bestimmte Befugnisse der Hauptversammlung vorbehält.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. KASS, J. BURR, A. RATZMANN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juin 2012. Relation: LAC/2012/25798. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 25. Juni 2012.

Référence de publication: 2012075050/86.
(120105798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2012.

81717

L

U X E M B O U R G

Café Belle époque S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 40.239.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 6 juin 2002, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, a prononcé la dissolution de la société à responsabilité limitée CAFE BELLE EPOQUE S.à r.l., ayant eu son
siège social à L-3514 DUDELANGE, 9, route de Kayl, inscrite au registre des sociétés sous le numéro B 40.239 et en a
ordonné la liquidation.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge au tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg et liquidateur Maître Lise REIBEL, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créances sont à déposer au greffe du tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale avant le 21 juin 2002.

Pour extrait conforme
Maître Lise REIBEL
54, rue Charles MARTEL
B.P. 2503
L-1035 Luxembourg
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2012069332/21.
(120098870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

Imperiale Lounge Bar, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5555 Remich, 1, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 169.341.

STATUTS

L'an deux mille douze, le cinq juin;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Filipe DA SILVA MONTEIRO, gérant de société, né à Luxembourg, le 26 octobre 1981, demeurant à

L-5536 Remich, 9bis Hierzebierg; et

2) Madame Rita MENELLI, gérant de société, née à Differdange, le 3 novembre 1954, demeurant à L-5536 Remich,

9bis Hierzebierg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "IMPERIALE LOUNGE BAR", (ci-après la "Socié-
té"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement
par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 2. La Société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, y compris la petite

restauration avec l’achat et la vente des articles de la branche.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision de la gérance.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés

délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs

aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

81718

L

U X E M B O U R G

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'/aux associé(s) en proportion avec sa/leur participation dans le capital

de la Société.

La gérance est autorisée à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions

suivantes:

1. la gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution

des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

81719

L

U X E M B O U R G

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Filipe DA SILVA MONTEIRO, préqualifié, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Madame Rita MINELLI, préqualifiée, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Loi anti-blanchiment

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les

bénéficiaires réels de la Société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas, respectivement que la Société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-5555 Remich, 1, Place du Marché.
2. Sont nommés aux fonctions de gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Filipe DA SILVA MONTEIRO, gérant de société, né à Luxembourg, le 26 octobre 1981, demeurant à L-5536

Remich, 9bis Hierzebierg, gérant technique; et

- 2) Madame Rita MENELLI, gérant de société, née à Differdange, le 3
novembre 1954, demeurant à L-5536 Remich, 9bis Hierzebierg, gérante administrative.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant

technique ou par la signature conjointe de la gérante administrative et du gérant technique.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. DA SILVA MONTEIRO, R. MENELLI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juin 2012. LAC/2012/26177. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 13 juin 2012.

Référence de publication: 2012068843/137.
(120098445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

81720

L

U X E M B O U R G

Hereford Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.375.

<i>Extract of the minutes of the meeting of the board of directors of the Company held at the registered office of the Company in

<i>Luxembourg on 16 May 2012:

The Board of Directors formally takes note of the resignation of Mr Rolf Diderrich as from May 16,2012 and agrees

on the cooptation of Mr Enrico Mela, residing professionally at 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg as new
member of the Board as of May 16,2012 in replacement of Mr Rolf Diderrich.

Certified true extract
Romain Moebus / Yves de Vos
<i>Directors

French translation - Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société qui s'est tenue en date du 16 mai 2012 au siège

<i>de la Société à Luxembourg.

Le conseil d'administration prend formellement note de la démission de Monsieur Rolf Diderrich au 16 mai 2012 et

décide de coopter Monsieur Enrico Mela, de résidence professionnelle à 26, avenue de la Liberté, L -1930 Luxembourg
comme nouveau membre du conseil d'administration à partir du 16 mai 2012 en remplacement de Monsieur Rolf Di-
derrich.

Extrait certifié conforme
Romain Moebus / Yves de Vos
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2012069500/25.
(120098619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 160.383.

Les Comptes Annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2012.

Référence de publication: 2012068931/10.
(120098734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

E.P.F. European Property Foundation S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 73.064.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2012.

E.P.F. EUROPEAN PROPERTY FOUNDATION S.à r.l.
Représenté par M. Matthijs BOGERS
<i>Gérant

Référence de publication: 2012069384/14.
(120098970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

Majerus-Parmentier Constructions Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 36, Wämperweeg.

R.C.S. Luxembourg B 150.200.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

81721

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012068932/10.
(120097902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Nowa Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 67.960.

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale de l’actionnaire unique en date du 12 juin 2012

1. Mme Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat de gérante.
2. Mme Nancy BLEUMER a démissionné de son mandat de gérante.
3. Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 10 novembre 1975, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée gérante pour une
durée indéterminée.

4. M. Vincent REGNAULT, administrateur de sociétés, né à Anderlecht (Belgique), le 4 septembre 1982, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant pour une
durée indéterminée.

Luxembourg, le 13.6.2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour NOWA HOLDING SARL
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012068958/20.
(120097751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Lunon A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.692.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendzwölf, am fünften Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Carlo WERSANDT, mit Amtssitz zu Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUNON

A.G., in Liquidation, mit Sitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle, gegründet laut notarieller Urkunde vom
5. Dezember 2007 des Notars Jean SECKLER, mit Amtssitz zu Luxemburg, veröffentlicht im „Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations" Nummer 181 vom 23. Januar 2008, eingetragen im Handels - und Gesellschaftsregister von
Luxemburg unter Sektion B und Nummer 134692.

Laut Urkunde des amtierenden Notars vom 30. November 2011 veröffentlicht im „Memorial C, Recueil des Sociétés

et Associations" Nummer 43 vom 6. Januar 2012, wurde die Gesellschaft in Liquidation gesetzt.

Gemäss Urkunde unter Privatschrift vom 8. Mai 2012 wurde CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à r.l. zum Prüfungs-

kommissar ernannt.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Philippe PONSARD, „ingénieur commercial", mit

beruflicher Anschrift in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Der Vorsitzende bestellt zur Schriftführerin Frau Carine GRUNDHEBER, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in

L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Die Versammlung ernennt zur Stirnmzählerin Frau Audrey LEITIENNE, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in

L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:
1. Vorlage des Berichtes des Prüfungskommissars.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder, des Aufsichtskommissars, des Liquidators und

des Prüfungskommissars.

3. Feststellung der Liquidation.
4. Beschlussfassung über den Aufbewahrungsort der Gesellschaftsakten.
5.  Ernennung  eines  Bevollmächtigten  für  die  endgültige  Abwicklung  der  Gesellschaftskonten  und  für  die  Erfüllung

sämtlicher Formalitäten.

81722

L

U X E M B O U R G

II. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Aktionäre und prüft die

unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

III. Dass gemäß vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschließen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsi-

tzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Bericht des Prüfungskommissars und die Liquidationsbilanz anzu-

nehmen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Verwaltungsratsmitgliedern, dem Aufsichtskommissar, dem Liquidator und

dem Prüfungskommissar volle und uneingeschränkte Entlastung für ihre Tätigkeit zu erteilen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Liquidation abgeschlossen ist und dass die Gesellschaft nicht mehr besteht.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, dass die Gesellschaftsakten während fünf Jahren am Sitz der CF Corporate Ser-

vices hinterlegt und aufbewahrt werden.

<i>Fünfter Beschluss

Die  Generalversammlung  ernennt  CF  Corporate  Services  als  Bevollmächtigten  für  die  endgültige  Abwicklung  der

Gesellschaftskonten und für die Erfüllung sämtlicher Formalitäten.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesell-

schaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro (1.000,- €).

WORUEBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: P. PONSARD, C. GRUNDHEBER, A. LEITIENNE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juin 2012. LAC/2012/26171. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 13 juin 2012.

Référence de publication: 2012068911/69.
(120098289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Meco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 134.048.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Gérant Unique tenue au siège social en date du 1 

er

 juin 2012 que le siège social de la société

a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2012.

Référence de publication: 2012068935/12.
(120098515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

81723

L

U X E M B O U R G

MGG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2312 Luxembourg, 2A, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 157.754.

Le siège social de MGG S.à.r.l. est transmis au 2A, rue de la Paix, L-2312 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2012.

Fiduciaire comptable B+C S.à.r.l.

Référence de publication: 2012068940/11.
(120097637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Baden Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 143.577.

Lors de l’Assemblée Extraordinaire des actionnaires tenue le 14 juin 2012, il a été résolu ce qui suit:
- D’approuver la démission de Melle. Åsa Åhlund comme administrateur au conseil d’administration de la société;
- D’élire Melle. Elin Sjöling, demeurant professionnellement au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg comme

administrateur au conseil d’administration de la société.

At the Extraordinary General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on June 14 

th

 ,

2012, it has been resolved the following:

- To relieve Ms. Åsa Åhlund as a director of the board for the company;
- To elect Ms. Elin Sjöling, residing professionally at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg as a new director

of the board for the company.

Référence de publication: 2012069270/16.
(120098572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

NS Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 80.367.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 11 juin 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs,
- Monsieur Théo LIMPACH, Administrateur, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur, 30, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Marc MAISONNEUVE, Administrateur-Président, 98, rue Saint-Jean, CH-1211 Genève, Suisse.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 11 juin 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, cabinet de révision agréé, 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2,

L-5365 Munsbach, R.C.S. Luxembourg B47771,

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 11 juin 2012.

<i>Pour NS Luxembourg S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2012068959/20.
(120098167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

New La Rosière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3396 Roeser, 10, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 105.519.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

81724

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2012068950/10.
(120098555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Medic Participations S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 141.369.

DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le cinq juin.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à L-1446 Luxembourg, 12, Jean Engling, (le

"mandataire"), agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société Wesholding S.à r.l., ayant son siège social à Suite
13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, République des Seychelles, (le "mandant"),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signé signée ne varietur par le man-

dataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme MEDIC PARTICIPATIONS S.A. (la "Société"), ayant son siège social à L-1260 Luxembourg,

5, Rue de Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 141.369,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), le 18
juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2322 du 23 septembre 2008 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, le 3 septembre
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2322 du 23 septembre 2008;

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 31.000,-(TRENTE ET UN MILLE EUROS), représenté

par 310 (TROIS CENT DIX) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (CENT EURO) chacune;

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite Société;
IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société;

V.- Que le mandant, en sa qualité de liquidateur de la susdite Société, déclare que les dettes connues ont été payées

et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la Société
dissoute et que la liquidation de la Société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les
engagements sociaux;

VI.- Qu'il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société

dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la Société

dissoute.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, ès-qualités qu'elle agit, connue du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juin 2012. LAC/2012/26178. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 13 juin 2012.

Référence de publication: 2012068936/47.
(120098344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

81725

L

U X E M B O U R G

Mit Holding S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 113.998.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1 

er

 juin 2012 que le siège social

de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2012.

Référence de publication: 2012068943/12.
(120097951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Black Tie Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 157.838.

In the year two thousand and twelve on the fifth day of June.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Black Tie Luxco S. à r .l.", a "société à responsabilité

limitée", having its registered office at L-2086 Luxembourg, 412 F route d’Esch incorporated by deed enacted on 28
December 2010, published in the Memorial C number 329 on the 18 February 2011, inscribed at trade register Luxem-
bourg section B number 157838.

The meeting is presided by Flora Gibert, notary’s clerk, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms Nathalie Clercx, with professional address

in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As results from the attendance list, the 20,000,000 (twenty million) shares, representing the whole capital of the

company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Change of the end of business year to July 31 

st

 and subsequent amendment of article 14 of the articles of association

of the Company which shall henceforth read as follows:

“ Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on August first of each year and ends on thirty first July

of the following year.”

2. Determination of the end of the current business year on July 31 

st

 , 2012.

3. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders resolves to change the financial year, which shall from now on begin on the

first day of August and end on the thirty-first day of July of the following year.

The general meeting of the shareholders decides to amend article fourteen of the articles of association of the Company

which shall henceforth read as follows:

“ Art. 14. Financial Year. The Company's financial year begins on August first and ends on July thirty-first of the following

year.”

<i>Second resolution

The general meeting of partners decides that the current financial year, which has begun on the first day of January

2012, will end on the thirty-first day of July 2012.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

81726

L

U X E M B O U R G

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français:

L'an deux mille douze, le cinq juin.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Black Tie Luxco S.

àr .l.", ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412 F, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 157838, constituée suivant acte reçu le 28 décembre 2010, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C numéro 329 du 18 février 2011.

L'assemblée est présidée par Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mme Nathalie Clercx, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il résulte de la liste de présence que les 20.000.000 (vingt millions) de parts, représentant l'intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'exercice social et modification subséquente de l'article 14 des statuts de la Société, lequel se lira

dorénavant comme suit:

« Art. 14. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier août de chaque année et se terminera

le trente et un juillet de l'année suivante.»

2. Fixation de la fin de l'exercice social en cours au 31 juillet 2012.
3. Divers.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'exercice social qui débutera désormais le premier août de

chaque année et se terminera le trente et un juillet de l'année suivante.

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'article quatorze des statuts, lequel aura dorénavant la teneur

suivante:

« Art. 14. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier août de chaque année et se terminera

le trente et un juillet de l'année suivante.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés décide que l'exercice social en cours, qui a débuté le premier janvier 2012, se

terminera le trente et un juillet 2012.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, le mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. GIBERT, N. CLERCX, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juin 2012. Relation: LAC/2012/26162. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

81727

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, 14 juin 2012.

Référence de publication: 2012069277/96.
(120098898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

ML Ray Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 105.567.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2012.

Référence de publication: 2012068944/11.
(120098389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Motor Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 70.108.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1 

er

 juin 2012 que le siège social

de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2012.

Référence de publication: 2012068946/12.
(120098273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

MOTO24H S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 143.971.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13/06/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2012068947/12.
(120098110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Pan European Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 38.052.

La liste des Fondés de pouvoir A et B a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012068977/12.
(120098538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

81728

L

U X E M B O U R G

Structor, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 143.045.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 21 mars 2012

1. Le siège social de la société a été transféré au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 avril 2012.

2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1 

er

 avril 2012.

3. A été nommé administrateur, avec effet au 1 

er

 avril 2012:

Monsieur Philippe GILAIN, né le 14.05.1967 à Dinant, Belgique, demeurant professionnellement au 4, rue Peternelchen,

L-2370 Howald.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.
4. L'adresse professionnelle de Monsieur Eric LECLERC et Monsieur Christophe JASICA, administrateurs, a été trans-

férée au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.

<i>Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2012069074/18.
(120097729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Panev S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 41.036.

La liste des Fondés de pouvoir A et B a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012068978/12.
(120098537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Rafferty 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.553.

Par résolutions de l’associé unique prises en date du 7 juin 2012, les décisions suivantes ont été prises:
Acceptation de la démission de Monsieur Israel Domingo Basilio, avec adresse professionnelle au 1, Allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, de son mandat de gérant de la société avec effet au 30 avril 2012.

Nomination de Madame Polyxeni Kotoula, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg, en tant que gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Il a également été décidé de transférer le siège social de la société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet immédiat.

De plus, l’adresse professionnelle du gérant suivant a changé et se trouve à présent au:
Monsieur Jorge Pérez Lozano, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2012.

<i>Pour la société
TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2012069013/22.
(120098282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

81729

L

U X E M B O U R G

Prologis Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 124.622.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2012.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012068999/12.
(120098200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Promotions Schmit &amp; Klein S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 28.185.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012069000/12.
(120098261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Prorech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 102, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 90.249.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le gérant

Référence de publication: 2012069001/10.
(120098486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Triton III No. 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 143.937.

Le siège social de
1. Triton Fund III L.P.
2. Triton Fund III G L.P.
3. Triton Fund III Executives L.P.
4. Triton Fund III No. 2 L.P.
5. Triton Fund III F&amp;F No. 2 L.P.
6. Triton Fund III F&amp;F No. 3 L.P.
7. Triton Fund III F&amp;F No. 4 L.P.
8. Triton Fund III F&amp;F G L.P.
a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.

<i>Pour Triton III No. 11 S.à r.l.
Un Mandataire

Référence de publication: 2012069105/20.
(120097921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

81730

L

U X E M B O U R G

Taranis International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 45.277.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 mai 2012

<i>Résolution:

L'assemblée prend acte de et accepte la démission de Monsieur Giorgio Bianchi, employé privé, demeurant profes-

sionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg de sa fonction d'administrateur.

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Gregorio PUPINO, employé privé, demeu-

rant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Son mandat ayant comme échéance l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2012069127/20.
(120098341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

DenTheater.lu, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2426 Luxembourg, 9, rue Marcel Reuland.

R.C.S. Luxembourg F 9.183.

STATUTS

Les soussignés ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif (a.s.b.1.) régie par la loi modifiée du

21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et les statuts ci-après

Constitution - Dénomination - Siège - Objet

Art.  1 

er

  .    Il  est  créé,  conformément  à  la  loi  du  21  avril  1928,  une  association  sans  but  lucratif,  dénommée:

"DenTheater.lu".

Art. 1 

er

 a.  Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Art. 1 

er

 b.  L'association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. L'association a pour objet de promouvoir le théâtre dans toutes ses formes.
Sur le plan politique et confessionnel, l'association observera une stricte neutralité.
A ces fins, l'association pourra posséder divers équipements, exploiter tous les services à but culturel, passer toutes

conventions utiles avec les pouvoirs publics ou les particuliers, et participer à toutes associations ayant un objet compatible
avec le sien.

Art. 3. L'association est composée de personnes physiques ou morales à savoir:
- membres fondateurs qui ont assisté à l'assemblée générale constitutive.
- membres actifs qui s'acquittent de la cotisation annuelle et qui collaborent directement à la réalisation de l'objet

social de l'association.

- membres donateurs: ce titre est décerné aux personnes ou collectivités qui payent leur cotisation ou qui rendent

des services à l'association.

- membres d'honneur: ce titre est décerné par l'assemblée générale ordinaire, sur proposition du comité, aux per-

sonnes ou aux collectivités de renom qui approuvent et soutiennent les tâches entreprises par l'association.

Il est tenu, au siège de la société, un registre contenant l'identité et la qualité des membres de chaque catégorie, avec

l'indication de la date d'admission et, éventuellement, de leur démission, décès ou exclusion.

Art. 4. Le montant et les modalités de versement des cotisations sont fixés annuellement par l'assemblée générale, sur

proposition du comité. Le comité fixera la cotisation à payer par les membres actifs et donateurs, le montant de cette
cotisation ne pouvant pas être inférieur à 10 euros.

81731

L

U X E M B O U R G

Art. 5. La qualité de membre se perd:
a) par décès;
b) par démission écrite de l'intéressé et envoyée au président du comité;
c) par défaut de paiement des cotisations dues, constaté par l'assemblée générale;
d) par radiation prononcée par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers, pour refus d'observer les prescriptions

dés statuts ou des règlements intérieurs ou pour tout autre motif grave, propre à l'associé ou à la personne morale qui
l'a délégué. Tout membre exposé à la radiation est admis à présenter ses explications oralement ou par écrit au comité
avant décision de l'assemblée générale.

Assemblée générale

Art. 6. L'assemblée générale est composée de tous les membres. Elle se réunit au moins une fois par an, eh session

ordinaire, et en session extraordinaire sur convocation du comité ou sur demande du cinquième au moins de ses membres.
Seuls les membres actifs et fondateurs ont un droit de vote.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres fondateurs

et actifs sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée à nouveau et à huit jours d'intervalle.

Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres fondateurs et actifs présents ou représentés.

Chaque membre fondateur et actif ne dispose que d'une seule voix.
Tout  membre fondateur et actif  empêché peut se  faire représenter à l'assemblée générale par un autre  membre

fondateur ou actif, mais chaque membre ne peut détenir qu'une seule procuration. Les membres donateurs et d'honneur
n'ont que voix consultative.

Il est dressé procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire et les membres

qui le désirent. Des extraits en sont délivrés par le secrétaire aux membres, à leur demande, et à toute personne justifiant
d'un intérêt légitime.

L'assemblée générale désigne les réviseurs de caisse qui vérifient les comptes de l'exercice, clos et le projet de budget

de l'exercice suivant, établis par le comité, et font connaître leurs conclusions à l'assemblée générale.

Les statuts ne peuvent être modifiés que par un vote de l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers des membres

fondateurs et actifs présents où représentés et pour autant que les deux tiers des membres fondateurs et actifs soient
présents ou représentés.

A défaut, une nouvelle assemblée pourra être convoquée, à laquelle les membres fondateurs et actifs pourront déli-

bérer, quel que soit le nombre des membres fondateurs et actifs présents ou représentés, à la majorité des deux tiers
des membres fondateurs et actifs présents ou représentés.

Administration - Comité

Art. 7. L'association est administrée par un comité qui doit rendre compte à l'assemblée générale une fois par an.

Art. 8. Le comité se réunit au moins une fois tous les trois mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président

ou sur la demande d'un tiers de ses membres fondateurs et actifs.

Il est composé de personnes élues par l'assemblée générale.
Un tiers du comité est renouvelable tous les ans, suivant un ordre, déterminé, les deux premières fois par tirage au

sort, et ensuite par ordre d'ancienneté.

Les membres sortants sont rééligibles.
Le mandat prend fin par expiration du terme, décès, démission ou révocation par l'assemblée générale.
En cas de décès, de révocation ou de démission d'un membre du comité, la prochaine assemblée générale aura pour

mission de pourvoir à son remplacement.

Il peut être pourvu à son remplacement jusqu'à l'assemblée générale la plus proche par cooptation d'une personne

désignée par le comité.

L'ordre du jour des séances est établi par le secrétaire, suivant l'accord du président. Il comporte obligatoirement les

sujets dont la discussion est demandée par un des membres du comité.

Art. 9. La présence de la moitié des membres du comité est nécessaire pour la validité des délibérations.
Celles-ci sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Chaque membre ne dispose que d'une seule voix. Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre

membre du comité, mais chaque membre présent ne peut détenir qu'une seule procuration.

La voix du président est prépondérante en cas de partage. Selon les besoins et à titre consultatif, le président ou son

remplaçant peut convoquer aux réunions du comité toute personne étrangère au comité dont la présence lui paraîtrait
utile ou opportune.

Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Des extraits

peuvent en être délivrés à toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

81732

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Le comité, lors de sa constitution ou de son renouvellement choisit parmi les membres fondateurs et actifs,

au scrutin secret.

a) un président
b) un ou plusieurs vice-président(s)
c) un secrétaire
d) un trésorier
e) un directeur artistique

Art. 11. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration intéressant l'association.
Tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale est de la compétence du comité.

Art. 12. Sauf délégation spéciale émanant du comité, les actes qui engagent l'association sont signés par le président

ou, à son défaut, par un membre du comité délégué à cette fin, et par le secrétaire.

Les actions judiciaires sont suivies, au nom du comité, par le président ou un autre membre du comité délégué à cet

effet.

Art. 13. Les membres de l'association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont

confiées par les présents statuts.

Le patrimoine de l'association répond seul des engagements contractés en son nom et aucun membre ne peut, en

aucun cas, en être rendu responsable.

Comptes sociaux

Art. 14. L'exercice social de l'association commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre, sauf le premier

exercice qui commence le 19 mars 2006 et se termine le 31 décembre 2006.

Les recettes de l'association se composent de:
1. Recettes annuelles ordinaires comprenant:
a) les cotisations et dons de ses membres
b) les subventions du Ministère de la Culture, des communes ou d'autres établissements publics
c) les ressources résultant de l'exercice de ses activités
2. Les dépenses de l'association comprennent:
a) les dépenses de fonctionnement:. -
sont celles nécessitées, par le fonctionnement administratif de l'association, dont une quote-part pour l'amortissement

du matériel faisant partie du patrimoine de l'association.

b) les dépenses de production:
sont celles résultant de l'exercice de ses activités, en conformité avec son objet social.

Dissolution

Art. 15. La dissolution de l'association ne peut intervenir que par décision de l'assemblée générale comprenant les

deux tiers des membres fondateurs et actifs présents ou représentés et après un vote à la majorité des deux tiers des
membres fondateurs et actifs présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée à nouveau et à huit jours d'intervalle. Elle délibère

alors valablement, quel que soit le nombre des membres fondateurs et actifs présents ou représentés, mais, dans ce cas,
sa décision devra être soumise à l'homologation du tribunal civil.

Art. 16. En cas de dissolution de l'association, l'actif subsistant, après extinction du passif, sera versé au profit d'un

organisme poursuivant un objet social similaire.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2006.

Renée OTT-REUTER / Danielle REUTER / Martine TUREGARD-HAMILIUS / Danielle WENNER / Pierre BODRY /
Claude FRITZ / Marcel HAMILIUS / Patrick KAYSER / Georges NEUEN
<i>Membres fondateurs

Référence de publication: 2012069181/134.
(120097501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.

81733

L

U X E M B O U R G

Automat' Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 19, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 25.598.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue à Leudelange le 28 mars 2012

L'Assemblée générale renouvelle les mandats de gérance de:
- Monsieur Mark WHITE
- Monsieur Jean-Marc DEMERDJIAN
- Monsieur Philippe OP DE BEECK
- Monsieur Jérôme CORAIL
Tous avec la même adresse professionnelle au 19, rue Léon Laval à L-3372 Leudelange.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
L'assemblée générale nomme à la fonction de réviseur d'entreprises la société DELOITTE AUDIT s.à.r.l avec siège à

Luxembourg pour la durée d'un an

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Automat'Services s.à.r.l.

Référence de publication: 2012069185/20.
(120098685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Prorech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 102, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 90.249.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le gérant

Référence de publication: 2012069002/10.
(120098487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Q Build, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.360.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012069004/9.
(120098608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Quadro Capital Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 115.813.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012069005/9.
(120098433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

MEIF4 Luxembourg B Holdings S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 166.170.

Par résolutions signées en date du 5 juin 2012, l’associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:
1. changement de classe de mandat de Mme Rosa VILLALOBOS de «gérant de classe A» à «gérant» de la Société;

81734

L

U X E M B O U R G

2. changement de classe de mandat de M. Philip HOGAN de «gérant de classe B» à «gérant» de la Société;
3. changement de classe de mandat de M. Hilko SCHOMERUS de «gérant de classe B» à «gérant» de la Société;
5. nomination de M. Charles ROEMERS, né le 15 mars 1965 à Moresnet (Belgique), ayant son adresse professionnelle

au 37, Rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée
illimitée;

6. nomination de M. Jean-François TRAPP, né le 15 juillet 1975 à Thionville (France), ayant son adresse professionnelle

au 37, Rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée
illimitée.

Dès lors, le conseil de gérance se compose ainsi:
Mme Rosa VILLALOBOS
M. Philip HOGAN
M. Hilko SCHOMERUS
M. Charles ROEMERS
M. Jean-François TRAPP
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2012.

Référence de publication: 2012069634/26.
(120098575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

Quant Solutions Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.446.

EXTRAIT

L’Assemblée Extraordinaire du 29 Mai 2012 a nommé l’administrateur suivant:
- Monsieur SLUYTER Curt Linus, Administrateur, avec adresse professionnelle, Rue Carrera 44, Medellin, Colombie.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 mars 2012.

<i>Pour Quant Solutions SICAV

Référence de publication: 2012069006/12.
(120097702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Research Invest Protocol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.102.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2012.

Référence de publication: 2012069011/10.
(120098175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Indufin Capital Partners S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en

Capital à Risque.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 133.146.

L'an deux mille douze, le vingt-cinq mai,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement en capital à risque sous

forme d'une société anonyme «INDU IN CAPITAL PARTNERS S.A., SICAR», en abrégé «ICP S.A., SICAR» ayant son
siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 133.146, constituée suivant acte notarié en date du 28 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 2604 du 15 novembre 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte du notaire instrumentant en date du 20 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 461 du 22 février 2012 (la «Société»).

81735

L

U X E M B O U R G

L'assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Madame Pascale Finck, employée privée, demeurant

professionnellement à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval,

qui désigne comme secrétaire Madame Marie Kaiser, employée privée, demeurant professionnellement à L-1212 Lu-

xembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  Philippe  Liska,  employé  privé,  demeurant  professionnellement  à

L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société à concurrence de quatre millions deux cent trois mille trois cent quatre-

vingt-treize euros (EUR 4.203.393.-) pour le ramener de son montant actuel de cinquante-sept millions six cent quarante
et un mille cent et cinq euros (EUR 57.641.105) à cinquante-trois millions quatre cent trente-sept mille sept cent douze
euros (EUR 53.437.712.-) par l'annulation de:

- un million quatre cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-trois (1.488.853) actions propres de classe A1,
- un million quatre cent cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-onze (1.459.591) actions propres de classe A2,
- soixante-dix-neuf (79) actions propres de classe B2, et
- un million deux cent cinquante-quatre mille huit cent soixante-dix (1.254.870) actions propres de classe A3.
2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de quatre millions deux cent trois

mille trois cent quatre-vingt-treize euros (EUR 4.203.393.-) pour le ramener de son montant actuel de cinquante-sept
millions six cent quarante et un mille cent et cinq euros (EUR 57.641.105) à cinquante-trois millions quatre cent trente-
sept mille sept cent douze euros (EUR 53.437.712.-) par l'annulation de:

- un million quatre cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-trois (1.488.853) actions propres de classe A1,
- un million quatre cent cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-onze (1.459.591) actions propres de classe A2,
- soixante-dix-neuf (79) actions propres de classe B2, et
- un million deux cent cinquante-quatre mille huit cent soixante-dix (1.254.870) actions propres de classe A3.
Toutes les actions annulées étant détenues par la Société même, aucun paiement ne sera effectué en vertu de l'annu-

lation.

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 6.1. et le 1 

er

 alinéa de l'article

6.5. des statuts de la Société pour leurs donner désormais la teneur suivante:

« Art. 6.1. Capital Social. Le capital social émis de la Société s'élève à EUR 53.437.712.- (cinquante-trois millions quatre

cent trente-sept mille sept cent douze euros).»

« Art. 6.5. Répartition du Capital Social. Le capital social émis de la Société de EUR 53.437.712.- (cinquante-trois

millions quatre cent trente-sept mille sept cent douze euros) est représenté par 22.832.011 (vingt-deux millions huit cent
trente-deux mille onze) actions de classe A1 ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les "Actions de Classe
A1"), 1.596 (mille cinq cent quatre-vingt-seize) actions de classe B1 ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune
(les "Actions de Classe B1"), 10.249.915 (dix millions deux cent quarante-neuf mille neuf cent quinze) actions de classe
A2 ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les "Actions de Classe A2"), 224 (deux cent vingt-quatre)
actions de classe B2 ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les "Actions de Classe B2"), 20.351.966 (vingt
millions trois cent cinquante et un mille neuf cent soixante-six) actions de classe A3 ayant une valeur nominale d'un euro

81736

L

U X E M B O U R G

(EUR 1) chacune (les "Actions de Classe A3") et 2.000 (deux mille) actions de classe B3 ayant une valeur nominale d'un
euro (EUR 1) chacune (les "Actions de Classe B3").»

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ deux mille euros (EUR 2.000.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. FINCK, M. KAISER, P. LISKA et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 juin 2012. LAC/2012/25112. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2012.

Référence de publication: 2012069527/86.
(120099221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

Racine Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.298.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2012069012/10.
(120097962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Ramsac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 96.670.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2012.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2012069014/12.
(120097938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Renda S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 129.447.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2012.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012069016/12.
(120097961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

81737

L

U X E M B O U R G

Boom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 120.019.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à Steinfort, en date du 12 juin 2012

que:

Suite à la démission de deux administrateurs, le nouveau conseil d'administration se présente comme suit:
Monsieur Grégory WIAME, administrateur de sociétés, né à Namur (B) le 27 octobre 1975, demeurant profession-

nellement à L - 8437 Steinfort, 68, Rue de Koerich, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017,

Monsieur Michel BOSSIS, employé, né à Ixelles (B) le 9 février 1948, demeurant professionnellement à L- 8437 Steinfort,

68, Rue de Koerich, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017,

Madame Sandra BOSSIS, administrateur de sociétés, née à Messancy (B) le 21 janvier 1974, demeurant professionnel-

lement à L- 8437 Steinfort, 68, Rue de Koerich, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017,

Madame Sandra BOSSIS, administrateur de sociétés, née à Messancy (B) le 21 janvier 1974, demeurant professionnel-

lement à L- 8437 Steinfort, 68, Rue de Koerich, est nommée nouvel administrateur délégué, jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en l'année 2017, avec pouvoir de signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012069301/20.
(120098722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

Ermitage Japan Absolute Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 86.576.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue au siège social le 11 août 2009 a adopté les résolutions sui-

vantes:

1. L'Assemblée a élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.
- Monsieur Jonathan Wauton, Administrateur, demeurant au 22 Napoleon Road Twickenham, TW13EP Royaume-Uni.
- Monsieur Sidney Michael Place, Administrateur, demeurant au 49 Carlisle Avenue, Hurlingham 2196, Afrique du Sud
2. L'Assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en

2010.

- Monsieur David Morrissey, Administrateur, demeurant au 47 The Esplanade, St Helier JE1 9LB Jersey;
- Monsieur Lester Petch, Administrateur, demeurant au 1 Cyber Tower, Cybercity, Ebene, Ile Maurice;
- Monsieur James Cayzer-Colvin, Administrateur, demeurant à Cayzer House, 30 Buckingham Gate, SW1E 6NN Lon-

dres, Royaume-Uni).

3. L'Assemble a pris note de la démission de Monsieur Mark Hucker avec effet au 1 

er

 juillet 2009 de son mandat

d'administrateur de la Société.

4. L'Assemblée a ré-élu KPMG Audit dont le siège social se situe 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg à la fonction

de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2010.

5. L'Assemblée a ratifié le changement du siège social de la société du 40 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au

16 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg à compter du 30 avril 2009.

<i>Pour ERMITAGE JAPAN ABSOLUTE FUND
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2012069391/28.
(120098566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

Renimax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 55.485.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

81738

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012069017/9.
(120097831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Rich Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 111.700.

Les comptes annuels au 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012069019/9.
(120098064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Regus Enterprises, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 167.934.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Regus No. 4, a limited liability company (Société à responsabilité limitée) incorporated in Luxembourg and registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 158071, having its registered office at 26, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg (the “Appearing Party”),

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Monaco under private seal on 24 May 2012; such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and
the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state that:
- That the private limited liability company “Regus Enterprises” (the “Company”), having its registered office at 26,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under B167934,
was incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg, on 29 March
2012, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- That the appearing party is the sole member (the "Sole Member") of the Company and that it has taken the following

resolutions:

<i>Resolutions

<i>First resolution

The Sole Member decided to insert article 7.4 into the articles of incorporation of the Company as follows:

“ 7.4. The directors (gérants) may decide to appoint a day to day manager (the “Manager”) of the Company, who shall

have, amongst other powers as may be decided from time to time by the directors (gérants) the power to act in the
name and on behalf of the Company, to carry out and approve all acts and operations falling within the scope of the
business licence.“

<i>Second resolution

The Sole Member decided to insert article 10.2 into the articles of incorporation of the Company as follows:

“ 10.2. The Company shall also be bound by the sole signature of the Manager in all matters relating to activities of

the Company falling within the scope of the business licence.”

Finally, the Sole Member decided to ratify any appointment of a Manager by the directors (gérants) that may have

occurred in the past.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

81739

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, this person signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-neuf mai.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Regus No. 4, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158071, ayant son siège social au 26, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg (la «partie Comparante»),

ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé lui délivrée à Monaco le 24 mai 2012; laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur
par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
- Que la société à responsabilité limitée “Regus Enterprises” (la «Société»), établie et ayant son siège social au 26

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg constituée selon acte reçu par Maître Joseph Elvinger le 29 mars 2012, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- La partie comparante est la seule associée actuelle (l'«Associée Unique») de la Société et qu'elle a pris, par son

mandataire, les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'insérer l'article 7.4 dans les statuts de la Société comme suit:

« 7.4. Les gérants peuvent décider de nommer un «délégué à la gestion journalière» (le «Gestionnaire») de la Société,

qui aura, entre autres pouvoirs qui peuvent être déterminés de temps à autre par les gérants, le pouvoir d'agir au nom
et pour le nom de la Société, de réaliser et approuver tous actes et opérations entrant dans le champ de la licence
d'exploitation.»

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'insérer l'article 10.2 dans les statuts de la Société comme suit:

« 10.2. La Société sera également engagée par la seule signature du Gestionnaire dans toutes les questions relatives

aux activités de la Société relevant du champ d'application de la licence d'exploitation.»

Enfin, L'Associé Unique a décidé de ratifier toutes nominations d'un Gestionnaire par les gérants qui se sont produites

dans le passé.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; et qu'à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: S. Lecomte, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1 

er

 juin 2012. Relation: LAC/2012/25086. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): I. Thill.

Référence de publication: 2012069726/90.
(120099167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

81740

L

U X E M B O U R G

Risk &amp; Insurance Services S.A. (Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 33.393.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 décembre 2011

Le Conseil d'Administration a décidé de co-opter Monsieur Soren Moth Poulsen, demeurant à Borupvang 4, DK-2750

Ballerup, Danemark, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Lars Thykier, administrateur démis-
sionnaire.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 2 mai 2012

L'assemblée générale ordinaire a décidé de confirmer l'élection de Monsieur Soren Moth Poulsen comme nouvel

administrateur en remplacement de Monsieur Lars Thykier, administrateur démissionnaire, faite par le Conseil d'Admi-
nistration dans sa réunion du 8 décembre 2011.

L'assemblée générale ordinaire a réélu Monsieur Lars Hem Simonsen, Monsieur Soren Moth Poulsen et Monsieur

Kristian Kristensen comme administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

L'assemblée générale ordinaire a élu Deloitte S.A. comme réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire

qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2012.

<i>Pour RISK &amp; INSURANCE SERVICES S.A. (Luxembourg)

Référence de publication: 2012069020/22.
(120098051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Risk Dynamics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.292.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012069021/9.
(120098266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Château de Beggen Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 4.652.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 8. Juni 2012

Die Versammlung hat unter anderem einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung nimmt die Rücktrittserklärung des Verwaltungsratsmitglieds Herr Simon HAUGER, mit Wir-

kung zum 6. Juni 2012, zur Kenntnis und akzeptiert diese.

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung ernennt mit Wirkung zum 7. Juni 2012 und bis zur Hauptversammlung, die im Jahre 2013

stattfinden wird,

Herrn Christian SAILER, Diplom-Betriebswirt (FH), geboren am 11.06.1969 in STUTTGART, Deutschland, geschäft-

sansässig in D-70174 STUTTGART, Fritz-Elsas-Straße 31,

zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

81741

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 13. Juni 2012.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2012069320/23.
(120098873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

Risk Dynamics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.292.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 juin 2012

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2011:

- Monsieur Olivier BOURRAT, Directeur Général, demeurant à 19/RC, Rue Mignot Delstanche, B - 1050 Ixelles,

Président;

- Madame Dominique DEHIN, Directeur Général, demeurant à 19/RC, Rue Mignot Delstanche, B - 1050 Ixelles;
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Marc THILL, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L -

1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2011:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2012.

Référence de publication: 2012069022/22.
(120098274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Triton III No. 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 143.936.

Le siège social de
1. Triton Fund III L.P.
2. Triton Fund III Executives L.P.
3. Triton Fund III F&amp;F No. 2 L.P.
4. Triton Fund III F&amp;F No. 3 L.P.
5. Triton Fund III F&amp;F No. 4 L.P.
6. Triton Fund III F&amp;F G L.P.
a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.

<i>Pour Triton III No. 10 S.à r.l.
Un Mandataire

Référence de publication: 2012069103/18.
(120097923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Rollins Capital S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 137.967.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1 

er

 juin 2012 que le siège social

de la société a été transféré de son ancienne adresse au 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg

81742

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2012.

Référence de publication: 2012069023/12.
(120097891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Ronndriesch 123 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 84.107.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13/06/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2012069025/12.
(120098271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Roosevelt International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 118.593.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012069026/9.
(120098205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

Criali Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 110.028.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 29 mai 2012

Il résulte dudit procès-verbal:
le renouvellement des mandats de Monsieur Lex Benoy, né le 29/05/1954 à Luxembourg et demeurant profession-

nellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, de Madame Nadia Digiuni Sprenger, née le 30 septembre 1970
à Wetzikon (Suisse) et demeurant à CH-6926 Montagnola, via dei Guardi 5 (Suisse) et de Madame Nathalie Sorbara, née
le 11 janvier 1972 à Saint-Avold (France) et demeurant professionnellement au 1, Riva Albertolli, CHF-6900 Lugano en
tant qu'administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice
2016.

le renouvellement du mandat de la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.àr.L, immatriculée au Registre

du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B33849 et ayant son siège social au 45-47, route d'Arlon,
L-1140 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2016.

Luxembourg, le 29 mai 2012.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2012069360/21.
(120098717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

WP2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3446 Dudelange, 20, rue Mathias Cungs.

R.C.S. Luxembourg B 152.581.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012069165/9.
(120098419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.

81743

L

U X E M B O U R G

S.M. Tuyauteries Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3542 Dudelange, 203, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 137.272.

L'an deux mille douze, le vingt-et-un mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg);

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Sylvestre CHIGIONI, responsable technique, né à Metz (France), le 29 juillet 1965, demeurant à F-57140

Plesnois, 1 bis, rue Jeanne d'Arc, et

2.- Monsieur James MAIREL, directeur, né à Rembercourt-Sommaisne (France), le 7 janvier 1957, demeurant à F-57300

Hagondange, 26, rue d'Amnéville,

ici représentés par Maître Joëlle CHOUCROUN, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,

34B, rue Philippe II, en vertu de deux (2) procurations lui délivrées, lesquelles après avoir été signées «ne varietur» par
la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "S.M. Tuyauteries S.à r.l.", avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 137.272, a
été constituée originairement sous la dénomination sociale de "MAINTENANCE CHAUFFAGE SARL", suivant acte reçu
par Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, en date du 10 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 955 du 17 avril 2008,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du:
- 5 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2373 du 4 décembre 2009,

contenant notamment l'adoption de la dénomination actuelle, et

- 25 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 847 du 23 avril 2012
- Que les parties comparantes sub 1) et 2) sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Sylvestre CHIGIONI, prédésigné et représenté comme dit ci-avant, cède par les présentes ses 50 (cinquante)

parts sociales qu'il détient dans la prédite société à Monsieur James MAIREL, prédésigné et représenté comme dit ci-
avant, pour le prix convenu entre parties, qui accepte.

Cette cession de parts est approuvée conformément à l'article 7 des statuts et à dorénavant associé unique la considère

comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social vers L-3542 Dudelange, 203, rue du Parc, et de modifier en

conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Commune de Dudelange.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de huit cent cinquante euros, sont à charge de la société,

et l'associée unique s'y engage personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Joëlle CHOUCROUN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mai 2012. Relation GRE/2012/1840. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 14 juin 2012.

Référence de publication: 2012069752/52.
(120098697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

81744


Document Outline

Automat' Services

Baden Capital S.A.

Black Tie Luxco S.à r.l.

Boom S.A.

Café Belle époque S.à r.l.

Château de Beggen Participations S.A.

Criali Investment S.A.

DenTheater.lu

E.P.F. European Property Foundation S.à.r.l.

Ermitage Japan Absolute Fund

Hereford Funds

Imperiale Lounge Bar

Indufin Capital Partners S.A., SICAR

LF Funds

Lunon A.G.

Majerus-Parmentier Constructions Sàrl

Meco S.à r.l.

Medic Participations S.A.

MEIF4 Luxembourg B Holdings S.à. r.l.

MGG

Microcap 08/09 - FTL S.C.A., SICAR

Microcap 08/09 - ITM S.C.A., SICAR

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Mit Holding S.A. - SPF

ML Ray Investor S.à r.l.

MOTO24H S.àr.l.

Motor Lux S.A.

New La Rosière S.à r.l.

NIFE Carlo Seccomandi

Nowa Holding Sàrl

NS Luxembourg S.A.

Pan European Ventures S.A.

Panev S.A.

PEME 09 - FTL S.C.A, SICAR

PEME 09 - ITM S.C.A., SICAR

Prologis Fund Management S.à r.l.

Promotions Schmit &amp; Klein S.à r.l.

Prorech S.A.

Prorech S.A.

Q Build

Quadro Capital Management S.à r.l.

Quant Solutions Sicav

Racine Investissement S.A.

Rafferty 3 S.à r.l.

Ramsac S.A.

Regus Enterprises

Renda S.A.

Renimax S.A.

Research Invest Protocol S.A.

Rich Investments S.à r.l.

Risk Dynamics S.A.

Risk Dynamics S.A.

Risk &amp; Insurance Services S.A. (Luxembourg)

Rollins Capital S.A.

Ronndriesch 123 S.A.

Roosevelt International S.à r.l.

S.M. Tuyauteries Sàrl

Structor

Taranis International S.A.

Triton III No. 10 S.à r.l.

Triton III No. 11 S.à r.l.

WP2 S.à r.l.