This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1701
6 juillet 2012
SOMMAIRE
Aedes International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
81603
Aforest Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81641
Agence Moneygram Metroplus Sàrl . . . . . .
81638
Alcubo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81630
Alfred Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81613
Allegro Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81615
Allegro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81616
Allegro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81616
AllianceBernstein Institutional Invest-
ments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81616
Allianz Global Investors Fund . . . . . . . . . . .
81617
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81617
Alsina S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81639
Ana Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81615
Ancolie Holding S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . .
81614
Antinéum SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81631
ARAGON Service & Administration S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81642
Atelier de Menuiserie Heusbourg Frères
S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81635
Autodis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81641
Avaya International Enterprises Limited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81644
Barclays European Infrastructure Projects
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81646
Billecart Expansion Holdings S.A. . . . . . . . .
81602
Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81639
Carren Gere S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81602
Cencan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81646
CLdN ro-ro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81644
Codelem Investissements S.A. . . . . . . . . . .
81634
Crédit Suisse (Luxembourg) S.A. . . . . . . . .
81647
db PrivatMandat Comfort . . . . . . . . . . . . . .
81646
Deutschland Property Partners . . . . . . . . .
81620
Eclipp L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81614
Elle Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81647
Energy Asset Management S.à r.l. . . . . . . .
81615
Energy Asset Management S.à r.l. . . . . . . .
81616
European CleanTech I SE . . . . . . . . . . . . . . .
81609
Fides et Spes Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81647
Fortis Commercial Finance . . . . . . . . . . . . .
81620
GP Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81643
Holden Recoveries S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
81644
Hottinger International Fund . . . . . . . . . . .
81647
International Real Estate Portfolio 08/09 -
FTL S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81618
International Real Estate Portfolio 08/09 -
ITM S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81618
KBL EPB Equity Fund II . . . . . . . . . . . . . . . .
81604
Malicar Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81605
Mecca World Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
81614
MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l. . .
81619
Mondeltone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81603
Omnium Textile S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81613
Partners Group Global Value SICAV . . . .
81605
Patch International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
81602
Plastiche S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81632
Regus International Services . . . . . . . . . . . .
81636
Saltri HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81630
Selection F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81616
Servus Group HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
81632
Sevens Beteiligung S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
81634
Tabiadasc Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . .
81605
TF Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81648
TIAA Lux 11 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81638
TreeTop Global Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81648
TreeTop Portfolio SICAV . . . . . . . . . . . . . . .
81648
Triton III LuxCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
81638
81601
L
U X E M B O U R G
Patch International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 161.856.
Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le <i>24 juillet 2012i> , à dix heures, au siège social, en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2011, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,
- Affectation du résultat,
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée se tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la dis-
solution ou non de la société conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 modifiée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012078306/1161/18.
Carren Gere S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 107.459.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>23 juillet 2012i> à 15.00 heures dans les bureaux de l'Etude Tabery & Wauthier, 10, rue Pierre d'Aspelt,
L-1142 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'administration sur le projet de fusion-absorption de Carren Gere S.A. ès qualité société
absorbée, par la société Entraide et Solidarité S.A., ès qualité de société absorbante (la «Fusion»);
2. Approbation du projet commun de fusion;
3. Reconnaissance de la dissolution sans liquidation de la Société;
4. Reconnaissance de la date effective de la Fusion d'un point de vue comptable;
5. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat;
6. Décharge au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de son mandat;
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012079086/322/20.
Billecart Expansion Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 27.288.
Les actionnaires de la Société sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
qui se tiendra le mercredi, <i>25 juillet 2012i> à 11.30 heures, au siège de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes de l'exercice social
clos le 31 décembre 2011 et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2011;
2. Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2011;
3. Quitus aux administrateurs;
4. Election des membres du conseil d'administration;
5. Quitus au commissaire;
6. Election du commissaire;
7. Questions diverses.
81602
L
U X E M B O U R G
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'assemblée ne requièrent aucun quorum et que les
décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Lux-Audit S.A.
<i>Commissairei>
Référence de publication: 2012079088/23.
Mondeltone S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.847.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>23 juillet 2012i> à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations Statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012080640/795/18.
Aedes International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 99.178.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>23 juillet 2012i> à 11.00 heures à Esch/Alzette, en l'Etude de Maître Francis KESSELER:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du projet de fusion daté du 12 mars 2012 respectivement du 21 mars 2012 prévoyant l'absorption de
AEDES INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3, avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B99178, ci-après dénommée "la société absorbée" ou "notre Société", par la société "AEDES S.pA.", une société
anonyme de droit italien dénommée ayant son siège statutaire et administratif au 21 Bastioni di Porta Nuova, Milan,
Italie, inscrite au Registre des Entreprises à Milan (Registro Imprese di Milano) sous le numéro 00824960157 (ci-
après nommée "la société absorbante"), la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans
liquidation de l'ensemble du patrimoine activement et passivement sans exception ni réserve de la société absorbée
à notre Société, ledit projet de fusion ayant été publié au Mémorial C n°1429 du 8 juin 2012, conformément à
l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés telle que modifiée;
2. Présentation du rapport écrit du conseil d'administration de la société absorbante expliquant et justifiant d'un point
de vue juridique le projet de fusion.
3. Constatation que, la société absorbante détenant à 100 % la société absorbée, la fusion ne donnera pas lieu à une
augmentation de capital de la société absorbante avec création d'actions nouvelles que par suite d'absence d'aug-
mentation de capital et d'absence d'émission d'actions nouvelles par la société absorbante il n'y a pas d'échange
d'actions et donc pas de rapport d'échange ni de rapport de réviseur d'entreprises et ce en vertu de l'article 26.1
(2).
4. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.
5. Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de notre société par la société
absorbante, aux conditions prévues par le projet de fusion, sans création d'actions nouvelles mais par la seule
création d'un compte de réserve de fusion et transfert de tous les actifs et passifs de notre société à la société
absorbante avec dissolution sans liquidation de notre société par suite de la fusion et plus particulièrement adoption
de l'objet social de la société absorbante, lequel se lit en langue française comme suit:
Art. 3. Objet
81603
L
U X E M B O U R G
La société a comme objet l'acquisition, la vente, la construction et la commutation de n'importe quelle nature ainsi
que la gestion des immeubles de propriété de la société. La société traite également de ce qui suit:
- l'exercice des activités qui ne sont pas directement liées au public, comme suit:
1. les accessions de participations, acquisition d'entreprises ou quotes-parts d'entreprises;
2. la coordination technique, administrative et financière des sociétés auxquelles elle participe, ainsi que leur finan-
cement;
3. les investissements financiers directement et/ou par l'intermédiaire d'organisations compétentes, dans des so-
ciétés italiennes et étrangères;
4. les services et activités en faveur de tiers en matière de services relatifs à la consultation financière, commerciale,
technique et administrative.
La société pourra également effectuer toutes les opérations commerciales, financières, industrielles, de fourniture
mobilière et immobilière qui s'avèrent nécessaires; elle pourra également jouir des bénéfices d'exploitation pour
la réalisation d' objets sociaux (y compris la délivrance de garanties personnelles ou réelles également effectuées
dans l'intérêt de tiers, ainsi que son engagement pour ce qui concerne des prêts et des financements qui peuvent
également être hypothécaires) avec formelle exclusion relative à l'activité fiduciaire et professionnelle réservée ex
lege, le rassemblement des économies entre le public, les activités réservées aux SIM et aux SGR, l'exercice de
n'importe quelle activité relative à la loi par rapport au public, qualifiée comme "activité financière". Le rassemble-
ment des économies est admise dans les limites et dans les modalités selon les normes établies par l'art. 11 du T.U.
n. 385/1993 et par la réglementation secondaire qui y est liée; c'est-à-dire que ce rassemblement est autorisé selon
les modalités et les limites prévues par la réglementation pro tempore en vigueur.
6. Décharge à accorder aux administrateurs et commissaires de notre société pour l'exécution de leurs mandats
respectifs.
7. Détermination du lieu de conservation pendant le délai légal des documents sociaux de notre société.
Le tout sous la condition suspensive de l'approbation du même projet de fusion aux conditions prévues par ledit projet
de fusion par l'organe compétent de la société absorbante et la réalisation de cette fusion suivant les lois applicables en
Italie.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012080657/1023/61.
KBL EPB Equity Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 43.091.
Etant donné que le quorum n'a pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2012, Mesdames
et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à la
SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de notre SICAV, qui aura lieu le <i>23 juillet 2012i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du projet de fusion des compartiments comme suit:
Compartiments Absorbés
Compartiments Absorbants
KBL EPB Equity Fund II - North America
KBL EPB Equity Fund - North America Value
KBL EPB Equity Fund II - Japan
KBL EPB Equity Fund - Japan Value
KBL EPB Equity Fund II - Europe
KBL EPB Equity Fund - Europe Value
2. Présentation et approbation des comptes de la Société à la date du 20 juin 2012
3. Dissolution de KBL EPB Equity Fund II à la date du 31 juillet, date effective de la Fusion
4. Divers
Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des voix exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire repré-
senter à l'Assemblée.
Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions un jour ouvrable avant la date de
l'assemblée au siège de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L - 2955 Luxembourg. Des procurations
sont disponibles au siège de la SICAV.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012071979/755/26.
81604
L
U X E M B O U R G
Tabiadasc Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 85.240.
The shareholders are hereby convened to the
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
which will be held on Thursday, the <i>26th of July 2012i> at 2.00 p.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the supervisory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2011.
3. Appropriation of results as of December 31, 2011.
4. Discharge to the directors and to the supervisory auditor for the performance of their mandates during the related
fiscal year.
5. Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.
6. Resignation of Mrs. Virginie DOHOGNE as B director, and discharge.
7. Appointment of Mr. Xavier SOULARD, company director, born in Châteauroux (France), on August 14, 1980,
residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as B director until the
end of the statutory general shareholders' meeting of 2013.
8. Sundry.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012080700/29/23.
Malicar Finance S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 31.830.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>25 juillet 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
mars 2012.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012080676/1023/17.
Partners Group Global Value SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 124.171.
As the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Partners Group Global Value SICAV (hereinafter referred
to as the "Company") held on June 28, 2012 could not validly deliberate and vote on the proposed agenda due to lack of
quorum the Shareholders are informed that the reconvened
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company will be held at its registered office at 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg at 11.30
am (Luxembourg time) on <i>August 07, 2012.i>
The reconvened Extraordinary General Meeting of Shareholders will be held to deliberate and vote on amendments
to the articles of incorporation of the Company (hereinafter referred to as the "Articles") as described in the following
agenda:
81605
L
U X E M B O U R G
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the third paragraph of article 5 of the Articles to read as follows:
"The board of directors is authorized without limitation to issue further fully paid shares at any time pursuant to
Article 24 hereof without reserving the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to
be issued. Separate pre-emption rights for the acquisition of shares tendered for redemption exist in favour of
existing shareholders in the context of the Annual Redemption Procedure as set out in Article 21 hereof."
2. Amendment of the fourth paragraph of article 5 of the Articles to read as follows:
"The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other
duly authorized agent, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for such new shares, remaining
always within the limits imposed by the Law."
3. Amendment of the fifth paragraph of article 5 of the Articles to read as follows:
"Shares may be of different classes and such classes may have specific rights or be subject to specific liabilities and
be issued under such conditions as the board of directors may decide."
4. Amendment of the formerly tenth paragraph of article 5 of the Articles to read as follows:
"Unless decided to the contrary by the board of directors in the interests of, or to achieve equal treatment of the
shareholders, the shareholders of the class concerned may continue to request redemption or conversion of their
shares until the effective date of the liquidation. Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon
the close of the liquidation of the class will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of their bene-
ficiaries."
5. Amendment of the eigth paragraph of article 6 of the Articles to read as follows:
"A dividend declared but not claimed on a share, within a period of five years from the payment notice given thereof,
cannot thereafter be claimed by the holder of such share and shall be forfeited and revert to the Company. No
interest will be paid on dividends declared, pending their collection."
6. Amendment of the ninth paragraph of article 6 of the Articles to read as follows:
"All issued registered shares shall be registered in the Register which shall be kept by the Company or by one or
more persons designated for such purpose by the Company. The Register shall contain the name of each holder
of registered shares, his residence or elected domicile, the number of shares held by him and the amount paid in
on each such share. Every transfer of a registered share shall be entered in the Register."
7. Amendment of article 6 of the Articles by adding the following paragraph after the eleventh paragraph of this article:
"In the context of the Annual Dealing Procedure as detailed in Article 21 hereof, the registrar and transfer agent
of the Company is entitled to sign (to the extent necessary) transfer forms in relation to shares presented for
redemption and transferred to shareholders/investors wishing to acquire shares under the Annual Dealing Proce-
dure."
8. Amendment of article 12 of the Articles by adding the following paragraph after the first paragraph of this article:
"Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of share-
holders may provide that the quorum and the majority at this general meeting will be determined according to the
shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"). The
right of a shareholder to attend at a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attaching to
his shares shall be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date."
9. Amendment of the second paragraph of article 14 of the Articles to read as follows:
"The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the
shareholders or the board of directors may appoint another director and, in the case of a shareholders meeting,
in the absence of a director, any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting."
10. Amendment of article 17 of the Articles to read as follows:
"No contract or other transaction between the Company and any other corporation or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any director or officer of the
Company who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall
contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such connection and/or relationship with such
other corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction submitted for approval to the
board of directors an interest conflicting with that of the Company, such director or officer shall make such interest
known to the board of directors and shall not consider or vote on any such transaction, and any such transaction
shall be reported to the next general meeting of shareholders.
The preceding paragraph does not apply where the decision of the board of directors relates to operations entered
in the ordinary course of business at arm's length."
11. Amendment of article 20 of the Articles to read as follows:
"The Company shall appoint an approved statutory auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall carry out the
duties prescribed by article 154 of the Law. The approved statutory auditor shall be elected by the annual general
81606
L
U X E M B O U R G
meeting of shareholders for a period ending at the next annual general meeting and shall hold office until its suc-
cessor is elected."
12. Amendment of article 21 of the Articles to read as follows:
"A) Monthly Dealing Procedure
In principle net redemptions will be limited per rolling twelve month period to a percentage figure of the Net Asset
Value determined from time to time by the directors and disclosed in the prospectus.
If the requests for redemption received exceed such percentage the board of directors may reduce the redemption
requests pro-rata and defer such redemption requests to the immediately succeeding period. Deferred redemption
requests will be dealt with on equal terms with new redemption requests.
The board of directors may also determine a prior notice period required for lodging any redemption request or
decide to waive restrictions on redemptions.
The specific period for payment of the redemption proceeds of any class of shares of the Company as well as the
details on the processing of the monthly redemption will be published in the prospectus.
The redemption price shall be the Net Asset Value for a class of shares, as at the relevant Valuation Point determined
in accordance with the provisions of Article 23 less any applicable charges, commissions and dilution levies as the
prospectus may provide.
The board of directors may extend the period for payment of redemption proceeds as disclosed in the prospectus
to such period as shall be necessary to repatriate proceeds of the sale of investments in the event of impediments
due to exchange control regulations or similar constraints in the markets in which a substantial part of the assets
of the Company shall be invested. Payment of redemption proceeds may be effected in any freely convertible
currency as disclosed in the prospectus.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other
duly authorized agent, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.
The redemption price shall be rounded down to two decimal places, as the board of directors may from time to
time determine, and such rounding shall accrue to the benefit of the Company.
With the consent of the shareholder(s) concerned, the board of directors may (subject to the principle of equal
treatment of shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in specie by allocating to the redeeming
shareholders investments from the portfolio equal in value to the Net Asset Value attributable to the shares to be
redeemed minus applicable charges, commissions and dilution levies as described in the prospectus.
Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to
Article 22 hereof or as otherwise determined by the board of directors. In the event of suspension under Article
22 hereof, redemption requests will be dealt with as of the first valuation point on which redemptions are processed
after the end of the suspension save where the request for redemption has been revoked.
However, the board of directors may decide, at their discretion, not to accept redemptions for a period of up to
12 months, if deemed in the interest of existing shareholders.
B) Annual Dealing Procedure
Under exceptional circumstances further detailed in the prospectus the board of directors may apply an Annual
Dealing Procedure as disclosed in the prospectus.
Under this procedure redemptions will not be limited to a given percentage figure and will be processed annually
at a secondary value dealing price determined as disclosed in the prospectus.
The board of directors may also determine a prior notice period required for lodging any redemption request. The
annual redemption day and annual redemption payment day will be disclosed in the prospectus.
The specific period for payment of the secondary value dealing price of any class of shares of the Company as well
as the details on the processing of the annual redemption will be published in the prospectus.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other
duly authorized agent, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.
The secondary value dealing price is based on the Net Asset Value, as at the annual redemption day, adjusted by a
spread reflecting the expected or actual discount, relative to Net Asset Values, of prices obtained through secondary
sales under the then prevailing market conditions. For the purpose of determining the spread and secondary value
dealing price it shall be assumed that the Company will realise such portion of assets believed to represent a fair
and reasonable part of the assets in view of the level of the redemption requests received.
The secondary value dealing price shall be rounded down to two decimal places, as the board of directors may
from time to time determine, and such rounding shall accrue to the benefit of the Company.
With the consent of the shareholder(s) concerned, the board of directors may (subject to the principle of equal
treatment of shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in specie by allocating to the redeeming
shareholders investments from the portfolio equal in value to the secondary value dealing price attributable to the
shares to be redeemed as described in the prospectus.
The board of directors may, at their discretion, grant redeeming shareholders the right to withdraw (a) their
redemption request for any annual redemption day, or (b) the deferred part of their redemption request under
the Monthly Dealing Procedure, in either case, provided that such notice is given prior to the applicable annual
redemption day.
C) General
81607
L
U X E M B O U R G
Shares of the capital of the Company redeemed by the Company shall be cancelled. A number of shares presented
for redemption under the Annual Dealing Procedure equal to the number of shares to be acquired under the Annual
Dealing Procedure will not be redeemed by the Company but shareholders agree that those shares will be trans-
ferred to shareholders/investors having applied to acquire shares at the secondary value dealing price. Shares
acquired at the secondary value dealing price may be subject to a lock-up period of 12 months (as disclosed in the
prospectus). During such period those shares may not be redeemed.
Any shareholder may, by irrevocable request, obtain conversion of whole or part of his shares into shares of another
class at the respective Net Asset Values or secondary value dealing prices of the relevant classes. The board of
directors may impose restrictions as to, inter alia, possibility and frequency of conversion, and may make conversion
subject to payment of such charge, as it shall determine and as described in the prospectus.
The board of directors may extend the period for payment of redemption proceeds to such period as shall be
necessary to repatriate proceeds of the sale of investments in the event of impediments due to exchange control
regulations or similar constraints in the markets in which a substantial part of the assets of the Company shall be
invested. Payment of redemption proceeds may be effected in any freely convertible currency as disclosed in the
prospectus.
If a redemption, conversion or sale of shares would reduce the value of the holdings of a single holder of shares of
one class below such minimum investment value as the board of directors shall determine from time to time, then
such shareholder shall be deemed to have requested the redemption or the conversion of all his shares of such
class as the board of directors may decide.
The board of directors may in its absolute discretion compulsorily redeem any holding with a value of less than
EUR 10,000 or such amount as may be determined by the board of directors from time to time and as described
in the prospectus.
The board of directors may, if at any moment, the total Net Asset Value of the shares of any class of shares is less
than such amount as determined by the board of directors from time to time, redeem all the shares of such class
at the Net Asset Value."
13. Amendment of the first paragraph of article 22 of the Articles to read as follows:
"The Net Asset Value of each class of shares shall be determined by the Company from time to time as the board
of directors may direct (but normally on a monthly basis) and, if any such day is not a Luxembourg bank business
day, on the following Luxembourg bank business day (every such day or time of determination of Net Asset Value
being referred to herein as a "Valuation Point")."
14. Amendment of article 24 of the Articles to read as follows:
"In relation to the Monthly Dealing Procedure, whenever the Company shall offer shares for subscription, the price
per share at which such shares shall be offered and sold shall be based on the Net Asset Value of the relevant class
of shares as hereinabove defined plus such subscription fee and/or commission as the sale documents may provide.
The price so determined shall be payable at the latest on a point in time specified in the Company's prospectus not
exceeding one month following the relevant Valuation Point. The board of directors is authorized to accept requests
for subscription in kind under the conditions set forth by Luxembourg law and as described in the prospectus.
In relation to the Annual Dealing Procedure, no new shares shall be issued. The number of shares to be acquired
under the Annual Dealing Procedure shall (to the extent necessary) be transferred to shareholders having submitted
an application for acquisition at the secondary value dealing price. All shareholders have a pre-emptive right to
acquire the shares submitted for redemption pro-rata to their holdings during the application of the Annual Dealing
Procedure."
15. Minor changes to articles 6, 12, 22, 23 and 25 of the Articles from an editorial point of view, such as the use of
upper or lower case letters or the correction of relevant typing errors.
Please note that the prospectus of the Company will be updated to reflect those amendments, once approved.
<i>Voting:i>
In accordance with the provisions of article 67-1 of the amended Law of 10 August 1915 regarding commercial com-
panies there is no quorum required for this reconvened Extraordinary General Meeting of Shareholders to validly
deliberate and vote on the proposed agenda and resolutions are passed by the favourable vote of the majority of two
thirds of the votes cast at the reconvened Extraordinary General Meeting of Shareholders. Each Share is entitled to one
vote.
The majority at the meeting will be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg
time) on the fifth day prior to the meeting, i.e. August 02, 2012 (the "Record Date"). The rights of a shareholder to attend
a general meeting and to exercise a voting right attaching to his/her/its shares are determined in accordance with the
shares held by this shareholder at the Record Date.
Shareholders may vote in person or by proxy.
Proxies received for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 28 June 2012 will be valid for this recon-
vened Extraordinary General Meeting of Shareholders, unless they are revoked.
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012080762/755/197.
81608
L
U X E M B O U R G
European CleanTech I SE, Société Européenne.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 155.076.
Notice is hereby given to the holders of shares of European CleanTech I SE (the "Company") that two general meetings
of shareholders of the Company are hereby convened.
The first general meeting of shareholders, the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders, will be held on <i>July 20, 2012i> at 11:00 Central European Summer Time ("CEST"). The meeting will be
held at Hotel Le Royal, 12 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
At the annual general meeting, the shareholders shall deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the management report issued by the management board and the report of the independent auditor
to the general meeting of shareholders for the financial year ended December 31, 2011;
2. Approval of the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2011;
3. Allocation of the result;
4. Discharge of the members of the management board and the supervisory board; and
5. Appointment of the independent auditor of the Company for the financial year ending December 31, 2012.
The second general meeting of shareholders, the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders, will be held on <i>July 20, 2012i> at 11:30 CEST. The meeting will be held at Hotel Le Royal, 12 boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
At the extraordinary general meeting, the shareholders shall deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the proposed initial business combination with Electrawinds NV conditional upon the
approval of (i) either item 6 or item 7; and (ii) item 8 of the agenda of this extraordinary general meeting of
shareholders;
2. Change of the name of the Company into "Electrawinds SE" and related amendment of Article 1 of the articles of
association of the Company, with effect as of the Consummation (as defined below) and conditional upon approval
of item 1 of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders;
3. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company in the form made available on the
website of the Company since June 19, 2012, with effect as of the Consummation and conditional upon approval
of item 1 of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders;
4. Acknowledgement of the supplementary special report of the management board, increase of the authorized capital
and renewal of the authorization period, with effect as of the Consummation and conditional upon approval of item
1 and item 3 of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders: during the period of five (5) years
from the publication of the resolutions of this extraordinary general meeting of shareholders, the board of directors
is authorized to issue class A shares, to grant options to subscribe for class A shares and to issue any other
instruments convertible into class A shares within the limit of the authorized capital, to such persons and on such
terms as the board of directors shall see fit, and specifically also to proceed to such issue without reserving for the
existing shareholders a preferential right to subscribe to the class A shares issued;
5. Acknowledgment of the resignations of the supervisory board members and the management board members, and
discharge of the supervisory board members and the management board members, all with effect as of the Con-
summation and conditional upon the approval of item 1 of the agenda of this extraordinary general meeting of
shareholders;
6. Appointment of directors of the Company conditional upon and with effect as of the time at which the management
board and supervisory board of the Company are replaced by the general meeting of shareholders with a board of
directors of the Company in accordance with section IV, § 4, sub-§ 1 of the Luxembourg law on commercial
companies of August 10, 1915, as amended;
7. Appointment of new supervisory board members (i) with effect as of the Consummation, (ii) conditional upon the
approval of item 1 of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders, and (iii) subject to item 3
of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders not being approved or voted by the general
meeting of shareholders; and
8. Granting of an irrevocable power of attorney to the management board to confirm compliance with conditions for
the conversion of all 958,333 class B1 shares into a corresponding amount of class A shares, to acknowledge
occurrence of the consummation of the initial business combination with Electrawinds NV and to make any state-
ment, sign all documents, represent the shareholders in front of a Luxembourg notary and to do everything which
81609
L
U X E M B O U R G
is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfillment of the resolutions approved by
the extraordinary general meeting of shareholders, with effect as of the Consummation and subject to the approval
of item 1 of the agenda of this extraordinary general meeting of shareholders.
"Consummation" shall mean immediately after the meeting of the management board on the date on which the Com-
pany becomes shareholder of Electrawinds NV acknowledging, inter alia, the consummation of the initial business
combination with Electrawinds NV.
<i>Quorum and majoritiesi>
Annual general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders will deliberate validly regardless of the number of shares present or
represented. Decisions related to all items on the agenda of the annual general meeting of shareholders will be passed
by a simple majority of the votes validly cast at the annual general meeting of shareholders.
<i>Extraordinary general meeting of shareholdersi>
Regarding the extraordinary general meeting of shareholders, the following rules apply pursuant to the articles of
association and the law:
(i) The extraordinary general meeting of shareholders will deliberate validly upon item 1 of the agenda of the extraor-
dinary general meeting of shareholders only if a quorum of at least twenty-five percent (25%) of the class A shares is
present or represented. Decisions relating to item 1 of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders
will be passed by a simple majority of the votes of the class A shares validly cast.
(ii) The extraordinary general meeting of shareholders will deliberate validly upon items 2, 3 and 4 of the agenda of
the extraordinary general meeting of shareholders only if a quorum of at least fifty percent (50%) of the share capital is
present or represented for each class of shares individually. Decisions relating to items 2, 3 and 4 of the agenda of the
extraordinary general meeting of shareholders will be passed of two thirds (2/3) of the votes validly cast for each class
of shares individually.
(iii) The extraordinary general meeting of shareholders will deliberate validly upon items 5, 6, 7 and 8 of the agenda
of the extraordinary general meeting of shareholders regardless of the number of shares present or represented. Deci-
sions related to items 5, 6, 7 and 8 of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders will be passed by
a simple majority of the votes validly cast.
Item 7 of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders will only be presented for vote if item 3 of
the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders is not approved or voted (including, for the avoidance
of doubt, due to a lack of quorum).
Items 1 (to the extent the relevant quorum is reached), 5, 6, 7 and 8 of the agenda of this extraordinary general meeting
of shareholders will be presented for deliberation and vote also if the quorum of at least fifty percent (50%) of the share
capital present or represented for each class of shares individually required for items 2, 3 and 4 of the agenda of the
extraordinary general meeting of shareholders is not reached at the time they are presented for deliberation of the
extraordinary general meeting of shareholders.
<i>Right to amend the content of the agendai>
Pursuant to the Company's articles of association and the Luxembourg law of May 24, 2011 on certain rights of
shareholders in listed companies (the "Luxembourg Shareholders' Rights Law"), which implemented the European Union
Directive on Shareholders' Rights (2007/36/EC) (the "Shareholders' Rights Directive") and involved certain changes to
the procedures for calling and conducting general shareholders' meetings, one or several shareholders representing at
least five percent (5%) of the Company's share capital may request that one or several items be added to the agenda of
any general meeting of shareholders and file draft resolution(s) in this respect. Pursuant to Article 4 of the Luxembourg
Shareholders' Rights Law and the Company's articles of association, such request and draft resolution(s) must be received
at the Company's registered office by registered letter or by e-mail at least twenty-two (22) days prior to the date of the
relevant general meeting of shareholders, i.e., prior to June 29, 2012, accompanied by a proof of the shareholding of such
shareholder(s) and the address or e-mail address which the Company may use in order to deliver the acknowledgment
of receipt of such request. The Company must acknowledge reception of such request within forty-eight (48) hours of
receipt of such request. In case such request entails a modification of the agenda of the relevant general meeting of
shareholders, the Company will make an amended agenda available at the latest fifteen (15) days prior to the meeting.
The proposed amendments to the Company's articles of association set forth in the proposed resolution on item 3
of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders will, inter alia, amend the notice periods so as to be
in line with Article 4 of the Luxembourg Shareholders' Rights Law.
<i>Documentsi>
Copies of the proxy statement including, inter alia, relevant information with respect to the proposed initial business
combination with Electrawinds NV, together with a supplement to the proxy statement, inter alia, indicating the key dates
in connection with the July 20, 2012 annual general meeting of shareholders and extraordinary general meeting of sha-
reholders, the draft resolutions of the annual general meeting of shareholders and the extraordinary general meeting of
81610
L
U X E M B O U R G
shareholders as well as the documents submitted to the two general meetings of shareholders and the revised agendas,
if any, further to a requested addition in accordance with the above will be available on the Company's website
(www.ectse.com) as from June 19, 2012.
Upon request to info@ectse.com, copies of the abovementioned documents will be mailed to the shareholders.
<i>Share capital of the Companyi>
The Company's issued share capital is currently set at three hundred forty-five thousand euro (€345,000), represented
by (i) eleven million five hundred thousand (11,500,000) redeemable class A shares, (ii) nine hundred fifty-eight thousand
three hundred thirty-three (958,333) redeemable class B1 shares, (iii) nine hundred fifty-eight thousand three hundred
thirty-three (958,333) redeemable class B2 shares, and (iv) nine hundred fifty-eight thousand three hundred thirty-four
(958,334) redeemable class B3 shares.
Each share entitles the holder thereof to one vote.
<i>Right to participate in the meetingsi>
According to Article 5 of the Luxembourg Shareholders' Rights Law, the record date for general meetings of share-
holders of listed companies incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg has been set to fourteen
(14) days prior to the date of the corresponding general shareholders' meeting. Therefore, any shareholder who holds
one or more shares of the Company at midnight (24:00 (midnight) CEST), on July 6, 2012 (the "Record Date"), registers
by such time for the annual general meeting of shareholders and the extraordinary general meeting of shareholders (see
under "-Registration for the meetings" below for more details) and, if applicable, timely furnishes the certificate specified
below, shall be admitted to participate and vote in the annual general meeting of shareholders to be held on July 20, 2012
at 11:00 CEST and the extraordinary general meeting of shareholders to be held on July 20, 2012 at 11:30 CEST. One of
the purposes of the proposal to the Company's shareholders to amend the articles of association of the Company (item
3 of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders) is to reflect changes brought along by the Luxem-
bourg Shareholders' Rights Law in the Company's articles of association, which currently provide for a record date falling
five (5) days prior to the date of the relevant general meeting of shareholders. For the avoidance of doubt, the fourteen
(14) days' period does prevail at all times over the five (5) days' period.
All shareholders wishing to participate (in person, or by voting through proxy or voting form) in the general meetings
of shareholders of the Company shall notify the Company thereof at the latest on the Record Date in writing by mail,
fax or by e-mail.
Class A shareholders (whose class A shares are held in book-entry form through the operator of a securities settlement
system or with a professional depositary or sub-depositary designated by such depositary) should request from such
operator or depositary or sub-depositary a certificate certifying the number of shares recorded in their account on the
Record Date.
To participate and vote in the annual general meeting of shareholders and/or the extraordinary general meeting of
shareholders, class A shareholders shall submit a copy of the certificate via their custodian bank by mail, by fax or by e-
mail to the Centralizing Agent of the Company in the period from July 6, 2012, 24:00 (midnight) CEST, until July 19, 2012
11:30 CEST. Shareholders having validly tendered their class A shares for redemption by providing a redemption notice
to the Company and transferring the shares tendered for redemption to the special account of the Company do not need
to register separately for the extraordinary general meeting of shareholders in respect of such shares (please refer to "-
Redemption process of class A shares" below for more details).
To participate and vote in the annual general meeting of shareholders and the extraordinary general meeting of sha-
reholders, class B shareholders shall submit a copy of their share certificate(s) by mail, fax or by e-mail in the period from
July 6, 2012, 24:00 (midnight) CEST, until July 19, 2012, 11:30 CEST, to the Centralizing Agent of the Company, being:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Attn.: TSS/GES, Post-IPO Services
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main, Germany
Fax: +49 69 910-38794
E-mail: dct.tender-offers@db.com
Any shareholder and/or proxyholder participating in the annual general meeting of shareholders and/or the extraor-
dinary general meeting of shareholders in person shall carry proof of identity at the annual general meeting of shareholders
and/or the extraordinary general meeting of shareholders.
<i>Registration for the meetingsi>
Shareholders wishing to participate in the annual general meeting of shareholders and/or the extraordinary general
meeting of shareholders need to register for these meeting(s) by submitting their registration by mail, fax or by e-mail
until July 6, 2012, 24:00 (midnight) CEST to the Centralizing Agent of the Company at the address referred to above.
Registration forms are provided on the website of the Company (www.ectse.com) which should be used. Shareholders
having registered for the meeting(s) may provide proxy or voting forms in case they do not wish to participate in person
in the meeting(s) until July 19, 2012, 11:30 CEST (see under "-Representation" below).
81611
L
U X E M B O U R G
<i>Representationi>
In the event that any shareholder appoints another person, shareholder or not, as his proxy to vote on his behalf, the
proxy must be submitted by mail, fax or by e-mail to the Centralizing Agent of the Company no later than July 19, 2012,
11:30 CEST.
Proxy forms provided on the website of the Company (www.ectse.com) may be used and only signed proxy forms
will be taken into account. One person may represent more than one shareholder. Shareholders having presented a
redemption notice do not need to provide a separate proxy (see under "-Redemption process of class A shares" below).
Holders of Public Shares who have registered for the annual general meeting of shareholders and/or the extraordinary
general meeting of shareholders (see under "-Registration for the meetings" above for more details) and have executed
a proxy but who wish to revoke such proxy may do so by timely delivery of a properly executed later-dated proxy or
revoking in writing the proxy in writing to the Centralizing Agent no later than on July 19, 2012, 11:30 CEST.
A proof of shareholding (see above under "-Right to participate in the meetings") together with the completed and
executed proxy form, if any, must be submitted to the Centralizing Agent of the Company by July 19, 2012, 11:30 CEST.
In case of a conflict of interest, the proxyholder shall disclose certain specified facts which may be relevant for the
undersigned in assessing any risk that the proxyholder might pursue any interest other than the interest of the undersigned.
For more information, see the proxy statement under "Questions and answers about the proposals for Public Sharehol-
ders-How do I vote?-Representation by proxy" available on the website of the Company (www.ectse.com).
<i>Voting formsi>
Each shareholder may also vote in the annual general meeting of shareholders and/or the extraordinary general meeting
of shareholders through a voting form. The voting form may be submitted by mail, by fax or by e-mail to the Centralizing
Agent of the Company no later than on July 19, 2012, 11:30 CEST and should be accompanied by a proof of shareholding
(see above under "-Right to participate in the meetings"). Only voting forms provided by the Company on its website
(www.ectse.com) may be used and only signed voting forms will be taken into account.
Please note that the vote in writing does not dispense a shareholder from the (additional) registration obligation
referred to above under "-Right to participate in the meetings".
Holders of Public Shares who have registered for the annual general meeting of shareholders and/or the extraordinary
general meeting of shareholders and have executed a voting form but who wish to revoke such voting form may do so
by timely delivery of a properly executed later-dated voting form or revoking the voting form in writing to the Centralizing
Agent no later than on July 19, 2012, 11:30 CEST.
<i>Redemption process of class A sharesi>
In the event a class A shareholder wishes to exercise his redemption rights in accordance with the articles of asso-
ciation, such class A shareholder shall follow the following procedure:
(i) a redemption notice shall be submitted via the relevant custodian bank by mail, fax or by e-mail to the Centralizing
Agent of the Company no later than at 24:00 (midnight) CEST on July 4, 2012. Only redemption notices provided by the
Company on its website (www.ectse.com) may be used and only signed redemption notices will be taken into account;
(ii) the class A shares tendered for redemption shall be transferred not later than at 18:00 CEST on July 4, 2012 to a
special account of the Company being the following:
Account number: 100 8828089 01
Account name: European CleanTech I S.E. Abwicklungsdepot für Aktienrückkauf-/Kaufoption
Name of Bank: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
BIC-Code: DEUTDEFF
Clearstream Banking AG, Frankfurt, participant number: 7003;
(iii) by submitting a redemption notice, a class A shareholder wishing to exercise his redemption rights grants a proxy
to Mr. Sven-Roger von Schilling, an A director of the Company with full power of substitution, instructing that such shares
shall be voted against all items of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders.
By signing the redemption notice, the respective class A shareholder acknowledges that he/she/it may be contacted
by a third party interested in acquiring the class A shares tendered for redemption. For more detailed information with
respect to the redemption price, please refer to the proxy statement available on the website of the Company
(www.ectse.com).
A class A shareholder having submitted his redemption notice to the Company may withdraw such redemption notice
in respect of all or a portion of the class A shares tendered for redemption by delivering a withdrawal notice via the
relevant custodian bank by mail, fax or by e-mail to the Centralizing Agent of the Company no later than on or prior to
July 19, 2012 at 11:30 (CEST). Only withdrawal notices in the form provided by the Company on its website
(www.ectse.com) may be used and only signed withdrawal notices will be taken into account. In case a redemption notice
is withdrawn, the shares will be returned to the account specified by the shareholder and will not be redeemed. To
participate in the general meeting, shareholders who have withdrawn their redemption notice do not need to register
for the general meeting separately, but need to provide a new form of proxy or voting form as described before in the
case they are not intending to attend the general meeting in person.
81612
L
U X E M B O U R G
Redemptions of class A shares are subject to the approval and the consummation of the initial business combination
of the Company with Electrawinds NV. If the initial business combination with Electrawinds NV is not consummated, the
tendered class A shares will be returned to the account specified by the shareholders who have tendered them for
redemption.
<i>Languagei>
The meeting will be held in English language.
Luxembourg, in June 2012.
For the management board of the Company.
Référence de publication: 2012070626/250/239.
Omnium Textile S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 3.329.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>16 juillet 2012i> à 10.00 heures, pour
délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire,
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice
clos au 31 décembre 2011,
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Nominations statutaires,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012071982/19.
Alfred Berg, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 145.536.
The STATUTORY GENERAL MEETING
will be held on Friday, <i>July 20, 2012i> at 2:00 p.m., at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, building
H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate on
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the report of the Board of Directors and of the auditors;
2. Approval of the accounts for the financial period closed as at March 31, 2012 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares,
at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned
in the prospectus.
The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of
their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the
Meeting.
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will
be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012072708/755/26.
81613
L
U X E M B O U R G
Mecca World Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 12, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 162.735.
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société MECCA WORLD GROUP S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue extraordinairement qui se tiendra au 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg, le <i>17 juillet 2012i> à 10,00 heures
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Evolution de la société;
2. Projet de comptes annuels au 31.12.2011;
3. Divers.
<i>Le Commissaire.i>
Référence de publication: 2012074625/15.
Eclipp L, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 146.928.
The STATUTORY GENERAL MEETING
will be held at 2.00 p.m on <i>Friday July 20, 2012i> at the premises of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, sis
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the report of the Board of Directors and of the auditors;
2. Approval of the accounts for the financial period closed as at March 31, 2012 and allocation of the results;
3. Discharge to the directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares,
at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned
in the prospectus.
The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of
their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the
Meeting.
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will
be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
<i>THE BOARD OF DIRECTORS.i>
Référence de publication: 2012072709/755/25.
Ancolie Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 41.913.
Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des Actionnaires qui aura lieu exceptionnellement le mercredi <i>18 juillet 2012i> à 11.00 heures à Luxembourg, au siège
social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle
du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
2. Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2011 et du compte de profits et pertes y relatifs; affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31
décembre 2011.
81614
L
U X E M B O U R G
4. Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
<i>Le conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012073815/34/19.
Ana Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 75.064.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>17 juillet 2012i> à 10.00 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012075293/755/18.
Allegro Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 20, Wengertswee.
R.C.S. Luxembourg B 136.148.
<i>Extrait des résolutions de la société, prises en date du 4 juin 2012i>
L'actionnaire unique décide de réélire Ernst & Young S.A., avec adresse au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la société, pour une période prenant fin à la date à laquelle l'actionnaire
unique prendra ses résolutions sur les comptes annuels de la société pour l'année financière se terminant le 31 décembre
2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 13 juin 2012.
Manuel Hauser.
Référence de publication: 2012069225/14.
(120099310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.
Energy Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 114.836.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société, prises en date du 12 juin 2012i>
L'actionnaire unique de la société, Allegro S.à r.l., enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B136.517 et dont le siège social est au 23, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, décide de réélire Ernst
& Young S.A., avec adresse au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, en qualité de réviseur d'entreprises agréé de
la société, pour une période prenant fin à la date à laquelle l'actionnaire unique prendra ses résolutions sur les comptes
annuels de la société pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 12 juin 2012.
Allegro S.à r.l.
Référence de publication: 2012068111/16.
(120097287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
81615
L
U X E M B O U R G
Allegro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 136.517.
<i>Extrait des résolutions de l’actionnaire unique de la société, prises en date du 12 juin 2012i>
L'actionnaire unique de la société, Allegro Group S.à r.l., enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B136148 et dont le siège social est à 20, Wengertswee, L-5485 Wormeldange-Haut, Lu-
xembourg, décide de réélire Ernst & Young S.A. avec adresse au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, en qualité
de réviseur d'entreprises agréé de la société, pour une période prenant fin à la date à laquelle l'actionnaire unique prendra
ses résolutions sur les comptes annuels de la société pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 12 juin 2012.
Allegro Group S.à r.l.
Référence de publication: 2012067947/16.
(120096799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Energy Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 114.836.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 12 juin 2012.
<i>Pour Allegro S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012067437/11.
(120096683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2012.
Allegro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 136.517.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 12 juin 2012.
<i>Pour Allegro S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012067283/11.
(120096684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2012.
Selection F, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de SELECTION F a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. / BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme / Société Anonyme
<i>Société de gestion / Banque Dépositaire
i>Dieter HEIN / Guy WAGNER / Nadine SCHAACK / Michèle BIEL
<i>Directeur / Administrateur Directeur / Fondée de Pouvoir / Conseiller de la Directioni>
Référence de publication: 2012077601/12.
(120110480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2012.
AllianceBernstein Institutional Investments, Fonds Commun de Placement.
CLOSURE NOTICE
The Board of Managers of the Company decided to close the following sub-funds of AllianceBernstein Institutional
Investments:
81616
L
U X E M B O U R G
- AllianceBernstein Institutional Investments - High Yield Loan Portfolio (JPY) as of 12 March 2012;
- AllianceBernstein Institutional Investments - Global Plus Fixed Income Portfolio (CHF) as of 22 May 2012.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à. r.l.
<i>The Board of Managersi>
Référence de publication: 2012078303/5937/11.
Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 71.182.
NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
The Board of Directors of Allianz Global Investors Fund (SICAV) announces that the following funds have been merged
into the Sub-Fund Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM European Equity Dividend of the Company as of 16 May
2012.
ISIN
WKN
Fund Name
Share Class Status
LU0391761227 A0Q5M1 Aktien Deutschland "Wait or Go"
A (EUR)
Merging Fund
LU0257507052 A0J4LV
Fondak Europa
A (EUR)
Merging Fund
LU0257505866 A0J4LX
Fondak Europa
P (EUR)
Merging Fund
LU0414045582 A0RF5F
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM European Equity
Dividend
A (EUR)
Receiving Fund
LU0257506328 A0J4LW
Fondak Europa
W2 (EUR) Merging Fund
LU0414047281 A0RF5U
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM European Equity
Dividend
IT (EUR)
Receiving Fund
As a result of the merger the funds Aktien Deutschland "Wait or Go" and Fondak Europa were liquidated.
Senningerberg, July 2012.
<i>By order of the Board of Directors
i>Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012080723/755/25.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 27.856.
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER
Der Verwaltungsrat der Allianz Global Investors Luxembourg S.A. (die "Verwaltungsesellschaft") gibt bekannt, dass
per 16. Mai 2012 die folgenden Fonds in den Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM European Equity
Dividend der Allianz Global Investors Fund (SICAV) verschmolzen wurden:
ISIN
WKN
Fondsname
Anteil-
klasse
Status
LU0391761227
A0Q5M1
Aktien Deutschland "Wait or Go"
A (EUR)
untergegangener
Fonds
LU0257507052
A0J4LV
Fondak Europa
A (EUR)
untergegangener
Fonds
LU0257505866
A0J4LX
Fondak Europa
P (EUR)
untergegangener
Fonds
LU0414045582
A0RF5F
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM European
Equity Dividend
A (EUR) aufnehmender
Fonds
LU0257506328
A0J4LW
Fondak Europa
W2
(EUR)
untergegangener
Fonds
LU0414047281
A0RF5U
Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM European
Equity Dividend
IT (EUR)
aufnehmender
Fonds
Aufgrund der Verschmelzung wurden die Fonds Aktien Deutschland "Wait or Go" und Fondak Europa aufgelöst.
Senningerberg, Juli 2012.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft.i>
Référence de publication: 2012080746/755/33.
81617
L
U X E M B O U R G
International Real Estate Portfolio 08/09 - FTL S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous
la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque,
(anc. International Real Estate Portfolio 08/09 - ITM S.C.A., SICAR).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 143.502.
Im Jahre zweitausendzwölf, am einunddreißigsten Mai.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,
sind die Aktionäre der International Real Estate Portfolio 08/09 - ITM S.C.A., SICAR (die "Gesellschaft") mit Sitz in 18,
Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 143502,
zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die „Außerordentliche Generalversammlung") zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde am 8. Dezember 2008 gemäß notarieller Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit dem
Amtssitz in Luxemburg, gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
vom 7. Januar 2009 veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt am 28. Dezember 2010, in der berichtigten Fassung vom
16. März 2011, geändert und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 13. Mai 2011 veröffentlicht.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Francis Kass, Rechtsanwalt, ansässig in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Jennifer Burr, Rechtsanwältin, ansässig in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Anika Ratzmann, Rechtsanwältin, ansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
1. Kenntnisnahme der Umstrukturierung des Komplementärs, „Institutional Trust Management Company S.à r.l.", von
einer Société à responsabilité limitée (S.à r.l.) in eine Société anonyme (S.A.) und Namensänderung des Komplementärs
von „Institutional Trust Management Company S.à r.l." in „Feri Trust (Luxembourg) S.A.".
2. Mit Punkt 1 einhergehende Namensänderung der Gesellschaft von „International Real Estate Portfolio 08/09 - ITM
S.C.A., SICAR" in „International Real Estate Portfolio 08/09 - FTL S.C.A., SICAR".
3. Als Folge der vorhergehenden Punkte, Änderung der folgenden Artikel der Satzung:
- Artikel 1 Absatz 1 (Name): Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft.
- Artikel 5 Absatz 1 (Haftung): Änderung der Bezeichnung des Komplementärs.
- Artikel 16 Absatz 1 und 2 (Komplementär): Änderung der Bezeichnung des Komplementärs.
II. Gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915") ist
die Außerordentliche Generalversammlung nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten ist. Ferner sind nach dieser Vorschrift Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der Stimmen
der anwesenden oder vertretenen Aktionäre zu fassen.
III. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien
gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertre-
tern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten
Vertretern und dem amtierenden Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigefügt,
um mit ihr zusammen registriert zu werden.
IV. Da ausschließlich Namensaktien im Umlauf sind, erfolgte die Einberufung zu dieser Außerordentlichen General-
versammlung am 24. April 2012 per Einschreiben an alle Aktionäre.
V. Aus der Anwesenheitsliste und dem Auszug aus dem Aktionärsregister geht hervor, dass von den 13.765,699 Aktien,
die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, 13.582,721 Aktien in dieser Außerordentlichen Generalver-
sammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.
VI. Demnach wurde das für eine Satzungsänderung gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes von 1915 gesetzlich vorges-
chriebene Anwesenheitsquorum von 50% des Gesellschaftskapitals erreicht, die Außerordentliche Generalversammlung
der Gesellschaft ist daher beschlussfähig und kann über die vorhandene Tagesordnung beraten und beschließen.
Nach Beratung fasst die Außerordentliche Generalversammlung folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Außerordentliche Generalversammlungnimmt die Umstrukturierung des Komplementärs der Gesellschaft „Insti-
tutional Trust Management Company S.à r.l." von einer Société à responsabilité limitée (S.à r.l.) in eine Société anonyme
(S.A.) und die Namensänderung des Komplementärs von „Institutional Trust Management Company S.à r.l." in „Feri Trust
(Luxembourg) S.A." zur Kenntnis.
81618
L
U X E M B O U R G
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, als Folge des vorhergehenden Beschlusses, den Namen der
Gesellschaft von „International Real Estate Portfolio 08/09 - ITM S.C.A., SICAR" in „International Real Estate Portfolio
08/09 - FTL S.C.A., SICAR" zu ändern.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, als Folge der vorhergehenden Beschlüsse, Artikel 1 Absatz 1,
Artikel 5 Absatz 1 sowie Artikel 16 Absatz 1 und 2 der Satzung zu ändern. Die zuvor genannten neugefassten Artikel der
Satzung lauten wie folgt:
Art. 1. (Absatz 1). Name. Hiermit wird zwischen vorbenannten Parteien und denjenigen, die in Zukunft Inhaber aus-
zugebender Aktien (die „Aktien") werden, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in der Form einer Investment-
gesellschaft zur Anlage in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque, SICAR) unter dem Namen
International Real Estate Portfolio 08/09 - FTL S.C.A., SICAR (die „Gesellschaft") gegründet.
Art. 5. (Absatz 1). Haftung. Die Feri Trust (Luxembourg) S.A. ist Komplementär der Gesellschaft (der „Komplemen-
tär"). Als solches ist er Geschäftsführer (gérant) und Aktionär der Gesellschaft. Er hält eine Aktie - die „Komplementär-
saktie" -, die nicht übertragbar ist und weder zu Dividendenzahlungen noch zu Kapitalrückführungen berechtigt. Der
Komplementär haftet persönlich und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht aus deren Ver-
mögen bezahlt werden können.
Art. 16. (Absatz 1 und 2). Komplementär. Die Gesellschaft wird von der Feri Trust (Luxembourg) S.A. als Komple-
mentär geführt.
Der Komplementär ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach Luxemburger Recht. Der Komplementär besitzt
die umfassende Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, soweit das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Gesellschaft
nicht ausdrücklich bestimmte Befugnisse der Hauptversammlung vorbehält.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. KASS, J. BURR, A. RATZMANN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juin 2012. Relation: LAC/2012/25799. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 25. Juni 2012.
Référence de publication: 2012074919/87.
(120105827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2012.
MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 166.043.
Par résolutions signées en date du 5 juin 2012, l’associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:
1. changement de classe de mandat de Mme Rosa VILLALOBOS de «gérant de classe A» à «gérant» de la Société;
2. changement de classe de mandat de M. Philip HOGAN de «gérant de classe B» à «gérant» de la Société;
3. changement de classe de mandat de M. Hilko SCHOMERUS de «gérant de classe B» à «gérant» de la Société;
5. nomination de M. Charles ROEMERS, né le 15 mars 1965 à Moresnet (Belgique), ayant son adresse professionnelle
au 37, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée
illimitée;
6. nomination de M. Jean-François TRAPP, né le 15 juillet 1975 à Thionville (France), ayant son adresse professionnelle
au 37, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée
illimitée.
Dès lors, le conseil de gérance se compose ainsi:
Mme Rosa VILLALOBOS
M. Philip HOGAN
M. Hilko SCHOMERUS
M. Charles ROEMERS
81619
L
U X E M B O U R G
M. Jean-François TRAPP
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012068937/26.
(120097850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Fortis Commercial Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 107.880.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 2 avril 2012i>
1. M. Olivier THIEBAUT a démissionné de son mandat d’administrateur.
2. M. Marcel HOH a démissionné de son mandat d’administrateur.
3. M. Yves MEHAUDENS a démissionné de son mandat d’administrateur.
4. M. Pierre DE CORTA a démissionné de ses mandats d’administrateur et président du conseil d’administration.
5. M. Jean-Claude SCHNEIDER, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 23
mars 1953, demeurant à L-6165 Ernster (Grand-Duché de Luxembourg), 7B, rue Principale, a été nommé administrateur
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2015.
6. M. Jean PFEIFFENSCHNEIDER, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 7
octobre 1958, demeurant à L-2550 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 66, avenue du X Septembre, a été
nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2015.
7. M. Luc HENRARD, administrateur de sociétés, né à Etterbeek (Belgique), le 24 février 1956, demeurant à L-1952
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 9, rue Nina et Julien Lefèvre, a été nommé administrateur jusqu’à l’issue
de l’assemblée générale statutaire de 2015.
8. M. Yves MEHAUDENS, administrateur de sociétés, né à Courtrai (Belgique), le 21 novembre 1965, demeurant à
B-6001 Charleroi, 154, avenue Mascaux, a été nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de
2015.
9. M. Marcel HOH, administrateur de sociétés, né à Strasbourg (France), le 14 avril 1954, demeurant à L-1933 Lu-
xembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 41, rue Siggy Vu Letzebuerg, a été nommé administrateur jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale statutaire de 2015.
Luxembourg, le 14 juin 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Fortis Commercial Finance S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012069437/31.
(120098705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.
Deutschland Property Partners, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 169.287.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the eleventh day of May.
Before the undersigned, Me Francis Kesseler, a notary resident in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
RHC Partners LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, according to the
records of the Secretary of the state of Delaware under the organisational number 0466405, having its registered office
at Trolley Square, Suite 20C, Wilmington, New Castle County, Delaware 19806, United States,
here represented by Julia von der Osten, Rechtsanwaltin, whose professional address is 18-20, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 11 May 2012.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
81620
L
U X E M B O U R G
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "Deutschland Property Partners" (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg-city, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-
ferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in
the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed
for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company shall in particular be appointed
and act as the managing general partner (associé commandité gérant) of DB Deutschland Property Partners S.C.A., a
corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions). The Company may in particular acquire,
by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial
instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty one thousand euros (EUR 31,000.-), represented by thirty one thousand (31,000)
shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
81621
L
U X E M B O U R G
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle
shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as
if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager or, in case
one or several class A managers and one or several class B managers have been appointed, by the joint signature of any
class A manager and any class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted
at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
81622
L
U X E M B O U R G
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (the Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the time line fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the time line fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by its managers) and shareholder(s) to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following
the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or(b) by way of Written Share-
holders' Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. The annual General Meeting (if held) shall be held at the registered office or at any other place within the
municipality of the registered office, as specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 11.00 a.m..
If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
81623
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2012.
<i>Subscription and Paymenti>
Round Hill Capital LLC, represented as stated above, subscribes for represented by thirty one thousand (31,000)
shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution
in cash of thirty one thousand euros (EUR 31,000.-).
The amount of thirty one thousand euros (EUR 31,000.-) is at the Company's disposal.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand six hundred euro (€ 1,600.-).
81624
L
U X E M B O U R G
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Johanna van Oort, director, born on 28 February 1967 at Groningen, with professional address in 13-15 avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg,
- Joost Tulkens, director, born on 26 April 1973 at Someren, with professional address in 13-15 avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, and
- Antje Lubitz, manager, born on 14 January 1973 in Berlin, with personal address in Schulzendorf, Helgolandstrasse
7, Germany.
2. The registered office of the Company is located at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le onzième jour de mai,
Par devant le soussigné M
e
Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Round Hill Capital LLC, une société régie par les lois de l'Etat du Delaware, inscrite sous le numéro 0466405 confor-
mément au registre du secrétaire d'état de l'Etat du Delaware, dont le siège social se situe à Trolley Square, Suite 20C,
Wilmington, New Castle County, Delaware 19806, United States
représentée par Julia von der Osten, Rechtsanwaltin, avec adresse professionnelle à 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 11 mai 2012.
Après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite
procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Deutschland Property Partners" (la Société). La Société est une
société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société sera en particulier désignée et
agira en tant qu'associé gérant commandité de DB Deutschland Property Partners S.C.A., une société en commandite
par actions. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres,
actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et
plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut
participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre
81625
L
U X E M B O U R G
investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque
nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société sœur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés
sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et un mille parts sociales
sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à
la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et
un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au
Luxembourg.
81626
L
U X E M B O U R G
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la
condition qu'un ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au
moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont
consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous
les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou partout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation.
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant, ou si les associés
ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, par les signatures conjointes d'un
gérant de classe A et d'un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont
adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (les Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
81627
L
U X E M B O U R G
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérants et du ou des associé(s) envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
13.5. L'Assemblée Générale annuelle (si elle a lieu) se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la
municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 11
heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.
Art. 14. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
81628
L
U X E M B O U R G
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux
réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Round Hill Capital LLC, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trente et un mille (31.000) parts
sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et de les libérer intégralement par
un apport en numéraire d'un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-).
Le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la disposition de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille six cents euros (€ 1.600,-).
<i>Résolution de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Johanna van Oort, administrateur, née le 28 février 1967 à Groningen, ayant son adresse professionnelle au 13-15
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
- Joost Tulkens, administrateur, né le 26 avril 1973 à Someren, ayant son adresse professionnelle au 13-15 avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, et
- Antje Lubitz, gérant, né le 14 janvier 1973 à Berlin, Schulzendorf, Helgolandstrasse 7, Allemagne.
2. Le siège social de la Société est établi au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: von der Osten, Kesseler.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 16 mai 2012. Relation: EAC/2012/6293. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
81629
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012068087/507.
(120097252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Saltri HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 143.913.
L'addresse professionnel de Lars Frankfelt a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Saltri HoldCo S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068447/11.
(120097422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Alcubo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 133.080.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mil douze, le cinq juin.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société ALCUBO S.A., en liquidation, une société
anonyme ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée en date du 15 octobre
2007 suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2753 du 29 novembre 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, à la section B, sous le numéro 133080.
La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentaire en date du 30 novembre 2011 comprenant
nomination d'ODESSA SECURITIES S.A., ayant son siège social à Panama, Salduba Building, 53
rd
Street East, en tant que
liquidateur.
CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à r.l., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a
été nommée commissaire de contrôle à la liquidation par acte sous seing privé en date du 15 mai 2012.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant pro-
fessionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le Président nomme comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, demeurant professionnel-
lement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Audrey LEITIENNE, employée privée, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour
l'exécution de leurs mandats respectifs.
3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instru-
mentaire, resteront aussi annexées au présent acte.
III) Il appert de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont
présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
81630
L
U X E M B O U R G
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, approuve ledit
rapport ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le
notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au
commissaire de contrôle à la liquidation pour l'exercice de leurs mandats respectifs.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au
siège de CF Corporate Services, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés ou aux créanciers
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il appar-
tiendra.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition du présent acte en vue de clôturer les
comptes de la Société et d'accomplir toutes les formalités.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ mille deux cents euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. PONSARD, C. GRUNDHEBER, A. LEITIENNE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juin 2012. LAC/2012/26172. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012068617/76.
(120098338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Antinéum SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 155.096.
L’an deux mille douze, le quatre juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANTINEUM S.A. (RCS
B155096) ayant son siège social 7 rue d'Amsterdam L-1126 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo
Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire instrumentant, en date du 11 août 2010,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2125 du 8 octobre 2010.
La séance est ouverte sous la présidence de M. Raymond Goebel, docteur en droit, dont l'adresse professionnelle est
à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur, Madame Johana BODART, employée privée, dont l'adresse
professionnelle est à Luxembourg.
Le Président expose ensuite:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signée par le président, le secrétaire et le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence
81631
L
U X E M B O U R G
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregis-
trement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les TROIS CENT VINGT CINQ (325) actions représentant
l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social de L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam à L-2633 Senningerberg, 6a Route de Trèves et
modification afférente de l'article 3 alinéa 1
er
des statuts.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1126 Luxembourg, 7 rue d'Amsterdam à
L-2633 Senningerberg, 6A, Route de Trèves et de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:
« Art. 3. Alinéa 1
er
: Le siège social est établi à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signés avec Nous, notaire la présente
minute.
Signé: R. GOEBEL, J. BODART et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juin 2012. Relation: LAC/2012/26033. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 juin 2012.
Référence de publication: 2012069230/44.
(120098755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.
Servus Group HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 142.857,15.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.588.
L’addresse professionnel de Lars Frankfelt a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Servus Group Holdco S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068453/11.
(120096893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Plastiche S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 64.244.
In the year two thousand and twelve, on the fifth day of June.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "PLASTICHE SA.", a “société anonyme”, having its
registered office at L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame, R.C.S. Luxembourg section B number 64244, incorporated
by deed enacted by Maître Marthe Thyes-Walch on the 17
th
of April 1998, published in the Memorial C number 524 of
the 17
th
of July 1998.
The meeting is presided by Mr Benoît Parmentier, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Eric Thibesard, with professional address
in Luxembourg.
The chairman requests the notary to record that:
81632
L
U X E M B O U R G
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the one million three hundred fifty nine thousand four hundred sixty seven
(1,359,467) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- Restatement of the article 12 of articles of association to be read as follows in English and French version:
“Vis-à-vis third parties, barring special delegation by the board of directors, all acts not pertaining to the daily mana-
gement of the Company and representing a commitment for the Company, such as but not limited to the purchase and
sale of financial fixed assets, the granting of corporate guarantees, the incorporation of private or commercial companies,
and powers of attorney regarding such acts shall be validly signed by two directors, one of whom shall always be Ravago
Management S.à r.l.”
“Vis-à-vis des tiers, sauf délégation spéciale du Conseil d’Administration, tout acte ne concernant pas la gestion quo-
tidienne de la société et engageant la société, tel que mais non limité à l'achat et la vente d’actifs financiers immobilisés,
l'octroi de garanties, la constitution de sociétés civiles ou commerciales, et les procurations concernant de tels actes
seront valablement signées par deux administrateurs , dont obligatoirement Ravago Management S.à r.l.”
2.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>Sole resolutioni>
The meeting decides to restate the article 12 of the articles of incorporation to be read as follows:
“Vis-à-vis third parties, barring special delegation by the board of directors, all acts not pertaining to the daily mana-
gement of the Company and representing a commitment for the Company, such as but not limited to the purchase and
sale of financial fixed assets, the granting of corporate guarantees, the incorporation of private or commercial companies,
and powers of attorney regarding such acts shall be validly signed by two directors, one of whom shall always be Ravago
Management S.à r.l.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille douze le cinq juin,
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PLASTICHE S.A.", ayant son
siège social situé à L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous la section B 64.244 constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, en date du 17 avril
1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 524 en date du 17 juillet 1998.
L'assemblée est présidée par Monsieur Benoît Parmentier.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Thibesard.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les un million trois cent cinquante neuf mille quatre cent soixante sept
(1.359.467) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale ex-
traordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Refonte de l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante en anglais et en français
81633
L
U X E M B O U R G
“Vis-à-vis third parties, barring special delegation by the board of directors, all acts not pertaining to the daily mana-
gement of the Company and representing a commitment for the Company, such as but not limited to the purchase and
sale of financial fixed assets, the granting of corporate guarantees, the incorporation of private or commercial companies,
and powers of attorney regarding such acts shall be validly signed by two directors, one of whom shall always be Ravago
Management S.à r.l.”
“Vis-à-vis des tiers, sauf délégation spéciale du Conseil d’Administration, tout acte ne concernant pas la gestion quo-
tidienne de la société et engageant la société, tel que mais non limité à l'achat et la vente d’actifs financiers immobilisés,
l'octroi de garanties, la constitution de sociétés civiles ou commerciales, et les procurations concernant de tels actes
seront valablement signées par deux administrateurs, dont obligatoirement Ravago Management S.à r.l.”
2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide de refondre l’article 12 pour lui donner la teneur suivante:
Article XII “Vis-à-vis des tiers, sauf délégation spéciale du Conseil d’Administration, tout acte ne concernant pas la
gestion quotidienne de la société et engageant la société, tel que mais non limité à l'achat et la vente d’actifs financiers
immobilisés, l'octroi de garanties, la constitution de sociétés civiles ou commerciales, et les procurations concernant de
tels actes seront valablement signées par deux administrateurs , dont obligatoirement Ravago Management S.à r.l.”
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: B. PARMENTIER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 juin 2012. Relation: LAC/2012/26161. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
Référence de publication: 2012069709/97.
(120098929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.
Sevens Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 152.113.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012068455/10.
(120098039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Codelem Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 108.069.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue au siège social de la Société le 7 juini>
<i>2012.i>
Lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social de la Société le 7 juin 2012, il a été décidé de:
1. réélire, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir en l'année 2013 pour statuer sur l'approbation
des comptes annuels au 31 décembre 2012, les administrateurs de la Société, à savoir:
- Monsieur Vincent GOY, résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
- Monsieur Eric BIREN, résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg; et
- Madame Marie-Rose LUGLI, résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg.
2. réélire Madame Monique Tommasini, résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société, pour une période venant à expiration à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir en l'année 2013 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels
au 31 décembre 2012.
81634
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012068676/23.
(120098525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Atelier de Menuiserie Heusbourg Frères S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-9641 Brachtenbach, Maison 46.
R.C.S. Luxembourg B 94.172.
L'an deux mille douze, le six juin.
Pardevant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux.
ont comparu:
1.- Madame Marie Rose HEUSBOURG, salariée, née à Wiltz, le 08 octobre 1955, demeurant à L-9641 Brachtenbach,
maison 43.
2.- Madame Eve MILBERT, sans état, née à Noertrange, le 12 avril 1933, demeurant à L-9641 Brachtenbach, maison
53.
3.- Monsieur Lucien THILLENS, demeurant à L9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges
agissant au nom de
Madame Irène THILMANY, sans état, née à Luxembourg, le 27 décembre 1940, demeurant à CH-5615 Fahrwangen,
6 Stickiweg.
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 06 octobre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée aux présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Suite aux décès des Messieurs Alphonse HEUSBOURG, Antoine HEUSBOURG, Aloyse HEUSBOURG et Félix HEUS-
BOURG, ci-après mentionnés, les comparantes, représentés comme dit, sont seules et et uniques associées de la société
en commandite simple “ATELIER DE MENUISERIE HEUSBOURG FRÈRES”(1982 2100 239) avec siège social à L- 9641
Brachtenbach, maison 46;
constituée suivant acte sous seing privé du 25.02.1962, enregistré à Wiltz, le 28.02.1962, volume 146, folio 70, case 2,
publié au Recueil Spécial du Mémorial C No 21 du 17 mars 1962;
modifiée par acte sous seing privé du 27.10.1975, enregistré à Luxembourg, le 31.10.1975, volume 309, folio 15, case
3, publié au Recueil Spécial du Mémorial C N0 27 du 11 février 1976;
modifiée une dernière fois par acte sous seing privé du 31 décembre 1982, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier
1983, volume 353, folio 49, case 5, publié au Recueil Spécial du Mémorial C N0 57 du 19 mars 1983. RCS B94172
Lequelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1.- constatation de la répartition des parts de la société suite au décès des Messieurs Alphonse HEUSBOURG, Antoine
HEUSBOURG, Aloyse HEUSBOURG et Félix HEUSBOURG
2.- nomination d'un gérant
3.- cession de part
4.- divers.
Les associées ont ensuite abordé l'ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
Suite au décès de Monsieur Alphonse HEUSBOURG en date du 08/01/1982 ses soixante-quinze parts (75) appartien-
nent à Madame Marie Rose HEUSBOURG, prénommée.
Suite au décès de Monsieur Antoine HEUSBOURG en date du 06/07/1995 ses soixante-quinze parts (75) appartiennent
à Madame Cathérine HEUSBOURG, et suite au décès de Madame Cathérine HEUSBOURG, en date du 04 mars 2008,
lesdites soixante-quinze parts appartiennent à Marie Rose HEUSBOURG, prénommée.
Suite au décès de Monsieur Aloyse HEUSBOURG en date du 18/05/2009 ses soixante-quinze parts (75) appartiennent
à Madame Eve MILBERT, prénommée.
Suite au décès de Monsieur Félix HEUSBOURG en date du 18/07/2010 ses soixante-quinze parts (75) appartiennent
à Madame Irène THILMANY, prénommée.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Antoine HEUSBOURG et Monsieur Aloyse HEUSBOLTRG étant décédés, ils sont revoqués comme gérants
avec décharge.
81635
L
U X E M B O U R G
Monsieur Serge LEONI, menuisier, né à Wiltz, le 17 février 1955, demeurant à L-9641 Brachtenbach, maison 63, et
Madame Marie-Rose HEUSBOURG, prénommée, sont nommés comme gérants de la société pour une durée illimitée.
La société sera valablement engagée jusqu'à 12.500,00.-€ par la signature individuelle d'un des gérants, au-delà, la signature
des deux gérants est requise.
<i>Troisième et Dernière résolutioni>
Madame Irène THILMANY, préqualifiée, déclare alors céder et transporter par les présentes sous les garanties de
droit:
- trente-sept (37) parts sociales à Monsieur Serge LEONI, prénommé.
- Trente-huit (38) parts sociales à Madame Rosy HEUSBOURG, sans état, née à Wiltz, le 12 octobre 1959, demeurant
à L-9641 Brachtenbach, maison 63.
Monsieur Serge LEONI et Madame Rosy HEUSBOURG sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de
ladite date et ils ont droit à partir de là aux revenus et bénéfices auxquels ces parts donnent droit et ils seront subrogé
dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.
Les cédants reconnaissent avoir reçu du cessionnaire le prix de la cessation avant les présentes dont quittance.
Monsieur Serge LEONI et Madame Marie-Rose HEUSBOURG, en leur qualité de gérant de ladite société déclarent au
nom de celle-ci, accepter la cession intervenue, le tout conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
En conséquence, l'art. 6 est modifié comme suit:
“ Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de sept mille quatre cent trente-six virgule quatre-vingt-un EUROS
(7.436,81.-€) divisé en trois cent (300) parts de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf EUROS (24,79.-€) chacune.
Il est attribué à:
Madame Marie Rose HEUSBOURG, prénommée, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 parts
Madame Eve MILBERT, prénommée, cent-treize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 parts
Madame Rosy HEUSBOURG, prénommée, trente-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 parts
Monsieur Serge LEONI, prénommé, trente-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 parts
Total des parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 parts»
DONT ACTE, fait et passé à Clervaux, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Heusbourg, Milbert, Leoni S., Heusbourg, L. Thillens, Martine Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 08 juin 2012. Relation: CLE/2012/642. Reçu soixante-quinze euros = 75,oo.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Rodenbour C.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre aux Firmes
Clervaux, le 11 juin 2012.
Martine WEINANDY.
Référence de publication: 2012069183/84.
(120098211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Regus International Services, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 158.073.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Regus No. 4, a limited liability company (Société à responsabilité limitée) incorporated in Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 158071, having its registered office at 26, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg,
here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Monaco under private seal on 24 May 2012; such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and
the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
This appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state that:
- That the private limited liability company “Regus International Services” (the “Company”), established under the
name Rickmansworth Property Holding (Luxembourg) S.à r.l. and having its registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 158073, was incorporated by deed
81636
L
U X E M B O U R G
of Maitre Carlo WERSANDT on 1 January 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 644 dated 5 April 2011,
- The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître
Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg, on 17 April 2012, not yet published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
- That the appearing party is the sole member (the "Sole Member") of the Company and that it has taken the following
resolutions:
<i>Resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The Sole Member decided to insert article 7.4 into the articles of incorporation of the Company as follows:
“ 7.4. The directors may decide to appoint a day-to-day manager (the “Manager”) of the Company, who shall have,
amongst other powers as may be decided from time to time by the directors, the power to act in the name and on behalf
of the Company, to carry out and approve all acts and operations falling within the scope of the business licence.”
<i>Second resolutioni>
The Sole Member decided to insert article 10.3 into the articles of incorporation of the Company as follows:
“ 10.3. The Company shall also be bound by the sole signature of the Manager in all matters relating to activities of
the Company falling within the scope of the business licence”.
Finally, the Sole Member decided to ratify any appointment of a Manager by the directors that may have occurred in
the past.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, this person signed together
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-neuf mai.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Regus No. 4, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158071, ayant son siège social au 26 Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg,
ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privé lui délivrée à Monaco le 24 mai 2012; laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur
par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
- Que la société à responsabilité limitée “Regus International Services” (la «Société»), établie et ayant son siège social
au 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, e été constituée sous le nom Rickmansworth Property Holding (Luxem-
bourg) S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, en date du premier janvier 2011, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 644 du 5 avril 2011 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 158073;
- Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par Maître Joseph Elvinger le 17 avril
2012, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
- La partie comparante est la seule associée actuelle (l' «Associée Unique») de la Société et qu'elle a pris, par son
mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'insérer l'article 7.4 dans les statuts de la Société comme suit:
81637
L
U X E M B O U R G
« 7.4. Les gérants peuvent décider de nommer un «délégué à la gestion journalière» (le «Gestionnaire») de la Société,
qui aura, entre autres pouvoirs qui peuvent être déterminés de temps à autre par les gérants, le pouvoir d'agir au nom
et pour le nom de la Société, de réaliser et approuver tous actes et opérations entrant dans le champ de la licence
d'exploitation.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'insérer l'article 10.3 dans les statuts de la Société comme suit:
« 10.3. La Société sera également engagée par la seule signature du Gestionnaire dans toutes les questions relatives
aux activités de la Société relevant du champ d'application de la licence d'exploitation.»
Enfin, L'Associé Unique a décidé de ratifier toutes nominations d'un Gestionnaire par les gérants qui se sont produites
dans le passé.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; et qu'à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: S. Lecomte, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1
er
juin 2012. Relation: LAC/2012/25087. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): I. Thill.
Référence de publication: 2012069727/97.
(120099161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.
Triton III LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.877.
Le siège social de Triton Fund III F&F L.P. a été transféré à 23-27 Seaton Place St Helier Jersey JE2 3QL.
<i>Pour Triton III LuxCo 1 S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012068524/11.
(120097416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
TIAA Lux 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 167.150.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 avril 2012.
Référence de publication: 2012068529/10.
(120097155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.
Agence Moneygram Metroplus Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 13, rue de Reims.
R.C.S. Luxembourg B 132.704.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
81638
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012068602/10.
(120098653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Alsina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 120.287.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2012.
.
Référence de publication: 2012068604/10.
(120098568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 150.964.
In the year two thousand and twelve, on the thirty-first of May;
Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1) Cargill International, Inc, a company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its
registered office at CT Corporation, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware, United States of America, under
number 4778502,
holder of two billion four hundred twenty-one million four hundred seventy-eight thousand one hundred eighty-six
(2,421,478,186) shares of the Company,
here represented by Ms. Anne MAUSKE, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on May 30, 2012,
2) Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., as described below,
temporary holder of four million four hundred twenty-four thousand four hundred sixty (4,424,460) shares of the
Company, but not entitled to vote,
here represented by Ms. Anne MAUSKE, prenamed, by virtue of a proxy, given on May 31, 2012,
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all the shareholders of Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l. (the “Company”), a société
à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
address at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 150.964 incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing
in Luxembourg, on January 25, 2010, published on March 4, 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 473. The articles of association of the Company have last been amended pursuant to a deed of Maître Martine
SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on May 10, 2012, not yet published in the Mémorial C.
The appearing parties representing the entire share capital of the Company and having waived any notice requirement
consider the following agenda:
<i>Agenda:i>
1) Reduction of the share capital of the Company by an amount of four million four hundred twenty-four thousand
four hundred sixty United States Dollars (USD 4,424,460) so as to reduce it from its current amount of two billion four
hundred twenty-five million nine hundred two thousand six hundred forty-six United States Dollars (USD 2,425,902,646
USD) to two billion four hundred twenty-one million four hundred seventy-eight thousand one hundred eighty-six United
States Dollars (USD 2,421,478,186) by cancellation of four million four hundred twenty-four thousand four hundred sixty
(4,424,460) shares that are temporarily held by the Company and subsequent amendment to article 5.1 of the Company's
articles of association.
2) Miscellaneous.
After having reviewed the items of the agenda, the appearing parties require the notary to enact the following reso-
lution:
81639
L
U X E M B O U R G
<i>Sole resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of four million
four hundred twenty-four thousand four hundred sixty United States Dollars (USD 4,424,460) so as to reduce it from
its current amount of two billion four hundred twenty-five million nine hundred two thousand six hundred forty-six
United States Dollars (USD 2,425,902,646 USD) to two billion four hundred twenty-one million four hundred seventy-
eight thousand one hundred eighty-six United States Dollars (USD 2,421,478,186) by cancellation of four million four
hundred twenty-four thousand four hundred sixty (4,424,460) shares, that are temporarily held by the Company.
As a consequence, the general meeting of shareholders resolves to amend article 5.1 of the Company's articles of
association which shall henceforth read as follows:
“ 5.1. the Company's share capital is set at two billion four hundred twenty-one million four hundred seventy-eight
thousand one hundred eighty-six United States Dollars (USD 2,421,478,186), represented by two billion four hundred
twenty-one million four hundred seventy-eight thousand one hundred eighty-six (2,421,478,186) shares having a par value
of one United States Dollar (USD 1) each.”
<i>Costsi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and
in case of discrepancy between the English and the French versions, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, known to the notary by name, first
name and residence, the said proxyholder of the persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trente et un mai.
Par-devant nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU:
1) Cargill International, Inc., une société constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège
social à CT Corporation, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis
d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, sous le numéro
4778502,
titulaire de deux milliards quatre cent vingt et un millions quatre cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-six
actions (2.421.478.186) actions, mais n'ayant pas le droit de voter,
ici représentée par Mademoiselle Anne MAUSKE, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée le 30 mai 2012,
2) Cargill International, Luxembourg 1 S.à r. l., telle que décrite ci-dessous,
titulaire temporaire de quatre millions quatre cent vingt-quatre mille quatre cent soixante (4.424.460) actions, mais
n'ayant pas le droit de vote,
ici représentée par Mademoiselle Anne MAUSKE, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 30 mai 2012.
Les procurations paraphées ne varietur par les mandataires des comparantes et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparantes sont les seules associées de la société Cargill International, Luxembourg 1 S.à r. l. (la « Société »),
une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 150.964 constituée selon acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à
Luxembourg, le 25 janvier 2010, publié le 4 mars 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 473.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de
résidence à Luxembourg, le 10 mai 2012, non encore publié au Mémorial C.
Les comparantes, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé à toute notification, ont
revu l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Réduction du capital social de la Société d'un montant de quatre millions quatre cent vingt-quatre mille quatre cent
soixante Dollars américains (USD 4.424.460) pour le réduire de son montant actuel, soit deux milliards quatre cent vingt-
81640
L
U X E M B O U R G
cinq millions neuf cent deux mille six cent quarante-six Dollars américains (USD 2.425.902.646) à deux milliards quatre
cent vingt et un millions quatre cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-six Dollars américains (USD 2.421.478.186)
par annulation de quatre millions quatre cent vingt-quatre mille quatre cent soixante (4.424.460) parts sociales, tempo-
rairement détenues par la Société, et modification corrélative de l'article 5.1 des statuts de la Société.
2) Divers.
Après avoir passé en revue les points figurant à l'ordre du jour, les comparantes ont demandé au notaire instrumentant
d'acter la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale des associés décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre millions
quatre cent vingt-quatre mille quatre cent soixante Dollars américains (USD 4.424.460) pour le réduire de son montant
actuel, soit deux milliards quatre cent vingt-cinq millions neuf cent deux mille six cent quarante-six Dollars américains
(USD 2.425.902.646) à deux milliards quatre cent vingt et un millions quatre cent soixante-dix-huit mille cent quatre-
vingt-six Dollars américains (USD 2.421.478.186) par annulation de quatre millions quatre cent vingt-quatre mille quatre
cent soixante 4.424.460 parts sociales, temporairement détenues par la Société.
En conséquence, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société comme
suit:
« 5.1. La Société a un capital social de deux milliards quatre cent vingt et un millions quatre cent soixante-dix-huit mille
cent quatre-vingt-six Dollars américains (USD 2.421.478.186,-), représenté par deux milliards quatre cent vingt et un
millions quatre cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-six (2.421.478.186) parts sociales ayant une valeur nominale
d'un Dollar américain (USD 1,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à sa charge à raison du présent acte est évalué environ à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire instrumentaire par
nom, prénom et demeure, la mandataire des comparantes a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. MAUSKE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juin 2012. LAC/2012/25385. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée.
Luxembourg, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012069315/132.
(120099009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.
Aforest Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4959 Bascharage, 43-45, ZAC Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 68.705.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012068613/9.
(120098667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Autodis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 18, Op der Drieschen, Zone Industrielle «Um Monkeler».
R.C.S. Luxembourg B 79.626.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 3 avril 2012i>
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Marc GRAAS, demeurant pro-
fessionnellement à 18, Zone Industrielle «Um Monkeler», Op der Drieschen L-4149 Esch/Alzette jusqu’à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
81641
L
U X E M B O U R G
L’assemblée constate que le dénomination de son réviseur d’entreprises agréé MAZARS, société enregistrée au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B56248, avec siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg, a été modifiée en FIDUO avec effet au 1
er
juillet 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2012068634/16.
(120098510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
ARAGON Service & Administration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 147.114.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendzwölf, den vierten Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz in Niederanven.
Sind erschienen:
1) Herr Manfred HELBACH, Wirtschaftsprüfer, geboren am 7. Oktober 1942 in Trier, wohnhaft in D-54296 Trier, 9,
Trebetastrasse (Deutschland),
2) Frau Adalina ZENT, geborene BROTZEL, Dipl. Dolmetscherin, geboren am 24. Februar 1964 in Duschanbe (Tad-
schikistan), wohnhaft in D-54298 Igel, 9, Schauinsland (Deutschland).
Die Komparenten erklären:
1) Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ARAGON Service & Administration S.à r.l., mit Sitz in L-5365
Munsbach, 1a, Parc d'Activité Syrdall, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B,
Nummer 147114, gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Paul DECKER, mit Amtssitz in
Luxemburg, am 23. Dezember 2010, veröffentlich im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 31. Juli 2009,
Nummer 1484.
2) Dass das Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von zwölftausendfünfhundert
EURO (12.500.-) hat, eingeteilt in zweihundertfünfzig (250) Anteile mit einem Nennwert von je fünfzig EURO (50.-).
3) Dass Herr Manfred HELBACH, vorbenannt, und Frau Adalina ZENT, geborene BROTZEL, vorbenannt, die einzigen
Eigentümer aller Gesellschaftsanteile sind.
4) Dass die vorgenannten Erschienenen, als einzige Gesellschafter ausdrücklich erklären, die Gesellschaft mit sofortiger
Wirkung auflösen zu wollen und sich als Liquidatoren zu bestimmen.
5) Dass die Erschienenen sofort die zweite und dritte ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft ein-
berufen, gemäss Artikel 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, und beide sofort
hintereinander abgehalten werden.
6) Dass die Erschienenen, in ihrer Eigenschaft als Liquidatoren, genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der
Gesellschaft ARAGON Service & Administration S.à r.l. besitzen, dass sämtliche Passiva beglichen wurde und dass die
Passiva in Verbindung mit der Gesellschaftsauflösung eingezahlt ist;
7) Dass Herr Manfred HELBACH und Frau Adalina ZENT, geborene BROTZEL, in ihrer Eigenschaft als einzige Ge-
sellschafter sich unwiderruflich verpflichten, das eventuelle Passiva der Gesellschaft, welche am heutigen Tage noch nicht
bekannt und nicht beglichen ist, durch sie beglichen wird; dass somit sämtliche Passiva der Gesellschaft beglichen ist.
8) Dass die etwaigen Aktiva den einzigen Gesellschaftern zugeteilt werden.
Der Liquidationsbericht, nachdem dieser „ne varietur" durch die Erschienenen und den unterzeichnenden Notar un-
terschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde zwecks Einregistrierung beigebogen.
Die Erschienenen ernennen zum Prüfungskommissar Herrn Norbert Ebsen, Buchhalter, geboren am 5. März 1969 in
Grevenmacher, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher, 7, Rue de l'Eglise, mit Auftrag den Liquidationsbericht zu überprüfen.
Nachdem die Erschienenen Kenntnis genommen haben vom Bericht des Prüfungskommissars, stimmen sie den
Schlussfolgerungen des Berichtes zu, heißen die Liquidationskonten und den Liquidationsbericht gut und erteilen Herrn
Norbert Ebsen Entlast für die Ausübung ihres Mandats.
Der Bericht des Prüfungskommissars, nachdem dieser „ne varietur" durch die Erschienenen und den unterzeichnenden
Notar unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde zwecks Einregistrierung beigebogen.
9) Dass sie in einer dritten ausserordentlichen Generalversammlung die Auflösung dieser Gesellschaft beschliessen,
welche damit definitiv abgeschlossen ist und die Gesellschaft nicht mehr existiert. Somit ist deren Liquidation mit Wirkung
auf den heutigen Tage beendet.
10) Dass sie dem Geschäftsführer Entlastung für die Ausübung seines Amtes erteilen.
81642
L
U X E M B O U R G
11) Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in D-54296
Trier, 9, Trebetastrasse aufbewahrt bleiben werden.
Für alle erforderlichen Schritte wird dem Eigner einer Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde, Vollmacht erteilt.
Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft festgestellt.
<i>Bevollmächtigungi>
Die Erschienenen erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichnenden Notars Spezialvollmacht, in ihren
Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Manfred Helbach, Adalina Zent geborene Brotzel, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 8 juin 2012. LAC/2012/26574. Reçu 75,- EUR.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole Frising.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 14. Juni 2012.
Référence de publication: 2012068625/65.
(120098669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
GP Capital, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8479 Eischen, 31, cité Bettenwiss.
R.C.S. Luxembourg B 141.944.
L’an deux mille douze, le septième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Monsieur Philippe-Benoît GENICOT, administrateur de sociétés, né le 28 mars 1976 à Etterbeek (Belgique), demeurant
au 31, Cité Bettenwiss, L-8479 Eischen,
ici représenté par Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant professionnellement au 560A, rue de Neudorf, L – 2220
Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Eischen.
La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui
suit:
- que Monsieur Philippe-Benoît GENICOT, précité est le seul actuel associé (l' «Associé Unique») de la société à
responsabilité limitée GP CAPITAL constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 10, Rue Neuve, L -8367 Hagen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 141944 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 septembre
2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2508 du 14 octobre 2008;
- que le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée
par cent (100) parts sociales, d'une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-).
Ensuite, la partie comparante, représentant l'intégralité du capital, a requis le notaire soussigné de constater les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 10, Rue Neuve, L -8367 Hagen au 31, Cité
Bettenwiss, L-8479 Eischen.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Associé Unique décide de modifier en conséquence la première phrase de l'article 5 des statuts de la société qui se
lira comme suit:
Art. 5. Première phrase . Le siège social est établi dans la commune de Hobscheid.
<i>Pouvoirsi>
Le comparant donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant
individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.
81643
L
U X E M B O U R G
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, même date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil
et résidence, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Renée Aakrann-Fezzo, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 08 juin 2012. LAC / 2012 / 26581. Reçu 75.-
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole Frising.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 14 juin 2012.
Référence de publication: 2012069487/45.
(120098737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.
Avaya International Enterprises Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège de direction effectif: L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 81.868.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012068635/14.
(120098818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Holden Recoveries S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 11.000,00.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 154.622.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2012.
Pour extrait conforme
Christophe Cahuzac
Référence de publication: 2012068817/13.
(120098447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
CLdN ro-ro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 103.758.
L'an deux mille douze, le treize juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée "CLdN ro-ro S.A.", ayant son siège
social à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, constituée sous la dénomination de "CONSEA S.A." aux termes d'un acte
reçu par Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 octobre 2004, publié au
Mémorial C numéro 25 du 11 janvier 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 103758.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, pré-
qualifiée, en date du 20 décembre 2010, publié au Mémorial C numéro 327 du 18 février 2011.
La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Michel JADOT, Ingénieur commercial et de
gestion, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine BERNARD, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
81644
L
U X E M B O U R G
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jozef ADRIAENS, employé privé, demeurant professionnellement à
L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux
ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de la société de EUR 200.000.000.-pour le porter de EUR 26.691.751,61 à EUR
226.691.751,61 sans création ni émission d’actions nouvelles.
2. Réduction de capital d'un montant de EUR 47.091.751,61 par incorporation des pertes reportées ainsi que par une
partie des résultats de l'exercice au 31 décembre 2011, de façon à réduire le capital de son montant actuel de EUR
226.691.751,61 à la somme de EUR 179.600.000.-.
3. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
B) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objet portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 200.000.000.- (deux cent millions
d'euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 26.691.751,61.-(vingt-six millions six cent quatre-vingt-onze mille
sept cent cinquante et un euros et soixante et un cents) à EUR 226.691.751,61 (deux cent vingt-six millions six cent
quatre-vingt-onze mille sept cent cinquante et un euros et soixante et un cents), sans création ni émission d'actions
nouvelles, par un apport en espèces par l'actionnaire unique existant.
Le montant de l'augmentation de capital de EUR 200.000.000.- (deux cents millions d'euros) est libéré à concurrence
de EUR 80.000.000.- (quatre-vingt millions d'euros), ce dernier montant se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 47.091.751,61 (quarante-sept millions
quatre-vingt-onze mille sept cent cinquante et un euros et soixante et un cents) pour le ramener de son montant actuel
de EUR 226.691.751,61 (deux cent vingt-six millions six cent quatre-vingt-onze mille sept cent cinquante et un euros et
soixante et un cents), à la somme de EUR 179.600.000.(cent soixante-dix-neuf millions six cent mille euros).
Cette réduction de capital sera réalisée par incorporation des pertes reportées ainsi que par une partie des résultats
de l'exercice au 31 décembre 2011 pour un montant total de EUR 47.091.751,61 (quarante-sept millions quatre-vingt-
onze mille sept cent cinquante et un euros et soixante et un cents).
La preuve de l'existence des pertes reportées ainsi que par une partie des résultats a été donnée au notaire instru-
mentant par un bilan établi au 31 décembre 2011.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la résolution prise ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
« Art. 3. Le capital social est fixé à CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLIONS SIX CENT MILLE EUROS (EUR
179.600.000.-), représenté par CENT SOIXANTE-SEPT (167) actions, sans désignation de valeur nominale.»
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société et sont estimés
approximativement à 6.700.- EUR.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,
prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.Jadot, M.-R.Bernard, J.Adriaens, Moutrier Blanche
81645
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 juin 2012. Relation: EAC/2012/7586. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2012.
Référence de publication: 2012069349/78.
(120099185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.
Barclays European Infrastructure Projects S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 134.027.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64405 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012068641/10.
(120098813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Cencan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 23.451.
Il est porté à la connaissance de tous que la dénomination du réviseur d’entreprises agréé, à savoir, DELOITTE S.A.,
a fait l'objet d'un changement.
La nouvelle dénomination est la suivante:
DELOITTE AUDIT S.À R.L.
560, Rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012068689/16.
(120098532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
db PrivatMandat Comfort, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 101.715.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2012i>
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Klaus-Michael Vogel als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Ge-
neralversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Klaus-Michael Vogel als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen
Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Manfred Bauer als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die General-
versammlung beschließt, das Mandat von Herrn Manfred Bauer als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.
Die Generalversammlung bestätigt Herrn Michael Koschatzki als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Ge-
neralversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Michael Koschatzki als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen
Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.
Die Generalversammlung bestätigt Frau Silvia Wagner als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalver-
sammlung beschließt, das Mandat von Frau Silvia Wagner als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalver-
sammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.
Die Generalversammlung beschließt, die KPMG Luxembourg S.à.r.l., geschäftsansässig in 9, Allee Scheffer, L-2520
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 zu er-
nennen.
81646
L
U X E M B O U R G
DWS Investment S.A. (Verwaltungsgesellschaft)
Unterschriften
Référence de publication: 2012069212/28.
(120098927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.
Crédit Suisse (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 11.756.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 14 juin 2012.
Référence de publication: 2012068703/10.
(120098620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Elle Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 29.520.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 mai 2012i>
Le Conseil d'Administration prend note de la démission aux fonctions d'administrateur de la société de M. Sergio
Dell'Acqua, né le 21 octobre 1956 à Lugano et demeurant en Suisse, CH-6932 Breganzona, Via Sass Curona, 5 avec effet
au 28 mai 2012.
Luxembourg, le 08 juin 2012.
<i>Pour ELLE FINANCE S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012068729/14.
(120098132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Fides et Spes Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 31.923.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012068764/9.
(120097832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
Hottinger International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 24.050.
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2012i>
L’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Elo Zisman ROZENCWAJG, Président;
- Monsieur Eric MENOTTI, Administrateur;
- Monsieur Frédéric HOTTINGER, Administrateur;
- Monsieur Jean-Pierre DE CLERCQ, Administrateur;
- Monsieur Jörg AUF DER MAUR, Administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2012.
L’Assemblée Générale renomme comme réviseur d'entreprises agréé:
- Deloitte Audit Sàrl.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
81647
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2012.
Référence de publication: 2012068829/21.
(120097753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2012.
TreeTop Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.731.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2012.
<i>Pour TreeTop Portfolio SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE
<i>Directeur / -i>
Référence de publication: 2012070575/15.
(120100536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
TreeTop Global Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 117.170.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2012.
<i>Pour TreeTop Global SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE
<i>Directeur / -i>
Référence de publication: 2012070573/15.
(120099948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2012.
TF Holding S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 98.056.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue à Luxembourg, eni>
<i>date du 12 juin 2012 à 10 heures.i>
L'assemblée décide:
1. D'accepter de renouveler le mandat d'administrateur - délégué de Madame Françoise FORGUES demeurant au 52,
rue Maurice Trubert F-64200 Biarritz, pour une période de 4 ans, son mandat expire le 06 novembre 2016
2. D'accepter de renouveler le mandat de la société PARTNERS SERVICES S.A. au poste de commissaire aux comptes
ayant son siège social au 63-65, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg,
section B, sous le numéro 89.823 pour une période de 4 ans, son mandat expire le 06 novembre 2016.
La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 12 juin 2012.
<i>Pour la société
i>Philippe FORGUES
<i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2012069800/20.
(120098764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
81648
Aedes International S.A.
Aforest Lux S.àr.l.
Agence Moneygram Metroplus Sàrl
Alcubo S.A.
Alfred Berg
Allegro Group S.à r.l.
Allegro S.à r.l.
Allegro S.à r.l.
AllianceBernstein Institutional Investments
Allianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Alsina S.à r.l.
Ana Holding S.A., SPF
Ancolie Holding S.A.-SPF
Antinéum SA
ARAGON Service & Administration S.à r.l.
Atelier de Menuiserie Heusbourg Frères S.e.c.s.
Autodis S.A.
Avaya International Enterprises Limited
Barclays European Infrastructure Projects S.à r.l.
Billecart Expansion Holdings S.A.
Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l.
Carren Gere S.A.
Cencan S.A.
CLdN ro-ro S.A.
Codelem Investissements S.A.
Crédit Suisse (Luxembourg) S.A.
db PrivatMandat Comfort
Deutschland Property Partners
Eclipp L
Elle Finance S.A.
Energy Asset Management S.à r.l.
Energy Asset Management S.à r.l.
European CleanTech I SE
Fides et Spes Spf S.A.
Fortis Commercial Finance
GP Capital
Holden Recoveries S.à r.l.
Hottinger International Fund
International Real Estate Portfolio 08/09 - FTL S.C.A., SICAR
International Real Estate Portfolio 08/09 - ITM S.C.A., SICAR
KBL EPB Equity Fund II
Malicar Finance S.A.
Mecca World Group S.A.
MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l.
Mondeltone S.A.
Omnium Textile S.A.
Partners Group Global Value SICAV
Patch International S.A.
Plastiche S.A.
Regus International Services
Saltri HoldCo S.à r.l.
Selection F
Servus Group HoldCo S.à r.l.
Sevens Beteiligung S.à r.l.
Tabiadasc Real Estate S.A.
TF Holding S.A.
TIAA Lux 11 S.à r.l.
TreeTop Global Sicav
TreeTop Portfolio SICAV
Triton III LuxCo 1 S.à r.l.