logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1430

8 juin 2012

SOMMAIRE

3rd WAY S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68640

Agenotec Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68621

Alpha Advisory Company S.A.  . . . . . . . . . .

68629

A.T.T.C. Control S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68639

Capisco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68639

Cardiologics S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68614

Catwalk Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68639

CB Richard Ellis Global Alpha Series S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68620

Chauffage Sanitaires Kocan S.à r.l. . . . . . . .

68623

Cole Bay Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68636

D&D Group S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68639

Fleurs Marnie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68640

Fosca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68632

Gottleuba S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68638

GPF GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68626

Investec GLL SGO REF Holding Alpha  . . .

68634

Megapolis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68630

MOM asbl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68608

Nordea Multi Manager Funds  . . . . . . . . . . .

68640

North Star SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68632

OX Resto Concepts S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

68637

Parthenos S.A. SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68633

Sakura House Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68618

Sera Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68640

Seven Club S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68624

Solar Boyz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68610

Synapse Universal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68620

TEMTEX S. A. & Cie. INVESTCO deuxiè-

me S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68629

TEMTEX S. A. & Cie. INVESTCO premiè-

re S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68631

Ter Beke Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68630

That's It A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68630

THEOLIA Management Company S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68630

Tiberius X-Line  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68594

TRE Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68631

Trinity Street Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68625

Triton III LuxCo B 15 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

68626

Twinhope Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68631

Two I.C. Finance S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . .

68631

Tyco Holding IV (Denmark) SE . . . . . . . . . .

68628

Ultima Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68632

Up-To-Date, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68620

Verim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68636

Verso S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68634

Verso S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68634

Vicem Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68636

Vicem Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68636

Vonadu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68637

Warelux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68637

Wattshow S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68637

Weber Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

68637

Yaltha (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68638

Ziglione Participations Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68638

68593

L

U X E M B O U R G

Tiberius X-Line, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 168.916.

RECTIFICATIF

du dépôt initial L120084265

du 24/05/2012

In the year two thousand and twelve, on May the sixteenth.
Before the undersigned Cosita Delvaux, notary residing in Redangesur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Tiberius Asset Management AG, a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, having its regis-

tered  office  Baarerstrasse  53,  CH-6300  Zug  registered  with  the  Swiss  Commercial  Registry  under  number
CH-170.3.028.502-3, duly represented by Katharina Kahstein, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Zug
on May 13, 2012.

The aforementioned proxy will remain attached to this document to be filed at the same time with the registration

authorities.

Such appearing party, acting in its above-stated capacity, has requested the notary to state the following Articles of

incorporation of a public limited company:

Preliminary Title

Definitions

“2010 Law”

Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective
investment, as amended and/or replaced from time to time.

“1915 Law”

Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and/or
replaced from time to time.

“Accumulation Shares” or
“Acc Shares”

Shares which accumulate their income so that the income is included in the price of
the Shares.

“Administrator”

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., Luxembourg, acting as fund
administrator (i.e. as registrar and transfer agent) and Paying Agent.

“Auditor”

KPMG Luxembourg S.à r.l., acting as auditor.

“Article”

An article of the Articles.

“Articles”

This document.

“Board”

The board of directors of the Company.

“Business Day”

A complete week day (other than Saturday or Sunday) on which banks are normally
open for business in Luxembourg unless otherwise defined for a Fund in the
prospectus.

“Company”

Tiberius X-Line, which term shall, where appropriate, include any Fund from time to
time thereof.

“Consolidation Currency”

The Currency of the Company, i.e. the USD.

“Custodian”

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., acting as custodian bank.

“CSSF”

Commission de Surveillance du Secteur Financier or its successor in charge of the
supervision of undertakings for collective investment in the Grand Duchy of
Luxembourg.

“Dealing Currency”

The currency or currencies in which subscribers may subscribe for Shares in any
Share Class as indicated in Section 1.3. and in Appendix III of the Prospectus.

“Dealing Day”

Unless otherwise provided for in Appendix III of the Propectus, each Business Day
which does not fall within a period of suspension of the calculation of the Net Asset
Value per Share of the relevant Fund and such other Business Day as the Board may
decide from time to time.

“Director”

A member of the Board.

“Distributor”

Any person or entity duly appointed from time to time to distribute or arrange for
the distribution of Shares.

“Distribution Period”

The period from one date, on which dividends are paid by the Company to the next.
This may be annual or shorter, where dividends are paid more regularly.

“Distribution Shares” or
“Dist Shares”

Shares which distribute their income.

68594

L

U X E M B O U R G

“Domiciliary Agent”

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., acting as domiciliary agent.

“EEA”

The European Economic Area.

“Eligible Market”

An official stock exchange or another Regulated Market.

“Eligible State”

Any Member State, any member state of the OECD, and any other state which the
Board deems appropriate with regard to the investment objective of each Fund.

“EMU”

The Economic and Monetary Union

“EU”

The European Union.

“EU Savings Directive”

The European Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of
interest payments, as amended and/or replaced from time to time.

“EUR”

The European currency unit (also referred to as the Euro).

“Feeder Fund”

A Fund which has been approved to invest at least 85% of its assets in units or shares
of another UCITS or sub-funds thereof (i.e., the Master Fund).

“Fund” or “Sub-Fund”

A separate portfolio of assets for which a specific investment policy applies and to
which specific liabilities, income and expenditure will be applied. The assets of a Fund
are exclusively available to satisfy the rights of Shareholders in relation to that Fund
and the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation,
operation or liquidation of that Fund.

“Hedged Share Class”

The Share Class(es) for which the Company engages in one or more hedging
transaction(s).

“Institutional Investor”

As defined from time to time by the CSSF within the framework of the Luxembourg
law, guidelines and administrative practice.

“Investor”

A subscriber for or holder of Shares, as the case may be. This term includes, where
appropriate, the term “Shareholder”.

“Management Company”

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., acting as management company.

“Master Fund”

A UCITS, or a sub-fund thereof, in which one or more Feeder Fund(s) invest at least
85% of their assets.

“Member State”

A member state of the EU.

“Mémorial”

The Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, an official gazette of the Grand
Duchy of Luxembourg.

“Money Market Instruments”

Instruments normally dealt in on the money market which are liquid and have a value
which can be accurately determined at any time.

“Net Asset Value”

The Net Asset Value per Share multiplied by the number of Shares.

“Net Asset Value per Share”

The value per Share in any Share Class, expressed in the Dealing Currency and
determined in accordance with the relevant provisions described in the Section
headed “Calculation of Net Asset Value”.

“OECD”

The Organisation for Economic Co-operation and Development.

“Paying Agent”

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., acting as paying agent.

“Personal Data”

The data including inter alia the name, address and invested amount of each Investor.

“Promoter”

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, acting as promoter.

“Prospectus”

The prospectus of the Company, as amended from time to time.

“Reference Currency”

Currency as defined in Appendix III of the prospectus for each Sub-Fund.

“Regulated Market”

Any market which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the
public according to the Directive 2004/39/EC of 30 April 2004 on markets in financial
instruments, as amended and/or replaced from time to time.

“Retail Investor”

An investor which does not qualify as an Institutional Investor.

“Share Class”

A class of Shares with a specific fee structure or other distinctive feature(s).

“Share”

A share of no par value in any one Share Class in the capital of the Company.

“Shareholder”

A holder of Share(s) entitled to an undivided co-ownership of the assets and liabilities
comprising the relevant Fund and to participate and share in the gross income of the
relevant Fund, registered by the Management Company as the owner of the Shares.

“UCITS”

An “undertaking for collective investment in transferable securities” within the
meaning of article 1(2) letters (a) and (b) of the UCITS Directive.

“UCITS Directive”

The European directive 2009/65/EC on undertakings for collective investment in
transferable securities, as amended and/or replaced from time to time.

“UCI”

An “undertaking for collective Investment” as defined under Luxembourg law.

“USD”

The United States currency unit (also referred to as the United States Dollar).

68595

L

U X E M B O U R G

“VaR”

Value at Risk, a risk measurement tool to determine the global exposure risk of the
Company.

All references herein to time are to Central European Time (CET) unless otherwise indicated.
Words importing the singular shall, where the context permits, include the plural and vice versa.

Title I. Name - Registered Office - Duration - Purpose

Art. 1. Name. There exists among the Shareholders and those who may become owners of Shares hereafter issued,

a public limited company (“société anonyme”) qualifying as an investment company with variable share capital (“société
d’investissement à capital variable”) under the name of “Tiberius X-Line”.

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a decision of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent

which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation  of  these  abnormal  circumstances;  such  provisional  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the
Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities

and other assets permitted by law with the aim of spreading investment risks and affording its Shareholders the results
of the management of its assets. The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem
useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted under the 2010 Law.

Title II. Share Capital - Shares - Net Asset Value

Art. 5. Share Capital - Share Classes. The capital of the Company shall be represented by fully paid-up Shares of no

par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 11. The minimum
capital shall be as provided by law one million two hundred and fifty thousand euro (Euro 1,250,000.-).

The Shares to be issued within each Fund pursuant to Article 7 may, as the Board shall determine, be of different Share

Classes. The proceeds of the issue of each Share Class for each Fund shall be invested in securities of any kind and other
assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the Board for each Fund subject to the invest-
ment restrictions provided by law or determined by the Board.

The Board shall establish a portfolio of assets constituting one or more Funds for one or more Share Class(es) in the

manner described in Article 11. As between Shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive
benefit for the relevant Share Class of each Fund.

The Company shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in particular towards

the Company’s creditors, each Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.

The Board may create each Fund for a limited or an unlimited duration. In addition, the Board has the power at any

time to merge Funds or, provided the duration of the relevant Fund is unlimited or has expired, to proceed to a com-
pulsory redemption of all Shares outstanding in that Fund, on the basis of the applicable Net Asset Value per Share as of
the Dealing Day at which the decision shall take effect, taking into account actual expenses incurred in connection with
the merger or redemption and subject to the following procedures:

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Shares Class shall, if

not expressed in USD, be converted into USD and the capital shall be the total of the net assets of all the Share Classes.

Art. 6. Form of Shares.
(1) The Board shall determine whether the Company shall issue Shares either in bearer form or in registered form.
All Shares in issue shall either be embodied in the global certificate or shall be registered in the register of Shareholders

which shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register
shall contain the name of each owner of registered Shares, his or her residence or elected domicile as indicated to the
Company, the number of registered Shares held by him/her/it and the amount paid-up on each such Share.

The global certificate shall be signed by two Directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile.

However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the Board; in the latter case, it
shall be manual.

The inscription of the Shareholder’s name in the register of Shares evidences his/her/its right of ownership on such

registered Shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the Share-
holder or whether the Shareholder shall receive a written confirmation of his/her/its shareholding.

If bearer Shares are issued, registered Shares may be converted into bearer Shares and bearer Shares may be converted

into registered Shares at the request of the holder of such Shares. A conversion of registered Shares into bearer Shares

68596

L

U X E M B O U R G

will be effected by cancellation of the registered share certificate, if any, and the respective clearing system shall have the
relevant bearer Shares added to the global certificate, thereby increasing the number of bearer Shares represented by
the global certificate by the number of Shares added, and an entry shall be made in the register of Shareholders to evidence
such cancellation. A conversion of bearer Shares into registered Shares will be effected by cancellation of the global share
certificate, and, if requested, by issuance of a registered share certificate in lieu thereof, and an entry shall be made in the
register of Shareholders to evidence such issuance, and the respective clearing system shall have the relevant Shares
deleted from the global certificate by the number of Shares thus deleted. At the option of the Board, the costs of any
such conversion may be charged to the Shareholder requesting it.

The share certificates shall be signed by two Directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile.

However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the Board; in the latter case, it
shall be manual. The Company may issue temporary Share certificates in such form as the Board may determine.

(2) If bearer Shares are issued, they shall be embodied in the global share certificate. Upon the issue of bearer Shares,

the respective clearing system shall, at the Board’s request, have the new bearer Shares added to the global certificate,
thereby increasing the number of bearer Shares represented by the global certificate by the number of bearer Shares
thus added. Transfer of registered Shares shall be effected (i) if Share certificates have been issued, upon delivering the
certificate or certificates representing such Shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory
to the Board, and (ii), if no Share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the
register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of
attorney to act therefore. Any transfer of registered Shares shall be entered into the register of Shareholders; such
inscription shall be signed by one or more director(s) or officer(s) of the Company or by one or more other persons
duly authorized thereto by the Board. The global share certificate shall be held in custody on behalf of the Shareholder
(s) by the respective clearing system, in its capacity as administrator of the central securities depositary of the bearer
Shares.

(3) Shareholders entitled to receive registered Share certificates must provide the Company with an address to which

all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of Shareholders.

In the event that a Shareholder does not provide an address, the Board may permit a notice to this effect to be entered

into the register of Shareholders and the Shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the
Company, or at such other address as may be so entered into by the Board from time to time, until another address shall
be provided to the Company by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his/her/its address as entered
into the register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such
other address as may be determined by the Board from time to time.

(4) If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Board that his/her/its Share certificate has been mislaid,

mutilated or destroyed, then, at his/her/its request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and
guarantees, including but not restricted to a debt instrument issued by an insurance company, as the Board may determine.
At the issuance of the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate
in replacement of which the new one has been issued shall become void. Mutilated Share certificates may be cancelled
by the Board and replaced by new certificates.

The Board may, at its election, charge to the Shareholder the costs of a duplicate or of a new Share certificate and all

reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof, or in connection
with the cancellation of the original Share certificate.

(5) The Company recognizes only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the

ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single attorney
to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights
attached to such Share(s).

(6) The Company may decide to issue fractional Shares. Such fractional Shares shall not be entitled to vote but shall

be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Share Class on a pro rata basis. In the case of bearer
Shares, only certificates evidencing full Shares will be issued.

Art. 7. Issue of Shares. The Board is authorized without limitation to issue fully paid up Shares at any time without

reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscribe for the Shares to be issued.

The Board may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued in any Share Class; the Board

may, in particular, decide that any Share Class shall only be issued during one or more offering periods or at such other
periodicity as provided for in the Prospectus.

Whenever the Company offers Shares for subscription, the price per Share shall be the Net Asset Value per Share of

the relevant Share Class as determined in compliance with Article 11. Such price shall be increased by such charges and
commissions as the Prospectus may provide. The price so determined shall be payable within a period as determined by
the Board which shall in general not exceed seven (7) Business Days from the relevant Dealing Day.

The Board may delegate to any Director, manager, officer or other duly authorized agent the power to accept sub-

scriptions and to receive payment of the price of the new Shares to be issued.

68597

L

U X E M B O U R G

The Company may accept to issue Shares in consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with

the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from an independent
auditor (“réviseur d’entreprises agréé”).

Art. 8. Redemption of Shares. Any Shareholder may request the redemption of all or part of his/her/its Shares by the

Company, under the terms and procedures set forth by the Board and within the limits provided by law, these Articles
and the Prospectus.

The redemption price shall be paid within a period as determined by the Board which shall not exceed seven (7)

Business Days from the relevant Dealing Day or at the date on which the Share certificates, if any, have been received
by the Company, notwithstanding the provision of Article 12. Any request for redemption shall be irrevocable except in
the event of a suspension of the calculation of the Net Asset Value per Share in the relevant Share Class.

The redemption price shall be equal to the Net Asset Value per Share of the relevant Share Class, as determined in

accordance with the provisions of Article 11, less such charges and commissions (if any) at the rate provided for by the
Prospectus. The relevant redemption price may be rounded up or down as the Board shall determine.

If as a result of any redemption request, the number of Shares hold by a Shareholder in any Share Class would fall

below such number or such value as determined by the Board, then the Board may decide that this request be treated
as a request for redemption of the full balance of such Shareholder’s holding of Shares in such Share class.

Further, if on any given date redemption requests pursuant to this Article and switching requests pursuant to Article

9 exceed a certain level determined by the Board in relation to the number of Shares in issue of a specific Share Class,
the Board may decide that part or all of such requests for redemption or switching will be deferred for a period that the
Board considers to be in the best interest of the Company. On the next Dealing Day following that period, these re-
demption and switching requests will be met in priority to later requests.

The Board may determine to satisfy the payment of the redemption price to any Shareholder who agrees, in specie

by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in connection with such Share Class(es) equal
in value  (calculated  in  the  manner  described  in  Article  11)  as  of the Dealing Day on which the redemption  price is
calculated, to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall
be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other Shareholders of the
relevant Share Class(es) and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor. The costs shall be
borne by the redeeming Shareholder.

All redeemed Shares shall be cancelled.

Art. 9. Conversion of Shares. Any Shareholder is entitled to request the conversion of one or more Share(s) in one

Share Class into the corresponding amount of Shares in (i) either another Share Class(es) within the same Fund or (ii)
one or more Share Class(es) in different Fund(s), as further described in the Prospectus.

The Board may set restrictions i.e. on the frequency, terms and conditions of the conversion and subject them to the

payment of such charges and commissions as it shall determine in the Prospectus.

If as a result of any request for conversion the number of Shares held by any Shareholder in any Share Class would

fall below such number or such value as determined by the Board, then the Board may decide that this request be treated
as a conversion request for the full balance of such Shareholder’s holding in such Share Class.

The converted Shares shall be cancelled in the original Share Class.

Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares and Compulsory Redemption of Shares. The Company may restrict or

prevent the ownership of Shares by any person, firm or corporate body if in the opinion of the Board such holding may
be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or
if as a result thereof the Company may become subject to tax laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg.

Specifically but without limitation, the Company may restrict the ownership of Shares by any U.S. Person, and for such

purposes the Company may:

A. - decline to issue any Shares and decline to register any transfer of a Share where it appears to it that such registry

or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such Shares held by a U.S. Person; and

B. - at any time require any person whose name is entered in or any person seeking to register the transfer of Shares

on the register of Shareholders, to provide it with any information, supported by affidavit which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shares rests in a U.S. person, or whether
such registry will result in beneficial ownership of such Shares by a U.S. Person; and

C. - decline to accept the vote of any U.S. Person at any meeting of Shareholders; and
D. - where it appears to the Board that any U.S. Person, either alone or in conjunction with any other person, is a

beneficial owner of Shares, compulsory redeem or cause to be compulsory redeemed from any such Shareholder all
Shares held by such Shareholder in the following manner:

(1) The Company shall serve a notice (“Purchase Notice”) upon the Shareholder holding such Shares or appearing in

the register of Shareholders as the owner of the Shares to be repurchased, specifying the Shares to be compulsory
repurchased and the manner and date in which the repurchase price will be calculated and completed.

68598

L

U X E M B O U R G

Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed

to such Shareholder at his/her/its last address known to or appearing in the books of the Company. The said Shareholder
shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the Share certificate(s) representing the Shares specified
in the repurchase notice.

Immediately after the close of business on the Business Day specified in the Purchase Notice, such Shareholder shall

cease to be the owner of the Shares specified in such notice and, in the case of registered Shares, his/her/its name shall
be removed from the register of Shareholders, and in the case of bearer Shares, the certificate(s) representing such Shares
shall be cancelled.

(2) The price at which each such Share is to be repurchased shall be an amount based on the Net Asset Value per

Share of the relevant Share Class as at the Dealing Day specified by the Board for the compulsory redemption of the
relevant Shares, less any redemption charge and/or any service charge provided for in the Prospectus.

(3) Payment of the repurchase price will be made available to the former owner of such Shares in the relevant Dealing

Currency and will be deposited for payment to such owner by the Company either with a bank in Luxembourg or
elsewhere (as specified in the Purchase Notice) upon final determination of the repurchase price specified in such notice
and unmatured distribution coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former
owner shall have no further interest in such Shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in
respect thereof, except the right to receive the repurchase price (without interest) from such bank. Any redemption
proceeds receivable by a Shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date
specified in the Purchase Notice, may thereafter not be claimed and shall revert to the relevant Share Class(es). The
Board shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such repurchase and to authorize such
action on behalf of the Company.

(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any

case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Board at the date of any purchase notice, provided in such case the
said powers were exercised by the Board in good faith. The Board has further the right to compulsory redeem part or
all of the Share(s) held by a Shareholder who engages or envisages to engage in market timing, late trading or similar
activities. The provisions of the previous paragraphs applying mutatis mutandis and may be further specified in the Pros-
pectus.

Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The Net Asset Value per Share in each Shares Class shall be calculated

in the relevant Dealing Currency as follows:

1. The Net Asset Value per Share of each Share Class will be calculated on each Dealing Day in the Dealing Currency

of the relevant Share Class. It will be calculated by dividing the total net asset value attributable to each Share Class, being
the proportionate value of its assets less its liabilities, by the number of Shares of such Share Class then in issue. The
resulting Net Asset Value per Share shall be rounded to the nearest two decimal places.

2. The valuation of the Net Asset Value of the different Share Classes shall be made in the following manner:
A. The assets of the Company shall be deemed to include:
(a) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
(b) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not yet

collected);

(c) all securities, shares, debt instruments, debentures, options or subscription rights and other derivative instruments,

warrants, units or shares of undertakings for collective investments and other investments and securities belonging to
the Company;

(d) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company (the

Company may however adjust the valuation to fluctuations in the market value of securities due to trading practices such
as trading exdividends or ex-rights);

(e) all accrued interest on any securities held by the Company except to the extent such interest is comprised in the

principal thereof;

(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such preli-

minary expenses may be written off directly from the capital of the Company; and

(g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
(1) The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,

cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Company may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof.

68599

L

U X E M B O U R G

(2) The value of such securities, financial derivative instruments and assets will be determined on the basis of the official

settlement price or last available price on the stock exchange or any other Regulated Market as aforesaid on which these
securities or assets are traded or admitted for trading.

(3) If a security is not traded or admitted on any official stock exchange or any Regulated Market, or in the case of

securities so traded or admitted the last available settlement price or the last available closing price of which does not
reflect their true value, the Board is required to proceed on the basis of their expected sales price, which shall be valued
with prudence and in good faith.

(4) The financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other

organised market are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or closed by
an offsetting transaction at any time at their fair value at the Board's initiative. The reference to fair value shall be un-
derstood  as  a  reference  to  the  amount  for  which  an  asset  could  be  exchanged,  or  a  liability  be  settled,  between
knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. The reference to reliable and verifiable valuation shall be
understood as a reference to a valuation, which does not rely only on market quotations of the counterparty and which
fulfils the following criteria:

(a) The basis of the valuation is either a reliable up-to-market value of the instrument, or, if such value is not available,

a pricing model using an adequate recognised methodology.

(b) Verification of the valuation is carried out by one of the following:
(i) an appropriate third party which is independent from the counterparty of the OTC derivative, at an adequate

frequency and in such a way that the Company is able to check it;

(ii) a unit within the Management Company which is independent from the department in charge of managing the assets

and which is adequately equipped for such purpose.

(5) The value of swaps is calculated by the calculation agent of the swap transactions, according to a method based on

market value, recognised by the Board and verified by the Fund’s auditor.

(6) Units or Shares in undertakings for collective investments shall be valued on the basis of their last available net

asset value as reported by such undertakings.

(7) Liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an

amortised cost basis. All other assets, where practice allows, may be valued in the same manner.

(8) If any of the aforesaid valuation principles do not reflect the valuation method commonly used in specific markets

or if any such valuation principles do not seem accurate for the purpose of determining the value of the Company's assets,
the Board may fix different valuation principles in good faith and in accordance with generally accepted valuation principles
and procedures.

(9) Any assets or liabilities in currencies other than the Reference Currency of the Fund will be converted using the

relevant spot rate quoted by a bank or other recognised financial institution.

The Board are authorised to apply other appropriate valuation principles for the assets of the Funds and/or the assets

of a given Share Class if the aforesaid valuation methods appear impossible or inappropriate due to extraordinary cir-
cumstances or events.

B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(a) all borrowings, bills and other amounts due;
(b) all administrative and other operative expenses due or accrued including all fees payable to the investment manager,

the custodian and any other representatives and agents of the Company;

(c) all known liabilities due or not yet due, including the amount of dividends declared but unpaid;
(d) an appropriate amount set aside for taxes due on the date of valuation and other provisions or reserves authorised

and approved by the Board covering among others liquidation expenses; and

(e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares.
In determining the amount of such liabilities, the Board shall take into account all expenses payable by the Company

which shall comprise formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers, director’s fees
and reasonable out-of-pocket expenses, accountants, custodian, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent
and permanent representatives in places of registration, and/or any other agent employed by the Company, fees related
to listing the Shares on any stock exchange, fees related to the Shares being quoted on another regulated market, fees
for legal and auditing services, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising
or preparing and printing of prospectuses or any other offering documents of the Company, explanatory memoranda or
registration statements, taxes or governmental charges, and all other operational expenses, including the cost of buying
and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex.

For the purposes of the valuation of its liabilities, the Board may duly take into account all administrative and other

expenses of a regular or periodic character by valuing them for the entire year or any other period and by dividing the
amount concerned proportionately for the relevant fractions of any such period.

68600

L

U X E M B O U R G

In circumstances where the interests of the Company or its Shareholders so justify (for instance avoidance of market

timing practices), the Board may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing to adjust the value
of the Company’s assets, as further described in the offering documents of the Company.

IV. For the purpose of this Article:
1) Shares to be redeemed under Article 8 shall be treated as existing and taken into account until immediately after

the close of business on the date on which the redemption price thereof was determined, and from such time and until
paid by the Company such price shall be deemed to be a liability of the Company;

2) Shares to be issued shall be treated as being in issue as from the close of business on the date on which the issue

price thereof was determined, and from such time and until received by the Company such price shall be deemed to be
a debt due to the Company;

3) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the currency in which the Net

Asset Value for the relevant Share Class s calculated shall be valued after taking into account the market rate or rates of
exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value per Share; and

4) where on any Dealing Day the Company has contracted to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company

and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;

- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company

and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;

provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Dealing

Day, then its value shall be estimated by the Company.

Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and

Switching of Shares.  With  respect  to  each  Share  Class,  the  Net  Asset  Value  per  Share  and  the  price  for  the  issue,
redemption and switching of the Shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed
thereto by the Company, at least twice a month at a frequency determined by the Board.

The Board may suspend the calculation of the Net Asset Value per Share of any Share Class in any Fund and/ or the

issue and/or redemption and/ or switching of any Share Class in any Fund into Shares of a Share Class of the same Fund
or any other Fund, in respect of the assets attributable to any Share Class, of one or more of the following circumstances:

a) during any period when, according to the opinion of the Board, any of the principal stock exchanges or any other

Regulated Markets on which any substantial portion of the Company's investments of the relevant Share Class for the
time being are quoted, is closed, or during which dealings are restricted or suspended; or when for any other reason the
prices of any investments of the Company attributable to any Fund cannot promptly or accurately be ascertained; or

b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation

of investments of the relevant Fund by the Company is impracticable; or

c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any

of the Company's investments or the current prices or values on any market or stock exchange; or

d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of such Shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments
or payments due on redemption of such Shares cannot in the opinion of the Board be effected at normal rates of exchange;
or

e) if the Company is being or may be wound-up on or following the date on which notice is given of the meeting of

Shareholders at which a resolution to wind up the Company is proposed; or

f) during any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Company or its Sha-

reholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or other detriment which the
Company or its shareholders might so otherwise have suffered;

g) if the calculation of the share or unit price in the respective Master Fund, in which one or more Fund(s) invest in,

has been suspended; or

h) in the event of a merger or a similar event concerning the Company and/or one or more Fund(s) if deemed necessary

by the Board in the best interest of the Shareholders concerned; or

i) in case of the suspension of the calculation of an index underlying a financial derivate investment material to a Fund.
Such suspension of the calculation of the Net Asset Value per Share of any Fund or Share Class shall not affect the

valuation of other Funds or Share Classes, unless these Funds or Share Classes are also affected.

Any such suspension of the calculation of the Net Asset Value shall be notified to the subscribers and shareholders

requesting redemption or conversion of their Shares on receipt of their request for subscription, redemption or con-
version.

During any period of suspension, Shareholders having applied for subscription, redemption or switching of Shares may

withdraw their request. Failing such cancellation, the Shares shall be issued, redeemed or switched by reference to the
Net Asset Value per Share first calculated after the end of the suspension period.

68601

L

U X E M B O U R G

Title III. Administration and Supervision

Art. 13. The Board. The Company shall be managed by a Board composed of not less than three Directors, who need

not be Shareholders. They shall be elected for a term not exceeding six (6) years. The Directors shall be elected by the
Shareholders at a general meeting of Shareholders; the latter shall further determine the number of Directors, their
remuneration and the term of their office.

Directors shall be elected by the majority of the votes validly cast.
Any Director may be removed with or without cause or be replaced at any time by a resolution adopted by a general

meeting of Shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a Director, the remaining Directors may temporarily fill such vacancy; the

Shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.

Art. 14. Board meetings. The Board shall choose from among its members a chairman, and may choose from among

its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall write
and keep the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders. The Board shall meet upon call by the
chairman or any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at the meetings of the Board and of the Shareholders. In his or her absence, the Shareholders

or the Directors shall decide by a majority vote that another Director, or in case of a Shareholders’ meeting, that any
other person shall be in the chair of such meetings.

The Board may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any

other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such appointments
may  be  cancelled  at  any  time  by  the  Board.  The  officers  need  not  be  Directors  or  Shareholders.  Unless  otherwise
stipulated by these Articles, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the Board.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least twenty-four hours prior to the date

set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set
forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other
similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
resolution adopted by the Board.

Any Director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means

of communication another Director as his or her proxy. A Director may represent several of his or her colleagues.

Any Director may participate in a meeting of the Board by conference call or similar means of communications equip-

ment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means
shall constitute presence in person at such meeting. The Directors may only act at duly convened meetings of the Board.
The Directors may not bind the Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by a
resolution of the Board.

The Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the Directors, or any other number of Directors

that the board may determine, are either present or represented.

Resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the relevant meeting. Copies of extracts

of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting
or any two Directors.

Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented. In the event that at any meeting

the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the

Directors’ meetings duly convened and hold; each Director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex,
telefax or any other similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and may appear on a
single document or multiple copies of an identical resolution and all documents shall form the record that proves that
such decision has been taken.

Art. 15. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and

administration within the Company’s purpose, in compliance with the investment policy as determined in Article 18. All
powers not expressly reserved by law to the general meeting of Shareholders are in the competence of the Board.

Art. 16. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two

Directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board.

Art. 17. Delegation of power. The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the

Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out acts in fur-
therance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not
to be Directors and who shall have the powers determined by the Board and who may, if the Board so authorises, sub-
delegate their powers.

Art. 18. Investment policy. The Board, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine (i) the

investment policies to be applied in respect of each Fund, (ii) the hedging strategy to be applied to specific Share Classes

68602

L

U X E M B O U R G

and (iii) the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within the restrictions as shall
be set forth by the Board in compliance with applicable laws and regulations.

Within those restrictions, the Board may decide that investments be made:
(i) in transferable securities admitted to official listing on a stock exchange or dealt in on another Regulated Market;
(ii) in transferable securities admitted to official listing on a stock exchange or dealt in on another Regulated Market

located within any other country of Western or Eastern Europe, Asia, Oceania, the American continents or Africa;

(iii) in recently issued transferable securities provided that the terms of issue provide that application be made for

admission to official listing in any of the stock exchanges or Regulated Markets referred to above and that such admission
is secured within a year of the issue;

(iv) in accordance with the principle of risk spreading, up to 100% of the net assets attributable to each Share Class

may be invested in transferable securities issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities, by any other
member state of the OECD or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s),
provided that in the case where the Company decides to make use of this provision, it shall, on behalf of the relevant
Share Class(es), hold securities from at least six (6) different issues and securities from any one issue may not account
for more than 30% of the net assets attributable to such Share Class(es);

(v) in securities of another UCI, provided that if such a UCI is an UCITS of the open-ended type and is linked to the

Company by common management or control or by a substantial direct or indirect holding, investment in the securities
of such UCI shall be permitted only if such UCI, according to its constitutional documents, has specialized in investment
in a specific geographical area or economic sector and if no fees or costs are charged on account of transactions relating
to such acquisition;

(vi) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board in

compliance with applicable laws and regulations;

(vii) shares or units of a Master Fund qualifying as UCITS.
The Board, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the Prospectus, that

(i) all or part of the assets of the Company or of any Fund be co-managed on a segregated basis with other assets held
by other investors, including other UCIs and/or their sub-funds, and/or that (ii) all or part of the assets of two or more
Funds be co-managed amongst themselves on a segregated or on a pooled basis. Provide that a Fund may, in accordance
with the relevant provisions of the Prospectus, invest in one or more Fund(s) (cross Fund investments) to the widest
extend permitted by applicable Luxembourg laws and regulations.

Moreover, the Board may adopt, for one or more Fund(s), masterfeeder strategies in view of pooling its assets and

achieving economies of scale between European–domiciled UCITS within the meaning of article 1, paragraph 2 (a) and
(b) of the UCITS Directive. The relevant Feeder Fund can thus derogate from the standard diversification limits in order
to invest its assets in only one Master Fund or compartment thereof. The Feeder Fund will have to invest at least 85%
of its assets in the Master Fund with the 15% remaining assets being invested in other eligible assets. A Feeder Fund may
either cease to be a Feeder Fund or replace its Master Fund, Shareholders will then be informed accordingly and both,
the Prospectus and the relevant KII will be adapted accordingly after the prior approval of the CSSF.

Investments in each Fund may be made either directly or indirectly through wholly-owned subsidiaries, as the Board

may from time to time decide and as described in the Prospectus. Reference in these Articles to “investments” and
“assets” shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made
and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiary.

The Company is authorized to use techniques and instruments relating to transferable securities and money market

instruments as further provided for in the Prospectus.

Art. 19. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any Director or officer of the Company
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest

opposite to the interests of the Company, such Director or officer shall make known to the Board such opposite interest
and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest
therein shall be reported to the next following general meeting of Shareholders.

The term “opposite interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without

interest  in  any  matter,  position  or  transaction  involving  the  Management  Company,  the  Investment  Manager  or  the
Custodian, or such other person, company or entity as may from time to time be determined by the Board in its discretion.

Art. 21. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any Director or officer, and his or her heirs,

executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him or her in connection with any action, suit or
proceeding to which he or she may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the

68603

L

U X E M B O U R G

Company or, at its request, of any other company of which the Company is a Shareholder or a creditor and from which
he or she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he or she shall be finally adjudged
in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemni-
fication shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is
advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of
indemnification shall not exclude other rights to which he or she may be entitled.

Art. 22. Auditors. The accounting data related in the Annual Report shall be audited by an independent auditor (“ré-

viseur d’entreprises agréé”) appointed and remunerated by the Company.

The Auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2010 Law.

Title IV. General Meetings - Accounting Year - Distributions

Art. 23. Representation. The general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders. Its

resolutions shall be binding upon all the Shareholders regardless of the Share Class(es) held by them. It shall have the
broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 24. General Meetings of Shareholders. The general meeting of Shareholders shall meet upon call by the Board.
It may also be called upon the request of Shareholders representing at least one fifth of the share capital.
The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the Company’s registered office or

at a place specified in the notice of meeting on the first Tuesday of May at 11:00 a.m. Luxembourg time.

If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day.
Other meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective convening

notices.

The convening notices to general meetings of Shareholders may provide that the quorum and the majority at the

general meeting shall be determined according to the Shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on
the fifth day prior to the general meeting (referred to as “Record Date”). The rights of a Shareholder to attend a meeting
and to exercise the voting rights attaching to his or her Shares are determined in accordance with the Shares held by this
Shareholder at the Record Date. The Company is not required to send the annual accounts, the report of the Auditor
and the management report to the Shareholders at the same time as the convening notice to the annual general meeting.
The convening notice shall indicate the place and the practical arrangements for providing these documents to the Sha-
reholders and shall specify that each Shareholder may request that they are sent to him. Notices of all general meetings
are sent by registered mail to all registered Shareholders at their registered address at least eight (8) calendar days prior
to such meeting. Such notice will indicate the time and place of such meeting and the conditions of admission thereto,
will contain the agenda and will refer to the requirements of Luxembourg law with regard to the necessary quorum and
majorities at such meeting. Notices of all general meetings will be published in the Mémorial, in Luxembourg newspaper
(s) and in other newspaper(s) as the Board may decide, for Shareholder who hold bearer Shares, if any, to the extent
required by Luxembourg law.

The agenda shall be prepared by the Board except in the instance where the meeting is called on the written demand

of the Shareholders in which instance the Board may prepare a supplementary agenda.

If all Shares are in registered form only convening notices may be mailed by registered mail only.
If all the Shareholders are either present or represented and consider themselves as being duly convened and informed

of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by the Shareholders in order to attend any meeting

of Shareholders.

The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters. To the extent required by law,
the notice may, in addition, be published in the Mémorial, in one or more Luxembourg newspapers, and/or in such other
newspaper(s) as the Board may decide in its sole discretion.

The General Meeting can decide on all Company matters. The power to make the following decisions, in particular,

is reserved to the General Meeting:

(1) appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the auditor, and the determination of their

compensation, discharge of the directors and the auditors, if required;

(2) consideration of the reports of the Board of Directors and the auditor, approval of the annual financial statements;
(3) appropriation of net income for the year (taking into account the advance distributions already paid out by the

Board of Directors);

(4) Amendments to the Articles of Association;
(5) Dissolution and liquidation of the Company;
(6) Mergers and splits of the Company.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote

of the Shareholders present or represented regardless of the proportion of the capital represented.

68604

L

U X E M B O U R G

Resolutions with respect to the appointment and dismissal of members of the Board of Directors shall require the

approval of a minimum of two thirds of the votes cast by the Shareholders present or represented regardless of the
proportion of the capital represented.

This requirement shall not apply when other attendance and majority requirements are mandated by law.

Art. 25. Quorum and Majority Conditions. The quorum requirements are those provided for under Luxembourg law

and regulations.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the

votes validly cast.

Art. 26. General Meetings of Shareholders in a Fund or in a Share Class. The Shareholders in all the Share Class(es)

issued in respect of a specific Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matter which relate exclusively
to such Fund.

In addition, the Shareholders of any Share Class may hold, at any time, general meetings for any matter which relates

exclusively to that Share Class.

The provisions of Article 24, paragraphs 1, 2, 6, 7, 8, 9 and 10 shall apply to such general meetings.
Each whole Share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles. Shareholders may

act either in person or by giving a written proxy to another person who needs not be a Shareholder and may be a Director.

Any proxy granted by a Shareholder shall remain valid for any convened meeting, unless it is expressly revoked or

provided otherwise therein.

Any resolution of the general meeting of Shareholders, affecting the rights of the holders of Shares in any Share Class

vis-à-vis the rights of the holders of Shares in any other Share Class(es), shall be subject to a resolution of the general
meeting of Shareholders of such Share Class(es) in compliance with article 68 of the 1915 Law

Art. 27. Merger of the Company, the Funds and/or Share Classes and reorganisation of a Fund. In the event that for

any reason the value of the net assets in any Fund or Share Class has decreased to an amount determined by the Board
to be the minimum level for such Fund or Share Class to be operated in an economically efficient manner, or if a change
in the economical or political situation relating to any Fund or Share Class would have material adverse consequences
on the investments of that Fund or Share Class or in order to proceed to an economic rationalization, or if the agreement
with the Investment Manager has been terminated and such Investment Manager has not been replaced by a replacement
investment manager, the Board may decide to compulsorily redeem all the Shares of the relevant Shares Class(es) at the
Net Asset Value per Share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) as of
the Dealing Day on which such decision takes effect. The decision of the Board will be published (either in newspaper(s)
to be determined by the Board or by way of a notice sent to the Shareholders at their addresses indicated in the register
of Shareholders) prior to the effective date and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the
compulsory redemption operations. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between,
the Shareholders, the Shareholders concerned may continue to request redemption or switching of their Shares without
redemption or switching charges (but taking into account actual realization prices of investments and realization expenses)
prior to the effective date.

Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, the Shareholders of any one or all

Share Class(es) may, at a general meeting of Shareholder upon proposal of the Board resolve to redeem all the Shares
of the relevant Share Class(es) and refund to the Shareholders the Net Asset Value of their Shares (taking into account
actual realization prices of investments and realization expenses) as of the Dealing Day on which such decision shall take
effect. There shall be no quorum requirement for such general meeting of Shareholders which shall decide by a resolution
taken by simple majority of the votes validly cast.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited

with the Custodian for a period of nine (9) months; after this period, these assets will be deposited with the Caisse de
Consignations on behalf of the persons entitled thereto and the corresponding rights shall lapse in accordance with
applicable law (in principle, 30 years).

Under the same circumstances as provided in the first paragraph of this Article, the Board may decide to merge any

Fund with another existing Fund or with another Luxembourg or foreign UCITS or any subfund thereof. Such decision
will be published in the same manner as described above (and, in addition, the publication will contain information in
relation to the other Fund or Luxembourg or foreign UCITS, or sub-fund thereof, as applicable), no less than one (1)
month before the date on which the merger becomes effective in order to enable Shareholders to request redemption
or switching of their Shares, without redemption or switching charges, during such period. At the expiry of this period,
the relevant decision shall bind all the Shareholders who have not exercised such right.

Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraphs, a merger of any Share Class with

another Share Class or a Luxembourg or foreign UCITS, or any sub-fund thereof, may be decided by a general meeting
of the Shareholders concerned for which there shall be no quorum requirement and which will decide by a simple majority
of votes validly cast.

68605

L

U X E M B O U R G

In the event that the Board determines that it is required in the interests of the Shareholders of the relevant Fund or

that a change in the economic or political situation relating to the Fund concerned has occurred which would justify the
reorganisation of one Fund by means of either a split or a consolidation into two or more Funds (followed, if necessary,
by the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to the Shareholders), such resolution may be
resolved upon by the Board. Such decision will be published in the same manner as described above and, in addition, the
publication will contain information in relation to the two or more new Funds. Such publication will be made no less than
one (1) month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to enable the Shareholders to
request, during that period of time, the redemption of same or all of their Share(s) without redemption charges.

All redeemed Shares shall be cancelled.

Art. 28. Accounting year. The accounting year of the Company shall commence on the first day of January and shall

terminate on the last day of December of the same calendar year.

Art. 29. Distributions. The general meeting of Shareholders shall, upon proposal of the Board and within the limits

provided for by law, determine how the results of the Company shall be disposed of, and may from time to time declare,
or authorize the Board to declare, distributions.

Any resolution as to the distribution to Shareholders of a specific Share Class shall be only subject to a vote of the

Shareholders of the relevant Share Class.

In respect of each Share Class entitled to distributions, the Board may decide to pay interim distributions in accordance

with applicable laws and regulations.

The payment of the distributions shall be made to the account indicated in the register of Shareholders in case of

registered Shares and upon presentation of the distribution coupon to the agent or agents therefore designated by the
Company in case of bearer Shares.

Interim dividends may at any time be paid on the Share Class upon decision of the Board in compliance with applicable

laws and regulations.

The Board may pay the distributions in the Dealing Currency and at such time and place as it shall determine from

time to time.

The Board may decide to distribute stock dividends in lieu of cash distributions upon such terms and conditions as

may be set forth by the Board.

Any distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert to the

relevant Share Class(es). No interest shall be paid on a distribution declared by the Company and kept by it at the disposal
of its beneficiary.

Title V. Final provisions

Art. 30. Custodian. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking

or saving institution as defined by the law of April 5, 1993, on the financial sector as amended and/or replaced from time
to time (herein referred to as the “Custodian”).

The Custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2010 Law.
If the Custodian desires to retire, the Board shall use its best endeavours to find a successor Custodian. The Board

may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian
has been appointed to act in the place thereof.

Art. 31. Dissolution. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders

subject to the quorum and majority requirements applicable for the amendments to these Articles.

Whenever the share capital falls below two thirds of the minimum capital indicated in Article 5, the question of the

dissolution of the Company shall be referred to the general meeting of Shareholders by the Board. The general meeting
of Shareholders, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the Shares represented at the
meeting.

The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share

capital falls below one fourth of the minimum capital set by Article 5; in such an event, the general meeting of Shareholders
shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by Shareholders holding one fourth
of the Shares represented at the meeting and validly cast.

The meetings must be convened so that they are held within a period of forty (40) days from the determination that

the net assets of the Company have fallen below two thirds or one fourth respectively of the legal minimum, as the case
may be.

Art. 32. Liquidation. The Company may be liquidated at any time by a resolution adopted by an extraordinary general

meeting of Shareholders, at which meeting one or several liquidators will be named and their powers defined. Liquidation
shall be carried out by one or several liquidator(s), who may be physical persons or legal entities, duly approved by the
CSSF and appointed by the general meeting of Shareholders which shall determine their powers and their compensation.

68606

L

U X E M B O U R G

The decision to liquidate a Fund may also be taken at a meeting of Shareholders of the particular Fund concerned. The

liquidation of one Fund does not entail the automatic liquidation of the other Fund(s).

The liquidation of the Company and/or any of its Fund(s) shall in principle be completed within nine (9) months. Any

liquidation proceeds of a Fund or of the Company shall be deposited in escrow at the Caisse de Consignation at the close
of the liquidation. Amounts not claimed from escrow within the period fixed by law shall be forfeited in accordance with
the provisions of Luxembourg law.

Art. 33. Amendments to the Articles. These Articles may be amended by a general meeting of Shareholders subject

to the quorum and majority requirements provided for by law.

Art. 34. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender, words importing persons

or Shareholders also include corporations, partnerships, associations and any other organized group of persons whether
incorporated or not.

Art. 35. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915

Law.

Art. 36. Transitory Dispositions. The first Financial Year will begin on the date of the formation of the Company and

will end on 31 December 2012.

<i>Subscription and Payment

These Articles having thus been drawn up by the appearing party which has subscribed and entirely paid-up the following

Shares:

Subscriber

Number

of

shares

Subscription

price per

share

Tiberius Asset Management AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

100.- USD

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 50,000.- USD

All these Shares have been entirely paid up of by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euros (USD

50,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>1. Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the

1915 Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the appearing party

as a result of its formation are estimated at approximately Euro 2,900.-.

<i>Extraordinary general meeting

The single Shareholder, representing the entire subscribed capital, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The following persons are appointed as Directors for a period ending with the next annual general meeting of Share-

holders:

1) Andreas Jockel - Chairman
2) Max von Frantzius - Vice-Chairman
3) Stephan Rudolph - Board Member

<i>Second resolution

The registered office of the Company is fixed at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Third resolution

The following is elected as independent auditor for a period ending with the next annual general meeting:
KPMG Luxembourg S.à r.l., 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, this deed, including the Articles of incorporation, is worded in English.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, first names, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.

Signé: K. KAHSTEIN, C. DELVAUX.

68607

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Redange/Attert, le 21 mai 2012. Relation: RED/2012/665. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 22 mai 2012.

Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012064137/793.
(120090418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.

MOM asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 28, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg F 9.169.

STATUTS

Entre les soussignés:
- Prénom, Nom, adresse, profession, nationalités
- Walter Lima Ramos, 28, av. Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
- Actuellement en Chômage, Luxembourgeoise.
- Fatima Monteiro Rocha, 13, rue René Weimerskirch, L-2713 Luxembourg.
- Femme de ménage, Luxembourgeoise.
- Tony Melo Monteiro, 28, av. Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
- Actuellement en Chômage, Luxembourgeoise

et toutes celles ou ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie

par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination «MOM asbl» association sans but lucratif.

Art. 2. L'association a pour objet de:
1- de regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer de manière générale à des activités

culturelles et sportives.

2- de créer des événements culturels.
3- de créer ou d'élargir des structures d'accueil, d'appui, de pratiques et d'expression culturelle.
4- de favoriser les contacts et échanges entre tous les ressortissants du Luxembourg.
5- de promouvoir la formation sociale et civique de ses membres de façon à contribuer à sa participation à la vie

publique.

Art. 3. L'association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. L'association a son siège social au 28, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg. Le siège social peut être

transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché du Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 5. La durée de l'association est illimitée.

II. Exercice social

Art. 6. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

III. Membres

Art. 7. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d'adminis-

tration à la suite d'une demande formulée de manière écrite ou verbale.

Art. 8. Les membres s'engagent à respecter le principe et l'objet de l'association, ainsi que les décisions de l'assemblée

générale et du conseil d'administration.

Art. 9. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite

au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 6 mois à compter du jour de l'échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 10. Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte

aux intérêts de l'association. À partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la
décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est
envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

68608

L

U X E M B O U R G

Art. 11. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont produites et

ce au 31 décembre.

IV. Cotisations

Art. 12. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une

cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Le montant de cette cotisation annuelle ne peut
être supérieur à 100 euros.

Art. 13. L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement

des cotisations versées.

V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un
cinquième des membres le demande par écrit en proposant un ordre du jour au conseil d'administration.

Art. 15. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, moyennant courrier

postale ou électronique et affichage devant mentionner l'ordre du jour proposé.

Art. 16. Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

Art. 17. L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- la modification des statuts et règlement interne;
- la nomination et révocation des administrateurs et des éventuels réviseurs de caisse;
- l'approbation des budgets et comptes;
- la dissolution de l'association.

Art. 18. Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par voie

postale ou courrier électronique. Elles sont conservées dans un registre au siège de l'association et signées par un membre
du conseil d'administration; elles sont consultables par les membres associés et personnes tiers.

VI. Administration

Art. 19. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 3 membres, élus par l'assemblée générale

à la majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale. La durée de leur mandat est de 3 ans. Le conseil d'admi-
nistration se compose d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier. Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants:
le président représente l'association, le secrétaire est le responsable des écrits de l'association, le trésorier gère les
comptes.

Art. 20. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président chaque fois que les intérêts de l'asso-

ciation l'exigent ou à la demande de deux tiers de ses membres. Il ne peut valablement délibérer que si 2/3 membres au
moins sont présents. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres élus.

Art. 21. Le conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'association. Il exécute les directives à lui dévolues

par l'assemblée générale conformément à l'objet de l'association.

Art. 22. Il représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'association soit valablement engagée à

l'égard de ceux-ci, la signature d'un membre en fonction sont nécessaires.

Art. 23. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activités,

les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Art. 24. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 25. Les ressources de l'association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur,
- l'autofinancement.

VII. Modification des statuts, dissolution et liquidation

Art. 26. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou

68609

L

U X E M B O U R G

représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre
des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 27. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association ayant des buts similaires.

VIII. Dispositions finales

Art. 28. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre

aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Ainsi fait à Luxembourg, le 4 juin 2012.

Walter Lima Ramos / Fatima Monteiro Rocha / Tony Melo Monteiro
<i>Les membres fondateurs

Référence de publication: 2012064728/112.
(120090771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.

Solar Boyz, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.824.847,00.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 167.933.

L'an deux mille douze, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Solar Boyz, une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mars 2012, en cours d'imma-
triculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et en voie de publication au Mémorial C (ci-après
la «Société»).

L'assemblée a élu comme président Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président a nommé comme secrétaire et l'assemblée a nommé comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire,

demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le nom des associés présents ou représentés à l'assemblée et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent ont été

portés sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par les parties comparantes, le président, le scrutateur,
le secrétaire et le notaire instrumentaire, et les procurations signées «ne varietur» par les associés représentés à l'as-
semblée, le président, le scrutateur, le secrétaire et le notaire instrumentaire, sont restées attachées au présent acte pour
être enregistrées avec lui.

II. Il ressort de la liste de présence que les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales représentant l'entièreté du

capital social de la Société étaient représentées à l'assemblée.

III. Les parties comparantes ont déclaré avoir été suffisamment informées de l'ordre du jour de l'assemblée au préalable

et renoncer à toute formalités de convocation. L'assemblée étant ainsi été régulièrement constituée, a pu valablement
délibérer sur l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'article 11.2, paragraphe (iv) des statuts de la Société.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
- Augmentation du capital social d'un montant d' un million huit cent douze mille trois cent quarante sept Euros

(1.812.347 EUR) par la création et l'émission de parts sociales traçantes de classe A et de classe B qui traceront la
performance et le rendement d'actifs particuliers de la Société;

- Souscription des nouvelles parts sociales de classe A et de classe B par les associés et libération par apport en nature

d'actions;

- Modification des règles de fonctionnement du conseil de gérance et de représentation de la Société;
- Modification des articles 5, 6.2, 6.4, 8, 15 et 16.2 des statuts de la Société;

68610

L

U X E M B O U R G

- Octroi d'un pouvoir à tout gérant et tout employé de Headstart S.à r.l. de procéder au nom et pour le compte de

la Société à l'inscription dans le registre des associés de la Société des parts sociales de classe A et de classe B et d'accomplir
les formalités y relatives.

Ceci étant rappelé, l'assemblée a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

<i>Première résolution

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un million huit cent douze mille trois

cent quarante sept Euros (1.812.347 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (12.500
EUR) à un million huit cent vingt quatre mille huit cent quarante sept Euros (1.824.847 EUR) par la création et l'émission
de neuf cent douze mille neuf cent quatre vingt quinze parts (912.995) parts sociales de classe A et huit cent quatre vingt
dix neuf mille trois cent cinquante deux (899.352) parts sociales de classe B, d'une valeur nominale d'un Euro (1 EUR)
chacune, dont les droits et obligations sont déterminés par la modification des statuts de la Société, telle qu'elle résulte
des résolutions ci-après.

Les parts sociales de classe A et les parts sociales de classe B traceront séparément la performance et le rendement

d'un ou plusieurs actifs particuliers de la Société, tels que déterminés en application des dispositions des statuts modifiés
résultant des résolutions ci-après.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée a décidé d'accepter la souscription des parts sociales de classe A par Monsieur Jean Canzoneri, demeurant

au 100, rue Marius Aufan, F-92300 Levallois-Perret, et la souscription des parts sociales de classe B par Monsieur Thomas
Pasquet, demeurant au 7, rue Marcel Cerdan, F-92300 Levallois-Perret, ainsi que leur entière libération par des apports
en nature composés d'actions de Beezik, une société par actions simplifiée de droit français sise au 153 rue de Courcelles,
75017 Paris, France, immatriculée sous le numéro RCS Paris 504 421 165 (ci-après «Beezik»).

<i>Souscription et Libération

Monsieur Jean Canzoneri précité, représenté comme établi ci-dessus, est intervenu pour souscrire les neuf cent douze

mille neuf cent quatre vingt quinze (912.995) parts sociales de classe A et les libérer intégralement par un apport en
nature composé de mille sept cent quarante (1.740) actions de Beezik, évaluées globalement à au moins neuf cent douze
mille neuf cent quatre vingt quinze Euros (912.995 EUR).

Monsieur Thomas Pasquet, représenté comme établi ci-dessus, est intervenu pour souscrire les huit cent quatre vingt

dix neuf mille trois cent cinquante deux (899.352) parts sociales de classe B et les libérer intégralement par un apport en
nature composé de mille sept cent quatorze (1.714) actions de Beezik, évaluées globalement à au moins huit cent quatre
vingt dix neuf mille trois cent cinquante deux Euros (899.352 EUR).

<i>Preuve de l'existence et de la valeur des apports

La preuve de l'existence et de la valeur des apports a été donnée par une copie du registre des actionnaires de la

société Beezik et une déclaration des parties comparantes.

<i>Réalisation effective de l'apport

Preuve de la propriété des actions Beezik apportées a été donnée au notaire instrumentaire, à qui les associés sou-

scripteurs ont en outre déclaré:

- Que les actions Beezik apportées sont entièrement libérées;
- Que ces actions sont nominatives;
- Qu'il n'existe aucun droit de préemption, d'option ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir

le droit d'en acquérir une ou plusieurs;

- Que ces actions sont librement transmissibles;
- Que ces actions sont libres de tout gage, garantie ou usufruit;
- Qu'ils sont bien les propriétaires actuels des actions qu'ils apportent;
- Que toutes les formalités sont en cours de réalisation aux fins d'effectuer le transfert des actions apportées au profit

de la Société et la rendre effective vis-à-vis des tiers.

<i>Troisième résolution

L'assemblée a décidé de modifier les règles de fonctionnement du conseil de gérance et de représentation de la Société

en imposant, conformément aux dispositions des statuts modifiés telles qu'elles résultent des résolutions ci-après:

- la présence ou représentation de tous les gérants pour toute délibération et décision du conseil de gérance;
- l'unanimité des voix pour toute décision du conseil de gérance;
- la signature conjointe de tous les gérants pour la représentation de la Société vis-à-vis des tiers en remplacement de

la signature conjointe de deux gérants.

68611

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il a été décidé de remplacer les articles 5, 6.2, 6.4, 8, 15 et 16.2 des statuts de la

Société comme suit:

« Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à un million huit cent vingt quatre mille huit cent quarante sept Euros (1.824.847 EUR),

représenté par:

- douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»),
- neuf cent douze mille neuf cent quatre vingt quinze (912.995) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe

A»), et

- huit cent quatre vingt dix neuf mille trois cent cinquante deux (899.352) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales

de Classe B»),

ayant  une  valeur  nominale  d'un  Euro  (1  EUR)  chacune,  toutes  sous  forme  nominative,  souscrites  et  entièrement

libérées.

Les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B sont désignées «Parts Sociales Traçantes» et les Parts

Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Traçantes sont désignées ci-après collectivement les «parts sociales» ou indivi-
duellement une «part sociale».

5.2 Les Parts Sociales Traçantes tracent séparément la performance et le rendement d'un ou plusieurs actifs particuliers

de la Société (les «Actifs Cibles»).

5.3 Les Actifs Cibles relatifs aux parts sociales de classe A se composent de (i) 3.336 des 6.622 actions de la société

anonyme de droit luxembourgeois Ebuzzing, ayant son siège social au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg et imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.995, que la Société détiendra
le ou autour du 29 mars 2012 en conséquence de son entrée dans le capital de ladite société, et/ou (ii) tout actif pouvant
raisonnablement être considéré comme ayant remplacé tout ou partie des Actifs Cibles mentionnés sub (i), en ce compris
tout produit pouvant provenir de la vente de ces actifs, de même que le réinvestissement d'un tel produit.

Les Actifs Cibles relatifs aux parts sociales de classe B se composent de (iii) 3.286 des 6.622 actions de la société

anonyme de droit luxembourgeois Ebuzzing, ayant son siège social au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg et imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.995, que la Société détiendra
le ou autour du 29 mars 2012 en conséquence de son entrée dans le capital de ladite société, et/ou (iv) tout actif pouvant
raisonnablement être considéré comme ayant remplacé tout ou partie des Actifs Cibles mentionnés sub (iii), en ce compris
tout produit pouvant provenir de la vente de ces actifs, de même que le réinvestissement d'un tel produit.

5.4 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.5 Toute prime d'émission versée doit restée attachée aux parts sociales à raison desquelles elle a été versée ou être

remboursée exclusivement aux détenteurs de telles parts.»

«6.2 Les Parts Sociales Ordinaires sont librement cessibles entre les associés. Les Parts Sociales Traçantes ne peuvent

être cédées entre associés jusqu'au 29 mars 2016.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.»

«6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables

suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

En cas de rachat de Parts Sociales Traçantes, l'associé dont les Parts Sociales Traçantes sont rachetées peut exiger

que le prix de rachat soit payé par allocation des Actifs Cibles relatifs à la catégorie de Parts Sociales Traçantes concernée,
dans la limite de sa quote-part sur ces actifs, telle que déterminée proportionnellement au nombre de Parts Sociales
Traçantes qu'il détient dans ladite catégorie.»

« Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le «Conseil»).
8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad

hoc, le(s)quel(s) peut(peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités

68612

L

U X E M B O U R G

et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de
son/leur mandat(s).

8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au

Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés. Les

décisions du Conseil sont valablement adoptées à l'unanimité des voix des gérants présents ou représentés.

(vi) Les résolutions de la réunion du Conseil sont prises par écrit et inscrites sur un procès-verbal. Ce procès-verbal

est signé par tous les gérants présents.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au jour de la réunion.

Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables

et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3 Représentation
(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de tous les gérants, ou

par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été
valablement délégués conformément aux articles 8.1 (ii) et 8.3 (ii) des Statuts.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

« Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent affecter ce bénéfice à un

compte de réserve, le reporter ou l'allouer au paiement d'un dividende en faveur des Parts Sociales Ordinaires, des Parts
Sociales de Classe A ou des Parts Sociales de Classe B, dans le respect des règles décrites ci-dessous. Les droits des
associés sur ce bénéfice seront déterminés de la manière suivante:

(i) les détenteurs de Parts Sociales Traçantes auront, proportionnellement au nombre de Parts Sociales Traçantes de

la catégorie concernée qu'ils détiennent, un droit exclusif sur la partie du bénéfice correspondant à (a) tous les produits
et revenus réalisés par la Société en relation avec les Actifs Cibles relatifs à la catégorie de Parts Sociales Traçantes
concernée moins (b) tous les coûts et pertes directement ou indirectement relatifs auxdits Actifs Cibles, les points (a)
et (b) étant déterminées par la Conseil;

(ii) les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires auront droit au solde du bénéfice après déduction du montant revenant

aux détenteurs des Parts Sociales Traçantes, proportionnellement au nombre de Parts Sociales Ordinaires qu'ils détien-
nent.

15.3 Sous réserve des dispositions de l'article 15.2, des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment,

aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  disponibles  (en  ce  compris  la  prime

d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; et

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires.»

«16.2 Le boni de liquidation après le paiement des dettes est réparti entre les associés, avant ou après réalisation des

actifs, de la manière suivante:

68613

L

U X E M B O U R G

(i) Les Parts Sociales Traçantes sont remboursées avant les Parts Sociales Ordinaires. Les détenteurs de Parts Sociales

Traçantes ont droit à la fraction du boni de liquidation en relation avec les Actifs Cibles relatifs à cette catégorie de Parts
Sociales Traçantes, telle que déterminée par le Conseil en tenant compte des règles exposées à l'article 15.2. (le «Boni
de Liquidation Traçant»). Entre eux, le Boni de Liquidation Traçant se partage proportionnellement au nombre de Parts
Sociales Traçantes qu'ils détiennent chacun dans la catégorie de Parts Sociales Traçantes concernée. Chaque détenteur
de Parts Sociales Traçantes a le droit d'exiger le paiement en nature de sa quote-part dans le Boni de Liquidation Traçant,
via l'allocation préférentielle des Actifs Cibles, dans la limite de sa quote-part sur ces actifs, telle que déterminée pro-
portionnellement au nombre de Parts Sociales Traçantes qu'il détient dans ladite catégorie.

(ii) Le solde du boni de liquidation, après paiement des Boni de Liquidation Traçants, est partagé entre les détenteurs

de Parts Sociales Ordinaires proportionnellement au nombre de Parts Sociales Ordinaires qu'ils détiennent.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée a décidé de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société ou tout employé de Headstart S.à r.l.

pour procéder individuellement et sous sa seule signature, au nom et pour le compte de la Société, à l'inscription dans
le registre des associés des parts sociales de classe A et de classe B nouvellement émises et d'accomplir, le cas échéant,
toutes les formalités y relatives.

Aucun sujet ne restant à discuter, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société à raison des présentes s'élèvent

approximativement à deux mille sept cents Euros (2.700.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 avril 2012. Relation: LAC/2012/15796. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Référence de publication: 2012052863/229.
(120073364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Cardiologics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 167.482.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the eighth day of March.
Before us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Eugen WEINBERG, born on the seventh of September 1977 in Bichkek, Russia, residing in D-60327 Frankfurt am

Main, Mainzer Landstrasse 153, duly represented by Mr Nicolas Vainker, réviseur d'entreprises, with professional address
in Luxembourg, by virtue of a proxy dated fourteenth of February 2012.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such proxyholder of the appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of

a limited liability company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is “Cardiologics S.à r.l.”.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has as one of its principal objectives the investment in medical software research for smartphones

and medical devices and the acquisition, and eventual sale, of the intellectual property rights related to new research.

68614

L

U X E M B O U R G

The Company has as its objects the holding of participations, in whatever form, foreign or luxembourgish, as well as

the management, control and development of these participations.

The Company can acquire through purchase, contribution-in-kind, option, or in any other manner investments in any

currency and to dispose of these by sale, cession, exchange, or any other method.

The Company can equally buy and develop intellectual property rights and other related rights connected to these,

or assist in their completion.

The Company can borrow and grant companies in which it has direct, or indirect interest, every assistance, loans,

advances, or guarantees.

The Company shall be able to carry out any operation, whether commercial, industrial, or financial, that is deemed to

be in its interest and the achievement of its objects.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00) divided

into one hundred (100) corporate units without nominal value.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may

only be done in accordance with the law on commercial companies.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties the managers have the most extensive powers to act individually on behalf of the company in

all circumstances.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on

commercial companies.

Art. 15. The business year begins on first January and ends on 31 December of each year.

Art. 16. Every year on 31 December, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution

will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2012.

<i>Subscription and Payment

The one hundred (100) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, Mr Eugen Weinberg,

prenamed.

68615

L

U X E M B O U R G

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00) as was certified to the notary executing this deed

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

thousand euro (EUR 1,000.-).

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

The following has been elected as manager:
- Mr Eugen Weinberg, residing at Mainzer Landstrasse 153, D-60327 Frankfurt,
with the powers indicated in article 11 of the Articles of Incorporation.
The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The manager is elected for an undetermined period.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

WHEREOF.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above person

appearing, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same proxyholder of
the person appearing and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be
prevailing.

The present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the person appearing, who is

known to the notary by his surnames, Christian names, civil status and residences, said proxyholder of the person ap-
pearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le huit mars,
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

M. Eugen WEINBERG, né le sept septembre 1977 à Bichkek, Russie, demeurant à D-60327 Frankfurt am Main, Mainzer

Landstrasse 153, ici représenté par M. Nicolas Vainker, reviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 14 février 2012.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société

à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de “Cardiologics S.à r.l.”.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a comme un de ses principaux objectifs l'investissement dans des logiciels informatiques médicaux

pour smartphones et appareils médicaux ainsi que l'acquisition, et la vente éventuelle, des droits de propriété intellectuelle
en relation avec ces nouvelles recherches.

68616

L

U X E M B O U R G

La société a comme objectif la détention des participations, sous quelque forme que ce soit, étrangères ou luxem-

bourgeoises, ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société peut faire par achat, par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre

manière, des investissements dans n'importe quelle devise et en disposer par vente, cession, échange ou autres modes.

La société peut également acheter et développer des droits de propriété intellectuelle ainsi que les droits y rattachés

et assister à leur exécution.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société dans laquelle elle a un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-.EUR) représenté par cent (100) parts sociales

sans valeur nominale.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que

dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir sous leur signature individuelle au nom

de la société dans toutes les circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Paiement

Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, M. Eugen WEINBERG, prénommé.

68617

L

U X E M B O U R G

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille euros (1.000,- EUR).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Est appelé aux fonctions de gérant, M. Eugen Weinberg demeurant à Mainzer Landstrasse 153, D-60327 Frankfurt am

Main, avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts.

Il pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat du gérant est établi pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

DONT ACTE.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire du com-

parant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par noms, prénoms,

états et demeures, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Vainker, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2012. Relation: LAC/2012/11016. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 15 mars 2012.

Référence de publication: 2012032796/203.
(120042904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.

Sakura House Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 19, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 168.552.

STATUTS

L'an deux mille douze, le dix-sept avril.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Aijian DU, cuisinier, né à Zhejiang (Chine), le 28 février 1962, demeurant à L-4263 Esch-sur-Alzette, 23, rue Saint

Nicolas;

2.- Chengguo CHEN, cuisinier, né à Zhejiang (Chine), le 13 septembre 1971, demeurant à I-90037 Piana Degli Albanesi,

48, Via Pres. M. Costantini. Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société
à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de SAKURA HOUSE SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Remich.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant de cuisine japonaise et chinoise ainsi que toutes opérations

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

68618

L

U X E M B O U R G

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent

vingt-quatre (124.-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Libération

Les parts ont été souscrites comme suit:

1.- Aijian DU, cuisinier, né à Zhejiang (Chine), le 28 février 1962, demeurant à L-4263 Esch-sur-Alzette, 23, rue
Saint Nicolas, cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2.- Chengguo CHEN, cuisinier, né à Zhejiang (Chine), le 13 septembre 1971, demeurant à I-90037 Piana Degli
Albanesi, 48, Via Pres. M. Costantini, quatre-vingt-quinze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Total: Cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à huit cent cinquante (850.-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-5533 Remich, 19, Esplanade.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1.- Aijian DU, cuisinier, né à Zhejiang (Chine), le 28 février 1962, demeurant à L-4263 Esch-sur-Alzette, 23, rue Saint

Nicolas, gérant technique;

2.- Chengguo CHEN, cuisinier, né à Zhejiang (Chine), le 13 septembre 1971, demeurant à I-90037 Piana Degli Albanesi,

48, Via Pres. M. Costantini, gérant administratif.

La société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

<i>Déclaration

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire aux comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux comparants,
connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, Ils ont signé le présent acte avec
le notaire.

Signé: Du, Chen et Molitor.

68619

L

U X E M B O U R G

Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 25 avril 2012. Relation EAC/2012/5302. Reçu soixante quinze euros 75.-

<i>Le Receveur ff. (signé): Halsdorf.

Référence de publication: 2012052877/71.
(120073100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Up-To-Date, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6114 Junglinster, 14, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 112.289.

Suite à un transfert de parts sociales sous seing privé, les parts sociales sont détenues comme suit:

Madame Diane PUTZ-ORIGER, demeurant
à L-6114 Junglinster, 10-12, route d'Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Junglinster, le 4 mai 2012.

<i>La société

Référence de publication: 2012052935/13.
(120073504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Synapse Universal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 130.550.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 07 mai 2012

Changement de l'adresse de l'administrateur Per Bergqvist:
Sa nouvelle adresse est: 33, rue N.S. Pierret à L-2335 Luxembourg
Changement de l'adresse de l'administrateur-délégué Per Bergqvist:
Sa nouvelle adresse est: 33, rue N.S. Pierret à L-2335 Luxembourg
Changement de l'adresse de l'administrateur Christel Bergqvist:
Sa nouvelle adresse est: 33, rue N.S. Pierret à L-2335 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012052913/15.
(120073407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

CB Richard Ellis Global Alpha Series S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 156.904.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 8 mai 2012

En date du 8 mai 2012, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de prendre note de la démission de Monsieur Frank VITAGLIONE de son mandat de gérant de catégorie B de la

Société avec effet au 6 mars 2012;

- de prendre note de la démission de Monsieur Claude NIEDNER de son mandat de gérant de catégorie A de la Société

avec effet au 29 mars 2012.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de la manière suivante:
- Monsieur Daniel LAURENCIN, gérant de catégorie A
- Monsieur Neil ROSS, gérant de catégorie A
- Monsieur Stuart SAVIDGE, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2012.

CB Richard Ellis Global Alpha Series S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012055566/22.
(120078112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.

68620

L

U X E M B O U R G

Agenotec Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 167.703.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwölf, am achten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1) Herr Steffen ROSE, Elektroniker, geboren in Nebra (D) am 16. Mai 1964, wohnhaft in D-65620 Waldbrunn, Bahn-

hofstrasse, 18,

2) Herr Eric DUCAUROY, Ingenieur, geboren in Senlis (F) am 27. Mai 1967, wohnhaft in D-54338 Schweich, im

Flürchen, 7b.

Vorgenannte Parteien haben den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezü-

gliche Gesetzgebung zu Grunde liegt.

Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Schadstoffsanierung, Entkernung, und Rüekbauarbeiten. Des Weiteren hat

sie zum Zweck die Vermietung und den Handel mit Materialien und Maschinen für die obengenannten Arbeiten.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck

verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt
oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen „AGENOTEC GROUP S. à r. l.".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schengen.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb derselben Gemeinde verlegt

werden.

Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großher-

zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert EURO (12.500V EUR) eingeteilt in ein-

hundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig EURO (125.- EUR).

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes

über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung unter Lebenden von Gesellschaft-

santeilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlung und mindestens fünfundsiebzig
Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der

Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitest gehenden

Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesell-

schafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.

Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft können zu jeder Zeit und auch ohne rechtmäßigen Grund von der

Generalversammlung der oder des Gesellschafters abberufen werden.

Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

68621

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 16. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-

kapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn

von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bes-

timmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2012.

<i>Zeichnung der Anteile

Alle einhundert (100) Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

1) Herr Steffen Rose, vorgenannt, sechsundsiebzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 Anteile

2) Herr Eric Ducauroy, vorgenannt, fünfundzwanzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Anteile

TOTAL: Einhundert (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anteile 100

Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert EURO (12.500.-

EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise

eintausend Euro (1.000.- EUR).

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sodann sind die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer Gene-

ralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Zum Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:
Herr Steffen Rose.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. ROSE, E. DUCAUROY, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 13 mars 2012. Relation: REM/2012/239. Reçu soixante-quinze euros 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

68622

L

U X E M B O U R G

Remich, den 19. März 2012.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2012037324/105.
(120049937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.

Chauffage Sanitaires Kocan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9189 Vichten, 18B, rue du Lavoir.

R.C.S. Luxembourg B 168.691.

STATUTS

L'an deux mille douze.
Le dix-huit avril.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A COMPARU

Monsieur Muslija KOCAN, ouvrier, né à Ivangrad, le 20 février 1966, demeurant à L-9189 Vichten, 18B, rue du Lavoir.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu'il déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

CHAUFFAGE SANITAIRES KOCAN S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet:
- l'installation de chauffage et de sanitaire,
- le dépannage, l'entretien et la réparation de chauffage,
- l'activité de carreleur,
- la vente d'articles se rapportant directement ou indirectement à son objet,
- l'activité de commerce en général
- l'activité d'E-commerce
- l'activité de consultant
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Vichten.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100)

PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

68623

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur Muslija KOCAN, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de DOUZE MILLE CINQ

CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENT EUROS (€ 900,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réunie en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Sont nommés gérants de la société:
a) Monsieur Mirsad MEKIC, ouvrier, né à Bijelo Polje, le 06 février 1961, demeurant à L-8010 Strassen, 216, route

d'Arlon;

b) Monsieur Muslija KOCAN, prénommé
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
III.- Le siège social de la société se trouve à L-9189 Vichten, 18B, rue du Lavoir.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Kocan, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 avril 2012. Relation: EAC/2012/5461. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012055570/78.
(120078188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.

Seven Club S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 168.581.

STATUTS

L'an deux mille douze.
Le vingt avril.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- La société "D.R.E.E. SA" (RC B 153.638), établie et ayant son siège social à L-8058 Strassen, 1, beim Schlass,
ici représentée par son administrateur Elson PARRACHO DOS SANTOS, étudiant, demeurant à L-2222 Luxembourg,

284, rue de Neudorf,

Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle

déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "Seven Club S.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Foetz.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une discothèque avec débit de boisson alcooliques et non alcooliques,

ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

68624

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-€), représenté par CENT (100) parts

sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.-€) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- D.R.E.E. SA, susdite, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à sept cent euros (700.-€).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l'associé unique, a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
- Daniel FERNANDES SOUSA, employé privé, demeurant à L-8011 Strassen, 331, route d'Arlon.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et

de l'infraction de blanchiment au code pénal, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées
à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: PARRACHO DOS SANTOS, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 avril 2011 LAC/2012/19446. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations

Luxembourg, le 7 mai 2012.

Référence de publication: 2012052886/63.
(120073835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Trinity Street Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 150.237.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

68625

L

U X E M B O U R G

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA
Jean Philippe CLAESSENS / Armelle MOULIN

Référence de publication: 2012052916/11.
(120072926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Triton III LuxCo B 15 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 159.751.

Les comptes annuels au 30 Septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Triton III Luxco B 15 S.à r.l.
Un Mandataire

Référence de publication: 2012052917/11.
(120073127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

GPF GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.511.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth of April.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Griffin Investments Partners Holding S.à r.l., having its registered office at 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg, owner of 100% of the entire issued and outstanding shares quotas of the company (Partner).

Hereby represented by Mr Gianpiero SADDI, notary’s clerck, with professional address in Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that the Partner represents the entire share capital of GPF GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its

registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (the Company), incorporated by notarial deed
on January 19, 2007 published on the Memorial Recueil des Sociétés et Associations C 368 on March 14, 2007.

- that, the Partner has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Partner resolves to amend the signatory power of its managers and decides the subsequent amendment of article

12 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

"The Company is managed by one or more managers who need not to be partners.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance").
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the partners holding a majority

of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager.
In case of plurality of managers, the company shall be bound by the joint signature of two managers, including the

signature of a Luxembourg resident manager, or by the sole signature of a Luxembourg resident manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the Chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

68626

L

U X E M B O U R G

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority.

The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members having participated."

<i>Second resolution

The Partner resolves to acknowledge the resignation of Mr. Tomasz Klukowski as manager of the Company with

immediate effect, and to give him full discharge from further responsibilities in respect of the carrying out of his duties.

<i>Third resolution

The Partner resolves to appoint Mr. Sjors van der Meer and Mrs. Christelle Ferry, both having their professional

address at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as managers of the Company with immediate effect, for
an unlimited period.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the

present original deed.

Follows the french version:

L’an deux mille douze, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg

A COMPARU:

Griffin Investments Partners Holding S.à r.l., ayant son siège social au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-

bourg, détenant 100% du capital social de la Société ("l’Associé")

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d’une procuration sous seing privé,

laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  «ne  varietur»  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

L’Associé, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu’il est l’associé actuel de la société GPF GP S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social L-1653

Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, constituée par acte notarié le 19 janvier 2007, publie au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C 368 du 14 mars 2007 ci après la «Société»

Que l’Associé a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé décide de modifier le pouvoir de signature de ses gérant et décide en conséquence de modifier l'article 12

des statuts, qui auront dorénavant la rédaction suivante:

«La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.

68627

L

U X E M B O U R G

Tous les pouvoirs non expressément réservés à I’ assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La compagnie est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique. En cas de pluralité des gérants,

la compagnie sera engagée par la signature conjointe de deux gérants, incluant la signature d'un gérant résident au Lu-
xembourg, ou par la seule signature d’un gérant résident au Luxembourg.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera

élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou

représentés.

Un gérant pourra être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la
réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à un conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre

moyen de télécommunication initié depuis Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une participation en personne au conseil de gérance. Cette
décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et
signé(s) par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une réunion

du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance ayant participé.»

<i>Deuxième résolution

L'associé prend note de la démission avec effet immédiat de Mr. Tomasz Klukowski en tant que gérant de la Société,

et le décharge de toutes responsabilités en rapport avec ses fonctions.

<i>Troisième résolution

L’Associé décide de nommer M. Sjors van der Meer et de Mme. Christelle Ferry, ayant leur adresse professionnelle

au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérants de la Société avec effet immédiat, pour une
durée indéterminée.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 avril 2012. LAC/2012/19436. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2012.

Référence de publication: 2012056373/140.
(120079052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.

Tyco Holding IV (Denmark) SE, Société Européenne.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 162.786.

Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

68628

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012052918/10.
(120073853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Alpha Advisory Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.375.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 février 2012

- La démission de Mr. Marc LIMPENS et de Mr. Harald CHARBON, en tant qu'administrateurs de classe B de la Société

est acceptée avec effet au 15 février 2012

- Mme. Sarah de Quant, née le 12 décembre 1961, à Bebington, Royaume Uni, résidant professionnellement au les

Sporades, 36 Avenue des Papalins, 98000 Monaco a été nommé administrateur de classe B de la Société avec effet au 15
février 2012

- L'annulation des classes dans le Conseil d'Administration est acceptée.
- Le Conseil d'Administration de la Société se compose des trois (3) personnes suivantes:
* Mr. Paul de Quant,
* Mr. Thierry Carlot,
* Mme. Sarah de Quant,
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'an 2012.

Pour copie conforme
Signatures

Référence de publication: 2012054928/21.
(120076754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.

TEMTEX S. A. &amp; Cie. INVESTCO deuxième S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 146.316.

<i>Gesellschafterbeschluss im Umlaufverfahren

Die Gesellschafter der TEMTEX S.A. &amp; Cie. INVESTCO deuxième S.e.c.s. mit dem Sitz in 05 rue Bachergaass, L-5444

Schengen, eingefragen im B146316 sind

1. INNCONA Management S.ar.l. , mit dem Sitz in L-5444 Schengen, 05 rue Baachergaass eingetragen im Handelsre-

gister B 128812,

2. TEMTEX Management S.A. mit dem Sitz in L-5444 Schengen, rue Baachergaass, eingetragen im Handelsregister B

129851, die beiden vorgenannten Gesellschaften als persönlich haftende Gesellschafter und die TEMTEX Management S.
A. als alleinige geschäftsführende Gesellschafterin sowie

3. Herr Stefan Eikelmann, wohnhaft in Alt Schürkesfeld 26, D-40670 Meerbusch, als alleiniger Kommanditist.
Dies vorausgeschickt, beschließen die Gesellschafter Folgendes:
A. Die Gesellschaft wurde am 29.06.2007 mit einem Stammkapital von 175.100 € gegründet.
B. Die Gesellschaft wird rückwirkend zum 31.12.2009 aufgelöst.
Der alleinige Kommanditist, Herr Stefan Eikelmann, kündigt hiermit die Gesellschaft um 31.12.2009. Die Gesellschaft

wird rückwirkend auf den 31.12.2009 liquidiert.

C. Zum Liquidator wird die TEMTEX Management S.A., vertreten durch den Geschäftsführer Dipl. Volkswirt Joachim

Grote, bestellt

Sämtliche Beschlüsse wurden mit den Stimmen des Gesellschafters Herr Stefan Eikelmann und damit mit einer Mehrheit

von 100% minus einer Stimme gefasst.

Meerbusch, den 21.12.2010. / Schengen, am 21.12.2010.

<i>- / Für die TEMTEX Management S.A.
Stefan Eikelmann / Dipl. Volkswirt J. Grote
<i>Kommanditist / -

Référence de publication: 2012056104/29.
(120078735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.

68629

L

U X E M B O U R G

Ter Beke Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 40.550.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société TER BEKE LUXEMBOURG
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012052919/11.
(120073748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

That's It A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 95.618.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012052920/10.
(120073352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

THEOLIA Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 163.192.

EXTRAIT

La Société prends acte que l'adresse exacte de l'associé unique, la société THEOLIA S.A. est la suivante: "75, rue Denis

Papin - 13100 Aix-en-Provence, France".

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 5 mai 2012.

Référence de publication: 2012052921/14.
(120072938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Megapolis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 159.419.

<i>Extrait des décisions des associés au 27 avril 2012

Ce dépôt remplace le dépôt enregistré à Luxembourg et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-

xembourg le 08/05/2012 sous la référence L120074202

1. Madame Aude GOFFART, employée, née à Saint-Avold (France), le 10 mai 1977, demeurant à L-1145 Luxembourg,

59, rue des Aubépines a été nommée comme gérant pour une période indéterminée.

2. Le nombre des gérants est augmenté de 1 (un) à 2 (deux).
3. La société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature de son gérant unique ou, le cas

échéant, par les signatures conjointes de deux gérants de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 mai 2012.

<i>Pour Megapolis S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2012053377/19.
(120074640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

68630

L

U X E M B O U R G

TRE Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 146.281.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 mai 2012.

Référence de publication: 2012052924/10.
(120073805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

TEMTEX S. A. &amp; Cie. INVESTCO première S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 146.317.

<i>Gesellschafterbeschluss im Umlaufverfahren

Die Gesellschafter der TEMTEX S.A. &amp; Cie. INVESTCO première S.e.c.s. mit dem Sitz in 05 rue Bachergaass, L-5444

Schengen, eingefragen im Handelsregister unter B146317 sind

1. INNCONA Management S.ar.l., mit dem Sitz in L-5444 Schengen, 05 rue Baachergaass eingetragen im Handelsre-

gister B 128812,

2. TEMTEX Management S.A. mit dem Sitz in L-5444 Schengen, rue Baachergaass, eingetragen im Handelsregister B

129851, die beiden vorgenannten Gesellschaften als persönlich haftende Gesellschafter und die TEMTEX Management S.
A. als alleinige geschäftsführende Gesellschafterin sowie

3. Herr Stefan Eikelmann, wohnhaft in Alt Schürkesfeld 26, D-40670 Meerbusch, als alleiniger Kommanditist.
Dies vorausgeschickt, beschließen die Gesellschafter Folgendes:
A. Die Gesellschaft wurde am 29.06.2007 mit einem Stammkapital von 175.100 € gegründet.
B. Die Gesellschaft wird rückwirkend zum 31.12.2009 aufgelöst.
Der alleinige Kommanditist, Herr Stefan Eikelmann, kündigt hiermit die Gesellschaft zum 31.12.2009. Die Gesellschaft

wird rückwirkend auf den 31.12.2009 liquidiert.

C. Zum Liquidator wird die TEMTEX Management S.A., vertreten durch den Geschäftsführer Dipl. Volkswirt Joachim

Grote, bestellt.

Sämtliche Beschlüsse wurden mit den Stimmen des Gesellschafters Herr Stefan Eikelmann und damit mit einer Mehrheit

von 100% minus einer Stimme gefasst.

Meerbusch, den 21.12.2010. / Schengen, am 21.12.2010.

<i>- / Für die TEMTEX Management S.A.
Stefan Eikelmann / Dipl. Volkswirt J. Grote
<i>Kommanditist / -

Référence de publication: 2012056105/29.
(120078736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.

Twinhope Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 148.955.

Des compléments des comptes annuels au 31 décembre 2010 déjà déposés en date du 15 avril 2011 sous le numéro

L110059692 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L’agent domiciliataire

Référence de publication: 2012052929/11.
(120073018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Two I.C. Finance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 65.860.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

68631

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clemency, le 5 mai 2012.

Référence de publication: 2012052930/10.
(120072963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Ultima Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 143.834.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2012.

Référence de publication: 2012052931/10.
(120073947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

North Star SA, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 156.037.

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 4 mai 2012:
- acceptation de la démission de Monsieur Erik van Os en tant qu'administrateur avec effet au 4 mai 2012;
- nomination, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, en tant que nouvel administrateur de la Société

avec effet immédiat au 4 mai 2012, de Madame Florence Rao, née le 02 octobre 1975 à Troyes (France), ayant sont
adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2014;

- confirmation que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé par les administrateurs suivants:
* Madame Ekaterina Reshtnikova
* Madame Elena Zhelesznova
* Madame Florence Rao
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 Mai 2012.

<i>Pour la société
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2012055244/23.
(120076968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.

Fosca, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 102.578.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 2 avril 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance suivants:
- Iain Reichwald, Membre du conseil de surveillance, avec adresse professionnelle au 5, Wigmore Street, W1U 1PB

Londres, Royaume-Uni

- Brigitte Sagnes, Membre du conseil de surveillance, avec adresse professionnelle au 26, Avenue des Champs Elysées,

75008 Paris, France

- Luc Laloy, Membre du conseil de surveillance, avec adresse professionnelle au 26, Avenue des Champs Elysées, 75008

Paris, France

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

2. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agrée de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400,

Route d'Esch, L-1014 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

68632

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 mai 2012.

Référence de publication: 2012055637/22.
(120077740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.

Parthenos S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Ris-

que.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 154.509.

L'an deux mille douze, le douze avril.
Par-devant Nous Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, agissant

en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel
dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de la société «Parthenos S.A.

SICAR», société anonyme sous la forme d'une société d'investissement en capital à risque (la «Société»), établie et ayant
son siège social au 1921 boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 154.509. La Société a été constituée suivant acte
notarié en date du 20 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1570 du
2 août 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 4 mars 2011,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1341 du 21 juin 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Cécile HESTIN, avocat, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et scrutatrice Mademoiselle Patricia MARCHI, employée privée, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour

1. Modification de la date statutaire de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle, pour être portée du quatrième

jeudi du mois de juin à onze heures au deuxième jeudi du mois d'avril de chaque année à onze heures et pour la première
fois en l'an deux mille douze.

2. Modification subséquente de l'alinéa 2 de l'article 19 des statuts de la Société.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de modifier la date statutaire de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle, pour la porter

du quatrième jeudi du mois de juin à onze heures au deuxième jeudi du mois d'avril de chaque année à onze heures et
pour la première fois le 12 avril 2012.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 19 des statuts de la

Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 19. Deuxième alinéa. L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la Loi du 10 août 1915 à Lu-

xembourg au siège social de la Société, chaque deuxième jeudi du mois d'avril à 11.00 heures. Si ce jour est férié pour
les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

68633

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: C. HESTIN, P. MARCHI, J.P. MEYERS.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 avril 2012. Relation: EAC/2012/4970. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. HALSDORF.

Référence de publication: 2012056564/59.
(120078847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2012.

Verso S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 143.620.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 avril 2012, l'assemblée a pris, les résolutions

suivantes:

Le siège social de la société est transféré au 29, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg.
Florence Bastin, administrateur de la société, née le 2 juillet 1975 à Haine St Paul, demeure à titre professionnnel

également au 29, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

La société FINEUGEST S.A., B166743, avec siège social au 29, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg, est

nommée commissaire aux comptes en remplacement de Fiscalité Immobilière S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012052941/16.
(120073120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Verso S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 143.620.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

24, Rue Léon Kauffman L-1853 Luxembourg
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012052942/11.
(120073759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Investec GLL SGO REF Holding Alpha, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 136.469.

In the year two thousand and twelve,
on the second day of May.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

“Investec GLL Fund Management Company S.A.”, a public limited company (société anonyme) incorporated and or-

ganised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 15, Rue Bender, L-1229 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number
B 136.469,

acting on behalf of “Investec GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund”, a Luxembourg mutual fund -spe-

cialised  investment  fund  established  pursuant  to  the  Luxembourg  law  of  13  February  2007  relating  to  specialised
investment funds,

represented by Kirill Schitomirski, Rechtsanwalt, residing professionally in L-2314 Luxembourg, by virtue of proxy

given under private seal in Luxembourg on 11 April 2012.

Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole unitholder of Investec GLL SGO REF Holding Alpha S.à r.l., a Luxembourg limited

liability company (une société à responsabilité limitée) incorporated by a notarial deed drawn up by Maître Jean-Joseph

68634

L

U X E M B O U R G

Wagner, notary residing in Sanem, on 11 February 2008, registered in Esch-sur-Alzette A.C. on 15 February 2008, Re-
lation: EAC/2008/2235, and registered with the Trade and Company Register on 27 February 2008, under reference
L080031221.05, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 716,
page 34328, dated 22 March 2008 (the "Articles"), having its registered office at 15, Rue Bender, L-1229 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
136.469 (the "Company") and whose Articles have been amended for the last time by a notarial deed drawn up by the
same notary Jean-Joseph Wagner, on 29 November 2011, published in the Mémorial under number 716, page 34328
dated 29 March 2012.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the notary to enact the following:
- only because of a material mistake, contained in both French and English versions of the notarial deed of incorporation,

the name of the sole unitholder was wrongly indicated as "Investec GLL Fund Management Company S.A. for Investec
GLL Special Global Opportunities Real Estate Fund", whereas the correct name is "Investec GLL Fund Management
Company S.A. for Investec GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund".

For filing and publications, all power is conferred to the bearer of a copy of the present deed.

Done and passed in Luxembourg, days, months and years above the present.
After reading, the above named appearing party, has signed, with Us the undersigned notary, which has drawn up the

present act.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille douze,
le deuxième jour du mois de mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

«Investec GLL Fund Management Company S.A.» une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social

au 15, Rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.469,

agissant pour le compte d'«Investec GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund», un fonds commun de pla-

cement – fonds d'investissement spécialisé luxembourgeois établi conformément à la loi luxembourgeoise du 13 février
2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés,

représentée par Maître Kirill Schitomirski, Rechtsanwalt, ayant sa résidence professionnelle au L-2314 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 11 avril 2012.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte devant être déposé aux autorités d'enregistrement. La partie comparante est l'associé unique de «Investec
GLL SGO REF Holding Alpha S.à r.l.», une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, constituée par un acte notarié
de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 11 février 2008, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le
15 février 2008, Relation EAC/2008/2235 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg en date du
17 février 2008, sous la référence L080031221.05, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le "Mé-
morial") sous le numéro 716, page 34328 en date du 22 mars 2008 (les "Statuts"), ayant son siège social au 15, Rue Bender,
L-1229 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 136.469 (la "Société") et dont les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un
acte notarié du même notaire Jean-Joseph Wagner, le 29 novembre 2011, publié au Mémorial sous le numéro 716, page
34328 en date du 29 mars 2012.

Laquelle comparante, représentée tel qu'indiqué ci-dessus, a requis le notaire d'acter ce qui suit:
- que par suite d'une erreur matérielle, aussi bien contenue dans la version anglaise que française de l'acte notarié de

constitution, la dénomination de l'associé unique a été indiquée de manière erronée comme étant celle d'"Investec GLL
Fund Management Company S.A. pour Investec GLL Special Global Opportunities Real Estate Fund", alors que la déno-
mination  sociale  correcte  est  "Investec  GLL  Fund  Management  Company  S.A.  pour  Investec  GLL  Global  Special
Opportunities Real Estate Fund";

Pour les dépôt et publication, tout pouvoir est conféré au porteur d'une expédition du présent acte.

Fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la partie comparante prémentionnée a signé avec Nous ,notaire instrumentant le présent acte.
Signé: K. SCHITOMIRSKI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 mai 2012. Relation: EAC/2012/5806. Reçu douze Euros (12.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012055146/77.
(120076775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.

68635

L

U X E M B O U R G

Cole Bay Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 121.197.

Par la présente, je vous informe que je démissionne, avec effet au 30 avril 2012, de ma fonction de gérant de la société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, COLE BAY S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-2551 Luxem-
bourg, 41, avenue du X Septembre, constituée par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 16 octobre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et
le numéro 121.197.

Luxembourg, le 30 Avril 2012.

P. AMARANTE LIMITED
S. Mme Selma Louise FRANCIS

Référence de publication: 2012052980/15.
(120073177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Verim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 50.912.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 30 avril 2012, que:
- La démission de Monica Tiuba, en tant qu'administrateur de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Giovanni La Forgia, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouvel

administrateur de la société avec effet immédiat et jusque l'assemblée Générale Ordinaire de 2013.

Pour extrait conforme.

Luxembourg.

Référence de publication: 2012052945/14.
(120073467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Vicem Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 132.813.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 4 mai 2012 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.
En outre, suite à des changements d'adresses Madame Orietta RIMI et Monsieur Roberto sont désormais domiciliés

au 26-28 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, 7 mai 2012.

Référence de publication: 2012052946/14.
(120073451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Vicem Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 132.813.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2012.

Référence de publication: 2012052947/10.
(120073854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

68636

L

U X E M B O U R G

OX Resto Concepts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 143.097.

Herr Robert M. WITTE, Diplom Kaufmann, geboren am 25.01.1972, in Berlin (Deutschland), wohnhaft in SW 10.9QY

London, Drayton GArdens, Grove Court, Flat 14 (Gross Britanien) hat gemäss Vertrtag vom 23.03.2012 achtunddreizig
(38) Anteilen der Gesellschaft "OX Resto Concepts S.à r.l.", welche Ihm gehören an.Herrn Buelent H. SEN, geboren am
07.11.1969 in Ankara (Türkei), wohnhaft in 17, Rue Louis XIV, L-1948 Luxemburg; übertragen, verkauft.

Nach dem Verkauf besitzt Herr Buelent SEN dreiundsiebzig (73) Anteile der Gesellschaft "OX Resto Concepts S.à

r.l.".

Bülent Sen
<i>Geschäftsleitung

Référence de publication: 2012052991/16.
(120073820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Vonadu, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 21, rue Alfred de Musset.

R.C.S. Luxembourg B 74.569.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 mai 2012.

<i>Pour compte de Vonadu Sàrl
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2012052950/12.
(120073915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Warelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 103.740.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012052953/9.
(120073370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Wattshow S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 141.875.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012052954/9.
(120073803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Weber Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 144.175.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

68637

L

U X E M B O U R G

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012052955/11.
(120072981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Yaltha (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 73.535.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 03 mai 2012

Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans:
Monsieur Gallo Aniel, né le 6 février 1962 à Torre Annunziata, demeurant à L-8211 Mamer, Route d'Arlon 53
Madame Masson Mireille, née le 13 juin 1966 à Ougrée, demeurant à L-8211 Mamer, Route d'Arlon 53
Madame Alié Madeleine, née 11 octobre 1940 à Rendeux, demeurant à L-8211 Mamer, Route d'Arlon 53
Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué pour une durée de 6 ans:
Monsieur Gallo Aniel, né le 6 février 1962 à Torre Annunziata, demeurant à L-8211 Mamer, Route d'Arlon 53
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
Fiduciaire et Expertise (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70.909, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012052961/17.
(120073344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Ziglione Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.490.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012052962/10.
(120073903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Gottleuba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 253.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 112.532.

L'adresse des gérants suivants a été modifiée comme suit:
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie A, demeurant professionnellement au 40, Avenue Monterey, L-2163

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Costas Constantinides, gérant de catégorie A, demeurant professionnellement au 40, Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

-  Monsieur  Philip  Gittins,  gérant  de  catégorie  B,  demeurant  professionellement  au  40,  Avenue  Monterey,  L-2163

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Russel Perchard, gérant de catégorie B, demeurant professionnellement au 40, Avenue Monterey, L-2163

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait au Luxembourg, le 11 mai 2012.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2012055651/22.
(120078123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.

68638

L

U X E M B O U R G

A.T.T.C. Control S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 60.319.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 2 mai 2012

L’administrateur démissionnaire, Madame Erika Mulder, est remplacé avec effet immédiat par Monsieur Koen Van

Huynegem, expert comptable, 143, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Koen Van Huynegem / Edward Patteet
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012053003/13.
(120074261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

Capisco S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 34.827.

Suite à votre courrier en date du 19 avril 2012 concernant la mise à jour des informations inscrites auprès du Registre

de commerce et des sociétés, nous vous informons par la présente que la société mentionnée sous rubrique n'est plus
domiciliée à notre adresse depuis le 16 mai 2001.

SGG S.A.
Alex PHAM / Corinne BITTERLICH
<i>Manager / Senior Vice Président

Référence de publication: 2012052977/12.
(120073200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Catwalk Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 167.087.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 3 mai 2012.

Patrick SERRES
<i>Notaire

Référence de publication: 2012052979/12.
(120073175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

D&amp;D Group S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R.C.S. Luxembourg B 156.551.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société D&amp;D Group S.A. SPF qui s'est tenue

en date du 1 

er

 avril 2012 que:

1. Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 5 rue de la Reine, L-2418 Luxembourg.
2. Monsieur Bernard MANRY, avec adresse professionnelle au 5 rue de la Reine, L-2418 Luxembourg, a été nommé

Administrateur de la société avec effet à ce jour, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2017, en
remplacement de Monsieur François MANRY démissionnaire.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2012.

Pour Extrait conforme
Signature
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2012052981/18.
(120073198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

68639

L

U X E M B O U R G

Fleurs Marnie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 47, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 166.229.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 3 mai 2012.

Patrick SERRES
<i>Notaire

Référence de publication: 2012052983/12.
(120073197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Nordea Multi Manager Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 155.517.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 30 mars 2012

Il résulte dudit procès-verbal que:
1) sont réélus au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2013, Messieurs:
Mr. Jari Kivihuhta
Mr. Henrik von Knorring
Mr. Lars Erik Høgh
2) est réélu au poste de réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2013:
KPMG Luxembourg Sarl

Luxembourg, le 3 mai 2012.

Nordea Investment Funds S.A.
Emmanuel Vergeynst / Lidja Palumbo

Référence de publication: 2012052988/18.
(120073416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Sera Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 29.884.

Société constituée le 10 janvier 1989 par Maître Marc Elter (Mémorial C n° 142 du 24.05.89).

Les statuts furent modifiés le 8 décembre 2006 par Me Robert Schuman (Mém 215 du 20.02.07).

EXTRAIT

Suite à la réunion du Conseil d'administration tenue le 27 avril 2012, il est nommé Monsieur Jean Wagener, 10A

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg comme Président du Conseil d'administration, son mandat prendra fin à l'issue
de l'Assemblée à tenir en 2015.

Pour extrait
Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2012052992/16.
(120073168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

3rd WAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 74.285.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012056033/9.
(120078580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

68640


Document Outline

3rd WAY S.A.

Agenotec Group S.à r.l.

Alpha Advisory Company S.A.

A.T.T.C. Control S.A.

Capisco S.A.

Cardiologics S.à r.l.

Catwalk Europe S.A.

CB Richard Ellis Global Alpha Series S.à r.l.

Chauffage Sanitaires Kocan S.à r.l.

Cole Bay Sàrl

D&amp;D Group S.A. SPF

Fleurs Marnie S.à r.l.

Fosca

Gottleuba S.à r.l.

GPF GP S.à r.l.

Investec GLL SGO REF Holding Alpha

Megapolis S.à r.l.

MOM asbl

Nordea Multi Manager Funds

North Star SA

OX Resto Concepts S.à r.l.

Parthenos S.A. SICAR

Sakura House Sàrl

Sera Immobilière S.A.

Seven Club S.à r.l.

Solar Boyz

Synapse Universal S.A.

TEMTEX S. A. &amp; Cie. INVESTCO deuxième S.e.c.s.

TEMTEX S. A. &amp; Cie. INVESTCO première S.e.c.s.

Ter Beke Luxembourg

That's It A.G.

THEOLIA Management Company S.à r.l.

Tiberius X-Line

TRE Investments S.A.

Trinity Street Funds

Triton III LuxCo B 15 S.à r.l.

Twinhope Finance S.A.

Two I.C. Finance S.A. SPF

Tyco Holding IV (Denmark) SE

Ultima Holding S.A.

Up-To-Date, S.à r.l.

Verim S.A.

Verso S.A.

Verso S.A.

Vicem Real Estate S.A.

Vicem Real Estate S.A.

Vonadu

Warelux S.à r.l.

Wattshow S.A.

Weber Investment S.A.

Yaltha (SPF) S.A.

Ziglione Participations Luxembourg S.A.