logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1399

6 juin 2012

SOMMAIRE

Aabar Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67124

Alcove Europe Three S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

67128

ArcelorMittal International Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67127

Cofoot Management s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

67141

Comptoir Pharmaceutique Luxembour-

geois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67142

Continental Investment Holding . . . . . . . . .

67127

Copacore Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67121

Coralis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67137

Crakoukass S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67137

D4S Designer 4 Sport S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

67140

Dassil Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67139

DataCenterEnergie S.A. (DCE)  . . . . . . . . .

67139

Deloitte Audit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67139

Dyamina S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67140

Eni International N.A. N.V. S.àr.l.  . . . . . . .

67140

Eurodyne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67146

EUROHYPO Europäische Hypotheken-

bank S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67146

Europa Financing S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

67146

European Motorway Investments 1  . . . . . .

67151

European Solar Opportunities II . . . . . . . . .

67141

EYNAV Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67147

Ferrero Trading Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

67148

Financière Lafayette S.C.A.  . . . . . . . . . . . . .

67149

Finbelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67150

Finbelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67150

Finpharma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67151

First Gate Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

67151

Fiver S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67151

Fiver S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67152

Friederike MLP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67147

Friederike MLP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67148

Friederike MLP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67148

Granilo Holding B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67148

GT Global Invest (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

67150

HDF Sicav SPE (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67146

Hertford Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

67106

Internationale Participations Financières

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67152

IRM Fund S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67152

Lexwood Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67123

M3 Architectes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67128

Metales Polonia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67152

Mimar Participation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

67124

Nordest Investments & Opportunities (Lu-

xembourg) SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67140

Optik Hoffmann S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

67121

Optique Schaefers Lucien S.à r.l.  . . . . . . . .

67124

Prospector Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

67134

QIAGEN Deutschland Finance Holding

(Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67149

Sèvres III S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67149

Top Way Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67137

Tor-Isteg-Steel-Corporation  . . . . . . . . . . . .

67147

67105

L

U X E M B O U R G

Hertford Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 147.002.

Bolton Group II B.V. to be incorporated (the "Absorbed Company") a private company with limited liability still under

incorporation under the laws of the Netherlands, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number
55386547, and will have its address at 1054 ES Amsterdam, Stadhouderskade 14 H (The Netherlands).

The Absorbed Company to be incorporated will be incorporated as a result of a demerger of Bolton Group B.V., upon

which Bolton Group B.V. shall incorporate the Absorbed Company, of which company Hertford Holding S.à r.l., the sole
shareholder of Bolton Group B.V., shall hold all shares upon its incorporation. Upon said demerger, the Absorbed Com-
pany shall acquire a part of the assets of Bolton Group B.V. under universal succession of title and Bolton Group B.V.
shall continue to exist. The undertakings assumed hereunder by the Absorbed Company are assumed in its name and on
its behalf by Hertford Holding S.à r.l., being the representative of the Absorbed Company according to the extract of the
Absorbed Company issued by the trade register of the Chamber of Commerce in Amsterdam. Once the Absorbed
Company is duly incorporated and registered as such with the trade register of the Chamber of Commerce in Amsterdam
the Absorbed Company will ratify pursuant to article 2:203 paragraph 1 of the Dutch Civil Code, any and all acts performed
on behalf of the Absorbed Company prior to its incorporation.

PROJET COMMUN DE FUSION

Publication faite en vertu de l'article 262 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en vue d'une

fusion transfrontalière dans le cadre de laquelle Bolton Group II B.V., préqualifiée, sera absorbée par Hertford Holding
S.à r.l., préqualifiée.

L'assemblée générale de Hertford Holding S.à r.l. se réunira sans convocation préalable après l'écoulement d'un mois

qui suivra la publication du présent avis au Mémorial C.

La présente publication comprend le projet commun de fusion et les statuts de la société absorbante Hertford Holding

S.àr.l.

Luxembourg, le 31 mai 2012.

<i>Pour les sociétés
Signature

HERTFORD HOLDING S.À R.L.,
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE.
GEPLAATST KAPITAAL: EUR 1.900.000
Maatschappelijk zetel: L-1212 Luxemburg, 3, Rue des Bains.
Geregistreerd in het Handelsregister Luxemburg: onder nummer B 147002
(de "Verkrijgende Vennootschap")
BOLTON GROUP II B.V. IN OPRICHTING
ZAL EEN GEPLAATST KAPITAAL HEBBEN VAN: EUR 25.000
zal haar zetel hebben in: Amsterdam, adres: 1054 ES Amsterdam, Stadhouderskade 14 H (Nederland). Geregistreerd

als B.V. i.o. bij het handelregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 55386547

(de "Verdwijnende Vennootschap")

GEZAMENLIJK VOORSTEL TOT FUSIE

I. De Vennootschappen. De Verdwijnende Vennootschap zal als vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden

opgericht bij splitsing van Bolton Group B.V., waarbij Bolton Group B.V. de Verdwijnende Vennootschap zal oprichten,
van  welke  vennootschap  Hertford  Holding  S.à  r.l.,  de  enig  aandeelhouder  van  Bolton  Group  B.V.,  bij  oprichting  alle
aandelen zal houden. Bij voornoemde splitsing zal de Verdwijnende Vennootschap een deel van het vermogen van Bolton
Group B.V. onder algemene titel verkrijgen en zal Bolton Group B.V. blijven bestaan.

De veronderstellingen opgenomen in dit document zullen door Hertford Holding S.à r.l. blijkens het uittreksel van het

handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam vertegenwoordiger van de Verdwijnende Vennootschap,
namens de Verdwijnende Vennootschap worden gemaakt.

Zodra de Verdwijnende Vennootschap is opgericht en als zodanig is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

van Koophandel in Amsterdam, zal de Verdwijnende Vennootschap op grond van artikel 2:203 lid 1 Nederlands Burgerlijk
Wetboek alle rechtshandelingen verricht namens de Verdwijnende Vennootschap voor haar oprichting bekrachtigen.

De Verkrijgende Vennootschap is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Société à responsabilité limitée)

opgericht en beheerst door het recht van Luxemburg, met maatschappelijke zetel L-1212 Luxemburg, 3, Rue des Bains,
en geregistreerd bij het Handelregister in Luxemburg onder nummer B 147002.

67106

L

U X E M B O U R G

De Verkrijgende Vennootschap zal houder zijn van vijftig (50) aandelen op naam, elk met een nominale waarde van

500 euro (EUR 500), in de Verdwijnende Vennootschap, zijnde alle uitstaande aandelen van de Verdwijnende Vennoot-
schap.

De hiervoor bedoelde geplaatste aandelen zullen geheel volgestort zijn, er zijn geen certificaten van aandelen met

medewerking van de Verdwijnende Vennootschap uitgegeven en er is geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht
op de hierboven genoemde aandelen gevestigd.

De Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap worden tezamen ook genoemd de "Vennoot-

schappen".

De Vennootschappen zijn niet ontbonden, noch verkeren zij in staat van faillissement of hebben zij surseance van

betaling aangevraagd.

De Vennootschappen behoren tot een groep van vennootschappen die direct of indirect gehouden worden door

Bolton Group International SRL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en beheerst door het recht
van Italië ("BGI Groep"). De BGI Groep heeft besloten om haar groepsstructuur te reorganiseren, onder meer door de
fusie tussen de Vennootschappen zoals hiefonder beschreven, maar ook door fusies, reorganisaties of andere overdrach-
ten van vennootschappen binnen de BGI Groep op enig moment.

II. Fusie van de Vennootschappen. Het gehele bestuur/alle directeuren van elk van de Vennootschappen heeft/hebben

de fusie tussen de Vennootschappen (de "Fusie") goedgekeurd, waarbij, na ontbinding zonder liquidatie, alle activa en
passiva van de Verdwijnende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap zullen overgaan in overeenstemming met
artikel 274 van de Luxemburgse vennootschapswet van 10 augustus 1915 als gewijzigd (de "Wet") en waarbij de Verkrij-
gende Vennootschap het gehele vermogen van de Verdwijnende Vennootschap onder algemene titel verkrijgt als gevolg
waarvan de Verdwijnende Vennootschap zal ophouden te bestaan in overeenstemming met Afdeling 1, 2, 3 en 3a Titel 7
Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (het "Nederlands Burgerlijk Wetboek"), en in overeenstemming met dit
gezamenlijk fusieplan of gezamenlijk voorstel tot fusie (het "Fusieplan").

Aangezien alle aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap zullen worden gehouden door de Verkla-

gende Vennootschap, zijn artikel 2:333 lid 1 Nederlands Burgerlijk Wetboek en Artikel 278 van de Wet van toepassing.

Noch de Verkrijgende Vennootschap noch de Verdwijnende Vennootschap kent een raad van commissarissen.
Het bestuur van de Verdwijnende Vennootschap zal aan de enig aandeelhouder van de Verdwijnende Vennootschap

vragen een aandeelhoudersvergadering (de "Vergadering") voor een Nederlandse notaris te houden zo snel als praktisch
mogelijk is na verloop van een maand na het deponeren en het publiceren van het Fusieplan in overeenstemming met de
Artikelen 9 en 262 van de Wet, en na verloop van een maand na het deponeren van het Fusieplan en het publiceren van
de aankondiging daarvan in overeenstemming met de artikel 2:314 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, om zodoende
de Fusie van de Vennootschappen in overeenstemming met het Fusieplan goed te keuren.

Het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap zal, conform Artikel 263 (1) van de Wet, een buitengewone vergadering

van de aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap in aanwezigheid van een notaris beieggen, om tot de Fusie te
besluiten in overeenstemming met het Fusieplan en ervoor te zorgen dat de Fusie effect zal sorteren. De buitengewone
vergadering van de aandeelhouder zal zo spoedig mogelijk na verloop van een maand na het deponeren en publiceren van
het Fusieplan overeenkomstig de Artikelen 9 en 262 van de Wet en Artikel 2:314 Nederlands Burgerlijk Wetboek plaats-
vinden.

Alle activa en passiva behorende tot de Verdwijnende Vennootschap (bekend of onbekend) zullen krachtens wet (ipso

jure) per de datum van het van kracht worden van de Fusie, zowel tussen de Vennootschappen als vis-à-vis derden, worden
overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap in overeenstemming met, en onderworpen aan, Artikel 274 van de Wet.
De Fusie zal van kracht en effectief worden op de dag waarop de notariële akte wordt verleden voor een notaris in
Luxemburg.

III. Goedkeuring van de Besluiten tot Fusie. De Statuten van de Verkrijgende Vennootschap bevatten geen specifieke

voorschriften  met  betrekking  tot  het  besluit  tot  fusie.  Het  besluit  tot  fusie  zal  worden  genomen  door  de  algemene
vergadering van aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap.

Het besluit tot fusie zal worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Verdwijnende

Vennootschap.

IV. Samenstelling van het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap. De Fusie heeft geen effect op de samenstelling

van het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap.

V. Statuten van de Verkijgende Vennootschap. De Statuten van de Verkrijgende Vennootschap zijn, sinds haar oprich-

ting op 30 juni 2009 (gepubliceerd in Memorial C n° 1391 van 20 juli 2009, p. 66745) niet gewijzigd. De doorlopende
tekst van de Statuten van de Verkrijgende Vennootschap is aangehecht aan dit Fusieplan (Annex 1). De Statuten van de
Verdwijnende Vennootschap zullen niet worden gewijzigd ter gelegenheid van de Fusie.

VI. Gevolgen van de Fusie voor de Crediteuren en Debiteuren van de Verdwijnende Vennootschap. Alle activa en

passiva zullen, zonder uitzondering, overgaan op de Verkrijgende Vennootschap op grond van de wet, zonder dat daarbij
achting behoeft te worden geslagen op de periode waarin deze waren verkregen of aangegaan.

67107

L

U X E M B O U R G

VII. Effecten van de Fusie op de Verkrijgende Vennootschap. De Fusie zal geen effect hebben op de goodwill van de

Verkrijgende Vennootschap. De waarde van de Verdwijnende Vennootschap zal worden opgenomen in de vrij uitkeerbare
reserves van de Verkrijgende Vennootschap, welke zal toenemen.

VIII. Datum Waarop de Fusie van Kracht Wordt Vanuit Accounting Oogpunt. Vanuit accounting oogpunt, zullen de

werkzaamheden van de Verdwijnende Vennootschap worden behandeld als ware zij verricht door de Verkrijgende Ven-
nootschap vanaf 3 juli 2012. De financiële gegevens van de Verdwijnende Vennootschap zullen worden verwerkt in de
jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 juni 2012.

IX. Informatie over de Waardering van de Activa en Passiva van de Verdwijnende Vennootschap die Zullen Worden

Verkregen Door de Verkrijgende Vennootschap. De waardering van de relevante activa en passiva van de Verdwijnende
Vennootschap  die  door  de  Verkrijgende  Vennootschap  zullen  worden  verkregen  is  gespecificeerd  in  de  tussentijdse
vermogensopstelling van de Verdwijnende Vennootschap per 31 mei 2012. De waardering vond plaats op basis van netto
boekwaarde van 31 mei 2012.

X. Verslag van een Onafhankelijke Expert. Volgens Artikel 266 (1) en 278 van de Wet is in verband met de Fusie geen

verslag van een onafhankelijke expert vereist en zal een dergelijk verslag niet opgemaakt worden.

XI. Laatste Jaarrekeningen. De vastgestelde jaarrekeningen over 2009, 2010 en 2011 van de Verkrijgende Vennoot-

schap,  alsmede  de  tussentijdse  vermogensopstelling  met  betrekking  tot  de  activa  en  passiva  op  31  mei  2012  van  de
Verdwijnende Vennootschap, zijn gebruikt om de voorwaarden voor de fusie vast te stellen, respectievelijk zijn opgesteld
in verband met deponering bij het Nederlandse Handelsregister.

De Verkrijgende Vennootschap zal de activa en passiva van de Verdwijnende Vennootschap verkrijgen onder algemene

titel tegen netto boekwaarde zoals uiteengezet in de tussentijdse vermogensopstelling van de Verdwijnende Vennootschap
met betrekking tot haar activa en passiva op 31 mei 2012.

XII. Voorstel voor de Hoogte van de Schadeloosstelling bij Toepassing van Artikel 2:333H van het Nederland Burgeriljk

Wetboek. Aangezien de Verkrijgende Vennootschap de enig aandeelhouder is van de Verdwijnende Vennootschap, is
artikel 2:333h van het Nederlands Burgerlijk Wetboek niet van toepassing, ook al is de Verkrijgende Vennootschap een
vennootschap naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Omdat de Verkrijgende Vennootschap alle aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap zal houden, is

overeenkomstig Artikel 278 van de Wet geen tegenprestatie verschuldigd in verband met de Fusie. Verder behoeft dit
document, overeenkomstig Artikel 278 van de Wet en vanwege het feit dat geen tegenprestatie verschuldigd is in verband
met de Fusie, geen details te geven over de ruilverhouding of betalingen in cash (Artikel 261 (2),b van de Wet), de
voorwaarden verbonden aan het toekennen van aandelen of andere zekerheiden van de Verkrijgende Vennootschap
(Artikel 261 (2), c van de Wet) of de datum vanaf wanneer zulke aandelen recht zullen geven op winstuitkeringen van de
Verkrijgende Vennootschap (Artikel 261 (2), d van de Wet).

XIII. Rechten/voordelen. Aan geen van de bestuurders, accountants van de Vennootschappen noch aan enige bij de

voorgenomen fusie betrokken derde, zoals onafhankelijke experts als bedoeld in Artikel 266 (1) van de Wet, zal enig
voordeel in verband met de Fusie worden toegekend.

De Verdwijnende Vennootschap heeft geen effecten verstrekt aan enig (rechts)persoon anders dan de aandelen geh-

ouden door de Verkrijgende Vennootschap in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap.

XIV. Rechten of Vergoedingen die Door de Verkrijgende Vennootschap Worden Toegekend Krachtens Artikel 261

(2), F van de Wet en Artikel 2:320 Juncto Artikel 2:312 Lid 2 Sub C van Het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Er zijn geen
(rechts)personen die anders dan als aandeelhouder bijzondere rechten jegens de Verdwijnende Vennootschap hebben
en er zijn geen aandeelhouders die speciale rechten hebben en geen houders van zekerheden anders dan aandelen of
corporate units of andere personen met een speciaal recht jegens de Verdwijnende Vennootschap, zodat geen rechten
of vergoedingen behoeven te worden toegekend door de Verkrijgende Vennootschap.

XV. Voorgenomen Maatregelen in Verband met de Overgang van het Aandeelhouders Chap van de Verdwijnende

Vennootschap. Er zullen geen maatregelen worden genomen anders dan het aantekenen in het aandeelhoudersregister
van de Verdwijnende Vennootschap dat als gevolg van de Fusie de Verdwijnende Vennootschap is opgehouden te bestaan.

XVI. Voornemens in Verband met het Voorzetten dan wel Beeindigen van de Werkzaamheden. De werkzaamheden

van de Verdwijnende Vennootschap zullen door de Verkrijgende Vennootschap op dezelfde voet worden voortgezet als
zij werden verricht voor de Fusie.

XVII. Werknemers. Er zijn geen werknemers in dienst van de Vennootschappen. De Fusie heeft geen effect vanuit een

sociaal oogpunt.

XVIII. Waarschijnlijke Gevolgen op Tewerkstelling. De Fusie zal geen effect hebben op de tewerkstelling.

XIX. Procedures in Verband met Medezeggenschap van Werknemers. De regelingen met betrekking tot medezeg-

genschap van werknemers als bedoeld in artikel 2:333k van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en Artikel 261 (4), c van
de Wet zijn niet van toepassing aangezien er geen (centrale) ondernemingsraad of ander vennootschapsorgaan bevoegd

67108

L

U X E M B O U R G

is te adviseren over de voorgenomen fusie en om die reden vennootschappelijke medezeggenschap zou hebben. Daarom
kan er geen informatie over de procedure tot vaststelling van de regelingen worden gegeven.

XX. Overige Bepalingen. De Verkrijgende Vennootschap zal alle vereiste en benodigde formaliteiten verrichten om

de Fusie te finaliseren.

Dit gezamenlijke voorstel tot fusie mag op verschalende versies worden getekend en het geheel daarvan zal het ge-

zamenlijke voorstel tot fusie vormen.

HERTFORD HOLDING S.À R.L.
Jean Hoos / Gerhard A. Greidanus / Freddy R. Martell
<i>Bestuurder / Bestuurder / Bestuurder
BOLTON GROUP II B.V. I.O.
Hertford Holding S.à r.l. / Hertford Holding S.à r.l. / Hertford Holding S.à r.l.
Jean Hoss / Gerhard A. Greidanus / Freddy R . Martell
<i>Bestuurder / Bestuurder / Bestuurder

HERTFORD HOLDING S.À R.L.,
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE.
CORPORATE CAPITAL: EUR 1,900,000
Registered office: L-1212 Luxembourg, 3, Rue des Bains.
Register of Commerce and Companies (RCS) Luxembourg: registered with the RCS under number B 147002
(the "Absorbing Company")
BOLTON GROUP II B.V. TO BE INCORPORATED
WHICH SHALL HAVE A CORPORATE CAPITAL OF: EUR 25,000
and its corporate seat shall be in: Amsterdam, address: 1054 ES Amsterdam, Stadhouderskade 14 H (the Netherlands).
Registered as company (B.V.) to be incorporated with the trade register of the Chamber of Commerce in Amsterdam

under number 55386547

(the "Absorbed Company")

JOINT MERGER PROPOSAL

I. The companies. The Absorbed Company will be incorporated as a private company with limited liability (besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) as a result of a demerger of Bolton Group B.V., upon which Bolton Group
B.V. shall incorporate the Absorbed Company, of which company Hertford Holding S.à r.l., the sole shareholder of Bolton
Group B.V., shall hold all shares upon its incorporation. Upon said demerger, the Absorbed Company shall acquire a part
of the assets of Bolton Group B.V. under universal succession of title and Bolton Group B.V. shall continue to exist.

The undertakings assumed hereunder by the Absorbed Company are assumed in its name and on its behalf by Hertford

Holding S.à r.l., being the representative of the Absorbed Company according to the extract of the Absorbed Company
issued by the trade register of the Chamber of Commerce in Amsterdam.

Once the Absorbed Company is duly incorporated and registered as such with the trade register of the Chamber of

Commerce in Amsterdam the Absorbed Company will ratify pursuant to article 2:203 paragraph 1 of the Dutch Civil
Code, any and all acts performed on behalf of the Absorbed Company prior to its incorporation.

The  Absorbing  Company  is  a  private  limited  liability  company  (Société  à  responsabilité  limitée)  incorporated  and

existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered office at L-1212 Luxembourg, 3, Rue des Bains,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 147002.

The Absorbing Company shall be the owner of fifty (50) registered shares, each with a par value of 500 Euro (EUR

500), in the Absorbed Company, representing all the shares of the Absorbed Company.

The said issued shares will be fully paid-up, no depositary receipts for the above shares have been issued with the

concurrence of the Absorbed Company, nor has a right of usufruct or a right of pledge been established on the above
shares.

The Absorbing Company and the Absorbed Company are collectively referred to as the "Companies".
The Companies have not been dissolved, nor have they been declared bankrupt or have they filed a petition for

suspension of payments.

The Companies belong to a group of companies owned directly or indirectly by Bolton Group International SRL, a

private limited liability company incorporated and existing under the laws of Italy ("BGI Group"). The BGI Group has
decided to reorganize its group structure which includes the merger of the Companies as described below, as well as
mergers, combinations or other movements of companies within the BGI Group from time to time.

II. Merger of the companies. The entire management boards of each of the Companies has approved the merger of

the Companies (the "Merger") whereby, following its dissolution without liquidation, the Absorbed Company will transfer
to the Absorbing Company all of its assets and liabilities in accordance with Article 274 of the Luxembourg Law of August

67109

L

U X E M B O U R G

10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), and upon which the Absorbing Company shall acquire the
entire assets and liabilities (gehele vermogen) of the Absorbed Company under universal succession of title (algemene
titel) as a consequence of which the Absorbed Company shall cease to exist in the meaning of Chapters 1, 2, 3 and 3A
of Part 7, Book 2 of the Dutch Civil Code (the "Dutch Civil Code"), and in accordance with this joint merger plan or
joint merger proposal (the "Merger Proposal").

As all shares in the capital of the Absorbed Company will be held by the Absorbing Company, article 2:333 paragraph

2 of the Dutch Civil Code and Article 278 of the Law shall apply.

Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Company has a Supervisory Board.
The management board of the Absorbed Company shall request the sole shareholder of the Absorbed Company to

hold a meeting of shareholders (the "Meeting") before a Dutch notary as soon as practicable, after one month has elapsed
following the filing and publication of the Merger Proposal in accordance with Articles 9 and 262 of the Law, and after
one month has elapsed following the filing of the Merger Proposal and publication of the notice thereof in accordance
with article 2:314 of the Dutch Civil Code, in order to approve the Merger of the Companies in accordance with the
Merger Proposal.

The management board of the Absorbing Company shall convene an extraordinary general meeting of the shareholder

of the Absorbing Company in the presence of a notary, pursuant to Article 263 (1) of the Law, in order to resolve upon
the Merger in accordance with the Merger Proposal and to render the Merger effective. The extraordinary general meeting
shall be held as soon as practicable after one month has elapsed following the filing and publication of the Merger proposal
in accordance with Articles 9 and 262 of the Law and Article 2:314 of the Dutch Civil Code.

All the assets and liabilities belonging to the Absorbed Company (known or unknown) as of the effective date of the

Merger will by operation of the law, ipso jure, both as between the Companies and vis-à-vis third parties, be transferred
to the Absorbing Company in accordance with, and subject to, Article 274 of the Law. The Merger becomes in full force
and effect as from the day on which the notarial merger deed has been executed by a notary in Luxembourg.

III. Approval of the resolutions to merge. The articles of association of the Absorbing Company do not contain specific

provisions concerning the resolution to merge. The resolution to merge shall be adopted by the general meeting of
shareholders of the Absorbing Company.

The resolution to merge shall be adopted by the general meeting of shareholders of the Absorbed Company.

IV. Composition of the management board of the absorbing company. The Merger will not affect the composition of

the management board of the Absorbing Company.

V. Articles of association of the absorbing company. The Absorbing Company's articles of association have not been

amended since its incorporation on 30 June 2009 (published in Memorial C n° 1391 of 20 July 2009, p. 66745). The
complete text of the articles of association of the Absorbing Company is attached to this Merger Proposal (Annex 1).
The articles of association of the Absorbed Company shall not be amended on occasion of the Merger.

VI. Effects of the merger for the creditors and Debtors of the absorbed company. All assets and liabilities will, without

exception be transferred to the Absorbing Company by virtue of law, without regard as to the period at which they were
acquired or assumed.

VII. Effects of the merger on the absorbing company. The Merger will not have any effect on the goodwill of the

Absorbing Company. The value of the Absorbed Company will be included in the free distributable reserves of the
Absorbing Company which will increase.

VIII. Effective date of the merger from an accounting point of view. From an accounting point of view, the operations

of the Absorbed Company shall be treated as having been carried out on behalf of the Absorbing Company as of July 3,
2012.  The  financial  data  of  the  Absorbed  Company  shall  be  accounted  for  in  the  annual  accounts  of  the  Absorbing
Company as of June 1, 2012.

IX. Information on the valuation of assets and Liabilities of the absorbed company to be acquired by the absorbing

company. The valuation of the relevant assets and liabilities of the Absorbed Company to be acquired by the Absorbing
Company is specified in the interim financial statements of the Absorbed Company, dated as of May 31, 2012. The valuation
was done on the basis of net book value as of May 31, 2012.

X. Independent expert's report. Pursuant to Article 266 (1) and 278 of the Law, no independent expert report is

required in connection with the Merger and no such report will be prepared.

XI. Last annual accounts. The adopted annual, accounts for 2009, 2010 and 2011 of the Absorbing Company, as well

as the interim financial statement of the Absorbed Company regarding its assets and liabilities as at May 31, 2012 have
been used to establish the conditions of the Merger, respectably prepared with respect to the deposit with the Dutch
Trade register.

The Absorbing Company shall acquire the Absorbed Company's assets and liabilities under universal succession of

title at their net book value as set out in the interim financial statement of the Absorbed Company, regarding its assets
and liabilities as at May 31, 2012.

67110

L

U X E M B O U R G

XII. Proposal of amount of damages by application of article 2:333H of the dutch civil code and Articles 278 and 261

(2), B, C, D of the law. Due to the fact that the Absorbing Company is the sole shareholder of the Absorbed Company,
article 2:333h of the Dutch Civil Code is not applicable, even though the Absorbing Company is a company under the
law of another Member State of the European Union or the European Economic Area.

As the Absorbing Company will hold all the issued shares of the Absorbed Company, no consideration will be payable

under the Merger in accordance with Article 278 of the Law. Furthermore, pursuant to Article 278 of the Law and as a
result of there being no consideration for the Merger this document is not required to and does not, give details of the
share exchange ratio or amount of a cash payment (Article 261 (2),b of the Law), the terms relating to the allotment of
shares or other securities of the Absorbing Company (Article 261 (2), c of the Law) or the date from which any such
shares shall participate in profits of the Absorbing Company (Article 261 (2), d of the Law).

XIII. Rights/Advantages. No special advantage will be granted to the directors, auditors of the Companies, nor to third

parties, such as independent experts referred to at Article 266 (1) of the Law, in connection with or as a result of the
Merger.

The Absorbed Company has not issued to any person any securities other than the shares held by the Absorbing

Company in the share capital of the Absorbed Company.

XIV. Rights to be granted or compensation to be awarded by the absorbing company pursuant to article 261 (2), F of

the law and Pursuant to article 2:320 in conjunction with article 2:312 paragraph 2 sub C. of the dutch civil code. As there
are no persons who, in any other capacity than as shareholder, have special rights vis-à-vis the Absorbed Company and
there are no shareholders having special rights and no holders of securities other than shares or corporate units, or other
persons having special rights vis-à-vis the Absorbed Company, no special rights nor compensations will be granted at the
expense of the Absorbing Company to anyone.

XV. Contemplated measures in connection with the transfer of ownership of the absorbed company. No measures

shall be taken other than the recording in the shareholders register of the Absorbed Company that as a consequence of
the Merger the Absorbed Company has ceased to exist.

XVI. Intentions regarding continuation or winding up of activities. The activities of the Absorbed Company shall be

continued by the Absorbing Company in the same manner.

XVII. Employees. There are no employees in the Companies. The Merger has no effect from a social point of view.

XVIII. Likely effects on employment. The Merger will not have any effect on employment.

XIX. Procedures for employee participation. The provisions with regard to employee participation as stated in article

2:333k of the Dutch Civil Code and Article 261 (4), c of the Law are not applicable since there is no (central) works
council or other corporate body which is entitled to advise with regard to the contemplated merger and therefore has
company co-determination (vennootschappelijke medezeggenschap).

Therefore no information about determination of the provisions can be given.

XX. Additional provisions. The Absorbing Company shall carry out all required and necessary formalities in order to

complete the Merger.

The present joint merger proposal may be signed in different counterparts which taken together shall form the same

joint merger proposal.

HERTFORD HOLDING S.À R.L.
Jean Hoos / Gerhard A. Greidanus / Freddy R. Martell
<i>Director / Director / Director
BOLTON GROUP II B.V. I.O.
Hertford Holding S.à r.l. / Hertford Holding S.à r.l. / Hertford Holding S.à r.l.
Jean Hoss / Gerhard A. Greidanus / Freddy R. Martell
<i>Director / Director / Director

HERTFORD HOLDING S.À R.L., SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE.
CAPITAL SOCIAL: EUR 1.900.000
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, Rue des Bains. R.C.S. Luxembourg: immatriculée auprès du RCS sous le numéro

B 147002

(la "Société Absorbante")
BOLTON GROUP II B.V. EN CONSTITUTION
QUI AURA UN CAPITAL SOCIAL DE: EUR 25.000
et son siège social sera à : Amsterdam, adresse: 1054 ES Amsterdam, Stadhouderskade 14 H (Pays-Bas).
Immatriculée comme une société (B.V.) à être constituée et immatriculée avec le registre de commerce de la Chambre

de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 55386547

67111

L

U X E M B O U R G

(la "Société Absorbée")

PROJET DE FUSION

I. Les sociétés. La Société Absorbée sera constituée comme une société privée à responsabilité limitée (besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) suite à une scission de Bolton Group B.V., suivant laquelle Bolton Group
B.V. constituera la Société Absorbée, société de laquelle, Hertford Holding S.à r.l., l'actionnaire unique de Bolton Group
B.V., détiendra toutes les actions dès qu'elle sera constituée. Dès la scission mentionnée, la Société Absorbée acquerra
une partie des actifs de Bolton Group B.V. à titre de succession universelle et Bolton Group B.V. continuera d'exister.

Les engagements assumés ci-après par la Société Absorbée sont assumés en son nom et pour son compte par Hertford

Holding S.à r.l., qui est le représentant de la Société Absorbée conformément à l'extrait de la Société Absorbée émis par
le registre de commerce de la chambre de commerce d'Amsterdam.

Une fois la Société Absorbée est dûment constituée et enregistrée en tant que telle auprès du registre de commerce

de la chambre de commerce d'Amsterdam la Société Absorbée ratifiera conformément à l'article 2:203 paragraphe 1 du
Code civil néerlandais, tous les actes accomplis pour le compte de la Société Absorbée avant sa constitution.

La Société Absorbante est une société privée à responsabilité limitée, constitué et existante en conformité avec les

lois du Grand-duché de Luxembourg, avec siège social à L-1212 Luxembourg, 3, Rue des Bains, immatriculée auprès le
Registre de Commerce et Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147002.

La Société Absorbante sera la propriétaire de cinquante (50) actions nominatives ayant une valeur nominale de cinq

cents euro (EUR 500) chacune dans la Société Absorbée, représentant toutes les actions de la Société Absorbée.

Les actions émises seront intégralement souscrites, aucun certificat n'a été émis pour ces actions avec l'accord de la

Société Absorbée, et aucun droit d'usufruit ou de gage n'a été établi sur les actions susmentionnées.

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont conjointement dénommées ci-après comme les "Sociétés".
Les Sociétés n'ont pas été dissoutes, elles n'ont pas été déclarées en faillite et elles n'ont pas introduit une demande

pour une suspension de paiements.

Les Sociétés appartiennent à un group de sociétés détenu directement ou indirectement par Bolton Group Interna-

tional SRL, une société privée à responsabilité limitée, constitué et existante en conformité avec les lois du Italie ("Groupe
BGI"). Le Groupe BGI a décider de réorganiser la structure du groupe, ce qui inclut la fusion des Sociétés telle que décrite
ci-dessous, ainsi que les fusions, réorganisations ou autres transferts des sociétés au sein du Groupe BGI, le cas échéant.

II. Fusion des sociétés. Les conseils de gérances de chacune des Sociétés ont approuvés à l'unanimité la fusion des

Sociétés (la "Fusion"), selon laquelle, par suite d'une dissolution sans liquidation, la Société Absorbée transfère à la Société
Absorbante tout le patrimoine actif et passif conformément à l'Article 274 de la Loi de 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), et sur lesquels la Société Absorbante acquerra la totalité des actifs et des
passifs (gehele vermogen) de la Société Absorbée en vertu de la succession universelle du titre (algemene titel) et en
conséquence de laquelle la Société Absorbée cessera d'exister conformément aux Chapitres 1, 2, 3 et 3A de Partie 7,
Livre 2 du Code Civil Néerlandais (le "Code Civil Néerlandais") et du présent plan de Fusion commun ou projet de Fusion
commun (le "Projet de Fusion").

Alors que toutes les actions dans le capital de la Société Absorbée seront détenues par la Société Absorbante, l'article

2:333 § 1 du Code Civil Néerlandais et l'article 278 de la Loi seront d'application.

Ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée n'ont établi un conseil de surveillance.
Le conseil de gérance de la Société Absorbée demandera à l'actionnaire unique de la Société Absorbée de tenir une

assemblée générale des actionnaires (la "Réunion") devant un notaire néerlandais le plus vite possible après qu'un délai
d'un mois ne soit écoulé après le dépôt et la publication du Projet de Fusion conformément aux Articles 9 et 262 de la
Loi et après qu'un délai d'un mois ne soit écoulé après le dépôt du Projet de Fusion et la publication de sa mention
conformément à l'article 2:314 du Code Civil Néerlandais, afin approuver la Fusion des Sociétés conformément au Projet
de Fusion.

Le conseil de gérance de la Société Absorbante convoquera une assemblée générale extraordinaire des actionnaires

de la Société Absorbante en présence d'une notaire, conformément à l'Article 263 (1) de la Loi, afin de décider la Fusion
selon le Projet de Fusion et de rendre la Fusion définitive. L'assemblée générale extraordinaire sera tenue le plus vite
possible après qu'un délai d'un mois ne soit écoulé après le dépôt et la publication du Projet de Fusion conformément
aux articles 9 et 262 de la Loi et à l'article 2:314 du Code civil néerlandais.

L'intégralité du patrimoine actif et passif détenu par la Société Absorbée (connu ou pas) sera, à partir de la date définitive

de la Fusion de plein droit, ipso jure, vis-à-vis des Sociétés et vis-à-vis des tiers, transféré à la Société Absorbante con-
formément à et selon l'Article 274 de la Loi. La Fusion prendra pleinement effet à partir du jour où l'acte de Fusion aura
été exécuté par un notaire à Luxembourg.

III. Approbation des décisions de fusion. Les statuts de la Société Absorbante ne contiennent pas de conditions spé-

cifiques concernant la décision de procéder à une fusion. La décision de fusionner sera adoptée par l'assemblée générale
de la Société Absorbante.

La décision de fusionner sera approuvée par l'assemblée générale de la Société Absorbée.

67112

L

U X E M B O U R G

IV. Composition du conseil de gérance de la société absorbante. La Fusion n'aura aucun effet sur la composition du

conseil de gérance de la Société Absorbante.

V. Statuts de la société absorbante. Les statuts de la Société Absorbante n'ont pas été modifiés depuis sa constitution

le 30 juin 2009 (publié au Mémorial C n° 1391 du 20 juillet 2009, p. 66745). Le texte intégral des statuts de la Société
Absorbante est joint à ce Projet de Fusion (Annexe 1). Les statuts de la Société Absorbée ne sont pas modifiés à l'occasion
de la Fusion.

VI. VI. Effets de la fusion pour les créanciers et Débiteurs de la société absorbée. Conformément à la Loi, tous actifs

et passifs de la Société Absorbée seront transférés sans exception à la Société Absorbante, sans tenir compte de la date
à laquelle ils ont été acquis ou assumés.

VII. Effets de la fusion sur la société absorbante. La Fusion n'aura aucun effet sur le goodwill de la Société Absorbante.

La valeur de la Société Absorbée sera inclue dans les réserves librement distribuables de la Société Absorbante, qui
augmenteront.

VIII. Date définitive de la fusion du point vue comptable. Du point vue comptable, les opérations de la Société Absorbée

seront considérées comme accomplies par la Société Absorbante à partir du 3 juillet 2012. Les données financières de la
Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absorbante au 1 

er

 juin 2012.

IX. Information sur la valorisation des actifs et Passifs de la société absorbée devant être acquis par la société absor-

bante. La valorisation des actifs et passifs pertinents de la Société Absorbée devant être acquis par la Société Absorbante
est détaillée dans l'état financier intérimaire de la Société Absorbée, daté du 31 mai 2012. La valorisation a été effectuée
sur base de la valeur nette comptable au 31 mai 2012.

X. Rapport de l'expert indépendant. Conformément à l'article 266 (1) et 278 de la Loi, un rapport d'un expert indé-

pendant n'est pas requis en relation avec la Fusion et un tel rapport ne sera pas préparé.

XI. Derniers comptes annuels. Les comptes annuels approuvés pour les exercices 2009, 2010 et 2011 de la Société

Absorbante, ainsi que l'état financier intérimaire de la Société Absorbée, en ce qui concerne ses actif et passifs en date
du 31 mai 2012, ont été utilisés pour établir les conditions de la Fusion, préparés respectivement pour le dépôt auprès
le registre de commerce néerlandais.

La Société Absorbante acquerra tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, à titre de succession universelle, à

leur valeur nette comptable telle que définie dans l'état financier intérimaire de la Société Absorbée, en ce qui concerne
ses actif et passifs en date du 31 mai 2012.

XII. Proposition du montant de dommages en application de l'article 2:333H du code civil néerlandais. Eu égard au fait

que la Société Absorbante est le actionnaire unique de la Société Absorbée, l'article 2:333h du Code Civil Néerlandais
n'est pas d'application, même si la Société Absorbante est une société établie selon la loi d'une autre Etat Membre de
l'Union Européen ou de l'Espace Economique Européen.

Comme la Société Absorbante détiendra tous les titres émis par la Société Absorbée, aucune contrepartie ne sera

due en relation avec la Fusion conformément à l'article 278 de la Loi. En outre, conformément à l'article 278 de la Loi et
en conséquence du fait qu'aucune contrepartie n'est due en relation avec la Fusion, le présent document ne doit pas, et
ne donne aucun détail quant au ratio d'échange des actions ou au montant d'un paiement en numéraire (article 261 (2),
b de la Loi), quant aux termes régissant l'allocation des actions ou autres titres de la Société Absorbante (article 261 (2),
c de la Loi) ou la date à partir de laquelle lesdites actions participent au bénéfice de la Société Absorbante (261 (2), d de
la Loi).

XIII. Droits/Avantages. Aucun avantage particulier ne sera accordé aux administrateurs, experts comptables des So-

ciétés, ni à des tiers, tels que experts indépendants dont est fait référence à l'article 266(1) de la Loi en relation avec ou
en conséquence de la Fusion.

La Société Absorbée n'a pas émis des titres autres que des actions détenues par la Société Absorbante dans le capital

social de la Société Absorbée.

XIV. Droits ou compensations a accorder par la société absorbante selon l'article 261 (2), F de la loi et selon l'article

2:320 en conjonction avec l'article 2:312 § 2 C. du code civil néerlandais. Dans la mesure où il n'y a aucune personne qui,
autrement  qu'en  tant  qu'actionnaire,  possède  des  droits  spéciaux  vis-à-vis  de  la  Société  Absorbée,  et  qu'il  n'y  a  pas
d'actionnaires ayant des droits spéciaux et pas de détenteurs d'autres titres autres que des actions ou unités sociales, ou
d'autres personnes ayant des droits spéciaux vis-à-vis de la Société Absorbée, aucun droit spécial ou autre compensation
ne seront octroyés à quiconque au dépens de la Société Absorbante.

XV. Mesures envisagées concernant le transfert de propriété de la société absorbée. Aucune mesure ne sera prise

autre que l'inscription dans le registre des actionnaires de la Société Absorbée du fait que suite à la Fusion la Société
Absorbée cessera d'exister.

XVI. Intentions concernant la continuation ou la dissolution des activités. Les activités de la Société Absorbée seront

continuées par la Société Absorbante de la même manière.

67113

L

U X E M B O U R G

XVII. Employés. Il n'y a pas d'employés dans les Sociétés. La Fusion n'entrainera pas d'effet du point de vue social.

XVIII. Effets probables sur l'emploi. La Fusion n'aura aucun effet sur l'emploi.

XIX. Procédures pour la participation des employés. Les conditions à l'égard la participation des employés telles que

prévues à l'article 2:333k du Code Civil Néerlandais et à l'article 261 (4) de la Loi ne sont pas d'application car il n'y a
pas de conseil d'entreprise (central) ou d'autres organes sociaux qui sont autorisés à rendre un avis concernant la Fusion
proposée et qui ont en conséquence un pouvoir de cogestion (vennootschappelijke medezeggenschap). Par conséquent,
aucune information concernant la détermination des dispositions ne peut être donnée.

XX. Conditions additionelles. La Société Absorbante effectuera toutes les formalités nécessaires afin de concrétiser

la Fusion.

Ce projet commun de fusion pourra être signé en différents exemplaires qui pris ensemble formeront le même projet

commun de fusion.

HERTFORD HOLDING S.À R.L.
Jean Hoos / Gerhard A. Greidanus / Freddy R. Martell
<i>Gérant / Gérant / Gérant
BOLTON GROUP II B.V. I.O.
Hertford Holding S.à r.l. / Hertford Holding S.à r.l. / Hertford Holding S.à r.l.
Jean Hoss / Gerhard A. Greidanus / Freddy R. Martell
<i>Gérant / Gérant / Gérant

In the year two thousand and nine, on the thirtieth day of the month of June.
Before Me Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg) was held an extraordinary general meeting

of members of Gordon Investments N.V., a company incorporated under the laws of the "Netherlands Antilles" and
having its registered office and main place of business at Berg Arrarat 1, P.O. Box 3889, Curaçao, Netherlands Antilles
and registered into the Company Registrar under numbers 13801 (0) (the "Company").

The meeting is opened at 01,25 p.m. under Mr Gerhard Greidanus, chairman of the board of directors of Bolton Group

International S.A., residing at Stadthouderskade 14 H, 1054 ES Amsterdam, The Netherlands, being in the chair.

The chairman appoints as secretary Mr. Jean Hoss, avocat à la Cour, residing in 2, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg.

Mr. Peter Sassoon, executive of Bolton Group Coordination B.V., Geneva residing at 30, rue du Rhône, CH-1204

Geneva, Switzerland and Mr. Maarten van de Vaart, member of the board of directors of Bolton Trading Corporation
S.A., residing at 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg have been elected as the scrutineers.

All present and accepting their appointments.
The bureau being thus constituted the chairman notes the representation of the entire issued share capital of the

Company and requests the notary to record the proceedings:

I. The agenda of the meeting is as follows:
1. Transfer of the registered office and of the main place of business of the Company to Luxembourg, conversion of

the Company into a S.à r.l. under Luxembourg law and adoption by the Company of the Luxembourg corporate nationality.

2. Valuation by the members and by the board of Managers of the Company of all assets and liabilities.
3. Change of the corporate name to Hertford Holding S.à. r.l.
4. Restatement of the Articles of Association and of the corporate capital of the Company in compliance with Lux-

embourg Company law.

5. Authorisation to the board of Managers to prepare the balance sheet based on the evaluation of the assets and

liabilities.

II. The attendance list establishes that all shares are represented; the list shall be signed by the members or their

proxyholders, the bureau and the notary and will be annexed to the present deed registered therewith.

III. The whole share capital being present the meeting declares that the shareholders have received full knowledge of

the agenda before the opening of the meeting and that there was no need therefore to dispatch formal notices.

IV. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on the item of the agenda.
V. Chairman recalls to the meeting that pursuant to minutes duly notarised of an extraordinary general meeting of the

members held in Curacao the meeting has resolved: (i) to transfer the registered office and the main place of business of
the Company to Luxembourg; (ii) to convert the Company from a company subject to the laws of Netherlands Antilles
to a company henceforth subject to Luxembourg law and (iii) to grant full authority to each of the Managers of the
Company to do and sign all deeds to perfect the conversion and transfer of the Company.

This conversion and transfer of registered office abroad without a prior liquidation may be validly passed under the

laws of this country to which it was subject. After deliberation the meeting passed at the unanimous vote of the following
resolutions.

67114

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The meeting resolved to approve to the extent necessary
(i) the transfer of the registered office and main place of business of the Company from Berg Arrarat 1, P.O. Box 3889,

Curaçao, Netherlands Antilles, to 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

(ii) the conversion of the Company to a Luxembourg S.à r.l. in continuation of its legal existence as the same corporate

entity and without liquidation, and

(iii) the adoption by the Company of the Luxembourg corporate nationality.

<i>Second resolution

The meeting resolved based on a Valuation Report presented by the Members and the board of Managers to value:
- the total current assets of the Company at 17,475 €;
- the total liabilities of the Company at 128,660 €;
- the total net assets of the Company at 896,871,400 €.

<i>Third resolution

The meeting further resolved to change the corporate name to Hertford Holding S.à r.l.

<i>Fourth resolution

The Meeting further resolved
(i) to restate the corporate capital at one million nine hundred thousand Euro (€ 1,900,000) to be represented by

nineteen thousand (19,000) shares of one hundred Euro (€ 100) par value.

The board of Managers is authorised in exchange of the present bearer certificates to make the appropriate entries

into the register of members of the Company,

(ii) to restate the Articles of Association in their entirety so that they should read from now on as follows:

Art. 1. The Company exists as a limited liability company (société à responsabilité limitée) formed between the ap-

pearing party and all persons who will become members. It shall be governed by these articles and by the Luxembourg
company law. The name of the Company is "Hertford Holding S.à r.l.".

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans or otherwise) to companies or other enterprises in which

the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs, take any
controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand-Duchy of Luxembourg by decision of the board of Managers.

Art. 5. The capital of the Company is fixed at one million nine hundred thousand Euro (€ 1,900,000) divided into

nineteen thousand (19,000) shares, all of the same class, with a par value of one hundred Euro (€ 100) each.

Art. 6. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company's assets and profits.

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter

vivos to non-members is subject to the consent of a majority of at least seventy five percent of the Company's capital
and a majority by head count, of the members.

Art. 8. The Company is managed by several Managers who need not be members.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the Managers are appointed for an
undetermined period. The Managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time without being entitled to any severance payment.

Any Manager may participate in any meeting of the board of Managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be

67115

L

U X E M B O U R G

represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote, it being understood that at least two Managers must be present in person or by conference call.

Written notice of any meeting of the board of Managers must be given to the Managers twenty four (24) hours at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of Managers.

The board of Managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
of the documents duly executed will give evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions,
may be conclusively certified or an extract thereof may be issued and signed as provided for in the next paragraph.

The Company will be bound by the joint signature of any two of the Managers. In any event the Company will be validly

bound by the sole signature of any person of persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any
two of the Managers or by the board of Managers.

Art. 9. The Managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the proper performance of their duties.

Art. 10. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 11. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg law

on commercial companies in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of members of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
members of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to members to their address appearing in

the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed

in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the reso-
lutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

members representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the members shall be convened of consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes east, regardless of the portion of capital represented, (ii) However,, decisions
concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by (y) a majority by head count of the members (z)
representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company
are to be taken by members representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

Art. 12. The fiscal year begins on 1 

st

 January and ends on 31 

st

 December of the same year.

Art. 13. Every year as of 31 

st

 December, the annual accounts are drawn up by the manager or board of Managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit five (5) percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten (10) percent of the capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the Managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable reserves
but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.

The share premium account may be distributed to the members upon decision of a members meeting. The members

may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be members and who are appointed by the members who will specify their powers and remunerations.

Art. 17. If, and as long as one member holds all the shares, the Company shall exist as a single member Company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of
the same law apply.

67116

L

U X E M B O U R G

Art. 18. For anything not dealt with in the present Articles of Association, the members refer to the relevant Luxem-

bourg laws.

<i>Fifth resolution

The meeting resolved to authorise the board of Managers to prepare the balance sheet based on the valuation of the

assets and liabilities as determined by the meeting.

<i>Special disposition

The current accounting year started on 1 

st

 January 2009 and shall terminate on 31 

st

 December 2009.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately five thousand Euro (€ 5,000).

<i>Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 3, rue des Bains L-1212 Luxembourg.
2. The number of Managers is set at 3, acting as board of Managers.
Are confirmed as Managers for an undetermined period of time:
- Mr Gerhard A. Greidanus, born on 26 

th

 August 1942 in Hilversum, chairman of the board of directors of Bolton

Group International S.A., residing at Stadhouderskade 14 H, 1054 ES Amsterdam, The Netherlands.

- Mr Freddy R. Marten, born on 7 

th

 July 1935 in Alexandria Egypt, director of Bolton Group International S.A., residing

at 30, rue du Rhône, CH-1204 Geneva, Switzerland.

- Mr Jean Hoss, born on 2 

nd

 August 1937 in Luxembourg, avocat à la Cour, residing in 2, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version française:

L'an deux mille neuf, le trentième jour du mois de juin.
Par devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg) s'est réunie l'assemblée gé-

nérale  extraordinaire  des  membres  de  Gordon  Investments  N.V.,  une  société  constituée  sous  les  lois  des  Antilles
néerlandaises avec siège social et siège de son activité économique à Berg Arrarat 1, P.O. Box 3889, Curaçao, Antilles
néerlandaises et inscrite au registre des sociétés sous le numéro 13801 (0) (la «Société»).

La séance est ouverte à treize heures vingt-cinq sous la présidence de M. Gerhard Greidanus, président du conseil

d'administration de Bolton Group International S.A., demeurant à Stadhouderskade 14 H, 1054 ES Amsterdam, Pays-Bas.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Jean Hoss, avocat à la Cour, demeurant à 2, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg.

M. Peter Sassoon, dirigeant de Bolton Group Coordination B.V., Genève, demeurant à 30, rue du Rhône, CH-1204

Genève, Suisse et M. Maarten van de Vaart, membre du conseil d'administration de Bolton Trading Corporation S.A.,
demeurant à 3 rue des Bains, L-1212 Luxembourg ont été choisis comme scrutateurs.

Tous présents et acceptant leur nomination.
Le bureau ainsi constitué, le Président prend note que la totalité du capital social émis de la Société est représenté et

prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social et du siège de l'activité économique de la Société au Luxembourg, transformation de la

Société en S.à r.l. soumise aux lois luxembourgeoises et l'adoption par la Société de la nationalité luxembourgeoise.

2. Evaluation par les associés et par le Conseil de Gérance de la Société des actifs et des passifs de la Société.
3. Changement de la dénomination sociale en Hertford Holding S.àr.l.
4. Reformulation des statuts et du capital social de la Société conformément à la loi luxembourgeoise sur les sociétés.
5. Autorisation au Conseil de Gérance de préparer le bilan basé sur l'évaluation des actifs et des passifs de la Société.

67117

L

U X E M B O U R G

II. La liste de présence établit que toutes les actions sont représentées; la liste de présence sera signée par les membres

présents ou leurs mandataires, par le bureau et le notaire instrumentaire et sera annexé au présent procès-verbal pour
être enregistré avec lui.

III. La totalité du capital social étant présent, l'assemblée reconnaît avoir eu, préalablement à l'ouverture de l'assemblée,

connaissance entière de l'ordre du jour, de sorte qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des convocations.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre

du jour.

V. Le Président rappelle que, conformément à un procès-verbal dûment certifié d'une assemblée générale extraordi-

naire  des  actionnaires  tenue  à  Curaçao  l'assemblée  a  décidé:  (i)  de  transférer  le  siège  social  et  le  siège  de  l'activité
économique de la Société au Luxembourg; (ii) de transformer la Société d'une société soumise aux lois des Antilles
néerlandaises en une société soumise dorénavant au droit luxembourgeois et (iii) d'accorder l'autorisation à chaque
Gérant de faire et de signer tous les actes nécessaires à la transformation et le transfert de la Société.

Cette transformation et ce transfert du siège social à l'étranger sans liquidation préalable peuvent être valablement

décidés sous les lois du pays auxquelles la société était sujette. Après délibération, l'assemblée prend par vote unanime
les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'assemblée a décidé d'approuver
(i) le transfert du siège social et du siège de l'activité économique de la Société de Berg Arrarat 1, P.O. Box 3889,

Curaçao, Antilles néerlandaises, à 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

(ii) la transformation de la Société en une S.à r.l. luxembourgeoise avec maintien de son existence légale comme la

même personne morale et ceci sans liquidation, et

(iii) l'adoption par la Société de la nationalité luxembourgeoise.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée a décidé, en se basant sur le rapport d'évaluation présenté par les membres et le Conseil de Gérance

d'évaluer:

- le total des actifs actuels de la Société à 17.475 €;
- le total du passif de la Société à 128.660 €;
- le total des actifs nets de la Société à 896.871.400 €;

<i>Troisième résolution

L'assemblée a décidé ensuite de changer la dénomination sociale en Hertford Holding S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée a décidé ensuite
(i) de fixer le capital social à un million neuf cent mille euros (€ 1.900.000) devant être représenté par dix-neuf mille

(19.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (€ 100) chacune.

Le Conseil de Gérance est autorisé de faire en échange des présents certificats au porteur les inscriptions appropriés

dans le registre des associés de la Société,

(ii) de reformuler les statuts dans leur entièreté qui auront dorénavant la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  La Société existe en tant que société à responsabilité limitée formée entre la partie comparante et toutes

les personnes qui deviendront associés par la suite. Elle sera régie par les présents statuts et par la loi luxembourgeoise
sur les sociétés. La dénomination de la Société est «Hertford Holding S.à r.l.».

Art. 2. L'objet de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par achat, souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement, d'actions, d'obligations, de certificats de créances, notes et
autres titres de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La
Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire
de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations et de

certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par prêts ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle

la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de
contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de
ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

67118

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Le siège social de la Société est à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

du Luxembourg par une décision du Conseil de Gérance.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à un million neuf cent mille euros (€ 1.900.000) divisé en dix-neuf mille

(19.000) parts sociales, toutes de la même catégorie, et d'une valeur nominale de cent euros (€ 100) chacune.

Art. 6. Chaque part donne droit à son propriétaire à un droit proportionnel aux actifs et profits de la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, le transfert

de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'accord d'une majorité d'au moins soixante-quinze pourcents
du capital social de la société et d'une majorité par personne de ses associés.

Art. 8. La Société est administrée par plusieurs Gérants qui n'ont pas besoin d'être associés. Ils sont nommés et

révoqués par l'assemblée générale des associés à la majorité simple, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions. Si aucun terme n'est indiqué, les Gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les Gérants sont
rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment sans avoir
droit à une indemnité de rupture.

Tout Gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence
téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les Gérants peuvent être représentés à la réunion du conseil par un
autre Gérant, sans limitation quant au nombre des procurations qu'un Gérant peut accepter et voter, étant entendu qu'au
moins deux Gérants doivent être présents en personne ou par conférence téléphonique.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance doit être donné aux Gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
Gérant par écrit, par câble, télégramme, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une con-
vocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance peut également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires

par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble des documents dûment exécuté constituera la preuve de la résolution. Les résolutions des Gérants,
y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis et signé dans
les conditions prévues au paragraphe suivant.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux des Gérants. Dans tous les cas la Société sera valablement

engagée par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par
deux des Gérants ou par le Conseil de Gérance.

Art. 9. Les Gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de

la société ils sont responsables de l'exécution correcte de leurs obligations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées.

Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution écrite valable (le cas échéant)

représente l'entièreté des associés de la Société.

Les  assemblées  peuvent  être  convoquées  par  une  convocation  adressée  par  lettre  recommandée  aux  associés  à

l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle
assemblée. Si l'entièreté du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans
convocation préalable.

Dans le cas de résolutions écrites, le texte de ces résolutions doit être envoyé par lettre recommandée aux associés

à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective des
résolutions proposées. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité telle que prévue par la loi
concernant les décisions collectives (ou sous réserve de la satisfaction des exigences de majorité, à la date y précisée).
Des résolutions écrites peuvent être passées à l'unanimité à tout moment sans convocation préalable. A moins que la loi
n'en dispose autrement, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées
par les associés représentant plus que la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée
ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre re-
commandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion du capital
représentée, (ii) Cependant, des décisions concernant une modification des statuts seront prises par (y) une majorité par
personne des associés (z) représentant au moins trois quart du capital social émis et (iii) les décisions concernant le

67119

L

U X E M B O U R G

changement de la nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent (100) pourcents du capital
social émis.

Art. 12. L'année fiscale commence le 1 

er

 janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Chaque année, au 31 décembre, le Gérant ou le conseil de gérance établissent les comptes annuels.

Art. 14. Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 15. Cinq pourcent (5%) du bénéfice net sont alloués au compte de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire si cette réserve atteint dix pourcents (10%) du capital social de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par les Gérants,

duquel ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne
peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés
et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve constitué en vertu
de la loi ou par les présents statuts.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés sur décision de l'assemblée des associés. Les associés

peuvent décider d'allouer n'importe quel montant du compte de prime d'émission au compte de réserve légal.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin

d'être associés et qui sont nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179(2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles
200-1 et 200-2, entre autres, de la Loi sont d'application.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts. Les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur à Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée a décidé d'autoriser le Conseil de Gérance de préparer le bilan basé sur l'évaluation des actifs et passifs

telle que déterminée par l'assemblée.

<i>Disposition transitoire

L'année comptable en cours a commencé le 1 

er

 janvier 2009 et se termine le 31 décembre 2009.

<i>Dépenses, Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa

constitution sont évalués à environ cinq mille euros (€ 5.000).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l'unique associé a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 3, rue des Bains L-1212 Luxembourg.
2. Le nombre des Gérants est fixé à 3, agissant comme Conseil de Gérance.
Sont confirmés comme membres du Conseil de Gérance pour une durée indéterminée:
- Monsieur Gerhard Greidanus, né le 26 août 1942 à Hilversum, Président du conseil d'administration de Bolton Group

International S.A., demeurant à Stadhouderskade 14 H, 1054 ES Amsterdam, Pays-Bas.

- Monsieur Freddy R. Martell, né le 7 juillet 1935 à Alexandrie Egypte, administrateur de Bolton Group International

S.A., demeurant à 30, rue du Rhône, CH-1204 Genève, Suisse.

- Maître Jean Hoss, né le 2 août 1937 à Luxembourg, avocat à la Cour, demeurant à 2, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg.

Dont Acte, fait à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu aux comparants, qui ont requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, les com-

parants ont signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: G. GREIDANUS, J. HOSS, P. SASSOON, M. VAN DE VAART, J. GLODEN.
Enregistré à Grevenmacher, le 01 juillet 2009. Relation: GRE/2009/2349. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

The undersigned notary certifies that the "Bolton Group International S.A.", a société anonyme under Luxembourg

law, with registered office in L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés
in Luxembourg under number B 21159, is the sole associate of the Company "Hertford Holding S.à r.l." with registered

67120

L

U X E M B O U R G

office at L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains, prenamed; the prenamed sole associate holds the nineteen thousand
(19,000) shares of the Company.

Le notaire instrumentaire soussigné certifie que "Bolton Group International S.A.", une société anonyme de droit du

Luxembourg, avec siège social à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 21159, est l'associée unique de la Société "Hertford Holding S.à r.l." avec siège social
à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains, prénommée; l'associée unique, prénommée, détient les dix-neuf mille (19.000)
parts sociales,Signé: J. GLODEN.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier timbré aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Grevenmacher, le 06 juillet 2009.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2012062863/829.
(120088904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2012.

Optik Hoffmann S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 13-17, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 115.216.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2012.

Référence de publication: 2012051040/10.
(120070948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Copacore Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.678.

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth of April.
Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri HELLINCKX,

notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of COPACORE FUND, a société anonyme qualifying as

a société d’investissement à capital variable, having its registered office at Luxembourg, registered to the Luxembourg
Trade and Companies' Register, under the number B 142678, incorporated pursuant to a notarial deed on the 20 

th

 of

October 2008, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 2766 of November 14, 2008.

The meeting was opened with Mr Grégory FOUREZ, bank employee, residing professionally in Luxembourg, in the

chair, who appointed as secretary Mr Alain KAISER, bank employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Séverine OLIGER, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the present meeting has been convened by notices published:
a) in the Mémorial, Recueil Spécial C:
- number 797 of March 27, 2012
- number 941 of April 12, 2012
b) in the Letzebuerger Journal:
- on March 27, 2012
- on April 12, 2012
c) in the Tageblatt
- on March 27, 2012
- on April 12, 2012
II. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decision to put the Fund into liquidation;
2. Appointment of Mazars 10A, rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg, as Liquidator
3. Decision to convene a second extraordinary general meeting of shareholders in order
- To acknowledge the audited financial statements for the period from 1 

st

 January 2012 to the date of the liquidation

- To grant discharge to the board of directors for the period from 1 

st

 January 2012 to date of the liquidation.

67121

L

U X E M B O U R G

- To hear the report of the Liquidator on the liquidation of the Fund.
- To receive the report of the Auditor on the liquidation of the Fund.
- To give discharge to the Liquidator.
- To decide on the close of the liquidation and to entrust the central administration with the safekeeping for a period

of 5 years of all accounting documents, books, registers and all other documents of the Fund.

- To decide on any other business which be brought before the meeting.
III. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

IV. - That pursuant to the attendance list, 377 hares out of 6,846.98 hares in circulation, are represented at the present

meeting.

The Chairman informs the meeting that a first extraordinary general meeting had been convened with the same agenda

as the agenda of the present meeting indicated hereabove, for the 23 

rd

 of March 2012 and that the quorum requirements

for voting the items of the agenda had not been attained.

In accordance with article 67-1 of the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, the present meeting may

thus deliberate validly no matter how many shares are present or represented.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution:

The meeting decides to dissolve the Company and to put it into liquidation as of this day.

<i>Second resolution:

The meeting decides to appoint Mazars Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt L2530 Luxembourg (RCS Luxembourg

B 159962), as Liquidator.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the general meeting

in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential

rights  mortgages,  actions  for  rescission;  remove  the  attachment,  with  or  without  payment  of  all  the  preferential  or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his

powers he determines and for the period they will fix.

The liquidator is authorised to pay a provision on the liquidating dividends to the shareholders according article 148

of the law on commercial companies.

<i>Third resolution

The meeting decides to convene a second extraordinary general meeting of shareholders in order
- To acknowledge the audited financial statements for the period from 1 

st

 January 2012 to the date of the liquidation

- To grant discharge to the board of directors for the period from 1 

st

 January 2012 to date of the liquidation.

- To hear the report of the Liquidator on the liquidation of the Fund.
- To receive the report of the Auditor on the liquidation of the Fund.
- To give discharge to the Liquidator.
- To decide on the close of the liquidation and to entrust the central administration with the safekeeping for a period

of 5 years of all accounting documents, books, registers and all other documents of the Fund.

- To decide on any other business which be brought before the meeting.
There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Signé: G. FOUREZ, A. KAISER, S. OLIGER et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2012. Relation: LAC/2012/19991. Reçu douze euros (12.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

67122

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 10 mai 2012.

Référence de publication: 2012054313/89.
(120075553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.

Lexwood Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.871.

DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le dix-neuf avril.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Odile BERNS, employée, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la Pé-

trusse,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de PB CONSULTANT LTD S.A., une société de droit du Panama dont le

siège social est établi à East 53 

rd

 Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2 

nd

 Floor, Panama City (République de Panama),

immatriculé sous le numéro 658032,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 27 mars 2012,
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société LEXWOOD HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la

Pétrusse, a été constituée suivant acte notarié en date du 13 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro C 1106 du 7 juin 2006;

- que le capital social de la société LEXWOOD HOLDING S.A. s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS

(31.000 EUR) représenté par MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EURO (31 EUR) chacune,
entièrement libérées;

- que PB CONSULTANT LTD S.A., pré-qualifiée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions et qu'elle déclare

avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

- que PB CONSULTANT LTD S.A., pré-qualifiée, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder

à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 27 février 2012,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

L'actionnaire unique déclare encore que
- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du

passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 27 février 2012 étant seulement
un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et/ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2330 Luxembourg,

128, Boulevard de la Pétrusse.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement mille euros (EUR 1.000).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: O. BERNS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 avril 2012. Relation: LAC/2012/19021. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

67123

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 9 mai 2012.

Référence de publication: 2012054537/54.
(120075844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.

Mimar Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 156.959.

Il résulte du transfert de parts sociales en date du 2 mai 2012 que:
Marc Millot, avec adresse au 4-6, Avenue Victor Hugo, étage 3C, L-1750 Luxembourg, a transféré:
- 1,240 parts sociales à TSM Services (Luxembourg) S.à r.l., RCS Luxembourg, B 152398 avec siège social au 16, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012050998/16.
(120070780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Optique Schaefers Lucien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 38, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 53.817.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour OPTIQUE SCHAEFERS LUCIEN S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012051042/11.
(120070263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Aabar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 157.199.

In the year two thousand and twelve on the fourth day of April.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Aabar Investments PJS, a company organized under the laws of the United Arab Emirates, having its registered office

at Ministry of Energy Building, 12 

th

 Floor, Corniche Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and registered with the

trade register of Abu Dhabi under commercial license number 1003011,

hereinafter referred to as the “Sole Shareholder”,
here represented by Mr. Gérard Maîtrejean, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal, dated 2 April 2012.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. The Sole Shareholder owns one hundred percent (100%) of the share capital of Aabar Holdings S.à r.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-),
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.199, and incorporated under the
name Luxco 134 S.à r.l. by deed of Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, on 29 November 2010, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 113, dated 20 January 2011, page 5411, the articles of

67124

L

U X E M B O U R G

which have been amended for the last time by deed of the undersigned noatry, on 29 February 2012, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”).

II. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

a. Increase of the share capital of the Company by an amount of twenty-five Euro (EUR 25.-) in order to bring it from

its current amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500 ) to an amount of twelve thousand five hundred
and twenty-five Euro (EUR 12,525 ), by the issuance of one (1) share (part sociale), with a nominal value of twenty-five
Euro (EUR 25.-) (the “New Share”), and the same rights and obligations as the existing shares (parts sociales);

b. Subscription and full payment at nominal value of the New Share, i.e twenty-five Euro (EUR 25.-), together with a

share premium of one million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred and seventy-five Euro (EUR 1,999,975.-),
by a contribution in kind of two million Euro (EUR 2,000,000.-), by Aabar Investment PJS;

c. Subsequent amendment of Article 6 of the articles of association of the Company, in order to reflect the above

share capital increase;

d. Miscellaneous.
III. All the shares (parts sociales) in circulation being represented at the present general meeting of shareholders, and

the Sole Shareholder having waived its right to receive convening notice, the Sole Shareholder can validly decide on all
the items of the agenda.

After the foregoing has been approved, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>1. First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of twenty-

five Euro (EUR 25.-), in order to bring it from its current amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-)
to twelve thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 12,525.-), by the issuance of the New Share, having the same
rights and obligations as the existing shares (parts sociales).

<i>2. Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to accept the subscription for and full payment of the New Share, together with a

share premium, by Aabar Investments PJS, prenamed, as follows:

Number of

share

subscribed

Nominal

value

(EUR)

Share

premium

(EUR)

Total

value/pay-

ment

(EUR)

Contribution in kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

25

1,999,975

2,000,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

25

1,999,975

2,000,000

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, prenamed, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the New Share and to

pay it in full at the nominal value, together with share premium of one million nine hundred ninety-nine thousand nine
hundred and seventy-five Euro (EUR 1,999,975.-), by contribution in kind of One Hundred Sixty-Three (163) shares (parts
sociales), having a nominal value of twentyfive Euro (EUR 25.-) each of Aabar Luxembourg S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145.459 (“Aabar Luxembourg”).

The  ownership  and  the  value  of  the  shares  (parts  sociales)  of  Aabar  Luxembourg  contributed  in  kind  have  been

confirmed through a report from Aabar Investments PJS, prenamed, dated 2 April 2012, and a report from the Company,
dated 2 April 2012.

Such documents, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed in order to be filed at the same time with the tax administration (administration de l’enre-
gistrement).

<i>3. Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder RESOLVES to amend Article 6 of the articles of

association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 12,525.-),

represented by five hundred and one (501) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.”

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately three thousand euro (€ 3,000.-).

67125

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with the notary the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le quatre avril,
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Aabar Investments PJS, une société organisée selon les lois des Emirats arabes unis, ayant son siège social au Ministry

of Energy Building, 12 

th

 Floor, Corniche Road, Abu Dhabi, Emirats arabes unis, et inscrite au registre du commerce de

Abu Dhabi sous une licence de commerce numéro 1003011,

ci-après l’«Associé Unique»
ici représenté par Mr Gérard Maîtrejean, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé du 2 avril 2012.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant,

annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L’Associé Unique détient 100% du capital social de Aabar Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital social
de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 157.199, et constituée par un acte de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, sous la
dénomination Luxco 134 S.à r.l., le 29 novembre 2010, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 113 du 20 janvier 2011, page 5411, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière par un acte notaire soussigné,
le 29 février 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»)

II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

a. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) pour le porter de son

montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), à un montant de douze mille cinq cents vingt-cinq Euros
(EUR 12.525,-), par l’émission d’une (1) part sociale, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) (la «Nou-
velle Part Sociale»), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

b. Souscription et libération intégrale à la valeur nominale de la Nouvelle Part Sociale, c’est-à-dire vingt cinq Euros

(EUR 25,-), avec une prime d’émission d’un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-quinze Euro
(EUR 1.999.975,-) par apport en nature de deux millions d’Euro (EUR 2.000.000,-) par Aabar Investments PJS;

c. Modification subséquente de l’Article 6 des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation de capital précitée;
d. Divers.
III. Toutes les parts sociales en circulation étant représentées à la présente assemblée générale des actionnaires, et

l’Associé Unique ayant renoncé à son droit de recevoir la convocation, l’Associé Unique peut valablement décider sur
tous les points à l’ordre du jour.

Ces faits précités ayant été approuvés, l’Associé Unique prend les résolutions suivantes:

<i>1. Première résolution

L’Associé Unique DECIDE d’augmenter le capital social souscrit de la Société d’un montant de vingt-cinq Euro (EUR

25,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent vingt-
cinq Euro (EUR 12.525,-) par l’émission de la Nouvelle Part Sociale, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.

<i>2. Deuxième résolution

L’Associé Unique DECIDE d’accepter la souscription et la libération intégrale de la Nouvelle Part Sociale, avec une

prime d’émission, par Aabar Investments PJS, prénommée, de la manière suivante:

67126

L

U X E M B O U R G

Nombre

de part

sociale

souscrite

Valeur

nominale

(EUR)

Prime

d’émission

(EUR)

Valeur/Payment

total (EUR)

Apport en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

25,-

1.999.975,-

2.000.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

25,-

1.999.975,-

2.000.000,-

<i>Souscription/ Libération

L’Associé Unique, prénommé, représenté comme ci-dessus indiqué, déclare souscrire à la Nouvelle Part Sociale et

libérer intégralement cette dernière à sa valeur nominale, avec une prime d’émission d’un million neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf mille neuf cent soixante-quinze Euro (EUR 1.999.975,-) par un apport en nature de cent soixante trois (163)
parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune, de Aabar Luxembourg S.à r.l., une
société à responsabilité limitée ayant son siège social 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, et enregistrée au
Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 145.459 («Aabar Luxembourg» ).

La propriété et la valeur des parts sociales de Aabar Luxembourg apportées en nature a été confirmée par un rapport

de Aabar Investments PJS, prénommée, daté du 2 avril 2012, et un rapport de la Société, daté du 2 avril 2012.

Ces documents, après avoir été signés «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexés au présent acte pour être enregistrés au même moment auprès de l’administration de l’enregistrement.

<i>3. Troisième résolution

En conséquence des décisions précédentes, l’Associé Unique DECIDE de modifier l’Article 6 des statuts de la Société

qui doivent désormais être lus comme suit:

« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent vingt-cinq Euro (EUR 12.525,-), représenté par cinq cent une

(501) parts sociales de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.»

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

de cette assemblée générale extraordinaire des présentes sont estimés à trois mille euros (€ 3.000,-).

DONT ACTE, le présent acte notarié a été passé à Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Le document ayant été lu à la partie comparante, elle-même connue par le notaire par son nom, prénom, statut civil

et résidence, laquelle partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Maîtrejean, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 avril 2012. Relation: EAC/2012/4658. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012051283/166.
(120071575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

ArcelorMittal International Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 6.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012051288/9.
(120071693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Continental Investment Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 161.861.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

67127

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 3 mai 2012.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2012051387/11.
(120071838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

M3 Architectes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R.C.S. Luxembourg B 58.144.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 2 mai 2012

<i>à 11.00 heures

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Alain LINSTER de son poste d’administrateur avec effet au 1

er

 février 2012.

Il sera remplacé par Madame Françoise HALSDORF, épouse DELL, née le 07.02.1961 à Luxembourg (L), demeurant

à L – 1316 Luxembourg, 34, Rue des Carrières.

Ce mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2015.
Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L – 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.
Ce mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale à tenir en l’an 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2012051542/19.
(120071833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Alcove Europe Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 159.315.

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth of April;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

The company Alcove Holdings Europe S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered

office in L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 139814, representing the full amount of the corporate capital of twelve thousand
five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) corporate units of Alcove Europe
Three S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated under the Laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-1130 Luxembourg, 37, rue d’Anvers, R.C.S. Luxembourg number
B 159315, (the “Company”),

duly represented by Mrs. Morgane IMGRUND, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private

seal.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy of the appearing person and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed to be filed together with the registration authorities.

The  afore-mentioned  Alcove  Holdings  Europe  S.à  r.l.  is  the  sole  member  (the  “Sole  Member”)  of  the  Company,

incorporated by a deed of notary Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg, on 4 March, 2011, published in the official
Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg (“Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”), number 1116, dated
26 May 2011, which articles of association have not been amended since its incorporation.

The appearing party, represented as here above stated, in its capacity as Sole Member of the Company has requested

the undersigned notary to state the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member resolves to extend the corporate purpose of the Company in order to allow the Company to grant

loans or guarantees of any kind from to a third party and to receive loans or guarantees from any kind from to a third
party.

<i>Second resolution

The Sole Member resolves to create two (2) categories of corporate units, one (1) category of corporate units A (the

“A Units”) and one (1) category of corporate units B (the “B Units”).

67128

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The Sole Member resolves to convert and re-allocate the current existing twelve thousand five hundred (12,500)

corporate units with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each into six thousand two hundred fifty (6,250) A Units and
six thousand two hundred fifty (6,250) B Units so that subscribed corporate capital of the Company of twelve thousand
five hundred Euros (EUR 12,500.-) will be represented by six thousand two hundred fifty (6,250) A Units and six thousand
two hundred fifty (6,250) B units with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

<i>Fourth resolution

The Sole Member resolves to introduce the requirement of an auditor appointed to audit the annual accounts of the

Company.

<i>Fifth resolution

Subject to the approval of the above mentioned resolution and for the purpose of straightening out certain articles of

the articles of association of the Company, the Sole Member resolves to amend, articles 4, paragraph 4, 5, paragraph 1,
10, 14, paragraph 1 and 17, to introduce a Title IV Supervision of the Company and a relevant new article 21 and renumber
the current Title IV and article 21 and 22 of the articles of association, which shall hence have the following wording:

Art. 4. Paragraph 4. “The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates, loan

notes and debentures, convertible or non-convertible, within the limits provided by law to the benefit of direct or indirect
subsidiary, to companies being part being part of the same group of companies as the Company or third parties. The
Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee within the limits of the to or in favour of the companies,
trusts or enterprises in which it has a direct or indirect participating interest, to companies being part of the same group
of companies as the Company or third parties.”

Art. 5. Paragraph 1. “The subscribed corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-)

represented by six thousand two hundred fifty (6,250) units of category A (“A Units”) and six thousand two hundred fifty
(6,250) units of category B (“B Units” together hereinafter referred to as the “corporate units” or “units” and individually
the “corporate unit” or “unit”) with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.”

Art. 10. “If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.
The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members repre-

senting at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

Except with the prior written consent of the other members representing at least three quarters (3/4) of the Com-

pany's capital, no member shall create or permit to subsist (i) any adverse claim or right or third party right or interest,
(ii) any equity, (iii) any option or right of pre-emption or right to acquire or right to restrict, (iv) any mortgage, charge,
assignment, pledge, hypothecation, lien, or security interest or arrangement of whatever nature, (v) any reservation of
title or (vi) any hire purchase, lease or instalment purchase agreement over, or grant any option or other rights in all or
any of the corporate units held by it, other than by a transfer of such corporate units in accordance with the provisions
of these articles of association.

Any purported transfer not in compliance with these articles of association shall be void.
If a member wishes to transfer any corporate units owned by it (a “Selling Member”), in any transaction, the Selling

Member shall deliver prior written notice of

its wish to transfer (a “Notice of Intention”) to the Company and to the other member (the “Non-Selling Member”)

setting forth its wish to make such transfer, and specifying:

- the name of the proposed transferee, and the number and class of corporate units proposed to be transferred (the

“Offered Units”); and

- the price at which such Selling Member proposes to transfer the Offered Units (the “Offer Price”) and other applicable

terms and conditions (“Right of First Offer”).

Upon receipt of the Notice of Intention, the Non-Selling Member shall have the right to purchase at the Offer Price

the Offered Units, exercisable by the delivery of notice to the Selling Member (the “Notice of Exercise”), with a copy to
the Company, within ten (10) business days from the date of receipt of the Notice of Intention.

If no such Notice of Exercise has been delivered by the Non-Selling Member within such ten (10) business day period,

or such Notice of Exercise does not relate to all of the Offered Units covered by the Notice of Intention, then the Selling
Member shall be entitled to transfer all of the Offered Units to a third party within forty five (45) business days after the
delivery of such Notice of Intention on terms no more favourable to the third party than those presented to the Non-
Selling Member and subject to the acceptance of the transferee to be bound by the contractual arrangements existing
between the Selling and the Non-Selling Member.

If the Selling Member does not sell the Offered Units to a third party on terms no more favourable to the third party

than those presented to the Non-Selling Member within such forty five (45) business day period, the Offered Units shall
again be subject to the Right of First Offer as set forth above.

67129

L

U X E M B O U R G

In the event that the Non-Selling Member exercises its right to purchase all of the Offered Units, the Selling Member

shall sell all of the Offered Units to the Non-Selling Member, in the amounts set forth in the Notice of Intention.

The transfer of corporate units by any member to any company or non-corporate entity that controls and therefore

owns or directly or indirectly controls more than fifty per cent(50%) of the voting rights of the member, is controlled
by, or is under common control with a member, to the spouse or any child of a member, to any partnership including a
member, his spouse or children or any corporate entity that is fully owned by either a member, his spouse or his children
is not subject to the aforementioned Right of First Offer.

The transfer of corporate units to third parties shall be subject to the prior entering by the acquiring third party into

a deed of adherence to the contractual arrangements existing from time to time between the existing members of the
Company.In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of
units representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however,
the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.”

Art. 14. Paragraph 1. “The board of managers may choose from among its members a chairman who shall not have a

casting vote. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the board of managers and of the members.”

Art. 17. “Towards third parties the Company is validly bound by the joint signatures of one manager of Category A

and one manager of Category B, or by the single signature of the sole manager, or by the single or joint signatures of one
or more day-to-day managers appointed in accordance with article 16 paragraph 3, or the single or joint signatures of
any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.”

“Title IV. Supervision of the Company

Art. 21. “The operations of the Company may be supervised by one or several statutory auditor(s) (“commissaire aux

comptes”), which may be members or not. The general meeting of members shall appoint the statutory auditors, and
shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.”

Title V. Winding up - Liquidation

Art. 22. “In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.

Each unit gives right to one fraction of the net liquidation assets of the Company in direct proportion to the number

of units in existence.”

Art. 23. “All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.”

<i>Sixth resolution

The Sole Member resolves to approve the transfer of a participation of six thousand two hundred fifty (6,250) B Units

representing fifty percent (50%) of the corporate capital of the Company to Kamcon Investments Ltd, a limited company
incorporated under the laws of Ireland with registered offices at 33 Mespil Road, Ballsbridge, Dublin 4, Republic of Ireland,
with CO registration number 510025, in accordance with article 189 of the amended law of August, 10, 1915 on com-
mercial companies.

<i>Seventh resolution

The Sole Member resolves to grant mandate to the law firm Wildgen, Partners in Law with offices at 69, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, to perform all legal action in relation with the aforesaid resolutions, and in particular,
to update the member’s register to reflect the aforementioned changes.

<i>Costs, Evaluation

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 1,300. (one thousand three hundred Euros).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing party, and
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by first and last name,

civil status and residence, the said proxy-holder signed together with Us, the notary, the present original deed.

67130

L

U X E M B O U R G

Folgt die deutsche Übersetzung des Vorangehenden:

Im Jahre zweitausendzwölf, am dreizigsten April;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, ansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

Ist erschienen:

Die Gesellschaft Alcove Holdings Europe S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (“société à responsabilité

limité”) Luxemburger Rechts, mit Sitz in L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, Großherzogtum Luxemburg eingetragen
im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 139814, welche das gesamte Gesellschaftskapital
von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), dargestellt durch zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500) Gesell-
schaftsanteile  der  Gesellschaft  Alcove  Europe  Three  S.à  r.l.,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (“société  à
responsabilité limitée“) Luxemburger Rechts, mit Sitz in L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, Großherzogtum Luxem-
burg  eingetragen  im  Luxemburger  Handels-  und  Gesellschaftsregister  unter  Nummer  B  159315,  repräsentiert  (die
„Gesellschaft“),

ordnungsgemäß  vertreten  durch  Frau  Morgane  IMGRUND,  Rechtsanwältin,  wohnhaft  in  Luxemburg,  kraft  privat-

schriftlicher Vollmacht.

Die besagte Vollmacht verbleibt nach „ne varietur“ Zeichnung durch die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und

den unterzeichnenden Notar anliegend an der vorliegenden Urkunde, um mit dieser gleichzeitig bei Registrierungsbe-
hörden eingereicht zu werden.

Die vorgenannte Alcove Holdings Europe S.à r.l. ist Alleingesellschafter (der „Alleingesellschafter“) der Gesellschaft,

gegründet durch Urkunde von Maître Martine SCHAEFFER Notar mit Amtssitz in Luxemburg vom 4. März 2011, veröf-
fentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“), Nummer
1116 vom 26. Mai 2011, deren Satzung seit der Gründung der Gesellschaft nicht geändert wurde.

Die erschienene Partei, wie oben genannt vertreten, ersucht den unterzeichneten Notar in ihrer Eigenschaft als Al-

leingesellschafter der Gesellschaft, die folgenden Beschlüsse aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt den Gesellschaftszweck auszuweiten um der Gesellschaft zu ermöglich Dritten

Darlehen und Garantien zuzusprechen und von Dritten Darlehen oder Garantien zu empfangen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt zwei (2) Kategorien von Gesellschaftsanteilen zu erstellen, eine (1) A Gesellschafts-

anteilkategorie („A Anteile“) und eine (1) B Gesellschaftsanteilkategorie („B Anteile“).

<i>Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die zwölf tausend fünf hundert (12,500) existierenden Gesellschaftsanteile mit ei-

nem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) in sechs tausend zwei hundert fünfzig A Anteile und sechs tausend zwei
hundert fünfzig B Anteile aufzuteilen und zuzuordnen, so dass das Stammkapital der Gesellschaft zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500,-) in sechs tausend zwei hundert fünfzig A Anteile und sechs tausend zwei hundert fünfzig B Anteile
mit einen Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) eingeteilt wird.

<i>Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Ernennung eines Rechnungsprüfers zur Überprüfung der Jahresabschlüsse der

Gesellschaft in die Gesellschaftssatzung einzuführen.

<i>Fünfter Beschluss

Vorausgesetzt die vorangehenden Beschlussfassungen angenommen, und zwecks Bereinigung einiger Artikel der Sat-

zung der Gesellschaft, beschließt der Alleingesellschafter Artikel 4, Paragraph 4, 5, Paragraph 1, 10, 14, Paragraph 1 und
17 zu ändern, Titel IV Überwachung der Gesellschaft einzuführen und jeweilig einen neuen Artikel 21 einzuführen und
Title IV Artikel 21 und 22 der Gesellschaftssatzung zu renummerier, welche fortan den folgenden Inhalt haben werden:

Art. 4. Paragraph 4. “Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen, bevorzugte Kapitalzer-

tifikate,  Schuldscheine  und  Schuldanerkennungen,  seien  diese  konvertierbar  oder  nicht  konvertierbar,  innerhalb  der
gesetzlich festgelegten Grenzen zu Gunsten der Gesellschaften, Treuhandunternehmen oder Unternehmen in welchen
sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, zu Gunsten von Gesellschaften, welche der gleichen Gesellschaftsgruppe
wie die Gesellschaft angehören oder Dritten ausgeben. Die Gesellschaft kann Unterstützung jeglicher Art, Darlehen,
Vorschuss oder Garantien innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen zu Gunsten der Gesellschaften, Treuhandun-
ternehmen oder Unternehmen in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, zu Gunsten von Gesellschaften,
welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören oder Dritten, gewähren.“

Art. 5. Paragraph 1. „Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt

in sechs tausend zwei hundert fünfzig (6.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie A („A Anteile“) und sechs tausend zwei

67131

L

U X E M B O U R G

hundert fünfzig (6.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie B („B Anteile“ zusammen bezeichnet als die „Gesellschaftsan-
teile“ oder einzeln das „Gesellschaftsanteil“) mit einen Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-).“

Art. 10. “Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaftern

übertragbar.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter benötigt die in einer Gesellschaf-

terversammlung erteilten Zustimmung von Gesellschaftern die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals reprä-
sentieren.

Mit Ausnahme der vorherigen schriftlichen Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche mindestens drei viertel

(3/4)  des  Gesellschaftskapitals  darstellen,  ist  es  jedem  Gesellschafter  untersagt  (i)  jegliche  gegenteilige  Forderungen,
Rechte, Drittrechte oder Beteiligungen, (ii) jegliche Kapitalanteile, (iii) jegliche Optionen, Vorkaufs-, Erwerbsrechte oder
Einschränkungen, (iv) jegliche Hypotheken, Belastungen, Abtretungen, Verpfändungen, Beleihungen, Pfandrechte oder
Sicherungsrechte oder Zusicherungen jeglicher Art, (v) jegliche Eigentumsvorbehalte oder (vi) jegliche Kaufmieten, Miet-,
Ratenkaufverträge über oder Options- oder andere Rechte an allen oder Teilen der gehaltenen Gesellschaftsanteile, in
anderer Weise als durch Übertragung der Gesellschaftsanteile gemäß den Vorschriften dieser Satzung zu schaffen oder
dessen Fortbestand zu ermöglichen.

Jegliche Übertragung, welche nicht gemäß der vorliegenden Satzung vorgenommen wurde gilt als nichtig.
Sollte ein Gesellschafter jegliche von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile in jeglicher Transaktion übertragen wollen

(der „Verkaufende Gesellschafter“), muss der Verkaufende Gesellschafter der Gesellschaft und dem anderen Gesell-
schafter  (der  „Nicht-Verkaufende  Gesellschafter“)  einen  vorherigen  schriftlichen  Bescheid  bezüglich  seiner  Übertra-
gungsabsicht zustellen (der „Absichtsbescheid“), welcher seine Absicht sowie folgende Angaben beinhaltet:

- den Namen des vorgeschlagenen Übertragungsbegünstigten und die Anzahl und Anteilsklasse der zu übertragenden

Gesellschaftsanteile (die „Angebotenen Anteile“); und

- den Preis zu dem der Verkaufende Gesellschafter die Angebotenen Anteile anbietet (der „Angebotspreis“) und die

weiteren anwendbaren Übertragungsbedingungen (das „Erstangebotsrecht“).

Nach Erhalt des Absichtsbescheids hat der Nicht-Verkaufende Gesellschafter das Recht die Angebotenen Anteile zum

Angebotspreis zu kaufen, wobei er dieses Recht durch Zustellung eines Bescheids (der „Ausübungsbescheid“) an den
Verkaufenden Gesellschafter, mit Kopie an die Gesellschaft innerhalb von zehn (10) Werktagen nach Erhalt des Ab-
sichtsbescheids geltend macht.

Sollte kein Ausübungsbescheid innerhalb der zehn (10) Werktagefrist durch den Nicht-Verkaufenden Gesellschafter

zugestellt worden sein, oder sollte der Ausübungsbescheid sich nicht auf alle Angebotenen Anteile beziehen, welche im
Absichtsbescheid angegeben waren, hat der Verkaufende Gesellschafter das Recht alle Angebotenen Anteile einem Drit-
ten innerhalb von fünf und vierzig (45) Werktagen nach Erhalt des Ausübungsbescheids unter nicht günstigeren als dem
Nicht-Verkaufenden  Gesellschafter  angebotenen  Bedingungen,  und  vorausgesetzt,  der  Übertragungsbegünstigte  ver-
pflichtet sich in die vertraglichen Abmachungen, welche zwischen dem Verkaufenden und Nicht-Verkaufenden Gesell-
schafter bestehen einzutreten, übertragen..

Sollte der Verkaufende Gesellschafter die Angebotenen Anteile einem Dritten nicht unter nicht günstigeren als dem

Nicht-Verkaufenden Gesellschafter angebotenen Bedingungen innerhalb der fünf und vierzig Werktagesfrist übertragen,
unterliegen die Angebotenen Anteile wiederum dem obengenannten Erstangebotsrecht.

Sollte der Nicht-Verkaufende Gesellschafter von seinem Recht alle Angebotenen Anteile zu kaufen Gebrauch machen,

wird der Verkaufende Gesellschafter alle Angebotene Anteile dem Nicht-Verkaufenden Gesellschafter, zu den in dem
Absichtsbescheid festgelegten Beträgen verkaufen.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen durch jeglichen Gesellschafter an eine Gesellschaft oder eine natürliche

Person, welche den Gesellschafter kontrolliert und entsprechend direkt oder indirekt mehr als fünfzig Prozent (50%) der
Stimmrechte des Gesellschafters kontrolliert, durch den Gesellschafter kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kon-
trolle mit dem Gesellschafter steht, an den Ehegatten oder jegliche Kinder des Gesellschafter, an jegliche Partnerschaft
in welche der Gesellschafter, dessen Ehegatte oder dessen Kinder involviert sind oder an jegliche unternehmerische
Einheit, welche vollständig durch den Gesellschafter, dessen Ehegatte oder jegliche seiner Kinder gehalten wird, unterliegt
nicht dem vorgenannten Erstangebotsrecht.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an einen Dritten unterliegt dem vorherigen Abschluss durch den erwerb-

enden  Dritten  einer  Beitrittserklärung  zu  den  vertraglichen  Abmachungen,  welche  von  Zeit  zu  Zeit  zwischen  den
bestehenden Gesellschafter der Gesellschaft bestehen.

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von

der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter
repräsentieren. In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte
oder den überlebenden Ehepartner erfolgt.“”

Art. 14. Paragraph 1. „Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen, der keine aus-

schlaggebende Stimme hat. Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer zu sein braucht und der
für die Abfassung der Sitzungsprotokolle der Geschäftsführung und der Gesellschafter verantwortlich ist.“

67132

L

U X E M B O U R G

Art. 17. „Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der

Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B oder durch die einzelne oder gemeinsame Unterschrift des
täglichen Geschäftsführer, ernannt gemäß Artikel 16, Paragraph 3, oder durch die Einzelunterschrift des alleinigen Ge-
schäftsführers oder durch die Einzel- oder die gemeinsame Unterschrift jeder Person(en), die durch die Geschäftsführung
berechtigt wurde, verpflichtet.“

“Title IV. Überwachung der Gesellschaft

Art. 21. „Die Geschäfte der Gesellschaft wird überwacht durch eine oder mehrere Rechnungsprüfer (“commissaire

aux comptes”), welcher nicht unbedingte Gesellschafter der Gesellschaft sein Müssen. Die außerordentlich Hauptver-
sammlung  der  Gesellschafter  ernennt  den  Rechnungsprüfer  und  bestimmt  ihre  Anzahl,  ihre  Entlohnung  und  ihre
Ernennungsdauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten kann.“

Title V. Auflösung und Liquidation

Art. 22. „Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

natürliche oder juristische Personen sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über diese Auflösung entschieden hat und die ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft den Gesellschaftern entsprechend ihrer gehaltenen

Geschäftsanteile zugeteilt.“

Art. 23. „Für alle Punkte, die nicht durch die Regelungen der vorliegenden Satzung geregelt sind, gelten die Bestim-

mungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften, wie abgeän-
dert.“

<i>Sechster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt der Übertragung der Beteiligung an sechs tausend zwei hundert fünfzig (6.250) B

Anteile, welche fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft darstellen zu Gunsten von Kamcon Investments
Ltd, eine „limited company“ gegründet und bestehend gemäß irischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 33 Mespil Road,
Ballsbridge, Dublin 4, Republik Irland, mit CO Eintragungsnummer 510025, gemäß Artikel 189 des geänderten Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften zuzustimmen.

<i>Siebter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt der Anwaltskanzlei Wildgen, Partners in Law mit Sitz in 69, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg Vollmacht zu erteilen jegliche gesetzliche Maßnahme in Zusammenhang mit den vorgenannten Be-
schlussfassungen zu ergreifen, und insbesondere das Gesellschafterregister der Gesellschaft zu aktualisieren.

<i>Kosten, Bewertungen

Die Kosten, Gebühren und anderen Auslagen die der Gesellschaft aus der vorliegenden Urkunde entstehen, werden

auf ungefähr EUR 1.300,- (tausenddreihundert Euro) geschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen Partei,

die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschie-
nenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die englische Fassung
maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei, dem instrumentierenden

Notar nach Vor-und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar,
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. IMGRUND, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 mai 2012. LAC/2012/20084. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 7 mai 2012.

Référence de publication: 2012053666/298.
(120075039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.

67133

L

U X E M B O U R G

Prospector Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 163.602.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of March.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Prospector Offshore Drilling Limited (Cyprus), a company organized under the laws of Cyprus, having its registered

office at Diagoras House, 7 

th

 Floor, 16 Pantelis, Catelaris Street, 1097 Nicosia, Republic of Cyprus, registered with the

Registrar of Companies of Cyprus under number 268531,

duly represented by Mr. Bastien BURIN, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on March

20, 2012.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxy of the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of Prospector Finance S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred
euro  (EUR  12,500.-),  having  its  registered  office  at  65,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  L-1331  Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 163 602 (the “Company”), incorporated
pursuant to a notarial deed dated 19 September 2011, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations,
number 2756 of 11 November 2011. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time
pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, dated 7
December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 447 of 20 February 2012.

The sole partner may thus validly deliberate on all items of the agenda:

<i>Agenda:

1. Change of the currency of the share capital of the Company from euro to US dollar at the exchange rate EUR/USD

of 1.31168 as at 12 March 2012;

2. Change of the nominal value of the shares from one hundred euro (EUR 100.-) to one US dollar (USD 1.-);
3. Increase of the share capital of the Company from its present amount of sixteen thousand three hundred ninety-

six US dollar (USD 16,396.-) up to twenty thousand US dollar (USD 20,000.-) by the issue of three thousand six hundred
four (3,604) new shares with a par value of one US dollar (USD 1.-) each;

4. Delegation of power;
5. Subsequent amendment of article 6 of the Company’s articles of incorporation;
6. Correction of a spelling mistake in the resolutions of the sole partner dated 6 December 2011; and
7. Miscellaneous.
Then the sole partner took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to change the currency of the share capital of the Company from euro (EUR) to US dollar

(USD) at the exchange rate EUR/USD of 1.31168 as at 12 March 2012 published at www.oanda.com by conversion of
the current share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) into sixteen thousand three hundred
ninety-six US dollar (USD 16,396.-) so that the share capital of the Company is fixed at sixteen thousand three hundred
ninety-six US dollar (USD 16,396.-).

<i>Second resolution

The sole partner decides to change the nominal value per share of the Company from one hundred euro (EUR 100.-)

to one US dollar (USD 1.-) and, as a consequence to split the existing shares so that the share capital of sixteen thousand
three hundred ninety-six US dollar (USD 16,396.-) is represented by sixteen thousand three hundred ninety-six (16,396)
shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each.

<i>Third resolution

The sole partner resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three thousand six hundred

four US dollar (USD 3,604.-) to bring it from its present amount of sixteen thousand three hundred ninety-six US dollar
(USD 16,396.-) up to twenty thousand US dollar (USD 20,000.-) by the issue of three thousand six hundred four (3,604)
new shares, having a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each.

67134

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription - Payment

There appears Mr. Bastien BURIN, pre-named, who declares to subscribe in the name and for the account of Pros-

pector Offshore Drilling Limited (Cyprus), pre-named, to three thousand six hundred four (3,604) shares, for a total
amount of three thousand six hundred four US dollar (USD 3,604.-), on the basis of a proxy given on March 20, 2012,
which will remain attached to the present deed.

The shares so subscribed have been fully paid up in cash by the subscriber so that the amount of three thousand six

hundred four US dollar (USD 3,604.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Fourth resolution

The sole partner decides to grant power to the board of managers of the Company to exchange the existing shares

of the Company against the new shares of the Company and to take any necessary measures in relation to the exchange
of the existing shares of the Company against the new shares of the Company.

<i>Fifth resolution

As a result of the first, second and third resolutions, the sole partner decides to amend article 6 of the articles of

association of the Company which shall read as follows:

“ Art. 6. The Company's share capital is set at twenty thousand US dollar (USD 20,000.-) represented by twenty

thousand (20,000) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”

<i>Sixth resolution

Due to a factual error in the resolutions of the sole partner of the Company dated 6 December 2011, the name of

one of the managers of the Company has been erroneously stated as “Koenraad Van den Haegen”, although his correct
name is “Koenraad Van der Haegen”.

Any other provision of the said resolutions dated 6 December 2011 remains unchanged.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the one thousand five hundred

euro.

WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English and followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil

status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

Prospector Offshore Drilling Limited (Cyprus), une société régie par les lois de Chypre, ayant son siège social au

Diagoras House, 7th Floor, 16 Pantelis, Catelaris Street, 1097 Nicosie, République de Chypre, immatriculée au registre
des sociétés de Chypre sous le numéro 268531,

dûment représentée par Monsieur Bastien BURIN, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration donnée le 20 mars 2012.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l’associé unique de Prospector Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et

existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de douze mille cinq cent euro (EUR 12.500,-),
ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163 602 (la «Société»), constituée suivant acte notariée daté du
19 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2756 en date du 11 novembre
2011. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, daté du 7 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 447
en date du 20 février 2012.

L’associé unique peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

67135

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la devise du capital social de la Société de l’euro au US dollar à un taux de change EUR/USD de

1,31168 tel qu’arrêté au 12 mars 2012;

2. Changement de la valeur nominale des parts sociales de cent euro (EUR 100,-) à un US dollar (USD 1,-);
3. Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de seize mille trois cent quatre-

vingt-seize US dollar (USD 16.396,-) à vingt mille US dollar (USD 20.000) par l’émission de trois mille six cent quatre
(3,604) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d’un US dollar (USD 1,-) chacune;

4. Délégation de pouvoir;
5. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société;
6. Correction d’une erreur matérielle dans les résolutions de l’associé unique du 6 décembre 2011; et
7. Divers.
L’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer la devise du capital social de la Société de l’euro ("EUR") en US dollar («USD») au

taux de change EUR/USD de 1,31168 au 12 mars 2012 publié sur www.oanda.com par la conversion du capital social
actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) en seize mille trois cent quatre-vingt-seize US dollar (USD 16.396,-)
de sorte que le capital social de la Société est fixé à seize mille trois cent quatre-vingt-seize US dollar (USD 16.396,-).

<i>Deuxième Résolution

L’associé unique décide de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société d’un montant de cent euro (EUR

100,-) à un US dollar (USD 1,-) et en conséquence de diviser les parts sociales existantes de sorte que le capital social de
seize mille trois cent quatre-vingt-seize US dollar (USD 16.396,-) soit représenté par seize mille trois cent quatre-vingt-
seize (16.396) parts sociales d’une valeur nominale d’un US dollar (USD 1,-) chacune.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de trois mille six cent quatre US dollar

(USD 3.604,-) pour le porter de son montant actuel de seize mille trois cent quatre-vingt-seize US dollar (USD 16.396,-)
à un montant de vingt mille US dollar (USD 20.000,-) par l’émission de trois mille six cent quatre (3,604) nouvelles parts
sociales ayant une valeur nominale d’un US dollar (USD 1,-) chacune.

<i>Souscription - Libération

A comparu Monsieur Bastien BURIN, prénommé, qui déclare souscrire au nom et pour le compte de Prospector

Offshore Drilling Limited (Cyprus), prénommée, aux trois mille six cent quatre (3,604) parts sociales, pour un montant
total de trois mille six cent quatre US dollar (USD 3.604,-) en vertu d’une procuration donnée le 20 mars 2012, qui restera
attachée au présent acte.

Les parts souscrites ont été entièrement libérées en numéraire par le souscripteur de sorte que la somme de trois

mille six cent quatre US dollar (USD 3.604,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire soussigné.

<i>Quatrième Résolution

L’associé unique décide de donner pouvoir au conseil de gérance de la Société pour échanger les parts sociales exi-

stantes contre de nouvelles parts sociales de la Société et pour prendre toutes mesures nécessaires en relation avec
l’échange des parts sociales existantes de la Société contre de nouvelles parts sociales de la Société.

<i>Cinquième résolution

Suite aux première, deuxième et troisième résolutions, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la

Société, pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt mille US dollars (USD 20.000,-) représenté par vingt mille (20.000)

parts sociales, d'une valeur d’un US dollar (USD 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

<i>Sixième résolution

Par suite d’une erreur matérielle, contenue dans les résolutions de l’associé unique de la Société du 6 décembre 2011,

le nom d’un des gérants de la Société a été indiqué erronément comme étant «Koenraad Van den Haegen», alors que
son nom exact est «Koenraad Van der Haegen».

Toutes les autres dispositions figurant au dit acte du 6 décembre 2011, demeurent inchangées.

67136

L

U X E M B O U R G

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison du présent acte sont évalués à environ mille cinq cents euros.

DONT ACTE, fait et passé Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: B. BURIN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 mars 2012. Relation: EAC/2012/4225. Reçu soixante-quinze Euros (75,-EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012053440/169.
(120074053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

Coralis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 85.722.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

(rectification dépôt n° L120055582 du 06/04/2012).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012051389/10.
(120071599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Crakoukass S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 131.718.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012051390/9.
(120071701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Top Way Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8814 Bigonville, 23, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 168.638.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwölf, am sechsundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichnen Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.

Ist erschienen:

Dame Edeltraut ROCKEL, Geschäftsfrau, geschieden, geboren am 31. Mai 1960 in Altentreptow (D) (matr: 1960 05

31 509) wohnhaft in L-9172 Michelau, Willspull,

Welche Komparentin erklärt zwischen ihr und allen denjenigen welche im Nachhinein Anteilhaber werden könnten,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des
Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet „TOP WAY Sàrl“

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Ausschank von alkoholischen und nichtalkolischen Getränken und kleine Res-

tauration.

Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, die mit-

telbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes
beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen, die ihr als geeignet
erscheinen.

67137

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet. Sie kann durch

Beschluss der des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit genommen
wird, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Bigonville.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.-EUR) eingeteilt in hundert

(100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR).

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind

die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Gene-
ralversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustim-
mung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt.

Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder

mehrere Bevollmächtigte weiterleiten.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar. Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.

<i>Abschätzung, Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf € 800.- abgeschätzt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die hundert (100) Anteile wurden von Dame Edeltraut ROCKEL gezeichnet.
Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.EUR) wurden vollständig und in bar eingezahlt, so

dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.-EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem
amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

67138

L

U X E M B O U R G

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Anteilinhaber folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Dame Edeltraut ROCKEL, vorbenannt.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.
2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-8814 Bigonville, 23, rue principale

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Edeltraut ROCKEL, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 27 avril 2012. Relation: DIE/2012/5098. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur

 (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im

Memorial erteilt.

Ettelbruck, den 10. Mai 2012

Référence de publication: 2012054736/89.
(120075990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.

Dassil Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 156.377.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64123 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012051397/10.
(120071425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

DataCenterEnergie S.A. (DCE), Société Anonyme.

Siège social: L-3235 Bettembourg, 4, rue Alexander Graham Bell.

R.C.S. Luxembourg B 140.229.

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2012, la société BDO Audit S.A., ayant son siège social à L-1653

Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, est nommée réviseur d’entreprises pour l’exercice 2012, en remplacement
de la société Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable en abrégé CLERC S.A., démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2012051398/14.
(120071552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 67.895.

La liste des signataires autorisés a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2012.

Référence de publication: 2012051401/11.
(120071440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

67139

L

U X E M B O U R G

Nordest Investments &amp; Opportunities (Luxembourg) SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.184.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 2 février 2012

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 2 février 2012, que:
1. L’assemblée prend acte de la démission de la société à responsabilité VERIDICE Sàrl de son mandat de Commissaire

aux comptes avec effet 30 décembre 2011. Elle décide d’accepter cette démission et de nommer en son remplacement
la société à responsabilité CONCILIUM Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro
161634 jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.

2. L’assemblée décide de renouveler les mandats de tous les administrateurs et celui d’administrateur et d’adminis-

trateur-délégué de Monsieur Alessandro Rizzo jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2012.

NORDEST INVESTMENTS &amp; OPPORTUNITIES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2012051579/19.
(120071522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Dyamina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 161.028.

Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012051403/12.
(120071808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

D4S Designer 4 Sport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 163.669.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012051408/10.
(120071227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Eni International N.A. N.V. S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 94.134.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associée unique en date du 19 avril 2012

1. M. Marco TALAMONTI a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 10 avril 2012.
2. M. Oswaldo CHACON, administrateur de sociétés, né le 19 octobre 1973 à Quito (Equateur), demeurant à 10,

Ebury Bridge Road, GB-SW1W 8PZ Londres, a été nommé comme gérant avec effet au 10 avril 2012 pour une durée
indéterminé.

67140

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Eni International N.A. N.V. S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012051412/16.
(120071752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

European Solar Opportunities II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 127.914.

EXTRAIT

L'un des associés de la société, à savoir HSBC ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND GP LIMITED, a changé

sa dénomination sociale et son adresse comme suit:

- INFRARED ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND GP LIMITED, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU Londres,

Royaume Uni.

Luxembourg, le 3 mai 2012.

<i>Pour EUROPEAN SOLAR OPPORTUNITIES II
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2012051421/16.
(120071888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Cofoot Management s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3862 Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen.

R.C.S. Luxembourg B 144.554.

L'an deux mille douze, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- La société anonyme «COSTANTINI GROUP S.A.», ayant son siège social à L-3862 Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 134.286,

détentrice de cinquante (50) parts sociales.
2.- Monsieur Mario Edgardo MENDOZA, entraîneur de football, né à Lamadrid (Argentine) le 26 janvier 1968, de-

meurant à B-6760 Virton, 9, rue Thill-Lorrain.

détenteur de cinquante (50) parts sociales.
Tous deux étant ici représentés aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant

à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date des 26 et 27
mars 2012, lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire
instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-dessus, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à res-

ponsabilité limitée "COFOOT MANAGEMENT s. à r.l." (numéro d'identité 2009 24 01 716), avec siège social à L-3441
Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 144.554, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 janvier 2009, publié au Mémorial C, numéro 458 du 3 mars 2009
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 septembre 2009, publié
au Mémorial C, numéro 1908 du 1 

er

 octobre 2009,

requièrent le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte à

L-3862 Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen et en conséquence de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article 2 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«  Art. 2. al. 1 

er

 .  Le siège de la société est établi à Schifflange; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-

Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.»

67141

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

La société anonyme "COSTANTINI GROUP S.A.", associée, constate que son siège social est désormais fixé à L-3862

Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à environ neuf cent cinquante euros (€ 950.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 24 avril 2012. Relation: CAP/2012/1520. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 7 mai 2012.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2012054169/47.
(120075259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.

Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 5.735.

Im Jahre zweitausendzwölf, am siebenundzwanzigsten April,
ist vor Maître Léonie GRETHEN, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg,
die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft „COMPTOIR PHARMACEUTIQUE

LUXEMBOURGEOIS S.A.“ zusammengetreten, mit Niederlassung und Gesellschaftssitz in L-3895 Foetz, 6, rue de l’In-
dustrie, gegründet gemäß einer am 22. November 1928 von Maître François Joseph Altwies, Notar mit damaligem Amtssitz
in Luxemburg, aufgenommenen Urkunde, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 68 vom 16. Dezember 1928, eingetragen
im Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 5.735.

Die Satzung wurde mehrmals abgeändert und zuletzt gemäß einer am 27. April 2007 von Maître Martine WEINANDY,

Notar mit Amtssitz in Clerf, aufgenommenen Urkunde, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 1486 vom 18. Juli 2007.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre findet statt unter dem Vorsitz von Herrn Wilfried HOLL-

MANN, mit professioneller Anschrift in L-3895 Foetz, 6, rue de l’Industrie.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer der außerordentlichen Hauptversammlung Frau Odette DELFOSSE, mit

professioneller Anschrift in L3895 Foetz, 6, rue de l’Industrie.

Die  außerordentliche  Hauptversammlung  der  Aktionäre  bestellt  zum  Stimmenzähler  Herrn  Jean-Claude  AST  und

Herrn Georges FOEHR, mit professioneller Anschrift in L-3895 Foetz, 6, rue de l’Industrie.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden

Notar Folgendes zu beurkunden:

I.- Dass die Tagesordnung der heutigen Außerordentlichen Hauptversammlung wie folgt lautet:
1.- Umstellung des Geschäftsjahres auf den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni des darauffolgenden Jahres und

Änderung des Datums der jährlichen Hauptversammlung mit entsprechender Abänderung der diesbezüglichen Satzung-
sartikel.

2.- Komplette Neufassung der Satzung in deutscher Sprache.
3.- Verschiedenes.
II.- Dass aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass von den FÜNFUNDZWANZIGTAUSEND (25.000) Aktien ohne

Nennwertangabe,

Aktien vertreten sind, was mehr als 3/4 der Stimmen entspricht. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten der

vertretenen Aktionäre werden nach ihrer Unterzeichnung durch die Mitglieder des Versammlungsbüros und dem am-
tierenden Notar der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu
werden.

III.- Dass die Einberufungsschreiben am 13. April 2012 per Einschreiben verschickt wurden.
IV.-  Dass  die  heutige  außerordentliche  Hauptversammlung  demzufolge  ordnungsgemäß  zusammengesetzt  ist  und

rechtsgültig über die Punkte der Tagesordnung befinden kann.

67142

L

U X E M B O U R G

Anschließend ist die außerordentliche Hauptversammlung, nach Billigung der Ausführungen des Herrn Vorsitzenden

und Feststellung ihrer rechtsgültigen Zusammensetzung, zur Tagesordnung übergegangen und hat, nach entsprechender
Erörterung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt die Umstellung des Geschäftsjahrs der Gesellschaft auf den Zei-

traum vom 1. Juli bis zum 30. Juni des darauffolgenden Jahres und die entsprechende Abänderung des diesbezüglichen
Satzungsartikels.

Die außerordentliche Hauptversammlung weist darauf hin, dass das am 1. Januar 2012 begonnene Geschäftsjahr am

30. Juni 2012 endet.

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt die Änderung des Datums der jährlichen Hauptversammlung und

die entsprechende Abänderung des diesbezüglichen Satzungsartikels.

<i>Zweiter Beschluss

Die  außerordentliche  Hauptversammlung  beschließt  die  komplette  Neufassung  der  Satzung  in  deutscher  Sprache,

welche fortan wie folgt lautet:

„ Art. 1. Bezeichnung - Gesellschaftsform. Zwischen dem Unterzeichneten und sämtlichen zukünftigen Eigentümern

der nachstehend geschaffenen Aktien wird eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung
„COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A.“ (die „Gesellschaft“) gegründet.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz wird in Foetz festgelegt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats

können Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, die Herstellung und der Verkauf von Erzeugnissen

im Bereich Arzneimittel, parapharmazeutische Artikel, Kosmetik, Chemie, Lebensmittel, Industrie, Unterhalt und medi-
zinische Ausrüstung sowie alle Geschäfte, die direkt oder indirekt damit verbunden sind.

Die Gesellschaft kann außerdem alle Geschäfte im Bereich Industrie, Handel oder Finanzen eingehen, die ihr die Aus-

führung und Entwicklung des Gesellschaftszwecks erleichtern können.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf EUR 4.500.000,-(vier Millionen fünfhunderttausend Euro)

festgelegt, eingeteilt in 25.000 (fünfundzwanzigtausend) Aktien ohne Nennwertangabe, die voll eingezahlt wurden.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der wie in Sachen Satzungsänderung befindenden Haupt-

versammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen zurückkaufen.

Art. 6. Aktien. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien. Es wird ein Aktienregister am Sitz der Gesellschaft

geführt, wo es von jedem Aktionär eingesehen werden kann. Das Eigentum an den Aktien geht aus der Eintragung in das
Aktienregister hervor.

Die Aktien können frei an jeden anderen Aktionär der Gesellschaft sowie an den Ehepartner oder an die direkten

Nachkommen eines Aktionärs abgetreten werden. Im Falle einer Aktienabtretung oder -übertragung an eine Drittperson
muss die Zulassung eines neuen Aktionärs gegebenenfalls innerhalb von fünfzehn Tagen ab Einigung der Parteien oder ab
dem die Aktienübertragung veranlassenden Ereignis beantragt werden. Der Verwaltungsrat befindet alsdann innerhalb
von zwei Monaten mit einfacher Stimmenmehrheit und endgültig über diesen Antrag, ohne dass es einer Rechtfertigung
seiner Entscheidung bedarf. Im Falle einer Ablehnung des Antrags und sofern der Verkäufer sein Angebot während der
drei  auf  diese  Ablehnung  folgenden  Monate  aufrechterhält,  muss  der  Verwaltungsrat  einen  oder  mehrere  Aktionäre
benennen, welche die abzutretenden oder übertragenen Aktien übernehmen. Der Abtretungspreis ist innerhalb eines
Monats nach der Übernahme zu begleichen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Im Falle einer Vielzahl von Eigentümern pro Aktie ist die

Gesellschaft befugt, die Ausübung sämtlicher damit verbundener Rechte auszusetzen, bis eine einzige Person ihr gegenüber
als Eigentümer dieser Aktie benannt wurde.

Art. 7. Aktionärsversammlung - Allgemeine Bestimmungen.  Die  ordnungsgemäß  zusammengesetzte  Aktionärsver-

sammlung der Gesellschaft vertritt sämtliche Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitest gehenden Befugnisse,
um sämtliche Handlungen im Zusammenhang mit den Gesellschaftsgeschäften anzuordnen, vorzunehmen oder zu bewil-
ligen.

Besteht die Gesellschaft aus einem Alleinaktionär, so übt dieser die der Hauptversammlung zustehenden Befugnisse

aus.

Art. 8. Jährliche Hauptversammlung - Feststellung des Jahresabschlusses. Die jährliche Hauptversammlung der Aktio-

näre tritt am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort am letzten Donnerstag
des Monats Oktober um 11.30 Uhr zusammen.

67143

L

U X E M B O U R G

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt. Die

jährliche Hauptversammlung kann im Ausland zusammentreten, sofern der Verwaltungsrat dies nach freiem Ermessen
aufgrund außerordentlicher Umstände für erforderlich erachtet.

Art. 9. Sonstige Versammlungen. Die sonstigen Versammlungen der Aktionäre können an den in den jeweiligen Ein-

berufungsschreiben angegebenen Orten und zu den entsprechenden Uhrzeiten zusammentreten.

Vorbehaltlich einer gegenteiligen Bestimmung in der vorliegenden Satzung gelten für die Einberufungsschreiben sowie

für die Abhaltung der Aktionärsversammlungen der Gesellschaft die gesetzlich vorgeschriebenen Quorums-und Fristbe-
dingungen.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme, vorbehaltlich der durch das Gesetz und die vorliegende Satzung auferlegten

Einschränkungen. Jeder Aktionär kann an den Aktionärsversammlungen teilnehmen, indem er schriftlich, per Fax oder E-
Mail eine Drittperson zu seinem Bevollmächtigten bestellt.

Bei der Quorums-und Mehrheitsberechnung gelten auch diejenigen Aktionäre als anwesend, die durch Videokonferenz

oder durch sonstige Mittel, die ihre Identifizierung gestatten, an der Versammlung teilnehmen, sofern diese Mittel tech-
nische Merkmale aufweisen, welche eine effiziente Teilnahme an der Versammlung gewährleisten, deren Verhandlungen
kontinuierlich übertragen werden.

Vorbehaltlich einer gegenteiligen gesetzlichen Bestimmung werden die Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen

Aktionärsversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jedwede weiteren seitens der Aktionäre zu erfüllenden Bedingungen festlegen, um an einer

Aktionärsversammlung teilzunehmen.

Falls sämtliche Aktionäre bei einer Aktionärsversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Ta-

gesordnung informiert zu sein, kann die Versammlung ohne vorheriges Einberufungsschreiben oder vorherige Veröffent-
lichung abgehalten werden.

Art. 10. Zusammensetzung des Verwaltungsrats. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat, bes-

tehend aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Besteht die Gesellschaft jedoch
aus einem Alleinaktionär oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft
nur noch einen Alleinaktionär zählt, kann der Verwaltungsrat bis zur ordentlichen Hauptversammlung nach der Feststel-
lung einer Vielzahl von Aktionären auf ein Mitglied beschränkt werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchstens sechs

Jahren ernannt und bleiben bis zur Ernennung ihrer Nachfolger im Amt. Sie sind wiederwählbar.

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds frei, so haben die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das Recht,

sie vorübergehend zu besetzen. In diesem Fall nimmt die Hauptversammlung anlässlich ihrer nächsten Sitzung die end-
gültige Wahl vor.

Art. 11. Sitzungen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie gege-

benenfalls einen stellvertretenden Vorsitzenden. Des Weiteren kann er einen Schriftführer wählen, der kein Verwal-
tungsratsmitglied  sein  muss  und  mit  der  Verfassung  der  Protokolle  der  Verwaltungsratssitzungen  und  der
Hauptversammlungen der Aktionäre beauftragt wird.

Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden, des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder zweier Ver-

waltungsratsmitglieder an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei einer Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem es ein anderes

Verwaltungsratsmitglied schriftlich, per Fax oder E-Mail zu seinem Bevollmächtigten bestellt.

Bei der Quorums-und Mehrheitsberechnung gelten auch diejenigen Verwaltungsratsmitglieder als anwesend, die durch

Videokonferenz oder durch sonstige Mittel, die ihre Identifizierung gestatten, an der Verwaltungsratssitzung teilnehmen,
sofern diese Mittel technische Merkmale aufweisen, welche eine effiziente Teilnahme an der Sitzung des Verwaltungsrats
gewährleisten, deren Verhandlungen kontinuierlich übertragen werden. Eine anhand solcher Fernkommunikationsmittel
stattfindende Sitzung gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Der Verwaltungsrat ist nur rechtsgültig beratungs-und beschlussfähig, sofern mindestens die Hälfte seiner Mitglieder

in der Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmen-
mehrheit der in dieser Sitzung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein  schriftlich  gefasster,  von  allen  Verwaltungsratsmitgliedern  gebilligter  und  unterzeichneter  Beschluss  ist  ebenso

wirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Der Verwaltungsrat kann einstimmig Zirkularbeschlüsse fassen, indem er seine Zustimmung schriftlich, per Fax oder

E-Mail oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel mit anschließender schriftlicher Bestätigung erteilt. Das
Ganze wird in einem Protokoll festgehalten, welches als Beweis für die Billigung der Beschlüsse gilt.

Zählt die Gesellschaft lediglich ein Verwaltungsratsmitglied, so übt dieses die dem Verwaltungsrat zustehenden Befu-

gnisse aus.

67144

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat besitzt die weitest gehenden Befugnisse, um sämtliche

Verwaltungs-und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. In seinen Zuständigkeitsbereich fal-
len alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft und der Vertre-

tung  der  Gesellschaft  für  das  Geschäftsgebaren  an  ein  oder  mehrere  Verwaltungsratsmitglied(er),  Direktor(en),  Ge-
schäftsführer  und  sonstige  Vertreter,  ob  Aktionäre  oder  Nichtaktionäre,  übertragen,  welche  unter  den  vom
Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen und im Rahmen der von ihm erteilten Befugnisse handeln. Ferner kann er Be-
fugnisse und Sondervollmachten an jedwede Personen erteilen, die nicht Verwaltungsratsmitglied sein müssen, sowie
jedwede Bevollmächtigten und Angestellten ernennen und abberufen und deren Vergütungen festlegen.

Art. 13. Vertretung. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die Einzelunterschrift des einzigen Verwalters oder

durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats verpflichtet, wobei eine dieser Unters-
chriften diejenige des Präsidenten oder des Vize-Präsidenten des Verwaltungsrats sein muss, gebunden.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen

gebunden, denen eine spezielle Vollmacht vom Verwaltungsrat übertragen worden ist, jedoch nicht über die Grenzen
dieser speziellen Vollmacht hinaus.

Art. 14. Überwachung. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Rechnungsprüfer(n), die nicht

Aktionär sein müssen. Die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche auch ihre Anzahl, ihre
Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit festlegt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie sind wiederwählbar.

Art. 15. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauffolgenden

Jahres.

Art. 16. Gewinnverteilung. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) der Bildung eines

gesetzlichen Reservefonds zugeführt. Diese Zuführung erübrigt sich, sobald und solange die gesetzliche Reserve zehn
Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht.

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, auf Vorschlag des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Saldos

des jährlichen Nettogewinns.

Im Falle teilweise eingezahlter Aktien, werden Dividenden anteilmäßig zu dem auf diese Aktien eingezahlten Betrag

ausgezahlt.

Es  können  Vorschussdividenden  in  Übereinstimmung  mit  den  gesetzlich  vorgesehenen  Bedingungen  ausgeschüttet

werden.

Art. 17. Auflösung. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, erfolgt die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidator

(en) (natürliche oder juristische Personen), die von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, welche auch
ihre Befugnisse und Vergütungen festlegt.

Art. 18. Verschiedenes. Für sämtliche nicht in der vorliegenden Satzung geregelten Punkte, unterwerfen sich die Par-

teien den Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften
und den jeweiligen Abänderungsgesetzen.“

Da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand sich zu Wort meldet, hebt der Vorsitzende die Sitzung auf.

<i>Kosten

Alle aufgrund der vorliegenden Urkunde geschuldeten Kosten und Honorare, welcher Art auch immer, gehen zu Lasten

der Gesellschaft.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Foetz, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Auslegung an die Komparenten, die dem Notar alle mit Namen, Vornamen, Stand und Wohnsitz

bekannt sind, haben diese das vorliegende Protokoll mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: Hollmann, Delfosse, Ast, Foehr, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 mai 2012. Relation: LAC/2012/20222. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 7. Mai 2012.

Référence de publication: 2012053107/195.
(120074768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

67145

L

U X E M B O U R G

Eurodyne, Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 10.646.

<i>Extrait de la décision des administrateurs

<i>Résolution:

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer avec effet au 4 février 2011 le siège social à l'adresse

suivante:

1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg

Pour copie conforme

Référence de publication: 2012051417/13.
(120071678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 30.469.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012051418/9.
(120071376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Europa Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 76.176.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012051419/10.
(120071456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

HDF Sicav SPE (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 135.265.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 17 avril 2012 a adopté les résolutions sui-

vantes:

1. L'assemblée a élu comme Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinairequi se tiendra en 2013:
- Madame Véronique Degenne (demeurant en France, 40 rue de la Pérousse, 75116 Paris).
2. L'assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2013:
- Monsieur Christopher Wetherhill (demeurant aux Bermudes, 1 Turtle Bay Crescent, SN01 Southampton),
- Monsieur Patrice Josnin (demeurant en France, 21 Avenue des Saphirs, 44500 La Baule),
- Maître Jérôme Wigny (demeurant à Luxembourg, 2 Place Winston Churchill, 2014 Luxembourg).
3. L'assemblée a ré-élu PricewaterhouseCoopers S.à r.l, dont le siège social se situe 400 route d'Esch L-1471 Luxem-

bourg, à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale ordinaire de
2013.

<i>Pour HDF SICAV SPE (LUX)
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2012052656/22.
(120073645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

67146

L

U X E M B O U R G

EYNAV Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 166.585.

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire tenue par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence

à Luxembourg en date du 23 avril 2012, qu’il a été procédé à la nomination d’un administrateur supplémentaire, à savoir:

Monsieur DE LEYE Marc, Emilien, Jean-Paul, né le 05/02/1955 à UCCLE (BEL), dont l’adresse professionnelle est au

19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Son mandat expirera lors de l’assemblée devant se tenir en 2013.

Luxembourg, le 30 avril 2012.

Pour extrait conforme
Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2012051422/15.
(120071372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Friederike MLP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 166.092.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Référence de publication: 2012051425/10.
(120071018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Tor-Isteg-Steel-Corporation, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 5.323.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 07 mai 2012:

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Maître Reginald NEUMAN, demeurant à 4, Poststrasse, CH-6403 Küssnacht am Rigi, aux fonctions d'Administrateur

et Président du Conseil

- Monsieur Bart J.A. DUIJNDAM, demeurant à 30, Lassuslaan, NL- 3727 LK BILTHOVEN, aux fonctions d'adminis-

trateur;

- Madame Ginny VOIGT-GERMAIN, demeurant à 27, Wingertgasse, FL- 9490 Vaduz, aux fonctions d'administrateur;
- Madame Nicole BERVARD, demeurant à 16, rue Dante, L- 1412 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur Rudolf SCHMIDT, demeurant à 31, Salesianergasse, A-1010 Wien, aux fonctions d'administrateur;
- Madame Vanessa COSI-VOIGT, demeurant à 25, Pradafant, FL- 9490 Vaduz, aux fonctions d'administrateur;
- d'Administration;
- Monsieur Rudolf SCHMIDT JR., demeurant à 20b, Winzerstrasse, A- 1130 Wien, aux fonctions d'Administrateur,

Vice-Président.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2012.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- Monsieur Robert MOULIN, 21, Rue Aloyse Hoffmann, L- 6913 Roodt-sur-Syre.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 09 mai 2012.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2012054069/29.
(120075554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.

67147

L

U X E M B O U R G

Friederike MLP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 166.092.

<i>Rectificatif L120071018 déposé le 03/05/2012

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2012.

Référence de publication: 2012051427/11.
(120071621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Friederike MLP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 166.092.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2012.

Référence de publication: 2012051428/10.
(120071934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Ferrero Trading Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.

R.C.S. Luxembourg B 46.117.

Les adresses des administrateurs de la Société sont les suivantes:
1. Monsieur Bruno FERRONI réside au 31/1, Via del Lago, I-16011 Arenzano (Italie);
2. Monsieur Giuseppe MARANO réside au 271, rue de Neudorf, L-2221 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Référence de publication: 2012051430/12.
(120071109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Granilo Holding B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,00.

Siège de direction effectif: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 116.802.

Suite à une erreur matérielle, il est à noter les informations suivantes concernant l'Associé unique de la Société,

Sandycove N.V.:

La dénomination de la société est la suivante:
- Sandycove Corporation B.V.
La forme juridique de la société est la suivante:
- Société à responsabilité limitée
Le nom du registre d'immatriculation est le suivant:
- Curaçao Commercial Register
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Granilo Holding B.V.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012052427/21.
(120072487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

67148

L

U X E M B O U R G

QIAGEN Deutschland Finance Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.012.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.570.

Suite à la démission de Madame Cathey Barry en tant que gérant de classe B de la Société avec effet au 24 avril 2012,

l'associé  unique  de  la  Société  a  décidé  de  nommer  Monsieur  NG  Meng  Heng,  demeurant  au  88,  Da  Er  Wen  Road,
Zhangjiang Hi Tech Park, Bâtiment 20, 201203 Pudong, Shanghai, Chine, comme gérant de classe B de la Société avec
effet au 24 avril 2012 pour une durée indéterminée.

De sorte que le Conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Pierre Schill, gérant de classe A,
- Sabrina Collette, gérant de classe A,
- Axel Backheuer, gérant de classe B,
- Meng Heng, NG, gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2012.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2012052440/21.
(120072505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

Financière Lafayette S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 90.887.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2011:

L’Assemblée renomme comme réviseur d’entreprise:
PricewaterhouseCoopers sàrl, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2012051431/14.
(120071859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Sèvres III S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.299.125,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue du Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 119.773.

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 24 avril 2012, l'associé de la Société a:
- accepté les démissions de Nicolas Gheysens en tant que gérant de classe A de la Société et de Wolfgang Zettel en

tant que gérant de classe B de la Société avec effet au 22 avril 2012;

- nommé Stanislas de Joussineau de Tourdonnet en tant que gérant de classe A de la Société et Stefan Lambert en tant

que gérant de classe B de la Société avec effet au 23 avril 2012 pour une durée indéterminée;

de sorte que le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Stanislas de Joussineau de Tourdonnet, né le 22 juin 1981 à Paris en France, gérant, avec
adresse professionnelle à Stirling Square, 7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD,
Royaume-Uni

Gérant de la Classe A

Stefan Lambert, né le 8 janvier 1964 à Trêves en Allemagne, gérant, avec adresse
professionnelle à 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg

Gérant de la Classe B

67149

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Stefan Lambert
<i>Gérant

Référence de publication: 2012052995/25.
(120073261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

GT Global Invest (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 127.042.

EXTRAIT

Veuillez noter le changement d'adresse de Monsieur Peter Dickinson, gérant, avec effet au 20 février 2012, comme

suit:

- 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012051458/15.
(120071667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Finbelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 77.948.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 27 avril 2012 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>1, rue joseph Hackin

L’assemblée générale ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’administrateurs de messieurs, Koen

LOZIE et Joseph WINANDY et de la société COSAFIN S.A. 1 rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg, représentée par
Monsieur Jacques BORDET, 1 rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg.

- L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de The Clover, 4, rue

d’Arlon, L-8399 WINDHOF.

- Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui statuera

sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.

Pour copie conforme
FIDUPAR

Référence de publication: 2012051433/18.
(120071347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Finbelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 77.948.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2012051434/10.
(120071348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

67150

L

U X E M B O U R G

European Motorway Investments 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 146.260.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 4 mai 2012, a renouvelé les mandats des gérants:
- Mme Karen DEAL, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y4QU Londres, Royaume Uni, gérant A,
- Mr Sébastien POCHON, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y4QU Londres, Royaume Uni, gérant A,
- Mr Manuel HACK, Maître es sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant B,
- Mr Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L~ 1116 Luxembourg, gérant

B,

- Mme Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant B,
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 4 mai 2012.

<i>Pour EUROPEAN MOTORWAY INVESTMENTS 1
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2012052587/20.
(120073419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

First Gate Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 105.619.

Dépôt à rectifier ou compléter
Comptes annuels
Déposé le 02/05/2012
Numéro dépôt L120070410
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02.05.12.

Référence de publication: 2012051436/14.
(120071111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Finpharma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 84.079.

Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012051435/9.
(120071120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Fiver S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 39.018.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 2 mai 2012 à 10.00 heures à Luxembourg

<i>1 rue Joseph Hackin

- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Joseph WINANDY Administrateur et Pré-

sident, de Monsieur Koen LOZJE, Administrateur et de COSAFIN S.A., Administrateur dont le siège social est situé 1
rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg (représentée par Monsieur Jacques BORDET, 1 rue Joseph Hackin L-1746 Lu-
xembourg), ainsi que du Commissaire aux comptes, Monsieur Pierre SCHILL.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée

générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2012.

67151

L

U X E M B O U R G

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012051437/18.
(120071761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Fiver S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 39.018.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2012051438/10.
(120071762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Metales Polonia S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 161.175.

Il résulte des résolutions des Actionnaires de la société en date du 15 février 2012, les décisions suivantes:
1. Démission de l'administrateur suivant:
M. Mark Wallace, administrateur, employé privé, demeurant professionnellement à 535 Madison Avenue, Floor 11,

New York, New York 10022.

2. Nomination de l'administrateur suivant pour une durée jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en 2016:
Mlle. Amelia J. Zoler, administrateur, employée privée, née aux Etats-Unis d’Amérique, le 3 février 1966 et demeurant

professionnellement à 535 Madison Avenue, Floor 11, New York, New York 10022.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 mai 2012.

Référence de publication: 2012051547/17.
(120071095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Internationale Participations Financières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 23, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 107.585.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012054490/9.
(120075676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.

IRM Fund S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 143.636.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012054492/9.
(120075926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

67152


Document Outline

Aabar Holdings S.à r.l.

Alcove Europe Three S.à r.l.

ArcelorMittal International Luxembourg

Cofoot Management s.à r.l.

Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois S.A.

Continental Investment Holding

Copacore Fund

Coralis S.A.

Crakoukass S.A.

D4S Designer 4 Sport S.à r.l.

Dassil Invest S.à r.l.

DataCenterEnergie S.A. (DCE)

Deloitte Audit

Dyamina S.à r.l.

Eni International N.A. N.V. S.àr.l.

Eurodyne

EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.

Europa Financing S.à r.l.

European Motorway Investments 1

European Solar Opportunities II

EYNAV Capital S.A.

Ferrero Trading Lux S.A.

Financière Lafayette S.C.A.

Finbelux S.A.

Finbelux S.A.

Finpharma S.A.

First Gate Holding S.A.

Fiver S.A., SPF

Fiver S.A., SPF

Friederike MLP S.à r.l.

Friederike MLP S.à r.l.

Friederike MLP S.à r.l.

Granilo Holding B.V.

GT Global Invest (Lux) S.à r.l.

HDF Sicav SPE (Lux)

Hertford Holding S.à r.l.

Internationale Participations Financières S.A.

IRM Fund S.C.A.

Lexwood Holding S.A.

M3 Architectes S.A.

Metales Polonia S.A.

Mimar Participation S.à r.l.

Nordest Investments &amp; Opportunities (Luxembourg) SA

Optik Hoffmann S.à r.l.

Optique Schaefers Lucien S.à r.l.

Prospector Finance S.à r.l.

QIAGEN Deutschland Finance Holding (Luxembourg) S.à r.l.

Sèvres III S. à r.l.

Top Way Sàrl

Tor-Isteg-Steel-Corporation