logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1387

5 juin 2012

SOMMAIRE

Comodoro Finance SA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66531

Crèche Mes Premiers Pas . . . . . . . . . . . . . . .

66534

Cullen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66531

Daniel Schlechter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66534

D.E.D. Toitures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66532

Delphi Property Investment S.A.  . . . . . . . .

66535

Delta Lloyd Privilege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66535

Dogi' Investment Strategy S.A. . . . . . . . . . .

66536

Dogi' Investment Strategy S.A. . . . . . . . . . .

66541

Drill-Tech-Fondations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

66542

Duault & Jacquemin, Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

66542

DuPont Teijin Films Luxembourg S.A.  . . .

66566

Dynamic Investment Fund  . . . . . . . . . . . . . .

66566

Eco-Maison S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66569

ECP TTL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66566

Ednarts Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

66567

Egon Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66569

Energies Van Kasteren S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

66567

EP Blafjall S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66573

Eprec Bundesallee S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

66568

Espirito Santo Control S.A.  . . . . . . . . . . . . .

66573

Espirito Santo Financial Group S.A. . . . . . .

66573

Espirito Santo International S.A.  . . . . . . . .

66574

Etablissements Klauner  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66574

European General Investments . . . . . . . . . .

66567

European Paper Group s. à r.l.  . . . . . . . . . .

66574

European Real Estate Debt S.à r.l.  . . . . . . .

66568

European Real S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66575

F&C Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66575

F&C Management Luxembourg S.A. . . . . .

66575

F&C Portfolios Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66576

Ferris Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66556

Finance BR S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66542

First Gate Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66576

G.A. - Fund -L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66568

Groupement des Industriels Forains  . . . . .

66569

KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l.  . . . . . . . . .

66534

KHM OP Neuhauser Strasse 18 Beteiligung

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66568

Leeward Ventures Partners  . . . . . . . . . . . . .

66576

Maison 86 Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

66566

Modaven S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66542

Pareto Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66536

Princes Exchange (Luxembourg) Holding

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66545

Sat Télécommunications S.A.  . . . . . . . . . . .

66575

SHCO 35 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66536

Travel Retail S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66544

UBS (Lux) Institutional Sicav II  . . . . . . . . . .

66573

Verspeet- Bogaert Société en nom collec-

tif.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66530

Vimo & Partner S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66535

Wintergreen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66530

66529

L

U X E M B O U R G

Wintergreen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 74.888.

suite à une réunion du Conseil d'Administration en date du 16 avril 2012 il a été convenu ce qui suit:
- le siège social de la société est transféré au 23, rue Aldringen L - 1118 Luxembourg
- la démission de M. Marc Liesch, en sa qualité d'administrateur et administrateur-délégué est acceptée, avec effet

immediat

-  élection  d'un  nouvel  administrateur  et  administrateur-délégué:  M.  Christoph  Nellinger,  70,  Grand-Rue  L  -  1660

Luxembourg

Le conseil d'Administration se compose comme suit:
INTER-HAUS-Luxembourg S.A., Administrateur et Administrateur-délégué,
70, Grand-Rue, L - 1660 Luxembourg
Mme Andrea THIELENHAUS, Administrateur et Administrateur-délégué,
70, Grand-Rue, L - 1660 Luxembourg
M. Christoph Nellinger, Administrateur et Administrateur-délégué,
70, Grand-Rue, L - 1660 Luxembourg
Leurs mandats prendront fin en date du 16 avril 2018
L'adresse du chargé du contrôle des comptes:
AUTONOME DE REVISION, commissaire
70, Grand-Rue
L - 1660 Luxembourg
Le mandat du commissaire prendra fin en date du 16 avril 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2012.

WINTERGREEN S.A.
Signature

Référence de publication: 2012054208/30.
(120075312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.

Verspeet- Bogaert Société en nom collectif., Société en nom collectif.

Enseigne commerciale: Topfloor Luxembourg senc.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 168.542.

STATUTS

<i>Extrait de l'Acte de Constitution

Dénomination Raison Sociale
Verspeet - Bogaert Société en nom collectif.
Enseigne Commerciale
Topfloor Luxembourg senc
Forme Juridique
Société en Nom Collectif
Siège Social
29 avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Associés
Monsieur Franky Verspeet
Né à Aalst le 17/02/1974
Résident à B-9140 TEMSE Schoenstraat 96
Madame Nicole Bogaert
Né à Temse le 09/01/1968
Résident à B-9140 TEMSE Schoenstraat 96

66530

L

U X E M B O U R G

<i>Objet Social

La société pourra accomplir toutes activités commerciales s, effectuer des opérations industrielles ou financières, ainsi

que tous transferts de propriété immobilier ou mobilier.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option

<i>Gérant

Madame Nicole Bogaert
Né à Temse le 09/01/1968
Résident à B-9140 TEMSE Schoenstraat 96
La Société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant

<i>Capital Social

2.500 Euro libéré intégralement, divisé en 100 parts sociaux de 25 Euro chacune

<i>Souscription du Capital

1- Monsieur Franky Verspeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Parts
2- Madame Nicole Bogaert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Parts

<i>Date de Constitution

er

 Mai 2012

La Société est constituée pour une durée illimitée

Fait et Passé à Luxembourg, le 1 

er

 Mai 2012 (deux mille et douze).

Mr Francky Verspeet / Mme Nicole Bogaert.

Référence de publication: 2012052342/49.
(120072541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

Comodoro Finance SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 82.387.

<i>Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2012.

<i>Commissaire aux Comptes

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société

Corporate Assistance and Services nv, société de droit Belge, Molenheidebaan 107, 3190 Boortmeerbeek jusqu'à l'as-
semblée générale de 2016.

Rudi DIERICK
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2012050834/14.
(120070713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Cullen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1120 Luxembourg, 1, rue d'Allamont.

R.C.S. Luxembourg B 61.707.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012050838/10.
(120070280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

66531

L

U X E M B O U R G

D.E.D. Toitures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3770 Tétange, 121, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 168.485.

STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Sead KORAC, couvreur, né le 25 juin 1972 à Berane (Montenegro), demeurant 121, rue Principale à L3770

Tétange,

agissant en son nom personnel.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de:

"D.E.D. TOITURES S.à r.l.".
L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également

prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère uni-personnel de la société.

Art. 2. Le siège social est établi à Tétange (commune de Kayl).
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de toiture, couvreur, charpentier, ferblantier-zingueur

avec l'achat et la vente des articles de la branche, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou indirec-
tement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir
entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente-et-un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), représenté par

CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de

préemption.

b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu'au partage des-dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont

applicables.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs.

Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-

Duché qu'à l'étranger.

66532

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation

personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'associé.

Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mille

douze (31.12.2012).

<i>Souscription et Libération

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur Sead KORAC, couvreur, né le 25 juin

1972 à Berane (Montenegro), demeurant 121, rue Principale à L-3770 Tétange, pré-qualifié.

L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès-à-présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille cent euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Peter ALT, né à Niedersaubach/Lebach (Allemagne) le 25 décembre 1935, demeurant 16, Zum Wiesengrund,

à D-66822 Lebach.

2. Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Sead KORAC, couvreur, né le 25 juin 1972 à Berane (Montenegro), demeurant 121, rue Principale à L3770

Tétange.

La société est valablement engagée en toutes circonstances, par la signature conjointe du gérant technique et du gérant

administratif.

3. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-3770 Tétange, 121, rue Principale.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: S.Korac, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 mai 2012. Relation: EAC/2012/5574. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2012.

Référence de publication: 2012050839/100.
(120070996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

66533

L

U X E M B O U R G

Daniel Schlechter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9412 Vianden, 12, rue de la Frontière.

R.C.S. Luxembourg B 103.868.

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2012 que Monsieur Daniel Schlechter est révoqué de son

poste d’administrateur avec effet immédiat.

Est nommé en son remplacement Monsieur Aloyse Wagner, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg,

9, rue Robert Stümper. Son mandat d’administrateur se terminera lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2012050841/15.
(120070831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Crèche Mes Premiers Pas, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 115, rue des Muguets.

R.C.S. Luxembourg B 148.963.

<i>Cession de parts

Il résulte d’une convention de cession de parts sous seing privé conclue le 30 avril 2012 que:
- Madame PEREIRA FERREIRA Vania Marisa épouse MARTINO, puéricultrice, née à Porto (Portugal), le 2 janvier 1980

demeurant à L-7519 ROLLINGEN, 16a, rue Belle-Vue, Gérante Technique de la Société à responsabilité limitée «Crèche
Mes Premiers Pas S.à r.l.» a cédé 50 de ses 50 parts sociales à la valeur nominale de EUR 125,00 par part sociale

- à Madame MACEDO RIBEIRO Andreia Catarina, éducatrice, née à Oleiros, Vila Verde (Portugal) le 15 mai 1982,

demeurant à L-1243 Luxembourg, 7, rue Félix de Blochausen, Gérante Administrative de la Société à responsabilité limitée
«Créche Mes Premiers Pas S.à r.l.» et détenteur d’actuellement 50 parts sociales.

A la suite de cette cession, les 100 (cent) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de EUR 12.500,00

de la Société à responsabilité limitée «Crèche Mes Premiers Pas S.à r.l.» sont réparties comme suit:

- MACEDO RIBEIRO Andreia Catarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
- Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Suite à cette cession de parts sociales, l’associé unique a pris également note de la démission de Madame PEREIRA

FERREIRA Vania Marisa épouse MARTINO, de sa fonction de gérante administrative avec effet au 30 avril 2012.

Luxembourg, le 08 mai 2012.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2012053086/23.
(120074720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 165.646.

<i>Auszug des schriftlichen Gesellschafterbeschlusses vom 23. April 2012

<i>Beschlüsse:

<i>1. Beschluss: Abberufung von Herrn M. Staratschek

Die Gesellschafter beschließen, Herrn Martin Staratschek, LLM. als A- Geschäftsführer der KH Kaufhaus Beteiligung

S.à r.l. mit sofortiger Wirkung abzuberufen.

<i>2. Beschluss: Abberufung von Herrn Thomas Bohnstedt

Die Gesellschafter beschließen Herrn Thomas Bohnstedt als A-Geschäftsführer der KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l.

mit sofortiger Wirkung abzuberufen.

66534

L

U X E M B O U R G

<i>3. Beschluss: Berufung von Herrn Timo Vorderer

Die Gesellschafter beschießen, Herrn Timo Vorderer, geboren am 05.08.1980 in D-76131 in Karlsruhe, geschäftlich

ansässig unter der Adresse 12, Maximiliansplatz, D-80333, München als A-Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer
für die KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l. mit sofortiger Wirkung zu berufen.

<i>4. Beschluss: Berufung von Dr. Thomas Goergen als Geschäftsführer

Die Gesellschafter beschließen, Herrn Dr. Thomas Goergen, geboren am 08.03.1969 in D-54290, Trier, geschäftlich

ansässig unter der Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, als A-Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer
für die KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l. mit sofortiger Wirkung zu berufen.

Référence de publication: 2012053320/24.
(120074000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

Vimo &amp; Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4972 Dippach, 32, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 113.973.

Suite à une assemblée générale dument constituée qui s'est tenue en date du 29/03/2012 à 10h au siège de la société,

il a été décidé qu'à compter de ce jour:

1.- Renouvellement de deux administrateurs
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler dans leurs mandats:
- Madame Giuseppina Vinciotti-Di Millo, employée privée, née à Roccamorice (Italie), le 24 mai 1953, demeurant

professionnellement à L-4972 Dippach, 32, route de Luxembourg.

- Monsieur Sergio dit Serge Vinciotti, retraité du Parlement Européen, né à Gualdo Tadino (Italie), le 18 février 1950,

demeurant professionnellement à L-4972 Dippach, 32, route de Luxembourg.

Monsieur Sergio Vinciotti prénommé est également renouvelé dans sa fonction d'administrateur délégué à la gestion

journalière, et nommé président du conseil d'administration.

2.- Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur:
- Monsieur Adrianno Vinciotti, administrateur de sociétés, né le 28 Octobre 1972 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-4972 Dippach, 32, route de Luxembourg.

3.- Démission d'un administrateur
L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de son mandat d'administrateur:
- la société VIMO S.A. avec siège social à L-8283 Kehlen, 9, rue Gaessel, R.C. B 50.180.
4.- Durée du mandat
Les mandats des administrateurs expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer en 2017.

<i>Pour le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2012054104/28.
(120075481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.

Delphi Property Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.943.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012050842/9.
(120070755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Delta Lloyd Privilege, Société d'Investissement à Capital Variable.

R.C.S. Luxembourg B 96.850.

Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, BGL BNP Paribas dénonce

sa fonction d’agent domiciliataire de Delta Lloyd Privilege immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 96.850 et domiciliée au 50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg avec effet au 17 novembre 2011.

66535

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 27 avril 2012.

BGL BNP Paribas

Référence de publication: 2012050843/11.
(120070829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Dogi' Investment Strategy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 114.591.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2012050845/12.
(120070205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Pareto Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 152.898.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 20 avril 2012

En date du 20 avril 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 6 décembre 2011, de Monsieur Sven O. Hegstad en qualité d'Administrateur

et de Président du Conseil d'Administration,

- de ratifier la cooptation de Monsieur Thorleif Simonsen, avec effet au 6 décembre 2011, Infiba AG, Paulusgasse 12,

CH - 4002 Bâle, en qualité d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur
Sven O. Hegstad, démissionnaire,

- de renouveler les mandats de Monsieur Thorleif Simonsen, de Madame Anna Måbäck et de Madame Véronique Gillet

en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, en 2013,

- de renouveler le mandat de Monsieur Thorleif Simonsen en qualité de Président du Conseil d'Administration pour

une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 mai 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Pareto Sicav
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012052231/22.
(120072665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

SHCO 35 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 168.447.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the fourth day of April.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, the undersigned.

THERE APPEARED:

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15 Avenue de la Liberté, registered with the Luxembourg
trade registry under number B 103.123,

here represented by Mrs Anne Coenen, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal in Luxembourg, on 4 April 2012.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary will remain

attached to the present deed for the purpose of registration.

66536

L

U X E M B O U R G

The appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary to draw up the following

articles of incorporation of a limited liability company ("société à responsabilitè limitèe"), governed by the relevant laws
and the present articles.

“ Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining

to such an entity as well as by present articles of incorporation.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

participation or in which it has a direct or an indirect interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.

Art. 4. The company will assume the name of “SHCO 35 S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy

of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12,500.-(twelve thousand five hundred euro) represented by

12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1.-(one euro) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law concerning

commercial companies.

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the

legal dispositions. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely trans-
ferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the

company to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.
Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or managers

have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company's object.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.

Any Manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission or

e-mail another Manager as his proxy.

66537

L

U X E M B O U R G

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment

regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

Art. 14. Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each

member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at
meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of members owning three quarters of the company's share capital.

If the Company has only one member, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company.

Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Art. 18. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the members.

The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18.9.33)
are satisfied."

<i>Transitory Disposition

The first financial year commences this day and ends on the thirtyfirst of December two thousand and twelve.

<i>Subscription and Payment.

The 12,500 (twelve thousand five hundred) shares are entirely subscribed by the sole shareholder ATC Corporate

Services (Luxembourg) S. A., predesignated, represented as above stated.

The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred

euro) as has been proved to the undersigned notary.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

eight hundred fifty Euro (EUR 850.-).

66538

L

U X E M B O U R G

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the appearing party, represented as above stated, representing

the whole of the corporate capital, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:

1) Is appointed as sole manager of the company for an undetermined period with powers as stipulated by article 12

of the articles of incorporation:

ATC Management (Luxembourg) S.à r.l. having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 103.336.

2) The registered office is established in L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, surname,

civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le quatre avril.
Pardevant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.123

ici représentée par Madame Anne Coenen, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé à Luxembourg en date du 4 avril 2012.

La prédite procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi

qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives,

ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination «SHCO 35 S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,-(douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

66539

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité  avec  les  dispositions  légales  afférentes.  Dans  l'hypothèse  où  il  n'y  a  qu'un  seul  associé  les  parts  sociales
détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes
de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens

de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion des gérants en désignant par écrit,
par lettre ou par câble, télégramme, télécopie ou email un autre gérant comme son mandataire.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion

du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être

prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes

de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,

66540

L

U X E M B O U R G

augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le

notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.»

<i>Disposition transitoire.

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille douze.

<i>Souscription et Libération.

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sont entièrement souscrites par l'associé unique ATC Corporate Services

(Luxembourg) S.A., prédésignée, représentée comme dit ci-avant.

Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500,-(douze mille cinq

cents euros), ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société du chef de sa constitution ont été évalués à environ huit cent cinquante euros (EUR

850,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

Et à l'instant, la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, s'est

ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée et a pris les
résolutions suivantes:

1) Est nommée gérant unique pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs tels que définis à l'article 12 des statuts:
ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., ayant son siège social au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.336.

2) Le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 1315, Avenue de la Liberté.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Coenen, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 10 avril 2012. Relation: DIE/2012/4336. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Diekirch, le 10 avril 2012.

Référence de publication: 2012050602/265.
(120069773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

Dogi' Investment Strategy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 114.591.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 27 avril 2012

Vincenzo ARNO, employé privé, domicilié au 136, Avenue Pasteur L-2309 Luxembourg, est démissionnaire de son

mandat de commissaire aux comptes. Mohammed KARA, Expert-comptable, professionnellement domicilié à L-1660
Luxembourg, 60 Grand-rue, est nommée commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2015.

66541

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
EASIT S.A.

Référence de publication: 2012050846/14.
(120070611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Finance BR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.500.000,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 146.618.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2012, Monsieur Yves BIEWER, né le 16 août 1963 à Lu-

xembourg, demeurant à L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, a été nommé gérant pour une durée illimitée en
remplacement de Madame Marie BOURLOND démissionnaire.

Luxembourg, le 30/04/2012.

<i>Pour: FINANCE BR S.à r.l
Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Valérie Wozniak / Valérie Albanti

Référence de publication: 2012050882/17.
(120070258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Drill-Tech-Fondations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 80.887.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AGIF S.A.
Signature

Référence de publication: 2012050848/11.
(120070955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Duault &amp; Jacquemin, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 11, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 82.775.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DUAULT &amp; JACQUEMIN, SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012050849/11.
(120070243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Modaven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 129.088.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of March,
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Modaven S.à r.l." (the "Company"), a société à

responsabilité limitée having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, incorporated on 4 

th

May 2007 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mé-
morial”) number 1642, on 3 

rd

 August 2007 and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg

66542

L

U X E M B O U R G

under number B129.088. The articles of incorporation of the Company (the “Articles”) have not been amended since its
incorporation.

The meeting was presided by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary Me Sascha Nolte, maître en droit, and as scrutineer Me Christophe Bregeon, maître

en droit, both residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them is shown on an attendance list signed

by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all twenty thousand (20,000) shares in issue in the Company were represented

at the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so
that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.

2. The agenda of the meeting is as follows:
- Change of the accounting year of the Company so that the accounting year shall begin on 1 

st

 April of each year and

end on 31 

st

 March of the following year, with the current accounting year commenced on 1 

st

 January 2012 to end on

31 

st

 March 2012, and consequential amendment of article 11 of the Articles.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Sole resolution

The meeting of the shareholders of the Company resolved to change the accounting year of the Company so that the

accounting year shall begin on 1 

st

 April of each year and end on 31 

st

 March of the following year, with the current

accounting year commenced on 1 

st

 January 2012 to end on 31 

st

 March 2012.

As a consequence, the meeting of the shareholders of the Company resolved to amend article 11 of the Articles to

read as follows:

“The accounting year begins on 1 

st

 April of each year and ends on 31 

st

 March of the following year.”

There being no further items on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day beforementioned.
After reading these minutes the proxyholders signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le vingt-septième jour du mois de mars,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de "Modaven S.à r.l." (la "Société"), une société à res-

ponsabilité limitée ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, constituée le 4 mai 2007 suivant
acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial"), numéro 1642, du 3
août 2007 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B129.088.
Les statuts de la Société (les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

L'assemblée a été présidée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Il fut désigné comme secrétaire Me Sascha Nolte, maître en droit, et comme scrutateur Me Christophe Bregeon,

maître en droit, tous deux demeurant à Luxembourg.

La présidente a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. Les associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,

signée par le mandataire, la présidente, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Il ressort de ladite liste de présence que la totalité des vingt mille (20,000) parts sociales émises dans la Société étaient

représentées à l'assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre
du jour de sorte que l'assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les points portés
à l'ordre du jour.

2. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
- Changement de l'exercice social de la Société de sorte que l'exercice social commence le 1 

er

 avril de chaque année

et se termine le 31 mars de l'année suivante, et que l'exercice social qui a commencé le 1 

er

 janvier 2012 se termine le

31 mars 2012, et la modification subséquente de l'article 11 des Statuts.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante:

66543

L

U X E M B O U R G

<i>Résolution unique

L'assemblée des associés de la Société a décidé de changer l'exercice social de la Société de sorte que la fin de l'exercice

social soit le 31 mars de chaque année et que l'exercice social qui a commencé le 1 

er

 janvier 2012 se termine le 31 mars

2012.

En conséquence, l'assemblée des associés de la Société a décidé de modifier l'article 11 des Statuts afin qu'il se lise

comme suit:

"L'exercice social commence le 1 

er

 avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties compa-
rantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg le jour susmentionné.
Après lecture du présent procès-verbal, les mandataires ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. HOSS, S. NOLTE, C. BREGEON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 avril 2012. Relation: LAC/2012/15522. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Référence de publication: 2012052751/86.
(120072972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

Travel Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 111.853.

EXTRAIT

Les associés de la Société ont accepté, en date du 27 avril 2012, la démission de Mme Myriam Deltenre et de M. Michael

Ristaino, avec effet au 27 avril 2012.

Les associés de la Société ont décidé, à la même date, de nommer Mme Laetitia Jolivalt, née le 29 mai 1984, à Thionville,

France, avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, M. Frédéric Gardeur, né le 11 juillet
1972, à Messancy, Belgique, avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et M. Alessandro
Maiocchi, né le 1 

er

 octobre 1974, à Venise, Italie, avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

en tant que gérants de la Société, avec effet au 27 avril 2012 et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
- Mme Laetitia Jolivalt, gérante;
- M. Frédéric Gardeur, gérant; et
- M. Alessandro Maiocchi, gérant.
Par ailleurs, par résolution du conseil de gérance de la Société en date du 27 avril 2012, il a été décidé de transférer

le siège social de la Société, avec effet au 30 avril 2012 du 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg au 412F, route d'Esch,
L-2086 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé à Luxembourg, le 08 mai 2012.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012054156/28.
(120074881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

66544

L

U X E M B O U R G

Princes Exchange (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 168.409.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the ninetieth day of April.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

REF Global (Luxembourg) Holding S.à r.l. (formerly Eleven Apricot S.à r.l.), a société à responsabilité limitée governed

by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Registry of Commerce and Companies of Luxembourg, under number B 159.182,

represented by Me Florence FORSTER, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on

19 April 2012, such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of
Incorporation”).

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of “Princes Exchange (Luxembourg) Holding S.à r.l.”

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or

in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well

as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set

by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or

any other similar event affecting one or several shareholders.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twenty thousand pound sterling (GBP 20,000.-)

divided into twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, all of which are
fully paid up.

66545

L

U X E M B O U R G

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed

amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders

but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the “Manager(s)”).

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their

mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or

class B Managers (the “Class B Managers”).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or

proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint

signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to

whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the “Secretary”).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two (2) of its members so require.

66546

L

U X E M B O U R G

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'

written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text (email included). Any such notice shall specify the time and the
place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by
properly documented consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings
held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers

holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be

signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,

heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Com-
pany is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved auditor, the business of the Company and its financial situation, including in particular its

66547

L

U X E M B O U R G

books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors who
need not be shareholders themselves.

The statutory or approved auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number

of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved auditor may,
as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the

Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting
of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the Company's registered office.

Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five

(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may exceptionally be held abroad
if, in the judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in

a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person

designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of

amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements
shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

66548

L

U X E M B O U R G

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial Year, Financial Statements, Distribution of Profits

Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half

of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have

been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, has been one hundred per cent (100%)
paid in cash as follows:

Shareholders

Subscribed

Capital

Number

of Shares

Share

Premium

Amount

paid-in

REF Global (Luxembourg) Holding S.à r.l. . . . . . . . GBP 20,000

20,000

GBP 10,580,000

GBP 10,600,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 20,000

20,000

GBP 10,580,000

GBP 10,600,000

The aggregate amount of ten million six hundred thousand pound sterling (GBP 10,600,000.-) was thus as from that

moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states
that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have
been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately four thousand eight hundred euros (EUR
4,800.-).

66549

L

U X E M B O U R G

<i>Transitory Provisions

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last

day of December of 2012.

<i>Shareholders' Resolutions

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at four (4) the number of Manager(s) and further resolved to

appoint the following for an unlimited duration:

- Mr Thomas Schmuckli, born in Wettingen (Switzerland) on 4 February 1963, having his professional address at 16,

Buettenweg, CH-8070 Zurich, Switzerland;

- Mr Mario Seris, born in Buchs AG (Switzerland) on 28 February 1955, having his professional address at 11, Wald-

meisterweg, CH-8057 Zurich, Switzerland;

-  Mr  Maximilien  Dambax,  born  in  Tarbes  (France)  on  2  February  1981,  having  his  professional  address  at  5,  rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; and

- Mr Stephane Bourg, born in Nantes (France) on 20 October 1973, having his professional address at 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing party, the present

deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same party and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such person signed, together with the undersigned notary, this
original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzwölf, am neunzehnten April.
Vor dem unterzeichnenden Notar Edouard Delosch, mit dem Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

REF Global (Luxembourg) Holding S.à r.l. (vormals Eleven Apricot S.à r.l.), eine société à responsabilité limitée lu-

xemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 159.182,

vertreten durch Florence FORSTER, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in Luxemburg, kraft der am 19. April 2012 in Lu-

xemburg erteilten Vollmacht.

Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet

wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet, die

den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die
„Satzung“) unterliegt.

Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren

Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Princes Exchange (Luxembourg) Holding S.à r.l.“ firmieren.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der

Stadt Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) ent-

weder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

Sollte(n) die (der) Geschäftsführer oder die Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse

politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale

66550

L

U X E M B O U R G

Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz
beziehungsweise zwischen der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen
könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen
Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der
Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unter-
liegt.  Die  genannten  vorübergehenden  Maßnahmen  sind  von  der  Geschäftsführung  zu  beschließen  und  den  hiervon
betroffenen Dritten mitzuteilen.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von

Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreu-
ung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Un-

terstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die  Gesellschaft  kann  auch  in  Immobilien,  geistiges  Eigentum  oder  jegliche  andere  bewegliche  oder  unbewegliche

Vermögensgüter investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldverschreibungen,

Schuldtiteln jeglicher Natur beziehungsweise Warrants oder anderen Bezugsrechten, begeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit ausüben, welche der Ausfüh-

rung und Entwicklung ihres Zweckes dienlich ist.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit dem

nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.

Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aussetzung von Bürgerrechten, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Zah-

lungsunfähigkeit oder andere ähnliche Begebenheiten welche einen oder mehrere Gesellschafter betreffen aufgelöst.

Kapitel II. Kapital, Anteile

Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwanzigtausend Pfund

Sterling (GBP 20.000,-), und ist in zwanzigtausend (20.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem Pfund Sterling (GBP
1,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und

Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf das alle Emissions-

aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten,  zur  Auszahlung  an  den/die  Gesellschafter  in  Form  von  Dividenden  oder  um  Mittel  zur  gesetzlichen  Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.

Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer von Anteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Be-

vollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile

können nur dann an NichtGesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.

Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.

Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser an-
genommen worden ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-

fenen Beschlüsse mit sich.

Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-

sellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit, der Konkurs

oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der
Gesellschaft zur Folge.

66551

L

U X E M B O U R G

Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer

Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschaf-

ter sein müssen, geführt (die (der) „Geschäftsführer“).

Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat“)

gegründet.

Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats

festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch
einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)

„Geschäftsführer A“)) oder als Geschäftsführer B (die (der) „Geschäftsführer B“)) zu qualifizieren.

Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.

Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,

um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-

prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).

Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle

Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit
bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn

mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Geschäftsführern,
gebunden.

Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben

(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen

gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über
die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.

Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende

Regeln:

Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende“). Er kann auch einen

Schriftführer  benennen, welcher  selbst  kein  Geschäftsführer  sein muss und  für  die Protokollführung  der Sitzung  der
Geschäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer“).

Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-

rungsrates muss einberufen werden, wenn zwei (2) seiner Mitglieder dies verlangen.

Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit

der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des

Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel (einschließlich Email) einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit
der Sitzung sowie die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann
durch  ordnungsgemäß  dokumentierten  Beschluss  jedes  Geschäftsführungsmitglieds  verzichtet  werden.  Für  Sitzungen,
deren  Zeit  und  Ort  in  einem  zuvor  von  der  Geschäftsführung  angenommenen  Beschluss  festgelegt  wurde,  ist  keine
gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden im Großherzogtum Luxemburg statt.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-

schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden. Jeder Geschäftsführer kann einen oder
mehrere Geschäftsführer vertreten.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner

amtierenden Mitglieder, wobei im Falle der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäfts-
führer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend oder vertreten sein
muss.

Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-

schäftsführungsrates gefasst.

66552

L

U X E M B O U R G

Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß

einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann
festgehalten sein in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.

Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.

Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-

weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.

Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die

(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem

Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäfts-
führern anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.

Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-

schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.

Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Markt-

bedingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.

Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder

irgend einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer  oder  Bevollmächtigte  der  Gesellschaft  persönlich  an  einer  solchen  Gesellschaft  oder  einem  solchen
Unternehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmens sind. Keine Person, welche in der zuvor beschriebenen Weise mit einer
Gesellschaft oder einem Unternehmen in Beziehung steht, mit der beziehungsweise dem die Gesellschaft vertragliche
Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, wird automatisch daran gehindert, über solche Verträge oder andere
Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung

hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.

Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-

lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.

Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-

schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft
der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich insbesondere der Bücher und Konten, durch Wirtschafts-
prüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.

Die statutorischen oder zugelassenen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den) Gesellschafter

ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und
können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden außer in
Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der zugelassene Wirtschaftsprüfer nur aufgrund schwerwiegendem Grund
oder in gegenseitigem Einverständnis abberufen werden kann.

Kapitel IV. Gesellschafter

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz

zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.

Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.

66553

L

U X E M B O U R G

Art. 19 Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden

muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am Gesellschaftssitz abgehalten.

Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-

zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den
Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn
(15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie
der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Be-
stimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-

halten oder an jedem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg; sie können ausnahmsweise im Ausland abgehalten
werden, wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Interesse des (der) Geschäftsführer(s) liegt,
dies erforderlich machen.

Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die

Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-

schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.

Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über

die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.

Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-

und Rederecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes

Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu

von den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafter-

versammlung anwesend sind, gewählt wird.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-

lung.

Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht einberufen wurde, zur Änderung der Satzung

oder zur Fassung von Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind,
unterliegen, werden Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals reprä-
sentieren. Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen
Beschlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der

Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen wird, entsprechen die Mehrheitsverhältnisse der Mehrheit der Anzahl
der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-

zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.

Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter

unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls

der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden
ist, unterzeichnet werden.

66554

L

U X E M B O U R G

Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von Gewinnen

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die

Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr

als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.

Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der

gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-

winn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäfts-
jahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die
Gesellschafter ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung be-
rechtigt.

Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-

henden  Bestimmungen,  können  die  Geschäftsführer  eine  Abschlagsdividende  an  die  Gesellschafter  auszahlen.  Die
Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst

werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-

liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-

quidationskosten wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Gesellschafter so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 30. Geltendes Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen

sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt
geltenden Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen worden, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert und

das Emmissionsaufgeld zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Gesellschafter

Gezeichnetes

Kapital

Anzahl

der Anteile

Emmissions-

aufgeld

Eingezahlter

Betrag

REF Global (Luxembourg) Holding S.à r.l. . . . GBP 20.000,-

20.000

GBP 10.580.000,-

GBP 10.600.000,-

Gesamtbetrag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 20.000,-

20.000

GBP 10.580.000,-

GBP 10.600.000,-

Die Summe von zehn Millionen sechshunderttausend Pfund Sterling (GBP 10.600.000,-) stand der Gesellschaft daher

von diesem Zeitpunkt an zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt,
dass die Maßgaben von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt
geltenden Fassung, erfüllt wurden.

<i>Kosten

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr viertausendachthundert Euro (EUR 4.800,-) geschätzt.

<i>Ubergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2012.

66555

L

U X E M B O U R G

<i>Gesellschafterbeschlusse

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf vier (4) festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit

als Geschäftsführer ernannt:

- Herr Thomas Schmuckli, geboren in Wettingen (Schweiz) am 4. Februar 1963, mit beruflicher Anschrift in 16, Bu-

ettenweg, CH-8070 Zürich, Schweiz;

- Herr Mario Seris, geboren in Buchs AG (Schweiz) am 28. Februar 1955, mit beruflicher Anschrift in 11, Waldmeis-

terweg, CH-8057 Zürich, Schweiz;

- Herr Maximilien Dambax, geboren in Tarbes (Frankreich) am 2. Februar 1981, mit beruflicher Anschrift in 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

- Herr Stephane Bourg, geboren in Nantes (Frankreich) am 20. Oktober 1973, mit beruflicher Anschrift in 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten

Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, dem

Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit
dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: F. Forster, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 23 avril 2012. Relation: RED/2012/4681. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur ff. (signé) THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C.

Diekirch, den 23. April 2012.

Référence de publication: 2012049936/633.
(120068563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

Ferris Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 168.449.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of the month of April.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Est4te Four Real Estate Pledge Fund L.P., an Albertan Limited Partnership with the Register of Corporations for the

Province of Alberta, registration number LP15993405, having its principal office at Sarnia House, Le Truchot, St Peter
Port, Guernsey GY1 4NA, represented by its managing general partner Est4te Four GP Limited, a company duly esta-
blished and existing under the laws of Guernsey, having its registered office at Sarnia House, Le Truchot, St Peter Port,
Guernsey GY1 4NA. here represented by Société Européenne de Banque, located 19-21 boulevard du Prince Henri L1724
Luxembourg itself represented by Mister Alfio RICIPUTO, pursuant to a proxy dated April 12 

th

 , 2012, which proxy,

signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be filed together with the present deed with
the registration authorities.

The  appearing  party  has  requested  the  undersigned  notary  to  draw  up  the  articles  of  incorporation  of  a  société

anonyme under the name of

Ferris Investments S.A. which is hereby established as follows:

Art. 1. Form and Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the

shares hereafter a company in the form of a société anonyme under the name of Ferris Investments S.A. (the “Company”)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), and
the present articles of incorporation (the “Articles”).

66556

L

U X E M B O U R G

The Company may have one shareholder (the “Sole Shareholder”) or several shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg (“Luxembourg”). It may be transferred within Luxembourg by a resolution of the board of directors of the
Company (the “Board”) or, in the case of a sole director (the “Sole Director”) by a decision of the Sole Director. All
references herein to the Board shall be deemed to be references to the Sole Director in case there is only a Sole Director.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the

manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 21. below.

Art. 4. Corporate objects. The object of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all

types of other companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of
shares, contributions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition
of patents and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly
linked to the said object. The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the
companies in which it has a holding or in which it has a direct or indirect interest. The Company may also carry out all
types of commercial, financial, property or securities operations linked directly or indirectly to the said object or which
may facilitate the realisation thereof.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at forty-three thousand Unites States dollars (USD 43,000)

consisting of forty-three thousand (43,000) ordinary shares in registered form with a nominal value of one United States
Dollar (USD 1) each.

The authorised capital is fixed at two hundred thousand United States Dollars (USD 200,000), represented by two

hundred thousand (200,000) shares having a nominal value of one United State Dollar (USD 1.-) each.

The Board of Directors is authorised, for a period of five years ending April 19 

th

 2017, to increase registered capital

within the limits of the authorised capital, at such time as it shall decide.

These capital increases, as determined by the Board of Directors, can be subscribed for and issued in the form of

shares with or without share premium to be paid up in full or in part in cash, in kind or by offset with certain, liquid and
immediately payable debts on the company or even, through the incorporation of deferred profits, available reserves or
share premiums in the event that the Meeting having decided on these deferred profits, reserves or premiums has so
stipulated, as determined by the Board of Directors.

The Board of Directors can delegate any member of the Board, director, authorised representative or other duly

authorised person to collect subscriptions and receive payment of the price of the shares representing all or part of this
capital increase.

Each time the Board of Directors has a registered capital increase duly recognised, the present article is to be consi-

dered automatically adapted to the change that has occurred.

The company’s authorised capital and registered capital can be increased or reduced by a decision of the General

Meeting of Shareholders deliberating as in an amendment to the articles of association.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

Art. 6. Shares. The shares are in registered form (actions nominatives) or in bearer form (actions au porteur) at the

choice of the shareholder(s).

A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will

be available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

66557

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company. In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted

meeting of the shareholders of the Company (the “General Meeting”) shall represent the entire body of shareholders of
the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the
Company.

In the case of a sole shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these

Articles, as long as the Company has only one shareholder decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting
shall be deemed to be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder. The decisions taken
by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the

registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in
the convening notice of the meeting, on 25 June of each year at 11.00 a.m. If such day is not a day where banks are
generally open for business in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following such business
day.

The  annual  General  Meeting  may  be  held  abroad  if,  in  the  absolute  and  final  judgment  of  the  Board,  exceptional

circumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

Any  shareholder  may  participate  in  a  General  Meeting  by  conference  call,  video  conference,  or  similar  means  of

communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partici-
pating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices. The notice periods and quorum provided for by

the Law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether by letter,

by telefax or e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant
shareholder, (2) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth
in the convening notice and (4) the votes (approval, refusal, abstention) expressed on each point of the agenda. The
original voting bulletins must be received by the Company before the relevant General Meeting.

Art. 10. Management. For so long as the Company has a Sole Shareholder or where the Law so allows, the Company

may be managed by a sole director (the “Sole Director”) who do not need to be (a) shareholder of the Company. Where
the Law so requires, the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not
be shareholders of the Company. The director(s) shall be elected for a term of one year and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company (the “Legal Entity”), the Legal Entity must designate a

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51bis of the Law.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the

number of directors and their remuneration

A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General

Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 11. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the “Chairman”) among its members and may

choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder.
The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting
or the other members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at
the relevant meeting, by simple majority.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting

which shall be in Luxembourg.

66558

L

U X E M B O U R G

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors in advance of the date set for such

meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly
in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether by letter, telefax, or e-mail received in circumstances allowing to
confirm the identity of the sender of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings
that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether by letter, telefax or

e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender another director as his or her proxy.

For any meeting of the Board, each member of the Board may designate another member of the Board to represent

him and vote in his name and place, provided that a given member of the Board may not represent more than one of his
colleagues, and that always at least two members are either present in person or assist at such meeting by way of any
means of communication complying with the requirements set forth in the next paragraph.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference, or similar means of

communications equipment whereby

(i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak

to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly
deliberate; participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board can only deliberate and act validly if at least the majority of the Company's directors is present or repre-

sented  at  a  meeting  of  the  Board,  Decisions  shall  be  taken  by  a  majority  of  the  votes  of  the  directors  present  or
represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

The Board may also in all circumstances and at any time with unanimous consent pass resolutions by circular means

and written resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of the same resolution and may
be evidenced by letter, telefax or e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender.

This Article 11 does not apply in case the Company is managed by a Sole Director.

Art. 12. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The minutes of any meeting of the

Board shall be signed by the Chairman of such meeting or the secretary, and the resolutions passed by the Sole Director
are recorded in a decision register held at the Company's registered office.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman, the secretary or any two members of the Board, or the Sole Director.

Art. 13. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed

all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 14. Delegation of powers. The Board may appoint any person as délégué à la gestion journalière, who can but

must not be a shareholder or a member of the Board, and who shall have full authority to act on behalf of the Company
in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

Art. 15. Binding signatures.  The  Company  shall  be  bound  towards  third  parties  in  all  matters  (including  the  daily

management) by (i) the joint signatures of any two members of the Board or (ii) in the case of a Sole Director, the
signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any person(s) to who such signatory power has been granted
by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

Art. 16. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or

entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is
interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or entity of or affiliated to the
Company.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any subsidiary or affiliated

company with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such
affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with
respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have a personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following General Meeting.

If the Company has a Sole Director, the transactions entered into between the Company and the Sole Director and

in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be recorded in the decision
register.

66559

L

U X E M B O U R G

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions

made in the ordinary course of business of the Company and which are entered into on arm's length terms.

Art. 17. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors

(commissaire(s) aux comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term of one year and shall be re-eligible.

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remune-

ration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting
with or without cause.

Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate on the

31 December of each year.

Art. 19. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated in article 5 above or as increased or reduced from time to time.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of.
The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places

and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Law.

Art. 20. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in Article 21. below. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 21. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,

subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.

Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitory provisions

The first accounting year begins on the date of incorporation and ends on 31 December 2012.
The first annual General Meeting will be held in 25 June 2013.

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to

forty-three thousand (43,000) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been paid up by the Shareholder to an extent of 100% (one hundred per cent) so that the sum

of forty-three thousand United States Dollars (USD 43,000) is at the free disposal of the Company, evidence thereof
having been given to the officiating notary.

<i>Costs

The approximate amount of the costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged

to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated to one thousand five hundred Unites States Dollars
(USD 1.500.-).

<i>Resolutions of the shareholder

The above named party, representing the whole of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. the following persons are appointed as directors until the annual general meeting to be held on June 25 

th

 , 2013

- Mr Andrea CASTALDO, bank employee, born on March, 30 

th

 , 1979 in Pomigliano D’Arco (NA-Italy), residing

professionally at L1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, President;

- Mr Sebastien SCHAACK, bank employee, born on July 22 

nd

 , 1978 in Thionville (France), residing professionally at

L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

- Mr Alfio RICIPUTO, bank employee, born on March 24 

th

 , 1978 in Namur (Belgium), residing professionally at L-1724

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

- Mr Nicolò Pio BARATTIERI DI SAN PIETRO, company’s director, born on July 6 

th

 , 1971 in Washington DC, United

States of America, residing professionally at 21, Collingham Road, SW5 0NU London, United Kingdom;

66560

L

U X E M B O U R G

2. that the following person is appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company until the

annual general meeting to be held on June 25 

th

 2013:

ComCo S.A., having its registered office at L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich, registered with the R.C.S. Luxembourg

under number B112813.

3. that the registered office of the Company is established at L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille douze, le dix-neuf avril.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Est4te Four Real Estate Pledge Fund L.P., un Limited Partnership inscrit auprès du registre de la Province d’ Alberta,

sous le numéro LP15993405, ayant son siège social à Sarnia House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1 4NA,
représenté par son general partner Est4te Four GP Limited, une société établie et existant sous le droit de Guernsey,
ayant son siège social à Sarnia House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1 4NA. Ici représentée par la Société
Européenne de Banque, sise 19-21 boulevard du Prince Henri L1724 Luxembourg, elle même représentée par Monsieur
Alfio RICIPUTO, en vertu d’une procuration sous seing privé date du 12 avril 2012, laquelle procuration, signee ne varietur
par la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au present acte pour être soumis avec lui aux
formalités de l’enregistrement.

La partie comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme sous la déno-

mination Imlay Investments S.A. qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.  Il est formé par la partie comparante et par tous ceux qui deviendront actionnaires

par la suite une société anonyme sous la dénomination de Ferris Investments S.A. (la "Société") qui sera régie par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") et les présents statuts (les "Statuts").

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires. La Société ne sera pas

dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ("Luxembourg").

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration
de la Société (le "Conseil") ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'"Administrateur Unique") par une décision de
l'Administrateur Unique. Toutes les références dans les présents statuts au Conseil sont censées être des références à
l'Administrateur Unique s'il n'existe qu'un Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compro-

mettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou
seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces cir-
constances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, malgré le
transfert temporaire de son siège sociale, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription
de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entres autres l’acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à quarante-trois mille Dollars des Etats-Unis (USD 43.000.-),

représenté par quarante-trois mille (43.000) actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale de un Dollar
des Etats-Unis (USD1.-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux cent mille Dollars des Etats-Unis (USD 200.000.-), représenté par deux cent mille

(200.000) actions d'une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis (USD 1.-) chacune.

66561

L

U X E M B O U R G

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 avril 2017, à augmenter

en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou
l’assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'adminis-
tration.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de(s) l’actionnaire(s).
Un registre de(s) actionnaire(s) de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout

actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions
qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts d’actions et les dates
de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

Art. 7. Transfert des actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite dans

le registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cession-
naire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément
aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d’actions d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société. Dans le cas d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée des

actionnaires de la Société régulièrement constituée (l'"Assemblée Générale") représentera l'ensemble des actionnaires
de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus afin d'ordonner, d’effectuer ou de ratifier les actes relatifs à toutes
les opérations de la Société.

Dans le cas d'un associé unique, l'Associé Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces

Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux
décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions
prises par l'Associé Unique sont documentées par voie de procès-verbaux.

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de cette assemblée, chaque
année le 25 juin à 11 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblé Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil constate souverainement que des circonstances

exceptionnelles le requièrent.

D'autres  assemblées  des  actionnaires  de  la  Société  pourront  se  tenir  aux  lieu  et  heure  spécifiés  dans  les  avis  de

convocation de l'assemblée.

Tout actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout

autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés,
(ii) toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) l'assemblée
est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une assemblée par un
tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle assemblée.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations et avis de convocation. Les délais de convocation et quorum

requis par la Loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des Assemblées Générales, dans la mesure
où il n’en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée

Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra agir à toute Assemblée Générale en désignant un mandataire par écrit, soit par lettre, par

télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

66562

L

U X E M B O U R G

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été

dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur des résolutions soumises à l'Assemblée

Générale à condition que les bulletins de vote écrits incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires
concernés, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'ordre du jour tel que décrit
dans l'avis de convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) exprimées pour chaque point
de l'ordre du jour. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale
en question.

Art. 10. Administration. Aussi longtemps que la Société a un Actionnaire Unique ou lorsque la Loi le permet, la Société

peut être administrée par un administrateur unique (l'"Administrateur Unique") qui n'a pas besoin d'être un associé de
la Société. Lorsque la Loi l'exige, la Société sera administrée par un Conseil composé d'au moins trois (3) administrateurs
qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Le(s) administrateur(s) sera/seront élu(s) pour un terme d’un an
et seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la "Personne Morale"), la Personne Morale

doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale en tant qu'Administrateur Unique ou en
tant que membre du Conseil conformément à l'article 51bis de la Loi.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d’administrateurs et leur rémunération. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut
être remplacé à tout moment par décision de l’Assemblée Générale.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans cause et/ou remplacé à tout moment par une résolution adoptée

par l’Assemblée Générale.

En cas de vacance d’un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra rapide-
ment être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunions du Conseil. Le Conseil doit nommer un président (le "Président") parmi ses membres et peut désigner

un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des
décisions de l'Assemblée Générale ou des résolutions prises par l'Associé Unique. Le Président présidera toutes les
réunions du Conseil et toute Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du
Conseil (le cas échéant) nommeront un autre président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote
à la majorité simple.

Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convo-

cation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs avant la date prévue pour la réunion, sauf

s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion
du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou

représentés lors de l’assemblée et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir pleine connaissance de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque membre du Conseil donné par
écrit soit par lettre, télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un
échéancier préalablement adopté par une résolution du Conseil.

Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit soit par lettre,

télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur, un autre administra-
teur comme son mandataire.

Chaque membre du Conseil peut, à toute réunion du Conseil, désigner un autre membre du Conseil pour le repré-

senter et voter en son nom et à sa place à condition qu'un membre donné du Conseil ne puisse pas représenter plus
d'un de ses collègues et qu'au moins deux membres du Conseil soient toujours physiquement présents ou assistent à la
réunion du Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication conforme aux exigences du paragraphe
qui suit.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout

autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être iden-
tifiés, (ii) toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) la
réunion est retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs de la Société est

présente ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés à cette assemblée. Dans le cas où lors d’une réunion, il existe une parité des votes pour et contre
une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

66563

L

U X E M B O U R G

Le Conseil peut également en toutes circonstances et à tout moment, avec l'assentiment unanime, passer des réso-

lutions par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et
effectives que si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent
apparaître sur un seul document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, télécopie, ou e-
mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

Le présent Article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil ou des résolutions de l'Administrateur Unique. Les procès-verbaux

de  toute  réunion  du  Conseil  doivent  être  signés  par  le  Président  de  la  réunion  en  question  ou  le  secrétaire,  et  les
résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans un registre tenu au siège social de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le

secrétaire ou deux membres du Conseil, ou l'Administrateur Unique.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil. Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition

et d’administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts
à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil.

Art. 14. Délégation de pouvoirs.  Le  Conseil  peut  nommer  toute  personne  aux  fonctions  de  délégué  à  la  gestion

journalière, lequel pourra mais ne devra pas être actionnaire ou membre du Conseil, et qui aura les pleins pouvoirs pour
agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion

journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil, ou (ii) dans le cas d'un Admi-
nistrateur Unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes à
qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou l'Administrateur Unique, mais uniquement dans
les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou
entité filiale ou affiliée de la Société.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une

filiale ou une société affiliée avec lequel la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne
prendra pas part au vote sur cette affaire, et un rapport devra être fait sur cette affaire et cet intérêt personnel de cet
administrateur à la prochaine Assemblée Générale.

Si la Société a un Administrateur Unique, les transactions conclues entre la Société et l'Administrateur Unique et dans

lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à l'intérêt de la Société doivent être inscrites dans le registre des
décisions.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil ou de l'Administrateur Unique

concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues
à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période d’un an et sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur mandat. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans
motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de chaque année.

Art. 19. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de tout temps,
conformément à l'article 5 des Statuts.

L’Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil et devront être payés

aux lieu et place choisis par le Conseil. Le Conseil peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions
et dans les limites fixées par la Loi.

66564

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l’Assemblée

Générale statuant comme en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après. En cas
de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent
être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette
liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de tout temps par l'Assemblée Générale

extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

réglées en application de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 25 juin 2013.

<i>Souscription

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu’il a souscrit les quarante-trois mille (43.000)

actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions ont été libérées par l’Actionnaire à hauteur de 100% (cent pour cent) de sorte que le montant de

quarante-trois mille Dollars des Etats-Unis (USD 43.000) est mis à la libre disposition de la Société, une preuve de laquelle
a été présentée au notaire instrumentant.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents Euros (EUR
1.500.-).

<i>Résolutions de l’associé unique

L’associé unique ci-dessus prénommé, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-

vantes:

1. les personnes suivantes sont nommées en tant qu'administrateurs jusque l'Assemblée Générale annuelle qui se

tiendra le 25 juin 2013

- Monsieur Andrea CASTALDO, employé de banque, né le 30 mars 1979 à Pomigliano D’Arco (NA-Italie), demeurant

professionnellement à L-1724 Luxembourg, President;

- Monsieur Sébastien SCHAACK, employé de banque, né le 22 juillet 1978 à Thionville (France), demeurant profes-

sionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

- Monsieur Alfio RICIPUTO, employé de banque, né le 24 mars 1978 à Namur (Belgique), demeurant professionnel-

lement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

Monsieur Nicolò Pio BARATTIERI DI SAN PIETRO, administrateur de sociétés, né le 6 juillet 1971 à Washington DC,

Etats-Unis d’Amérique, demeurant professionnellement à 21, Collingham Road, SW5 0NU Londres, Royaume-Uni;

2. que la personne suivante sera nommée commissaire en compte de la société jusque l’Assemblée Générale annuelle

qui se tiendra le 25 juin 2013:

ComCo S.A., établie et ayant son siège social à L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich, inscrite au R.C.S. Luxembourg

sous le numéro B 112813.

3. que le siège social de la société est établi au L-1724 Luxembourg, 1921, boulevard du Prince Henri;
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Riciputo et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 avril 2012. Relation: LAC/2012/18557. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

66565

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 27 avril 2012.

Référence de publication: 2012050327/521.
(120069833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.

ECP TTL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 79.545.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société ECP TTL S.A. qui s'est tenue en date du 17 avril

<i>2012

Il a été décidé
- de nommer Monsieur Didier Schönberger, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt,

L - 1142 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012050862/15.
(120070685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Maison 86 Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 168.081.

<i>Constatation AGE du 30/03/2012

Suite à l’assemblée générale extraordinaire, signée par les actionnaires en date du 30 mars 2012, il résulte les chan-

gements suivant:

Monsieur Alain BROEKAERT, né le 13 août 1964 à Halle et demeurant à 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462, est nommé

à la fonction d’administrateur à la date de la présente assemblée.

Monsieur  Alain  BROEKAERT,  né  le  13  août  1964  à  Halle  et  demeurant  à  1500  Halle,  Lenniksesteenweg  462  est

également désigné comme administrateur délégué de la société.

La société est engagée par la seule signature de l’administrateur délégué dans le cadre de la gestion journalière dans

son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires et représentation de la société concernant cette gestion.

Les mandats de tous les administrateurs ainsi que du commissaire aux comptes de la société s’achèveront à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire de 2017.

Fait à Luxembourg, le 30 mars 2012.

Référence de publication: 2012050993/19.
(120070757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

DuPont Teijin Films Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, rue Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 38.078.

les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Réné Tasch.

Référence de publication: 2012050851/10.
(120070324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Dynamic Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.827.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

66566

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012050854/10.
(120070612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Ednarts Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.275.

EXTRAIT

Veuillez noter le changement d'adresse de Messieurs Peter Dickinson et Philip Godley, gérants, avec effet au 20 février

2012, comme suit:

- 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012050855/16.
(120070927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

European General Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.997.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 19 avril 2012 à 10.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs, COSAFIN S.A., 1, rue

Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, représentée par Jacques BORDET, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, de
Monsieur Koen LOZIE, et Monsieur Joseph WINANDY, pour une nouvelle durée, celle-ci venant à échéance lors de
l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012,

- L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur

Pierre SCHILL pour une nouvelle durée, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2012.

Copie Conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012050872/18.
(120070086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Energies Van Kasteren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 163.307.

Monsieur Alain Van Kasteren, demeurant à L-1419 Luxembourg, 58, Montée de Dommeldange, a présenté sa démission

de son poste de gérant classe C avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2012050857/13.
(120070584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

66567

L

U X E M B O U R G

Eprec Bundesallee S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 109.988.

Par la présente, je donne ma démission comme gérant de la société et ceci avec effet au 30 avril 2012.

Berlin, le 23 avril 2012.

Joachim Klein.

Référence de publication: 2012050858/9.
(120070586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

European Real Estate Debt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.080,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.400.

EXTRAIT

Veuillez noter le changement d'adresse de Messieurs Peter Dickinson et Jonathan Herbert, gérants, avec effet au 20

février 2012, comme suit:

- 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012050859/16.
(120070926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

G.A. - Fund -L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 69.871.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 23 novembre 2011

En date du 23 novembre 2011, le conseil d’administration a décidé de:
- de coopter, en qualité d’administrateur, Monsieur Wim VERMEIR, L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy en

remplacement de Monsieur Jan DEREYMAEKER, L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, démissionnaire en date
du 31 août 2011.

Luxembourg, le 26 avril 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour G.A.-FUND-L
BNP Paribas Securities Services

Référence de publication: 2012050889/16.
(120070885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

KHM OP Neuhauser Strasse 18 Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 160.022.

<i>Auszug des schriftlichen Gesellschafterbeschlusses vom 23. April 2012

<i>Beschlüsse:

<i>1. Beschluss: Abberufung von Herrn M. Staratschek

Die Gesellschafter beschließen, Herrn Martin Staratschek. als A- Geschäftsführer der KHM OP Neuhauser Straße 18

Beteiligung S.à r.l. mit sofortiger Wirkung abzuberufen.

66568

L

U X E M B O U R G

<i>2. Beschluss: Abberufung von Herrn Thomas Bohnstedt

Die Gesellschafter beschließen Herrn Thomas Bohnstedt als A-Geschäftsführer der KHM OP Neuhauser Straße 18

Beteiligung S.à r.l. mit sofortiger Wirkung abzuberufen.

<i>3. Beschluss: Berufung von Herrn Timo Vorderer

Die Gesellschafter beschießen, Herrn Timo Vorderer, geboren am 05.08.1980 in D-76131 in Karlsruhe, geschäftlich

ansässig unter der Adresse 12, Maximiliansplatz, D-80333, München als A-Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer
für die KHM OP Neuhauser Straße 18 Beteiligung S.ä r.l. mit sofortiger Wirkung zu berufen.

<i>4. Beschluss: Berufung von Dr. Thomas Goergen als Geschäftsführer

Die Gesellschafter beschließen, Herrn Dr. Thomas Goergen, geboren am 08.03.1969 in D-54290, Trier, geschäftlich

ansässig in 5, rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg, als A-Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer für die KHM OP
Neuhauser Straße 18 Beteiligung S.à r.l. mit sofortiger Wirkung zu berufen.

Référence de publication: 2012053321/24.
(120074002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

Eco-Maison S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8293 Keispelt, 32, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 152.334.

Dans le cadre de l’exécution de notre mandat en tant que commissaire aux comptes, nous avons le regret de vous

informer de notre décision de déposer avec effet immédiat notre mandat de commissaire aux comptes de votre société.

Luxembourg, le 27 avril 2012.

TRIPLE A CONSULTING

Référence de publication: 2012050861/11.
(120070440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Egon Re, Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 73.799.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EGON RE
Signatures

Référence de publication: 2012050863/11.
(120070659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Groupement des Industriels Forains, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4477 Belvaux, 39, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg F 9.129.

STATUTS

Entre les personnes ci-après désignées, agissant comme membres fondateurs:
1) Monsieur Joe PIERUCCI, né le 4 janvier 1958 à Differdange, demeurant à L-4477 Belvaux, 39, rue de la Poste, de

nationalité luxembourgeoise,

2) Madame Lydie HOLLERICH, épouse PIERUCCI, née le 5 mai 1960 à Differdange, demeurant à L-4477 Belvaux, 39,

rue de la Poste, de nationalité luxembourgeoise,

3) Madame Magali ONDERWATER, née le 8 mars 1969 à Gand (Belgique), demeurant à L-4470 Soleuvre, 2, rue Emile

Mayrisch, de nationalité belge.

4) Monsieur Franck FRANCLET, né le 22 mai 1967 à Thionville (France), demeurant à L-4470 Soleuvre, 2, rue Emile

Mayrisch, de nationalité française,

5) Monsieur Nello AGURASTI, né le 11 février 1967 à Constantin (Roumanie), demeurant à L-1130 Luxembourg, 76,

rue d'Anvers, de nationalité roumaine,

6) Monsieur Jean-Marc VANDERVAEREN, né le 15 mars 1973 à Etterbeek (Belgique), demeurant à B-5300 Maizeret

(Andenne), 57, rue de Gadway, de nationalité belge,

66569

L

U X E M B O U R G

7) Monsieur Jean-François VANDERVAEREN, né le 16 août 1964 a Etterbeek (Belgique), demeurant à B-5300 Maizeret

(Andenne), 57, rue de Gadway, de nationalité belge,

8) Monsieur Thierry CARNIER, né le 2 août 1963, demeurant à Boulogne/Mer (France), demeurant à F-77310 Pon-

thierry, BP 88, de nationalité française,

9) Monsieur Frederick KOPP, né le 10 mars 1970 à Clermont Ferrant (France), demeurant à F-68170 Chatenois, grande

rue, de nationalité française

et tous ceux qui deviendront par la suite,
Il a été constitué en date de ce jour une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928

telle que modifiée par fa suite et par les statuts qui suivent:

Art. 1 

er

 . Qualités.  L'association prend la dénomination de Groupement des Industriels Forains, dénommée ci-après

"l'Association".

Son siège est établi à 39, rue de la poste L-4477 Belvaux. Il pourra être transféré en tous lieux à Belvaux ou dans toute

autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration.

L'association est créée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet. L'Association a notamment pour objet:
- de faciliter toute opération liée à l'activité de forains,
- de faire la promotion de l'activité de forains, et plus généralement de
- de défendre, encourager et maintenir les intérêts de la profession de forains ainsi que les intérêts sociaux de ses

membres.

L'Association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. Conditions d'admission des membres. L'association est composée de membres actifs et de membres sympa-

thisants.

Le nombre minimum de membres ne peut être inférieur à trois.
a) Les membres actifs ont seuls les droits prévus par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations

sans but lucratif.

Ils prennent part aux assemblées générales et ont seuls le droit de vote. Les membres sympathisants soutiennent et/

ou participent aux activités de l'association.

Ils ne jouissent pas du droit de vote. Ils ne peuvent prétendre qu'aux droits que la loi du 21 avril 1928 reconnaît aux

tiers intéressés.

b) Est admissible comme membre actif toute personne physique en manifestant la volonté déterminée à observer les

présents statuts et règlements agréés par le conseil d'administration.

Tout candidat membre actif doit faire l'objet d'un agrément préalable du conseil d'administration. L'agrément est

accordé ou refusé par le conseil d'administration statuant à la majorité de plus des (2) des administrateurs au vu du dossier
de  candidature  déposé  par  le  candidat  membre  actif.  La  décision  du  conseil  d'administration  est  souveraine  et  n'est
susceptible d'aucun recours. En outre, la qualité de membre actif nécessite le paiement de la cotisation annuelle.

Est admis comme membre sympathisant toute personne en manifestant la volonté, agréée par le conseil d'adminis-

tration et remplissant les conditions que celui-ci fixera à leur admission. Une carte de membre spéciale pourra leur être
remise.

Art. 4. Paiement des cotisations. Les membres actifs et sympathisants paient une cotisation annuelle qui est fixée par

l'assemblée générale en accord avec le trésorier.

Elle ne peut être supérieure à EUR 500. Les cotisations couvrent chaque exercice social. L'exercice social commence

te 1 

er

 septembre et se termine au 31 août de l'année suivante.

Les cotisations sont payables durant la première quinzaine du mois de septembre de chaque exercice social à première

demande du trésorier de l'association.

Un éventuel surplus de cotisation sera affecté à l'organisation d'un événement au nom et pour le compte de l'asso-

ciation.

Art. 5. Conditions de démission des membres. Tout membre est libre de se retirer de l'association en adressant sa

démission par écrit au conseil d'administration, étant précisé que les cotisations versées ne seront pas remboursées et
resteront intégralement acquises à l'association.

Est réputé démissionnaire tout membre qui aura refusé de payer la cotisation annuelle ou ayant omis de la payer deux

mois après qu'elle lui fut réclamée par le trésorier

Tout membre qui compromet les intérêts de l'association, qui se rend coupable de manquements graves à son égard

ou qui contrevient au règlement de l'association pourra être exclu de celle-ci.

L'exclusion (à temps ou définitive) d'un membre pourra être décidée par l'assemblée générale statuant à la majorité

des deux tiers des voix suite:

66570

L

U X E M B O U R G

- au fait qu'un membre se soit rendu responsable d'un acte ou d'une omission grave contraire aux statuts et règlements

de l'association,

- au fait qu'un membre s'est rendu responsable d'un acte ou d'une omission de nature à porter atteinte, soit à l'honneur

ou à sa considération personnelle, soit à la considération ou à l'honneur d'un autre membre, soit à la considération de
l'association,

- à tout acte préjudiciable à l'objet social de l'association,
- au non paiement du droit d'entrée et / ou de la cotisation annuelle qui lui incombe,
En cas de démission ou d'exclusion d'un membre, les droits d'entrée ainsi que les cotisations perçues restent acquis

à l'association.

Le conseil d'administration, après avoir entendu l'intéressé en ses explications, et statuant à la majorité des 2/3 de ses

membres, peut pour l'une des mêmes raisons, prononcer avec effet immédiat la suspension temporaire de l'affiliation
d'un membre. Cette suspension prendra fin lors de la prochaine assemblée générale qui sera appelée à statuer sur l'ex-
clusion de ce membre.

Art. 6. Assemblée générale. L'assemblée générale a spécialement dans ses attributions:
- la modification des statuts,
- la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration,
- l'approbation des budgets et des comptes,
- la dissolution de l'association à l'exclusion des membres,
- la nomination du commissaire aux comptes.
De surcroît, les décisions dépassant les pouvoirs légalement ou statutairement dévolus au conseil d'administration

seront prise en assemblée générale

L'assemblée générale se compose de bus les membres actifs à l'exclusion des sympathisants. Elle se réunit une fois par

an en session ordinaire sur convocation du conseil d'administration à émettre exclusivement par courriel au moins dix
jours avant fa date de la réunion de l'assemblée. La convocation doit contenir l'ordre du jour

L'assemblée générale pourra se réunir spontanément, sans respecter le formalisme ci-avant indiqué et prendra toute

décision utile dès lors que tous les membres actifs seront présents ou représentés.

L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Tout membre, à l'exclusion des membres sympathisants, a une voix délibérative aux assemblées générales. Chaque

membre ne peut avoir qu'une voix.

Les membres peuvent se faire représenter aux assemblées par un autre membre moyennant une procuration écrite,

chaque membre présent ne pouvant être chargé de représenter plus de trois membres. Le vote aux assemblées sera
effectué par bulletin ou éventuellement à main levée.

Seront exclus du vote les membres qui ne seraient pas à jour de leur cotisation.
En cas de besoin le conseil d'administration peut convoquer à chaque moment une assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration, et ce endéans les deux mois,

lorsque 1/5 des associés en font la demande.

Toute proposition signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle des membres doit

être portée à l'ordre du jour.

Les associés qui, en application des articles 10 et 11, veulent faire convoquer une assemblée générale extraordinaire

ou proposer une question à l'ordre du jour de l'assemblée, doivent soumettre au président du conseil d'administration
une note écrite précisant leur intention. S'il s'agit d'une question à porter à l'ordre du jour, cette note doit être entre
les mains du président du conseil d'administration huit jours avant la date de l'assemblée générale.

Des résolutions en dehors de l'ordre du jour ne peuvent être prises que si une majorité des deux tiers des voix émises

par les membres présents marque son accord pour procéder à un vote sur elles. Aucune résolution en dehors de l'ordre
du jour ne peut être prise sur les points indiqués à l'article 5.

L'assemblée  générale  ne peut valablement délibérer sur  les  modifications aux  statuts  que si l'objet de  celle-ci est

spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les 2/3 des membres.

Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des 2/3 des voix.
Si les 2/3 des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion il peut être convoqué une seconde

réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais dans ce cas la décision sera soumises
à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, les régies qui

précèdent sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée générale ne sera valablement constituée que si la moitié au moins des membres sont présents;
b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, et si elle est votée à la majorité des 3/4 des voix;

66571

L

U X E M B O U R G

c) si dans la seconde assemblée, les 2/3 des associés ne sont pas présents, la décision devra être homologuée par le

tribunal civil.

Les décisions de l'assemblée générale sont:
- portées à la connaissance des membres par voie de lettre circulaire,
- inscrites dans un registre ad hoc qui est tenu au siège social, et qui peut être consulté par des tiers.
Chaque membre de l'association devra faire connaître au conseil d'administration une adresse électronique.

Art. 7. Conseil d'administration. Le conseil d'administration se compose de trois membres au moins et quinze membres

maximum élus par l'assemblée générale pour un mandat de 3 ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière des affaires de l'association. Il

représente l'association dans ses relations avec les tiers.

Le conseil d'administration désignera parmi ses membres le président, le trésorier et le secrétaire général.
Si le conseil d'administration se compose de plus de quatre membres, les personnes qui exercent les fonctions pré

désignées forment le comité exécutif.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des administrateurs sont présents ou repré-

sentés. Toutefois, il peut délibérer quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés lorsqu'il sera
appelé à délibérer une seconde fois sur un objet inscrit à l'ordre du jour de la séance précédente.

Tout administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur sans qu'un administrateur présent ne puisse

disposer de plus d'une procuration.

Le conseil d'administration est présidé par le président ou à son défaut par le vice-président ou à son défaut par le

plus âgé des administrateurs présents.

Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés pour y voter. En cas de parité, la

voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans le registre de l'as-

sociation. Les délibérations du conseil d'administration sont signées par le président ou son remplaçant, sinon envoyées
de façon circulaire par courriel pour approbation.

L'association est engagée soit par la signature du président du conseil d'administration, soit par la signature du vice-

président, soit par la signature du trésorier.

La surveillance de l'administration est exercée par deux commissaires élus par l'assemblée générale pour une année

et rééligibles immédiatement après expiration de leur mandat. Les commissaires veillent à la stricte exécution des statuts
et exercent le contrôle sur toute la gestion de l'association, soit des écritures des livres, soit de l'état de la caisse.

Art. 8. Ressources sociales. Les ressources de l'association se composent:
- des cotisations annuelles versées par les membres actifs et sympathisants; il est loisible à chaque membre de verser

volontairement une cotisation supérieure;

- des subsides éventuellement versés par les pouvoirs publics intéressés à la poursuite de l'objet de l'association;
- des subventions spéciales accordées par les particuliers, les collectivités ou toute entreprise;
- des dons que l'association peut recevoir dans les conditions de l'article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif;

- du produit des fêtes, concours et manifestations.

Art. 9. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 septembre et se termine le 31 août de l'année qui suit.

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de l'approbation des statuts de l'assemblée constitutive et

se terminera le 31 août 2013.

Les comptes sont arrêtés au 31 août de chaque année et soumis pour approbation à l'assemblée générale avec le

rapport des commissaires aux comptes.

Art. 10. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés conformément aux prescriptions de

l'article 8 de la ici modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et ses amendements.

Art. 11. Dissolution. L'assemblée générale peut prononcer la dissolution de l'association si au moins 3/4 de ses membres

actifs sont présents ou représentés.

La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des 2/3 des membres actifs présents ou représentés.
En cas de décision de l'association, son patrimoine sera affecté après apurement du passif éventuel, selon les décisions

de l'assemblée générale à une association ayant un but similaire ou à une œuvre de bienfaisance.

L'assemblée générale qui prononcera la dissolution désignera le (ou les) liquidateur(s) et déterminera ses (leurs) pou-

voirs,

La dissolution de l'association ne pourra être prononcée que moyennant l'observation des formalités et conditions

énoncées par l'article 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

66572

L

U X E M B O U R G

Le président du conseil d'administration, ou toute autre personne désignée à cet effet par le conseil d'administration

est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi du 21 avril 1928.

Art. 12. Dispositions interprétatives. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, il y a lieu de se référer

à la loi modifiée du 21 avril 1923 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Les statuts approuvés par rassemblée
générale extraordinaire tenue le 5 avril 2012 et prennent effet à compter de ce jour.

Luxembourg, le 5 avril 2012.

J.PIERUCCI / L. HOLLERICH / M. ONDERWATER / F. FRANCLET /

N. AGURASTI / J-M VANDERVAEREN / J-F. VANDERVAEREN / T. CARRIER /

E. KOPP.

Référence de publication: 2012050908/194.
(120070823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

EP Blafjall S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 131.540.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64135 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012050866/10.
(120070457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Espirito Santo Control S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 13.634.

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration tenue par voie circulaire en date du 16 mars

2012 que M. Roland COTTIER, Administrateur est décédé le 18 février 2012.

Il ne sera pas pourvu à son remplacement et le nombre des membres du Conseil d’Administration a par conséquent

été réduit de douze à onze.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012050868/13.
(120070891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Espirito Santo Financial Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21/25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 22.232.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2012.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012050869/11.
(120070818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

UBS (Lux) Institutional Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.356.

<i>Extrait des décisions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 20 avril 2012

Sont réélus au conseil d'administration
- M. Tobias Meyer, Président du conseil d'administration, Brunngässlein 12, CH-4052 Bâle, pour une période se ter-

minant lors de l'assemblée générale annuelle de 2015.

- M. Thomas Portmann, Membre du conseil d'administration, Pelikanstrasse 19, CH-8001 Zurich, Suisse, pour une

période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2014.

66573

L

U X E M B O U R G

- M. Aloyse Hemmen, Membre du conseil d'administration, 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, pour une

période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2013.

Luxembourg, le 26 avril 2012.

<i>Pour UBS (Lux) Institutional SICAV II
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Benjamin Wacker / Mathias Welter
<i>Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2012051844/20.
(120071525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

Espirito Santo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 13.091.

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration tenue par voie circulaire en date du 16 mars

2012 que M. Roland COTTIER, Administrateur est décédé le 18 février 2012.

Il ne sera pas pourvu à son remplacement et le nombre des membres du Conseil d’Administration a par conséquent

été réduit de dix-huit à dix-sept.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012050870/13.
(120070892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Etablissements Klauner, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7327 Steinsel, 24, rue J.-F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 29.737.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ETABLISSEMENTS KLAUNER SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012050871/11.
(120070242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

European Paper Group s. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 7.254.

Suite à diverses modifications intervenues jusqu’à ce jour, les associés de la société “European Paper Group S.à.r.l. “,

ayant son siège au 412F route d’Esch L-2086 Luxembourg, sont actuellement:

- IGEPA BELUX anciennement GREPAPROOST, sise 4 Nijverheidslaan B-9880 AALTER, détenant 151 parts sociales

de la Société;

- IGEPA group Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, sise 4 Sachsenfeld D-20097 HAMBURG, détenant 350

parts sociales de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2012.

Certifié sincère et conforme
European Paper Group S.à.r.l.

Référence de publication: 2012050873/18.
(120070702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

66574

L

U X E M B O U R G

F&amp;C Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 82.782.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la société F&amp;C FUND, de

Brown Brothers Harriman siégant sur 2-8, rue Charles de Gaulle, L-2014 Luxembourg au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg où siège State Street Bank Luxembourg S.A. , avec effet au 30 Mars 2012.

Luxembourg, le 30 Avril 2012.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012050876/12.
(120070600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

European Real S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.103.

EXTRAIT

Veuillez noter le changement d'adresse de Monsieur Peter Dickinson, administrateur, avec effet au 20 février 2012,

comme suit:

- 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Veuillez en outre noter le changement d'adresse de Monsieur Philip Godley, administrateur, avec effet au 20 février

2012, comme suit:

- 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012050874/18.
(120070925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

F&amp;C Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 122.163.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la société F&amp;C MANAGE-

MENT LUXEMBOUG S.A., de Brown Brothers Harriman siégeant sur 2-8, rue Charles de Gaulle, L-2014 Luxembourg
au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg où siège State Street Bank Luxembourg S.A., avec effet au 9 Mars 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 Mai 2012.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012050877/13.
(120070990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Sat Télécommunications S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 100.345.

<i>Extrait du procès verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 09 avril 2012

Jusqu’à  l’issue  de  l’assemblée  générale  statutaire  appelée  à  se  prononcer  sur  les  comptes  de  2012,  les  personnes

suivantes composent le conseil d’administration:

- M. Eric Bernard, expert-comptable, né le 15 mai 1965, à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie,

- M. Hugues Baudenet D’Annoux, économiste, né le 13 novembre 1948, à Paris en France, demeurant à CH-1208

Genève, 4, avenue Krieg (Suisse),

66575

L

U X E M B O U R G

-  M.  Bob Faber,  expert-comptable, né  le  15  mai  1964, à Luxembourg, ayant son  domicile  professionnel  à  L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Extrait du procès verbal des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 09 avril 2012

A l'unanimité, le conseil d'administration décide jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire appelé à se prononcer

sur les comptes de 2012:

1) De reconduire M. Hugues Baudenet D’Annoux, dans sa fonction d’administrateur-délégué de la société.
2) De reconduire M. Hugues Baudenet D’Annoux dans sa fonction de président du Conseil d’administration.

Luxembourg, le 04 mai 2012.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SAT Télécommunications S.A.
BERNARD &amp; ASSOCIES, société civile

Référence de publication: 2012052285/25.
(120072848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

F&amp;C Portfolios Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 25.570.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la société F&amp;C PORTFOLIOS

FUND, de Brown Brothers Harriman siégant sur 2-8, rue Charles de Gaulle, L-2014 Luxembourg au 49, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg où siège State Street Bank Luxembourg S.A. , avec effet au 30 Mars 2012.

Luxembourg, le 30 Avril 2012.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012050878/12.
(120070583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

First Gate Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 105.619.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02.05.12.

Référence de publication: 2012050883/10.
(120070410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Leeward Ventures Partners, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 4, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 140.373.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société, à savoir, Leeward Fund Management Ltd, a transféré en date du 1 

er

 janvier 2012, ses

250 parts sociales à:

- BEOCARE INTERNATIONAL LIMITED, 25/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wanchai, Hong Kong, enregistrée

auprès du Registre de Commerce de Hong-Kong sous le numéro 1142294.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

<i>Pour LEEWARD VENTURES PARTNERS
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2012050970/16.
(120070987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

66576


Document Outline

Comodoro Finance SA

Crèche Mes Premiers Pas

Cullen S.A.

Daniel Schlechter S.A.

D.E.D. Toitures S.à r.l.

Delphi Property Investment S.A.

Delta Lloyd Privilege

Dogi' Investment Strategy S.A.

Dogi' Investment Strategy S.A.

Drill-Tech-Fondations S.A.

Duault &amp; Jacquemin, Sàrl

DuPont Teijin Films Luxembourg S.A.

Dynamic Investment Fund

Eco-Maison S.A.

ECP TTL S.A.

Ednarts Investments S.à r.l.

Egon Re

Energies Van Kasteren S.à r.l.

EP Blafjall S.à r.l.

Eprec Bundesallee S.à r.l.

Espirito Santo Control S.A.

Espirito Santo Financial Group S.A.

Espirito Santo International S.A.

Etablissements Klauner

European General Investments

European Paper Group s. à r.l.

European Real Estate Debt S.à r.l.

European Real S.A.

F&amp;C Fund

F&amp;C Management Luxembourg S.A.

F&amp;C Portfolios Fund

Ferris Investments S.A.

Finance BR S.à r.l.

First Gate Holding S.A.

G.A. - Fund -L

Groupement des Industriels Forains

KH Kaufhaus Beteiligung S.à r.l.

KHM OP Neuhauser Strasse 18 Beteiligung S.à r.l.

Leeward Ventures Partners

Maison 86 Luxembourg S.A.

Modaven S.à r.l.

Pareto Sicav

Princes Exchange (Luxembourg) Holding S.à r.l.

Sat Télécommunications S.A.

SHCO 35 S.à r.l.

Travel Retail S.à r.l.

UBS (Lux) Institutional Sicav II

Verspeet- Bogaert Société en nom collectif.

Vimo &amp; Partner S.A.

Wintergreen S.A.