This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1249
19 mai 2012
SOMMAIRE
A4Investments SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . .
59926
A & AHDP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59945
Aggmore Europe 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
59946
Agregia Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59925
Alchemy Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
59945
Alumni International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
59944
AOS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
59936
atHome Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59945
Atlas Copco Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . .
59929
Aviva Investors Hadrian Capital Fund 1 SI-
CAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59906
BeaTrend S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59944
BKM Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59950
City Rent Car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59941
Colophon - International Magazine Sympo-
sium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59928
Compagnie Financière de l'Union Euro-
péenne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59941
CS Fixed Income SICAV-SIF . . . . . . . . . . . .
59946
DEXIA Asset Management Luxembourg
S.A., en abrégé Dexia AM Luxembourg,
Dexia Asset Management ou Dexia AM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59927
Field Point I-A RE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59929
HTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59930
IXIS CMNA IP Asset Holdings (Luxem-
bourg) S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59934
Lagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59928
LASC Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
59947
LBREP II Europe S.à r.l., SICAR . . . . . . . . .
59935
Logwin AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59926
Logwin AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59945
Logwin AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59929
Lussemburgo Gestioni S.A. . . . . . . . . . . . . .
59946
Luxembourg Financial Group Holding S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59928
Modasia Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59928
Neptune Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59934
Nordic Finance Holding S.A. S.P.F. . . . . . .
59934
ORCHIDEE GESTION S.A., société de
gestion de patrimoine familial . . . . . . . . . .
59940
PPMT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59932
Reading Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
59935
Remacum Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59938
Socego Investments Holding S.A. . . . . . . . .
59930
Stena Forth Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
59935
Teal Corby S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59940
Tinsel Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59940
Ukrainian Agrarian Investments S.A. . . . .
59940
W.06 Lentzweiler « Victus » . . . . . . . . . . . .
59951
W. 06 VIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59951
59905
L
U X E M B O U R G
Aviva Investors Hadrian Capital Fund 1 SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 168.660.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the third day of May,
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
There appeared the following:
Aviva Investors Luxembourg a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, whose registered office
is at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered in the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B-25708 and represented by Elena Toshkova, private employee residing
professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 27 April 2012 and initialled "ne varietur"
which shall remain attached to these minutes in order to be registered with these;
who has requested the undersigned notary to draw up the deed of formation of a Luxembourg public limited company
("société anonyme") which is herewith established as follows (the "Articles"):
Denomination
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form
of a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital - spe-
cialised investment fund ("société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé") under the name
of "Aviva Investors Hadrian Capital Fund 1 SICAV-SIF" (the "Company").
Terms not defined in these Articles shall have the meaning given to them in the private placement memorandum of
the Company from time to time (the "PPM").
Duration
Art. 2. The Company and the sub-funds of the Company (the "Sub-Funds") are established for a limited period which
is the earlier of (a) all shares of the Company (the "Shares"), attributable to a specific Sub-Fund and the Company as a
whole (as applicable), having been fully redeemed (b) thirty five years after the date of the First Closing of the Company
or (c) any of the circumstances referred to in Article 29 and as described in the PPM.
Object
Art. 3. The exclusive object of the Company is to provide the shareholders of the Company (the "Shareholders") with
income through investing in Subordinated Infrastructure Bonds from underlying Infra Companies whether indirectly
through a Funding SPV or directly from an Infra Company situated (and in relation to business operations) in or deriving
the majority of their revenues from the EEA and/or EFTA countries in compliance with the investment objective and
policy as described in the PPM.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 13 February 2007 as amended on specialised
investment funds (the "2007 Law") and the PPM.
Registered office
Art. 4. The registered office of the Company is established in the commune of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
In the event that the board of directors of the Company (the "Board") determines that extraordinary political or
military developments or other events beyond the Company's reasonable control such as force majeure events including
acts of God or acts of terrorism have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad, but within the European Union, until the complete cessation of these
abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, not-
withstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Share capital - Shares
Art. 5. The capital of the Company shall be represented by Shares without par value issued at the price of one Euro
(EUR 1.-).
The subscribed capital is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000) represented by thirty one (31,000) shares with
no nominal value.
Shares shall be issued at a price indicated for each Sub-Fund in the PPM.
59906
L
U X E M B O U R G
The Board is authorised without limitation to allot and issue Shares and fractions thereof, at any time during the
Investment Period in accordance with Article 7 hereof and the PPM, without reserving the existing Shareholders a pre-
ferential right to subscription of the Shares to be issued. The Shares to be issued pursuant to Article 5 hereof may, as
the Board shall determine, be of different classes with such rights as the Board may determine (including those rights
described in the PPM).
Shareholders (other than applicants for Adviser Shares) subscribing for Shares in any Sub-Fund (other than the EIB
Sub-Fund) will be issued with partly paid Shares with full voting rights which when fully paid will equal the value of their
Commitment. Applicants for Adviser Shares will be issued with fully paid up Shares. Applicants for Carry Shares will be
issued with fully paid Carry Shares which will have the rights set out in the Articles and the PPM. Shares may be issued
as partly paid and entitle to partial repayments of the paid-in capital in the circumstances described in the PPM.
At the end of the Investment Period Shareholders will be released from any obligation to make Capital Contributions.
To the extent a Shareholder's Commitments have not been drawn down during the Investment Period, any such Unfunded
Commitments shall be cancelled by the Board at the end of the Investment Period. In order to ensure that, after the
Investment Period, each Shareholder holds a number of Shares that represents the amount of capital it has contributed
to the Company, the Board will effect a consolidation of Shares for each Shareholder who has Unfunded Commitments
which are to be cancelled, so that, after consolidation, each Shareholder will hold a number of fully paid Shares equal to
its Capital Contribution divided by the applicable Issue Price of such Shares. If, prior to the second anniversary of the
First Closing of the Company, a Second Sufficient Closing has not occurred, any Shareholder may within six weeks of
such anniversary date by notice to the Company cancel its Unfunded Commitment. The Fund will consolidate all Shares
held by a Shareholder whose Unfunded Commitment is cancelled in accordance with this provision into such smaller
number as the proportion of its Capital Contribution bears to its total Commitment immediately prior to such cancel-
lation.
Shareholders subscribing for Shares in the EIB Sub-Fund will be issued with Shares with full voting rights, whether fully
paid or partly paid, which when fully drawn will equal the value of their Commitment through an adjustment of the Issue
Price as described in Article 7.
The Board may increase the number of Shares by splitting such Shares into denominations of smaller values (although
by doing so, it shall maintain the voting balance between Shareholders allocated to different Sub-Funds persisting prior
to such action). The Board may also consolidate such Shares (including in the circumstances described in the PPM) and
may adjust the amount unpaid on any Shares so consolidated.
The Board may delegate to any duly authorised Director (as defined below) or officer of the Company or to any other
duly authorised person the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such Shares,
however always remaining within the limits imposed by law.
Such Shares may, as the Board shall determine, be attributable to different Sub-Funds which may be denominated in
different currencies. The proceeds of the issue of the Shares attributable to each Sub-Fund (after the deduction of any
charge, if applicable, which may be charged to them) shall be invested in accordance with the objectives set out in Article
3.
The minimum capital of the Company after a period of twelve (12) months following the registration of the Company
as a specialised investment fund shall be one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Euro.
The Maximum Commitment Threshold for the Company shall be the face value of Commitments for one billion
(1,000,000,000) Shares, as adjusted for the value of Commitments to General Co-Investment Vehicle as described in the
PPM.
The Maximum Commitment Threshold for the Sub-Funds (as applicable) shall be set out in the PPM.
The base currency of the Company is the Euro. The Company shall prepare consolidated accounts in Euro.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall in the
case of a Sub-Fund not denominated in Euro, be notionally converted into Euro in accordance with Article 26 and the
capital shall be the total of the net assets of all the Sub-Funds.
Form of shares
Art. 6. The Board will issue Shares in registered form only.
If the Board resolves that Shareholders may elect to obtain Share certificates and if a Shareholder does not expressly
elect to obtain Share certificates, he will receive in lieu thereof a confirmation of his shareholding. If a Shareholder wishes
to obtain more than one Share certificate, the Board may in its discretion levy a charge on such Shareholder to cover
the corresponding administrative costs incurred.
No charge may be levied upon the issue of a certificate for the balance of a shareholding following a transfer, redemption
or conversion of Shares.
Share certificates shall be signed by either two Directors or one Director and a person duly authorised by the Board
for such purpose. Signatures of the Directors may be either manual or printed or by facsimile. The signature of the
59907
L
U X E M B O U R G
authorised person shall be manual. The Company may issue temporary Share certificates in such form as the Board may
from time to time determine.
Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price per Share as set
forth in Article 7 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive Share certificates or,
subject as aforesaid, a confirmation of his shareholding.
Payments of distributions, if any, will be made to Shareholders at their indicated addresses in the register of Share-
holders (the "Register of Shareholders") or to such other address indicated to the Board in writing.
All Shares issued shall be recorded in the Register of Shareholders, which shall be kept either by the Company or by
one or more designated person(s) appointed by the Board and such Register of Shareholders shall contain the name of
each Shareholder, his residence or elected domicile (and in the case of joint holders the first named joint holder's address
only) so far as notified to the Company and the number of Shares held by him. Each transfer of a Share shall be recorded
in the Register of Shareholders upon payment of such customary fee as shall have been approved by the Board for
registering any other document relating to or affecting the title to any Share.
Shares shall be free from any restriction on the right of transfer (other than as set out in Article 9) and from any lien
in favour of the Company.
A transfer of Shares shall be effective upon the recording of the transfer by the Company in the Register of Shareholders
upon delivery of the certificate or certificates, if any, representing such Shares, to the Company along with other instru-
ments and in accordance with all preconditions of transfer satisfactory to the Board.
Each Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the
Company may be sent. Such address will be recorded in the Register of Shareholders. In the event of joint holders of
Shares (the joint holding of Shares being limited to a maximum of two (2) persons) only one address will be recorded
and any notices will be sent to that address only.
In the event a Shareholder does not indicate such address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered in the Register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be located at the registered
office of the Company, or such other address as may be so entered by the Board from time to time, until such time as
another address has been provided by such Shareholder to the Company. Each Shareholder may, at any time, change his
address as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company sent to its registered
office, or to such other address as may be determined by the Board from time to time.
If a payment made by any subscriber results in the issue of a fraction of a Share, such fraction shall be entered into the
Register of Shareholders. Fractions of Shares shall not carry a vote but shall, to the extent the Company shall determine,
be entitled to a corresponding fraction of any distribution.
Offer price
Art. 7. Shareholders may subscribe for Shares in accordance with the Articles, the PPM and the relevant Subscription
Agreement containing, inter alia, the relevant payment details and other terms of the Offer. Fractions of Shares may be
issued up to three decimal places.
At each Closing, Shareholders may commit to subscribe for Shares by entering into a Subscription Agreement, which,
upon acceptance, will be countersigned by the Board. The Board may in its sole discretion accept Commitments, either
in whole or in part from the prospective (or existing, as the case may be) Shareholder. The Subscription Agreement
includes a commitment to pay all or any part of the applicable Commitment upon request by the Board, as well as certain
representations and confirmations that have to be provided by the Shareholder to the Company.
Duly executed Subscription Agreements must be received by the Company at least five (5) Business Days before the
relevant Closing. Confirmation of accepted Subscription Agreements will be sent to the Shareholders at the address
indicated therein.
Commitments will be drawn down pro rata to Commitments to the relevant Sub-Fund or Sub-Funds subject to any
Further Investment Restrictions of such Sub-Fund from Shareholders as required to make Investments, pay fees and settle
other expenses of the relevant Sub-Fund as well as unallocated expenses of the Company as described in the PPM. Such
Commitments will be contributed towards payment of the Issue Price of a Shareholder's Shares, and the amount paid up
in respect of each Share attributable to the relevant Sub-Fund will be recorded in the Company's accounts.
In the case of the EIB Sub-Fund, Euro Shares will be issued at an initial Issue Price of one Euro (€1) per Share corres-
ponding to the Commitment in Euro to that Sub-Fund. Where the EIB Sub-Fund co-invests alongside the Euro Sub-Fund,
it will draw down funds in Euro and such amounts will be contributed toward additional payment of the partly paid Issue
Price for such Euro Shares.
Notwithstanding the Euro denomination of the EIB Sub-Fund Commitments, where the EIB Sub-Fund co-invests
alongside the Sterling Sub-Fund, drawdowns in relation to the EIB Sub-Fund will be made in Sterling.
In consideration for Capital Contributions paid in Sterling (the "Sterling Contribution") Shareholders in the EIB Sub-
Fund will be issued with a number of new Sterling Shares (the "New Sterling Shares") at an Issue Price of one pound
Sterling (£1) per Share. The Issue Price of the New Sterling Shares shall be fully paid upon issuance of the New Sterling
Shares.
59908
L
U X E M B O U R G
The issuance of the New Sterling Shares shall automatically result in a simultaneous consolidation of the Shares de-
nominated in Euro and issued by the EIB Sub-Fund. Such consolidation shall be made so as to (i) maintain the number of
voting rights held by the EIB Sub-Fund Shareholders and (ii) ensure that the maximum aggregate amount for which the
EIB Sub-Fund Shareholders can be drawn down will equal their Euro Commitment to the EIB Sub-Fund.
As a consequence, upon issuance of New Sterling Shares, (i) an equal number of Euro Shares of the EIB Sub-Fund will
be cancelled with the Capital Contribution paid-in in relation to the Euro Shares so cancelled being deemed paid-in in
relation to the remaining Euro Shares of the EIB Sub-Fund and (ii) the Issue Price of the Euro Shares of EIB Sub-Fund will
be adjusted by reducing the EIB Commitment by the Euro equivalent of the Sterling Contribution converted at an exchange
rate equal to the spot rate as published by the European Central Bank in Frankfurt five Business Days prior to the draw-
down date as notified by EIB to the Fund at the request of the latter, and dividing the resulting number by the number
of Euro Shares of the EIB Sub-Fund in issue further to (i) above.
In no circumstance shall the Fund or its representative be entitled to call any amount on the EIB Sub-Fund Shares,
whether in Euro or in Sterling, through issuance of new Shares or drawdowns on partly paid Shares, in excess of the EIB
Sub-Fund Commitment.
Shareholders will receive notification of a drawdown request in the form of a funding notice, which will be delivered
to Shareholders at least ten (10) Business Days prior to each drawdown (the "Funding Notice"). Drawdowns will be made
in the currency of denomination of the Shares (except as otherwise laid down in the PPM).
The Company may accept at its discretion, in respect of certain Cornerstone Investors (the "Restricted Investors"),
that drawdowns will be made only to such extent that the participation of the Restricted Investor will be less than a
percentage of such Restricted Investors' Commitment or the Total Commitment in order to comply with legal, internal
policy and/or regulatory requirements applicable to the Restricted Investor. In such case, the non-Restricted Investors
will be required to contribute on a pro rata basis the amount that has not been contributed for by the Restricted Investors,
limited to the non-Restricted Investors' Unfunded Commitment. The Company shall provide information to the non-
Restricted Investors regarding the limitation applicable to Restricted Investors upon request.
After the First Closing and until the Fund Final Closing, the Board may (subject as provided in the PPM) in its sole
discretion hold one or more Closings in respect of the Sub-Funds (each of which may be for one or more Sub-Funds)
where the Company accepts Commitments either in whole or in part from Shareholders. Such Subsequent Closings may
occur at any time on or prior to the Fund Final Closing, provided that the Board may conduct no more than three (3)
Closings (or closings of General Co-Investment Vehicles) that require substantial changes to the PPM without the consent
of a SRAC Special Resolution of all Main Sub-Fund SRACs.
Shareholders (other than applicants for Adviser Shares) participating in Subsequent Closings to a Sub-Fund (whether
as new Shareholders or by increasing existing Commitments) will be required to contribute to such SubFund, at such
Subsequent Closing in respect of the partly paid Shares issued to them:
(i) their pro rata share of any Capital Contributions made to or alongside the Sub-Fund for the purpose of making
Investments prior to such Closing (a "Closing Equalisation");
(ii) their pro rata share of the Management Fee as if they had been admitted and subscribed for Shares as at the First
Closing of the Company;
(iii) their pro rata share of the Establishment and Organisational Expenses and any other costs and expenses paid since
the First Closing of the Company, in each case based on the Shareholder's Commitment (or increase to their Commit-
ment) compared to the Total Commitments at the date of such Subsequent Closing;
(iv) an equalisation amount equal to their pro rata share of the income that has accrued (since the First Closing of the
Company or previous Payment Date, as applicable) in respect of the amounts in paragraph (i) above to the Subordinated
Infrastructure Bonds of the relevant Sub-Fund (including any Sub-Fund subject to an Investment Equalisation as a result
of such Closing), as determined by the Fund Manager; and
(v) with respect to the Sterling Index-Linked Sub-Fund only, an equalisation amount equal to their pro rata share of
the indexation that has accrued in respect of each Subordinated Infrastructure Bond since its acquisition (directly or
indirectly) by a Sub-Fund, as determined by the Fund Manager.
Amounts in relation to paragraph (i) and (iii) above which are received from Shareholders participating in a Subsequent
Closing will be allocated to existing Shareholders other than the holders of Adviser Shares pro rata either through: (a)
the Company retaining such amounts for the purpose of making further investments (and in this case, such retained
amounts will not be treated as realisations and shall be netted off against future Capital Contributions of existing Share-
holders); or (b) the Company returning such amounts to existing Shareholders and such amounts shall be capable of being
redrawn in the same currency from such Shareholders as Capital Contributions (and in this case the unpaid amount on
any partly paid Shares will increase by such returned amount). Amounts relating to paragraph (ii) above will be paid to
the Fund Manager and the Investment Adviser as appropriate.
Equalisation amounts in respect of paragraph (iv) and (v) above will be subsequently returned to existing Shareholders
other than the holders of Adviser Shares (i.e. the Shareholders immediately prior to such Subsequent Closing) on the
next Payment Day as an Income Distribution.
59909
L
U X E M B O U R G
During the Investment Period Shares shall be issued at a price of either one (1) pound sterling or one (1) euro depending
on the currency of denomination of the Sub-Fund to which the relevant Share is attributable.
The Board shall declare a Shareholder failing to satisfy any required payment of its Commitment pursuant to a Funding
Notice on or before the tenth Business Day from the date specified in the Funding Notice, to be a Defaulting Shareholder
and suspend the right of that Defaulting Shareholder's Shares to receive any Distributions or payments from the Company.
Such Defaulting Shareholder shall abstain from voting pursuant to the terms of its Subscription Agreement. In addition,
the Board may in its sole discretion whilst acting in the best interests of all other Shareholders (including where a Sha-
reholder does not abstain from voting as described above), impose measures on such Defaulting Shareholder as set out
in more detail in the PPM.
Lost and Damaged certificates
Art. 8. If a Shareholder can prove to the satisfaction of the Board that his Share certificate has been mislaid, mutilated
or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and guarantees,
including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may determine. At
the issuance of the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate
in place of which the new one has been issued shall become void.
The Company may, at its election, charge the Shareholder any exceptional out of pocket expenses incurred in issuing
a duplicate or a new Share certificate in substitution for one mislaid, mutilated, or destroyed.
Restrictions on shareholding and Transfer of shares
Art. 9. Shares may only be subscribed for by Eligible Shareholders investing either for their own account or for and
on behalf of a third party which qualifies as an Eligible Shareholder.
The Board shall have power to impose such restrictions as it, in its sole discretion, may consider necessary to ensure
that no Shares in the Company are subscribed for or held by or on behalf of any person, firm or corporate entity which
is not entitled to subscribe for or hold Shares in the Company or, as the case may be, in a specific Sub-Fund, including
the power to decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Company at any
meeting of Shareholders of the Company and the power to compulsorily redeem such Shares, as described below.
A transfer of Shares (other than Adviser Shares) will be permitted at any time, subject to the following:
(a) the transferee is an Eligible Shareholder and satisfies the eligibility criteria for the Shares of the relevant Sub-Fund;
(b) the transfer of Shares is in accordance with the Articles and the provisions of the PPM;
(c) any outstanding Unfunded Commitment relating to the Shares is transferred with the Shares and any remaining
liability attaching to and/or arising from the transferred Shares by the Shareholder is cancelled (there is no joint and
several liability in respect of the transferring Shareholder). Any such obligations shall be transferred from the Shareholder
to the transferee with the effect of discharging any debt. For the avoidance of doubt, the effect of discharging any debt
does not apply to the transferee;
(d) such transfer does not result in the transferor or the transferee holding less than the Minimum Holding Require-
ment;
(e) such transfer is not to (1) any U.S. Person that is not an "accredited investor", as defined in Regulation D promulgated
under the U.S. Securities Act or (2) any U.S. Person that is not a "qualified purchaser", as defined in Section 2(a)(51) of
the U.S. Investment Company Act;
(f) such transfer is not to any "benefit plan investor," as such term is defined in the regulations of the U.S. Department
of Labor promulgated under ERISA, as modified by Section 3(42) of ERISA;
(g) if the Shares are transferred in Japan or to a resident of Japan, (a) the transferee must be a qualified institutional
investor (tekikaku kikan toshika, as defined in Article 2, Paragraph 3, Item 1 of the Financial Instruments and Exchange
Act of Japan (the "FIEA") and Article 10, Paragraph 1 of the Cabinet Order concerning the Definitions in Article 2 of the
FIEA) and (b) the transferee must enter into a transfer restriction agreement not to transfer the Shares other than the
qualified institutional investors;
(h) both the transferor and transferee representing to the Board that such transfer does not violate applicable securities
laws and/or regulations;
(i) any transferee must agree to be bound by the same terms as the transferor and provide in writing the same
representations and warranties as contained in the Subscription Agreement applicable to the relevant Sub-Fund; and
(j) the prior written consent of the Board is obtained. In particular, prior to providing such consent, the Board shall
determine that the transferee has sufficient assets to satisfy any outstanding Commitments in respect of the Shares being
transferred,
each being a "Condition of Validity" and collectively the "Conditions of Validity".
The prior written consent of the Board shall not be required for a transfer of:
(a) Shares from a nominee of a Shareholder to another nominee of the same Shareholder;
(b) Shares from a nominee of a Shareholder to the Shareholder for which it is acting as a nominee;
(c) Shares from one Related Party to another Related Party of the same group; and/or
59910
L
U X E M B O U R G
(d) Adviser Shares to a Permitted Transferee thereof.
Adviser Shares may only be transferred to a Permitted Transferee until the earlier of (i) the implementation of a
Liquidity Event; or (ii) 15 years from the First Closing.
The Company may restrict or prevent the ownership of Shares by any person, firm or corporate body as further
detailed below. For such purposes, the Company may:
(1) decline to issue or oppose the transfer of any Share where such issue or transfer would or might result in such
Share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding Shares,
(2) at any time require any person whose name is entered in the Register of Shareholders to furnish the Company
with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or
not beneficial ownership of such Shares rests in a person who is precluded from holding Shares,
(3) where it appears to the Board that:
(i) the continued participation of a Shareholder is likely to cause the Company or any Sub-Fund to violate any material
law, regulation, or interpretation of law or would result in the Company or any Sub-Fund or any Shareholder suffering
material taxation or other economic disadvantages which they would not have suffered had such person ceased to be a
Shareholder;
(ii) such Shareholder has materially violated any provision of the PPM or the Articles;
(iii) such Shares have been transferred in breach of any Condition of Validity;
(iv) the Shares were acquired or are being held, directly or indirectly, by or for the account or benefit of any person
in violation of the provisions of the PPM or the Articles;
(v) (1) such redemption would be appropriate to protect the Company or any Sub-Fund from registration of the Shares
under the U.S. Securities Act, as amended, from registration of the Company or any Sub-Fund under the U.S.
Investment Company Act, as amended, or to prevent the assets of the Company from being considered assets of an
employee benefit plan subject to ERISA; or (2) the holding of such Shares would cause material regulatory or tax or other
fiscal disadvantage to the Company or any Sub-Fund; and (vi) such other circumstances exist where continued ownership
would be materially prejudicial to the interests of the Company or any Sub-Fund or any of its Shareholders;
compulsorily redeem from any such Shareholder all or such number of Shares held by such Shareholder as the Board
deems is necessary (in each case the "Redeemable Shares"), in the following manner:
(i) the Company shall serve a notice (the "Redemption Notice") upon the Shareholder holding such Shares or appearing
in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to be redeemed as
aforesaid, the Redemption Price, as defined below, the date of such redemption which must be a Business Day and the
place at which the Redemption Price (as defined below) in respect of such Shares is payable. Any such Redemption Notice
may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such Shareholder
at its last address known to the Company or appearing in the Register of Shareholders at least ten (10) Business Days
before the date of such redemption, which must be a Business Day. Immediately after the close of business on the date
specified in the Redemption Notice, the Shares specified in the Redemption Notice shall be cancelled. The said Shareholder
shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the Share certificate or certificates (if issued) representing
the Shares specified in the Redemption Notice;
(ii) the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall, subject to paragraph (iii) below be redeemed
(the "Redemption Price") shall be at up to the latest Net Asset Value per Share of the relevant Sub-Fund at the time of
redemption as determined in accordance with Article 26 and the PPM reduced by the unamortised portion of capitalised
acquisition costs and any redemption costs. Such redemption costs shall be capped at the lower of (1) 25 per cent. of
the Net Asset Value (per Share) of the Redeemable Shares; and (2) the costs estimated by the Board incurred by the
Company in effecting such redemption.
The cost of such calculation shall be borne by the redeeming Shareholder and shall form part of the redemption costs;
(iii) where a Shareholder is the subject of a compulsory redemption then such Shareholder may request an up-to-date
NAV valuation so that the prevailing Net Asset Value (per Share) may be calculated and which shall be used to determine
the Redemption Price;
(iv) payment of the Redemption Price will be made without interest as soon as practicable having regard to the liquidity
of the Company and the relevant Sub-Fund and the interests of remaining Shareholders after the effective date of the
redemption and will be paid in cash in the currency of denomination of the relevant Sub-Fund to the Shareholder appearing
as the owner thereof and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the
Redemption Notice) for payment to such person but only, in the event that a Share certificate or certificates had been
issued, upon surrender of such Share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice. Upon
deposit of such price as aforesaid no person interested in the Shares specified in such Redemption Notice shall have any
further interest in such Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except
the right of the Shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from
such bank as aforesaid;
59911
L
U X E M B O U R G
(v) any Shares in respect of which a Redemption Notice has been given shall not be entitled to participate in the
Distributions of the relevant Sub-Fund in respect of the period after the date of redemption and the Shareholder of such
Shares shall abstain from voting pursuant to the terms of its Subscription Agreement;
(vi) at the date of redemption, the Shareholder whose Shares are being redeemed shall be bound to deliver to the
Company, or any duly appointed agent thereof, the certificate issued in representation of the relevant Shares for can-
cellation; and
(vii) the exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith;
(4) where Shares have become Redeemable Shares, at the discretion of the Board compulsorily transfer such Redee-
mable Shares (or a portion of such Redeemable Shares) to another Shareholder or to an unaffiliated third party (who is
not a Shareholder, but is an Eligible Shareholder) excluding the Fund Manager, the Investment Adviser, Affiliates of the
Investment Adviser and any of their respective directors or employees, in lieu of or in combination with the redemption
of such Redeemable Shares in the following manner:
(i) the Company shall serve a notice (the "Transfer Notice") upon the Shareholder holding such Shares or appearing
in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be transferred, specifying the Shares to be transferred as
aforesaid and the date of such transfer which must be a Business Day. Any such Transfer Notice may be served upon
such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such Shareholder at its last address
known to or appearing in the Register of Shareholders at least ten (10) Business Days before the date of such transfer,
which must be a Business Day;
(ii) the consideration for Shares to be compulsorily transferred shall be calculated on the same basis as for Redeemable
Shares, as set out above;
(iii) payment of the transfer amount will be made as soon as possible and in any event by the effective date of the
transfer at the latest and will be paid in cash in the currency of denomination of the relevant Sub-Fund to the Shareholder
appearing as the owner thereof and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as
specified in the Transfer Notice) for payment to such person but only, in the event that a Share certificate or certificates
had been issued, upon surrender of such Share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice.
Upon deposit of such price as aforesaid, the Shareholder appearing as the owner of the Shares specified in such Transfer
Notice shall have no further interest in such Shares or any of them, nor claim against the Company or its assets in respect
thereof, except the right of the Shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without
interest) from such bank as aforesaid;
(iv) in respect of the period after the date of transfer, the transferring Shareholder shall not be entitled to participate
in the Distributions of the relevant Sub-Fund relating to any Shares for which a Transfer Notice has been given;
(v) at the date of transfer, the Shareholder whose Shares are being transferred shall be bound to deliver to the
Company, or any duly appointed agent thereof, the certificate issued in representation of the relevant Shares for transfer;
and
(vi) the exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Transfer Notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; or
(5) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Company in accordance with
this Article at any meeting of Shareholders.
Powers of the general meeting of shareholders
Art. 10. Any regularly constituted meeting of the Shareholders shall represent the entire body of Shareholders. Its
resolutions shall be binding upon all Shareholders regardless of the Shares they hold. It shall have the broadest powers
to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
General meetings
Art. 11. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Company, or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting, on the third Tuesday in May of each year at 11:00 a.m. or at such other time as may be prescribed
by the Board and for the first time in 2013.
If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day. The
annual general meeting of Shareholders may be held abroad, but within the European Union if, in the absolute and final
judgement of the Board, exceptional circumstances so require.
Other general meetings of Shareholders may be held at such place within the European Union and time as may be
specified by the Board in the respective notice of meeting.
59912
L
U X E M B O U R G
Special general meetings of Shareholders of any Sub-Fund and any Class may be convened by the Board to decide on
any matters relating exclusively to such one or more Sub-Funds or Classes and/or to a variation of their rights.
Quorum and Votes
Art. 12. Unless otherwise provided herein, the quorum and delays required by the laws of Luxembourg shall govern
the notice for and conduct of the general meetings of Shareholders, including the passing of resolutions.
If the share capital is divided into different Sub-Funds, the rights attached to any Shares of that Sub-Fund (unless
otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that Sub-Fund) may, whether or not the Company is being
wound up, be varied with the sanction of a Shareholder Extraordinary Resolution passed at a separate general meeting
of the Shareholders of that Sub-Fund (or as otherwise required by the prevailing laws of Luxembourg).
The provisions of these Articles relating to general meetings shall apply mutatis mutandis to every such separate
meeting, but so that the quorum for each separate general meeting shall be of the Shareholders of the Company (or with
respect to matters requiring the votes of the Shareholders in a particular Sub-Fund only, the relevant Shareholders of
the Sub-Fund concerned), either present in person or represented by proxy, holding not less than one-half of the issued
Shares of the Company, or of the relevant Sub-Fund, as applicable. There shall be no quorum requirement for any
adjourned general meeting of Shareholders of the Company, or of the relevant Sub-Fund, as applicable.
Each Share is entitled to one vote subject to the limitations imposed by these Articles. A Shareholder may act at any
meeting of Shareholders by appointing another person, which does not need to be a Shareholder, as its proxy in writing.
A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.
The Shareholders are also authorised to cast their vote by ballot papers ("formulaires") expressed in the English
language.
Any ballot paper ("formulaire") shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by
special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or
by fax at the fax number of the registered office of the Company.
Any ballot paper ("formulaire") which does not bear any of the following indications is to be considered void and shall
be disregarded for quorum purposes:
- name and registered office and / or residence of the relevant Shareholder;
- total number of Shares of the Company or the Sub-Fund, as the case may be, held by the relevant Shareholder and,
if applicable, number of shares of each Class held by the relevant shareholder in the Sub-Fund;
- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant Shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares
for which the relevant Shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorised representative of the relevant shareholder.
Any ballot paper (formulaire") shall be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on the
day on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the general meeting
of Shareholders.
Any ballot paper (formulaire") received by the Company after such deadline shall be disregarded for quorum purposes.
A ballot paper ("formulaire") shall be deemed to have been received:
(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an
internationally recognised courier company: at the time of delivery; or
(b) if delivered by fax: at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the trans-
mission receipt.
A Defaulting Shareholder and a Conflicted Shareholder must, pursuant to the terms of its Subscription Agreement,
abstain from participating in the Resolutions.
The Board may determine additional conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to participate at any
meeting of Shareholders.
Except for:
(1) decisions at a meeting of Shareholders duly convened in respect of: (a) amendments to the Articles, the PPM, the
Fund Management Agreement and/or the Investment Advisory Agreement which have a negative effect on the Sharehol-
ders or change the terms of the Company in material way; and (b) amendments to the PPM during the Initial Period with
respect to Satisfactory Terms as described in the PPM, will require the unanimous approval of the Shareholders in respect
of (a) and the unanimous approval of the Cornerstone Investors in respect of (b);
(2) decisions at a meeting of Shareholders duly convened in respect of: (a) the possibility to diverge from the rules set
forth in the PPM for the calculation and payment of the Management Fees; (b) the possibility for the Preferred Returns
to be set otherwise than in accordance with these rules set forth in the PPM; (c) the possibility to diverge from the rules
as set forth in the PPM for the calculation and payment of Carried Interest; (d) an amendment to the valuation metho-
dology; (e) decisions varying the rights of Shares; (f) decisions relating to amalgamation of Sub-Funds as described in Article
24; (g) decisions to appoint a replacement fund manager and investment adviser; (h) terminating the Suspension Period;
59913
L
U X E M B O U R G
(i) decision to continue the Investment Period after a 12 month Suspension Period as described in the PPM; and (j) a
decision to approve the additional or replacement member of the Investment Committee if the replacement member is
not a Key Person during the Investment Period, which shall all be passed by way of a Shareholder Extraordinary Resolution;
(3) decisions at a meeting of Shareholders duly convened in respect of: (a) the extension of the Investment Period; (b)
the permission for the Fund Manager and the Investment Adviser (and their respective Affiliates) to establish, manage or
advise Successor Funds (including Sub-Funds) prior to the date stated in the PPM; and (c) the reduction of Sub-Fund size
in relation to switching and approval of Switching Requests as described in Article 24, which shall all be passed by way of
a Shareholder Special Resolution; and
(4) as otherwise required by the prevailing laws of Luxembourg or the terms of the PPM,
resolutions or other decisions at a meeting of Shareholders duly convened will be passed by way of a Shareholder
Ordinary Resolution.
Convening notice
Art. 13. Shareholders shall meet upon call by the Board, pursuant to a notice setting forth the agenda, sent at least
ten (10) Business Days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address recorded in the Register
of Shareholders.
Directors
Art. 14. The Company shall be managed by the Board composed of five (5) natural persons. The Board shall at all times
be composed of one (1) Director who shall have been proposed by the Investment Adviser and one (1) Director who
shall have been proposed by the Fund Manager supported by a Shareholder Ordinary Resolution and shall be an inde-
pendent infrastructure finance expert and further three (3) Directors, one of whom shall not be an employee of a Related
Party, who shall have been proposed by the Fund Manager. All Directors shall have the relevant skills, expertise and
qualifications to serve on a fund of this nature and investment focus.
The Directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting (subject to the quorum and majority
requirements provided by the laws of Luxembourg) for a period not exceeding six (6) years and until their successors
are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and replaced at any
time by resolution adopted by the Shareholders in accordance with Luxembourg law. At least two (2) of the Directors
shall be based in Luxembourg.
In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and may elect a person as a Director to fill such vacancy until the next relevant meeting of Shareholders.
Proceedings of directors
Art. 15. The Board shall choose from among its members a chairperson, and may choose from among its members
one or more vice-chairpersons. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders. The Board shall meet upon a call by any
two (2) Directors, at the place indicated in the notice of meeting. At any such meeting, each Director shall have one vote.
The chairperson shall preside at all meetings of Shareholders and of the Board.
In case a chairperson is not appointed or in his absence, the Shareholders or the Board may vote to appoint any person
as chairperson pro tempore. The chairperson shall have no casting vote.
Notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours in advance of the
time set for such meeting in writing or by electronic mail or fax, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in
writing or by cable, telegram, telex, electronic mail or fax of such number of Directors required for a quorate meeting
as further provided in this Article. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex, electronic mail
or fax another Director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram, telex, electronic
mail or fax.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their
individual signature, except as specifically permitted by resolution of the Board.
Subject to the eighth paragraph of this Article, a meeting of the Board shall be quorate if at least three (3) Directors
who are eligible to vote are either present (which may be by way of a telephone conference call or video conference call)
or represented at a meeting of the Board.
Decisions of the Board will be taken by a Directors' Resolution (being 75 per cent. of the Directors (entitled to vote)
present or represented at such meeting). In case of a conflict of interest as provided for in Article 18 of these Articles,
the Board can validly deliberate and vote notwithstanding the non-fulfilment of the quorum conditions stated herein. In
such a case, decisions will be taken by a majority of the votes cast.
59914
L
U X E M B O U R G
Written resolutions of the Board can be validly taken if approved in writing and signed by all the Directors. Such
approval may be given in a single or in several separate documents sent by mail, fax, electronic mail, telegram or telex.
These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at meetings of the Board physically held.
The Board from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, a secretary, and any
assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management
of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be Directors or
Shareholders. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given
them by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board, acting under supervision of the Board. The Board may also delegate certain of its powers,
authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a Director or not) as it
thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are Directors and that no meeting of the committee
shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those
present are Directors.
Minutes of board meetings
Art. 16. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairperson pro tempore who presided over
such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by any two (2) Directors.
Determination of investment policies
Art. 17. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the
Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of Shareholders
may be exercised by the Board.
The Board has, in particular, power to determine the corporate policy as further set down in the PPM.
In the determination and implementation of the investment policy, the Board may cause the assets of the Company
to be invested directly or indirectly through one or more wholly owned subsidiary(ies) in accordance with the provisions
of the 2007 Law, as described in the PPM.
Directors' interest
Art. 18. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or is
a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm but subject as hereinafter
provided, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other
business.
In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote
on any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of Shareholders as prescribed by Article 57 of the law of 10th August 1915, as amended (the
"1915 Law").
Indemnity
Art. 19. The Company shall indemnify any Director or officer, and his/her heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other company of
which the Company is a shareholder or creditor (including any Holdco) and against which he is not entitled to be in-
demnified. Such person shall be so indemnified in all circumstances, except in relation to matters as to which he shall be
finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for fraud, bad faith, gross negligence or wilful misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty.
The Company shall indemnify members of the SRAC and any Shareholder whom such member of the SRAC represents
in respect of acts as a member of the SRAC (an "Indemnified SRAC Person") against all liabilities, losses, damages, costs
and expenses, including reasonable legal fees, incurred or threatened by reason of their activities in relation to the Fund
to the extent that such liabilities, losses, damages, costs and expenses do not arise as a result of fraud, gross negligence
or wilful misconduct by such Indemnified SRAC Person.
59915
L
U X E M B O U R G
Administration
Art. 20. The Company will be bound by the joint signatures of any two (2) Directors or by the signature of any Director
or officer to whom the relevant authority has been delegated by the Board.
Shareholder representative advisory committee
Art. 21. Unless otherwise set out in the PPM, a Shareholder Representative Advisory Committee ("SRAC") shall be
created for each Sub-Fund except the EIB SubFund in order to carry out the functions described in the PPM.
The SRAC for each of the Sterling Sub-Fund, the Euro Sub-Fund and the Sterling Index-Linked Sub-Fund will comprise
a maximum of nine members ("SRAC Membership Limit") including:
(i) one representative from each Cornerstone Investor, subject to the Board's ability to suspend or remove such
representative if the relevant Cornerstone Investor is a Defaulting Shareholder;
(ii) one representative of each Shareholder other than a Cornerstone Investor with a Commitment to the Company
in excess of one hundred million (100,000,000) Shares;
(iii) subject to SRAC Membership Limit and (i) and (ii) above and (iv) below, one representative appointed by each of
the largest five Shareholders (by Commitment to the relevant Sub-Fund) which are not Cornerstone Investors and which
do not qualify for SRAC membership under (ii) above, with such Shareholders being determined upon Final Closing of
each Sub-Fund; and,
(iv) one representative appointed (with any vote on the basis of each Shareholder's Commitments to the Sub-Fund,
including Commitments to a related Co-Investment Sub-Fund) by all Shareholders of the relevant Sub-Fund, other than
the Cornerstone Investors, a Shareholder who has appointed a representative to the SRAC in accordance with (ii) or
(iii) above, or a Defaulting Shareholder.
The composition of each SRAC for each Co-Investment Sub-Fund is set out in the relevant appendices of the PPM.
Each Shareholder entitled to appoint a SRAC member in accordance with (i) to (iv) above shall do so in writing by
sending notice to the Company.
Proceedings of the shareholder representative advisory committee
Art. 22. The Fund Manager will, on behalf of the Company, establish the policies and procedures for the operation of
the SRACs, which shall be presented at the first meeting of the relevant SRAC for approval by a SRAC Special Resolution.
Each member of the SRAC shall have one vote, provided that any SRAC member who has a conflict of interest shall not
be entitled to vote on a matter related to the conflict.
Each SRAC may meet by telephone conference or such other manner as the SRAC may determine.
The quorum for a meeting of a SRAC shall be the presence or the representation of the majority of the members of
such SRAC.
A telephone conference during which a quorum of the SRAC members as above-mentioned participates in the call
shall be valid as a meeting of a SRAC provided written minutes reflecting the decisions adopted during such telephone
conference signed by all the SRAC members attending such telephone conference call are made.
A meeting of the SRAC may be called by the Fund Manager and/or any SRAC member by written notice to be given
to all relevant SRAC members at least ten (10) Business Days prior to the date set for such meeting, except in circums-
tances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This
notice may be waived by unanimous consent in writing, by e-mail or any other similar means of communication. Separate
notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the relevant SRAC
members. A written resolution in substitution for a meeting that is signed by all the relevant SRAC members shall be
effective as a decision of the SRAC.
The Board shall forward to the relevant SRAC all relevant information within a period of time which is reasonably
sufficient in the view of the Board (being no less than five (5) Business Days unless the Board reasonably considers greater
urgency is required) to permit the SRAC to make an informed decision on the relevant matter prescribed above. In
addition, the Board shall respond to a reasonable request for information made by a SRAC member to assist such member
to discharge its functions.
The minutes of a meeting of the SRAC shall be approved at the next following meeting of the SRAC (or earlier by
circular resolution) and shall be sent to all Shareholders at the address notified to the Board in writing.
The SRAC members shall be reimbursed by the Company for out-of-pocket expenses and receive no remuneration.
The Board may suspend and/or remove a member from the SRAC where:
(i) the SRAC member's respective Shareholder ceases to be a Shareholder or is a Defaulting Shareholder; or
(ii) the SRAC member's respective Shareholder ceases to satisfy any of the qualification criteria set out above; or
(iii) such SRAC member has acted fraudulently, recklessly, negligently, in bad faith or with wilful misconduct or is
regularly and persistently absent from meetings despite having been duly notified.
Any suspension of a SRAC member shall continue until the event causing such suspension has been (if capable of
remedy) remedied.
59916
L
U X E M B O U R G
The term of office for each member shall be the term of the relevant Sub-Fund, unless replaced by notice given by the
relevant Shareholder. Other than as detailed below or in the PPM, any request, proposal or approval of each SRAC in
respect of the below shall be by way of a SRAC Ordinary Resolution. The purpose of each SRAC will be:
(i) to receive quarterly reports and presentations from the Fund Manager and the Investment Adviser (which shall
during the Investment Period present a summary of investment opportunities available to the Company and the reasons
deals previously on such list have been removed);
(ii) to attend ad hoc meetings to approve or reject recommendations (and to communicate the same to the Board )
made by the Fund Manager on:
1. any decisions regarding potential conflicts of interest and/or related party transactions of the relevant Sub-Fund;
and
2. any other decision presented to the SRAC with respect to the relevant Sub-Fund;
(iii) to approve any increase in ongoing surveillance and reporting fee due to the Investment Adviser, in respect of
providing an information service to a Bond Trustee (for a Subordinated Infrastructure Bond held by the relevant Sub-
Fund), above the maximum levels set out in the PPM;
(iv) to approve any transactions to be entered into between the Company and companies of the Aviva Group or HW
Group or Related Parties;
(v) to exercise their right to object to proposed Investments during the Initial Period;
(vi) any such other matter subject to SRAC Ordinary Resolution in the PPM.
Certain requests, proposals or approvals of the relevant SRAC shall be by way of a SRAC Special Resolution. Such
matters are:
(i) approving the temporary or permanent amendment of the Further Investment Objectives and/or the Further In-
vestment Restrictions;
(ii) approving the extension of the Fund Final Closing;
(iii) approving the terms of a Co-Investment Sub-Fund established by the Board (provided that for such approval the
SRAC Special Resolution of each SRAC of a Main Sub-Fund alongside whom such Co-Investment Sub-Fund may purchase
investments is required);
(iv) conducting more than three Subsequent Closings requiring substantial changes to the PPM (provided that the
approval of a SRAC Special Resolution of each Main Sub-Fund is required);
(v) the level of aggregate Commitments that may be (directly or indirectly) invested in any single underlying Infra
Company by a Main Sub-Fund to more than 20 per cent. (but to no more than 25 per cent.) in respect of one or more
specific Investments;
(vi) the level of aggregate Commitments in respect of each primary payment counter-party which does not have
sovereign status to each underlying Infra Company by a Main Sub-Fund to more than 20 per cent. (but to no more than
25 per cent) in respect of one or more specific investments;
(vii)to require the Board to appoint a named, suitably qualified and independent third party to undertake a valuation
of any asset of the relevant Sub-Fund;
(viii) any changes to the distribution policy of the relevant Sub-Fund;
(ix) any extension of the period to implement a Liquidity Event;
(x) approving that a divestment takes place during a Suspension Period;
(xi) hedging with a counterpart with a rating of less than A3; and
(xii)approval of SRAC policies and procedures; and
(xiii) any such other matter subject to SRAC Special Resolution.
Each SRAC shall also be available for consultation by the Board and Fund Manager and may make suggestion to, and
requests of, the Board or Fund Manager with respect to the management of the Company. However, other than decisions
relating to any of the matters set out above, neither the Board nor the Fund Manager is bound by such suggestions or
requests nor obligated to take direction from the SRAC. More specifically, the Company and the Fund Manager may need
to take actions in due course to comply with the EU Directive on Alternative Investment Fund Managers (the "AIFM
Directive").
The Fund Manager shall inform and consult with the Shareholders prior to the implementation of any relevant required
actions or changes to the Fund documentation. Any increase of the expenses or costs to be borne by the Fund as a
consequence of such changes and compliance with the AIFM Directive over any previously agreed amount of expenses
or costs shall be consulted with each SRAC. If any member of a SRAC has any objections in this respects it shall provide
written reasons to the Board and a committee comprising the independent members of the Board shall consider those
reasons and make a final determination.
No member of a SRAC, nor any Shareholder appointing any such member, shall owe a fiduciary duty to the Company
or to any other Shareholder in connection with its activities as a SRAC member.
59917
L
U X E M B O U R G
Auditor
Art. 23. The Fund Manager shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" who shall carry out the duties prescribed by
the 2007 Law. Any re-appointment or proposed change of the "réviseur d'entreprises agree" shall be approved by a
Shareholder Ordinary Resolution.
Redemption and Conversion of shares, Switching of unfunded commitment and
Amalgamation of sub-fund(s)
Art. 24. Shares can not be redeemed at the option of Shareholders except in accordance with the PPM.
Notwithstanding the above, the Company's initial Share capital subscribed at incorporation will be redeemed by the
Company at the first drawdown of the Company.
The Company has the power to fully and/or partially redeem its own Shares at any time within the sole limitations set
forth by law, the PPM and these Articles.
After the Investment Period, Distributions of Capital will be by means of a redemption of a Shareholder's Shares as
further described in Article 28 hereafter.
Redemptions will be made at the latest available Net Asset Value per Share (taking into account actual realisation
prices of Investments and realisation expenses).
Conversion of Shares from a given Sub-Fund into Shares of another Sub-Fund will be accepted and operated in ac-
cordance with the provisions as determined from time to time by the Board.
Each Cornerstone Investor other than EIB, for whom switching is not necessary will be entitled to switch Unfunded
Commitments between Main Sub-Funds without fee or other penalty:
(i) at any Subsequent Closing, provided that the aggregate amount by which the relevant Cornerstone Investor requests
a reduction in its respective Unfunded Commitments in respect of the relevant Main Sub-Fund (each such request being
a "Switching Request") does not exceed the aggregate amount of new Commitments made in respect of that Main Sub-
Fund at that Subsequent Closing (such amount being the "Available Switching Capacity"). If the aggregate amount of
Switching Requests exceeds the amount of Available Switching Capacity then each such Switching Request shall be satisfied
(so as to match in aggregate the amount of the Available Switching Capacity) in an amount equal to (i) the lower of (a)
the actual amount of the relevant Switching Request and (b) the same proportion of the Available Switching Capacity that
the Commitment of the relevant Cornerstone Investor represents of the aggregate Commitments of all Cornerstone
Investors to the relevant Sub-Fund making Switching Requests (each such proportionate amount being the relevant Cor-
nerstone Investor's "Commitment Entitlement"), with (ii) any remaining balance of Available Switching Capacity then being
allocated among those Cornerstone Investors having made Switching Requests in excess of their respective Commitment
Entitlement pro rata to the amount of the Switching Requests so made by such Cornerstone Investors; and/ or
(ii) at any time if Shareholders in the relevant Main Sub-Fund vote by Shareholder Special Resolution to approve the
reduction.
With respect to a switch in connection with (i) above on a Subsequent Closing:
(a) the Fund Manager shall provide notice to Cornerstone Investors no less than 65 days prior to the date on which
a the switch is proposed to take effect (the "Closing Switch Date");
(b) a Cornerstone Investor must provide any Switching Request to the Fund Manager no less than 30 days (or such
shorter period as agreed by the Company) prior to the Closing Switch Date;
(c) the Fund Manager shall calculate the available switching amount for each Cornerstone Investor based on all Switching
Requests received (the "Available Switching Amount") and communicate the applicable Available Switching Amount to
each Cornerstone Investor who has provided a Switching Request; and
(d) each Cornerstone Investor who has provided a Switching Request may reconfirm its Switching Request to the
Company no less than 15 days prior to the Closing Switch Date up to a maximum of the Available Switching Amount.
Once confirmed, such Switching Request is irrevocable.
With respect to a switch in connection with (ii) above occurring at other times following a Shareholder Special Re-
solution:
(a) a Cornerstone Investor may send the Fund Manager its Switching Request;
(b) on receipt of the first Switching Request, the Fund Manager shall notify all other Cornerstone Investors of the
initiating Cornerstone Investor's Switching Request;
(c) Cornerstone Investors shall have 15 days from receipt of such notification in (b) above to provide the Fund Manager
with any additional Switching Requests;
(d) following such 15 days, the Company shall call a meeting of the Shareholders of the relevant Sub-Fund to approve
all Switching Requests by Shareholder Special Resolution. All such Switching Requests will be effected as at the date on
which such Shareholder Special Resolution is passed (the "SH Approved Switch Date").
A Switching Request provided to the Fund Manager in relation to (ii) above shall be irrevocable from the time that the
Shareholder Special Resolution in (d) above is passed, but may be withdrawn at any time prior to the meeting.
On the Closing Switch Date or the SH Approved Switch Date:
59918
L
U X E M B O U R G
(iii) the Commitment of a Cornerstone Investor (a "Switching Shareholder") some or all of whose Unfunded Com-
mitment is to be switched from investing in or alongside one Main Sub-Fund (the "First Sub-Fund") to another (the "Second
Sub-Fund") will be adjusted so that it is reduced in relation to the First Sub-Fund, and increased in relation to the Second
Sub-Fund, by the amount determined under paragraph (i) or (ii) above (the "Switched Amount");
(iv) the number of Shares held by a Switching Shareholder in respect of a First Sub-Fund will be consolidated into such
number as would have been issued to that Switching Shareholder had its original Commitment to invest in or along side
the First Sub-Fund been equal to its reduced Commitment to such Main Sub-Fund; and
(v) the amounts paid up on all Shares in each First Sub-Fund will be equalised so that following such equalisation each
Shareholder in that First Sub-Fund will have been drawn down pro rata to its continuing Commitment to invest in or
along side that First Sub-Fund. In order to effect such equalisation, the Company will return to each Switching Shareholder
the amount of its Capital Contributions necessary to ensure it is so drawn down. If the currency of the First Sub-Fund
is different to the currency of the Second Sub-Fund, the Switched Amount will be converted into the currency of the
Second Sub-Fund at the spot rate as published by the European Central Bank in Frankfurt on or about the date the
equalisation is effected or, if no such rate is published on that date, on the preceding date on which such rate is published.
Such returned amounts shall be capable of being redrawn from such Switching Shareholders as Capital Contributions
(and in this case the unpaid amount on its partly paid Shares in such Sub-Fund will increase by such returned amount).
The Company, will at least 10 Business Days prior to the Switch Date, issue a Funding Notice to each Investor who
will be required to make Capital Contributions to a First Sub-fund in order to effect the equalisation referred to in
paragraph (iii) above.
The Board will reply promptly to any request by a Shareholder for information regarding any Sub-Fund in relation to
any Switching Request or other switch of Unfunded Commitments. For the avoidance of doubt, the Board shall not be
permitted to agree to a reduction or re-allocation of Commitments of any other Shareholder unless such reduction or
re-allocation has been authorised by Shareholder Special Resolution of the Sub-Fund in respect of which a reduction is
proposed to be made.
Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of a redemption will be deposited
with the Custodian for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the Caisse
de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.
All fully redeemed Shares shall be cancelled.
An amalgamation of Sub-Funds within the Company may be decided upon by a general meeting of the Shareholders
of the Sub-Funds concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such an
amalgamation by Shareholder Extraordinary Resolution.
Valuations and Suspension of valuations
Art. 25. The Net Asset Value per Share attributable to each relevant Sub-Fund shall be determined from time to time,
but in no instance less than every six months, as the Board may determine as outlined in the PPM. Each such day shall be
a "Valuation Day", provided that each Valuation Day shall be a Business Day.
Additional provisions may be contained in the PPM.
The Directors must without delay suspend the calculation of the Net Asset Value per Share and hence the redemption
of Shares of any Sub-Fund if it appears to the Directors that due to "exceptional circumstances" it is in the interest of the
Shareholders to do so. "Exceptional circumstances" notably include:
(i) if a stock exchange or market which forms the basis for the valuation of a substantial portion of the assets of the
Sub-Fund is closed other than for or during holidays, or when trading on such a stock exchange is restricted or suspended;
(ii) during any period when, as a result of the political, economical, military, terrorist or monetary events or any
circumstance outside the control, responsibility and power of the Directors, or the existence of any state of affairs in the
infrastructure sector, disposal of the assets of the Company is not reasonably practicable without materially and adversely
affecting and prejudicing the interests of Shareholders or if a fair price cannot be determined for the assets of the Company;
(iii) in the case of a breakdown in the means of communication normally used for valuing any asset of the any Sub-
Fund which is material, or, if for any reason the value of any asset of the relevant Sub-Fund which is material in relation
to the Net Asset Value may not be determined as rapidly and accurately as required;
(iv) if, owing to limitations on foreign exchange transactions or other transfers of assets, business transactions become
impracticable for the relevant Sub-Fund, or where it can be objectively demonstrated that purchases and sales of assets
cannot be effected at the normal rates;
(v) circumstances which are beyond the control of the Directors make it impracticable or not in the best interests of
the Shareholders of the relevant Sub-Fund to continue trading the assets of the Company attributable to such Sub-Fund;
(vi) in the case of the Company's liquidation or in the case a notice of termination has been issued in connection with
the liquidation of the Company a Sub-Fund or a Class;
(vii) where there is a material change to the general economical situation or in the condition of the relevant Investment
or of the infrastructure sector generally and it is not possible to make an adjustment to the valuation to reflect this in
59919
L
U X E M B O U R G
the Net Asset Value calculation, the Net Asset Value calculation shall be suspended until the valuation has been adjusted
by the Fund Valuer;
(viii) when the value of a substantial part of the assets of any consolidated subsidiary of the Company may not be
determined accurately; or
(ix) when for any other reason the prices of any assets and/or where the applicable techniques used to create exposure
to assets which do not belong to the Company, cannot promptly or accurately be ascertained.
The suspension shall cease as soon as practicable after the "exceptional circumstance" has ceased.
The suspension of a specific Sub-Fund or Class does not have any effect on the calculation of Net Asset Value and the
issue and redemption of the Shares of any other Sub-Fund or Class.
Determination of net asset value
Art. 26. The Company and each Sub-Fund have a Net Asset Value determined in accordance with International Ac-
counting Standards (IAS) and Luxembourg law, subject to adjustments for deferred tax liabilities, formation expenses and
acquisition costs and any other adjustments required to ensure that Shareholders are treated fairly and in accordance
with these Articles. The reference currency for the Net Asset Value of the Company is the Euro. The reference currency
of each Sub-Fund is detailed in the PPM.
Calculation of the Net Asset Value
The Net Asset Value of the Company and each Sub-Fund shall be calculated in good faith in Luxembourg on each
Valuation Day.
The Net Asset Value per Share shall be calculated by dividing (i) the net assets of the Company attributable to each
Sub-Fund, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such Sub-Fund, on any such
Valuation Day, by (ii) the number of Shares in the relevant Sub-Fund then outstanding, in accordance with the valuation
rules set forth below.
In determining the NAV of the Company and/or each Sub-Fund, the following shall be taken into account: (i) the
Investment valuations received from the Fund Valuer; (ii) any other assets of the Company (for example cash deposits),
and (iii) all costs of the Company (including an accrual for Carried Interest).
The accounts of the subsidiaries in which the Company has a majority interest will be consolidated with the accounts
of the Company and accordingly the underlying assets and liabilities will be valued in accordance with the valuation rules
described below. For the purpose of Net Asset Value calculation, assets and liabilities shall comprise all the assets and
liabilities that are recognised in the consolidated balance sheet of the Company at the end of the relevant period in
accordance with IAS and Luxembourg GAAP as adjusted as described above, and include the following:
The assets of the Company shall include:
(a) the Investments;
(b) all other investments registered in the name of the Company or any of its intermediary holding companies;
(c) all cash in hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
(d) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of properties, property rights,
securities or any other assets sold but not delivered);
(e) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights,
warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company;
(f) all stock dividends, cash dividends and cash payments receivable by the Company to the extent information thereon
is reasonably available to the Company or the Custodian;
(g) all interest accrued on Investments, any income accrued on other investments or interest accrued on other interest-
bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the value attributed
to such asset;
(h) the formation expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing Shares of the Company,
insofar as the same have not been written off; and
(i) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of the assets of the Company will be determined as follows:
(a) each Investment shall be valued under International Accounting Standards at amortised cost;
(b) in undertaking such calculation, if:
(i) the Fund Manager is aware of circumstances which, if un-remedied are likely to result in the Company not receiving
Income Receipts or Capital Receipts due in respect of an Investment when due, or
(ii) Income Receipts or Capital Receipts due in respect of a Subordinated Infrastructure Bond have not been paid within
30 days of their due date, an assessment of appropriate write down will be conducted for such Subordinated Infrastructure
Bond (and the forecast Income Receipts and Capital Receipts appropriately reduced or rescheduled).
The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(a) all borrowings, bills and other amounts due;
59920
L
U X E M B O U R G
(b) all such fees and expenses as are detailed in the PPM and all administrative expenses due or accrued including but
not limited to the costs of its constitution and registration with regulatory authorities, as well as legal, audit, management,
performance, custodial, paying agency and corporate and central administration agency fees and expenses, the costs of
legal publications, prospectuses, financial reports and other documents made available to Shareholders, translation ex-
penses and generally any other expenses arising from the administration of the Company, unless otherwise provided in
the PPM;
(c) all known liabilities, due or not yet due including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of all dividends declared by the Company for which no coupons have been presented and
which therefore remain unpaid until the day these dividends revert to the Company by prescription;
(d) any appropriate amount set aside for taxes due on the date of the valuation and any other provisions of reserves
authorised and approved by the Company; and
(e) any other liabilities of the Company of whatever kind and nature towards third parties reflected in accordance with
Luxembourg law.
In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company
and may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount rateably
for yearly or other periods. In addition, the Company may accrue in its account as reserves any amounts which, in the
Board's reasonable discretion, should be retained for the purposes of a reserve for expenses, claims or other purposes
in connection with investments or matters in respect of which the Company is committed to investment including an
appropriate provision for current taxes payable in the future based on the capital and income, as determined from time
to time by the Board, as well as such amount (if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in respect
of any risks or liabilities of the Company (i.e. liabilities for past events which are definite as to their nature and are certain
or probable to occur and can be measured with reasonable accuracy, which might arise during the life of the Company
and may include potential liabilities arising from any disputes (such as with a buyer or a tax authority) or as a result of
any warranty or other similar arrangement arising as a result of a disposal of an investment).
The assets and liabilities shall be allocated as follows:
(a) the proceeds to be received from the issue of Shares of any Sub-Fund shall be applied in the books of the Company
to that Sub-Fund and shall increase the proportion of the net assets attributable to that Sub-Fund;
(b) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds pro rata to their respective Net Asset Values (prior
to such attribution) or in such other manner as determined by the Central Administrative Agent acting in good faith,
provided that (i) where assets of several Sub-Funds are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool
of assets by an agent of the Company, the respective right of each Sub-Fund shall correspond to the prorated portion
resulting from the contribution of the relevant Sub-Fund to the relevant account or pool, and (ii) such right shall vary in
accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the Sub-Fund, as described in the PPM; and
(c) upon the payment of distributions to the Shareholders of any Sub-Fund, the Net Asset Value of such Sub-Fund shall
be reduced by the amount of such distributions.
For the purposes of this Article 26:
(a) Shares to be redeemed by the Company shall be treated as existing and shall be taken into account until the date
fixed for redemption, and from such time and until paid by the Company, the redemption price thereof shall be deemed
to be a liability of the Company;
(b) Shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the Board on
the Valuation Day on which such valuation is made and, from such time and until received by the Company, the subscription
price therefore shall be deemed to be an asset of the Company; and
(c) where on any Valuation Day the Company has contracted/committed to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company; or
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company,
provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Day, then its value shall be estimated by the Company.
The Net Asset Value as of any Valuation Day will be made available to Shareholders at the registered office of the
Company as soon as it is finalised and, in any event, within 120 calendar days following the relevant Valuation Day. In
addition, Shareholders will receive, with respect to each Quarterly Period, a Sub-Fund Fact Sheet within 45 Business Days
of the end of each Quarterly Period setting out (amongst other things, as more fully described in the PPM) the latest
calculated Net Asset Value and the related Net Asset Value (per Share) for the relevant Sub-Fund.
All assets denominated in a currency other than the reference currency of the respective Sub-Fund shall be converted
at the conversion rate between the reference currency and the currency of denomination as at the Valuation Day as
applicable under IAS or IFRS, as the case may be.
59921
L
U X E M B O U R G
For the avoidance of doubt, these provisions are rules for determining the Net Asset Value per Share and are not
intended to affect the treatment for accounting or legal purposes of the assets and liabilities of the Company or any Shares
issued by the Company. Unfunded Commitments will not be considered as assets of the Company for the purpose of
the calculation of the Net Asset Value.
Financial year
Art. 27. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate
on the last day of December of the same year, except in respect of the first accounting year which will start on the date
of the First Closing of the Company and end on 31 December 2012.
The accounts of the Company shall be expressed in Euro. The annual accounts, including the balance sheet and profit
and loss account, the Directors' report and the notice of the annual general meeting will be sent to Shareholders and/or
published and made available not less than fifteen (15) days prior to each annual general meeting.
Distribution of income and Capital
Art. 28. The general meeting of Shareholders in respect of each Sub-Fund shall, upon the proposal of the Board (if
any), subject to any interim distributions having been declared or paid, decide on distributions from time to time.
Distributions may, in respect of any Sub-Fund, include an allocation from a distribution equalisation account which may
be maintained in respect of any such Sub-Fund.
Interim distributions may, at the discretion of the Board, be declared subject to such further conditions as set forth
by law, and be paid out of the net assets of the relevant Sub-Fund.
The Company shall only make Distributions of Income or Distributions of Capital in cash. The Company will have the
ability to make distributions in-kind only to the extent that: (i) it has received the prior consent of the Shareholder to
which it is intending to make the distribution; (ii) it is in the best interest and subject to the equal treatment of all
Shareholders in the relevant Sub-Funds; and (iii) it is made in compliance with applicable laws.
Each Shareholder shall be sent a statement on each occasion a distribution is payable providing details of the calculation
of the distribution, including any Sub-Fund Expenses (collectively "Sub-Fund Expenses").
(1) Distributions of Income
Subject as described below, all income received by a Sub-Fund less expenses will be distributed semi-annually on each
Payment Date and on such other additional dates as the Board may determine, save where the Board, on the recom-
mendation of the Fund Manager, determines that it is in the interest of a Sub-Fund subject to the provisions of the PPM
to retain Income Receipts within the Sub-Fund. Income which is capable of distribution will be allocated and shared
between the Shareholders and the Carry Recipient as described in the PPM.
Income which is capable of distribution will comprise all income receipts and deposit receipts received by the relevant
Sub-Fund since the previous Payment Date and any other available cash determined by the Board to be income capable
of distribution ("Income Receipts") less:
(i) all fees and expenses (including corporate and operating expenses, annual net asset tax etc.) in running the Company
and relevant Sub-Fund and its subsidiary undertakings;
(ii) any applicable Management Fee;
(iii) any applicable Compensation Payment;
(iv) interest payments and hedging expenses;
(v) taxes;
(vi) plus/minus realised foreign exchange results; and
(vii) such other amounts determined by the Board on account of liabilities, contingent or otherwise, in respect of
Investments made by a Sub-Fund, as adjusted for any applicable Income Transfers and Capital Transfers as described in
the PPM.
(2) Distributions of Capital
As described below, all capital receipts (other than amounts relating to Capital Transfers) will be distributed semi-
annually on the next Payment Date and on such other additional dates as the Board may determine, save where the
Board, on the recommendation of the Fund Manager, determines it is in the interest of the Sub-Fund to retain Capital
Receipts within the Sub-Fund for the purposes of liquidity.
Capital which is capable of distribution will comprise:
(i) all capital receipts in respect of Investments made by a Sub-Fund (whether as a result of partial or full repayment
or cancellation of Subordinated Infrastructure Bond or otherwise);
(ii) any Capital Releases (after any relevant fees and expenses); and
(iii) clawbacks in respect of capital from the Carry Recipient escrow account, (collectively "Capital Receipts"), as
adjusted for any applicable Income
Transfers and Capital Transfers as described in the PPM.
59922
L
U X E M B O U R G
Distributions of Capital will be by means of a redemption of Shareholder's Shares at the latest available Net Asset
Value per Share, adjusted as appropriate to take into account any non-cash items (including but not limited to derivatives
and non cash liabilities).
The distributions declared will normally be paid in the currency in which the relevant Sub-Fund is expressed or in such
other currencies as reasonably selected by the Board and, taking into account prevailing commercial circumstances, may
be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may make a final determination of the
rate of exchange applicable to translate distribution monies into the currency of their payment. Stock distributions may
be declared.
Winding-up, Liquidation and Distribution upon liquidation
Art. 29. The Company can be terminated (and one or more liquidators appointed so to do) following a vote of
Shareholders in accordance with the prevailing laws of Luxembourg.
If the Company has not purchased an Investment prior to the first anniversary of the First Closing of the Company
(irrespective of whether this is due to one or more SRAC members having exercised their right of objection as described
in the PPM), at any time prior to the earlier of:
(i) the completion of the first Investment; and
(ii) the second anniversary of the First Closing of the Company,
(the "Winding-Up Condition"),
any Shareholder may request the Board to cancel, and on receipt of such request the Board shall promptly take the
necessary steps to cancel, such portion of its Unfunded Commitments and/or call a meeting of the Shareholders to
propose a resolution for the winding up of the Company. At such meeting, Shareholders may vote by Shareholder
Ordinary Resolution to:
(i) adjourn the meeting to a later time to be agreed by the Shareholders, where the resolution to wind up the Company
will be considered again; or
(ii) wind-up the Company.
The Company will consolidate all Shares held by a Shareholder whose undrawn Commitment is cancelled in accordance
with the above into such number as the proportion of its Capital Contribution bears to its total Commitment immediately
prior to such cancellation.
No compensation payment is payable to the Fund Manager nor the Investment Adviser in case of such termination.
At any time from two years after First Closing, upon a Shareholders Ordinary Resolution supporting such action, the
Board shall take all necessary steps to wind-up the Company.
In the event of a winding-up of the Company, liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may be
physical persons or legal entities) appointed by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.
In addition, unless the Company is being wound-up as a result of the Company not purchasing an Investment prior to
the first anniversary of the First Closing:
- the Fund Manager and the Investment Adviser will be entitled to receive a compensation payment equal to their
proportionate share of the Management Fee for (i) if Commitments to Shares issued are equal to or more than
500,000,000, the following four years; or (ii) if Commitments to Shares issued are less than 500,000,000, the following
five years. The compensation payment will be payable (i) from undrawn Commitments and (ii) any outstanding balance
from future proceeds received by the Company during the winding-up. Notwithstanding the above, no compensation
payment shall be payable if at the date on which the Shareholder Ordinary Resolution to terminate the Company is passed,
any Main Sub-Fund is not complying with the Minimum Performance Threshold.
- the Carry Recipient shall also be entitled to receive any accrued but unpaid Carried Interest due to it and any Carried
Interest accrued in the process of winding up the Company, (provided that, for the purposes of calculating the amount
of Carried Interest accrued during the winding up on the sale of an Investment during the winding up process: (i) any
Capital Receipts received by a Sub-Fund in excess of the amortised cost of such Investment will form part of the calculation
of Distributions of Income of such Sub-Fund; and (ii) where the value of an Investment has been impaired or written off
(rather than amortised), the amount of the Capital Receipt equivalent to the amount of that impairment or write off will
be disregarded and will not form part of the calculation of Distributions of Income of such Sub-Fund). The compensation
payment will be payable from (i) undrawn Commitments and (ii) any outstanding balance from proceeds received by the
Company during the winding-up and the ongoing Carried Interest will be payable in accordance with the provisions set
out in the PPM, in each case plus interest on overdue amounts at 7 per cent. per annum. Notwithstanding the above, no
compensation payment shall be due if at the date on which the Shareholder Ordinary Resolution to wind-up the Company
is passed, any Main Sub-Fund is not complying with the Minimum Performance Threshold.
Subsequently, the net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-Fund shall be distributed by the liquidators
to the holders of Shares attributable to each Sub-Fund in proportion of their holding of Shares attributable to such Sub-
Fund.
59923
L
U X E M B O U R G
With the consent of the Shareholders expressed in the manner provided for by Articles 67-1 and 142 of the 1915
Law, the liquidator may be authorised subject to giving one month's prior notice to the Shareholders to transfer all assets
and liabilities of the Company to a Luxembourg UCI in exchange for the issue to the Shareholders in the Company of
shares in such UCI in proportion to their shareholding in the Company. Any liquidation shall otherwise entitle a Share-
holder to a pro rata share of the liquidation proceeds corresponding to his Shares. Moneys available for distribution to
Shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by Shareholders will at the close of liquidation be
deposited at the Caisse des Consignations in Luxembourg pursuant to the 2007 Law, where they will be held at the
disposal of the Shareholders entitled thereto for thirty (30) years.
Amendment of articles
Art. 30. The Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum requi-
rements provided by the laws of Luxembourg (being at the date of incorporation of the Company a quorum of
Shareholders representing at least one half of the Shares) and requiring the approval of a Shareholder Ordinary Resolution,
provided that the unanimous approval of the Shareholders will be required for any amendments to the Articles that have
a negative effect on Shareholders or change the terms of the Company in a material way.
General
Art. 31. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the 2007
Law as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The initial corporate capital is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by thirty one thousand
(31,000) Shares. The Shares have been subscribed and issued as follows:
Aviva Investors Luxembourg, hereabove mentioned, has subscribed to thirty-one thousand (31,000) Shares without
par value, issued at a price of one Euro (EUR 1.-), each fully paid up in cash.
As a consequence the Company has at its disposal an amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) of which
evidence has been shown to the undersigned notary who expressly states the same.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above-mentioned party, in its capacity as sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder") has passed
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are elected as members of the Board for a period ending at the next annual general meeting:
- Mr Marc Bajer, born on 6 April 1956 in Detroit (United States of America) and residing professionally at Churerstrasse
77, CH-8808 Pfaffikon (Switzerland).
- Mr William Gilson, born on 17 April 1968 in Bridgnorth (United Kingdom) and residing professionally at 2, rue du
Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg (Luxembourg).
- Mrs Supreetee Kumudini Saddul, born on 6 November 1963 in Rose Hill (Mauritius) and residing professionally at
20, rue de l'Industrie, L-8399 Windhoff (Luxembourg).
- Mr Mark Phillips, born on 14 May 1965 in Dorking, Surrey (United Kingdom) and residing professionally at 2, rue du
Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg (Luxembourg).
- Mr Stephen Uhlig, born on 5 September 1950 in London (United Kingdom) and residing professionally at 9 Colinette
Road, London SW15 6QG (United Kingdom).
The Sole Shareholder resolved to authorise the Board to delegate the day to day management of the Company as well
as the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors or to the Fund Manager.
<i>Second resolutioni>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., with its registered office at 400, route d'Esch, BP 1443 L-1014 Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg) has been elected as auditor (réviseur d'entreprises agree) until the annual general meeting of
Shareholders to be held in 2013.
<i>Third resolutioni>
The registered office shall be at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company are
estimated at approximately three thousand Euros (EUR 3,000.-).
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present incorporation deed is worded in English.
59924
L
U X E M B O U R G
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with us the notary the present original deed.
Signé: E. TOSHKOVA, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 4 mail 2012. Relation: LAC/2012/20442. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €)
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 10 mai 2012.
Référence de publication: 2012054934/1079.
(120076792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2012.
Agregia Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 166.864.
L'an deux mille douze.
Le vingt-sept février.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, soussigné, s'est tenue l'assemblée générale ex-
traordinaire des associés de la société à responsabilité limitée AGREGIA LUXEMBOURG (ci-après "la Société"), avec
siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg numéro
B 166.864, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire préqualifié, en date du 10 février 2012, non
encore publié au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christina SCHMITVALENT, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé
privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale attachée aux parts sociales.
2.- Augmentation du capital social d'un montant de 151,51 EUR pour le porter de son montant actuel de 15.000,- EUR
à 15.151,51 EUR, par la création et l'émission d'une part sociale nouvelle sans désignation de valeur nominale, jouissant
des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
3.- Souscription et libération de la part sociale nouvellement émise.
4.- Modification afférente de l'article six, alinéa premier, des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés et leurs mandataires, par les membres du bureau
et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées "ne varietur" par les membres
du bureau et le notaire instrumentant.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées. Dès lors, l'as-
semblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les associés
ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.
IV.- Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale attachée aux parts sociales composant le capital social de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
De manière subséquente à la suppression de la valeur nominale des parts sociales décidée aux termes de la première
résolution, l'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de 151,51 EUR (cent cinquante
et un euros et cinquante et un cents) pour le porter de son montant actuel de 15.000,- EUR (quinze mille euros) à
15.151,51 EUR (quinze mille cent cinquante et un euros et cinquante et un cents), par la création et l'émission d'1 (une)
part sociale nouvelle sans désignation de valeur nominale, émise avec une prime d'émission de 39.848,49 EUR (trente
neuf mille huit cent quarante huit euros et quarante neuf cents), jouissant des mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.
La part sociale nouvellement émise a été souscrite et libérée entièrement par Monsieur Michel FEINTRENIE, entre-
preneur individuel, marié sous le régime de la communauté de biens à Madame Thuy Nga TRAN, née à Châteauroux
59925
L
U X E M B O U R G
(France), le 3 septembre 1956, demeurant à F-36500 Chezelles, 2, route d'Argy (France), par un apport en numéraire
d'un montant total de 40.000,- EUR (quarante mille euros), le montant de 151,51 EUR (cent cinquante et un euros et
cinquante et un cents) étant affecté au capital et le montant de 39.848,49 EUR (trente-neuf mille huit cent quarante-huit
euros et quarante-neuf cents), étant affecté à la prime d'émission.
La preuve de ce versement a été apportée au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'admettre Monsieur Michel FEINTRENIE, préqualifié, à la souscription de la part sociale nouvelle.
<i>Intervention des apporteurs - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite Monsieur Michel FEINTRENIE, préqualifié, ici représenté par son mandataire en vertu d'une pro-
curation, pour la souscription de la part sociale nouvelle, lequel a déclaré souscrire ladite part sociale nouvelle et la libérer
intégralement par un apport en numéraire ci-avant détaillé.
Monsieur Michel FEINTRENIE a également déclaré disposer de l'autorisation expresse de son épouse, Madame Thuy
Nga TRAN, de réaliser ces souscription et libération.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article six des statuts se trouve modifié et aura doré-
navant la teneur suivante:
" Art. 6. (alinéa premier)
Le capital social est fixé à 15.151,51 EUR (quinze mille cent cinquante et un euros et cinquante et un cents), représenté
par 101 (cent une) parts sociales sans désignation de valeur nominale chacune."
<i>Estimation - Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-
proximativement à la somme de mille cent cinquante euros.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Christina SCHMIT-VALENT, Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 01 mars 2012. Relation GRE/2012/786. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPÉDITION CONFORME.
Junglinster, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012045020/77.
(120060359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Logwin AG, Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.
R.C.S. Luxembourg B 40.890.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045769/9.
(120061446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
A4Investments SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 163.944.
EXTRAIT
(...)
Par la présente je démissionne comme administrateur d'A4INVESTMENTS SICAV-SIF (R.C.S. Luxembourg: B 163944)
avec effet immédiat.
(...)
59926
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Javier Valls Martinez
Référence de publication: 2012045580/15.
(120060940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
DEXIA Asset Management Luxembourg S.A., en abrégé Dexia AM Luxembourg, Dexia Asset Manage-
ment ou Dexia AM, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 136, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 37.647.
Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 2012:
Il a été procédé aux nominations statutaires suivantes:
<i>Troisième Résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de ratifier:
- la décision du Conseil d'administration de la Société du 12 décembre 2011 de coopter Monsieur Alexandre Joly
(ayant son adresse professionnelle Passerelle des Reflets, 1, Tour Dexia la Défense 2, F-92919 La Défense Cédex, France)
par voie de résolution circulaire en tant qu'Administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Stefaan Decraene;
- la décision du Conseil d'administration du 19 janvier 2012 de prendre acte des démissions de Monsieur Stefaan
Decraene en tant que Président du Conseil d'administration avec effet au 5 septembre 2011 et de Monsieur Christophe
Burm en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 20 octobre 2011;
- la décision du Conseil d'administration du 19 janvier 2012 d'élire parmi ses membres Monsieur Philippe Rucheton
(ayant son adresse professionnelle Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles, Belgique) en tant que nouveau Président du Conseil
d'administration et ce, avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013
A l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale, la composition du Conseil d'administration de la Société est la suivante:
Nom de l'Administrateur
Fonction
Adresse professionnelle
Expiration
du mandat
Philippe Rucheton
Président
Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles, Belgique
AGO 2013
Jean-Yves Maldague
Administrateur
délégué
136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,
Luxembourg
AGO 2013
Naïm Abou-Jaoudé
Administrateur-
Directeur
40, rue Washington, F-75408 Paris, France
AGO 2013
Alexandre Joly
Administrateur Passerelle des Reflets, 1, Tour Dexia la Défense
2, F-92919 La Défense Cedex, France
AGO 2013
Thierry Delroisse
Administrateur 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg,
Luxembourg
AGO 2013
Pierre Malevez
Administrateur 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg,
Luxembourg
AGO 2013
An Other Look To Efficiency
(en abrégé "OL2EF"),
représentée par
Olivier Lefebvre
Administrateur
indépendant
Chaussée de Dinant 755, B-5100
Namur-Wépion N° de registre:
RPM 0892.268.356
AGO 2013
<i>Quatrième Résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe
560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro
B 67.895, en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour l'exercice 2012, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire
2013 de la Société.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
Naïm Abou-Jaoudé / Jean-Yves Maldague
<i>Administrateur-Directeur / Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2012045117/48.
(120060342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
59927
L
U X E M B O U R G
Colophon - International Magazine Symposium, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 10, rue des Gaulois.
R.C.S. Luxembourg F 1.489.
DISSOLUTION
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2011i>
<i>Décisioni>
Les membres de l'association ont décidé le 31 décembre 2011 de dissoudre l'Association d'une manière coordonnée
et de la faire radier au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Il est décidé à l'unanimité, et conformément aux dispositions mentionnées dans les statuts de l'asbl, de transférer
l'ensemble du passif et de l'actif de l'association sans but lucratif - Colophon -International Magazine Symposium, en faveur
de la société anonyme MM Publishing and Media (anciennement MM Publishing s.a.), située au 10 rue des gaulois à Lu-
xembourg - Bonnevoie et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule B
95211.
Pour extrait conforme
MM Publishing SA / PARADISO SARL
Mike Koedinger
Michel dit Mike Koedinger
Référence de publication: 2012045628/21.
(120060810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Luxembourg Financial Group Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 128.323.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012045258/10.
(120060278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Lagon, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 130.363.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 avril 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012045260/11.
(120060157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Modasia Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 59.351.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2012.
Référence de publication: 2012045316/10.
(120060049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
59928
L
U X E M B O U R G
Atlas Copco Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 22.344.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 2 avril 2012 Au siège social à 74, rue de Merl L-2146i>
<i>Luxembourg à 11.00 heuresi>
1) L'Assemblée décide de nommer comme administrateurs:
- Alex Christiaan Jan Bongaerts
- Leif Göran Victorin
- Claude Weber,
Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013 délibérant sur les comptes
annuels de 2012.
2) L'Assemblée nomme comme réviseur d'entreprises indépendant DELOITTE, 560 rue de Neudorf, L-2220 LUXEM-
BOURG.
Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013 délibérant sur les comptes
annuels de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Claude Weber
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012045575/23.
(120061615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Logwin AG, Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.
R.C.S. Luxembourg B 40.890.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045770/9.
(120061447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Field Point I-A RE 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 122.073.
<i>Dépôt complémentaire au dépôt du 12 avril 2012 enregistré sous le numéro L120058798i>
Il résulte des résolutions des associés de la Société en date du 2 avril 2012, que la société Field Point I-A RE 5 S.à r.l.
a transféré une (1) part sociale qu'elle détenait dans la Société à:
- Q 207 GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 14, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B166.095.
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
Field Point I-A RE 5 S.a r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 parts sociales
Rock Ridge RE 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 parts sociales
Eleven Dahoon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale
Allianz Versorgungskasse Versicherungsverein a.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 parts sociales
Q 207 GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
59929
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Field Point I-A RE 1
Signature
Référence de publication: 2012045675/24.
(120060964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Socego Investments Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 39.904.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 février 2012i>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de MonNsieur Eric Tazzieri, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Fabrizio Terenziani, employé privé, avec adresse
professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Maître Antonio Galli, avocat, demeurant 16, Corso
Elvezia à CH-6901 Lugano, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BF Consulting Sàrl, ayant son siège social
16, rue de Larochette à L-9391 Reisdorf. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2011.
Luxembourg, le 29 février 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012045438/18.
(120060352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
HTI, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 129.654.
L'an deux mille douze, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HTI, (la "Société"), avec siège
social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'activités, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 129654, constituée en France le 11 février 1995, transférée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître
Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz, en date du 14 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, du 22 août 2007 sous le numéro 1778.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à L-6130
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé,
demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification du pouvoir des signatures des membres du conseil d'administration de la Société;
2. Modification subséquente des articles 7 et 12 des statuts;
3. Nomination des membres du conseil d'administration;
4. Nomination d'un nouveau commissaire.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
59930
L
U X E M B O U R G
Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le pouvoir de signature des membres du conseil d'administration par la création de
deux catégories d'administrateurs A et B.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 7 et 12 des statuts afin de leur donner la
teneur suivante:
“ Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé par des administrateurs de catégorie A
et par des administrateurs de catégorie B.
Si la société ne comporte qu'un associé unique le conseil d'administration peut être composé par un seul administrateur.
Dès que l'assemblée générale constate l'existence de plus d'un associé il y aura lieu de nommer un conseil d'administration
composé de trois membres au moins.
Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis
aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour le compte
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer
son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,
il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion."
“ Art. 12. Si la société comporte un conseil d'administration composé de plusieurs administrateurs la société sera
engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière a été
déléguée soit par les signatures conjointes d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.
Si la société fonctionne au moyen d'un administrateur unique ce dernier engage valablement la société en toute cir-
constance par sa seule signature."
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer le mandat de l'administrateur unique actuel, Monsieur Claude HOCHNER, et de
nommer un conseil d'administration composé par trois administrateurs.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Madame Brigitte Juliette BLUM, née à Mulhouse (France) le 2 mai 1960, demeurant au 9, Chemin des Ardennes,
F-68100 Mulhouse (France), en tant qu'administrateur de catégorie A;
- Monsieur Jean Louis VORBURGER, né à Mulhouse (France) le 1
er
aout 1958, demeurant à PO Box 171, Hawley PA,
18428 (USA), en tant qu'administrateur de catégorie A;
- La société à responsabilité limitée "TITAN" S.à r.l., ayant son siège social au 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen,
R.C.S. Luxembourg numéro B 164838, représentée par Monsieur Thanh NGUYEN, né à Vientiane (Laos), le 5 février
1970, et Monsieur Mark LE TISSIER, né à Guernsey, le 24 avril 1963, les deux demeurant professionnellement à L-8308
Capellen, 75, Parc d'activités, en tant qu'administrateur de catégorie B.
Le conseil d'administration engage valablement la société par les signatures conjointes d'un administrateur de catégorie
A et d'un administrateur de catégorie B.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2017.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer le mandat du commissaire actuel, la société à responsabilité limitée DUNE EXPER-
TISES, et d'appeler aux fonctions de commissaire la société anonyme Client Audit Services, ayant son siège social au 75,
Parc d'activités, L-8308 Capellen, R.C.S. Luxembourg numéro B 160904.
Le mandat du commissaire prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2017.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête.
59931
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Bob PLEIN Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mars 2012. Relation GRE/2012/1035. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012045206/95.
(120060346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
PPMT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9775 Weicherdange, Maison 11B.
R.C.S. Luxembourg B 168.103.
STATUTS
L'an deux mil douze, le trente mars.
Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
- La société «AFB Services Limited» ayant son siège social à Kowloon, Hong Kong (Chine), 610, Nathan Road, Flat/
Room 813 8/F, immatriculée au Companies Registry de Hong Kong sous le numéro 1370262,
ici dûment représentée par Monsieur Ludovic LO PRESTI, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à
L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener,
Laquelle comparante, telle que représentée, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée déclare constituer entre elle et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elle a
arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «PPMT S.à r.l.».
Art. 2. Le siège social est établi à Weicherdange.
Il peut être transféré dans les limites du lieu du siège par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants,
du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte
de tiers ou en participation, la prestation de services, l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'assistance au ma-
nagement et toutes prestations de services dans le cadre de la gestion d'entreprises privées et publiques. Cette
énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société
subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque. Elle
peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.
La société a également pour objet la réalisation, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation
avec ceux-ci, de toute opérations foncières et immobilières et notamment:
- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation et la
location de tous immeubles bâtis, meublés ou non;
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles
non bâtis.
Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à la promotion immobilière.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.
59932
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, entièrement souscrites par l'associée unique la société AFB Services Limited,
ayant son siège social à Kowloon, Hong Kong (Chine), 610, Nathan Road, Flat/Room 813 8/F.
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros
(12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, moyennant certificat bancaire.
La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,
sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 6. L'associé unique peut céder ses parts à qui il l'entend. Entre associés les parts sont librement cessibles.
Elles ne peuvent être cédées ou transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime
des associés.
En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. Le décès, l'incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin
à la société.
Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne
pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Gérance - Assemblée générale
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l'assemblée
générale qui fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 12. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de
l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu au
siège social.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix,
proportionnellement au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour
autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives
ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Année sociale - Bilan
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, confor-
mément aux dispositions légales en vigueur.
Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à
ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.
Dissolution - Liquidation
Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Mesure transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
59933
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à 1050,- €.
<i>Décisions de l'associée uniquei>
Et à l'instant l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, s'est réunie en lieu et place de l'assemblée
générale, et, a pris les résolutions suivantes:
1.- L'adresse du siège social est fixée à L-9775 Weicherdange, Maison 11B.
2.- Le nombre de gérants est fixé à un (1).
Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Claude VANPARYS, administrateur de sociétés, né à
Ostende (Belgique), le 20 juillet 1968, demeurant professionnellement à L-9775 Weicherdange, Maison 11B.
3.- Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Lo Presti, M.Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 avril 2012. Relation: LAC/2012/15493. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole Frising.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 12 avril 2012.
Référence de publication: 2012044427/117.
(120058725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2012.
Neptune Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 90.210.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012045328/10.
(120060165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Nordic Finance Holding S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 18.389.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012045333/10.
(120060229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
IXIS CMNA IP Asset Holdings (Luxembourg) S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 106.809.
<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 19 mars 2012 à 11h00i>
<i>"L'Assemblée"i>
L'Assemblée accepte la démission de Monseur Christopher Hayden de sa fonction de membre du conseil de surveil-
lance avec effet au 06 février 2012.
L'assemblée nomme Monsieur Jeremy Hood, né à Darby, Pennsylvanie (USA) le 10 juin 1964 comme nouveau membre
du conseil de surveillance avec effet au 06 février 2012.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des membres du conseil de surveillance.
59934
L
U X E M B O U R G
Sont membres du conseil de surveillance:
- Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
- William Branagh, administrateur, avec adresse professionnelle au Harborside Financial Center, Plaza V, Jersey City,
New jersey 07311, United States of America;
- Jeremy Hood, administrateur, avec adresse professionnelle au 1251 Avenue of the Americas 34
th
Floor New York,
NY 10020.
Le mandat des membres du conseil de surveillance prendra fin avec l'assemblée générale annuelle ayant lieu en 2013.
Fait à Luxembourg, le 11 avril 2012.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012045742/25.
(120061164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Reading Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.544,50.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 166.681.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2012.
Référence de publication: 2012045384/11.
(120060141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Stena Forth Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.626.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 6. April 2012.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2012045423/14.
(120060324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investis-
sement en Capital à Risque.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 106.232.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions des associés prises en date du 16 avril 2012 que:
- Monsieur Christophe Mathieu, né le 18 janvier 1978 à Verviers (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 2,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie A avec
effet au 16 avril 2012, pour une durée indéterminée;
Depuis le 16 avril 2012, le Conseil de Gérance est composé comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Monsieur Christophe Mathieu, né le 18 janvier 1978 à Verviers (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 2,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Madame Corine Frérot, née le 25 novembre 1973 à Brou-sur-Chantereine (France), ayant son adresse professionnelle
au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
59935
L
U X E M B O U R G
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Michael Tsoulies, né le 30 avril 1961 dans le Massachusetts (USA), ayant son adresse professionnelle à
Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6BR, Royaume-Uni; et
- Monsieur Rodolpho Amboss, né le 10 May 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), ayant son adresse profes-
sionnelle au 1271, Sixth Avenue, 38
th
floor, New York, NY 10020, Etats-Unis d'Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Pour extrait conforme
LBREP II Europe S.à r.l., SICAR
Signature
Référence de publication: 2012046011/29.
(120061159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
AOS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 168.153.
STATUTS
L'an deux mille douze, le trois avril.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, Luxembourg.
A COMPARU:
CAPE NORTH S.A., ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange, 5
ème
étage,
Ici représentée par son administrateur-délégué ayant pouvoir de signature individuelle, NATIONWIDE MANAGE-
MENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1
er
étage, elle-même représentée par son
administrateur-délégué, Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660 Lu-
xembourg, 60, Grand-rue
Lequel comparant représenté comme il est dit a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par la présente.
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires
de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:
- le conseil économique et les services aux entreprises;
- l'étude, le conseil, la gestion de tous projets;
- l'étude, le conseil, le montage et la gestion de toutes opérations immobilières;
- l'étude, le conseil, l'ingénierie et l'intégration de toutes technologies de la communication et de l'information et les
services s'y rapportant;
- la formation et le coaching;
- l'accomplissement de toutes activités commerciales. La société pourra acquérir tous titres et droits par voie de
participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur
et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.
D'une façon générale, la société peut réaliser tous actes et toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
techniques, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec tous les objets pré-décrits, elle pourra
prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement
ou au développement de ses objets.
La société pourra prêter, emprunter avec ou sans garanties et émettre des obligations ou autres instruments financiers
qui pourront être convertibles à toute société ou entreprise dans laquelle la société a un intérêt ou qui fait partie du
groupe de sociétés auquel appartient la société.
La société exercera son activité sous réserve des autorisations administratives éventuellement requises en la matière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «AOS LUXEMBOURG S.à r.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
59936
L
U X E M B O U R G
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représenté par
CENT VINGT-CINQ (125) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.
Toutes ces parts ont été souscrites par CAPE NORTH S.A., préqualifiée. Le souscripteur a entièrement libéré ses
parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-)
se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le
constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les
trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.000,-.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1
er
étage.
59937
L
U X E M B O U R G
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Yves Meert, directeur, né à Ixelles (Belgique), le 4 août 1964, demeurant à 12, rue Saint-Martin, B-6860
Léglise.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention du constituant sur la nécessité d'obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l'article deux des présents statuts.
Dont acte, passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le mandataire de la partie comparante a signé
avec le notaire le présent acte.
Signé: R. MAMDY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 avril 2012. Relation: LAC/2012/16162. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012045024/109.
(120060337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Remacum Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5620 Mondorf-les-Bains, 5, rue J.P. Ledure.
R.C.S. Luxembourg B 105.343.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille douze, le troisième jour du mois d’avril.
Par-devant nous Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de REMACUM SARL, une société à responsabilité
limitée en cours de liquidation régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-5620 Mondorf-les-Bains, 5,
rue J.P. Ledure, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Roger Arrensdorff, alors notaire de
résidence à Mondorf-les-Bains en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
sous le numéro 368 du 22 avril 2005, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 105.343 (la "Société").
La société a été mise en liquidation en date du 11 novembre 2010 suivant un acte reçu par Maître Roger ARRENS-
DORFF, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous
le numéro 18 du 5 janvier 2011, comprenant nomination de la Fiduciaire Générale du Nord S.A., société anonyme ayant
son siège social à L-9237 Diekirch, 3, Place Guillaume, en tant que liquidateur.
Monsieur Serge CREUTZ, né le 27 avril 1967 à Eupen (Belgique), demeurant à L-1917 Luxembourg, 13, rue Large, a
été nommée commissaire de contrôle à la liquidation par acte sous seing privé en date du 13 mars 2012.
L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert René CREUTZ, entrepreneur en bâtiments,
demeurant professionnellement à L-9227 Diekirch, 11, rue Esplanade,
qui a désigné comme secrétaire et scrutateur Monsieur André SASSEL, administrateur, demeurant professionnellement
à L-9237 Diekirch, 3, Place Guillaume.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Présentation du rapport du commissaire à la liquidation et approbation des comptes de liquidation;
2. Décharge au conseil de gérance, au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
3. Clôture de la liquidation;
4. Détermination du lieu où seront conservés les livres de la Société pendant une durée d'au moins cinq ans et des
autres mesures nécessaires à la clôture de la liquidation;
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
(ii) Que les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites, conformément à la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, par des lettres recommandées avec accusé de réception, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant par production des justificatifs.
59938
L
U X E M B O U R G
(iii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales détenues par les associés, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence et les procurations des
associés représentés, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité
de l'enregistrement.
(iv) Il ressort de la liste de présence que sur les 100 (cent) parts sociales émises par la Société, toutes les 100 (cent)
parts sociales représentant l’entièreté du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
tous les associés représentés ayant déclaré être régulièrement convoqués et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.
(v) Que l’assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
(vi) Que l’assemblée a pris, chaque fois à l’unanimité des voix représentées, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide, après avoir entendu les conclusions du rapport du commissaire à la liquidation, d'approuver les
comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par les membres du bureau,
les mandataires des associés représentés et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé
avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge au conseil de gérance, au liquidateur et au commissaire de contrôle à la
liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de clôturer la liquidation et prend acte que la Société, en liquidation, a définitivement cessé d'exis-
ter.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide que les livres et les documents sociaux de la Société seront conservés pour une durée d'au moins
de cinq ans au siège social de la société anonyme SETIM S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 96.625, à savoir au 11, rue Esplanade, L-9227 Diekirch.
L’assemblée décide en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés ou aux créanciers qui ne se
seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appar-
tiendra.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’une expédition du présent acte en vue de clôturer les
comptes de la Société et d’accomplir toutes les formalités.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués à environ huit cents euros (EUR 800,-).
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux membres du bureau, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. R. Creutz, A. Sassel, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 5 avril 2012. Relation: DIE/2012/4252. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 5 avril 2012.
Référence de publication: 2012045394/84.
(120060226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
59939
L
U X E M B O U R G
ORCHIDEE GESTION S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de
Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 155.260.
<i>Extrait du PV de l'assemblée conseil d'administration tenu le 17 avril 2012i>
Il est décidé:
- du transfert du siège social à l'adresse suivante: 47, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg. Cette décision prend
effet dès ce jour.
- de la nomination, en tant qu' administrateur, de la société RGG Consultants Inc, ayant son siège social #1 Mapp
Street à Belize City (Belize). Cette société est enregistrée au Registrar of International Business Companies sous le
numéro 54,048. Elle a pour représentant permanent Mr Michel Vansimpsen demeurant professionnellement 47 bd Joseph
II à L-1840 Luxembourg,
Cette décision prend effet dès ce jour, jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2015.
- de la nomination comme commissaire aux comptes de FMV Consulting SA, ayant son siège social au 47 boulevard
Joseph II L-1840 à Luxembourg, RCS n°B109612 jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2015. Cette décision prend effet dès ce
jour.
Pour acceptation du mandat
RGG Consultants Inc / FMV Consulting SA
Thystère MAYANITH
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012045822/24.
(120061429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Teal Corby S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 78.060.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
Référence de publication: 2012045455/11.
(120060145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Tinsel Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 121.180.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2012.
Référence de publication: 2012045463/10.
(120060152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Ukrainian Agrarian Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 161.615.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2012.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012045473/12.
(120060240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
59940
L
U X E M B O U R G
Compagnie Financière de l'Union Européenne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 51.317.
Suite à l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 février 2012, il a été décidé de renouveler le
mandat du commissaire aux comptes Audit Trust SA, L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, R.C.S. Luxembourg
B-63115, ainsi que les mandats des administrateurs suivants;
- VALON S.A., L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, R.C.S. Luxembourg B-63143;
- LANNAGE S.A., L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, R.C.S. Luxembourg B-63130;
- KOFFOUR S.A., L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, R.C.S. Luxembourg B-86086.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouveler pour une période de 6 ans, prenant
fin à l'issue de rassemblée générale ordinaire de l'an 2018.
Luxembourg, le 17 AVR. 2012.
<i>Pour: COMPAGNIE FINANCIERE DE L'UNION EUROPEENNE S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Valérie Wozniak / Tania Bernat
Référence de publication: 2012045629/21.
(120061711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
City Rent Car, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 65, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 168.131.
STATUTS
L'an deux mille douze, le quatre avril.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
1. La société «UNITED CORPORATE S.A.», une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois,
établie et ayant son siège social au 29 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 164
718),
ici représentée par Monsieur Jean NAVEAUX, administrateur de société demeurant professionnellement au 113 route
d'Arlon, L-1140 Luxembourg,
agissant en sa qualité d'administrateur unique de ladite société avec pouvoir de seule signature.
2.- Monsieur Jean-Luc CZAPLICKI, chef de travaux, né à Créhange (France), le 26 octobre 1957, demeurant 18 rue
de la teinturerie, F-67500 Haguenau (France).
Lesquelles parties comparantes, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité
limitée qu'elles déclarent constituer entre elles par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal la location sans chauffeur de véhicules terrestres à moteur (ci après dénommés
véhicules), l'achat et la revente de véhicules, l'importation et l'exportation, l'achat, la vente, l'exploitation et la pratique
de leasing de tous véhicules neufs ou d'occasions.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'ac-
complissement.
La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «CITY RENT CAR», société à responsabilité limitée.
59941
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par
cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par les associés ci-après, comme suit:
1.- La société «UNITED CORPORATE S.A.», prédésignée, quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . .
95
2.- Monsieur Jean-Luc CZAPLICKI, prénommé, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à
la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de son objet social.
La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont
plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale
extraordinaire des associés.
Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
59942
L
U X E M B O U R G
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l'article dix-sept (17) qui précède, l'année sociale commence aujourd'hui-même pour finir le 31
décembre 2012.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions
1.- Le siège social de la société est établi au 65, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
2.- Le nombre de gérants est fixé à un (1).
Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Luc CZAPLICKI, chef de travaux, né à Créhange (France), le 26 octobre 1957, demeurant 18 rue de la
teinturerie, F-67500 Haguenau (France).
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la partie constituante sur la nécessité
d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme
objet social à l'article deux des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Belvaux (Grand-Duché de Luxembourg), en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et
an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec
Nous notaire soussigné le présent acte.
Signé: J. NAVEAUX, J.L. CZAPLICKI, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 avril 2012. Relation: EAC/2012/4696. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012044618/129.
(120059839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.
59943
L
U X E M B O U R G
Alumni International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 71.488.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «Alumni
International S.à r.l.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxem-
bourg), en date du 05 avril 2012, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 avril 2012. Relation: EAC/2012/4770.
- que la société «Alumni International S.à r.l.» (la «Société»), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 71 488,
constituée suivant acte notarié du 20 août 1999 et publié au Mémorial C numéro 865 du 18 novembre 1999, au capital
social de quatorze mille neuf cent soixante-douze virgule soixante-dix-sept mille trois cent quarante-quatre euros
(14'972,77344 EUR) représenté par six cent quatre (604) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule
soixante-dix-huit mille neuf cent trente-six euros (24,78936 EUR) chacune,
se trouve à partir de la date du 05 avril 2012 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 02 octobre 2008 aux termes de laquelle la
Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de la Société dissoute, en l'occurrence au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 17 avril 2012.
Référence de publication: 2012045566/28.
(120061394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
BeaTrend S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5403 Bech-Kleinmacher, 6, rue Nico Klopp.
R.C.S. Luxembourg B 130.619.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le trente mars.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Madame Annick BEATRISINI, employée privée, demeurant à F-57480 Haute Sierck, 18, route de Bouzonville.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée «BeaTrend S.à r.l.», ayant son social à L-5403 Bech-Kleinmacher, 6, rue Nico
Klopp, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 130619, a été constituée
suivant acte notarié du 10 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2060 du 21
septembre 2007, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR).
Que le comparant, prénommé, est et restera propriétaire de toutes les parts sociales de ladite Société.
Qu'en tant qu'associé unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la
susdite Société, avec effet à ce jour.
Il déclare en outre prendre à sa propre charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société et qu'il entreprendra,
en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de l'engagement qu'il a pris à cet effet.
Que décharge pleine et entière est accordée au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'au moment de la disso-
lution.
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés à L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich, où
ils seront conservés pendant cinq (5) années.
Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu'en tête des présentes.
59944
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute,
Signé: A. BEATRISINI, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 4 avril 2012. Relation: REM/2012/319. Reçu soixante-quinze euros 75.-€.
<i>Le Receveuri>
(signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 12 avril 2012.
Patrick SERRES.
Référence de publication: 2012045515/36.
(120060171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Logwin AG, Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.
R.C.S. Luxembourg B 40.890.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045771/9.
(120061448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
atHome Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 78.663.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 12.04.2012.
Signature.
Référence de publication: 2012045530/10.
(120061317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
A & AHDP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 77.470.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2012i>
L'Assemblée a renouvelé le mandat des Administrateurs Monsieur Stefano GIUFFRA, Monsieur Didier GIRARD et
Monsieur Sylvain KIRSCH jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes annuels 2017.
L'Assemblée a renouvelé le mandat du Commissaire aux Comptes Fidugec Sàrl jusqu'à l'Assemblée statuant sur les
comptes annuels 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AGIF S.A.
Référence de publication: 2012045532/14.
(120060892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Alchemy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 112.479.
- Il convient de modifier l'adresse du gérant de Classe C, Monsieur Alain Steichen du 44, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, au 2, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012045534/11.
(120060958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
59945
L
U X E M B O U R G
Aggmore Europe 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 108.972.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 30 décembre 2011 que les mandats des administrateurs
et commissaire aux comptes de la société ont été renouvelles jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires
qui se tiendra en 2012:
- Matthijs BOGERS, Directeur non-exécutif,
- Stéphane HEPINEUZE, Directeur non-exécutif,
- Christopher MARSDEN, Directeur exécutif,
- Mr. John MCGLOUGHLIN, directeur exécutif, et
- Ernst & Young, Commissaire aux comptes.
L'adresse professionnelle de Mr. John MCGLOUGHLIN étant: Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, Ireland.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2012.
Référence de publication: 2012045557/19.
(120061105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
CS Fixed Income SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 131.404.
L'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2012 a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Luca Diener, Guy
Reiter, Femand Schaus et Germain Trichies en tant que membres du conseil d'administration de CS Fixed Income SICAV-
SIF.
Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013:
- Luca Diener, Membre du Conseil d'Administration
4, Kalandergasse, CH-8070 Zurich
- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Fernand Schaus, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Germain Trichies, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
PricewaterhouseCoopers S.à r.l, a été réélu comme réviseur d'entreprises et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger
Référence de publication: 2012045633/26.
(120061126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Lussemburgo Gestioni S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 148.820.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012045774/9.
(120060978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
59946
L
U X E M B O U R G
LASC Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 168.105.
STATUTS
L'an deux mille douze,
le trois avril.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
la société «LASC International Investment S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le
droit luxembourgeois établie et ayant son siège social au 1 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 146 218,
ici représentée par Monsieur Stéphane MORELLE, expert-comptable, demeurant professionnellement au 1, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 29 mars 2012,
ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
(ci-après «L’Associé Unique»),
Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée que la partie comparante prénommée déclare constituer:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par L’Associé Unique une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les
lois et règlements du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (ci-après «la Loi»), telle que modifiée, par les articles 1832 et suivants du Code Civil, ainsi que par les
présents statuts (les «Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
de parts sociales ou d’émission de nouvelles parts sociales.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société elle-même, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations ou d’instruments de dette
similaires.
La Société a également pour objet la prestation de mandats sociaux de Président, de directeur général, d’administrateur,
gérant ou directeur dans tous types de sociétés, commerciales ou non commerciales, luxembourgeoises ou étrangères,
quelques soit leur secteur d’activités en ce compris le secteur financier.
D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «LASC Management S.à r.l.», société à responsabilité
limitée.
Art. 4. Durée. La Société est établie pour une durée indéterminée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Associé Unique ou par résolution de l’assemblée générale
des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l’Associé
Unique ou en vertu d’’une résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Il peut encore être transféré en tout autre lieu de la commune du siège social statutaire moyennant une décision du
Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants par décision du Conseil de Gérance.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se
trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger.
59947
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) divisé en cent
vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision de
L’Associé Unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et Obligations attachées aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire une voix à
l’assemblée générale des associés.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des bénéfices et de l’actif net de la Société, en proportion directe avec
le nombre de parts sociales existantes.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi et les Statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Associé
Unique ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l’Associé Unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, se reporter aux valeurs constatées dans les bilans, inventaires
sociaux et décisions de L’Associé Unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d’un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles.
Si la Société est composée d’une pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés mais ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou
acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un associé. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout
autre événement similaire affectant l’Associé Unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Les gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs
gérants sont nommés, ils constituent un Conseil de Gérance.
Les membres du Conseil de Gérance peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement
«Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’Associé Unique ou par l'assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, l’Associé Unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat, leurs rémunérations et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, a les pouvoirs les plus étendus
pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou
l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social de la Société. Le Gérant ou le Conseil de
Gérance a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant, soit en défendant.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’Associé Unique ou à l’assemblée générale des associés par la Loi ou
par les présents Statuts sont de la compétence du Gérant ou du Conseil de Gérance.
Le Gérant ou le Conseil de Gérance peut déléguer des pouvoirs spécifiques à un ou plusieurs mandataires. Le Gérant
ou le Conseil de Gérance détermine les responsabilités et, s’il en est, la rémunération de ces mandataires, la durée ainsi
que toute autre condition de leur mandat.
Art. 15. Conseil de Gérance - Procédure. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société
l'exige ou sur convocation de l’un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
brièvement exposés dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou
représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi
être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
59948
L
U X E M B O U R G
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée
et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant de catégorie
A et au moins un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont valablement
prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de
catégorie B ont été nommés, ces résolutions sont approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de
catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
Tout gérant peut participer à la réunion du Conseil de Gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 16. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant le gérant ou l’un des gérants, de même que sa démission ou sa révocation pour juste motif, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers ou ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 17. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.
Art. 18. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique
ou en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe ou la signature
individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seulement dans les
limites de ce pouvoir.
Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B), la
Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie
B.
Toutefois, un gérant de catégorie A peut valablement représenter seul la société dans l’exercice de tout mandat social
dont la société est titulaire, à charge pour ce gérant d’informer par écrit l’ensemble des autres gérants des actes qu’il
aura ainsi accompli seul.
Art. 19. Assemblée générale des associés. Lorsque la société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les
pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 ainsi que l’article 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale des associés ou par
vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote par écrit et de l’envoyer à la Société, dans un
délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 20. Décisions. Les décisions de L’Associé Unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas, seront
établies par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des
associés, ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Art. 21. Modification statutaire. Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par
la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la
Loi.
Art. 22. Année sociale. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre
de la même année.
Art. 23. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la
société et un bilan résumant cet inventaire.
Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourra prendre connaissance au siège social desdits
inventaire et bilan.
Art. 24. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des
frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.
59949
L
U X E M B O U R G
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera L’Associé Unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.
Art. 25. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que
ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par L’Associé
Unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et émoluments.
Art. 26. Disposition générale. Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents Statuts sont régies par la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
L’Associé Unique ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré par un
apport en numéraire les montants ci après énoncés:
Associé
Capital
souscrit
(EUR)
Nombre
de parts
sociales
Libération
(EUR)
LASC International Investment S.àr.l., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,-
125
12.500,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,-
125
12.500,-
La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article
183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Evaluation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à mille euros.
<i>Résolutions de l’Associé Uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’Associé Unique prénommé, représentant la totalité du capital
souscrit, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le siège social est fixé au 1, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé Gérant unique de la société pour une durée illimitée:
Monsieur Serge CYFERMAN, gérant de société, né à Sarreguemines (France), le 24 mars 1960, demeurant 52, route
de Lens-Crans, CH-3963 Crans-Montana, Suisse.
En conformité avec l’article DIX-HUIT (18) des statuts des présents statuts, le gérant unique a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valablement par sa seule signature.
Dont acte fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxmebourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante connu du soussigné
notaire par ses nom et prénom usuels, état et demeure, le même mandataire a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. MORELLE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 06 avril 2012. Relation: EAC/2012/4675. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012044334/207.
(120058772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2012.
BKM Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 138.575.
<i>Extrait du PV de l'assemblée conseil d'administration tenu le 17 avril 2012i>
1. le transfert du siège social à l’adresse suivante: 47 boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg. Cette décision prend
effet dès ce jour.
2. Nomination, comme administrateur, la société RGG Consultants Inc, ayant son siège social 1 Mapp Street à Belize
City (Belize). Cette société est enregistrée au Registrar of International Business Companies sous le numéro 54,048. Elle
59950
L
U X E M B O U R G
a pour représentant permanent Mr Michel Vansimpsen demeurant professionnellement 47 bd Joseph II à L-1840 Luxem-
bourg, Cette décision prend effet dès ce jour, jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2014.
3. Nomination comme commissaire aux comptes de FMV Consulting SA, ayant son siège social au 47 boulevard Joseph
II L-1840 à Luxembourg, RCS n°B109612 jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2014. Cette décision prend effet dès ce jour.
Pour acceptation du mandat
RGG Consultants Inc / FMV Consulting SA / Thystère MAYANTH
<i>- / - / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012045596/19.
(120061379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
W.06 Lentzweiler « Victus », Société à responsabilité limitée,
(anc. W. 06 VIRO).
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 105.512.
L'an deux mille douze, le trois avril.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
W. 01 «Les Galaxies», une société anonyme ayant son siège social au 4-6, Rue des Trois Cantons, L-3980 Wickrange,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à la section B sous le numéro 103.347,
ici représentée par Monsieur Michel WAEHNERT, gérant de société, demeurant au 10, Rue de l'Alzette, L-3396
Roeser, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé,
laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
I.- Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter qu'elle est
le seul et unique associé (ci-après la "l'associé unique") de la société «W.06 VIRO», une société à responsabilité limitée
avec siège social au 4-6, Rue des Trois Cantons, L-3980 Wickrange, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 105.512, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER,
notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 430 du 10 mai 2005, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis (ci-après la "Société").
II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts
sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes entièrement libérées et souscrites
par l'associé unique, prénommé.
III.- L'associé unique prénommé, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale extraor-
dinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes, qu'il a demandé au notaire
d'acter comme suit:
<i>Ordre du jour :i>
1. Changement de la dénomination de la Société de «W.06 VIRO» en «W.06 Lentzweiler «Victus»».
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
«La Société prend la dénomination W.06 Lentzweiler «Victus».»
3. Modification de l'article 6 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libé-
rées.»
4. Insertion d'un nouvel article des statuts sous le numéro 10, qui aura la teneur suivante:
«La Société sera engagée par la signature de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.»
5. Renumérotation subséquente de tous les articles suivants des statuts de la Société.
6. Démission de Monsieur Michel WAEHNERT en tant que gérant et décharge à lui accorder pour l'exécution de son
mandat jusqu'à la date de ce jour.
7. Confirmation de Monsieur Guy ROLLINGER en tant que gérant unique.
59951
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'associé unique a décidé de changer la dénomination de la Société de «W.06 VIRO» en «W.06 Lentzweiler «Victus»»
et de modifier par conséquent l'article 2 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La Société prend la dénomination W.06 Lentzweiler «Victus».»
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libé-
rées.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide d'insérer un nouvel article des statuts sous le numéro 10, qui aura la teneur suivante:
«La Société sera engagée par la signature de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.».
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à l'insertion d'un nouvel article des statuts sous le numéro 10, l'associé unique décide de renuméroter les anciens
articles 10 à 19 des statuts de la société en articles 11 à 20.
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Michel WAEHNERT en tant que gérant et lui accorde
décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L'associé unique confirme Monsieur Guy ROLLINGER en tant que gérant unique de la société nommé pour une durée
indéterminée, avec les pouvoirs définis à l'article 10 des statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société en raison du
présent acte sont évalués approximativement à mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-).
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire
par ses nom, prénom, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Waehnert, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 5 avril 2012. Relation: DIE/2012/4257. Reçu soixante-quinze (75,--) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Diekirch, le 5 avril 2012.
Référence de publication: 2012045478/85.
(120060336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
59952
A4Investments SICAV-SIF
A & AHDP S.A.
Aggmore Europe 1 S.A.
Agregia Luxembourg
Alchemy Holding S.à r.l.
Alumni International Sàrl
AOS Luxembourg S.à r.l.
atHome Group S.A.
Atlas Copco Reinsurance S.A.
Aviva Investors Hadrian Capital Fund 1 SICAV-SIF
BeaTrend S.à r.l.
BKM Investments
City Rent Car
Colophon - International Magazine Symposium
Compagnie Financière de l'Union Européenne S.A.
CS Fixed Income SICAV-SIF
DEXIA Asset Management Luxembourg S.A., en abrégé Dexia AM Luxembourg, Dexia Asset Management ou Dexia AM
Field Point I-A RE 1
HTI
IXIS CMNA IP Asset Holdings (Luxembourg) S.C.A.
Lagon
LASC Management S.à r.l.
LBREP II Europe S.à r.l., SICAR
Logwin AG
Logwin AG
Logwin AG
Lussemburgo Gestioni S.A.
Luxembourg Financial Group Holding S.A.
Modasia Holding S.A.
Neptune Lux S.A.
Nordic Finance Holding S.A. S.P.F.
ORCHIDEE GESTION S.A., société de gestion de patrimoine familial
PPMT S.à r.l.
Reading Luxembourg S.à r.l.
Remacum Sàrl
Socego Investments Holding S.A.
Stena Forth Lux 1 S.à r.l.
Teal Corby S.à r.l.
Tinsel Group S.A.
Ukrainian Agrarian Investments S.A.
W.06 Lentzweiler « Victus »
W. 06 VIRO