This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1162
9 mai 2012
SOMMAIRE
ArcelorMittal Clean Technology Venture
Capital Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55764
Asset Backed-D S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55741
Bimolux S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55753
BLK BR HY (Luxembourg) Investments,
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55750
BLK COY (Luxembourg) Investments, S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55754
CanGro Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55768
CanGro Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55767
Diversified Growth Company en abrégé
D.G.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55749
Emilion Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
55747
Eurolux Creations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
55757
Fleet Lease S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55767
Gaïa Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55760
Ham Investment Corporation S.à r.l. . . . .
55771
Hansainvest Trust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55747
Hekuba S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55772
Hekuba S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55760
International Company of Institutional
Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55768
International Ressources S.A. . . . . . . . . . . .
55769
Investment Grade Europe S.A. . . . . . . . . . .
55763
Kid Care S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55763
Kiddie's Place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55763
Kluusterstuff S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55771
LAUX & MEURERS Elektro S.à r.l. . . . . . .
55764
Laux & Meurers Luxemburg, LML, Spezia-
list für Bäder und Heizungen G.m.b.H.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55764
Les Espaces Saveurs S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
55772
Living Planet Fund Management Company
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55741
Living Planet Fund Management Company
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55741
Luxco Holdings CEP II S. à r.l. . . . . . . . . . . .
55769
Multilateral Trade SPF S.A. . . . . . . . . . . . . .
55776
Paddington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55730
Patron Mayor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55765
P H C - Pirguet Hôtel Consulting S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55764
Rakuten Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55761
Randstad Group Luxembourg S.à r.l. . . . .
55767
Randstad Luxembourg International S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55767
Spimelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55770
Sunflower Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
55765
Systema International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
55768
TLS Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55768
Vontobel Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55760
Wick Lane (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55765
55729
L
U X E M B O U R G
Paddington, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 168.530.
STATUTES
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,
ON THE TWENTY-FOURTH DAY OF APRIL,
before the undersigned Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Commercial register under the number B
28.878,
duly represented by Mr Rainer Krenz, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Luxembourg on 24 April 2012.
The aforementioned proxy will remain attached to this document to be filed at the same time with the registration
authorities.
Such appearing party, acting in its above-stated capacity, has requested the notary to state the following articles of
incorporation of a public limited company:
Title I. – Definitions – Name – Purpose – Duration – Registered office
Art. 1. Definitions.
- Act of 1915 means the Luxembourg Law of August 10, 1915, on Trading Companies, as currently amended;
- Act of 2007 means the Luxembourg Law of February 13, 2007, on Specialized Investment Funds, as currently amended;
- Articles of incorporation means the articles of incorporation of the Company.
- Business day means a day on which the banks are open for business in Luxembourg and Frankfurt a.M;
- Company or Fund or SICAV means PADDINGTON;
- Custodian means the Company’s custodian bank within the meaning of the Luxembourg Law of 2007, which is a bank
within the meaning of the Luxembourg Law of April 5, 1993, on the Financial Sector;
- General meeting means a meeting of the shareholders;
- Investment advisor means a company or person that gives non-binding investment advice to the investment manager
or the Company;
- Investment manager means a company entrusted with the management of the Company’s assets;
- Net asset value means the value of the Company’s assets less its liabilities, calculated as described in Article 9 of the
articles of incorporation;
- Prospectus means the Company’s prospectus, as amended from time to time;
- Shareholders means persons who have purchased shares in the Company’s capital;
- Shares means the shares of the Company; shares shall be issued in the form of uncertificated registered shares. All
shares must be fully paid in;
- USD means the currency of the United States of America
- Valuation day means the business day for the calculation of the Net Asset Value per Share determined by the Board
of Directors.
- Well-Informed Investor means an investor that qualifies as a Well-Informed Investor within the meaning of Article
2 of the Luxembourg Law of 2007. Well-Informed Investors are institutional investors, professional investors and any
other investors that meet the following requirements:
The investor has made a written statement affirming that the investor agrees to be classified as a skilled investor, and
the investor invests at least EUR 125,000, or the investor has a rating from a credit institution within the meaning of
Directive 2006/48/EC, an investment company within the meaning of Directive 2004/39/EC, or a management company
within the meaning of Directive 2001/107/EC that certifies the investor’s expertise, experience, and knowledge relating
to the investor’s ability to make a reasonable assessment of an investment in a special fund.
Art. 2. Name. The Company is hereby formed as a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment
company with variable share capital - specialised investment fund (société d’investissement à capital variable - fonds
d'investissement spécialisé) under the name of "PADDINGTON".
The Company has its own legal personality.
55730
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Purpose. The Company’s sole purpose is the investment of its assets in securities and other instruments
permitted by the 2007 Law with the aim of diversifying investment risks of spreading the investment risks and its allowing
its shareholders to benefit from the profits earned on its assets.
The Company may take any measures and carry out any transaction, which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the largest extent permitted under the 2007 Law.
The investment policy principles and investment restrictions specified in the Prospectus must be observed during
pursuit of the Company’s purpose and the acts performed for this end.
Art. 4. Duration. The Company shall be established for a definite term up to and including March 31, 2042. The
Company can be dissolved early at any time or have its term extended beyond March 31, 2042, by resolution of the
general meeting.
Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of
Luxembourg.
The Board of Directors is authorised to transfer the registered office of the Company within the municipality of
Luxembourg-City. The registered office may be transferred to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg
by means of a resolution of the sole Shareholder or in case of plurality of Shareholders by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of Shareholders deliberating in the manner provided for any amendment to the Articles
of Incorporation.
Branches, Subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military events have occurred or
are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Title II. – Share Capital – Shares – Net asset value
Art. 6. Share capital. The share capital of the Company shall be represented by no-par value registered shares and shall
correspond at all times to the net asset value of the Company’s shares as specified in Article 9 of the articles of incor-
poration. The original capital is equal to the minimum of thirty-one thousand euros (EUR 31,000). The Company’s
minimum capital is equal to one million two hundred and fifty thousand euros (EUR 1,250,000) and must be reached
within twelve (12) months after the date on which the Company has been authorised as a société d’investissement à
capital variable.
The initial share capital of the Company shall be set at forty-one thousand USD (USD 41,000) represented by four
hundred ten (410) shares, having a nominal value of one hundred USD (USD 100) each.
The Accounting Currency of the Company is the USD.
The Board of Directors shall invest the proceeds from share issues in accordance with the provisions of the Prospectus
and the investment policy and applicable investment restrictions stipulated in Article 16 of these articles of incorporation.
The currency used in the Company’s annual reports shall be the same currency in which its capital is denominated,
i.e., the USD. The net assets of the Company that are not expressed in USD shall be translated into USD in order to
calculate the Company’s share capital.
Art. 7. Form of shares. Shares of the Company can be acquired solely by Well-Informed Investors within the meaning
of the Law of 2007.
The Company only issues shares in uncertificated registered form and shares will remain in registered form. Shares
are issued without par value.
All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept at
the registered office by the Company or by one or more persons designated for this purpose by the Company, where it
will be available for inspection by any shareholder. Such register shall contain the name of each owner of registered shares,
his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held by him, the amount
paid up on each share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be
established by the entry in this register.
The Company shall not issue certificates for such inscription, but each shareholder shall receive a written confirmation
of his shareholding.
Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such
address will also be entered into the register of shareholders.
If a shareholder fails to provide an address, the Company may have a note to that effect recorded in the share register.
In such cases the shareholder’s address shall be deemed to be the address of the registered office of the Company or
any other address registered by the Company until the shareholder sends the Company notice of an address. A share-
55731
L
U X E M B O U R G
holder may request at any time by means of a written notification that the address entered in the share register be
changed.
The Company shall recognize only one legitimate shareholder per share. If one or more shares are jointly owned by
more than one person, or if ownership of a share or shares is contested, these persons must appoint a representative
who is to be considered the legal representative of the share(s) vis-à-vis the Company. The rights attached to the shares
may not be exercised until the effective appointment of such representative.
If a payment entitles a subscriber to acquire a fraction of a share, this fraction shall be entered in the share register.
Fractional shares shall carry no voting rights. However, if the Company so resolves, the shareholder shall participate in
net assets in proportion to the fraction of a share, be entitled to distributions in proportion to the fraction of a share,
and participate in liquidation proceeds in proportion to the fraction of a share if the Company is liquidated.
The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares do not carry voting rights, except where
their number is such that they represent a whole share, but are entitled to participate in the net assets attributable to
the relevant Class on a pro rata basis.
Art. 8. Capital commitments, Issuance, Payment, Redemption and Transfer of shares.
Capital commitments – Issuance of shares
Shares are exclusively reserved for subscription by well-informed investors within the meaning of article 2 of the 2007
Act (Well-Informed Investors). The SICAV may restrict or prevent the ownership of Shares in the SICAV by Prohibited
Persons, set out in the Prospectus.
Investors can undertake capital commitments in accordance with the provisions of the Prospectus whereby they
undertake to contribute the amount of their commitment in whole or in part when their commitments are called by the
Board of Directors (“Capital Call”). The Board of Directors shall specify the procedure in question in the Prospectus.
The failure of an investor or shareholder to make, within a specified period of time determined by the SICAV, any
required contributions or certain other payments to the Company, in accordance with the terms of the subscription
agreement or commitment to the Company, entitles the Company to impose on the relevant investor or shareholder
the penalties determined by the Company and detailed in the Prospectus which may include without limitation and subject
to the provisions of the Prospectus.
The Company may impose conditions on the issue of shares; any such condition to which the issue of shares may be
submitted will be detailed in the Prospectus provided that the Company may, without limitation:
(a) decide to set minimum commitments and minimum subscription amounts;
(b) impose restrictions on the frequency at which shares are issued (and, in particular, decide that shares will only be
issued during one or more offering periods or at such other intervals as provided for in the Prospectus);
(c) reserve shares of the Company exclusively to persons or entities that have entered into, or have executed, a
subscription agreement under which the subscriber undertakes inter alia to subscribe for shares, during a specific period,
up to a certain amount and makes certain representations and warranties to the Company. As far as permitted under
Luxembourg law, any such subscription agreement may contain specific provisions;
(d) determine any default provisions applicable to non or late payment for shares or restrictions on ownership of the
shares;
(e) decide that payments for subscriptions of shares shall be made in whole or in part on one or more dealing dates,
closings or Capital Call dates at which such date(s) the commitment of the investor will be called against issue of shares;
(f) set the initial offering date and the initial price for acceptance of the subscription agreement.
(g) set out in the Prospectus the provisions regarding issuance of shares and compensatory interest
The Company may, in its absolute discretion, accept or reject (partially or totally) any request for subscription for
shares.
The Company may accept at its own discretion full or partial subscriptions in kind of securities or assets, in accordance
with Luxembourg law, and provided that such assets are in accordance with the investment objectives and policies of the
Company. These investments will also be audited by the auditor assigned by the Company. All costs related to the
subscription in kind are borne by the shareholder acquiring shares in this manner.
Default
After receipt of a payment request, when a shareholder does not remit payment for a share tranche within the deadline
established, he becomes a defaulted shareholder and is in default without any further payment request or other notification
following the expiry of the deadline. Without prejudice to other statutory consequences, for the period he is in default,
the defaulted shareholder shall owe late-payment interest in the amount, specified in the Prospectus.
After a written payment request has been sent, when a shareholder does not pay the amount in arrears plus accrued
late-payment interest within a period of four weeks, the Company, in accordance with this article, can issue a written
declaration and seize the shares.
The Company can offset future distributions against defaulted shareholders’ open payment amounts due. The Company
can seize a defaulted shareholder’s shares and issue them to other shareholders. In addition, the defaulted shareholder
may also be made liable for damages resulting from the default.
55732
L
U X E M B O U R G
Redemption / Transfer of shares
No provision has been made for redemption of shares upon unilateral request by the shareholder. The Board of
Directors may decide to perform a mandatory redemption of a shareholder’s shares when it believes that
(i) the holding of shares by the shareholder in question is contrary to the interests of the other shareholders or the
Company or
(ii) could result in a violation of the law in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad or
(iii) could result in the Company becoming subject to taxation in a country other than the Grand Duchy of Luxembourg
or
(iv) it damages the interests of the Company in another manner.
In addition the Board of Directors of the Company can also decide to repurchase shares or fractional shares of the
Company so that, in this manner, proceeds from the sale of the Company’s assets can be paid out to the shareholders.
This decision to repurchase shares is binding on all shareholders and applies pro rata to their share in the net Fund assets
of the Company.
The shares in the Funds’ assets repurchased by the Company will be annulled in the Company’s books. The share
redemption price is determined using the net asset value of the shares on the Valuation Date on which the redemption
is performed and will be paid out in Luxembourg no later than twenty business days following the last day of the calculation
of the redemption price.
Any shareholder may dispose of its shares and sell them privately to well informed third-party investors. To ensure
that shareholders of the Company are complying with the requirements of the Luxembourg Law of 2007 at all times (the
buyer must be a Well-Informed Investor within the meaning of the aforementioned Law), that the Company’s shares are
not held by more than 100 Well-Informed Investors and that the buyer fully and totally takes over the remaining obligations
to the Company, transfers of shares require the prior express written consent of the Board of Directors. Disposal refers
in particular to the sale, exchange, transfer or the assignment of all or a portion of the Shares in the Fund. All obligations
are passed over to the buyer with a discharge of the original obligations of the transferring shareholder to the buyer.
Art. 9. Net asset value – Offering price. The Net Asset Value per Share shall be calculated by the Central Administrative
Agent under the ultimate responsibility of the Board of Directors upon the frequency set forth in the Appendices and at
least once a year (each a "Valuation Day") in accordance with Luxembourg law and Luxembourg General Accepted
Accounting Principles (Lux GAAP).
The Net Asset Value per Share will be expressed in the Reference Currency.
The Net Asset Value per Share of each Class on any Valuation Day is determined by dividing the value of the total
assets of the SICAV properly allocable to such Class less the liabilities of the SICAV properly allocable to such Class by
the total number of Shares of such Class outstanding on such Valuation Day.
The Net Asset Value per Share of the different Classes will differ within the SICAV as a result of the differing fee
structure and/or distribution policy of each Class.
The Net Asset Value per Share is calculated to 2 decimal places.
The Net Asset Value of the shares shall be calculated on a periodical basis according to the Appendix at the Valuation
Day. The Board of Directors may determine in its own discretion additional calculations of the Net Asset Value of the
shares.
A. The assets of the Company shall be deemed to include:
(a) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
(b) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not
collected);
(c) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscription rights and other derivative instruments, warrants,
units or shares of undertakings for collective investments and other investments and securities belonging to the Company;
(d) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company (the
Company may however adjust the valuation to fluctuations in the market value of securities due to trading practices such
as trading ex-dividends or ex-rights);
(e) all accrued interest on any securities held by the Company except to the extent such interest is comprised in the
principal thereof;
(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such preli-
minary expenses may be written off directly from the capital of the Company; and
(g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
B. The following valuation methods shall be used:
(a) Securities and/or units or shares which are listed on a stock exchange or dealt in on another regulated market will
be valued on the basis of the last available bid price.
55733
L
U X E M B O U R G
(b) Securities, which are not listed on a stock exchange nor dealt in on another regulated market, will be valued on
the basis of the probable net realisation value (excluding any deferred taxation) estimated with prudence and in good
faith by the Board of Directors.
(c) The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after
making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.
(d) The liquidating value of futures, forward or options contracts not dealt in on a stock exchange or another regulated
market shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Board of Directors,
on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options
contracts dealt in on a stock exchange or another regulated markets shall be based upon the last available settlement
prices of these contracts on such regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts are
dealt in by the SICAV; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with
respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be
such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable;
(e) Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates
curve. Index and financial instruments related swaps will be valued at their market value established by reference to the
applicable index or financial instrument. The valuation of the index or financial instrument related swap agreement shall
be based upon the market value of such swap transaction established in good faith pursuant to procedures established
by the Board of Directors;
(f) All other securities and other assets, including debt securities and securities for which no market quotation is
available, are valued on the basis of dealer-supplied quotations or by a pricing service approved by the Board of Directors
or, to the extent such prices are not deemed to be representative of market values, such securities and other assets shall
be valued at fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors. Money
market instruments held by the SICAV will be valued using an amortised cost method for all investments with a known
short-term maturity date. This involves valuing an investment at its cost and thereafter assuming a constant amortisation
to maturity of any discount or premium, regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the
investments. While this method provides certainty in valuation, it may result in periods during which value, as determined
by amortised cost, is higher or lower than the price the relevant Fund would receive if it sold the investment. The Board
of Directors will continually assess this method of valuation and recommend changes, where necessary, to ensure that
the SICAV's investments will be valued at their fair value as determined in good faith by the Board of Directors. If the
Board of Directors believes that a deviation from the amortised cost method may result in material dilution or other
unfair results to Shareholders, the Board of Directors shall take such corrective action, if any, as it deems appropriate to
eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results.
The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that
such valuation better reflects the fair value of any asset or liability of the SICAV in compliance with Luxembourg laws.
This method will then be applied in a consistent way. The Central Administrative Agent can rely on such deviations
as approved by the SICAV for the purpose of the Net Asset Value calculation.
The total Net Asset Value of the SICAV is equal to the sum of the net assets of the various activated Classes converted
into USD at the rates of exchange prevailing in Luxembourg on the relevant Valuation Day.
C. The liabilities of the Company shall include:
(1) all loans and other indebtedness for borrowed money (including convertible debt), bills and accounts payable;
(2) all accrued interest on such loans and other indebtedness for borrowed money (including accrued fees for com-
mitment for such loans and other indebtedness);
(3) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, management and advisory fees including per-
formance fees (if any), custody fees, paying agency, cash management fees (if any) domiciliary and corporate agency fees
as well as reasonable disbursements incurred by the service providers);
(4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid distributions declared by the Company, where the Valuation Day falls on
the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
(5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the calculation day, as determined from
time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board of Directors, as well as
such amount (if any) as the Board of Directors may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent
liabilities of the Company;
(6) all other liabilities of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg Law. In determining
the amount of such liabilities the Board of Directors shall take into account all expenses payable by the Company and
may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount rateably
for yearly or other periods.
The assets and liabilities shall be allocated as follows:
55734
L
U X E M B O U R G
(1) The proceeds to be received from the issue of Shares of any Class shall be applied in the books of the Company
corresponding to that Class, provided that if several Classes are outstanding in the Fund, the relevant amount shall increase
the proportion of the net assets of the Fund attributable to that Class;
(2) The assets and liabilities and income and expenditure applied to the Fund shall be attributable to the relevant Class;
(3) Where any asset is derived from another asset, such asset shall be attributable in the books of the Company to
the same Class as the assets from which it is derived and on each revaluation of such asset, the increase or decrease in
value shall be applied to the relevant Class;
(4) Where the Company incurs a liability in relation to any asset of a particular Class or in relation to any action taken
in connection with an asset of a particular Class, such liability shall be allocated to the relevant Class;
(5) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Class, such asset or liability shall be allocated to all the Class(es), pro rata to their respective Net Asset Values or in such
other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith, provided that (i) where assets of several
Classes are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by an agent of the Board of Directors,
the respective right of each Class shall correspond to the prorated portion resulting from the contribution of the relevant
Class to the relevant account or pool, and (ii) such right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals
made for the account of the Class, as described in the sales documents for the Shares of the Company; and
(6) Upon the payment of distributions to the Shareholders of any Class, the Net Asset Value of such Class shall be
reduced by the amount of such distributions.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with Luxembourg law.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision taken by the Board of Directors or by
any bank, company or other organization which the Board of Directors may appoint for the purpose of calculating the
Net Asset Value per Share, in calculating the Net Asset Value per Share, shall be final and binding on the Company and
present, past or future Shareholders.
Art. 10. Temporary suspension of calculation of the net asset value and the issuance of shares. The Company has the
right to suspend the calculation of the Net Asset Value per Share as well as the issuance of shares on a temporary basis
if and so long as circumstances exist which make it necessary to do so and if suspension is justified in the interests of the
shareholders, in particular:
(a) during any period when any of the principal markets or stock exchanges on which a substantial portion of the
investments of the SICAV from time to time is quoted, is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which
dealings thereon are restricted or suspended;
(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation
of assets owned by the SICAV would be impracticable;
(c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments attributable to the SICAV or the current prices or values on any market or stock exchange;
(d) during any period when the SICAV is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of Shares of the SICAV or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of
investments or payments due on redemption of Shares of the SICAV cannot in the opinion of the Directors be effected
at normal prices or rates of exchange;
(e) during any period when the SICAV is being liquidated or as from the date on which notice is given of a meeting of
Shareholders at which a resolution to liquidate the SICAV is proposed;
(f) when for any other reason beyond the control of directors the prices of any investments owned by the SICAV
attributable to the SICAV cannot promptly or accurately be ascertained.
When calculation of the Net Asset Value or the issuance of shares has been suspended, notification to all shareholders
will be sent by post to the address entered in the register of shareholders or by another suitable method.
Title III. – Management – Supervision
Art. 11. Board of directors. The Company shall be managed by a Board of Directors.
The Company’s Board of Directors shall consist of three or more members. The members of the Board of Directors
do not need to be shareholders of the Company. The Board of Directors shall be appointed by the general meeting.
The general meeting shall determine the term of office of the members of the Board of Directors and the number of
members on the Board of Directors.
The total term of office of a member of the Board of Directors cannot exceed six years. Members of the Board of
Directors may be re-elected. The general meeting may dismiss members of the Board of Directors at any time without
providing grounds. If a member of the Board of Directors leaves during his or her term of office, the remaining members
of the Board of Directors can elect by majority vote a member of the Board of Directors to occupy the vacant position
on the Board of Directors provisionally until the next general meeting.
Art. 12. Meeting of the board of directors. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman.
The first chairman may be appointed by the first general meeting of Shareholders.
55735
L
U X E M B O U R G
The Board of Directors may choose one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a
Director, who shall write and keep the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders. The
Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two Directors, in Luxembourg or as the case may be
from time to time any such other place as indicated in the notice of such meeting.
The chairman shall preside at the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders. In his absence, the
Shareholders or the Directors shall decide by a majority vote that another Director, or in case of a Shareholders' meeting,
that any other person shall be in the chair of such meetings.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours prior
to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing or by cable, e-mail, facsimile
transmission or any other similar means of communication, of each Director. Separate notice shall not be required for
meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting by appointing in writing, by cable, e-mail, facsimile transmission or any other
similar means of communication another Director as his proxy. A Director may represent several of his colleagues.
Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video conference or similar
means of communications equipment complying with technical features which guarantee an effective participation to the
meeting allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an
effective participation of such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at
the registered office of the Company. Each participating Director shall be authorised to vote by video or by telephone.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The Directors may not bind the
Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the Directors are present or
represented.
Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented. In the event that at any meeting
the number of votes for or against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, in his
absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or by any two Directors. Copies of extracts of
such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting
or any two Directors.
Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the board
meetings; each Director shall approve such resolution in writing, by telefax or any other similar means of communication.
Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves that such decision has
been taken.
Art. 13. Powers of the board of directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of disposition, management and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment
policy and investment restrictions as determined in article 16 of these Articles of Incorporation and the Prospectus.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of
Shareholders are in the competence of the Board of Directors.
Art. 14. Corporate signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two
Directors or by the joint or single signature of any officer(s) of the Company or of any other person(s) to whom authority
has been delegated by the Board of Directors.
Art. 15. Delegation of power. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and
affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member of
the Board of Directors, officers or other agents, legal or physical person, who may but are not required to be Shareholders
of the Company, under such terms and with such powers as the Board shall determine and who may, if the Board of
Directors so authorizes, sub-delegate their powers.
The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any person, and may, in particular appoint
any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any other officers that the Company
deems necessary for the operation and management of the Company. Such appointments may be cancelled at any time
by the Board of Directors. The officers need not be Directors or Shareholders of the Company. Unless otherwise
stipulated by these Articles of Incorporation, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the
Board of Directors.
Furthermore, the Board of Directors may create from time to time one or several committees composed of Directors
and/or external persons and to which it may delegate powers as appropriate.
The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 16. Investment policy and Investments restrictions. The Board of Directors shall determine the Company’s in-
vestment policy, the hedging strategies for the Company’s net assets, and the other principles to be applied during the
55736
L
U X E M B O U R G
course of management of the Company and the conduct of its operations in accordance with the principle of risk-
spreading, the applicable statutory and regulatory provisions, and the provisions of the Prospectus.
Art. 17. Investment manager / Investment advisor / Investor advisory board. The Board of Directors has the power
to delegate management of the Company’s assets to one or more investment managers. The investment manager shall
make its decisions regarding the purchase and sale of the Company’s assets on the basis of a written agreement in
accordance with the Company’s investment policy as laid down in Article 16 of these articles of incorporation and under
the overall supervision of the Board of Directors.
The investment manager has the right to avail itself of the assistance of third parties in the performance of the aforesaid
duties, in particular by appointing a marketing consultant.
During management of its assets, the Company has the right to use the services of an investment advisor whose
investment recommendations are not binding on the Company.
The legal relationships between the Company and the investment advisor shall be governed by the provisions of the
respective service agreements taking into account the related provisions in the Prospectus.
The Company intends to establish an Investor Advisory Board (IAB). The IAB shall consist of a reasonable number of
voting members selected from i. e. the ranks of the shareholders, the Investment Manager (not an exhaustive list). The
Board of Directors shall appoint the members of the IAB taking into account the size of the capital commitments. The
duties and powers of the IAB shall be governed by the provisions of the Prospectus and the Rules of Procedure of the
IAB.
Art. 18. Conflict of interests. Any kind of conflict of interest is to be fully disclosed to the Board of Directors. The
Company will enter into all transactions on an arm’s length basis.
The Directors of the Company, the Directors of the Investment Manager and any affiliate thereof, its members and
staff may engage in various business activities other than the Company’s and/or the Investment Manager’s business,
including providing consulting and other services (including, without limitation, serving as director) to a variety of part-
nerships, corporations and other entities, not excluding those in which the Company invests. However, the Directors of
the Company, the directors of the Investment Manager and its members will devote the time and effort necessary and
appropriate to the business of the Company. The Directors of the Company, the directors of the Investment Manager
and any affiliate thereof, its members and staff may also invest and trade for their own accounts. Because the Directors
of the Company and the directors of the Investment Manager, the members and affiliates of the Investment Manager can
have other accounts managed by them, the interests of the Company and other accounts, in the selection, negotiation
and administration of investments, may conflict. Although it is aimed to avoid such conflicts of interest, the Directors,
the Investment Manager and its members will attempt to resolve all nonetheless arising conflicts in a manner that is
deemed equitable to all parties under the given circumstances.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate,
officer or employee of, such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a director,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting
upon any matters with respect to such contract or other business.
Any Director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that
of the Company shall advise the Board of Directors thereof and cause a record of his statement to be included in the
minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any
other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the Directors may have
had an interest conflicting with that of the company.
The provisions of the preceding paragraph are not applicable when the decisions of the Board of Directors of the
Company or of the Director concern day-to-day operations engaged in normal conditions.
Art. 19. Indemnification of directors. The Company may indemnify any Director or officer and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its
request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence, fraud or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only
in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty.
The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
55737
L
U X E M B O U R G
Title IV. – General meetings
Art. 20. Powers of the general meeting. The general meeting can decide on all Company matters. The power to make
the following decisions in particular is reserved to the general meeting:
(a) appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the auditor, and the determination of their
compensation;
(b) approval of the annual financial statements;
(c) formal approval of the actions of the Board of Directors;
(d) appropriation of net income for the year (taking into account the advance distributions already paid out by the
Board of Directors);
(e) Amendments to the Articles of Incorporation;
(f) Dissolution and liquidation of the Company.
Resolutions pertaining to issues listed under article 20 (e) and article 20 (f), and with respect to the dismissal of
members of the Board of Directors shall require the approval of a minimum of 75% of the votes cast and may be adopted
only when at least 50% of the outstanding shares of the Company are represented at the General Meeting. This requi-
rement shall not apply when other attendance and majority requirements are mandated by law. These requirements also
do not apply in cases covered by article 26, if the dissolution and liquidation falls under the minimum share capital as
defined in article 6.
Art. 21. The annual general meeting – Other general meetings. The annual general meeting shall be held in accordance
with Luxembourg law on the third Wednesday of May in each year at 11:00 a.m., Central European Time, at a location
in Luxembourg stated in the convening notice.
If this day is not a Business day, the annual general meeting shall be held on the following Business day. The annual
general meeting may be held outside Luxembourg if the Board of Directors determines at its own discretion that this is
necessary due to force majeure.
Other general meetings can be held at such places and times as indicated in the corresponding convening notice.
Art. 22. Quorum, Voting and Convening of meetings. Unless otherwise provided for in these articles of incorporation,
the general meeting must be conducted in accordance with statutory provisions. Each share shall entitle the holder to
one vote regardless of the net asset value per share.
The convening notices for general meetings shall be sent to shareholders by registered mail at the last address recorded
in the share register.
A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person (who need not be a shareholder) as its
proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed, allowing another shareholder or person to act as his or her representative.
Unless provided otherwise by the law or these articles of incorporation, the decisions of the duly convened general
meeting shall be adopted by a simple majority of the votes cast by shareholders in attendance or represented. Shareholders
can participate in a general meeting through teleconferencing or similar communications media, provided the persons
participating in such way can be identified, and all participants in the meeting can hear each other and talk to each other
at all times. The shareholders who attend a general meeting in this way are considered to be present within the meaning
of the provisions above.
General meetings shall be convened by the Board of Directors. They can also be requested by shareholders holding
shares representing at least 10 per cent or more of the share capital. If the general meeting is not held within one month
of a request, the shareholders holding shares representing 10 per cent or more of the share capital can request the
appointment of an authorized representative by the President of the Commercial Chamber of the Luxembourg District
Court, which will then convene the general meeting. The general meeting must be convened in accordance with statutory
provisions.
Shareholders holding shares representing 10 per cent or more of the share capital also have the right to submit further
items for addition to the agenda by means of registered letter up to five days before the convened general meeting will
be held.
A general meeting may take place without a written convening notice if all the Company’s shareholders are present
or represented and consider themselves as being duly convened and duly informed of the agenda of the meeting.
Title V. – Closing provisions
Art. 23. Financial year. The first financial year shall begin on the day the Company is incorporated and end on 31
December 2012. All subsequent financial years will begin on 1 January and end on 31 December of each year.
Art. 24. Distribution policy. The appropriation of net income for the year for the Fund shall be determined by the
General Meeting based on a proposal by the Board of Directors.
Information on the nature of the distribution must be provided. All General Meeting resolutions relating to dividends
must be adopted in accordance with the procedures stipulated in these Articles of Incorporation.
55738
L
U X E M B O U R G
The principles of the distribution will be determined in the Prospectus.
In general, the income of the Company is not reinvested. Excepted from this reinvestment ban are
(i) proceeds up to the amount of the costs to be paid by the Company from the capital contributions as well as
(ii) amounts utilised to fulfil a potential over commitment strategy. If these excluded reinvestment-ban proceeds are
initially distributed, they will then increase the capital commitments yet to be called.
In general, the Company distributes its free liquidity as soon as possible after it has been received. In determining the
amount to be distributed, attention must be paid to there being an appropriate liquidity reserve from which the Company
can pay its costs and expenses. The Board of Directors, at its discretion, can adopt a resolution that no distribution shall
be made.
No distribution can be made when, as a result of such a distribution, the share capital of the Company will fall below
the minimum equal to a capital of EUR 1,250,000 prescribed by law.
The Board of Directors, at its discretion, can adopt a resolution for the Company to recall for reinvestment for the
account of the Fund, capital it returned during a distribution up to the amount of the original capital commitment.
As soon as the Board of Directors becomes aware that the distributed amounts could be subject to a recall at the
time of the distribution, within a commercially-reasonable period of time, it will inform investors by post, or other suitable
electronic means of communication, that at the time of the distribution there is a possibility of a capital recall.
The Board of Directors can decide to pay interim distributions in accordance with statutory provisions. Resolutions
on interim distributions shall not require a resolution by the General Meeting.
Distribution payments to owners of registered shares are sent to the addresses listed in the shareholders register and,
to the bank account, if any, listed therein.
Distributions shall be paid in USD and will be paid out on a date and at a location to be determined by the Board of
Directors at the appropriate time.
Art. 25. Auditors. The Board of Directors shall arrange for the preparation of an annual report.
This report shall include the balance sheet, the accounts classified by income and expenses for the financial year in
question, and the report on business operations during the financial year.
The accounting data in the Company’s annual report shall be examined by an auditor (“réviseur d’entreprises agréé”).
The auditor shall be appointed by the shareholders’ meeting and the fees for auditing paid by the Company. The auditor
must comply with all duties within the meaning of the Luxembourg Law of 2007.
Art. 26. Dissolution and Liquidation of the company. The Company can be dissolved at any time by resolution of the
general meeting subject to the conditions required for amendments to the articles of incorporation.
If the capital of the Company falls below two-thirds of the Company’s minimum capital stipulated in article 6 of these
articles of incorporation, the Board of Directors shall submit the issue of dissolution to the general meeting. In this case,
the general meeting may decide the issue without a quorum and adopt its resolution with a simple majority of the votes
cast.
If the capital of the Company falls below one-quarter of the Company’s minimum capital stipulated in article 6 of these
articles of incorporation, the Board of Directors shall submit the issue of dissolution to the general meeting, which shall
decide the issue without being subject to the quorum requirement. The resolution shall require approval by one-quarter
of the voting shares represented at the general meeting. The general meeting must be convened early enough to allow
it to be held within forty days after the day on which it was determined that the net assets of the Company had fallen
below two-thirds or below one-quarter of the legal minimum, as the case may be.
The liquidation shall be carried out by one or more liquidators, who may be natural or legal persons. The general
meeting shall appoint the liquidators and determine their powers and compensation. The appointment of the liquidators
must be approved by the regulatory agency. In the event of dissolution, the liquidator(s) shall realize the assets of the
Company in the interests of the shareholders, and, based on instructions from the liquidator(s), the depository bank shall
distribute the net liquidation proceeds (after deduction of all liquidation costs) to the shareholders in proportion to their
respective rights. In accordance with Luxembourg law, liquidation proceeds for shares that are not submitted for re-
demption shall be held in custody by the Caisse de Consignation for a period of 30 years after completion of the liquidation.
Art. 27. Custodian. To the extent required by law, the Company shall enter into a custodian bank agreement with a
bank. The scope of the duties to be performed by the Custodian is defined by the Luxembourg Law of 2007.
The Custodian or the Company’s Board of Directors may terminate the custodian agreement by giving three months’
notice. The Custodian shall make every effort to safeguard the shareholders’ interests during this period. The Custodian’s
duties under the custodian agreement shall continue until the Board of Directors appoints a successor.
Art. 28. Amendment of the articles of incorporation. The articles of incorporation may be amended by resolution of
the general meeting. The amendment resolution is subject to the provisions of the Luxembourg Law of 1915 and the
Luxembourg Law of 2007.
Art. 29. Jurisdiction. The place of performance shall be the registered office of the Company.
55739
L
U X E M B O U R G
The competent court in the Grand Duchy of Luxembourg shall have jurisdiction in the event of legal disputes between
the shareholders and the Company. The Company has the right to submit to the law and jurisdiction of other countries
in which the shares are distributed if investors resident there assert claims against the Company with respect to the
purchase of shares.
Art. 30. Applicable law. All matters not governed by these Articles of Incorporation and the Prospectus shall be
governed by the provisions of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies and the Luxembourg
Law of 2007, as such laws have been or may be amended from time to time.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and will end on 31 December 2012.
The first annual general meeting will be held on the 15
th
May 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., above named, represented as stated above, subscribes all the four
hundred ten (410) newly issued shares.
All these Shares are fully paid up in cash, so that the amount of forty-one thousand USD (USD 41.000) is forthwith at
the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26, 26-3 and 26-5 of the Companies
Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms
that these Articles comply with the provisions of article 27 of the Companies Act.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of formation are estimated at approximately three thousand five hundred euro (EUR 3,500).
<i>Extraordinary general meeting of shareholdersi>
The above named appearing party, representing the entire subscribed capital and acting as sole Shareholder of the
Company immediately takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are elected as Directors for a period ending on the date of the annual general meeting of
Shareholders to be held in 2015:
1. Mr Thomas Schlaus, Hardstrasse 201, 8005 Zurich, Switzerland;
2. Mr Stefan Molter, Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln, Deutschland;
3. Mr Andreas Jockel, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
4. Mr Alfons Klein, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The chairman of the Board of Directors shall be Mr Thomas Schlaus.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the Company is established at 4, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The following is elected as independent auditor for a period ending on the next annual general meeting of Shareholders
to be held in 2013:
KPMG Luxembourg S.à.r.l., with its registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 103.590.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the proxyholder of
the appearing party, this deed is worded in English.
Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, on the date named at the beginning of
this document.
All these shares have been fully paid up by the shareholders by payment in cash, so that the sum of USD 41,000.- paid
by the shareholders is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the
officiating notary.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the
notary the present original deed.
55740
L
U X E M B O U R G
Signé: R. KRENZ, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 26 avril 2012. Relation: RED/2012/561. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé) T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 27 avril 2012.
M
e
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012052229/622.
(120072528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Living Planet Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 93.908.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 28 avril 2011i>
- Sont réélus au conseil d'administration pour le terme de six ans:
* Monsieur André Hoffmann, président
* Monsieur Chiew Y. Chong, Administrateur
* Monsieur Eric G. Sarasin, Administrateur
- Est réélu réviseur d'entreprises agrée pour le terme de six ans PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2011.
Référence de publication: 2012052114/15.
(120072869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Living Planet Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 93.908.
<i>Extrait des résolutions prises par l‘ assemblée générale du 29 avril 2010i>
Sont réélus au conseil d’administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2011:
- Monsieur André Hoffmann
- Monsieur Eric G. Sarasin,
- Monsieur Chiew Y. Chong
Est réélu réviseur d’entreprises agréé pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2011:
- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2011.
Living Planet Fund Management Company S.A.
Référence de publication: 2012052115/17.
(120072869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.
Asset Backed-D S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 137.744.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of March,
before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Asset Backed-D S.A., a société anonyme governed
by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
(the “Company”), having been incorporated following a deed of the undersigned notary, dated 8 April 2008, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1158 of 13 May 2008, and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 137.744. The articles of incorporation have not been amended.
The meeting is declared open by Me Hermann Beythan, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the chair,
who appointed Me Claire Prospert, lawyer, with professional address in Luxembourg, as secretary.
The meeting elected Me Analia Clouet, lawyer, with professional address in Luxembourg, as scrutineer.
55741
L
U X E M B O U R G
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman called upon the notary to record that:
(i) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1 To fully restate article 7 of the articles of incorporation of the Company relating to the board of directors of the
Company.
2 To fully restate article 8 of the articles of incorporation of the Company relating to the meetings of the board of
directors of the Company.
3 To amend article 9 first paragraph of the articles of incorporation of the Company relating to the minutes of meetings
of the board of directors of the Company.
4 To amend article 10 first paragraph of the articles of incorporation of the Company relating to the powers of the
board of directors of the Company.
5 To set the date of the annual general meeting of the shareholders on the twentieth (20
th
) day of February at 11:00
a.m. and to amend article 15, first paragraph of the articles of incorporation of the Company to reflect the change of the
date of the annual general meeting of the shareholders.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialed “ne varietur” by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) The whole corporate capital is represented at the present meeting and all the shareholders present or represented
declare that they have been duly informed on all items of the above agenda prior to the meeting and that they waive the
convening notice.
(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to fully restate article 7 of the articles of incorporation of the Company relating to the
Board of Directors which shall from now on read as follows:
“ Art. 7.
7.1. Board of Directors.
The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be
shareholders.
The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a period
not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.
In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the
remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the shareholders
confirm the election at their next general meeting.
Subject to approval by the general meeting of shareholders, the Directors may receive a remuneration in respect of
the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses what-
soever incurred by the Directors in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's
corporate object.
7.2. Indemnification of Directors.
Subject to the provisions of and to the extent permitted by the Articles, every director or other officer (excluding an
auditor) of the Company, their successors, heirs and executors, shall be indemnified out of the assets of the Company
against any liability incurred by him in the actual or purported execution or discharge of his duties or the exercise or
purported exercise of his powers or otherwise in relation to or in connection with his duties, powers or office, but:
(a) this indemnity shall not apply to any liability to the extent that it is recovered from any other person;
(b) the indemnity is subject to such officer taking all reasonable steps to effect such recovery, so that the indemnity
shall not apply to the extent that an alternative right of recovery is capable of being enforced;
(c) the indemnity shall not apply to matters as to which the person concerned shall be finally adjudged to be liable for
gross negligence or misconduct; and
(d) this clause shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified may be entitled.”
55742
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to fully restate article 8 of the articles of incorporation of the Company relating to the
meetings of the board of directors of the Company which shall from now on read as follows:
“ Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a chairman.
It may also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors and of the general meeting of shareholders.
Subject to the provisions of these Articles, the board may regulate its proceedings as it thinks fit, provided that no
meeting of the board or committee meetings shall be held in the United Kingdom, the United States of America or
Germany and not less than 3 (three) board meetings are held annually in Luxembourg. No decision of the board can be
taken in the United Kingdom, the United States of America or Germany and any such meeting which is purported to be
held or any such decisions which are purported to be taken in the United Kingdom, the United States of America or
Germany shall be void.
The board of directors shall meet upon convocation by the chairman. A meeting of the board must be convened if any
two directors so require.
The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of directors, but in
his absence the general meeting of shareholders or the board will appoint another director as chairman pro tempore of
such general meeting of shareholders or meeting of the board of directors by a majority vote of those present at the
general meeting of shareholders respectively the meeting of the board of directors.
Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter, fax or any other electronic means
approved by the board of directors to all directors at least 48 hours in advance of the day set for such meeting, except
in circumstances of emergency, in which case the nature of such emergency will be set forth in the notice of meeting.
The notice shall indicate the place and agenda for the meeting.
Each director may waive this notice by his consent in writing or by cable, telex, fax or any other electronic means
approved by the board of directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
The quorum for board meetings shall be at least half of the directors present or represented and shall not include a
majority of directors who are residents of the United Kingdom, the United States of America or Germany for tax pur-
poses.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing
or by cable, telex, fax or any other electronic means approved by the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
Without prejudice to the second and seventh sentence of this Article 8, a person entitled to be present at a meeting
of the board or of a committee of the board shall be deemed to be present for all purposes if he is able (directly or by
electronic means) to speak to and be heard by all those present or deemed to be present simultaneously, provided that
he is not actually present in the United Kingdom, the United States of America or Germany at that time. A director so
deemed to be present shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed
to take place where it is convened to be held or (if no director is present in that place) where the largest group of those
participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of the meeting is.
A resolution in writing executed by all the directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting
of the board or (as the case may be) a committee of the board duly convened and held. For this purpose:
(a) a resolution may be in hard copy form or in electronic form sent to the registered office;
(b) a resolution may consist of several documents in hard copy form or electronic form, each executed by one or
more directors, or a combination of both; and
(c) a resolution must be executed by a majority of the directors outside the United Kingdom, the United States of
America and Germany.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to amend article 9, first paragraph of the articles of incorporation of the Company
relating to the minutes of the meetings of the board of directors of the Company.
Article 9, first paragraph shall from now on read as follows:
“ Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors will be
signed by the chairman of the meeting and by any other director or the company secretary. The proxies will remain
attached thereto.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolved to amend article 10, first paragraph of the articles of incorporation of the Company
relating to the powers of the board of directors of the Company.
Article 10, first paragraph shall from now on read as follows:
55743
L
U X E M B O U R G
“ Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform
all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the
present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders are within the competence of the board of
directors.”
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolved to set the date of the annual general meeting of the shareholders on the twentieth (20
th
) day of February at 11:00 a.m..
The general meeting resolved to amend article 15, first paragraph, of the articles of incorporation to reflect the change
of the date of the annual general meeting of the shareholders, which article 15, paragraph 1, will from now on read as
follows:
" Art. 15. Annual General Meeting. The Annual general meeting shall be held at the registered office of the Company
or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the twentieth (20
th
) day of February
at 11:00 a.m.”
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at EUR 1,500.-.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Asset Backed-D S.A., une société anonyme régie
par le droit luxembourgeois, avec siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
(la «Société») constituée par acte du notaire soussigné, en date du 8 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1158 en date du 13 mai 2008 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 137.744. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.
L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Me Hermann Beythan, avocat à la Cour, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Me Claire Prospert, avocat, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Analia Clouet, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1 Refonte complète de l'article 7 des statuts de Société relatif au conseil d'administration.
2 Refonte complète de l'article 8 des statuts de la Société relatif aux réunions du conseil d'administration.
3 Modification de l'article 9, premier alinéa des statuts de la Société relatif aux procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration.
4 Modification de l'article 10, premier alinéa des statuts de la Société relatif aux pouvoirs du conseil d'administration.
5 Fixation de la date de l'assemblée générale des actionnaires au vingtième (20
ème
) jour du mois de février à 11:00
heures et modification de l'article 15, premier alinéa, des statuts de la Société, afin de rendre compte de la modification
de la date de l'assemblée générale des actionnaires.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées «ne varietur» par les comparants
resteront pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.
55744
L
U X E M B O U R G
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de refondre complètement l'article 7 des statuts de la société relatif au conseil d'admi-
nistration qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 7.
7.1. Conseil d'administration.
La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,
il pourra être pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans
ce cas, les actionnaires confirmeront la nomination à leur prochaine assemblée générale.
Sous réserve de approbation par l'assemblée générale des actionnaires, les administrateurs pourront percevoir une
rémunération dans le cadre de l'activité de gestion de la Société et pourront, de surcroît, obtenir le remboursement de
tous les frais engagés par les administrateurs.
7.2. Indemnisation des administrateurs.
Sous réserve des dispositions des présents Statuts et dans la limite permise par ces derniers, chaque administrateur
ou autre personne responsable (à l'exception du réviseur) de la Société, leurs successeurs, héritiers, et exécuteurs tes-
tamentaires, sera indemnisée par prélèvement sur les actifs de la Société pour toute responsabilité encourue par ce
dernier dans l'exécution réelle ou supposée, ou la décharge de ses fonctions, l'exercice ou le supposé exercice de ses
pouvoirs ou sinon en relation ou en connexion avec ses devoirs, pouvoirs ou sa fonction, cependant:
(a) cette indemnité ne s'appliquera pas à une dette dans la mesure où cette dernière est recouverte auprès de toute
autre personne;
(b) l'indemnité n'est due que si la personne responsable a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir un tel
recouvrement, de sorte que l'indemnité ne pourra s'appliquer tant qu'un droit de recouvrement alternatif peut être mis
en œuvre;
(c) l'indemnité ne trouvera pas application dans les situations pour lesquelles l'intéressé sera définitivement tenu res-
ponsable de négligence grave ou de mauvaise conduite; et
(d) cette clause n'exclura pas tous les autres droits à indemnisation dont les personnes pourraient être bénéficiaires.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de refondre complètement l'article 8 des statuts de la Société relatif aux réunions du
conseil d'administration qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 8. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président.
Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires.
Sous réserve des dispositions des présents Statuts, le conseil d'administration peut déterminer les procédures le
concernant qu'il juge appropriées pourvu qu'aucune réunion du conseil d'administration ou d'un comité ne se tienne au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne et qu'il n'y ait pas au cours d'une même année moins de trois (3) réunions
du conseil d'administration se tenant au Luxembourg. Aucune décision du conseil d'administration ne peut être prise au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne et toute réunion présumée être tenue ou toute décision présumée être
prise au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne sera frappée de nullité.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si
deux administrateurs le demandent.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d'adminis-
tration, mais en son absence l'assemblée générale des actionnaires ou le conseil d'administration désignera temporaire-
ment à la majorité des actionnaires respectivement des administrateurs présents un autre administrateur pour présider
l'assemblée générale des actionnaires ou la réunion.
Avis écrits de toute réunion du conseil d'administration seront donnés par lettre, télécopieur ou tout autre moyen
électronique approuvé par le conseil d'administration à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue
pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation
de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par télex,
par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d'administration de chaque administrateur.
55745
L
U X E M B O U R G
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Le quorum des réunions du conseil d'administration est fixé à la moitié au moins des administrateurs présents ou
représentés et n'inclura pas une majorité d'administrateurs résidents fiscaux du Royaume-Uni, des Etats-Unis ou d'Alle-
magne.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par
câble, par télex ou par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d'administration un
autre administrateur comme son mandataire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Sans préjudice des dispositions de la seconde et de la septième phrase du présent Article 8, une personne dont la
présence est admise à une réunion du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration est réputée
être présente à toutes fins si elle est capable (directement ou par voie électronique) de parler et d'être entendue de
façon simultanée par toutes personnes présentes ou réputées être présentes, à la condition qu'elle ne soit en réalité pas
physiquement à ce moment là présente au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Allemagne. Un administrateur ainsi réputé
présent est autorisé à voter et par conséquent est pris en compte dans le calcul du quorum. Une telle réunion est réputée
avoir lieu à l'endroit spécifié dans la convocation ou (si aucun administrateur n'est présent à un tel lieu) là où le groupe
le plus important de participants est réuni, ou, s'il n'existe pas de groupe, là où le président de la réunion se trouve.
Une résolution écrite signée par l'ensemble des administrateurs est valable et exécutoire de la même façon que si elle
avait été adoptée lors d'une réunion du conseil d'administration ou (le cas échéant) d'un comité du conseil d'administration
dûment convoquée et tenue. A cette fin:
(a) une résolution peut être émise sous forme papier ou sous forme électronique envoyée au siège social;
(b) une résolution peut se composer de plusieurs documents sous forme papier ou sous forme électronique, chaque
document étant signé par un ou plusieurs administrateurs, ou une combinaison des deux; et
(c) une résolution doit être signée par la majorité des administrateurs en dehors du Royaume-Uni, des Etats-Unis et
de l'Allemagne.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 9, premier alinéa des statuts de la Société relatif aux procès verbaux
des réunions du conseil d'administration de la Société.
L'article 9, premier alinéa sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil
d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur ou par le secrétaire de la
Société. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 10, premier alinéa des statuts de la société relatifs aux pouvoirs du
conseil d'administration.
L'article 10, premier alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 10. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de fixer la date de l'assemblée générale des actionnaires le vingtième (20
ème
) jour du
mois de février à 11:00 heures.
L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 15, premier alinéa, des statuts de la Société, afin de rendre compte
de la modification de la date de l'assemblée générale des actionnaires, lequel article 15, premier alinéa, sera dorénavant
rédigé comme suit:
« Art. 15. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel
autre endroit indiqué dans les avis de convocation le vingtième (20
ème
) jour du mois de février de chaque année à 11:00
heures.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à EUR 1.500,-.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
55746
L
U X E M B O U R G
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: H. BEYTHAN, C. PROSPERT, A. CLOUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2012. Relation: LAC/2012/13688. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040091/300.
(120053538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Hansainvest Trust S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 156.308.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 3 avril 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012040252/11.
(120053660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Emilion Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 167.871.
STATUTS
L'an deux mille douze, le deux mars.
par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette,
A comparu:
Monsieur Jean-François FOURTOU, artiste, né le 30 avril 1964 à Paris, demeurant à Dar el Sadaka, BP 2415 Gueliz,
40000 Marrakech (Maroc), représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, avec adresse pro-
fessionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, et en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée laquelle
procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui,
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit, les
statuts d'une société à responsabilité limité, qu'il constitue, à savoir:
Titre I
er
. - Objet - Raison social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participation dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que
l'administration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. La société peut notamment détenir des intérêts dans
Emilion S.C.A., une société en commandite par actions et agir en qualité de gérant de cette société. La société n'exercera
pas directement une activité industrielle propre ni ne maintiendra un établissement commercial ouvert au public. D'une
manière générale, la société pourra effectuer toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement
de son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de " EMILION MANAGEMENT S.à.r.l.".
Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg en vertu d'une décision prise à l'assemblée générale des associés.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés. Si des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée
55747
L
U X E M B O U R G
de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l'étranger jusqu'à cessation de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société pourra établir tout siège d'activité secondaire, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, que
son activité rendra nécessaire.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Elle pourra être dissoute avec l'accord des associés représentant les trois quarts du capital social.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) divisé en 1.250 (mille deux
cent cinquante) parts sociales de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que
des bénéfices.
Art. 9. Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint d'un associé. Elles ne peuvent être
cédées entre vifs ou pour cause de mort à toutes autres personnes que moyennant l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Sauf en cas de cession entre associés ou au
profit du conjoint d'un associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans un délai de
trente jours à partir de la date de refus de la cession à une personne au profit de laquelle les parts ne sont pas librement
cessibles.
Toute cession de parts devra être constatée par acte notarié ou sous seing privé. Dans le dernier cas elle n'est
opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été signifié à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, de catégorie A et par un ou plusieurs
gérants associés ou non, de catégorie B.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire et autoriser les actes et opération relatifs à son objet.
Le ou les gérants de catégorie A ou B sont nommés pour une durée indéterminée.
En cas d'empêchement du ou des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés collectivement.
La société est valablement représentée et engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant
de catégorie B.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent,
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale et obligatoire jusqu'à
ce que celui-ci atteint dix pour cent du capital social.
55748
L
U X E M B O U R G
Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commence ce jour et finit le trente-et-un décembre 2012.
<i>Souscriptioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
Monsieur Jean-François FOURTOU, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Total: mille deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de EUR 12.500,- (douze mille
cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à mille trois cents euros (€ 1.300,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social s'est réunis en assemblée générale et à la l'unanimité
des voix ils ont prix les résolutions suivantes:
La société est administrée par un ou plusieurs gérants de catégorie A et par un gérant de catégorie B.
1.- Est nommé gérant de la catégorie A pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-François FOURTOU, prénommé.
En cas de décès du gérant de la catégorie A, il sera remplacé par:
- Monsieur Julien FOURTOU, et en cas de décès de ce dernier, il sera remplacé par:
- Monsieur Jean-René FOURTOU
2.- Est nommé gérant de la catégorie B pour une durée indéterminée:
- S.G.A. Services S.A., Société Anonyme, ayant son siège social 39, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, R.C. Luxembourg
B. No 76.118,
La signature de l'un des gérants de catégorie A devra être accompagnée de celle du gérant de catégorie B pour
représenter valablement la société.
3. Le siège social de la Société est établi à: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 mars 2012. Relation: EAC/2012/3289. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012040203/126.
(120053604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Diversified Growth Company en abrégé D.G.C., Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 7.565.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 3 avril 2012 a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Marc
Hoegger, Pierre-Yves Augsburger, Théo Limpach et Paolo Faraone en tant que membres du conseil d'administration de
Diversified Growth Company (D.G.C.).
55749
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration se compose dès lors comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale
ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013:
- Théo Limpach
23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg
- Marc Hoegger
98 rue de Saint Jean, CH-1201 Genève
- Pierre-Yves Augsburger
74 Grand Rue, L-1660 Luxembourg
- Paolo Faraone
74 Grand Rue, L-1660 Luxembourg
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, précédemment audit & compliance s.à r.l.,
a été élu comme réviseur d'entreprises et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Georges Beckene
Référence de publication: 2012042540/26.
(120056460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
BLK BR HY (Luxembourg) Investments, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 42.002,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 165.199.
In the year two thousand and twelve, the thirteenth day of January, before Maître Francis Kesseler, notary residing in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of BLK BR HY (Luxembourg) In-
vestments, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office
at 20, Rue de la Poste L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 165.199 and having a share capital of CAD 42,001.- (the Company). The
Company has been incorporated on August 26, 2011 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing Esch-
sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, in the course of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations. The articles of articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time
on August 30, 2011 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of
Luxembourg, in the course of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
THERE APPEARED:
BlackRock Funds II – High Yield Bond Portfolio, a company incorporated under the laws of the United States of
America, having its registered office at 55 East 52
nd
Street, New York, NY 10055, United States of America (the Sole
Shareholder),
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional address is in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one Canadian Dollar (CAD 1.-) in order to bring the
share capital of the Company from its present amount of forty-two thousand and one Canadian Dollars (CAD 42,001.-),
represented by fortytwo thousand and one (42,001) shares of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each to fortytwo thousand
and two Canadian Dollars (CAD 42,002.-), by way of the issue of one (1) new share of the Company having a par value
of one Canadian Dollar (CAD 1.-) having the same rights and obligations as the existing shares;
2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above by way of a contribution in cash;
3. Subsequent amendment to the article 5.1. of the articles of association of the Company in order to reflect the
increase of the share capital specified under item 1. above;
4. Modification of the financial year of the Company and article 13.1 of the articles of association of the Company;
55750
L
U X E M B O U R G
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company and any employee of Citco Luxembourg, each individually, to proceed
on behalf of the Company with the registration of the newly issued share in the register of shareholders of the Company;
and
6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one Canadian Dollar
(CAD 1.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of forty-two thousand and one
Canadian Dollars (CAD 42,001.-), represented by forty-two thousand and one (42,001) shares of one Canadian Dollar
(CAD 1.-) each to fortytwo thousand and two Canadian Dollars (CAD 42,002.-), by way of the issue of one (1) new share
of the Company having a par value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) having the same rights and obligations as the existing
shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to one (1) new
share having a par value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) and to fully pay up by way of a contribution in cash amounting
to three million and one Canadian Dollars (CAD 3,000,001.-) to be allocated as follows:
- one Canadian Dollar (CAD 1.-) is allocated to the nominal share capital account of the Company, and
- three million Canadian Dollars (CAD 3,000,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.
The amount of three million and one Canadian Dollars (CAD 3,000,001.-) is at the disposal of the Company, as has
been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the article 5.1 of the Articles
in order to reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5.1. The share capital is set at forty-two thousand and two Canadian dollars (CAD 42,002.), represented by
forty-two thousand and two (42,002) shares in registered form, having a nominal value of one Canadian dollar (CAD 1.-)
each.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to modify the financial year of the Company and resolves to amend article 13.1 of the
Articles, so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 13.1. The financial year begins on the first (1) of September and ends on the thirty-first (31) of August of each
year.”
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes and empowers and authorizes any manager of the Company and any employee of Alter Domus Luxembourg,
each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued share in the register of
shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately three thousand euro (€ 3,000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
55751
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le treizième jour du mois de janvier, par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de BLK BR HY (Luxembourg)
Investments, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 20, Rue
de la Poste L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 165.199 et ayant un capital social de CAD 42.001,- (la Société). La Société a été
constituée le 26 août 2011 suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand
Duché de Luxembourg, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les Statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 30 août 2011 suivant un acte de Maître Francis Kesseler,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en cours de publication au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
A comparu:
BlackRock Funds II – High Yield Bond Portfolio, une société régie par les lois des Etats-Unis d’Amérique, dont le siège
social se situe à 55 East 52
nd
Street, New York, NY 10055, Etats-Unis d’Amérique,
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/
Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé,
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. l’Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital de la Société;
II. l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant d’un dollar canadien (CAD 1,-) afin de le porter de son
montant actuel de quarante-deux mille un dollars canadiens (CAD 42.001,-), représenté par quarante-deux mille une
(42.001) parts sociales d’un dollar canadien (CAD 1,-) chacune, à quarante-deux mille deux dollars canadiens (CAD
42.002,-) par l’émission d’une (1) nouvelle part sociale de la Société d’une valeur nominale d’un dollar canadien (CAD
1,-) ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
2. Souscription et libération de l’augmentation de capital telle que mentionnée au point 1. ci-dessus par un apport en
numéraire;
3. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société afin d’y faire figurer l’augmentation du capital social
spécifiée au point 1.
4. Modification de l’exercice social de la Société et de l’article 13.1 des statuts de la Société;
5. Modification du registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société et tout employé de Citco Luxembourg, chacun agissant individuellement, afin
de procéder pour le compte de la Société à l’inscription de la part sociale nouvellement émises dans le registre des
associés de la Société.
6. Divers.
III. l’Associé Unique a pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant d’un dollar canadien (CAD 1,-) afin
de le porter de son montant actuel de quarante-deux mille un dollars canadiens (CAD 42.001,-), représenté par quarante-
deux mille une (42.001) parts sociales d’un dollar canadien (CAD 1,-) chacune, à quarante-deux mille deux dollars
canadiens (CAD 42.002,-) par l’émission d’une (1) nouvelle part sociale de la Société d’une valeur nominale d’un dollar
canadien (CAD 1,-) ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l’augmentation
du capital social de la manière suivante:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits, l’Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à une (1) nouvelle
part sociale d’une valeur nominale d’un dollar canadien (CAD 1.-), et la libère intégralement par un apport en numéraire
d’un montant de trois millions et un dollars canadiens (CAD 3,000,001.-), affecté de la manière suivante:
(i) un montant de un dollar canadien (CAD 1.-) au compte de capital social de la Société; et
(ii) un montant de trois millions dollars canadiens et soixante-trois cents (CAD 3.000.000.-) au compte de prime
d’émission de la Société.
55752
L
U X E M B O U R G
Le montant de trois millions et un dollars canadiens (CAD 3,000,001.-) est à la libre disposition de la Société, preuve
en a été donnée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts pour y faire
figurer les modifications ci-dessus, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5.1. Le capital social est fixé à quarante-deux mille deux dollars canadiens (CAD 42.002,), représenté par
quarante-deux mille deux (42.002) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar canadien
(CAD 1,-) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’exercice social de la Société et décide de modifier l’article 13.1 des Statuts, de
sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 13.1. L’exercice social de la Société commence le premier (1) septembre et prend fin le trente-et-un (31) août
de chaque année.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-
dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et tout employé de Citco Luxembourg, chacun agissant
individuellement, afin de procéder, pour le compte de la Société, à l’inscription de la part sociale nouvellement émise dans
le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ trois mille euros (€ 3.000,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte
original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 janvier 2012. Relation: EAC/2012/1023. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012040129/174.
(120053641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Bimolux S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 43.826.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 2 avril 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Madame Michelle DELFOSSE
aux fonctions d'administrateur de la société et a nommé en remplacement:
- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 2 avril 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 2 avril 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
55753
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 2 avril 2012.
<i>Pour BIMOLUX S.A. –SPF
i>Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2012042477/24.
(120056893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
BLK COY (Luxembourg) Investments, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 42.002,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 164.665.
In the year two thousand and twelve, the thirteenth day of January, before Maître Francis Kesseler, notary residing in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of BLK COY (Luxembourg) Invest-
ments, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at
20, Rue de la Poste L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 164.665 and having a share capital of CAD 42,001.- (the Company). The
Company has been incorporated on August 26, 2011 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing Esch-
sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, in the course of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations. The articles of articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time
on August 30, 2011 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of
Luxembourg, in the course of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
THERE APPEARED:
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc., a company incorporated under the laws of United States of America,
having its registered office at 55 East 52
nd
Street, New York, NY 10055, United States of America (the Sole Shareholder),
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional address is in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one Canadian Dollar (CAD 1.-) in order to bring the
share capital of the Company from its present amount of forty-two thousand and one Canadian Dollars (CAD 42,001.-),
represented by forty-two thousand and one (42,001) shares of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each to forty-two thousand
and two Canadian Dollars (CAD 42,002.-), by way of the issue of one (1) new share of the Company having a par value
of one Canadian Dollar (CAD 1.-) having the same rights and obligations as the existing shares;
2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above by way of a contribution in cash;
3. Subsequent amendment to the article 5.1. of the articles of association of the Company in order to reflect the
increase of the share capital specified under item 1. above;
4. Modification of the financial year of the Company and article 13.1 of the articles of association of the Company;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company and any employee of Citco Luxembourg, each individually, to proceed
on behalf of the Company with the registration of the newly issued share in the register of shareholders of the Company;
and
6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one Canadian Dollar
(CAD 1.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of forty-two thousand and one
Canadian Dollars (CAD 42,001.-), represented by forty-two thousand and one (42,001) shares of one Canadian Dollar
(CAD 1.-) each to forty-two thousand and two Canadian Dollars (CAD 42,002.-), by way of the issue of one (1) new
share of the Company having a par value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) having the same rights and obligations as the
existing shares.
55754
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to one (1) new
share having a par value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) and to fully pay it up by way of a contribution in cash amounting
to one hundred thirty-eight thousand seven hundred fifty-one Canadian Dollars (CAD 138,751) to be allocated as follows:
- one Canadian Dollar (CAD 1.-) is allocated to the nominal share capital account of the Company, and
- one hundred thirty-eight thousand seven hundred fifty Canadian Dollars (CAD 138,750) is allocated to the share
premium account of the Company.
The amount of one hundred thirty-eight thousand seven hundred fifty-one Canadian Dollars (CAD 138,751) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the article 5.1 of the Articles
in order to reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 5.1. The share capital is set at forty-two thousand and two Canadian dollars (CAD 42,002.¬), represented by
forty-two thousand and two (42,002) shares in registered form, having a nominal value of one Canadian dollar (CAD 1.-)
each."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to modify the financial year of the Company and resolves to amend article 13.1 of the
Articles, so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 13.1. The financial year begins on the first (1) of September and ends on the thirty-first (31) of August of each
year."
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes and empowers and authorizes any manager of the Company and any employee of Citco Luxembourg, each
individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued share in the register of
shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le treizième jour du mois de janvier, par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de BLK COY (Luxembourg)
Investments, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 20, Rue
de la Poste L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 164.665 et ayant un capital social de CAD 42.001,- (la Société). La Société a été
constituée le 26 août 2011 suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand
Duché de Luxembourg, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les Statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 30 août 2011 suivant un acte de Maître Francis Kesseler,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en cours de publication au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
A comparu:
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc., une société régie par les lois des Etats-Unis d'Amérique, dont le siège
social se situe à 55 East 52
nd
Street, New York, NY 10055, Etats¬Unis d'Amérique (l'Associé Unique),
55755
L
U X E M B O U R G
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch-
sur-Alzette, Grand-Duché de Luxebourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. l'Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un dollar canadien (CAD 1,-) afin de le porter de son
montant actuel de quarante-deux mille un dollars canadiens (CAD 42.001,-), représenté par quarante-deux mille une
(42.001) parts sociales d'un dollar canadien (CAD 1,-) chacune, à quarante-deux mille deux dollars canadiens (CAD
42.002,-) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale de la Société d'une valeur nominale d'un dollar canadien (CAD
1,-) ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;
2. Souscription et libération de l'augmentation de capital telle que mentionnée au point 1. ci-dessus par un apport en
numéraire;
3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin d'y faire figurer l'augmentation du capital social
spécifiée au point 1;
4. Modification de l'exercice social de la Société et de l'article 13.1 des statuts de la Société;
5. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société et tout employé de Citco Luxembourg, chacun agissant individuellement, afin
de procéder pour le compte de la Société à l'inscription de la part sociale nouvellement émises dans le registre des
associés de la Société.
6. Divers.
III. l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un dollar canadien (CAD 1,-) afin
de le porter de son montant actuel de quarante-deux mille un dollars canadiens (CAD 42.001,-), représenté par quarante-
deux mille une (42.001) parts sociales d'un dollar canadien (CAD 1,-) chacune, à quarante-deux mille deux dollars
canadiens (CAD 42.002,-) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale de la Société d'une valeur nominale d'un dollar
canadien (CAD 1, -) ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation
du capital social de la manière suivante:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits, l'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare qu'il souscrit à une (1) nouvelle
part sociale d'une valeur nominale d'un dollar canadien (CAD 1,-), et la libère intégralement par un apport en numéraire
d'un montant de cent trente-huit mille sept cent cinquante-et-un dollars canadiens (CAD 138.751), devant être affecté
de la manière suivante:
(i) un montant de un dollar canadien (CAD 1,-) au compte de capital social de la Société; et
(ii) un montant de cent trente-huit mille sept cent cinquante dollars canadiens (CAD 138.750) au compte de prime
d'émission de la Société.
Le montant de cent trente-huit mille sept cent cinquante-et-un dollars canadiens (CAD 138.751) est à la libre dispo-
sition de la Société, preuve en a été donnée au notaire instrumentant qui le reconnait expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts pour y faire
figurer les modifications ci-dessus, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5.1. Le capital social est fixé à quarante-deux mille deux dollars canadiens (CAD 42.002,¬), représenté par
quarante-deux mille deux (42.002) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar canadien
(CAD 1,-) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société et décide de modifier l'article 13.1 des Statuts, de
sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 13.1. L'exercice social débute le premier (1) septembre et prend fin le trente-et-un août (31) août de chaque
année.»
55756
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-
dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et tout employé de Citco Luxembourg, chacun agissant
individuellement, afin de procéder, pour le compte de la Société, à l'inscription de la part sociale nouvellement émise dans
le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ mille cinq cents euros (€ 1.500,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-AIzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte
original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 janvier 2012. Relation: EAC/2012/1032. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012040130/175.
(120053640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Eurolux Creations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 37, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 167.880.
STATUTS
L'an deux mille douze,
le vingt-trois mars.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
1.- Monsieur Vitor Manuel MAROCO RIBEIRO, employé privé, né à Vila Franca de Xira (Portugal), le 08 janvier 1971,
demeurant au 20 rue Marie-Louise Tidick-Ulveling, L-2619 Luxembourg.
2.- Madame Maria Arminda RIBEIRO NETO, commerçante, née à Monte Cordova (Portugal), le 19 septembre 1962,
demeurant au 20 rue Marie-Louise Tidick-Ulveling, L-2619 Luxembourg.
Lesquels comparants, ici personnellement présents, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée qu'il déclarent constituer entre eux par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal l'importation et l'exportation d'articles pour fumeurs, de souvenirs et divers
autres articles de la branche.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'ac-
complissement.
La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «EUROLUX CREATIONS S.à r.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
55757
L
U X E M B O U R G
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par
cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par les associés ci-après, comme suit:
1.- Monsieur Vitor Manuel MAROCO RIBEIRO, prénommé, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .
75
2.- Madame Maria Arminda RIBEIRO NETO, prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) se trouve dès maintenant à
la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de son objet social.
La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont
plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale
extraordinaire des associés.
Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
55758
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l'article dix-sept (17) qui précède, l'année sociale commence aujourd'hui-même pour finir le 31
décembre 2012.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions
1.- Le siège social de la société est établi au 37 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
2.- Est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Maria Arminda RIBEIRO NETO, commerçante, née à Monte Cordova (Portugal), le 19 septembre 1962,
demeurant au 20 rue Tidick-Ulveling, L-2619 Luxembourg.
3.- Est nommée gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Vitor Manuel MAROCO RIBEIRO, employé privé, né à Vila Franca de Xira (Portugal), le 08 janvier 1971,
demeurant au 20 rue Marie-Louise Tidick-Ulveling, L-2619 Luxembourg.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) gérants.
4.- Les gérants prénommés pourront nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révo-
quer.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la partie constituante sur la nécessité
d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme
objet social à l'article deux des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Helmsange/Walferdange (Grand-Duché de Luxembourg), les jours, mois et an qu'en tête des
présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec
Nous le notaire le présent acte.
Signé: V. M. MAROCO RIBEIRO, M. A. RIBEIRO NETO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 mars 2012. Relation: EAC/2012/3998. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
Référence de publication: 2012040204/129.
(120053726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
55759
L
U X E M B O U R G
Gaïa Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 151.809.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 1
er
avril 2012 que:
1. La démission de Tamas HORVATH, en tant que administrateur de type A, a été acceptée avec effet immédiat.
Le Conseil d'administration se compose dès lors comme suit:
<i>Administrateur de type A:i>
- Philippe SALPETIER;
<i>Administrateur de type B:i>
- Marjorie ALLO;
- Robert BLAIN;
- Kess VAN RAVENHORST.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 5 avril 2012.
Référence de publication: 2012042016/20.
(120055726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2012.
Hekuba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 127.136.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040249/10.
(120053708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Vontobel Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 78.142.
AUSZUG
Anlässlich der am 3. April 2012 abgehaltenen Generalversammlung wurde beschlossen,
- Axel Schwarzer
- Dr. Martin Sieg Castagnola
- Dominic Gaillard
- Remigio Luongo
als Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Generalversammlung im Jahre 2013 wiederzuernennen.
Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Rücktritt von
- Roger Studer
- Peter Fanconi
mit Wirkung ab dem 3. April 2012.
Anlässlich der Generalversammlung vom 3. April 2012 wurde zudem beschlossen,
- Carmen Lehr
mit beruflicher Adresse in 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg per 3. April 2012 als Verwaltungsratsmitglied
für das laufende Geschäftsjahr 2012, bis zur nächsten Generalversammlung im Jahre 2013 zu ernennen.
Anlässlich der am 3. April 2012 abgehaltenen Generalversammlung wurde beschlossen,
Ernst & Young S.A.
7, rue Gabriel Lippmann
Parc d'Activité Syrdall 2
55760
L
U X E M B O U R G
L-5365 Munsbach
als Prüfungsbeauftragte der Gesellschaft bis zur nächsten Generalversammlung im Jahr 2013 wiederzuernennen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 5. April 2012.
Vontobel Europe S.A.
Référence de publication: 2012042798/31.
(120056431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
Rakuten Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 136.664.
In the year two thousand and twelve, on the sixth of March
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette,
THERE APPEARED:
RAKUTEN, Inc., a company organised under the laws of Japan, having its registered office at 4-12-3 Higashishinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan and registered with the Tokyo Legal Affairs Bureau under number 010701-020592,
represented by Me Sandrine BRUZZO, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February
21, 2012.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary shall stay attached
to the present deed to be filed with the registration authorities.
Who declared and requested the notary to state:
1) That RAKUTEN, Inc., prenamed, is the sole shareholder of RAKUTEN EUROPE S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) with registered office at 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
incorporated by a deed of Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg on February 2, 2008, published in the
Mémorial C of March 29, 2008, number 768 (the “Company”). The articles of association have been amended several
times and for the last time by a deed of the undersigned notary on July 22, 2011, published in the Mémorial C of September
19, 2011, number 2204.
2) That the capital of the Company is set at two hundred twenty-three million five hundred ninety-five thousand Euro
(EUR 223,595,000) represented by four million four hundred seventy one thousand nine hundred (4,471,900) shares with
a nominal value of fifty Euro (EUR 50) each.
3) After this had been set forth, the above named shareholder representing the whole corporate capital, has decided
to hold an extraordinary general meeting and to take the following resolutions in conformity with the agenda of the
meeting:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the capital of the Company by an amount of seven million five hundred
thousand Euro (EUR 7,500,000) to raise it from its present amount of two hundred and twenty-three million five hundred
and ninety-five thousand Euro (EUR 223,595,000) to two hundred and thirty one million ninety five thousand (EUR
231,095,000) by the creation and the issue of one hundred and fifty thousand (150,000) new shares of a nominal value of
fifty Euro (EUR 50) each.
<i>Subscription and Paying upi>
Thereupon,
RAKUTEN, Inc., prenamed, represented as aforesaid has declared to subscribe one hundred and fifty thousand
(150,000) new shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50) each at an aggregate value of seven million five hundred
thousand Euro (EUR 7,500,000) by a contribution in cash, so that the amount of seven million five hundred thousand
Euro (EUR 7,500,000) is at the disposal of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder decides to amend article 6 of the articles of
association of the Company so as to be worded as follows:
“ Art. 6. The capital is fixed at two hundred and thirty one million ninety-five thousand Euro (EUR 231,095,000)
represented by four million six hundred and twenty-one thousand and nine hundred (4,621,900) shares with a nominal
value of fifty Euro (EUR 50) each, entirely subscribed and fully paid up.”
55761
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at four thousand three hundred euro (€ 4,300.-).
There being no further business before the meeting, the same was adjourned thereupon.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed together with us the notary, the present original deed.
Follows the french version
L'an deux mille douze, le six mars,
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
A COMPARU:
RAKUTEN, Inc., une société constituée sous les lois du Japon, ayant son siège social au 4-12-3 Higashishinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japon, et immatriculée auprès du Tokyo Legal Affairs Bureau sous le numéro 0107-01-
020592,
représentée par Me Sandrine BRUZZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée le 21 février 2012.
Laquelle procuration prémentionnée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d'acter:
1) Que RAKUTEN, Inc., préqualifiée, est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée RAKUTEN
EUROPE S.à r.l., avec siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 février 2008, publié au Mémorial C du 29 mars
2008, numéro 768 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 22 juillet 2011, numéro publié au Mémorial C du 19 septembre 2011, numéro
2204.
2) Que le capital social de la société est fixé à deux cent vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille euros
(223.595.000 EUR) représenté par quatre millions quatre cent soixante et onze mille neuf cents (4.471.900) parts sociales
de cinquante euros (50 EUR) chacune.
3) Ensuite l'associé, représentant l'intégralité du capital social, a décidé de se constituer en assemblée générale ex-
traordinaire et de prendre les résolutions suivantes, conformes à l'ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de sept millions cinq cent mille euros
(7.500.000 EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux cent vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze
mille euros (223.595.000 EUR) à deux cent trente et un millions quatre-vingtquinze mille euros (231.095.000 EUR) par
la création et l'émission de cent cinquante mille (150.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cinquante
euros (50 EUR) chacune.
<i>Souscription et Libérationi>
RAKUTEN, Inc., préqualifiée, représentée comme précité a déclaré souscrire les cent cinquante mille (150.000) nou-
velles parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (50 EUR) chacune pour un montant total de sept millions
cinq cent mille euros (7.500.000 EUR) par apport en numéraire, de sorte que le montant de sept millions cinq cent mille
euros (7.500.000 EUR) est à la disposition de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de modifier l'article 6, des statuts de la Société
pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital est fixé à deux cent trente et un millions quatre-vingtquinze mille euros (231.095.000 EUR) repré-
senté par quatre millions six cent vingt et un mille neuf cents (4.621.900) parts sociales de cinquante euros (50 EUR)
chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»
55762
L
U X E M B O U R G
<i>Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges sous quelques formes que ce soit, qui incombe à la société
en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à quatre mille trois cents euros (€ 4.300,-).
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Bruzzo, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 mars 2012. Relation: EAC/2012/3298. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012040407/113.
(120053188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Investment Grade Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 84.462.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040265/10.
(120053770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Kiddie's Place, Société à responsabilité limitée,
(anc. Kid Care S.à r.l.).
Siège social: L-8284 Kehlen, 23, rue de Kopstal.
R.C.S. Luxembourg B 163.842.
L'an deux mille douze, le neuf février.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Mario SPAUTZ, salarié, né à Dudelange, le 3 avril 1956, demeurant à L-8284 Kehlen, 23, rue de Kopstal.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "KID CARE S.à r.l.", ayant son siège social à L-8284 Kehlen, 23, rue de Kopstal,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 163.842, a été constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2859 du 23 novembre 2011. Les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,EUR), représenté par cent (100) parts sociales,
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune, entièrement libérées.
- Que le comparant est le seul et unique associé de ladite société et qu'il s’est réuni en assemblée générale extraor-
dinaire et a pris, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’associé unique décide de changer la dénomination de la société en KIDDIE’S PLACE et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de KIDDIE’S PLACE, (ci-après la Société")."
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 800,-EURs.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
55763
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Mario SPAUTZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher le 16 février 2012. Relation: GRE/2012/595. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040320/35.
(120053664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
ArcelorMittal Clean Technology Venture Capital Holdings, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 141.377.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012042440/9.
(120057048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
LAUX & MEURERS Elektro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 111, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 147.236.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040336/10.
(120053669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Laux & Meurers Luxemburg, LML, Spezialist für Bäder und Heizungen G.m.b.H., Société à responsabilité
limitée.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 111, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 91.678.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040329/11.
(120053651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
P H C - Pirguet Hôtel Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 90.238.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040390/10.
(120053791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
55764
L
U X E M B O U R G
Wick Lane (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.010.000,00.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 167.395.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les associés en date du 3 avril 2012 que la personne suivante a démissionné, avec
effet au 3 avril 2012, de sa fonction de gérant de la Société:
- Monsieur Christophe Gaul, né le 3 avril 1977 à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 17, rue des
Jardinier, L-1835 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte également desdites résolutions que les personnes suivantes ont été nommées, avec effet immédiat et pour
une durée Illimitée à la fonction de gérant de la Société:
- Monsieur Ryan David Prince, né le 31 janvier 1977 à Toronto, Canada, ayant son adresse professionnelle au 4
ème
étage, 161 Brompton Road, Londres, SW3 1QP, Royaume-Uni,
- Monsieur Hugo Johannes Leopold Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, ayant son adresse pro-
fessionnelle au 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Godfrey Andrew Abel, né le 2 juillet 1960 à Brixworth, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle
au 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis lors, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Laurence Martin, né le 5 novembre 1980 à Londres, Royaume-Uni, résidant au 79 Kenley Road, Londres
SW19 3DU, Royaume-Uni,
- Monsieur Ryan David Prince, prénommé,
- Monsieur Hugo Johannes Leopold Neuman, prénommé,
- Monsieur Godfrey Andrew Abel, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 3 avril 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
Signature
Référence de publication: 2012040508/33.
(120053676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Sunflower Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Patron Mayor S.à r.l.).
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 165.918.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third of March.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared
Mr. Raymond THILL, maître en droit, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,
as proxyholder on behalf of Patron Investments IV S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office in L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 160.456),
being the sole shareholder of Patron Mayor S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its
registered office at L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER,
notary residing in Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary residing in Luxembourg, on November
29, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 401 of February 15, 2012.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. All the shares being represented, the decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. That the item on which a resolution is to be passed is as follows:
- Modification of the registered name of the company into "Sunflower Property S.à r.l."
55765
L
U X E M B O U R G
After deliberation the following resolution was unanimously taken:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to change the name of the Company from Patron Mayor S.à r.l. to Sunflower Property S.à r.l. and to
consequentially amend article one of the articles of incorporation of the Company as follows:
" Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsablité limitée) under the name of "Sunflower
Property S.à r.l." (the Company)."
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto,
the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, appearing preson signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-trois mars.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu
Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor
Hugo,
agissant en vertu d'une procuration de Patron Investments IV S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son
siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur, étant l'associé unique de Patron Mayor S.à r.l. (la «Société»), une
société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur, constituée suivant acte
reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement du notaire instru-
mentaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, Numéro 401 du 15 février 2012.
Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d'acter que:
1. Toutes les parts sociales étant représentées, les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points à
l'ordre du jour.
2. Le point sur lequel la résolution est prise est le suivant:
- Changement du nom de la Société en "Sunflower Property S.à r.l". Après délibération, la résolution suivante est
adoptée à l'unanimité:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé de changer le nom de la Société de Patron Mayor S.à r.l. en «Sunflower Property S.à r.l.» et de modifier
l'article un des statuts de la Société comme suit:
« Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Sunflower Property S. à r.l.» (ci-
après, la Société).»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2012. Relation: LAC/2012/14183. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040395/73.
(120053591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
55766
L
U X E M B O U R G
Fleet Lease S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 119.722.
<i>Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 22 décembre 2011:i>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant arrivé à leur terme, l'Assemblée a décidé de
nommer jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015:
- M. Jozef Dockx, directeur de société, domicilié au 89 Groenenhoek B-2630 Aartselaer, en qualité d'Administrateur,
- M. Wilfried Dockx, directeur de société, domicilié au 69 Lode Vleeshouwerslaan B-2900 Schoten, en qualité d'Ad-
ministrateur,
- Melle Sarah Dockx, employée privée, domiciliée au 14 Leopold De Vriesstraat B-2600 Berchem, en qualité d'Admi-
nistrateur,
- Luxfiducia Sàrl, une société ayant son siège social au 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg, en qualité de Commissaire
aux Comptes
<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 22 décembre 2011:i>
Le conseil d'administration a nommé M. Jozef Dockx, directeur de société, domicilié au 89 Groenenhoek B-2630
Aartselaer, en qualité d'Administrateur-Délégué, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2012042574/23.
(120056635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
Randstad Group Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 138.754.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040409/10.
(120053702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Randstad Luxembourg International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 89.633.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040411/10.
(120053749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
CanGro Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.768,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 112.759.
EXTRAIT
Suite à la dissolution de CGH Lux S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 150107, seul et unique associé de la Société, les trente mille sept cent soixante huit (30.768) parts sociales lui appar-
tenant, ont été transférées à CanGro Holding, L.L.C., une limited liability company, constituée et existante selon le droit
de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation
55767
L
U X E M B O U R G
Trust Center, 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, et enregistrée auprès du Se-
crétariat d'Etat de l'Etat du Delaware, sous le numéro 4065685.
Depuis lors, toutes les parts sociales de la Société sont détenues par CanGro Holding, LLC, seul et unique associé de
fa Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 10 avril 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Référence de publication: 2012042489/25.
(120056961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
TLS Group S.A., Société Anonyme,
(anc. International Company of Institutional Services S.A.).
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 135.935.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040478/11.
(120053687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
CanGro Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 112.759.
L'an deux mille douze, le deux mars.
Le soussigné Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, déclare et constate que:
Lors de la rédaction de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CanGro
Holding S. à r.l. reçue par le notaire instrumentant en date du 04 juillet 2011, numéro 1336/11 de son répertoire, enre-
gistrée à Esch-sur-Alzette Actes Civils, le 14 juillet 2011 sous la relation EAC/2011/9404 (ci après «l'Acte»).
une erreur s'est immiscée dans le point IV de l'Acte, lors de la refonte des statuts de la société, à l'article seize relatif
à l'exercice social, étant donné qu'il n'y avait pas lieu de le modifier, de sorte qu'il faut le rectifier et le lire comme suit
dans la version française et anglaise de l'Acte:
Art. 16. The Company's financial year starts on the first of July and ends on the thirtieth of June of the following year.
Art. 16. L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Signé: Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 mars 2012. Relation: EAC/2012/3025. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2012041900/22.
(120056212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2012.
Systema International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 80.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 72.163.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 février 2012i>
- L'Associé Unique renouvelle les mandats de Gérants de Catégorie A de:
* Monsieur Manlio Cerroni, administrateur de sociétés, demeurant 42, Via del Colle à Pisoniano (Rome),
55768
L
U X E M B O U R G
* Monsieur Candido Saioni, administrateur de sociétés, demeurant 2, Piazza Bologna à Rome,
* Monsieur Massimo Rosati, administrateur de sociétés, demeurant 1, Via Reykjavik à Ladispoli (Rome)
- Ainsi que le mandat de Gérant de Catégorie B de:
* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg
* Monsieur David Carelli, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.
Ces mandats prendront fin le 31 décembre 2015.
Luxembourg, le 24 février 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012042288/21.
(120056132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2012.
International Ressources S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 112.104.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02 avril 2012.i>
L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer un administrateur, à savoir:
- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, administrateur, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié profes-
sionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg
Son mandat d'administrateur expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
L'Assemblée Générale accepte de renouveler le mandat d'administrateur et du délégué à la gestion journalière, à savoir:
- Monsieur Marc THEISEN, administrateur, né le 05 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profes-
sionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.
Son mandat d'administrateur et du délégué à la gestion journalière expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra
en l'année 2017.
Les administrateurs M. Claude ZIMMER et M. Marc THEISEN sont domiciliés professionnellement au 42-44, avenue
de la gare, L-1610 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.
La société Zimmer & Partners S.à.r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société
Anonyme.
La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012042621/24.
(120056426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
Luxco Holdings CEP II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.441.222,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.050.
<i>Extrait des résolutions prises l'associé unique de la Société en date du 23 mars 2012:i>
L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Nomination de M. Jens Hoellermann, résidant professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, 26 julliet 1971 à Oberhausen (Allemagne), en qualité de gérant de catégorie B de
la Société, avec effet au 23 mars 2012 et pour une durée indéterminée (en remplacement de M. Ganash Lokanathen,
démissionnaire).
- Nomination de M. Ian Kent, résidant professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, 3 décembre 1976 à Birmingham (Royaume-Uni), en qualité de gérant de catégorie B de la Société,
avec effet au 23 mars 2012 et pour une durée indéterminée.
Le conseil d'gérance se compose dorénavant comme suit:
- M. Dan Katsikas, gérant de catégorie A
- Mme. Sally Ann Rocker, gérant de catégorie A
- M. Robert Andrew Quinn, gérant de catégorie B
55769
L
U X E M B O U R G
- M. Simon Barnes, gérant de catégorie B
- M. Jens Hoellermann, gérant de catégorie B
- M. Ian Kent, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>un mandatairei>
Référence de publication: 2012042406/28.
(120056205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2012.
Spimelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4394 Pontpierre, 2A, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 108.285.
L'an deux mille douze, le seize mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Spimelux S.A.”, ayant son
siège social à L-4119 Esch-sur-Alzette, 68, rue Romain Fandel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 108.825, a été constituée originairement sous la dénomination sociale de SPIME
LUXEMBOURG TRANSPORT Sàrl, en abrégé SPIME LUX TRPT Sàrl, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 17 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1017 du 11 octobre 2005
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 26 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 857 du 8 janvier
2008, en adoptant sa forme juridique et dénomination actuelle,
ayant un capital de cent mille euros (100.000,-EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent
euros (100,-EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Jun-
glinster, 3, route de Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benvindo MENDES, admi-
nistrateur délégué de la Société, demeurant professionnellement à Pontpierre, 2a, rue de l'Ecole.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social vers L-4394 Pontpierre, 2A, rue de l'Ecole et modification afférente du premier alinéa de
l'article 4 des statuts.
2.- Divers.
B) Qu'une première assemblée a été convoquée par avis de convocation contenant l'ordre du jour envoyé par courrier
recommandé aux actionnaires nominatifs le 10 février 2012, mais qui n'a pas pu délibérer sur l'ordre du jour comme le
quorum n'a pas été atteint.
C) Qu'en conséquence la présente assemblée a été convoquée par deux (2) convocations au «Journal» ainsi que dans
le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 15 février 2012 et du 1
er
mars 2012, tel que prévu par
l'article 67-1 (2) de la loi sur les sociétés commerciales
D) Que sur les mille (1.000) actions émises deux cents (200) actions sont présentes ou représentées se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.
E) Après avoir approuvé l'exposé du Président et après avoir reconnu que le quorum requis a été atteint l'assemblée
aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:
55770
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social, avec effet au 16 août 2011, vers L-4394 Pontpierre, 2A, rue de l'Ecole,
et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. (1
er
alinéa). Le siège social est établi dans la Commune de Mondercange."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à huit cent cinquante euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Benvindo MENDES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher le 23 mars 2012. Relation: GRE/2012/1045. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040445/62.
(120053774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Ham Investment Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.320.
Il résulte que le Conseil de Gérance de la Société a pris la décision suivante en date du 4 avril 2012:
1. Le siège de la Société est transféré du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg à partir du 4 avril 2012.
Veuillez prendre note du changement d’adresse du Gérant suivant:
TMF Corporate Services S.A.
46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ham Investment Corporation S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012042035/19.
(120055681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2012.
Kluusterstuff S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 5, Place Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 148.735.
<i>Assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2012i>
L'associée unique représentant l'intégralité du capital social de la société «Kluusterstuff S.àr.l.» avec siège social à L-
9237 DIEKIRCH, 5, Piace Guillaume, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous
le numéro 148735 a pris les résolutions suivantes:
-1-
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Samuel MEMOLA demeurant à L-7762 Bissen, 8, route de Boevange,
de son poste de gérant technique de la société «Kluusterstuff S.àr.l.» avec siège social à L-9237 DIEKIRCH, 5, Place
Guillaume.
-2-
L'assemblée accepte la démission de Madame Daniela D'ARRIGO, de son poste de gérante administrative de la société
«Kluusterstuff S.àr.l.» avec siège social à L-9237 DIEKIRCH, 5, Place Guillaume.
55771
L
U X E M B O U R G
-3-
L'assemblée procède à la nomination de Madame Daniela D'ARRIGO demeurant à L-1510 Luxembourg, 86A, avenue
de la Faïencerie, au poste de gérant technique de la société «Kluusterstuff S.àr.l.» avec siège social à L-9237 DIEKIRCH,
5, Place Guillaume, en remplacement de Monsieur Samuel MEMOLA prénommé.
L'assemblée décide à l'unanimité que la société «Kluusterstuff S.àr.l.» est valablement engagée par la seule signature
du gérant technique.
Diekirch, le 4 avril 2012.
Daniela D'ARRIGO
<i>Associée uniquei>
Référence de publication: 2012042637/27.
(120056491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
Les Espaces Saveurs S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 78.320.
EXTRAIT
L'adresse de l'administrateur et administrateur-délégué Madame Alexandra DILSCHNEIDER-COLAIANNI est désor-
mais la suivante:
121, Rue de Muhlenbach
L-2168 Luxembourg
L'adresse de l'administrateur Madame Sandrine DILSCHNEIDER est désormais la suivante:
63, Route de Mondorf
L-5750 Frisange
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 6 avril 2012.
Référence de publication: 2012042125/18.
(120056080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2012.
Hekuba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.556.465,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 127.136.
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of the month of March.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Hekuba S.à r.l." (the "Company"), a société à
responsabilité limitée having its registered office at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg incorporated on 28 March
2007 by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the "Mémorial") number 1777 of 15 June 2007 and registered with the Trade and Companies Register
of Luxembourg under number B 127136. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last
time on 16 February 2012 by deed of Me Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial
number 790 of 26 March 2012.
The meeting was presided by Me Maryline Esteves, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Me Michel Nickels, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed
by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all thirty-five million five hundred and fifty six thousand four hundred and
sixty five (35,556,465) shares in issue in the Company were represented at the general meeting, and the shareholders of
the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted and able
to validly decide on all the items on the agenda.
II. The common draft terms of merger of the Company (as absorbing company) and GAIA Real Estate Investments
S.A. (as absorbed company) (the "Merger Proposal") had been approved by the board of directors of GAIA Real Estate
55772
L
U X E M B O U R G
Investments S.A. and the board of managers of the Company on 20 March 2012 and had been published on 29 February
2012 in the Mémorial number 527 in accordance with article 262 of the law of 10th August 1915 on commercial companies
as amended (the "1915 Law");
III. The items on which resolutions are to be passed are the following:
1) Presentation of the Merger Proposal of the Company;
2) Approval of the Merger Proposal and decision to realise the merger of the Company (as absorbing company) and
GAIA Real Estate Investments S.A. ("GAIA") (as absorbed company), according to article 259 of the law on commercial
companies dated 10 August 1915, as amended (the "1915 Law") by the contribution, following GAIA’s dissolution without
liquidation, of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of GAIA to the Company;
3) Approval of the contribution of all and any assets, liabilities, rights, obligations and contracts of GAIA to the Com-
pany;
4) Cancellation of all the shares in issue of the Company held by GAIA and issue of thirty four million six hundred and
seven thousand one hundred and three (34,607,103) shares (parts sociales) of a nominal value of one Euro (€1) each (the
"New Shares") and a cash payment of two Euros and seventy-four cents (€2.74) to the shareholders of GAIA in consi-
deration of the transfer of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of GAIA (as absorbed company)
to the Company, consequential amendment of the first phrase of article 5 of the articles of association of the Company,
allocation of the New Shares so issued as set forth in the table below:
Shareholder of the Absorbed Company
Number
of shares
Adama Holding Public Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,535,701
Magnat Real Estate AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,535,701
Immoeast Projekt Hekuba Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,535,701
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,607,103
5) Acknowledgement of the effective date of the merger.
IV. The provisions regarding mergers of the 1915 Law have been fulfilled:
a) publication on the 29 February 2012 of the Merger Proposal in the Mémorial number 527, at least one month before
the date of the general meetings deciding on the Merger Proposal;
b) drawing up of a written report by the board of directors respectively the board of managers of each of the merging
companies explaining the Merger Proposal and in particular the share exchange ratio, a copy of which will be annexed to
the present deed;
c) deposit of the documents required by article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Company at least
one month before the date of the general meeting of the merging companies respectively, except for the report of the
independent experts provided for by article 266 of the 1915 Law which was waived by shareholders of each of the merging
companies at their respective extraordinary general meetings dated 20 February 2012.
After the Meeting approved the foregoing, it passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting declared that it had appropriate and sufficient knowledge of the Merger Proposal of the Company, pro-
viding for the absorption of GAIA (the "Absorbed Company") by the Company.
The merger will be implemented by the contribution of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts
of the Absorbed Company, without exception and reserves, to the Company.
The Meeting noted that the Merger Proposal had been approved by the board of managers of the Company on 20
February 2012 and had been published in the Mémorial number 527 of 29 February 2012, in accordance with article 262
of the 1915 Law.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to approve the Merger Proposal in all its provisions and in its entirety, without exception or
reserves.
The Meeting resolved to realise the merger by the transfer by the Absorbed Company following its dissolution without
liquidation of any and all assets liabilities, rights, obligations and contracts to the Company, in accordance with article 259
of the 1915 Law.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to approve the merger of the Absorbed Company into the Company and the contribution of
all and any assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Absorbed Company to the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved to cancel all the shares in the Company in issue held by the Absorbed Company.
55773
L
U X E M B O U R G
The Meeting then resolved to issue thirty four million six hundred and seven thousand one hundred and three
(34,607,103) New Shares, in consideration of the transfer of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts
of the Absorbed Company to the Company and to pay an aggregate amount of two Euros and seventy-four cents (€2.74)
such amount not exceeding 10% of the nominal value of the shares issued by the Company in accordance with article
259 of the 1915 Law to the shareholders of the Absorbed Company, pursuant to the share exchange ratio set forth in
the Merger Proposal.
The New Shares are issued and allocated to the shareholders of the Absorbed Company as set forth in the table set
forth in the agenda.
Consequently, phrase 1 of article 5 of the articles of association of the Company has been amended so as to read as
follows:
" Art. 5. Share. The issued capital of the Company is set at thirty-five million five hundred and fifty-five thousand three
hundred and ninety-two Euro (€35,555,392) divided into thirty-five million five hundred and fifty-five thousand three
hundred and ninety-two (35,555,392) shares with a nominal value of one Euro (€1) each."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting noted that the merger is effective, from an accounting and tax point of view, as from 30 March 2012
without prejudice to the provisions of article 273 of the 1915 Law regarding the effects of the merger towards third
parties.
<i>Statementsi>
The undersigned notary stated, the existence and the legality of the deeds and formalities of the merger executed by
the Company and the Absorbed Company, and the Merger Proposal.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this merger are estimated at approximately € 7,000.-.
There being nothing further items on the agenda.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of discrepancies between the English and French text, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille douze, le trentième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de Hekuba S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée
ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée par acte de Me Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg,le 28 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»)
numéro 1177 du 15 juin 2007 et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 127136. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire soussigné, le 16 février 2012,
publié au Mémorial numéro 790 du 26 mars 2012.
L’assemblée a été présidée par Me Maryline Esteves, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur Me Michel Nickels, maître en droit, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenus appèrent de la liste de présence signée par les
mandataires, le Président, le Secrétaire et le scrutateur du notaire soussigné. Cette liste ainsi que les procurations res-
teront annexées au présent acte afin d’être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Tel qu’il résulte de la prédite liste de présence, toutes les trente-cinq millions cinq cent cinquante six mille quatre cent
soixante cinq (35.556.465) actions émises par la Société sont dûment représentées à la présente assemblée, et les ac-
tionnaires de la Société ont déclarés avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour et que l’assemblée peut donc
régulièrement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
II. Le projet de fusion de la Société (comme société absorbante) et GAIA Real Estate Investments S.A (comme société
absorbée) (le «Projet de fusion») a été approuvés par le Conseil d’administration le 20 février 2012 et a été publié le 29
février 2012 dans le Mémorial numéro 527 conformément à l’article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telles que modifiées (la «Loi de 1915»);
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
55774
L
U X E M B O U R G
1. Présentation du plan de fusion de la société;
2. Approbation du projet de fusion et décision d’approuver la fusion de la Société (comme société absorbante) et
GAIA Real Estate Investments S.A («GAIA») (comme société absorbée), conformément à l’article 259 de la loi du 10
août 1915 relative aux sociétés commerciales telles que modifiées (la «Loi de 1915») par le transfert suite à la dissolution
sans liquidation de GAIA, de tous les avoirs, dettes, droits, obligations et contrats de GAIA à la Société;
3. Approbation du transfert de tous les avoirs, dettes, droits, obligations et contrats de GAIA à la Société;
4. Annulation de toutes les actions émises par la Société détenue par GAIA et émission de trente quatre millions six
cent sept mille cent trois (34.607.103) actions avec une valeur nominale d’un euro chacune («les Actions nouvelles») et
un payement en espèces de deux euros soixante-quatorze cents (€ 2,74)aux actionnaires de GAIA en contre-partie au
transfert de tous les avoirs, dette, droits, obligations et contrats de GAIA (comme société absorbée) à la Société, en
conséquence modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société, attribution des Actions nouvelles
telles que précisé dans le tableau ci-dessous:
Actionnaire de la société absorbée
Nombre
d’actions
Adama Holding Public Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.535.701
Magnat Real Estate AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.535.701
Immoeast Projekt Hekuba Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.535.701
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.607.103
5. Approbation de la date effective de la fusion.
IV. Les dispositions relatives aux fusions de la loi de 1915 ont été respectées:
a) Publication en date du 29 février 2012 du projet de fusion dans le Mémorial numéro 527, au moins un mois avant
la date des assemblées générales décidant du Projet de fusion;
b) Rédaction d’un rapport écrit par le Conseil d’Administration de chacune des sociétés fusionnantes expliquant le
Projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions, une copie de ce rapport est annexée au présent acte;
c) Dépôt des documents requis par l’article 267 de la Loi de 1915 au siège social de la Société au moins un mois avant
la date de l’assemblée générale de chacune des sociétés fusionnantes, sauf en ce qui concerne le rapport de l’expert
indépendant prévu par l’article 266 de la Loi de 1915 qui a été tel que les actionnaires de chacune des sociétés ont
renoncés lors de leur assemblée générale extraordinaire du 20 février 2012.
Les actionnaires ont adopté unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a déclaré qu'elle avait une connaissance appropriée et suffisante du Projet de Fusion de la Société, pré-
voyant l'absorption de GAIA ("la Société Absorbée") par la Société.
La fusion sera réalisée par la contribution de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société Ab-
sorbée, sans exception ni réserves, à la Société.
L’assemblée constate que le Projet de fusion avait été approuvé par le conseil de gérance de la Société en date du 20
février 2012 et a été publié au Mémorial 527 du 29 février 2012, conformément aux dispositions de l'article 262 de la loi
de 1915.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d'approuver le Projet de fusion dans toutes ses dispositions et dans son entièreté, sans exception
ni réserves.
L’assemblée a décidé de réaliser la fusion par le transfert universel par la Société Absorbée, suite à sa dissolution sans
liquidation de tous ses actifs, passifs, droits, obligations et contrats à la Société, conformément à l'article 259 de la loi de
1915.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a décidé d'approuver la fusion de la Société Absorbée dans la Société et la contribution de tous les actifs,
passifs, droits, obligations et contrats de la Société Absorbée à la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée a décidé d'annuler toutes les actions de la Société détenues par la Société Absorbée.
L’assemblée a ensuite décidé d'émettre trente quatre millions six cent sept mille et cent trois (34.607.103) Actions
nouvelles, en contrepartie du transfert de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société Absorbée à
la Société et de payer un montant de deux euros et soixante quatorze centimes(€2,74), ce montant n'excèdent pas 10%
de la valeur nominale des actions émises par la Société, conformément à l'article 259 de la loi de 1915, suite au ratio
d'échange des actions tel que fixé dans le Projet de Fusion.
Les Nouvelles actions sont émises et attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée conformément à ce qui est
précisé dans le tableau repris dans l'ordre du jour.
55775
L
U X E M B O U R G
En conséquence, la première phrase de l'article 5 des Statuts de la Société a été modifiée afin d'avoir la teneur suivante:
" Art.5. Le capital social émis de la Société est fixé à trente cinq millions cinq cent cinquante cinq mille et trois cent
quatre-vingt douze euros (€35.555.392) divisé en trente cinq millions cinq cent cinquante cinq mille et trois cent quatre-
vingt douze (35.555.392) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (€1) chacune."
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée constate que la fusion est effective d'un point de vue comptable et fiscal à compter du 30 mars 2012, sans
préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi de 1915 concernant les effets de la fusion à l'égard des tiers.
<i>Déclarationsi>
Le notaire soussigné a constaté l'existence et la légalité des actions et formalités relatives à la fusion exécutées par la
Société Absorbée et la Société, ainsi que du Projet de Fusion.
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison
de l’augmentation de son capital social sont estimés à € 7.000,-.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu’à la demande des personnes
comparantes, ce procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes
personnes comparantes en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: M. Esteves, M. Nickels, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 avril 2012. Relation: EAC/2012/4347. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2012.
Référence de publication: 2012040248/215.
(120053401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.
Multilateral Trade SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 11.744.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Joseph KERSCHEN, notaire de résidence à L - DIFFERDANCE, en remplacement
de Maître Lucien SCHUMAN, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 28 janvier 1974, publié au Mémorial
Recueil Spécial C n° 72 du 03 avril 1974;
- Statuts modiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L –
Luxembourg, en date du 14 décembre 2010, oublié au Mémorial Recueil Spécial C n° 732 du 15 avril 2011.
Suite aux démissions de Messieurs Farouk Abdel Hamid EL OKDAH, Samir MAGHOUB et Adel ABOU ELAZM, il
résulte les décisions suivantes:
- Suite à l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 30 avril 2010, Monsieur Medhat MOKHTAR, domicilié
4, Villa 25 Street à Alshourouk-Le Caire en Egypte, a été nommé comme administrateur et président du Conseil d’Ad-
ministration, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
- Suite à l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 12 juin 2009, Monsieur Mohamed Raafat SHEHATA,
domicilié 2, Kobri El Kobba Building Street à El Kobba-Le Caire en Egypte, a été nommé comme administrateur, jusqu’à
la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
- Suite à l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 8 novembre 2010, Monsieur Tarek Hassan AMER,
domicilié Ahmed Hishmat Street n° 10 à Le Caire en Egypte, a été nommé comme administrateur, jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
Suite à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 juin 2009, il résulte que le mandat de Monsieur Claude
FABER, domicilié au 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg, au poste de commissaire aux comptes, est renouvelé
jusqu’en 2015.
Luxembourg, le 10 avril 2012.
<i>Pour la société MULTILATERAL TRADE SPF S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2012042684/29.
(120056614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
55776
ArcelorMittal Clean Technology Venture Capital Holdings
Asset Backed-D S.A.
Bimolux S.A.-SPF
BLK BR HY (Luxembourg) Investments, S.à r.l.
BLK COY (Luxembourg) Investments, S.à r.l.
CanGro Holding S.à r.l.
CanGro Holding S.à r.l.
Diversified Growth Company en abrégé D.G.C.
Emilion Management S.à r.l.
Eurolux Creations S.à r.l.
Fleet Lease S.A.
Gaïa Luxembourg
Ham Investment Corporation S.à r.l.
Hansainvest Trust S.A.
Hekuba S.à r.l.
Hekuba S.à r.l.
International Company of Institutional Services S.A.
International Ressources S.A.
Investment Grade Europe S.A.
Kid Care S.à r.l.
Kiddie's Place
Kluusterstuff S.à.r.l.
LAUX & MEURERS Elektro S.à r.l.
Laux & Meurers Luxemburg, LML, Spezialist für Bäder und Heizungen G.m.b.H.
Les Espaces Saveurs S.A.
Living Planet Fund Management Company S.A.
Living Planet Fund Management Company S.A.
Luxco Holdings CEP II S. à r.l.
Multilateral Trade SPF S.A.
Paddington
Patron Mayor S.à r.l.
P H C - Pirguet Hôtel Consulting S.à r.l.
Rakuten Europe S.à r.l.
Randstad Group Luxembourg S.à r.l.
Randstad Luxembourg International S.à r.l.
Spimelux S.A.
Sunflower Property S.à r.l.
Systema International S.à r.l.
TLS Group S.A.
Vontobel Europe S.A.
Wick Lane (Lux) S.à r.l.