This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1115
2 mai 2012
SOMMAIRE
Ballywilliam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53474
BCLI no. 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53492
BPM Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53492
BRE/Japan NPL 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
53489
Capon Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53494
Casolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53495
CCP Acquisition GS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
53495
Cerlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53476
CFC Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53497
Convert S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53497
Courtignac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53498
Dinio S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53492
DNB Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53505
Dolmen International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
53502
Eden Shoes Lux. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53505
Eden Shoes Lux. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53506
Edmund Frette S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53506
Edufin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53505
EF Cultural Tours S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
53505
EF Cultural Tours S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
53495
Euro Ethnic Foods Global . . . . . . . . . . . . . . .
53506
Euromill Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53506
Euroports Port Acquisitions Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53505
Euro Real Estate France I S.à r.l. . . . . . . . .
53508
Even Germany S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53506
Even Germany S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53507
Even RX Fünf Real Estate Partnership
S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53498
Even RX Properties S.C.A. . . . . . . . . . . . . . .
53507
Even RX Properties S.C.A. . . . . . . . . . . . . . .
53507
Exelenz S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53507
Expertises et Développements Publics S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53517
Feather Lease S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53517
Feuerhaus S.à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53518
F.F.F. Management & Trust S.A. . . . . . . . .
53517
Filao Beach S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53518
Finbra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53519
Flare Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53519
Flare Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53519
Fonds Direkt Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53518
Frösunda Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53518
GeoVille Environmental Services S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53520
German Real Estate Partners Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53518
German Real Estate Partners Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53520
Giacelma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53520
Giacelma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53520
Glacis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53490
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent
Quarante-Cinquième (445.) S.e.c.s. . . . . .
53495
Isanne S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53502
Japan Logistics II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
53489
Kanelium Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53477
KoBauLux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53498
LBCI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53508
LBCI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53519
LFH Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53520
Matterhorn Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
53502
Olympus Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53502
53473
L
U X E M B O U R G
Ballywilliam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 162.268.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of March,
Before us Maître Léonie Grethen, notary, residing in 10, Rue du Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg,
There appeared:
Ballywilliam S.A., société anonyme, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
at: 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 162.268 (the "Shareholder"),
hereby represented by Mrs Ina KROI, lawyer, with professional address in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxem-
bourg, the Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16
th
March 2012.
Which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of
Ballywilliam S.A., société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a corporate capital
of thirty one thousand Euros (31.000,- EUR), with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, the
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary on 17
th
June 2011 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 162.268 (the "Company"). The articles of
incorporation of the Company have not yet been amended.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda :i>
1. To increase the share capital of the Company by an amount of four hundred thirty four thousand Euros (EUR
434.000,-) so as to raise it from its present amount of thirty one thousand Euros (EUR 31.000,-) to four hundred sixty
five thousand Euros (EUR 465.000,-).
2. To issue four hundred thirty four thousand (434.000,-) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,-) per
share, having the same rights and privileges as the existing shares.
3. To accept subscription for these new shares, with payment of a total amount of four hundred thirty four thousand
Euros (EUR 434.000,-) and to accept full payment in cash for these new shares.
4. To amend paragraph one of article five of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital
increase.
5. Miscellaneous. has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred thirty-four
thousand Euros (EUR 434.000,-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31.000,-)
to four hundred sixty-five thousand Euros (EUR 465.000,-).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to issue four hundred thirty four thousand (434.000) new shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared Mrs Ina Kroi, prenamed, by virtue of the afore mentioned proxy.
The Subscriber declared to subscribe for four hundred thirty-four thousand (434.000,-) new shares with a nominal
value of one Euro (EUR 1,-), with payment of a total amount of four hundred thirty-four thousand Euros (EUR 434.000,-)
by and to fully pay in cash for these shares.
The amount of four hundred thirty-four thousand Euros (EUR 434.000,-) was thus as from that moment at the disposal
of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the four hundred thirty-four thousand
(434.000,-) new shares according to the above mentioned subscription.
53474
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to amend paragraph one of article five of the articles of incorporation of the Company in
order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
" Art. 5. Corporate Capital
The issued capital of the Company is set at four hundred sixty-five thousand Euros (EUR 465.000,-) divided into four
hundred sixty-five thousand (465.000,-) shares. Each issued share has a nominal value of one Euro (EUR 1,-), and is fully
paid up."
<i>Estimation of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately nineteen hundred Euros (EUR 1,900.00).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version, at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, the proxy-holder of the appearing party signed together with us,
the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L'an deux mille douze, le vingtième jour du mois de mars.
Par-devant nous Maître Léonie Grethen, notaire de résidence au 10, Rue du Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Ballywilliam S.A., société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15,
rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 162.268
(l’«Actionnaire»),
représenté aux fins des présentes par Mme Ina Kroi, juriste, demeurant professionnellement au 15, rue Edward Stei-
chen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 16 mars 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
L’Actionnaire a requis le notaire instrumentant d'acter que l’Actionnaire est le seul et unique Actionnaire de Ballywil-
liam S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de trente-et-un mille Euros
(EUR 31.000,-), dont le siège social est situé au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 17 juin 2011, et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162 268 (la «Société»).
L’Actionnaire, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions
à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour :i>
1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre cent trente-quatre mille Euros (EUR 434.000,-)
pour le porter de son montant actuel de trente un mille Euros (EUR 31.000,-) à quatre cent soixante-cinq mille Euros
(EUR 465.000,-);
2 Émission de quatre cent trente-quatre mille (434.000,-) actions nouvelles d'une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-),
ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existante;
3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles actions, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total
de quatre cent trente-quatre mille Euros (EUR 434.000,-) à libérer intégralement en espèces;
4 Modification du premier alinéa de l’article cinq des statuts de la Société, afin d’y refléter l’augmentation de capital;
5 Divers. L’actionnaire unique a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Actionnaire a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent trente-quatre mille
Euros (EUR 434.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à quatre cent
soixante-cinq mille Euros (EUR 465.000,-).
53475
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L’Actionnaire a décidé d’émettre quatre cent trente-quatre mille (434.000,-) actions nouvelles d'une valeur nominale
d’un Euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu Madame Ina Kroi, prénommée, en vertu d’une procuration susmentionnée.
Le Souscripteur a déclaré souscrire quatre cent trente-quatre mille (434.000) actions nouvelles d'une valeur nominale
d’un Euro (EUR 1,-) par action avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de quatre cent et trente quatre
milles Euros (EUR 434.000,-) à libérer intégralement en espèces.
Le montant de quatre cent trente-quatre mille Euros (EUR 434.000,-) a dés lors été mis à la disposition de la Société
à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
L’Actionnaire a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les quatre cent trente-quatre mille
(434.000,-) actions nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Actionnaire a décidé de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts de la Société pour y refléter les
résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital Social
Le capital émis de la Société est fixé à quatre cent soixante-cinq mille Euros (EUR 465.000,-) représenté par quatre
cent soixante-cinq mille (465.000,-) actions. Chaque action a une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) et est entièrement
libérée.»
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ mille neuf cents Euros (EUR 1.900,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessous, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête de la même partie comparante, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparant connue du notaire sous-
signé par ses nom, prénom usuel, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: Kroi, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2012. Relation: LAC/2012/13078. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012036556/139.
(120048976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Cerlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 74.794.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012038498/13.
(120051809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
53476
L
U X E M B O U R G
Kanelium Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 156.376.
L'an deux mille douze, le vingt-huit février,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie:
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KANELIUM INVEST S.A." (la «Société»),
ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 156.376, constituée suivant acte notarié en date du 21 octobre 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2672 du 6 décembre 2010.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussignée en date 16
décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1028 du 17 mai 2011.
L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Kees Broekhuyse, employé, demeurant pro-
fessionnellement à B-1000 Bruxelles, 2, rue de la Chancellerie,
qui désigne comme secrétaire Madame Corinne Bitterlich, directeur, avec adresse professionnelle à L-2086 Luxem-
bourg, 412F, route d’Esch.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Emeline Dubois, employée privée, avec adresse professionnelle à
L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Autorisation expresse au Conseil d’Administration de la Société, conformément aux articles 49-2 et 49-7 de la loi
sur les sociétés commerciales telle que modifiée, de prendre en gage des titres émis par la Société dans le cadre d’un
«Securities Pledge Agreement»;
2. Augmentation du capital afin de porter celui-ci de 49.000.000,- euros à 55.221.705,- euros par l’émission de (i)
812.631 actions ordinaires avec désignation de valeur nominale de EUR 1,- par action ordinaire (les «Actions Ordinaires»)
assorties conjointement d’une prime d’émission de EUR 2.373.695,15, par l’émission de (ii) 5.409.074 actions préféren-
tielles avec rachat obligatoire («APRO ou MRPS»), dont 3.110.854 APRO ou MRPS sans droit de vote et 2.298.220 APRO
ou MRPS avec droit de vote avec désignation de valeur nominale de EUR 1,- par MRPS;
3. Souscription et paiement des Actions Ordinaires et APRO ou MRPS par un apport en numéraire à la Société et
paiement de la prime d’émission sur les Actions Ordinaires;
4. Annulation du précédent capital autorisé d’EUR 15.000.000,-;
5. Introduction d’un capital autorisé fixé à EUR 16.904.606,-; rapport établi par le Conseil d’Administration fixant les
conditions dans lesquelles le capital peut être augmenté;
6. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des Convertible Private Equity Certificates «CEPCs» et de
limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du
capital autorisé;
7. Pouvoir de procéder aux inscriptions dans les registres des actionnaires suite aux modifications de l’actionnariat de
la Société;
8. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions qui précèdent;
9. Modification de l’article 18.2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les APRO ou MRPS, quelque soit leur catégorie, ont droit à un dividende préférentiel et cumulatif égal à 6% de la
valeur nominale des APRO ou MRPS calculés à compter de leur date d’émission (le «Premier Dividende Préférentiel»).
Le Premier Dividende Préférentiel se calcule par jour sur la base d’une année de 365 jours.
Dans l’hypothèse où (i) des APRO ou MRPS seraient émis à des dates différentes et (ii), à la date d’émission des
nouveaux APRO ou MRPS, le Premier Dividende Préférentiel accumulé jusqu’à cette date pour les APRO ou MRPS
existants serait, en tout ou en partie, impayé (le «Dividende Accumulé»), ce dernier sera payé par priorité aux titulaires
des APRO ou MRPS existants. La partie du Premier Dividende Préférentiel se rapportant à la période postérieure à la
date d’émission des nouveaux APRO ou MRPS sera ensuite payée pari passu entre tous les titulaires des APRO ou MRPS.»
10. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
53477
L
U X E M B O U R G
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est rappelé que par un acte de cession d’actions daté du 9 novembre 2010 (le «Share Purchase Agreement»), Holdings
Invest S.C., une société civile de droit luxembourgeois ayant son siège social sis 412 F Route d’Esch L-2086 Luxembourg,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro E 4227 («Holdings Invest») et Sol
S.A. SPF, une société de gestion et de patrimoine familial de droit luxembourgeois, ayant son siège social 72 rue Dr. J.
Peffer, L-2319 Howald immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.982
(«Sol»), ensemble avec d’autres vendeurs ont accepté de vendre à la Société la totalité des actions détenues dans SGG
Holdings SA, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social 412F route d’Esch L-2086 Luxembourg
et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.013 («SGG Holdings»).
Afin de garantir leurs obligations au titre du Share Purchase Agreement, Holdings Invest a accepté de transférer 10%
du Holdings Invest Purchase Price (tel que défini dans le Share Purchase Agreement) («Holdings Invest Escrow Amount»)
sur un compte bloqué ouvert en son nom et au nom de la Société auprès de Dexia Banque Internationale à Luxembourg
S.A. et Sol a accepté de transférer 10% du Sol Purchase Price (tel que défini dans le Share Purchase Agreement) («Sol
Escrow Amount») sur un compte bloqué ouvert en son nom et au nom de la Société auprès de Dexia Banque Interna-
tionale à Luxembourg S.A. Dans le cadre du financement de l’acquisition par SGG SA, une filiale de SGG Holdings, des
actions de IMFC Netherlands et du Groupe FAcTS, les actionnaires de la Société ont accepté de souscrire à de nouveaux
titres de la Société à concurrence d’un montant de cinq millions trois cent un mille et trente-neuf centimes (EUR
5.300.001,39) lors de la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l’«Augmentation de
Capital»).
(1) Holdings Invest, (2) Senoufo SPF SA, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 412F
Route d’Esch L-2086 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 157.220 («Senoufo») et détenue par les mêmes actionnaires que Holding Invest, (3) Mireille Gehlen, résidant 2, rue J.F.
Kennedy 3502 Dudelange et (4) François Winandy, résidant 104, rue des Pommiers 2343 Luxembourg, ont entrepris
d’investir un montant de cinq cent quatre-vingt-treize mille deux cent quarante euros et soixante-dix-huit centimes (EUR
593.240,78) (le «1
er
Montant Investi» dans l’Augmentation de Capital et Sol a entrepris d’investir un montant de trois
cent treize mille cinq cent «2
nd
cinquante-sept euros (EUR 313.557) (le Montant Investi») dans l’Augmentation de Capital.
Simultanément, Holdings Invest, Sol, Senoufo, Mireille Gehlen et François Winandy vont souscrire à certaines autres
valeurs mobilières émises par la Société ainsi qu’il suit (les «Titres»):
Actions CPECs MRPS S MRPS A
Holding Invest S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.180 164.485
Sol S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180.332 133.225
Senoufo SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.739
58.909
Mireille Gehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.294
3.172
François Winandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.294
3.172
Afin de permettre à Holdings Invest, Senoufo, Mireille Gehlen et François Winandy de souscrire leur part de Titres,
la Société a accepté de réduire le montant du Holdings Invest Escrow Amount du montant de cinq cent quatre-vingt-
quatre mille neuf cent soixante-trois euros et trente-quatre centimes (EUR 584.963,34) au«Montant Libéré». Consécu-
tivement à cette mainlevée, (i) un montant de quatre cent trente-cinq mille six cent cinquante euros et trente-quatre
centimes (EUR 435.650,34) sera viré sur le Dedicated Account (tel que défini dans le Share Purchase Agreement) pour
le compte de Holdings Invest, (ii) un montant de cent trente-quatre mille trois cent quatrevingt-un euros (EUR 134.381)
sera viré sur le Dedicated Account (tel que défini dans le Share Purchase Agreement) pour le compte de Senoufo, (iii)
un montant de sept mille quatre cent soixante-six euros (EUR 7.466) sera viré sur le Dedicated Account (tel que défini
dans le Share Purchase Agreement) pour le compte de Mireille Gehlen et (iv) un montant de sept mille quatre cent
soixante-six euros (EUR 7.466) sera viré sur le Dedicated Account (tel que défini dans le Share Purchase Agreement)
pour le compte de François Winandy. En contrepartie de ce qui précède, Holdings Invest, Senoufo, Mireille Gehlen et
François Winandy ont accepté de donner en gage en faveur de la Société leur portion des Titres souscrits au moyen du
Montant Libéré.
Afin de permettre à Sol de souscrire sa part de Titres, la Société a accepté de réduire le montant du Sol Escrow
Amount du montant égal au 2
nd
Montant Investi. En contrepartie de ce qui précède, Sol a accepté de donner en gage en
faveur de la Société sa portion des Titres.
53478
L
U X E M B O U R G
En vertu de ce qui précède, il est envisagé que Holdings Invest, Sol, Senoufo, Mireille Gehlen et François Winandy, en
qualité de constituants de gage, concluent avec la Société, en qualité de créancier gagiste, un gage portant sur les Titres
mentionnés ci-dessous («Les Titres Gagés») (le «Securities Pledge Agreement»), et les actionnaires reconnaissent avoir
reçu un projet du Securities Pledge Agreement.
Il est indiqué à l’assemblée que le conseil d’administration de la Société envisage de conclure le Securities Pledge
Agreement et à cet égard, en conformité avec les dispositions des articles 49-2 et 49-7 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), il est demandé que les actionnaires de la Société donnent leur accord
préalable exprès à la conclusion du Securities Pledge Agreement (l’«Autorisation»).
Après délibérations, l’Assemblée décide de donner l’Autorisation au Conseil d’administration sous les conditions sui-
vantes:
- La nature et le nombre maximal de titres pouvant être acquis par la Société au titre de la réalisation du Securities
Pledge Agreement sont les Titres suivants:
Actions CPECs MRPS S MRPS A
Holding Invest S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.540 162.984
Sol S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180.332 133.225
Senoufo SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.285
57.096
Mireille Gehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.294
3.172
François Winandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.294
3.172
- Cette Autorisation est donnée en conformité avec la Loi pour une durée de 2 ans;
- En cas de réalisation du Securities Pledge Agreement, la valorisation des Titres s’effectuera à un prix égal à leur valeur
de souscription.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de six millions deux cent vingt
et un mille sept cent cinq euros (EUR 6.221.705) pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf millions d’euros
(EUR 49.000.000) à cinquante-cinq millions deux cent vingt et un mille sept cent cinq (EUR 55.221.705) par l’émission de
huit cent douze mille six cent trente et une (812.631) actions ordinaires avec une valeur nominale d’un euro (EUR 1) par
action ordinaire assorties conjointement d’une prime d’émission de deux millions trois cent soixante-treize mille six cent
quatre-vingt-quinze euros et quinze centimes (EUR 2.373.695,15) (les «Actions Ordinaires») et cinq millions quatre cent
neuf mille soixante-quatorze (5.409.074) actions préférentielles avec rachat obligatoire (les «APRO ou MRPS») dont trois
millions cent dix mille huit cent cinquante-quatre (3.110.854) APRO ou MRPS sans droit de vote et deux millions deux
cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent vingt (2.298.220) APRO ou MRPS avec droit de vote d’une valeur nominale
d’un euro (EUR 1) par APRO ou MRPS.
<i>Souscription et libérationi>
Les huit cent douze mille six cent trente et une (812.631) actions ordinaires et les cinq millions quatre cent neuf mille
soixante quatorze (5.409.074) APRO ou MRPS dont trois millions cent dix mille huit cent cinquante-quatre (3.110.854)
APRO ou MRPS sans droit de vote et deux millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent vingt (2.298.220)
APRO ou MRPS avec droit de vote sont toutes souscrites comme suit:
1) trois cent quatorze mille trois cent soixante-huit (314.368) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro (EUR
1) par action ordinaire assorties d’une prime d’émission de neuf cent dix-huit mille deux cent soixante-huit euros et
quatre-vingt-treize centimes (EUR 918.268,93), soit pour un montant total d’un million deux cent trente-deux mille six
cent trente-six euros et quatre-vingt-treize centimes (EUR 1.232.636,93), étant entendu que la différence entre le prix
de souscription de chaque action ordinaire et de sa valeur nominale sera affectée à un compte de prime d’émission, sont
souscrites par ULRAN S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince
Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10.563,
ici représentée par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 21 février 2012, qui restera annexée au présent
acte;
2) un million deux cent trois mille quatre cent quarante et une (1.203.441) APRO ou MRPS sans droit de vote et huit
cent quatre-vingt-neuf mille soixante-treize (889.073) APRO ou MRPS avec droit de vote, ayant une valeur nominale d’un
euro (EUR 1) pour un montant total de deux millions quatre-vingt-douze mille cinq cent quatorze euros (EUR 2.092.514)
sont souscrits par REDCREST Consulting Ltd, une société de droit chypriote ayant son siège social à 2 Apostolos Varnavas,
Centaur House, 2571 Nisou, Nicosia, Cyprus, inscrite au registre des sociétés de Chypre sous le numéro 264672
ici représentée par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 8 février 2012, qui restera annexée au présent
acte;
3) vingt-cinq mille six cent trente-sept (25.637) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) par action
ordinaire assorties d’une prime d’émission de soixante-quatorze mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-huit
53479
L
U X E M B O U R G
centimes (EUR 74.885,68), soit pour un montant total de cent mille cinq cent vingt-deux euros et soixante-huit centimes
(EUR 100.522,68), étant entendu que la différence entre le prix de souscription de chaque action ordinaire et de sa valeur
nominale sera affectée à un compte de prime d’émission, et, quatre-vingt-dix-huit mille cent quarante (98.140) APRO ou
MRPS sans droit de vote et soixante-douze mille cinq cent trois (72.503) APRO ou MRPS avec droit de vote d’une valeur
nominale d’une euro (EUR 1) pour un montant total de cent soixante-dix mille six cent quarante-trois euros (EUR
170.643), sont souscrits par SURIDAM HOLDING S.A., SPF, une société anonyme ayant son siège social à L-1468 Lu-
xembourg, 14, rue Erasme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.290,
ici représentée par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 11 janvier 2012, qui restera annexée au présent
acte;
4) quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze (4.294) APRO ou MRPS sans droit de vote et trois mille cent soixante-
douze (3.172) APRO ou MRPS avec droit de vote, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, pour un montant
total de sept mille quatre cent soixante-six euros (EUR7.466) sont souscrits par Madame Mireille Gehlen, directeur,
demeurant à L-3502 Dudelange, 2, rue J.F. Kennedy,
ici représentée par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 12 janvier 2012, qui restera annexée au présent
acte
5) quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze (4.294) APRO ou MRPS sans droit de vote et trois mille cent soixante-
douze (3.172) APRO ou MRPS avec droit de vote, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, pour un montant
total de sept mille quatre cent soixante-six euros (EUR7.466) sont souscrits par Monsieur François Winandy, directeur,
demeurant à L-2343 Luxembourg, 104, rue des Pommiers,
ici représenté par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 28 février 2012, qui restera annexée au présent
acte
6) Cent quatre-vingt mille trois cent trente-deux (180.332) APRO ou MRPS sans droit de vote et cent trente-trois
mille deux cent vingt-cinq (133.225) APRO ou MRPS avec droit de vote, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1)
chacune, soit pour un montant total de trois cent treize mille cinq cent cinquante-sept euros (EUR 313.557), sont souscrits
par SOL SPF S.A, une société anonyme ayant son siège social à L-2319 Howald, 72, rue Dr J. Peffer, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.982,
ici représentée par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 12 janvier 2012, qui restera annexée au présent
acte;
7) Soixante-dix mille cent quatre-vingt (70.180) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) par action
ordinaire assorties d’une prime d’émission de deux cent quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix-
huit centimes (204.995,78), soit pour un montant total de deux cent soixante-quinze mille cent soixante-quinze euros
soixante-dix-huit centimes (EUR 275.175,78), étant entendu que la différence entre le prix de souscription de chaque
action ordinaire et de sa valeur nominale sera affectée à un compte de prime d’émission, sont souscrites par HOLDINGS
INVEST S.C, une société civile ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro E 4.247,
ici représentée par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 12 janvier 2012, qui restera annexée au présent
acte;
8) Soixante-dix-neuf mille sept cent trente-neuf (79.739) APRO ou MRPS sans droit de vote et cinquante-huit mille
neuf cent neuf (58.909) APRO ou MRPS avec droit de vote, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, soit
pour un montant total de cent trente-huit mille six cent quarante-huit euros (EUR138.648), sont souscrits par SENOUFO
S.A, SPF, une société anonyme ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.220
ici représentée par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 12 janvier 2012, qui restera annexée au présent
acte;
9) Cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-huit (154.788) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un
euro (EUR 1) par action ordinaire assorties d’une prime d’émission de quatre cent cinquante-deux mille cent trente-cinq
euros et soixante-quinze centimes (EUR 452.135,75), soit pour un montant total de six cent six mille neuf cent vingt.trois
euros et soixante-quinze centimes (EUR 606.923,75), étant entendu que la différence entre le prix de souscription de
chaque action ordinaire et de sa valeur nominale sera affectée à un compte de prime d’émission, sont souscrites par
JEWEL PARTNERS S.C, une société civile ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro E 4.575,
ici représentée par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse prénommé,
53480
L
U X E M B O U R G
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 17 janvier 2012, qui restera annexée au présent
acte;
10) Cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quarante-quatre (592.544) APRO ou MRPS sans droit de vote et
quatre cent trente-sept mille sept cent cinquante-six (437.756) APRO ou MRPS avec droit de vote, ayant une valeur
nominale de EUR 1,- pour un montant total de 1.030.300,- euros
sont souscrites par JEWEL SPF S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 41 Boulevard
Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164192,
ici représentée par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 17 janvier 2012, qui restera annexée au présent
acte;
11) Cent vingt-trois mille huit cent vingt-neuf (123.829) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1)
par action ordinaire assorties d’une prime d’émission de trois cent soixante et un mille sept cent quatre euros et cinquante
et un centimes (EUR 361.704,51), soit pour un montant total de quatre cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent trente-trois
euros et cinquante et un centimes (EUR 485.533,51), étant entendu que la différence entre le prix de souscription de
chaque action ordinaire et de sa valeur nominale sera affectée à un compte de prime d’émission et, quatre cent soixante-
quatorze mille trente-cinq (474.035) APRO ou MRPS sans droit de vote et trois cent cinquante mille deux cent cinq
(350.205) APRO ou MRPS avec droit de vote, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1), soit pour un montant total
de huit cent vingt-quatre mille deux cent quarante euros (EUR 824.240), sont souscrits par Monsieur Hans Leijdesdorff,
directeur, domicilié à Vliegheiweg, 3, NL-1272 PH Huizen,
ici représenté par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Amsterdam, le 11 janvier 2012, qui restera annexée au présent
acte;
12) Cent vingt-trois mille huit cent vingt-neuf (123.829) actions ordinaires avec désignation de valeur nominale d’un
(EUR 1) par action ordinaire assorties d’une prime d’émission de trois cent soixante et un mille sept cent quatre euros
et cinquante et un centimes (361.704,51), soit pour un montant total de quatre cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent
trente-trois euros et cinquante et un centimes (EUR 485.533,51), étant entendu que la différence entre le prix de sou-
scription de chaque action ordinaire et de sa valeur nominale sera affectée à un compte de prime d’émission et, quatre
cent soixante-quatorze mille trente-cinq (474.035) APRO ou MRPS sans droit de vote et trois cent cinquante mille deux
cent cinq (350.205) APRO ou MRPS avec droit de vote, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1), soit pour un
montant total de huit cent vingt-quatre mille deux cent quarante euros (EUR 824.240), sont souscrits par Madame Shareen
Perret Gentil domiciliée à Vliegheiweg, 3, NL-1272 PH Huizen
ici représentée par Monsieur Dirk Kees Broekhuyse prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Amsterdam, le 11 janvier 2012, qui restera annexée au présent
acte.
Les huit cent douze mille six cent trente et une (812.631) nouvelles actions ordinaires et cinq millions quatre cent neuf
mille soixante-quatorze (5.409.074) nouvelles actions préférentielles avec rachat obligatoire sont intégralement libérées
en espèces pour un montant total de huit millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatre cents euros et quinze cents
(EUR 8.595.400,15) dont un montant de six millions deux cent vingt et un mille sept cent cinq euros (EUR 6.221.705) est
affecté au capital social de la Société et le solde, soit deux millions trois cent soixante-treize mille six cent quatre-vingt-
quinze euros et quinze cents (EUR 2.373.695,15) compte de prime d’émission.
Le montant total de huit millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatre cents euros et quinze cents (EUR
8.595.400,15) est dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi que le prouve le certificat bancaire délivré au
notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’annuler le capital autorisé existant de quinze millions d’euros (EUR 15.000.000) et
d’introduire un nouveau capital autorisé d’un montant de seize millions neuf cent quatre mille six cent six euros (EUR
16.904.606).
Un exemplaire du rapport spécial prévu à l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée, restera annexé au présente pour être enregistré en même temps.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts de la
Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à cinquante-cinq millions deux cent vingt et un mille sept cent cinq euros (EUR
55.221.705) représenté par sept millions deux cent douze mille six cent trente et une (7.212.631) actions ordinaires (les
«Actions Ordinaires») d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, vingt-sept millions six cent dix mille huit cent
cinquante-quatre (27.610.854) actions préférentielles avec rachat obligatoire sans droit de vote (les «APRO ou MRPS
53481
L
U X E M B O U R G
sans droit de vote») et vingt millions trois cent quatrevingt-dix-huit mille deux cent vingt (20.398.220) actions préféren-
tielles avec rachat obligatoire avec droit de vote (les «APRO ou MRPS avec droit de vote», ensemble avec les «APRO
ou MRPS sans droit de vote», les «APRO ou MRPS») .
Il est fait référence aux Actions Ordinaires et aux APRO ou MRPS individuellement en tant qu’ «Action» et collecti-
vement en tant qu'«Actions».
5.2 Le capital autorisé de la Société est fixé à seize millions neuf cent quatre mille six cent six euros (EUR 16.904.606)
représenté par seize millions neuf cent quatre mille six cent six (16.904.606) Actions Ordinaires d’une valeur nominale
d’un euro (EUR 1) chacune.
En conséquence, le Conseil d’Administration est autorisé pour une période de 5 ans, à partir de la publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l’assemblée générale du 28 février 2012, à réaliser cette augmentation
de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque
et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles à déterminer les conditions de souscription et de
libération, à faire appel, le cas échéant, à des nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution
se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues par en la présente résolution, à faire constater en
la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à
mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment cons-
tatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus
doit être renouvelée tous les cinq ans et tant que le capital social émis résultant de ces augmentations demeure égal ou
inférieur au seuil des seize millions neuf cent quatre mille six cent six euros (EUR 16.904.606).
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre tout instrument de dette convertible ou non sous forme
nominative, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que tout
émission d’un instrument de dette convertible ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant attrait.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisée.
Le capital autorisé et le capital souscrit pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’autoriser le Conseil d’Administration à émettre des Convertible Private Equity
Certificates,«CPECs» et de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de
capital réalisée dans le cadre du capital autorisé.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner pouvoir à Madame Corinne Bitterlich, Mademoiselle Emeline Dubois et Mon-
sieur Alain Renard, chacun agissant individuellement, afin de procéder à toutes inscriptions nécessaires dans le registre
des actionnaires conformément aux modifications adoptées.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 18.2 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« 18.2. Les APRO ou MRPS, quelque soit leur catégorie, ont droit à un dividende préférentiel et cumulatif égal à 6%
de la valeur nominale des APRO ou MRPS calculés à compter de leur date d’émission (le «Premier Dividende Préféren-
tiel»). Le Premier Dividende Préférentiel se calcule par jour sur la base d’une année de 365 jours.
Dans l’hypothèse où (i) des APRO ou MRPS seraient émis à des dates différentes et (ii), à la date d’émission des
nouveaux APRO ou MRPS, le Premier Dividende Préférentiel accumulé jusqu'à cette date pour les APRO ou MRPS
existants serait, en tout ou en partie, impayé (le «Dividende Accumulé»), ce dernier sera payé par priorité aux titulaires
des APRO ou MRPS existants. La partie du Premier Dividende Préférentiel se rapportant à la période postérieure à la
date d’émission des nouveaux APRO ou MRPS sera ensuite payée pari passu entre tous les titulaires des APRO ou MRPS.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 412F, route d’Esch, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue française suivi d'une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth of February,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
53482
L
U X E M B O U R G
is held
an extraordinary general meeting of shareholders of "KANELIUM INVEST S.A." (the “Company”), a société anonyme,
with registered office at L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 156.376, incorporated pursuant to a notarial deed on 21 October 2010, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2672 on 6 December 2010.
The articles of incorporation of the Company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated
15 December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1028 dated 17 May 2011,
The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr Kees Broekhuyse, employee, residing professionally in B-1000 Bruxelles,
2, rue de la Chancellerie, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Corinne Bitterlich, director, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F,
route d’Esch.
The meeting elected as scrutineer Mrs Emeline Dubois, private employee, residing professionally in L-2086 Luxem-
bourg, 412F, route d’Esch.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the meeting is held with the following:
<i>Agendai>
1. Express authorization to be given to the Board of Directors of the Company, in accordance with articles 49-2 and
49-7 of the Law relating to Commercial companies as amended, to pledge securities issued by the Company in the
framework of a “Securities Pledge Agreement”
2. Capital increase so as to raise it from forty nine millions euros (EUR 49.000.000) up to fifty five millions two hundred
twenty-one thousand seven hundred and five euros (EUR 55.221.705) through the issue of (i) eight hundred twelve
thousand six hundred and thirty one (812.631) ordinary shares with a nominal value of one euro each (the “Ordinary
Shares”) together with a share premium fixed at two millions three hundred and seventy three thousand six hundred and
ninety five euros and fifteen cent (EUR 2.373.695,15) and (ii) five million four hundred and nine thousand seventy four
(5.409.074) mandatory redeemable preferred shares (“APRO or MRPS”) out of which three millions one hundred and
ten thousand eight hundred and fifty four (3.110.854) non voting APRO or MRPS and two millions two hundred ninety
eight thousand two hundred and twenty (2.298.220) voting APRO or MRPS with a nominal value of one euro each;
3. Subscription and payment of the Ordinary Shares and the APRO or MRPS by a contribution in cash and payment
of the share premium on the Ordinary Shares;
4. Cancellation of the precedent authorized capital fixed at fifteen millions euros (EUR 15.000.000);
5. Introduction of a new authorized capital fixed at sixteen millions nine hundred and four thousand six hundred and
six euros (EUR 16.904.606), report of the Board of Directors fixing the conditions for the capital increase;
6. Authorization to the Board of Directors to issue Convertible Private Equity Certificate (CPECs) and to limit or
suppress the preferential subscription right during share capital increases made within the framework of the authorized
capital;
7. Power to proceed to the registration in the Shareholder’s registers following the amendments to the shareholding
of the Company;
8. Amendment of article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the above decisions;
9. Amendment of article 18.2 of the articles of incorporation of the Company as follows:
«Each APRO or MRPS, voting or non voting, entitles its holder to a preferential and cumulative dividend at the rate
of 6% of the par value of the APRO or MRPS calculated since their issue date (the “First Preferential Dividend”). The
First Preferential Dividend shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days.
In case (i) APRO or MRPS be issued at different dates and (ii) at the issue date of new APRO or MRPS, the First
Preferential Dividend accrued until the issue date for the existing APRO or MRPS would be, wholly or in part, unpaid
(the “Accrued Dividend”), the later will be paid by priority to the holders of existing APRO or MRPS. The part of the
First Preferential Dividend, relating to the period after the issue date of the new APRO or MRPS, will be paid pari passu
between all the holders of APRO or MRPS.»;
10. Miscellaneous.
II. - That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented share-
holders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed together with the deed
with the registration authorities.
The proxyholders of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been
initialled ne varietur by the persons appearing.
III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were
necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting.
53483
L
U X E M B O U R G
IV. - That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
By a Share Purchase Agreement dated 9 November 2011 (the “Share Purchase Agreement”), Holding Invest S.C., a
société civile, having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under number E 4247 (“Holding Invest”) and SOL S.A., SPF, a société anonyme, having
its registered office at L-2319 Howald, 72, rue Dr J Peffer, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 151.982 (“Sol”), together with other Sellers have accepted to sell to the Company the whole shares
held in SGG Holdings S.A., a société anonyme, having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 152013 (“SGG Holdings”).
In order to guarantee their commitments in accordance with the Share Purchase Agreement, Holdings Invest has
accepted to transfer 10% of Holdings Invest Purchase Price (as defined in the Share Purchase Agreement) (“Holdings
Invest Escrow Amount”) on a blocked account opened in the names of Holdings Invest and of the Company and held
with Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. and Sol has accepted to transfer 10% of the Sol Purchase Price (as
defined in the Share Purchase Agreement) (“Sol Escrow Amount”) on a blocked account in the names of Sol and of the
Company and held with Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. In the framework of the financing of the purchase
by SGG S.A., a subsidiary of SGG Holdings S.A., of shares of IMFC Netherlands and of the Group FAcTS, the shareholders
of the Company have accepted to subscribe to new securities of the Company up to a limit of five millions three hundred
thousand and one euro thirty nine cent (EUR 5.300.001,39) at the present extraordinary general meeting of the share-
holders of the Company (the “Increase of Capital”).
(1) Holdings Invest, (2) Senoufo S.A., SPF, a société anonyme, having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F,
route d’Esch, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 157.220 (“Senoufo”) and
the shares of which are owned by the same shareholders as Holdings Invest, (3) Mrs Mireille Gehlen, residing in L-3502
Dudelange, 2, rue J. F. Kennedy and (4) Mr François Winandy, residing in L-2343 Luxembourg, 104, rue des Pommiers,
will invest an amount of five hundred ninety-three thousand two hundred forty euro and seventy-eight cent (EUR
593.240,78) (the “First Invested Amount”) at the occasion of the Increase of Capital and Sol will invest an amount of
three hundred thirteen thousand five hundred and fifty-seven euro (EUR 313.557) (the “Second Invested Amount”) at
the occasion of the Increase of Capital. Simultaneously, Holdings Invest, Sol, Senoufo, Mireille Gehlen and François Wi-
nandy will subscribe to securities to be issued by the Company as follows (the “Securities”):
Shares CPECs MRPS S MRPS A
Holding Invest S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.180 164.485
Sol S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180.332 133.225
Senoufo SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.739
58.909
Mireille Gehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.294
3.172
François Winandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.294
3.172
In order to enable Holdings Invest, Senoufo, Mireille Gehlen and François Winandy to subscribe to their part of
Securities, the Company has accepted to reduce the amount of the Holdings Invest Escrow Amount of an amount of five
hundred eighty-four thousand nine hundred sixty-three euro and thirty-four cent (EUR 584.963,34) (the “Released
Amount”) Consecutively to the reduction of the amount of the Holdings Invest Escrow Amount, (i) an amount of four
hundred thirty-five thousand six hundred fifty euro and thirtyfour cent (EUR 435.650,34) will be transferred to the
Dedicated Account (as defined in the Share Purchase Agreement) on behalf of Holdings Invest, (ii) an amount of one
hundred thirty-four thousand three hundred eighty-one euro (EUR 134.381) will be transferred to the Dedicated Account
(as defined in the Share Purchase Agreement) on behalf of Senoufo, (iii) an amount of seven thousand four hundred sixty-
six euro (EUR 7.466) will be transferred to the Dedicated Account (as defined in the Share Purchase Agreement) on
behalf of Mireille Gehlen and (iv) an amount of seven thousand four hundred sixty six euro (EUR 7.466) will be transferred
to the Dedicated Account (as defined in the Share Purchase Agreement) on behalf of François Winandy. As counterpart,
Holdings Invest, Senoufo, Mireille Gehlen and François Winandy have accepted to pledge in favour of the Company their
respective part of Securities subscribed with the Released Amount.
In order to enable Sol to subscribe to its part of Securities, the Company has accepted to reduce the amount of Sol
Escrow Amount of the amount equal to the Second Amount Invested. In exchange, Sol has accepted to pledge in favour
of the Company its part of Securities.
Consequently, it is considered that Holdings Invest, Sol, Senoufo, Mireille Gehlen and François Winandy as pledgors,
sign with the Company, as pledgee, a pledge agreement in relation with the Securities mentioned below (“the Pledged
Securities”) (“the Securities Pledge Agreement”), and the shareholders acknowledge having received a draft of Securities
Pledge Agreement.
The attention of the General Meeting is drawn to the fact that the Board of Directors of the Company considers to
sign the Securities Pledge Agreement and, in accordance with the articles 49-2 and 49-7 of the law of 10 August 1915 on
53484
L
U X E M B O U R G
commercial companies, as amended (the “Law”), it is requested that the shareholders of the Company give their prior
and express agreement to the conclusion of the Securities Pledge Agreement (the “Authorization”).
After deliberations, the meeting decides to give the Authorization to the Board of Directors under the following
conditions:
- The nature and the maximal number of Securities that may be acquired by the Company in execution of the Securities
Pledge Agreement are as follows:
Shares CPECs MRPS S MRPS A
Holding Invest S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.540 162.984
Sol S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180.332 133.225
Senoufo SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.285
57.096
Mireille Gehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.294
3.172
François Winandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.294
3.172
- This Authorization is given for a period of 2 years in accordance with the Law;
- In case of execution of the Securities Pledge Agreement, the valuation of the Securities will be made to a price equal
to the subscription value of their Securities.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of six million two hundred
twenty-one thousand seven hundred and five euro (EUR 6.221.705) so as to raise it from its present amount of forty-
nine million euro (EUR 49.000.000) up to fifty-five million two hundred twenty-one thousand seven hundred and five euro
(EUR 55.221.705) through the issue of eight hundred twelve thousand six hundred and thirty-one (812.631) ordinary
shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each together with a share premium fixed at two million three hundred
seventy-three thousand six hundred ninety-five euro and fifteen cent (EUR 2.373.695,15) (the “Ordinary Shares”), and
five million four hundred nine thousand and seventy-four (5.409.074) mandatory redeemable preferred shares with a
nominal value of one euro (EUR 1) each (MRPS or APRO) divided into three million one hundred ten thousand eight
hundred and fiftyfour (3.110.854) non voting MRPS or APRO and two million two hundred ninety-eight thousand two
hundred twenty (2.298.220) voting MRPS or APRO.
<i>Subscription and paymenti>
The eight hundred twelve thousand six hundred thirty-one (812.631) ordinary shares with a nominal value of one euro
(EUR 1) each (the “Ordinary Shares”), and the five million four hundred nine thousand seventy-four (5.409.074) MRPS
or APRO with a nominal value of one euro (EUR 1) each divided into three million one hundred ten thousand eight
hundred and fiftyfour (3.110.854) non voting MRPS or APRO and two million two hundred ninety-eight thousand two
hundred twenty (2.298.220) voting MRPS or APRO are subscribed as follows:
1) Three hundred forteen thousand three hundred sixty-eight (314.368) Ordinary Shares with a nominal value of one
euro (EUR 1) each, together with a share premium of nine hundred eighteen thousand two hundred sixty-eight euro and
ninety three cent (EUR 918.268,93) for a total subscription price of one million two hundred thirty-two thousand six
hundred thirty-six euro and ninety-three cent (EUR 1.232.636,93) being understood that the difference between the
subscription price and the nominal value of each Ordinary Share will be allocated to the share premium account,
are subscribed by ULRAN S.A. a société anonyme with registered office at L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du
Prince Henri, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B10.563
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Luxembourg, on 21
st
February 2012, which will remain attached
hereto, and
2) One million two hundred three thousand four hundred forty-one (1.203.441) non voting MRPS or APRO and eight
hundred eighty-nine thousand seventy-three (889.073) voting MRPS or APRO, each with a nominal value of one euro
(EUR 1) for a total subscription price of two million ninetytwo thousand five hundred fourteen euro (EUR 2.092.514) are
subscribed by REDCREST Consulting Ltd, a company incorporated under the laws of Cyprus, with registered office at 2
Apostolos Varnavas, Centaur House, 2571 Nisou, Nicosia, Cyprus, registered under number 264672,
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Luxembourg, on 8
th
February 2012, which will remain attached
hereto, and
3) Twenty-five thousand six hundred thirty-seven (25.637) Ordinary Shares with a nominal value of one euro (EUR 1)
together with a share premium of seventy-four thousand eight hundred eighty-five euro and sixtyeight cent (EUR
74.885,68) for a total subscription price of one hundred thousand five hundred twenty-two euro and sixty-eight cent
(EUR 100.522,68) being understood that the difference between the subscription price and the nominal value of each
Ordinary Share will be allocated to the share premium account, and ninety-eight thousand one hundred forty (98.140)
non voting MRPS or APRO and seventy-two thousand five hundred three (72.503) voting MRPS or APRO each with a
nominal value of one euro (EUR 1) for a subscription price of one hundred seventy thousand six hundred forty-three
53485
L
U X E M B O U R G
euro (EUR 170.643), are subscribed by SURIDAM HOLDING S.A., SPF, a société anonyme, having its registered office
at L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number
B47290
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Luxembourg, on 11
th
January 2012, which will remain attached
hereto, and
4) Four thousand two hundred ninety-four (4.294) non voting MRPS or APRO and three thousand one hundred
seventy-two (3.172) voting MRPS or APRO each with a nominal value of one euro (EUR 1) for a subscription price of
seven thousand four hundred sixty-six euro (EUR 7.466), are subscribed by Mrs Mireille Gehlen, residing in L-3502
Dudelange, 2, rue J. F. Kennedy;
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Luxembourg, on 12
th
January 2012, which will remain attached
hereto, and
5) Four thousand two hundred ninety-four (4.294) non voting MRPS or APRO and three thousand one hundred
seventy-two (3.172) voting MRPS or APRO each with a nominal value of one euro (EUR 1) for a subscription price of
seven thousand four hundred sixty-six euro (EUR 7.466) are subscribed by Mr François Winandy, residing in L-2343
Luxembourg, 104, rue des Pommiers;
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Luxembourg, on 28
th
February 2012, which will remain attached
hereto, and
6) One hundred eighty thousand three hundred thirty-two (180.332) non voting MRPS or APRO and one hundred
thirty-three thousand two hundred twenty-five (133.225) voting MRPS or APRO each with a nominal value of one euro
(EUR 1) for a subscription price of three hundred thirteen thousand five hundred fifty-seven euro (EUR 313.557) are
subscribed by SOL SPF S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2319 Howald, 72, rue Dr J Peffer, registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 151.982
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Luxembourg, on 12
th
January 2012, which will remain attached
hereto, and
7) Seventy thousand one hundred eighty (70.180) Ordinary Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each,
together with a share premium of two hundred and four thousand nine hundred ninety-eight euro and seventy-eight cent
(EUR 204.998,78) for a total subscription price of two hundred seventyfive thousand one hundred seventy-five euro and
seventy-eight cent (EUR 275.175,78) being understood that the difference between the subscription price and the nominal
value of each ordinary share will be allocated to the share premium account, are subscribed by HOLDINGS INVEST S.C.,
a société civile, having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under number E 4247
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Luxembourg, on 12
th
January 2012, which will remain attached
hereto, and
8) Seventy-nine thousand seven hundred thirty-nine (79.739) non voting MRPS or APRO and fifty-eight thousand nine
hundred and nine (58.909) voting MRPS or APRO each with a nominal value of one euro (EUR 1) for a subscription price
of one hundred thirty-eight thousand six hundred forty-eight euro (EUR 138.648) are subscribed by SENOUFO S.A., SPF,
a société anonyme, having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under number B 157.220;
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Luxembourg, on 12
th
January 2012, which will remain attached
hereto, and
9) One hundred fifty-four thousand seven hundred eighty-eight (154.788) Ordinary Shares with a nominal value of one
euro (EUR 1) together with a share premium of four hundred fifty-two thousand one hundred thirty-five euro and seventy-
five cent (EUR 452.135,75) for a total subscription price of six hundred and six thousand nine hundred twenty-three euro
and seventy-five cent (EUR 606.923,75) being understood that the difference between the subscription price and the
nominal value of each ordinary share will be allocated to the share premium account, are subscribed by JEWEL PARTNERS
S.C, a société civile, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 41, Boulevard Prince Henri, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number E 4.575,
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Luxembourg, on 17
th
January 2012, which will remain attached
hereto, and
53486
L
U X E M B O U R G
10) Five hundred ninety-two thousand five hundred forty-four (592.544) non voting MRPS or APRO and four hundred
thirty-seven thousand seven hundred fifty-six (437.756) voting MRPS or APRO each with a nominal value of one euro
(EUR 1) for a subscription price of one million thirty hundred three hundred euro (EUR 1.030.300) are subscribed by
JEWEL SPF S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 41, Boulevard Prince Henri,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 164192
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Luxembourg, on 17
th
January 2012, which will remain attached
hereto, and
11) One hundred twenty-three thousand eight hundred twenty-nine (123.829) Ordinary Shares with a nominal value
of one euro (EUR 1), together with a share premium of three hundred sixty-one thousand seven hundred and four euro
and fifty-one cent (EUR 361.704,51) for a total subscription price of four hundred eighty-five thousand five hundred thirty-
three euro and fifty-one cent (EUR 485.533,51) being understood that the difference between the subscription price and
the nominal value of each ordinary share will be allocated to the share premium account, and four hundred seventy-four
thousand and thirty-five (474.035) non voting MRPS or APRO and three hundred fifty thousand two hundred and five
(350.205) voting MRPS or APRO each with a nominal value of one euro (EUR 1) are subscribed by Mr Hans Leijdesdorff
residing in Vliegheiweg, 3, NL-1272 PH Huizen
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Amsterdam, on 11
th
January 2012, which will remain attached hereto,
and
12) One hundred twenty-three thousand eight hundred twenty-nine (123.829) Ordinary Shares with a nominal value
of one euro (EUR 1), together a share premium of three hundred sixty-one thousand seven hundred and four euro and
fifty-one cent (EUR 361.704,51) for a subscription price of four hundred eighty-five thousand five hundred thirty-three
euro and fifty-one cent (EUR 485.533,51) being understood that the difference between the subscription price and the
nominal value of each ordinary share will be allocated to the share premium account, and four hundred seventy-four
thousand and thirty-five (474.035) non voting MRPS or APRO and three hundred fifty thousand two hundred and five
(350.205) voting MRPS or APRO each with a nominal value of one euro (EUR 1) are subscribed by Mrs Shareen Perret
Gentil residing in Vliegheiweg, 3, NL-1272 PH Huizen.
here represented by Mr Dirk Kees Broekhuyse prenamed,
by virtue of one proxy under private seal given in Amsterdam, on 11
th
January 2012, which will remain attached hereto.
The eight hundred twelve thousand six hundred and thirty-one (812.631) new ordinary shares and the five million four
hundred nine thousand and seventy-four (5.409.074) new mandatory redeemable preferred shares are fully paid up in
cash for an aggregate amount of eight millions five hundred ninety five thousand four hundred euro and fifteen cents (EUR
8.595.400,15) a out of which an amount of six millions two hundred twenty-one thousand seven hundred and five euro
(EUR 6.221.705) is allocated to the share capital of the Company and the remaing amount, i.e. two millions three hundred
seventy three thousand six hundred ninety five euro and fifteen cents (EUR 2.373.695,15) to the share premium account.
The total amount of eight millions five hundred ninety five thousand four hundred euro and fifteen cents (EUR
8.595.400,15) is as of now at the free disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary by a bank
certificate.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to cancel the existing authorized capital of fifteen million euro (EUR 15.000.000) and to
create a new authorized capital and to fix it at sixteen million nine hundred and four thousand six hundred and six euro
(EUR 16.904.606).
An original of the special report provided for by article 32-3 (5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended, will remain attached to the present deed to be registered therewith.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the general meeting resolves to amend article 5 of the articles of
incorporation of the Company to give it henceforth the following wording:
“ Art. 5. Share capital.
5.1. The subscribed share capital is set at fifty-five million two hundred twenty-one thousand seven hundred and five
euro (EUR 55.221.705) consisting of seven million two hundred twelve thousand six hundred thirtyone (7.212.631) or-
dinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (“The Ordinary Shares”); twenty-seven million six hundred
ten thousand eight hundred and fifty-four (27.610.854) mandatory redeemable preferred shares without voting right with
a nominal value of one euro (EUR 1) each (“The non voting MRPS or APRO”) and twenty million three thousand ninety-
eight thousand two hundred and twenty (20.398.220) mandatory redeemable preferred shares with voting right with a
nominal value of one euro (EUR 1) each (“The voting MRPS or APRO” together with “The non voting MRPS or APRO”,
“The MRPS or APRO”).
Reference is made to the Ordinary Shares and to the MRPS or APRO individually as Share and together as Shares.
53487
L
U X E M B O U R G
5.2. The authorised capital is fixed at sixteen million nine hundred and four thousand six hundred and six euro (EUR
16.904.606) consisting of sixteen million nine hundred and four thousand six hundred and six (16.904.606) Ordinary
Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
Consequently the Board of Directors is authorised for a period of five years, as from the date of publication in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the extraordinary general meeting dated 28 February 2012, to render
effective such increase of capital and more especially to issue the new shares as a whole at once, by successive portions,
as the case may be, to fix the place and date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions
of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix all other terms and conditions which
are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution, to have documented in the notarial
form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of capital, in accordance with the law of
10 August 1915 as amended and especially under the conditions that the authorization has to be renewed every five years
and as long as the share capital issued as a result of such increases stay equal or lower than sixteen million nine hundred
and four thousand six hundred and six euro (EUR 16.904.606).
Moreover, the Board of Directors is authorised to issue any ordinary or convertible debt instrument, in registered
form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible debt instrument may only be made
within the limits of the authorized capital.
The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reim-
bursement and any other conditions which may be related to such issue.
A ledger of the registered instrument holders will be held at the registered office of the company.
The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of
capital within the limits of the authorized capital.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in
addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
The authorised and subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by
the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles.”
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to authorize the Board of Directors to issue Convertible Private Equity Certificates
“CPECs” and to suppress or limit the preferential subscription right in case of increase of capital within the limits of the
authorized capital.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolves to empower Mrs Corinne Bitterlich, Mr Alain Renard and Mrs Emeline Dubois, acting
individually, to proceed to all the necessary registrations in the Shareholders’ register so as to reflect the above adopted
amendments.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 18.2 of the articles of incorporation of the Company as follows:
« 18.2. Each APRO or MRPS, voting or non voting, entitles its holder to a preferential and cumulative dividend at the
rate of 6% of the par value of the APRO or MRPS calculated since their issue date (the “First Preferential Dividend”). The
First Preferential Dividend shall accrue daily and be calculated assuming a year of 365 days.
In case (i) APRO or MRPS be issued at different dates and (ii) at the issue date of new APRO or MRPS, the First
Preferential Dividend accrued until the issue date for the existing APRO or MRPS would be, wholly or in part, unpaid
(the “Accrued Dividend”), the later will be paid by priority to the holders of existing APRO or MRPS. The part of the
First Preferential Dividend, relating to the period after the issue date of the new APRO or MRPS, will be paid pari passu
between all the holders of APRO or MRPS.»;
There being no further business, the meeting is terminated.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, 412F, route d'Esch, on the day named at the beginning of
this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons this deed is worded in French followed by an English version; on request of the same appearing persons and in
case of divergences between the French and the English texts, the French text will prevail.
The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary this
original deed.
Signé: K. BROEKHUYSE, C. BITTERLICH, E. DUBOIS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mars 2012. LAC/2012/9760. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
53488
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012035687/687.
(120046798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Japan Logistics II S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BRE/Japan NPL 2 S.à r.l.).
Capital social: JPY 2.100.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.564.
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth day of March,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Japan Logistics Topco S.à r.l. (formerly BRE/Japan IV S.à r.l.),a société à responsabilité limitée, governed by the laws of
the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies register under number B 164.887,
duly represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 March 2012.
This proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of BRE/Japan NPL 2 S.à r.l.,a société à respon-
sabilité limitée having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies' register under number B 166.564, incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler,
notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg on 6 May 2011, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”).
The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the Company's name to “Japan Logistics II S.à r.l.".
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company which shall now
read as follows:
“ Art. 4. The Company will assume the name of “Japan Logistics II S.à r.l.”.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L'an deux mille douze, le seize mars,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Japan Logistics Topco S.à r.l. (anciennement BRE/Japan IV S.à r.l.)une société à responsabilité limitée, régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés sous section B numéro 164.887,
ici représentée par Mademoiselle Carole Noblet, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé donnée le 16 mars 2012.
La procuration signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de BRE/Japan NPL 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée
ayant son siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 166.564, constituée le 6 mai 2011 par un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de
53489
L
U X E M B O U R G
résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (la «Société»).
L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en “Japan Logistics II S.à r.l.”.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
“ Art. 4. La société prend la dénomination de “Japan Logistics II S.à r.l.”.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état civil et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. NOBLET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mars 2012. Relation: LAC/2012/12779. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Référence de publication: 2012036583/69.
(120049070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Glacis S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 167.685.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Renato FAVARO, restaurateur, demeurant à L4303 Esch-sur-Alzette, 19, rue des Remparts.
agissant en son nom personnel.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-personnelle à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée uni-personnelle sous la dénomination de:
"GLACIS S.à r.l.".
L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également
prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère uni-personnel de la société.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un établissement de restauration avec le service-traiteur, le commerce
de produits alimentaires et plats à emporter, avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, ainsi que toutes les
activités qui se rattachent directement et indirectement à son objet.
Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente-et-un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), représenté par
CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.
53490
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de
préemption.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition
de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu'au partage des-dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont
applicables.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.
A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances.
L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-
Duché qu'à l'étranger.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation
personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'associé.
Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions
légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mille
douze (31.12.2012).
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur Monsieur Renato FAVARO, restaurateur,
demeurant à L-4303 Esch-sur-Alzette, 19, rue des Remparts, préqualifié.
L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès-à-présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille cent euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Renato FAVARO, restaurateur, né à San Fedele Intelvi (Italie) le 16 décembre 1962, demeurant à L4303
Esch-sur-Alzette, 19, rue des Remparts.
53491
L
U X E M B O U R G
La société est valablement engagée par sa seule signature.
2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-2520 Luxembourg, 21-25, Allée Scheffer.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, le comparant a signé avec moi, notaire, la présente minute.
Signé: R. Favaro, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 mars 2012. Relation: EAC/2012/3942. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2012.
Référence de publication: 2012036739/95.
(120049218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
BPM Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 83.021.
Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012038482/12.
(120052013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Dinio S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 155.803.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DINIO S.A. S.P.F.
Société Anonyme - société de gestion de patrimoine familial
Référence de publication: 2012038530/11.
(120051614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
BCLI no. 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 19.800,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 164.096.
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth of March,
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED
BCLI no. 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.088,
here represented by Mrs. Audrey MUCCIANTE, avocat à la Cour, with professional address at 2-4, place de Paris,
L-2314 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 15 March 2012.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of "BCLI no. 2 S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
53492
L
U X E M B O U R G
number B 164.096, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 13 October 2011, whose articles
of incorporation (the "Articles") are published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2989
dated 6 December 2011. The Articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary, dated 22 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
386 dated 14 February 2012.
The appearing party representing the whole share capital of the Company requires the notary to act the following
resolutions taken in accordance with the provisions of Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies
of 10 August 1915, as amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise
the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded
in minutes or drawn up in writing and of Article 14 of the Articles:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder, pursuant to a request from its ultimate UK shareholder, decides to amend the financial year of
the Company, with immediate effect, which will run from 21 December of one year to 20 December of the following
year.
For the avoidance of doubt, the sole shareholder acknowledges and resolves that the current financial year of the
Company which started on 1 January 2012 will close on 20 December 2012, and that the subsequent financial year will
start on 21 December 2012 and will end on 20 December 2013.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to amend article 15 and article 16.1 of the
Articles of the Company, which shall henceforth read as follows:
" Art. 15. Financial year
The Company's financial year runs from twenty-one December of one year to twenty December of the following year.
The Shareholder(s) may shorten the term of the financial year at any time."
"16.1 Each year, as of the date of the financial year end, the board of managers will draw up a balance sheet, which will
(i) contain a record of all movable and immovable property of, and all the debts and other liabilities owed to and by, the
Company and (ii) be accompanied by an annex summarising all the commitments of the Company and debts of the
managers and/or auditors to the Company."
<i>Costs and Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède :
L'an deux mille douze, le seize mars;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
A COMPARU:
BCLI no. 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant
son siège social au 9 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.088,
ici représentée par Me Audrey MUCCIANTE, Avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée le 15 mars 2012,
laquelle procuration, signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être enregistrés en même temps avec l'autorité d'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de "BCLI no. 2 S.à r.l." (la «Société»), une société à responsabilité
limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 164.096, constituée suivant un acte reçu par le notaire soussigné le 13 octobre 2011, dont les statuts (les
"Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2989 le 6 décembre 2011. Les
Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire soussigné le 22 décembre
2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 386 le 14 février 2012.
53493
L
U X E M B O U R G
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, requit le notaire d'acter les résolutions suivantes
conformément à l'Article 200-2 de la loi concernant les sociétés commerciales, du 10 août 1915, comme modifié (la "Loi
sur les Sociétés"), suite à lequel l'associé unique d'une société à responsabilité limitée peux exercer les pouvoirs attribué
à l'assemblée des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront inscrites sur un procès-verbal et article
14 des Statuts:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide, sur demande exprès de son associé final anglais, de modifier l'exercice social de la Société,
avec effet immédiat, de sorte que l'exercice social de la Société commencera le 21 décembre d'une année et se terminera
le 20 décembre de l'année suivante.
Pour éviter tout doute, l'associé unique reconnaît et décide que l'exercice social en cours de la Société commencé le
1
er
janvier 2012 se terminera le 20 décembre 2012, et que l'exercice social suivant commencera le 21 décembre 2012
et se terminera le 20 décembre 2013.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 15 ainsi que le premier
paragraphe de l'article 16.1 des Statuts de la Société, lesquels devront dorénavant se lire comme suit:
" Art. 15. Exercice social
L'exercice social de la société commence le 21 décembre d'une année et se termine le 20 décembre de l'année suivante.
Le ou les associés peuvent abréger la durée de l'exercice social à tout moment."
"16.1. Chaque année, au dernier jour de l'exercice social, le conseil de gérance établit un bilan (i) comprenant un
inventaire des actifs mobiliers, immobiliers ainsi que de toutes les dettes actives et passives de la Société, et (ii) accompagné
d'une annexe synthétisant tous les engagements de la Société ainsi que les dettes des gérants et/ou commissaires aux
comptes envers la Société."
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. MUCCIANTE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mars 2012. LAC/2012/12717. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012036570/112.
(120048913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Capon Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 70.956.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
Référence de publication: 2012038494/10.
(120052034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
53494
L
U X E M B O U R G
Casolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4873 Lamadelaine, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 64.496.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038495/10.
(120051655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
CCP Acquisition GS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 145.435.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Eric Lechat
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012038496/12.
(120051486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
EF Cultural Tours S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 360.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 65.074.
Le bilan et le compte de profits et de pertes au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038548/11.
(120051892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent Quarante-Cinquième (445.) S.e.c.s., Société en Commandite sim-
ple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 167.664.
STATUTEN
Gesellschaftsvertrag
Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent Quarante-Cinquième (445.) S.e.c.s..
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort
des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-
burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.
(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In-und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-
weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.
53495
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à.r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der
Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à.r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.
Ausschließlich die INNCONA Management S.à.r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Dr. Hoerster, Winfried
Straße: Mozartstr. 5 Postleitzahl/Wohnort: Gießen, D-35392
Geburtsdatum/Geburtsort: 31.07.1943 / Ahrweiler
Beruf: Arzt
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist
erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen. Daneben zahlt der Kommanditist ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.
Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S,à.r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-
rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à.r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.
(2) Die INNCONA Management S.à.r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle
Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:
a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-
titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.
c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei
Versicherungsschäden;
f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von
300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen; i) Aufnahme neuer Gesellschafter.
Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à.r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht ein-
holen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschaf-
terversammlung nachzuholen.
Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-
schafterversammlung einberufen.
(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu
machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.
(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie
auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.
(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von
Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
53496
L
U X E M B O U R G
chlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.
(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu
übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.
(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.
Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.
(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht
mehr.
(4) Die Gesellschafter beschließen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen,soweit nicht in diesem Ver-
trag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Geschäfts-
betriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des Liquidators
bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.
(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sindNiederschriften anzufertigen und
den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres
und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).
Schengen, den 26.06.2007.
INNCONA Management S.à. r.l.
Unterschrift
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2012036773/114.
(120049022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
CFC Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 73.304.
Les comptes annuels au 31 octobre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012038500/10.
(120051823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Convert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 30, boulevard de Verdun.
R.C.S. Luxembourg B 84.043.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
53497
L
U X E M B O U R G
<i>Le Géranti>
Référence de publication: 2012038509/10.
(120051666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Courtignac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 135.228.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012038513/10.
(120051684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Even RX Fünf Real Estate Partnership S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 231.001,00.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 148.149.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012038560/11.
(120051444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
KoBauLux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4531 Differdange, 166, avenue Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.677.
STATUTS
L'an deux mille douze.
Le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU
La société anonyme HOLDING ONE S.A.H., avec siège social à L2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98.671,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
et
- Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt.
La société comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif
d'une société anonyme qu'elle déclare vouloir constituer et dont elle a arrêté‚ les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KoBauLux S.A..
Art. 2. Le siège de la société est établi à Differdange.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d’une
résolution de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d’actionnaires, au moyen d’une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires.
Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique aura le droit d’instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
53498
L
U X E M B O U R G
Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, la promotion immobilière ainsi que l'achat et
la vente de maisons en bois.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310)
actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100.-) par action.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés
jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera sera de même dans
le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Administration – Surveillance
Art. 8. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à un membre, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-
présidents du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du
président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou fax.
Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation
du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
53499
L
U X E M B O U R G
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité
des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 10. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signés par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d’administration ou par deux
administrateurs ou l’administrateur unique.
Art. 11. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-
complir tous les actes de disposition et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration ou de l’administrateur
unique.
Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d’admi-
nistration ou l’administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d’administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d’administrateur-délégué.
Art. 13. Le conseil d’administration ou l’administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit
en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:
- en cas d’administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle
du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore
- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pou-
voirs, ou
- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'admi-
nistration.
Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l’assemblée générale ou l’actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne peut pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 16. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement
par l’administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
53500
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation
des règles y relatives.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Disposition générale
Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par la société anonyme HOLDING ONE S.A.H., avec siège social
à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 98.671.
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme
de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents Euros
(€ 1.300.-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante représentant l'intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à un.
Est nommé administrateur unique:
Monsieur Claude WEINZIERL, ingénieur, demeurant à L-4941 Bascharage, 64, rue des Prés,
lequel aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque et
mainlevée.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société anonyme LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 25.797.
3) Le premier mandat de l'administrateur unique et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2017.
4) Le siège social est fixé à L-4531 Differdange, 166, avenue Charlotte.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instru-
mentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. GALOWICH, J.-P. FRANK, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 21 mars 2012. Relation: ECH/2012/491. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
53501
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012036794/191.
(120049025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Isanne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.176.
Le Bilan consolidé au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
(conforme Art. 314 du loi du 10 août 1915 concernant les sociétés)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
ISANNE S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012038632/14.
(120051785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Dolmen International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 95.920.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038533/9.
(120051391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Matterhorn Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Olympus Midco S.à r.l.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.826.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth of February.
Before Us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, acting
in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed.
THERE APPEARED:
“Matterhorn Topco & Cy S.C.A.”, a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 165.824,
here represented by Maître Linda Harroch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg
on 28 February 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of “Olympus Midco S.à r.l.”, (hereinafter the “Company”) a société à
responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Company Register under B 165.826, incorporated pursuant to a notarial deed dated 23 December 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 14 February 2012, number 393, page 18856.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the Company's name into “Matterhorn Midco S.à.r.l.” and to amend article 4
of the articles of incorporation of the Company that shall be read as follows:
“ Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination: “Matterhorn Midco S.à.r.l.”.”
53502
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of an amount of one hundred and
fifty-two million one hundred and thirty thousand five hundred and twenty Swiss Franc (CHF 152,130,520.00), so as to
raise it from its present amount of ninety-six thousand Swiss Franc (CHF 96,000.00) up to one hundred and fifty-two
million two hundred and twenty-six thousand five hundred and twenty Swiss Franc (CHF 152,226,520.00), by the issue
of one hundred and fifty-two million one hundred and thirty thousand five hundred and twenty (152,130,520) new shares
(collectively referred as the“New Shares”), each having a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-), each such New Shares
having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below
resolutions, paid up by a contribution in cash.
The aggregate contribution of seven hundred and sixty million six hundred and fifty-two thousand six hundred and
two Swiss Francs (CHF 760,652,602.00) in relation to the New Shares is allocated as follows (i) one hundred and fifty-
two million one hundred and thirty thousand five hundred and twenty Swiss Franc (CHF 152,130,520.00) to the
Company's share capital and (ii) six hundred and eight million five hundred and twenty-two thousand eighty-two Swiss
Francs (CHF 608,522,082.00) to the Company' share premium account.
<i>Subscription - Paymenti>
Matterhorn Topco & Cy S.C.A. prenamed. has declared to subscribe for one hundred and fifty-two million one hundred
and thirty thousand five hundred and twenty (152,130,520) New Shares and to pay them a total price of seven hundred
and sixty million six hundred and fifty-two thousand six hundred and two Swiss Francs (CHF 760,652,602.00) by means
of a contribution in cash. The aggregate contribution of seven hundred and sixty million six hundred and fifty-two thousand
six hundred and two Swiss Francs (CHF 760,652,602.00) in relation to the New Shares subscribed by Matterhorn Topco
& Cy S.C.A. is allocated as follows (i) one hundred and fifty-two million one hundred and thirty thousand five hundred
and twenty Swiss Franc (CHF 152,130,520.00) to the Company's share capital and (ii) six hundred and eight million five
hundred and twenty-two thousand eighty-two Swiss Francs (CHF 608,522,082.00) to the Company' share premium
account.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The sole partner decides to restate article 6.1 of the Company's articles of incorporation, which shall be read as
follows:
“ 6.1. The capital is fixed at one hundred and fifty-two million two hundred and twenty-six thousand five hundred and
twenty Swiss Franc (CHF 152,226,520.00) represented by one hundred and fifty-two million two hundred and twenty-
six thousand five hundred and twenty (152,226,520) shares of one Swiss Franc (CHF 1.00) each (the “Shares”), each
having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, “Shareholders” means the holders at the
relevant time of the Shares and “Shareholder” shall be construed accordingly.”
<i>Valuation - Costsi>
The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged
to it by reason of the present deed are estimated at seven thousand euros.
Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huit février.
Par-devant Nous Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxem-
bourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de l'original de la présente minute.
A COMPARU:
«Matterhorn Topco & Cy S.C.A.» une société en commandite par actions constituée et régie selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.824,
ici représentée par Maître Linda Harroch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé
donnée à Luxembourg, le 28 février 2012.
53503
L
U X E M B O U R G
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de «Olympus Midco S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 160.514, constituée selon un acte notarié en date du 23 décembre 2011, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 14 février 2012 numéro 393, page 18856.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société en «Matterhorn Midco S.à.r.l.» et de modifier
l'article 4 des statuts qui doit être lu comme suit:
« Art. 4. Dénomination. La Société adopte la dénomination: «Matterhorn Midco S.à r.l.».»
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de cent cinquante-deux millions
cent trente mille cinq cent vingt Francs Suisses (CHF 152.130.520,00), de façon à l'accroître de son montant actuel de
quatre-vingt-seize mille Francs Suisses (CHF 96.000,00) à cent cinquante-deux millions deux cent vingt six mille cinq cent
vingt Francs Suisses (CHF 152.226.520,00), par l'émission de cent cinquante-deux millions cent trente mille cinq cent vingt
(152.130.520) nouvelles parts sociales (collectivement désignées comme les «Nouvelles Parts Sociales»), chacune ayant
une valeur nominale d'un Franc Suisse (CHF 1.00) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts
de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées par un apport en numéraire.
Le montant total de l'apport de sept cent soixante millions six cent cinquante-deux mille six cent deux Francs Suisses
(CHF 760.652.602,00) est alloué (i) au capital social de la Société pour un montant de cent cinquante-deux millions cent
trente mille cinq cent vingt Francs Suisses (CHF 152.130.520,00) et (ii) au compte de prime d'émission pour un montant
de six cent huit millions cinq cent vingt-deux mille quatre vingt-deux Francs Suisses (CHF 608.522.082,00).
<i>Souscription - Paiementi>
Matterhorn Topco & Cy S.C.A., prénommée, a déclaré souscrire à cent cinquante-deux millions cent trente mille cinq
cent vingt (152.130.520) Nouvelles Parts Sociales pour un montant total de sept cent soixante millions six cent cinquante-
deux mille six cent deux Francs Suisses (CHF 760.652.602,00) payées par un apport en numéraire. L'apport total d'un
montant de sept cent soixante millions six cent cinquante-deux mille six cent deux Francs Suisses (CHF 760.652.602,00)
en relation avec ces Nouvelles Parts Sociales souscrites par Matterhorn Topco & Cy S.C.A., est alloué comme suit: (i)
cent cinquante-deux millions cent trente mille cinq cent vingt Francs Suisses (CHF 152.130.520,00) est alloué au capital
social et (ii) six cent huit millions cinq cent vingt-deux mille quatre vingt-deux Francs Suisses (CHF 608.522.082,00) est
alloué au compte de prime d'émission de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:
« 6.1. Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante-deux millions deux cent vingt six mille cinq cent vingt
Francs Suisses (CHF 152.226.520,00) représenté par cent cinquante-deux millions deux cent vingt six mille cinq cent vingt
(152.226.520) parts sociales, d'une valeur d'un Franc Suisse (1.00 CHF) chacune (les «Parts Sociales»); chacune ayant les
droits et obligations tel que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au moment
opportun de Parts Sociales et «Associé» devra être interprété conformément.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, en raison
du présent acte, sont évalués à sept mille euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête e la personne compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom,
état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. HARROCH, R. ARRENSDORFF.
53504
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 mars 2012. Relation: EAC/2012/2844. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012036875/138.
(120049099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
DNB Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 22.374.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 Mars 2012.
DNB LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012038532/12.
(120052016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Edufin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 132.568.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012038537/10.
(120051491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Euroports Port Acquisitions Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 117.542.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012038542/10.
(120051529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
EF Cultural Tours S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 360.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 65.074.
Le bilan consolidé et le compte de profits et de pertes consolidé au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038547/12.
(120051891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Eden Shoes Lux. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 147.868.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
53505
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012038544/10.
(120051752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Eden Shoes Lux. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 147.868.
Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012038545/10.
(120051753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Edmund Frette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 119.472.
Les Comptes Consolidés au 31 décembre 2010, le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d'entreprises
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038546/10.
(120051647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Euro Ethnic Foods Global, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 135.990.
Le bilan abrégé au 30 juin 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2012038552/10.
(120051727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Euromill Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn.
R.C.S. Luxembourg B 82.980.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038555/9.
(120051548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Even Germany S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 36.061,00.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 121.940.
Les comptes annuels consolidés au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012038558/13.
(120051447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
53506
L
U X E M B O U R G
Even RX Properties S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 42.860,00.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 124.378.
Les comptes annuels consolidés au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012038562/13.
(120051819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Even Germany S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 36.061,25.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 121.940.
Les comptes annuels statutaires au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012038559/12.
(120051448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Even RX Properties S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 42.860,00.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 124.378.
Les comptes annuels statutaires au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012038561/12.
(120051446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Exelenz S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 77.053.
Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 août 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Référence de publication: 2012038563/11.
(120051887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
53507
L
U X E M B O U R G
LBCI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 60.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.334.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2012.
<i>Pour LBCI S.à r.l.
i>Mr. Gianpaolo Bianchi
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012038673/14.
(120051572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Euro Real Estate France I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 167.659.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth day of March, with continuation on the nineteenth day of March,
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Euro Real Estate Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 49, boulevard Prince Henri; L-1724 Luxembourg, which
registration with the Luxembourg Trade and Companies register is pending,
here represented by Gerd Schneider, class A manager, with professional address at 25, Montée de Clausen, L-1343
Luxembourg
and by Nadine Billal, class B manager with professional address at 1 B, Kelerhof, D-85630 Grasbrunn.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name – Registered office – Object – Duration
Art. 1. Name
The name of the company is ”Euro Real Estate France I S.àr.l.” (the Company). The Company is a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and, in particular,
the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxemburg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
53508
L
U X E M B O U R G
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The purpose of the Company is further the aquisition, development and management as well as the sale of real
estate in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.
3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art .5. Capital
5.1. The share capital is set at one hundred thousand euro (EUR 100,000), represented by four thousand (4,000) shares
in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders. Where the Company has a sole shareholder, shares are freely
transferable to third parties. Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to
third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors. A share transfer is only binding upon the Company or third parties following
a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management – Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers
7.1. The Company is managed by several managers including at least one class A and one class B manager appointed
by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not to be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
53509
L
U X E M B O U R G
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound with respect to decisions involving amounts of up to ten thousand euro (10,000 Euro) by
the single signature of any one manager.
The Company is bound towards third parties in all other matters by the joint signatures of at least one class A manager
and one class B manager or by the single signature of any one class B manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Sole manager
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to
be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers
The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by
them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions only by
a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
53510
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Sole shareholder
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Allocation of profits
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the
date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company
VI. Dissolution – Liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
15.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
16.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.
16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject
to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
53511
L
U X E M B O U R G
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
Euro Real Estate Holding S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for four thousand
(4,000) shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and agrees to pay them in full by
a contribution in cash in the amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000). The amount of one hundred thousand
euro (EUR 100,000) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately EUR 1,600.- (one thousand six hundred Euro)
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entire sub-
scribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(a) Mr. Gerd Schneider, Tax Adviser, born on 17 November 1965 in Kaiserslautern, Germany, residing at 25, Montée
de Clausen, L-1343 Luxembourg, as class A manager;
(b) Mrs. Nadine Billal, Real Estate Manager, born on 25 May 1978 in Coburg, Germany, residing at Kelerhof 1 B in
D-85630 Grasbrunn, as class B manager.
2. The registered office of the Company is established at 49, boulevard Prince Henri; L-1724 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the days stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Mister Gerd Schneider, class A manager has signed on the sixteenth day of March and Nadine Billal, class B manager
has signed on the nineteenth day of March.
Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes :
Am sechszehnten und neunzehnten Tag des Monats März im Jahre zweitausendundzwolf,
ist vor dem unterzeichnenden Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg,
ERSCHIENEN:
die Euro Real Estate Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und organisiert nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 49, boulevard Prince Henri; L-1724 Lu-
xemburg, deren Registrierung im luxemburgischen Handels und Gesellschaftsregister anhängig ist,
hier vertreten durch Gerd Schneider, Klasse A Geschäftsführer, mit Geschäftsadresse in 25, Montée de Clausen,
L-1343 Luxembourg und
Nadine Billal, Klasse B Geschäftsführer, mit Geschäftsadresse in 1B, Kelerhof, D-85630 Grasbrunn.
Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen:
I. Firma – Gesellschaftssitz – Gesellschaftszweck – Dauer
Art. 1. Name
Der Name der Gesellschaft lautet „Euro Real Estate France I S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesell-
schaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft (der Rat) an einen anderen Ort innerhalb der
Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
53512
L
U X E M B O U R G
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Rates errichtet werden. Sollte der Rat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereig-
nisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesell-
schaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben
keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschafts-
sitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in-oder ausländischen Gesellschaften oder Un-
ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.
3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung sowie der Verkauf von Immobilien
sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland.
3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die
erforderliche Genehmigung, reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
3.4. Die Gesellschaft, ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz-und andere Risiken abzusichern.
3.5. Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf
Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.
Art. 4. Dauer
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Kapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Kapital
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000), bestehend aus viertausend
(4,000) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25); die Gesellschaftsanteile wurden
gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-
stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile
6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Gesellschaftsanteil
zu.
6.2. Die Gesellschaftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile an Dritte frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (inter vivos) an
Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Ge-
sellschaft vertreten müssen.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
53513
L
U X E M B O U R G
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter
eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern
7.1. Die Gesellschaft wird von mehreren Geschäftsführern, bestehend aus mindestens einem Klasse A und einem Klasse
B Geschäftsführer, verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch
ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein..
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen
werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.
(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-
lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-
nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
(v) Der Rat ist nur tagungs-und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Ge-
schäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsit-
zenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon-oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommuni-
kationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-
schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird in Angelegenheiten bis zu einem Betrag in Höhe von zehntausend Euro (10.000 Euro) durch
die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden.
In allen Übrigen Angelegenheiten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift
mindestens eines Klasse A Geschäftsführers sowie mindestens eines Klasse B Geschäftsführers oder durch die alleinige
Unterschrift mindestens eines Klasse B Geschäftsführers gebunden.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichung der mit Spezialvollmachten ausgestat-
teten Personen gebunden.
Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer
9.1. Wird die Gesellschaft von einem alleinigen Geschäftsführer verwaltet, sind die oben genannten Bestimmungen,
welche für den Rat oder für die Geschäftsführer gelten, auch auf den alleinigen Geschäftsführer sinngemäß anzuwenden.
9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.
53514
L
U X E M B O U R G
9.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift der mit Spezialvollmachten ausgestatteten
Personen gebunden.
Art. 10. Haftung der Geschäftsführer
Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der
Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Be-
stimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.
IV. Gesellschafter
Art. 11. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter
11.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch
Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt.
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im
Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt.
(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäβ einberufen betrachten.
(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder den ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann nur aufgrund der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
Art. 12. Alleingesellschafter
12.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch
der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.
12.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
12.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung – Aufsicht
Art. 13. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses
13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden
Jahres.
13.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn-und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,
welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
13.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn-und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines
Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.
53515
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Gewinnausschüttung
14.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
14.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
14.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um
die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der ge-
setzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2)
Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-
tung nicht gefährdet werden; und
(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
VI. Auflösung – Liquidation
15.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-
ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung
der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.
15.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-
schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
16.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbe-
schlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
16.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer
Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.
16.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-
den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon-oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-
enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Euro Real Estate Holding S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet vier tausend (4,000) Gesellschaftsanteile mit einem
Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Gesellschaftsanteile in
Höhe von einhunderttausend Euro (EUR 100.000).
Die Aktien wurden vollständig in Bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 100.000 (einhunderttausend Euro) jetzt
der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Urkunde entstehen, werden ungefähr EUR 1.600,- (ein tausend sechs hundert Euro) betragen.
53516
L
U X E M B O U R G
<i>Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Gesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeichneten
Gesellschaftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
(a) Herr Gerd Schneider, Steuerberater, geboren am 17. November 1965 in Kaiserslautern, Deutschland, geschäfts-
ansässig in der 25, Montée de Clausen, L-1343 Luxembourg, als Klasse A Geschäftsführer;
(b) Frau Nadine Billal, Real Estate Manager, geboren am 25. Mai 1978 in Coburg, Deutschland, geschäftsansässig in
Kelerhof 1 B in D-85630 Grasbrunn, als Klasse B Geschäftsführer.
2. Sitz der Gesellschaft ist in 49, boulevard Prince Henri; L-1724 Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichnenden
Notar unterschrieben.
Gerd Schneider, Klasse A Geschäftsführer hat am sechzehnten März unterschrieben und Nadine Billal, Klasse B Ge-
schäftsführer hat am neunzehnten März unterschrieben
Signé: G. SCHNEIDER, N. BILLAL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 21 mars 2012. Relation: LAC/2012/13024. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société à sa demande.
Luxembourg, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012036130/504.
(120048435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
E.D.P. S.A., Expertises et Développements Publics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 94.456.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038564/10.
(120051643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
F.F.F. Management & Trust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 42.411.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012038565/12.
(120052015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Feather Lease S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 139.183.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
53517
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012038567/10.
(120051780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Feuerhaus S.à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5374 Munsbach, 4, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg B 94.852.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038568/9.
(120051399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Fonds Direkt Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 70.709.
Les comptes annuels au 30. September 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für Fonds Direkt Sicav
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2012038570/11.
(120051735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Frösunda Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 152.062.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012038572/10.
(120051629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
German Real Estate Partners Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 450.000,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 122.589.
Les comptes annuels consolidés au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012038593/13.
(120051449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Filao Beach S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 31.065.
Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
53518
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 mars 2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012038577/12.
(120051671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Finbra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 62.242.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
FINBRA S.A.
Référence de publication: 2012038579/11.
(120051432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Flare Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 1A, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 127.247.
Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012038582/12.
(120051865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
LBCI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 60.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.334.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2012.
<i>Pour LBCI S.à r.l.
i>Mr. Gianpaolo Bianchi
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012038674/14.
(120051573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Flare Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 127.247.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012038583/12.
(120051866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
53519
L
U X E M B O U R G
GeoVille Environmental Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 124.588.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012038590/10.
(120051440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
German Real Estate Partners Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 450.000,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 122.589.
Les comptes annuels statutaires au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012038594/12.
(120051450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Giacelma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 122-124, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 63.613.
Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 Mars 2012.
Référence de publication: 2012038595/10.
(120051978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Giacelma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 122-124, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 63.613.
Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 Mars 2012.
Référence de publication: 2012038596/10.
(120051979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
LFH Corporation, Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 131.303.
Les comptes annuels au 31décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012038681/9.
(120051738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
53520
Ballywilliam S.A.
BCLI no. 2 S.à r.l.
BPM Luxembourg S.A.
BRE/Japan NPL 2 S.à r.l.
Capon Properties S.A.
Casolux S.A.
CCP Acquisition GS S.à r.l.
Cerlux S.A.
CFC Reinsurance S.A.
Convert S.à r.l.
Courtignac S.A.
Dinio S.A. S.P.F.
DNB Luxembourg S.A.
Dolmen International S.A.
Eden Shoes Lux. S.à r.l.
Eden Shoes Lux. S.à r.l.
Edmund Frette S.à r.l.
Edufin S.à r.l.
EF Cultural Tours S.à r.l.
EF Cultural Tours S.à r.l.
Euro Ethnic Foods Global
Euromill Invest S.A.
Euroports Port Acquisitions Luxembourg S.à r.l.
Euro Real Estate France I S.à r.l.
Even Germany S.C.A.
Even Germany S.C.A.
Even RX Fünf Real Estate Partnership S.C.S.
Even RX Properties S.C.A.
Even RX Properties S.C.A.
Exelenz S.à.r.l.
Expertises et Développements Publics S.A.
Feather Lease S.à r.l.
Feuerhaus S.à r. l.
F.F.F. Management & Trust S.A.
Filao Beach S.A.
Finbra S.A.
Flare Finance S.A.
Flare Finance S.A.
Fonds Direkt Sicav
Frösunda Luxco S.à r.l.
GeoVille Environmental Services S.à r.l.
German Real Estate Partners Luxembourg S.A.
German Real Estate Partners Luxembourg S.A.
Giacelma S.A.
Giacelma S.A.
Glacis S.à r.l.
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent Quarante-Cinquième (445.) S.e.c.s.
Isanne S.à r.l.
Japan Logistics II S.à r.l.
Kanelium Invest S.A.
KoBauLux S.A.
LBCI S.à r.l.
LBCI S.à r.l.
LFH Corporation
Matterhorn Midco S.à r.l.
Olympus Midco S.à r.l.