This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1102
30 avril 2012
SOMMAIRE
88 St. James Street S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
52883
Aldorf & Norbereit Invest S.A. . . . . . . . . . .
52852
BAAL Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52852
BRE/Japan NPL 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
52869
Capinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52890
Catalyst Buyout I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
52886
CEREP Bedford S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52890
Cherras Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52862
Clinlux S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52863
Consolidated Equipments S.A. . . . . . . . . . .
52891
CORNÈR BANQUE (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52891
CS Nordic Retail No.1 S.A. . . . . . . . . . . . . .
52891
CS Nordic Retail No.2 S.A. . . . . . . . . . . . . .
52895
CSN Resources S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52895
DB Akela Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52895
Eleven Apricot S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52892
EMVF Lux Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52863
EMVF Lux Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52871
Esaress International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52890
Flux Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52878
Fondation Ste Zithe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52857
Happy Goo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52880
HEPP IV Luxembourg JV S.à r.l. . . . . . . . . .
52861
HEPP IV Management Company S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52879
HMP Beratungsgesellschaft für Telekom-
munikations- und Sicherheitssysteme
GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52889
IBC-Worldwide International Business
Consulting & Partner S.à r.l. . . . . . . . . . . .
52885
Ilix Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52878
Immobilière Livange SA . . . . . . . . . . . . . . . .
52862
Immoparko S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52891
Invalda Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52862
Japan Logistics I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52869
Jay Enterprise Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52895
Kingberg Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . .
52892
Luxlode S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52885
Magritt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52871
Matterhorn Mobile Holdings S.A. . . . . . . . .
52862
Mefertrade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52871
MP Kings Lyric S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52884
Optident S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52885
Project Freedom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
52883
Quilvest & Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52885
Revolin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52852
Rockwell Collins European Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52896
Rockwell Collins International Financing
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52896
Rockwell Collins International Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52896
Scientific Games Global Gaming S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52885
Solution Façade Bâtiment Sàrl . . . . . . . . . .
52850
Triton Advisers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52862
TWO4TEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52890
UBS (Lux) Key Selection SICAV . . . . . . . . .
52896
52849
L
U X E M B O U R G
SOFAB Sàrl, Solution Façade Bâtiment Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4460 Belvaux, 20, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 167.619.
L'an deux mille douze, le vingt mars.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, agissant en remplacement de son confrère
dûment empêché, Maitre Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, lequel dernier restera dépositaire de la
présente minute.
Ont comparu:
Monsieur Tugay OCAK, façadier-crépisseur, né le 1
er
avril 1974 à Hanak (Turquie), demeurant 17, rue de Nancy à
F-57510 Puttelange-aux-Lacs,
Monsieur Zekay OCAK, façadier-crépisseur, né le 1
er
avril 1978 à Hanak (Turquie), demeurant 14, Lot des Fleurs,
rue Henri Bacher à F-57510 Puttelange-aux-Lacs,
ici représentés par Monsieur Jean-Luc FUCHS, Expert comptable, demeurant professionnellement à L-3391 PEPPAN-
GE, 1 rue de l’église,
en vertu des procurations données à Peppange, le 10 février 2012 lesquelles procurations, après avoir été signées NE
VARIETUR par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enre-
gistrées.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité
limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.
Titre I
er
. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé
par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de: Solution Façade Bâtiment SARL dont l’abréviation est SOFAB SARL.
Art. 3. Le siège social est fixé à Belvaux. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg,
d'un commun accord entre les associés.
Art. 4. La société a pour objet les activités de peintre, plafonneur, façadier.
Elle peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou
étrangères, assurer la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également créer, acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques et autres droits se rattachant à
ces brevets et marques ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître
utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II. - Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales
d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l'agrément
donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Titre III. - Gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
52850
L
U X E M B O U R G
Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les
révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire
tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à
l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.
Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes
nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opérations, encais-
ser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts
et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.
Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme.
En cas d'un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe de membres du Conseil de gérance. L'assemblée générale peut élire parmi les membres du Conseil
de gérance un ou plusieurs gérants qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature respective, pourvu
qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches
particulières, à un plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs.
Titre IV. - Décisions collectives d'associés
Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.
Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi
qu'un bilan et un compte des pertes et des profits.
Art. 13. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital;
le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social,
le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 14. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des actionnaires, la loi sur la société
unipersonnelle s'appliquerait.
Art. 15. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en
vigueur.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les parts ont été souscrites et libérées comme suit:
1. Monsieur Tugay OCAK préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 parts
2. Monsieur Zekay OCAK préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 parts
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été entièrement libérées en espèces par les souscripteurs au prorata de
leur souscription, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié expressément au notaire instrumentaire au moyen d’un certificat
bancaire.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros (900. €).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les comparants, associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:
1. La société est gérée par 1 (un) gérant.
2. Est nommé gérant unique de la société, Monsieur Tugay OCAK, façadier-crépisseur, né le 1
er
avril 1974 à Hanak
(Turquie), demeurant 17, rue de Nancy à F-57510 Puttelange-aux-Lacs,
Le gérant unique est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société par sa
seule signature.
52851
L
U X E M B O U R G
3. La durée du mandat du gérant est illimitée.
4. La société a son siège 20, rue de la Gare à L-4460 Belvaux.
<i>Clôturei>
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait que la société nouvellement constituée doit introduire
une demande pour faire le commerce. Sur ce, les comparants ont déclaré faire eux-mêmes les démarches nécessaires à
ces fins.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant
par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: Fuchs, Me MEYERS.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2012. Relation: EAC/ 2012/3799. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012035850/120.
(120047213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Revolin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 118.400.
<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique en date du 22 juin 2011i>
Démission et nomination d’un gérant
Acceptation de la démission de Monsieur Paul-Henry VIAL en tant que gérant de la société.
Nomination d’un nouveau gérant pour une durée illimitée:
- Monsieur Jean-Pierre VIAL
Né le 28 novembre 1943 à Corbeil-Essonnes (F)
Demeurant à F-94480 ABLON-SUR-SEINE, 29, rue du Maréchal Foch
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037654/16.
(120049768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Aldorf & Norbereit Invest S.A., Société Anonyme,
(anc. BAAL Capital S.A.).
Siège social: L-5670 Altwies, route de Luxembourg, Le Moulin.
R.C.S. Luxembourg B 152.129.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of February,
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in LUXEMBOURG, Grand-Duchy of Luxembourg,
Has assembled the Extraordinary General Meeting of the shareholders of BAAL Capital S.A., a public limited company
(société anonyme) existing under the laws of Luxembourg, with registered office in L-5619 MONDORF-LES-BAINS, 5,
rue John Gruen, registered with the Registry of Commerce and Companies (registre de commerce et des sociétés) of
Luxembourg under number B 152.129, duly incorporated through a notarial deed by Maître Karine REUTER, notary then
residing in REDANGE / ATTERT, Grand-Duchy of Luxembourg, on 25 March 2010, as published in the official gazette
’Mémorial, Recueil des Societes et Associations C’ number 968 of 7 May 2010 (the “Company”).
There appeared:
Ms. Barbara ALDORF, born on 17 December 1970 in ZWEIBRÜCKEN, Germany, professionally residing in L-5670
ALTWIES, Le Moulin, route de Luxembourg (the “Sole Shareholder”), and
Mr. Rainer NOBEREIT, born on 23 August 1956 in WATTENSCHEID, Germany, professionally residing in D-76532
BADEN-BADEN, Flugstraße 7, (the “New Shareholder”)
Here represented by:
52852
L
U X E M B O U R G
Mr. Niklas Tim NOBEREIT, born on 15 January 1985 in BOCHUM, Germany, professionally residing in D-76532
BADEN-BADEN, Flugstraße 7, by virtue of a proxy given in BADEN-BADEN on 28 February 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to state that:
Ms. Barbara ALDORF is hitherto the Sole Shareholder of BAAL Capital S.A.;
The Sole Shareholder wishes to change the Company’s denomination into ALDORF & NOBEREIT INVEST S.A.;
The Sole Shareholder wishes to transfer the Company’s registered office to ALTWIES, Grand-Duchy of Luxembourg;
The Company’s share capital is currently set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.00) represented by thirty-one
thousand (31,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) each, all fully subscribed and entirely paid in;
The Sole Shareholder wishes to increase the Company’s share capital;
The share capital of the Company shall be increased by the issuance of additional shares that shall be subscribed and
paid in by the other appearing party;
The Sole Shareholder wishes to further amend the articles of incorporation of the Company (the “Articles”) accor-
dingly.
The agenda is as follows:
1. Approval by the Sole Shareholder of the Company of the change of the Company’s denomination into “ALDORF
& NOBEREIT INVEST S.A.”.
2. Amendment and Restatement of Article 1 of the Articles accordingly, which shall henceforth have the following
content:
“ Art. 1. (Denomination). There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of ALDORF
& NOBEREIT INVEST S.A. (the ‘Company’).”
3. Approval by the Sole Shareholder of the Company of the transfer of the Company’s registered office from MON-
DORF-LES-BAINS to ALTWIES, Grand-Duchy of Luxembourg.
4. Amendment and Restatement of Article 2, 1
st
paragraph of the Articles accordingly, which shall henceforth have
the following content:
“ Art. 2. (Registered Office). The registered office of the Company is established at ALTWIES. It may be transferred
within the municipality of the registered office by a resolution of the board of directors of the Company.”
5. Approval by the Sole Shareholder of the Company of the increase of Company’s share capital, so as to bring it from
its present amount of thirtyone thousand Euros (EUR 31,000.00) to sixty-two thousand Euros (EUR 62,000.00), by the
creation and issuance of thirty-one thousand (31,000) additional shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) each,
and having the same rights as those attached to the existing shares of the Company.
6. Amendment and Restatement of Article 5 of the Articles accordingly, which shall henceforth have the following
content:
“ Art. 5. (Share Capital). The subscribed share capital is set at sixty-two thousand Euros (EUR 62,000.00) represented
by sixty-two thousand (62,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) each.”
7. Approval by the Sole Shareholder of the Company of the subscription and payment for the newly-issued shares of
the Company, by
Mr. Rainer NOBEREIT, aforementioned, for thirty-one thousand (31,000) additional shares with a par value of one
Euro (EUR 1.00) each, and having the same rights as those attached to the existing shares of the Company, and payment
of these newly-issued shares by contribution in cash for an aggregate amount of thirty-one thousand Euros (EUR
31,000.00).
8. Resolution to fix the number of members of the board of directors (conseil d’administration) of the Company at
three (3) and to appoint – alongside Ms. Barbara ALDORF, hitherto sole director of the Company – as additional directors
- Mr. Rainer NOBEREIT, aforementioned, and
- Mr. Niklas Tim NOBEREIT, aforementioned,
Each with immediate effect and for a term of six (6) years;
9. Authorisation to the Board of Directors to delegate its powers to conduct the daily management of the Company
to Ms. Barbara ALDORF as Managing Director (administrateur délégué à la gestion journalière);
10. Miscellaneous.
The following resolutions are passed in accordance with the provisions of the Company’s Articles and with the law of
10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “Law”):
<i>First resolution ref. agenda items 1 and 2i>
The Sole Shareholder resolves to change the denomination of the Company into
“ALDORF & NOBEREIT INVEST S.A.”,
52853
L
U X E M B O U R G
And to amend and restate Article 1 of the Articles accordingly, which shall henceforth have the following content:
“ Art. 1. (Denomination). There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of ALDORF
& NOBEREIT INVEST S.A. (the ‘Company’).”
<i>Second resolution ref. agenda items 3 and 4i>
The Sole Shareholder resolves to transfer of the Company’s registered office from MONDORF-LES-BAINS to
L-5670 ALTWIES, Le Moulin, route de Luxembourg,
And to amend and restate Article 2, 1
st
paragraph of the Articles accordingly, which shall henceforth have the following
content:
“ Art. 2. (Registered Office). The registered office of the Company is established at ALTWIES. It may be transferred
within the municipality of the registered office by a resolution of the board of directors of the Company.”
<i>Third resolution ref. agenda items 5 and 6i>
The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company, so as to bring it from its present
amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.00) to sixty-two thousand Euros (EUR 62,000.00), by the creation and
issuance of thirty-one thousand (31,000) additional shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) each, and having the
same rights as those attached to the existing shares of the Company,
And to amend and restate Article 5 of the Articles accordingly, which shall henceforth have the following content:
“ Art. 5. (Share Capital). The subscribed share capital is set at sixty-two thousand Euros (EUR 62,000.00) represented
by sixty-two thousand (62,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) each.”
<i>Fourth resolution ref. agenda item 7i>
The Sole Shareholder resolves to approve of the subscription and payment for the newly-issued shares of the Company,
by
Mr. Rainer NOBEREIT, aforementioned, for thirty-one thousand (31,000) additional shares with a par value of one
Euro (EUR 1.00) each, and having the same rights as those attached to the existing shares of the Company, and payment
of these newly-issued shares by contribution in cash for an aggregate amount of thirty-one thousand Euros (EUR
31,000.00).
Mr. Rainer NOBEREIT declares to subscribe to the thirty-one thousand (31,000) newly-issued shares. Such thirty-one
thousand (31,000) newlyissued shares are fully paid in by a contribution in cash, the proof of the existence and of the
value of the contribution having been provided to the undersigned notary.
As a consequence of the above, Mr. Rainer NOBEREIT is entitled to exercise his voting rights in the subsequent
resolutions together with Ms. Barbara ALDORF as shareholders (the “Shareholders”), having equal rights.
<i>Fifth resolution ref. agenda item 8i>
The Shareholders resolve to fix the number of members of the Board of Directors (conseil d’administration) of the
Company at three (3) and to appoint – alongside Ms. Barbara ALDORF, hitherto Sole Director of the Company – as
additional Directors
- Mr. Rainer NOBEREIT, aforementioned, and
- Mr. Niklas Tim NOBEREIT, aforementioned,
Each with immediate effect and for a term ending in the annual general shareholders’ meeting held in the year 2016.
<i>Sixth resolution ref. agenda item 9i>
The Shareholders resolve to authorise the Board of Directors to delegate its powers to conduct the daily management
of the Company to Ms. Barbara ALDORF as Managing Director (administrateur délégué à la gestion journalière) until the
annual general shareholders’ meeting held in the year 2016.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1500.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
represented as stated above, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the
same appearing parties, represented as stated above, in case of discrepancies between the English and the German text,
the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
52854
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the appearing parties, represented as stated above, known to the notary by their
names, first names, civil status and residences, said appearing parties, represented as stated above, signed together with
the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des Voranstehenden:
Im Jahre zweitausend und zwölf, am achtundzwanzigsten Februar,
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in LUXEMBOURG, Großherzogtum Lu-
xembourg,
Hat sich eingefunden, die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft BAAL Capital S.A., eine Ak-
tiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-5619 MONDORF-LES-BAINS, 5,
rue John Gruen, eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsregister (registre de commerce et des sociétés) Luxembourg
unter der Nummer B 152.129, gegründet gemäß einer Urkunde ausgefertigt durch die Notarin Maître Karine REUTER,
mit damaligem Amtssitz in REDANGE / ATTERT, Großherzogtum Luxembourg, am 25. März 2010, veröffentlicht im
luxemburgischen Amtsblatt ’Mémorial, Recueil des Societes et Associations C’ Nummer 968 vom 7. Mai 2010 (die “Ge-
sellschaft”).
Sind erschienen:
Frau Barbara ALDORF, geboren am 17. Dezember 1970 in ZWEIBRÜCKEN, Deutschland, beruflich ansässig in L-5670
ALTWIES, Le Moulin, route de Luxembourg (die “Alleinige Aktionärin”), und
Herr Rainer NOBEREIT, geboren am 23. August 1956 in WATTENSCHEID, Deutschland, beruflich ansässig in
D-76532 BADENBADEN, Flugstraße 7, (der “Neue Aktionär”),
Hier vertreten durch:
Herrn Niklas Tim NOBEREIT, geboren am 15. Januar 1985 in BOCHUM, Deutschland, beruflich ansässig in D-76532
BADEN-BADEN, Flugstraße 7,
Auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben in BADENBADEN am 28. Februar 2012, welche Vollmacht,
nachdem sie durch den Bevollmächtigten und den beurkundenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet wurde, der gegen-
wärtigen Urkunde angeheftet bleiben, um mit dieser einregistriert zu werden.
Welche Erschienenen den unterzeichneten Notar ersuchen, folgendes zu beurkunden:
Frau Barbara ALDORF ist bislang die Alleinige Aktionärin der BAAL Capital S.A.;
Die Alleinige Aktionärin wünscht, die Bezeichnung der Gesellschaft in ALDORF & NOBEREIT INVEST S.A. abzuändern;
Die Alleinige Aktionärin wünscht, den Gesellschaftssitz nach ALTWIES, Großherzogtum Luxembourg, zu verlegen;
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt derzeit einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,--), eingeteilt
in einunddreißigtausend (31.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,--), sämtlich gezeichnet und
voll einbezahlt;
Die Alleinige Aktionärin wünscht, das Aktienkapital der Gesellschaft zu erhöhen;
Das Aktienkapital der Gesellschaft soll mittels Ausgabe von zusätzlichen Aktien, die von dem anderen Erschienen
gezeichnet und einbezahlt werden, erhöht werden;
Die Alleinige Aktionärin wünscht des Weiteren, die Gründungssatzung der Gesellschaft (die “Satzung”) dementspre-
chend abzuändern.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Beschlussfassung der Alleinigen Aktionärin der Gesellschaft, die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern in “AL-
DORF & NOBEREIT INVEST S.A.”.
2. Entsprechende Abänderung und Neufassung von Artikel 1 der Satzung, der fortan wie folgt lauten soll:
“ Art. 1. (Benennung). Es wird eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung ALDORF & NOBEREIT
INVEST S.A. (die ‘Gesellschaft’) gegründet.”
3. Beschlussfassung der Alleinigen Aktionärin der Gesellschaft, den Gesellschaftssitz nach ALTWIES, Großherzogtum
Luxembourg, zu verlegen.
4. Entsprechende Abänderung und Neufassung von Artikel 2, Absatz 1 der Satzung, der fortan wie folgt lauten soll:
“ Art. 2. (Sitz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in ALTWIES, Großherzogtum Luxembourg.”
5. Beschlussfassung der Alleinigen Aktionärin der Gesellschaft, das Aktienkapital der Gesellschaft von seinem derzei-
tigen Stand von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,--) auf zweiundsechzigtausend Euro (EUR 62.000,--) zu erhöhen,
durch die Schaffung und Ausgabe von einunddreißigtausend (31,000) zusätzlichen Aktien mit einem Nominalwert von je
einem Euro (EUR 1,--), und mit den gleichen Rechten ausgestattet wie die bereits ausgegebenen und gezeichneten Aktien.
6. Entsprechende Abänderung und Neufassung von Artikel 5 der Satzung, der fortan wie folgt lauten soll:
“ Art. 5. (Kapital). Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiundsechzigtausend Euro (EUR 62.000,--), eingeteilt in
zweiundsechzigtausend (62.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,--).”
52855
L
U X E M B O U R G
7. Beschlussfassung der Alleinigen Aktionärin der Gesellschaft zur Zustimmung zu der Zeichnung und Einzahlung der
neu ausgegebenen Aktien der Gesellschaft durch
Herrn Rainer NOBEREIT, vorbezeichnet, von einunddreißigtausend (31.000) zusätzlichen Aktien mit einem Nominal-
wert von je einem Euro (EUR 1,--), und mit den gleichen Rechten ausgestattet wie die bereits ausgegebenen und
gezeichneten Aktien, und Einzahlung dieser neu ausgegebenen Aktien in bar zu einem Gesamtbetrag von einunddreißig-
tausend Euros (EUR 31.000,--).
8. Beschlussfassung der Aktionäre der Gesellschaft, die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (conseil d’admi-
nistration) der Gesellschaft auf drei (3) festzulegen und neben Frau Barbara ALDORF – bislang Alleinige Verwalterin der
Gesellschaft – zu weiteren Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft zu berufen:
- Herrn Rainer NOBEREIT, vorbezeichnet, und
- Herrn Niklas Tim NOBEREIT, vorbezeichnet, Jeweils mit sofortiger Wirkung und für einen Zeitraum von sechs (6)
Jahren;
9. Beschlussfassung der Aktionäre der Gesellschaft, den Verwaltungsrat der Gesellschaft anzuweisen und zu bevoll-
mächtigen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft an Frau Barbara ALDORF als Delegierte des
Verwaltungsrates zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft (administrateur délégué à la gestion journalière) zu
delegieren;
10. Verschiedenes.
Die folgenden Beschlüsse stehen in Einklang mit den jeweiligen Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft (die „Sat-
zung“) sowie des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner derzeit gültigen Fassung (das
“Gesetz”):
<i>Erster Beschluss (ref. 1. und 2. Punkt der Tagesordnung)i>
Die Alleinige Aktionärin beschließt, die Bezeichnung der Gesellschaft in „ALDORF & NOBEREIT INVEST S.A.“ abzu-
ändern,
Und Art. 1 der Satzung entsprechend wie folgt neu zu fassen:
“ Art. 1. (Benennung). Es wird eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung ALDORF & NOBEREIT
INVEST S.A. (die „Gesellschaft“) gegründet.”
<i>Zweiter Beschluss (ref. 3. und 4. Punkt der Tagesordnung)i>
Die Alleinige Aktionärin beschließt, den Sitz der Gesellschaft von MONDORF-LES-BAINS nach L-5670 ALTWIES, Le
Moulin, route de Luxembourg, zu verlegen,
Und Art. 2, Absatz 1 der Satzung entsprechend wie folgt neu zu fassen:
“ Art. 2. (Sitz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in ALTWIES, Großherzogtum Luxembourg.”
<i>Dritter Beschluss (ref. 5. und 6. Punkt der Tagesordnung)i>
Die Alleinige Aktionärin beschließt, das Aktienkapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Stand von einunddrei-
ßigtausend Euro (EUR 31.000,--) auf zweiundsechzigtausend Euro (EUR 62.000,--) zu erhöhen, durch die Schaffung und
Ausgabe von einunddreißigtausend (31.000) zusätzlichen Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,--),
und mit den gleichen Rechten ausgestattet wie die bereits ausgegebenen und gezeichneten Aktien,
Und Art. 5 der Satzung entsprechend wie folgt neu zu fassen:
“ Art. 5. (Kapital). Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiundsechzigtausend Euro (EUR 62.000,--), eingeteilt in
zweiundsechzigtausend (62.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,--).”
<i>Vierter Beschluss (ref. 7. Punkt der Tagesordnung)i>
Die Alleinige Aktionärin erklärt ihre Zustimmung zu der Zeichnung und Einzahlung der neu ausgegebenen Aktien der
Gesellschaft durch
Herrn Rainer NOBEREIT, vorbezeichnet,
Von einunddreißigtausend (31.000) zusätzlichen Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,--), und mit
den gleichen Rechten ausgestattet wie die bereits ausgegebenen und gezeichneten Aktien, und Einzahlung dieser neu
ausgegebenen Aktien in bar zu einem Gesamtbetrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,--).
Herr Rainer NOBEREIT erklärt, die einunddreißigtausend (31.000) neu ausgegebenen Aktien zu zeichnen und mit dem
vollen Nominalwert je gezeichneter Aktie in bar eingezahlt zu haben, worüber der Notarin der Nachweis erbracht wurde,
sodass der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,--) zur Verfügung steht.
Infolge der vorstehenden Zeichnung der neu ausgegebenen Aktien, ist Herr Rainer NOBEREIT befugt, hinsichtlich der
nachfolgenden Beschlüsse Gebrauch von seinem Stimmrecht zu machen. Insofern werden Frau Barbara ALDORF und
Herr Rainer NOBEREIT nachfolgend gemeinsam auch als die „Aktionäre“ bezeichnet.
52856
L
U X E M B O U R G
<i>Fünfter Beschluss (ref. 8. Punkt der Tagesordnung)i>
Die Aktionäre beschließen, die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (conseil d’administration) der Gesellschaft
auf drei (3) festzulegen und neben Frau Barbara ALDORF – bislang Alleinige Verwalterin der Gesellschaft – zu weiteren
Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft zu berufen:
- Herrn Rainer NOBEREIT, vorbezeichnet, und
- Herrn Niklas Tim NOBEREIT, vorbezeichnet,
Jeweils mit sofortiger Wirkung und für einen Zeitraum endend mit der jährlichen Gesellschafterversammlung welche
im Jahr 2016 stattfinden wird.
<i>Sechster Beschluss (ref. 9. Punkt der Tagesordnung)i>
Die Aktionäre beschließen, den Verwaltungsrat der Gesellschaft anzuweisen und zu bevollmächtigen, seine Befugnisse
zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft an Frau Barbara ALDORF, vorbezeichnet, als Delegierte des Verwal-
tungsrates zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft (administrateur délégué à la gestion journalière) zu delegieren,
bis zur jährlichen Gesellschaftversammlung welche im Jahr 2016 stattfinden wird.
Nachdem alle Punkte der Tagesordnung abgehandelt waren, beendet die Notarin die Sitzung.
<i>Kosteni>
Die Erschienenen schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger
Urkunde erwachsen, auf EUR 1500.
Die unterzeichnende Notarin, welche Englisch spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass auf Wunsch der erschie-
nenen Parteien bzw. Ihrer Bevollmächtigter vorliegende Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer Fassung in
deutscher Sprache abgefasst wird, wobei im Fall von Abweichungen die englische Fassung ausschlaggebend sein soll.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, in der Amtsstube der handelnden Notarin, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung durch die Notarin haben alle Erschienenen bzw. Ihre Bevollmächtigten, alle der Notarin nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, die vorliegende Urkunde zusammen mit der Notarin
unterschrieben.
Signé: B. Aldorf, N. T. Nobereit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 mars 2012. Relation: LAC/2012/9828. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 15 mars 2012.
Référence de publication: 2012035503/265.
(120046924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Fondation Ste Zithe, Fondation.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 32, rue Ste Zithe.
R.C.S. Luxembourg G 69.
<i>Situation comptable au 31 décembre 2011i>
<i>Bilan au 31 décembre 2011i>
ACTIF
Notes
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
C. ACTIF IMMOBILISE
III. Immobilisations financières
1. Parts dans des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
1,00
1,00
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,00
1,00
D. ACTIF CIRCULANT
III. Valeurs mobilières
3. Autres valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5/3.3
1.212.066,86 1.462.066,86
IV. Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques
et en caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
473.165,32
349.586,47
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.685.232,18 1.811.653,33
TOTAL DE L'ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.685.233,18 1.811.654,33
PASSIF
Notes
31.12.2011
31.12.2010
52857
L
U X E M B O U R G
EUR
EUR
A. CAPITAUX PROPRES
I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000,00
25.000,00
V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6/3.5
1.340.864,80 1.642.673,67
VI. Fonds restants de l'exercice courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.426,23
138.770,13
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.399.291,03 1.806.443,80
C. DETTES
9. Autres dettes
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . .
3.6
7.318,21
5.210,53
TOTAL DES DETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.318,21
5.210,53
D. COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1/3.7 et
4.3/4.6
278.623,94
0,00
a) projets au Malawi en voie de réalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222.620,55
b) projets au Luxembourg en voie de réalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.003,39
TOTAL DU PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.685.233,18 1.811.654,33
<i>Compte de profits et pertes pour l'exercice allant du 1 i>
<i>eri>
<i> janvier 2011 au 31 décembre 2011i>
Notes
2011
(01.01.2011 -
31.12.2011)
EUR
2010
(01.01.2010 -
31.12.2010)
EUR
A. CHARGES
3. Frais de personnel
a) Salaires et traitements du personnel au Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
0,00
181.553,83
5. Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
6.990,60
338.397,04
7. Intérêts et charges assimilées
b) Autres intérêts et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
1.171,62
1.444,99
10. Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
464,37
209,30
12. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus . . . . . . . . . . . . . .
2.108,25
0,00
13. Résultat de l'exercice (bénéfice de l'exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.426,23
138.770,13
TOTAL DES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.161,07
660.375,29
B. PRODUITS
4. Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
0,00
621.398,13
7. Autres intérêts et produits assimilés
b) Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
44.161,07
38.977,16
10. Résultat de l'exercice (perte de l'exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
TOTAL DES PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.161,07
660.375,29
Les notes en annexe font partie intégrante des comptes annuels.
Annexes aux comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2011
1. Généralités. La Fondation Sainte Zithe («la Fondation»), établissement d'utilité publique, a été constituée le 28
décembre 1994 pour une durée illimitée.
Son capital est de 25.000 €.
La Fondation a pour objet (extrait des statuts coordonnés du 7 juin 2006):
«...
a) Die umfassende Versorgung aller in Luxemburg wie im Ausland lebenden Schwestern, die der Kongregation
"Schwestern Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel" mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 32, rue Sainte Zithe, (nachfolgend
"die Kongregation"genannt) angehören.
Hierzu gehört die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Lebensraumes, Aus- und Weiterbildung, Behandlung und
Verpflegung in Krankheit und A lter sowie die Voraussetzungen für ein religiöses Leben in Gemeinschaft gemäß den
Satzungen der Kongregation.
b) Die Förderung der Krankenhaus-, Alten- und Betreuungseinrichtungen, die im Sinne der Gründer der Kongregation
fortzuführen sind.
In Afrika, insbesondere in Malawi, gehört neben der Gesundheitsversorgung umfassende Entwicklungsarbeit zu den
Aufgaben der Kongregation. Hierzu sind Maßnahmen gegen Hunger und U nterernährung sowie Bildungsarbeit und Ge-
sundheitsvorsorge zu rechnen.
52858
L
U X E M B O U R G
Die Stiftung soll unbeschadet ihrer Aktivitäten im Ausland dauerhaft karitative Aufgaben in Luxemburg wahrnehmen.
c) Die Förderung eines religiösen, kulturellen und s ozialen Rahmens für alte, verlassene oder notleidende Personen.
d) Die Unterstützung aller Projekte oder Initiativen, die diesen Tätigkeitsbereichen entsprechen.
...»
2. Présentation des comptes.
2.1. Généralités
A l'exception des méthodes dérogatoires décrites ci-après dans la présente note 2, les comptes annuels ont été
préparés en accord avec les principes comptables généralement admis au Luxembourg.
Une modification par rapport aux années précédentes a été apportée à l a comptabilisation des recettes et des dépenses
relatives aux projets de la Fondation. Celles-ci sont reprises dans les comptes de régularisation au passif du bilan.
Dans la mesure où les chiffres de l'exercice précédent n'ont pas été adaptés pour refléter l'adoption de cette nouvelle
méthode comptable, il n'y a pas de comparabilité directe des charges et des produits entre les exercices 2010 et 2011.
Nous renvoyons néanmoins à la note 3.7 relative au compte de régularisation passif qui détaille les recettes et dépenses
de 2011 ainsi que le cumul au 1
er
janvier 2011 de celles-ci sur les projets humanitaires en cours.
2.2. Périmètre comptable
Les présents comptes annuels représentent exclusivement les états financiers de la «Fondation Ste Zithe».
Ainsi les activités imputables à des personnes et/ou structures annexes existant sous la forme de fondation, d'asso-
ciation ou autres (amicales par exemple) et n'entrant pas directement dans le cadre de la «Fondation Ste Zithe» sont
exclues des présents états financiers.
2.3. Devises
Les comptes de la Fondation sont établis en Euro (EUR).
Les avoirs et les dettes libellés en devises étrangères sont convertis en Euro au cours de change en vigueur au moment
de la transaction. L'omission de leur évaluation au cours de change en vigueur à la clôture de l'exercice n'a pas d'effet
significatif sur les comptes.
Les produits et les charges en devises étrangères sont convertis en Euro au cours de change en vigueur au moment
de la transaction. Les gains et les pertes de change résultant de leur règlement sont comptabilisés dans le compte de
profits et pertes.
2.4. Créances
Les créances figurent à l'actif du bilan à leur valeur nominale.
S'il devient évident que le montant récupérable est inférieur à la valeur nominale, la réduction de valeur y afférente
est comptabilisée en compte de profits et pertes.
2.5. Valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont évaluées au plus bas de leur coût d'acquisition, incluant les frais accessoires, et de leur
valeur de marché, exprimée dans la devise de préparation des comptes annuels. Une correction de valeur est enregistrée
lorsque le prix du marché est inférieur au prix d'acquisition. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque
les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d'exister.
Les revenus d'intérêts sur obligations détenues en portefeuille sont enregistrés à la date d'encaissement du coupon.
Les intérêts courus non é chus sur obligations détenues en portefeuille ne sont donc pas comptabilisés à la date de clôture
au 31 décembre de chaque année.
2.6. Résultats reportés
Les résultats (bénéfices et pertes) générés par la Fondation ont été reportés à nouveau au passif du bilan. Toutefois,
au début de l'exercice 2011 le montant de 440.579,00 € a été affecté aux projets en voie de réalisation (voir notes 2.1.et
3.5.).
2.7. Dettes
Les dettes de la Fondation sont reprises au passif du bilan à leur valeur nominale.
3. Détail des postes du Bilan.
3.1. Généralités
Avec un total bilantaire de 1.685.233,18 €, la Fondation génère un bénéfice de l'exercice de 33.426,23 €.
3.2. Participations
En date du 31 décembre 2007, la Fondation a reçu donation de 350 actions de la Congrégation des Soeurs du Tiers
Ordre Régulier de Notre Dame du Mont Carmel S.A.. Ces actions ont fait l'objet d'une comptabilisation avec une valeur
symbolique de 1,00 € dans les présents Etats Financiers.
3.3. Valeurs mobilières
52859
L
U X E M B O U R G
La Fondation détient un portefeuille d'obligations côtées. En date du 18 octobre 2011 un titre d'un montant de
250.000,00€ a été remboursé par l'émetteur. Le montant en question a été versé au compte épargne. Le détail des titres
se décompose comme suit:
31.12.2011
31.12.2010
Prix d'acquisition au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.462.066,86
962.066,86
Acquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
500.000,00
Ventes / cessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (250.000,00)
0,00
Prix d'acquisition à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.212.066,86 1.462.066,86
Corrections de valeur au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
Corrections de valeur de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
Reprise de corrections de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
Corrections de valeur à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.212.066,86 1.462.066,86
La valeur de marché des valeurs mobilières s'élève à 1.253.217,50 € au 31 décembre 2011 (1.494.405,00 € au 31
décembre 2010). La plus-value latente correspondante (41.150,64 € au 31 décembre 2011) n'a pas été enregistrée dans
les comptes eu égard au principe de prudence.
3.4. Avoirs en banques, avoirs en CCP, chèques et en caisses
Le détail des «avoirs en banques, avoirs en CCP, chèques et encaisse» au 31.12.2011 se décompose comme suit:
31.12.2011 31.12.2010
Comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.674,28
3.058,75
Comptes épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470.491,04 346.527,72
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473.165,32 349.586,47
3.5. Résultats reportés
L'évolution du solde du compte «Résultats reportés» au cours des deux derniers exercices se présente de la façon
suivante (voir note 2.6.):
31.12.2011
31.12.2010
Résultats reportés à l'ouverture de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.642.673,67 1.559.167,12
Résultat de l'exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138.770,13
83.506,55
Somme affectée aux projets en voie de réalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (440.579,00)
0,00
Résultats à reporter à la clôture de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.340.864,80 1.642.673,67
3.6. Autres dettes
Le poste des «autres dettes» au 31 décembre 2011 correspond à des factures reçues ou à recevoir et impayées à cette
date.
Aucune des dettes reprises sous le poste des «Autres dettes» n'est garantie par des sûretés réelles.
Par ailleurs, la Fondation n'a pas, au 31 décembre 2011, d' «Autres dettes» dont la durée résiduelle est supérieure à
cinq ans.
3.7. Comptes de régularisation
L'évolution du solde du «Compte de régularisation» au cours des deux derniers exercices se présente de la façon
suivante:
Projets au
Malawi
Projets au
Luxembourg
Total
2011
Total
2010
Situation au 1
er
janvier 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408.654,00
31.925,00
440.579,00
0,00
Projets financés au cours de l'exercice 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . (593.451,73)
(24.595,00) (618.046,73)
0,00
Dons reçus au cours de l'exercice 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
407.418,28
48.673,39
456.091,67
0,00
Solde à la clôture au 31 décembre 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222.620,55
56.003,39
278.623,94
0,00
4. Détail des postes du compte de Profits et Pertes.
4.1. Frais de personnel
Suite à la modification apportée au début de l'exercice 2011à la comptabilité de la Fondation, les frais de personnel
représentant les salaires versés à d eux médecins exerçant à l'hôpital St Gabriel au Malawi, sont comptabilisés dans les
comptes de régularisation au passif du bilan (voir notes 2.1./2.6. et 3.7.).
Ces personnes exerçant à l'étranger, elles ne relèvent pas de la sécurité sociale luxembourgeoise. Leurs salaires n'ont,
à ce titre, pas fait l'objet de prélèvements sociaux au Luxembourg.
4.2. Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant
Pour l'exercice 2011 il n'y a pas de correction de valeur à enregistrer pour les valeurs mobilières, du fait qu'au
31.12.2011 le prix du marché était supérieur au prix d'acquisition (voir à ce sujet la note 3.3).
52860
L
U X E M B O U R G
4.3. Autres charges d'exploitations
Les projets de tout ordre financés par la Fondation figurent, à partir de l'exercice 2011, dans les comptes de régula-
risation au passif du bilan (voir notes 2.1./2.6. et 3.7.). Seules les dépenses courantes (petit équipement, honoraires
réviseur ...) sont comptabilisées dans les charges d'exploitation de la Fondation.
4.4. Intérêts et charges assimilées
Les intérêts et charges assimilées correspondent aux charges financières relatives aux comptes bancaires et aux valeurs
mobilières.
4.5. Charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles pour un montant de 464,37 € se composent principalement de charges relatives à l'exer-
cice 2010.
4.6. Autres produits d'exploitation
Les dons de tout ordre reçus par la Fondation figurent également dans les comptes de régularisation au passif du bilan,
à partir de l'exercice 2011 (voir notes 2.1./2.6. et 3.7.).
4.7. Intérêts et produits assimilés
Les intérêts et produits assimilés correspondent aux produits financiers relatifs aux comptes bancaires et aux valeurs
mobilières.
5. Engagements hors bilan. Au 31 décembre 2011, il n'existe aucun engagement hors-bilan.
<i>Budget 2012i>
Montants
en EUR
Projets en voie de réalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665.000,00
Charges externes, charges de comptes et frais financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,00
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675.000,00
Produits divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.000,00
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.000,00
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412.000,00
Membres du Conseil d'Administration
Soeur Brigitte, née Brigitte Schneiders, Supérieure Générale, Luxembourg, présidente
Soeur Wilfrieda, née Elisabeth Hoffmann, Assistante Générale, Luxembourg, vice-présidente
Soeur docteur Myriam, née Marguerite Ney,
membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxembourg, trésorerie,
Soeur Françoise, née Fanny Koedinger,
membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxembourg,
Soeur Michèle, née Josette Koedinger,
membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxembourg,
Monsieur le professeur docteur Ernest Gillen,
membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxembourg,
Monsieur Pit Hentgen
membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxembourg,
Monsieur Michel Wurth,
membre du Conseil d'Administration de la Fondation Ste Zithe, Luxembourg,
Etabli à Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Dr Hans Jürgen GOETZKE / Soeur Brigitte SCHNEIDERS
<i>Directeur général / Présidentei>
Référence de publication: 2012035614/229.
(120047720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
HEPP IV Luxembourg JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.732.701,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 154.832.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
52861
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012036203/11.
(120047898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Triton Advisers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 137.319.
Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Triton Advisers S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012037006/11.
(120049048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Invalda Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 158.274.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012036209/10.
(120048193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Immobilière Livange SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8212 Mamer, 28, rue Baerendall.
R.C.S. Luxembourg B 65.616.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012036214/10.
(120047945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Matterhorn Mobile Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.831.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 21 mars 2012.
Référence de publication: 2012036292/10.
(120048096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Cherras Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 130.488.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
52862
L
U X E M B O U R G
<i>Pour CHERRAS INVESTMENTS S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012037414/11.
(120049990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Clinlux S.A. Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 132.676.
Les comptes annuels pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2012.
Référence de publication: 2012037416/11.
(120050130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
EMVF Lux Finance, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 167.631.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the third day of February.
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
EMVF Lux Master, a private limited liabilty company, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528
Luxemburg, incorporated today by a deed drawn up by the undersigned notary, not yet registered with the Luxembourg
trade and companies' register, duly represented by Fiduciaire Eurolux, having its registerd office in L-1220 Luxembourg,
196, rue de Beggen, itself here repesented by Mrs Isabell FELTEN, employee, residing professionally in Luxembourg, 196,
rue de Beggen by virtue of a proxy delivered to her.
Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of
a société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.
Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.
The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited
liability for all debts and obligations of such entities.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of "EMVF Lux Finance".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
52863
L
U X E M B O U R G
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twenty thousand U.S. Dollar (USD 20,000.-) represented by twenty
thousand (20,000) shares with a par value of two U.S. Dollar (USD 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the
term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
52864
L
U X E M B O U R G
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder
Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's financial year begins on January 1
st
, of each year and ends on December 31
st
, of the same
year.
Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
The twenty thousand (20,000) shares of the Company have been subscribed by EMVF Lux Master, as aforementioned,
paid up by a contribution in cash for an amount of twenty thousand U.S. Dollar (USD 20,000.-), entirely allocated to the
share capital.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twenty thousand U.S. Dollar (USD 20,000.-) is as of
now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December
31
st
, 2012.
52865
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or
which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
The corporate capital is valued at EUR 15,201.40.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. As sole manager of the Company for an indefinite period is appointed: Mr. Mirko FISCHER, born on May 6
th
, 1975
in Gelsenkirchen, residing professionally in 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
- The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Es Folgt die deutsche Übersetzung des Englischen Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, am dritten Februar.
Vor dem unterzeichneten Dr. Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
EMVF Lux Master, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,
gegründet am heutigen Tage, auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, noch nicht im
Luxemburger Handels -und Gesellschaftsregister eingetragen, hier vertreten durch Fiduciaire Eurolux, mit Sitz in L-1220
Luxemburg, 196, rue de Beggen, selbst hier vertreten durch ihre Bevollmächtigte Frau Isabell FELTEN, Privatangestellte,
berufsansässig in Luxemburg, 196, rue de Beggen, aufgrund einer ihr ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung "ne varietur" durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegen-
wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Der Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société
à responsabilité limitée), die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die "Gesellschaft")
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in-und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-
chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "EMVF Lux Finance".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Be-
schluss der Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch
einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere
Filialen können entweder in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.
52866
L
U X E M B O U R G
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend U.S. Dollar (USD 20.000,-), aufgeteilt in zwanzigtausend
(20.000) Anteile mit einem Nennwert von je zwei USD (USD 1,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese
Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-
genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.
Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund ("cause légitime") hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.
Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort
einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Ge-
schäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden
ernennen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
52867
L
U X E M B O U R G
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.
Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied sowie deren Erben, Nach-
lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die nach vernünftigem Ermessen in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit,
einer Klage oder einem Verfahren, bei dem der Geschäftsführer oder das Geschäftsführerratsmitglied auf Grund seiner
Funktion als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäftsführer oder Geschäftsführerratsmitglied der Gesellschaft oder, auf
Anfrage der Gesellschaft, jeder anderen Körperschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist und
von der er nicht berechtigt ist, Entschädigung zu erhalten, Partei geworden ist, entstanden sind. Dies gilt für Angelegen-
heiten bei denen letztendlich eine schwere Pflichtverletzung (faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute
intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten
gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber
informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf
Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte, zu der die Person berechtigt ist, ausschließen.
Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschließen, Zwischendividenden auszu-
schütten, und zwar auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsfüh-
rerrat vorbereitet wird und aufzeigt, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag
nicht die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen
Gewinne und der zur Verteilung zur Verfügung stehenden Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verluste und
der Beträge, die einer gesetzlich oder durch die Satzung vorgeschriebenen Kapitalrücklage zugeführt werden.
D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember
desselben Jahres.
Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Ge-
schäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt
sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Zwischendividenden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen zugeteilt.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung, oder
gegebenenfalls der alleinige Gesellschafter, legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Insofern nichts
anderes vorgesehen ist, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
52868
L
U X E M B O U R G
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweist die Erschienene auf die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die zwanzigtausend (20.000) Gesellschaftsanteile wurden von EMVF Lux Master, vorgenannt, gezeichnet und durch
eine Bareinlage in Höhe von zwanzigtausend U.S. Dollar (USD 20.000,-) eingezahlt, die vollständig dem Gesellschaftskapital
zugewiesen wurde.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass die Gesellschaft über ein Gesellschaftskapital
von zwanzigtausend U.S. Dollar (USD 20.000,-) verfügt, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
1.200,-EUR.
Das Gesellschaftskapital wird auf 15.201,40-EUR abgeschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Gesellschafts-
kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
2. Zum einzigen Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Zeit wird ernannt:
Herr Mirko FISCHER, geboren am 6. Mai 1975 in Gelsenkirchen, beruflich wohnhaft in 11-13, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Junglinster, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.
Gezeichnet: Isabell FELTEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 février 2012. Relation GRE/2012/515. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.
Junglinster, den 22. März 2012.
Référence de publication: 2012035588/344.
(120047527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Japan Logistics I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BRE/Japan NPL 1 S.à r.l.).
Capital social: JPY 2.100.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.545.
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth day of March,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Japan Logistics Topco S.à r.l. (formerly BRE/Japan IV S.à r.l.),a société à responsabilité limitée, governed by the laws of
the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies register under number B 164.887,
duly represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 March 2012.
52869
L
U X E M B O U R G
This proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of BRE/Japan NPL 1 S.à r.l.,a société à respon-
sabilité limitée having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies' register under number B 166.545, incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler,
notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg on 6 May 2011, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”).
The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the Company's name to “Japan Logistics I S.à r.l.".
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company which shall now
read as follows:
“ Art. 4. The Company will assume the name of Japan Logistics I S.à r.l.”
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L'an deux mille douze, le seize mars,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Japan Logistics Topco S.à r.l. (anciennement BRE/Japan IV S.à r.l.) une société à responsabilité limitée, régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés sous section B numéro 164.887,
ici représentée par Mademoiselle Carole Noblet, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé donnée le 16 mars 2012.
La procuration signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de BRE/Japan NPL 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée
ayant son siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 166.545, constituée le 6 mai 2011 par un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (la «Société»).
L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en “Japan Logistics I S.à r.l.”.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
“ Art. 4. La société prend la dénomination de Japan Logistics I S.à r.l.”.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état civil et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. NOBLET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mars 2012. Relation: LAC/2012/12779. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
52870
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 21 mars 2012.
Référence de publication: 2012036055/69.
(120048237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Magritt S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 132.563.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012036302/10.
(120048131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Mefertrade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1880 Luxembourg, 69, rue Pierre Krier.
R.C.S. Luxembourg B 31.665.
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BLANCHE MOUTRIER
<i>NOTAIRE
i>En remplacement de Maître Aloyse BIEL
Référence de publication: 2012036306/12.
(120048170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
EMVF Lux Master, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 167.617.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the third day of February.
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
CARVAL INVESTORS LUXEMBOURG SARL, a société à responsabilité limitée de tritrisation, 11-13, Boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under the number B.117.261,
duly represented by Fiduciaire Eurolux, having its registerd office in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, itself here
repesented by Mrs Isabell FELTEN, employee, residing professionally in Luxembourg, 196, rue de Beggen by virtue of a
proxy delivered to her.
This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of a
société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.
Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.
The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited
liability for all debts and obligations of such entities.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
52871
L
U X E M B O U R G
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of "EMVF Lux Master".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twenty thousand U.S. Dollar (USD 20,000.-) represented by twenty
thousand (20,000) shares with a par value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is to be managed by at least one (1) category A manager and one (1) category B manager, who
do not need to be a shareholders.
In dealings with third parties, the managers have the most extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The managers are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fixes the term
of their office. The managers may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as the case
may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").
The board of managers shall deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, among whom at least
one (1) category A manager, is present or represented and all decisions are validly taken at the majority of the managers
present or represented, among whom at least one (1) category A manager.
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
52872
L
U X E M B O U R G
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be al-
located to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder
Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's financial year begins on January 1
st
, of each year and ends on December 31
st
, of the same
year.
Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
52873
L
U X E M B O U R G
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
The twenty thousand (20,000) shares of the Company have been subscribed by Carval Investors Luxembourg S.à r.l.,
as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twenty thousand U.S. Dollar (USD 20,000.-), entirely
allocated to the share capital.
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twenty thousand U.S. Dollar (USD 20,000.-) is as of
now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December
31
st
, 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or
which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
The corporate capital is valued at EUR 15,201.40.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. As managers of the Company for an indefinite period are appointed:
Mr. Mirko FISCHER, born on May 6
th
, 1975 in Gelsenkirchen, residing professionally in 11-13, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg, category A manager.
Mrs. Paulina DENIS, born in Radom (Poland) on October 25
th
, 1982, residing professionaly in 11-13, boulevard de
la Foire in L-1528 Luxembourg, as category B manager.
- The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des Englischen Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, am dritten Februar.
Vor dem unterzeichneten Dr. Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
CARVAL INVESTORS LUXEMBOURG SARL, société à responsabilité limitée de tritrisation, mit Sitz in 11-13, Bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels -und Gesellschaftsregister unter Nummer
B.117.261, hier vertreten durch Fiduciaire Eurolux, mit Sitz in L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen, selbst hier vertreten
durch ihre Bevollmächtigte Frau Isabell FELTEN, Privatangestellte, berufsansässig in Luxemburg, 196, rue de Beggen,
aufgrund einer ihr ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung "ne varietur" durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwär-
tiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société
à responsabilité limitée), die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die "Gesellschaft")
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
52874
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in-und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-
chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "EMVF Lux Master".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Be-
schluss der Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch
einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere
Filialen können entweder in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend U.S. Dollar (USD 20.000,-), aufgeteilt in zwanzigtausend
(20.000) Anteile mit einem Nennwert von je zwei USD (USD 1,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese
Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-
genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft soll durch mindestens einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäfts-
führer der Kategorie B geführt werden. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.
Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund ("cause légitime") hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.
Der Geschäftsführerrat soll sich nur beraten oder rechtsgültig handeln, wenn zumindest eine Mehrheit der Geschäfts-
führer, unter denen zumindest ein (1) Geschäftsführer der Kategorie A sein soll, anwesend sind oder ordentlich vertreten
wird. Alle Entscheidungen sind rechtsgültige beschlossen, wenn eine Mehrheit der Geschäftsführer anwesend ist oder
ordentlich vertreten wird, unter denen zumindest ein (1) Geschäftsführer der Kategorie A ist.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.
52875
L
U X E M B O U R G
Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort
einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Ge-
schäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden
ernennen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitglie-des kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.
Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied sowie deren Erben, Nach-
lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die nach vernünftigem Ermessen in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit,
einer Klage oder einem Verfahren, bei dem der Geschäftsführer oder das Geschäftsführerratsmitglied auf Grund seiner
Funktion als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäftsführer oder Geschäftsführerratsmitglied der Gesellschaft oder, auf
Anfrage der Gesellschaft, jeder anderen Körperschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist und
von der er nicht berechtigt ist, Entschädigung zu erhalten, Partei geworden ist, entstanden sind. Dies gilt für Angelegen-
heiten bei denen letztendlich eine schwere Pflichtverletzung (faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute
intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten
gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber
informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf
Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte, zu der die Person berechtigt ist, ausschließen.
Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschließen, Zwischendividenden auszu-
schütten, und zwar auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsfüh-
rerrat vorbereitet wird und aufzeigt, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag
nicht die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen
Gewinne und der zur Verteilung zur Verfügung stehenden Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verluste und
der Beträge, die einer gesetzlich oder durch die Satzung vorgeschriebenen Kapitalrücklage zugeführt werden.
D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
52876
L
U X E M B O U R G
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember
desselben Jahres.
Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Ge-
schäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt
sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Zwischendividenden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen zugeteilt.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung, oder
gegebenenfalls der alleinige Gesellschafter, legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Insofern nichts
anderes vorgesehen ist, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweist die Erschienene auf die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die zwanzigtausend (20.000) Gesellschaftsanteile wurden von Carval Investors Luxembourg S.à r.l., vorgenannt, ge-
zeichnet und durch eine Bareinlage in Höhe von zwanzigtausend U.S. Dollar (USD 20.000,-) eingezahlt, die vollständig
dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass die Gesellschaft über ein Gesellschaftskapital
von zwanzigtausend U.S. Dollar (USD 20.000,-) verfügt, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
1.200,- EUR.
Das Gesellschaftskapital wird auf 15.201,40 EUR abgeschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Gesellschafts-
kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
2. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft für eine unbestimmte Zeit werden ernannt:
Herr Mirko FISCHER, geboren am 6. Mai 1975 in Gelsenkirchen, beruflich wohnhaft in 11-13, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg, als Geschäftsführer der Kategorie A.
Frau Paulina DENIS, geboren am Radom (Polen) in 25. Oktober 1982, beruflich wohnhaft in 11-13, boulevard de la
Foire in L-1528 Luxemburg, als Geschäftsführerin der Kategorie B.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hier-mit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Junglinster, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.
52877
L
U X E M B O U R G
Gezeichnet: Isabell FELTEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 février 2012. Relation GRE/2012/514. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.
Junglinster, den 22. März 2012.
Référence de publication: 2012035589/359.
(120046884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Flux Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 133.013.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 décembre 2011i>
<i>Résolution 5: Démission de Monsieur René Sterckx comme Administrateuri>
Le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur René Sterckx avec effet à l'issue de la présente
réunion.
<i>Résolution 6: Nomination de Monsieur Contran Soumoy, comme Administrateur, en remplacement de Monsieur René Sterckx,i>
<i>démissionnairei>
Le Conseil d'Administration coopte Monsieur Gontran Soumoy, demeurant au 49, Pertendonckstraat, B-2520 Broe-
chem, en qualité d'Administrateur en remplacement du mandat de Monsieur René Sterckx, démissionnaire, pour la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2012 statuant
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Mandataire spéciali>
Référence de publication: 2012037484/22.
(120049783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Ilix Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 77.954.
L’an deux mille douze, le quinze mars.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réuni l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ILIX HOLDING S.A. (ci-après
la «Société»), ayant son siège social au 43, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B77954. La Société fut constituée suivant acte
du notaire soussigné reçu en date du 1 septembre 2000, publié au Mémorial C n°177 du 7 mars 2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Eddy DÔME, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 43,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg . Le président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en
droit, ayant son adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eddy DÔME, prénommé.
Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des 2.600 actions, représentant l’intégralité du capital social
actuellement fixé à 2.600.000 euros sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 6 alinéa 2 des statuts.
2. Démission de MM GHEZZI Luigi Enrico, THOMPSON Jamie Edward, D’ANDREA Domenico et GHEZZI Alberto.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
52878
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 6 alinéa 2 relatif au pouvoir de signature comme suit afin de lui donner la
teneur suivante:
« Art. 6. Alinéa 2. La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un des administrateurs.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de MM GHEZZI Luigi Enrico, THOMPSON Jamie Edward, D’ANDREA
Domenico et GHEZZI Alberto et leur donne décharge pour l’exercice de leur fonction respective.
Sont confirmés au poste d’administrateurs:
- Gilbert MULLER, demeurant 85, route du vin, L-5440 Remerschen;
- Eddy DÔME, demeurant professionnellement au 43, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Jean-Marie SCHUL, demeurant professionnellement au 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg;
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents Euros (EUR 1.200.-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: E. Dôme, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2012. LAC/2012/13008. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Référence de publication: 2012036211/51.
(120048060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
HEPP IV Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 141.642.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 22 mars 2012i>
En date du 22 mars 2012, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Otis SPENCER de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Piotr ANDRZEJEWSKI, né le 31 août 1978 à Sokolka, Pologne, résidant professionnellement
à l'adresse suivante: 26b, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société doit désormais se lire comme suit:
- Madame Renata MIAZGA
- Monsieur Gordon BLACK
- Monsieur Piotr ANDRZEJEWSKI
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2012.
HEPP IV MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012037508/22.
(120049771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
52879
L
U X E M B O U R G
Happy Goo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 12-18, rue Joseph Junck.
R.C.S. Luxembourg B 167.611.
STATUTS
L'an deux mille douze, le neuf mars.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. Madame Liu Yongjun, vendeuse, née le 29 décembre 1972 à Zhejiang, Chine, demeurant au 118, Route de Thionville,
L-2610 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg;
2. Madame Wu Sudan, vendeuse, née le 20 août 1979 à Fujian, Chine, demeurant au 31, Rue Michel Rodange, L-2430
Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité
limitée qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient
devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La société a pour objet la vente en détail de toutes denrées alimentaires et non-alimentaires. En outre la société
pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit pas spécialement reglementée.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles
ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «Happy Goo S.à r.l».
Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de
l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
52880
L
U X E M B O U R G
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de
communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le premier lundi du mois de
mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
52881
L
U X E M B O U R G
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfêrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire cent (100) parts sociales
comme suit:
Madame Liu Yongjun, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Madame Wu Sudan, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de neuf cents euros (EUR
900.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante qualifiée ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment
convoquée, s’est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
2.- Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Liu Yongjun, vendeuse, née le 29 décembre 1972 à Zhejiang, Chine, demeurant au 118, Route de Thionville,
L-2610 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en tant que gérant technique;
- Madame Wu Sudan, vendeuse, née le 20 août 1979 à Fujian, Chine, demeurant au 31, Rue Michel Rodange, L2430
Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en tant que gérant administratif.
3.- La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants dont obligatoirement une signature de gérant
technique.
4.- L’adresse du siêge social de la Société est fixée au 12-18, Rue Joseph Junck, L-1839 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connues du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, elles ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Y. Liu, S. Wu, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 13 mars 2012. Relation: DIE/2012/3019. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Diekirch, le 13 mars 2012.
Référence de publication: 2012035636/154.
(120046734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
52882
L
U X E M B O U R G
88 St. James Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. Project Freedom S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 153.664.
In the year two thousand and twelve, the ninth day of March,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole partner of Project Freedom S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 20, rue de la Poste, L2346
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 153.664 (the Company). The Company has been incorporated on June 9, 2010 pursuant to a deed of
Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published on July 22, 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1501 page 72013.
There appeared:
Competrol Establishment, a company, governed by the laws of Liechtenstein, with registered office at Heiligkreuz 6,
Vaduz, FL-9490, Furstentum, Liechtenstein, registered with the Public Register of the Principality of Lichtenstein under
number FL-0001.037.745-9 (the Sole Partner),
hereby represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal on March 9, 2012.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
The Sole Partner has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Partner holds all the shares in the corporate capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Change of the Company's name into 88 St. James Street S.à r.l.
2. Amendment to article 4 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the changes
adopted under item 1. above; and
3. Miscellaneous.
III. That the Sole Partner has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner resolves to change the Company's name into 88 St. James Street S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
The Sole Partner resolves to consequently amend and hereby amends article 4 of the Articles, which will henceforth
read as follows:
“ Art. 4. The Company will have the name “88 St. James Street S.à r.l.”
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated to be approximately one thousand three hundred Euros (1,300.- EUR).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
En l'an deux mille douze, le neuf mars,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Project Freedom S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
52883
L
U X E M B O U R G
B 153.664 (la Société). La Société a été constituée le 9 juin 2010 suivant un acte de Me Martine Schaeffer, notaire de
résidence à Luxembourg, publié le 22 juillet 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1501 page
72013.
A comparu:
Competrol Establishment, une société, régie par les lois de Liechtenstein, ayant son siège social à Heiligkreuz 6, Vaduz,
FL-9490, Furstentum, Liechtenstein, immatriculée au Registre public de la Principauté du Liechtenstein sous le numéro
FL-0001.037.745-9 (l'Associé Unique),
ici représentée par Régis Galiotto, clerc, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé le 9 Mars 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination sociale de la Société en 88 St. James Street S.à r.l.;
2. La modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société (les Statuts); et
3. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en 88 St. James Street S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier par conséquent et par la présente modifie l'article 4 des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
“ Art. 4. La Société aura la dénomination “88 St. James Street S.à r.l.”
<i>Estimation des coûtsi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille trois cents
Euro (1.300,- EUR).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergence
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom usuels, état civil
et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mars 2012. Relation: LAC/2012/12619. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 mars 2012.
Référence de publication: 2012036358/94.
(120048202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
MP Kings Lyric S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 159.662.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Référence de publication: 2012036328/10.
(120047811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
52884
L
U X E M B O U R G
Optident S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5531 Remich, 17, route de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 83.912.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037617/9.
(120050257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Quilvest & Partners, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 156.529.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012036382/10.
(120048124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
Scientific Games Global Gaming S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 151.297.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 22 mars 2012.
Référence de publication: 2012036414/10.
(120048120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
IBC-Worldwide International Business Consulting & Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5330 Moutfort, 110A, route de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 106.626.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 15 mars 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le luge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à
responsabilité limitée IBC-Worldwide International Business Consulting & Partner S.à r.l., avec siège social à L-5330
Moutfort, 110a, route de Remich, de fait inconnue à cette adresse, inscrite auprès du Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B106626, ordonnées par jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Lu-
xembourg, sixième chambre, du 9 décembre 2010.
Pour extrait conforme
Christian Steinmetz
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012037815/18.
(120049949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Luxlode S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 166.548.
EXTRAIT
En date du 16 mars 2012, ILP III S.c.A. SICAR, a transféré 100 parts sociales de la Société qu'elle détenait à Progressio
Investimenti II représenté par Progressio SGR S.p.A., une société constituée sous la loi italienne, ayant son siège sociale
52885
L
U X E M B O U R G
à Via G. Grazioli 25, 38100 Trento, Italie et immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Trento sous le numéro
01861540225.
Il résulte d'une résolution écrite des associés de la Société en date du 16 mars 2012 que Monsieur Massimo Longoni,
né le 6 décembre 1970 à Como (Italie), demeurant au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, a été
nommé en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Il en résulte que la Société et désormais dotée d'un conseil de gérance composé comme suit:
- Monsieur Adrien Coulombel;
- Monsieur Massimo Longoni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012037822/23.
(120049960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Catalyst Buyout I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 627.325,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 119.578.
In the year two thousand and twelve, on the sixteenth of March.
Before Maître Joseph Elvinger Civil Law Notary, residing in Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
Catalyst General Partner Limited, a company duly organised and validly existing under the laws of Jersey, having its
registered office at Wests Centre St Helier Jersey JE4 8PQ, Channel Islands and registered under the number 94516
acting as general partner of the Catalyst Buyout Fund 1 L.P., a limited partnership established under the Limited Part-
nerships (Jersey) Law 1994, with number LP819, (hereinafter referred to as the “Sole Shareholder”),
represented by Mrs Flora Gibert, private employee, professionally residing in Luxembourg by virtue of a proxy given
under private-seal.
The said proxy will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of
the société à responsabilité limitée established in Luxembourg under the name of Catalyst Buyout I S.à r.l., with registered
office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of five
hundred sixty-seven thousand three hundred and twenty-five euros (EUR 567,325.-) incorporated pursuant to a deed of
Maître Jean-Joseph Wagner, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 18 September
2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (hereinafter referred to as the “Mémorial
C”) number 2022 dated 27 October 2006 (the “Company”); the articles of association of which have been amended for
the last time pursuant to a deed enacted by the undersigned Notary, on 1 July 2011 published in the Memorial C number
2022 dated 1 September 2011.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital by an amount of sixty thousand euros (EUR 60,000.-) so as to raise it from its
present amount of five hundred and sixty seven thousand three hundred and twenty five euros (EUR 567,325.-) to six
hundred twenty-seven thousand three hundred and twenty five euros (EUR 627,325.-).
2 To issue two thousand four hundred (2,400) new share-quotas with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-)
each, to be fully paid up, having the same rights and privileges as the existing share-quotas and entitling to dividends as
from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.
3 To accept subscription for these two thousand four hundred (2,400) new share-quotas by the Shareholder and to
accept payment in full for such new share-quotas by a contribution in cash.
4 To amend article 5 of the articles of incorporation, in order to reflect the above resolutions.
5 Miscellaneous.
52886
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the corporate capital by an amount of sixty thousand euros (EUR 60,000.-) so
as to raise it from its present amount of five hundred and sixty seven thousand, three hundred and twenty five euro (EUR
567,325.-) to six hundred twenty-seven thousand three hundred and twenty five euros (EUR 627,325.-).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to issue two thousand four hundred (2,400) new share-quotas with a nominal value of
twenty-five euros (EUR 25.-) each, to be fully paid up, having the same rights and privileges as the existing share-quotas
and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed
capital increase.
<i>Third resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared Mrs Flora Gibert, acting in her capacity as duly authorised attorney-in-fact of the Shareholder,
by virtue of the pre-mentioned proxy (the “Subscriber”).
The Subscriber declared to subscribe for the two thousand four hundred (2,400) new share-quotas with a nominal
value of twenty-five euros (EUR 25.-) each and to make payment for such new share-quotas by a contribution in cash.
The amount of sixty thousand euros (EUR 60.000,-) is thus as from now at the free disposal of the Company; evidence
thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles
of incorporation, which will from now on read as follows:
" Art. 5. Corporate capital. The issued capital of the Company is set at six hundred twenty-seven thousand three
hundred and twenty five euros (EUR 627,325.-) divided into twenty-five thousand and ninety-three (25,093) share-quotas
Each issued share -quota has a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) and is fully paid up."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase
are estimated at one thousand four hundred euros (EUR 1,400.-).
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who are known to the notary by its surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le seize mars
Pardevant Maître Joseph Elvinger notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
Catalyst General Partner Limited, une société constituée et régie par les lois de Jersey, ayant son siège social à Wests
Centre St Helier Jersey JE4 8PQ, et enregistrée sous le numéro 94516 en tant que associé commandité de Catalyst Buyout
Fund 1 L.P., société en commandite établie sous le «Limited Partnership (Jersey) Law 1994» («l'Associé»),
représentée par Madame Flora Gibert, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé. Ladite procuration restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistre-
ment.
L'Associé de la société a requis le notaire instrumentant d'acter que le comparant est l' associé unique de la société à
responsabilité limitée établie au Luxembourg sous le nom de Catalyst Buyout I S.à r.l., ayant son siège social au 46A,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 567.325,-(cinq
cent soixante-sept mille trois cent vingt-cinq euros) et constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
Notaire de residence à Luxembourg en date du 18 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations (ci-après le “Mémorial C”) numéro 2022 du 27 octobre 2006 (la «Société»), dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par le notaire soussigné en date du 1
er
juillet 2011, publié au Mémorial C
numéro 2022 du 1
er
septembre 2011.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir
sur base de l'ordre du jour suivant:
52887
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 60.000,-(soixante mille euros) pour le porter de
son montant actuel de EUR 567.325,-(cinq cent soixante-sept mille trois cent vingt-cinq euros) à EUR 627.325,-(six cent
vingt-sept mille trois cent vingt-cinq euros).
2 Emission de 2.400 (deux mille quatre cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-(vingt-cinq
euros) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à
partir du jour de la délibération de l'assemblée générale votant sur l'augmentation de capital proposée.
3 Acceptation de la souscription de ces 2.400 (deux mille quatre cents) nouvelles parts sociales par l'Associé et
acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales nouvelles par un apport en numéraire.
4 Modification de l'article 5 des statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus.
5 Divers.
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la société à concurrence de soixante mille euros (EUR 60.000,-)
pour le porter de son montant actuel de cinq cent soixante-sept mille trois cent vingt-cinq euros (EUR 567.325,-) à six
cent vingt-sept mille trois cent vingt-cinq euros (EUR 627.325,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé a décidé d'émettre 2.400 (deux mille quatre cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR
25,-(vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux
dividendes à partir du jour de la délibération de l'assemblée générale votant sur l'augmentation de capital proposée.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite Madame Flora Gibert, précitée, s'est présentée agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de l'As-
socié, en vertu de la procuration pré mentionnée (le «Souscripteur»).
Le Souscripteur a déclaré souscrire les 2.400 (deux mille quatre cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale
de EUR 25,-(vingt-cinq euros) chacune et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire.
Le montant de EUR 60.000,-(soixante mille euros) est à partir de maintenant à la libre disposition de la Société; la
preuve ayant été apportée au notaire instrumentant.
Ensuite, l'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ladite libération et d'émettre les 2.400 (deux mille quatre
cents) nouvelles parts sociales au Souscripteur.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des
statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à EUR 627.325,-(six cent vingt-sept mille trois cent vingt-
cinq euros) représenté par 25.093 (vingt-cinq mille quatre-vingt treize) parts sociales. Chaque part sociale a une valeur
nominale de EUR 25,(vingt-cinq euros) et est entièrement libérée.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à EUR 1.400,-(mille quatre cents euros).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 19 mars 2012. Relation: LAC/2012/12569. Reçu soixante quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2012036059/141.
(120048232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
52888
L
U X E M B O U R G
HMP Beratungsgesellschaft für Telekommunikations- und Sicherheitssysteme GmbH, Société à respon-
sabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 28, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 50.015.
Im Jahre zweitausendzwölf, am zweiten März.
Vor Uns Maître Joseph ELVINGER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
SIND ERSCHIENEN:
1) Herr Robert FERRY, Diplomingenieur, geboren in Diekirch, am 6. Oktober 1932, wohnhaft in L-4032 Esch-sur-
Alzette, 5, rue Bessemer.
2) Herr Günter HERZ, Kaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 9. Juni 1942, wohnhaft in D-56072 Koblenz, 32,
Trierer Strasse.
3) Herr Georg MOOSMANN, Diplomingenieur, geboren in Schramberg (Deutschland), am 7. April 1948, wohnhaft
in D-77654 Offenburg, AntonFendrich-Strasse, 5.
4) Herr Frank MAITRY, Diplomingenieur, geboren in Luxemburg, am 18. März 1964, wohnhaft in L-1913 Luxemburg,
28, rue Leandre Lacroix.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen ihre Erklärungen folgendermaßen zu beurkunden:
I.- Die Komparenten sub 1) -4) sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HMP
BERATUNGSGESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNIKATIONS- UND SICHERHEITSSYSTEME GmbH", mit Sitz in
L-1913 Luxembourg, 28, rue Léandre Lacroix, gegründet durch Urkunde, aufgenommen am 10. Januar 1995, veröffentlicht
im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 208 vom 11. Mai 1995.
II.- Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 26.000.-(sechsund zwanzigtausend Euros) eingeteilt in 1.040.-(tausend und
vierzig) Anteile von je EUR 25.(fünfundzwanzig Euros) voll eingezahlt.
Diese Anteile gehören den Gesellschaftern wie folgt:
1) Herrn Robert FERRY vorbenannt, zweihundertvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
2) Herrn Günter HERZ, vorbenannt, dreihundertzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
3) Herrn Georg MOOSMANN, vorbenannt, zweihundertvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
4) Herrn Frank MAITRY, vorbenannt, zweihundertvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
Total: tausend und vierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.040
III.- Alsdann nehmen die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse an:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Rücktritt folgender Geschäftsführer anzunehmen: Herr Robert FERRY zum 31.
Dezember 2010, Herr Georg MOOSMANN zum 31. Dezember 2010, Herr Günter HERZ zum 31. August 2011 und
ihnen volle und endgültige Entlastung betreffend die Erfüllung ihrer jeweiligen Mandaten ab dem jeweiligen Datum zu
geben.
M. Frank MAITRY ist der alleinige Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsfürer verpflichtet.
<i>Zweiter Beschlussi>
Herr Robert FERRY erklärt andurch abzutreten und in vollem Eigentum zu übertragen unter aller Gewähr rechtens
an MyCOM S.à r.l., mit Sitz L-1913 Luxembourg, 28, rue Léandre Lacroix, dies annehmend, hier vertreten durch ihren
Geschäftsführer Herr Frank MAITRY:
240 (zweihundertvierzig) Anteile von je EUR 25.-(fünfundzwanzig Euros) der hiervor bezeichneten Gesellschaft "HMP
BERATUNGSGESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNIKATIONS- UND SICHERHEITSSYSTEME GmbH".
<i>Dritter Beschlussi>
Herr Günter HERZ erklärt andurch abzutreten und in vollem Eigentum zu übertragen unter aller Gewähr rechtens
an MyCOM S.à r.l., mit Sitz L-1913 Luxembourg, 28, rue Léandre Lacroix, dies annehmend, hier vertreten durch ihren
Geschäftsführer Herr Frank MAITRY:
320 (dreihundertzwanzig) Anteile von je EUR 25.-(fünfundzwanzig Euros) der hiervor bezeichneten Gesellschaft "HMP
BERATUNGSGESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNIKATIONS- UND SICHERHEITSSYSTEME GmbH";
<i>Vierter Beschlussi>
Herr Georg MOOSMANN erklärt andurch abzutreten und in vollem Eigentum zu übertragen unter aller Gewähr
rechtens an MyCOM S.à r.l., mit Sitz L-1913 Luxembourg, 28, rue Léandre Lacroix, dies annehmend, dies annehmend,
hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herr Frank MAITRY:
52889
L
U X E M B O U R G
240 (zweihundertvierzig) Anteile von je EUR 25.-(fünfundzwanzig Euros) der hiervor bezeichneten Gesellschaft "HMP
BERATUNGSGESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNIKATIONS-UND SICHERHEITSSYSTEME GmbH".
Alsdann erklärt Herr Frank MAITRY, alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft, die hiervor dokumentierten Über-
tragungen im Namen der Gesellschaft anzunehmen und sie derselben als rechtsverbindlich und gültig zugestellt zu
betrachten, gemäss Artikel 1690 des luxemburgischen bürgerlichen Gesetzbuches.
<i>Fünfter Beschluss:i>
Die Gesellschafter beschliessen Artikel 6 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 26.000.-(sechsund zwanzigtausend Euros) eingeteilt in 1.040.-(tausend und
vierzig) Anteile von je EUR 25.-(fünfundzwanzig Euros) voll eingezahlt.
Worüber Protokoll, Aufgenommen zu Luxemburg. Im Jahr, Monat und am Tag wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende
Protokoll unterschrieben.
Signé: R. Ferry, G. Herz, G. Moosmann, F. Maitry, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 mars 2012. Relation: LAC/2012/10396. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): C. Frising.
Référence de publication: 2012036206/72.
(120048225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
TWO4TEK, Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.
R.C.S. Luxembourg B 151.491.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012037007/10.
(120049694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2012.
Capinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 90.360.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012037408/10.
(120050306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
CEREP Bedford S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 124.279.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012037410/10.
(120049988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Esaress International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 8.050.000,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 155.709.
Le nom du gérant de catégorie A de la Société, Monsieur Hugo Johannes Leopold NEUMANN doit être lu Monsieur
Hugo Johannes Leopold NEUMAN.
52890
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037454/11.
(120049953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
CORNÈR BANQUE (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 30.880.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu en date du 14 mars 2012i>
Le mandat du réviseur d'entreprise:
Ernst & Young
est renouvelé pour une période de un (1) an, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
l'année 2013.
Signatures.
Référence de publication: 2012037421/13.
(120050081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Consolidated Equipments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.582.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012037420/10.
(120050261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
CS Nordic Retail No.1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 128.983.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012037424/10.
(120050425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Immoparko S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 29.961.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 janvier 2012.i>
<i>Résolutionsi>
Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur DOSSELLI Gian Paolo demeurant via Pace 21 IT-25122 Brescia
- Monsieur Pascal HENNUY demeurant professionnellement 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg.
- Monsieur François DIFFERDANGE demeurant professionnellement 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg.
L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs délégués suivants:
- Monsieur DOSSELLI Gian Paolo demeurant via Pace 21 IT-25122 Brescia
- Monsieur Pascal HENNUY demeurant professionnellement 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg.
L’assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société KIONA
HOLDING LTD et décide de la remplacer par la société Jawer Consulting SA ayant son siège social au 241, route de
Longwy L-1941 Luxembourg.
Les mandats ainsi attribués viendront à échéance lors de l’assemblée générale à tenir en 2017.
52891
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012037529/22.
(120050297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Kingberg Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 37.972.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2012.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2012037550/12.
(120050322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Eleven Apricot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 140.320,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 159.182.
In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of March.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
REF Global Holding AG,a société anonyme governed by the laws of Switzerland, with registered office at 17, Bahn-
hofstrasse, CH-6300 Zug, Switzerland and registered with the Trade and Company Register under number 6407212 (the
³Shareholder´),
hereby represented by Me Florence FORSTER, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Zurich, on 12 March 2012.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of
Eleven Apricot S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg, with registered office at
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri
Hellinckx, residing in Luxembourg of 26 January 2011, published in the Mémorial C number 1066 on 20 May 2011 and
entered in the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, under the number B 159.182 (the "Company"). The
articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary,
of 23 December 2011, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital by an amount of two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-) so as to raise it
from its present amount of one hundred thirty-seven thousand eight hundred twenty euro (EUR 137,820.-) to one
hundred forty thousand three hundred twenty euro (EUR 140,320.-).
2 To issue two thousand five hundred (2,500) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having
the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of share-
holders resolving on the proposed capital increase.
3 To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium and to accept payment in full for
such new shares by a contribution in cash.
4 To amend article 8 of the articles of incorporation, in order to reflect the capital increase.
5 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the corporate capital by an amount of two thousand five hundred euro (EUR
2,500.-) so as to raise it from its present amount of one hundred thirty-seven thousand eight hundred twenty euro (EUR
137,820.-) to one hundred forty thousand three hundred twenty euro (EUR 140,320.-).
52892
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to issue two thousand five hundred (2,500) new shares with a nominal value of one euro
(EUR 1.-) per share and a total share premium in an amount of two hundred forty-seven thousand five hundred euro
(EUR 247,500.-).
<i>Third resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon has appeared Me Florence FORSTER, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact
of REF Global Holding AG, prenamed, by virtue of the pre-mentioned proxy (the ³Subscriber´).
The Subscriber declared to subscribe for two thousand five hundred (2,500) new shares having each a nominal value
of one euro (EUR 1.-) with payment of a share premium in a total amount of two hundred forty-seven thousand five
hundred euro (EUR 247,500.-) and to make payment for such new shares by a contribution in cash.
The amount of two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) is thus as from now at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
Thereupon, the Shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the two thousand five
hundred (2,500) new shares to the Subscriber.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolution, the Shareholder resolved to amend article 8 of the articles of incorporation, which
will from now on read as follows:
" Art. 8. The issued capital of the Company is set at one hundred forty thousand three hundred twenty euro (EUR
140,320.-) divided into one hundred forty thousand three hundred twenty (140,320) shares, with a nominal value of one
euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase
are estimated at one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing party, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known by the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douzième jour du mois de mars.
Pardevant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
REF Global Holding AG, une société anonyme constituée et régie par le droit Suisse, établie et ayant son siège social
à 17, Bahnhofstrasse, CH6300 Zug, Suisse et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
6407212 («l’Associé»),
représentée aux fins des présentes par Me Florence FORSTER, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une
procuration sous seing privé donnée à Zurich le 12 mars 2012.
La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
L’Associé de la Société a requis le notaire instrumentant d'acter que le comparant est le seul et unique associé de
Eleven Apricot S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 janvier 2011, publié au Mémorial C numéro 1066 le 20 mai
2011 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 159.182 (la «Société»). Les statuts de la
Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 23 décembre 2011, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir
sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) pour le
porter de son montant actuel de cent trente-sept mille huit cent vingt euros (EUR 137,820,-) à cent quarante mille trois
cent vingt euros (EUR 140.320,-).
52893
L
U X E M B O U R G
2 Émission de deux mille cinq cents (2.500) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune,
ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du
jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital proposée.
3 Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles, avec paiement d’une prime d’émission, et acceptation
de la libération intégrale de ces parts sociales nouvelles par apport en espèces.
4 Modification de l’article 8 des statuts, afin de refléter l’augmentation de capital.
5 Divers.
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la société à concurrence de deux mille cinq cents euros
(EUR 2.500,-) pour le porter de son montant actuel de cent trente-sept mille huit cent vingt euros (EUR 137.820,-) à cent
quarante mille trois cent vingt euros (EUR 140.320,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique a décidé d’émettre deux mille cinq cents (2.500) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d’un
euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices
de la société à partir du jour des présentes résolutions.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite Me Florence FORSTER, précité, s’est présenté agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de REF
Global Holding AG, précitée, en vertu de la procuration prémentionnée (le «Souscripteur»).
Le Souscripteur a déclaré souscrire deux mille cinq cents (2.500) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d’un
euro (EUR 1,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent quarante-sept mille cinq
cents euros (EUR 247.500,-) et libérer intégralement ces parts sociales nouvelles par un apport en espèces.
Le montant de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société,
la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.
Ensuite, l’Associé unique a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les deux mille cinq cents
(2.500) parts sociales nouvelles au Souscripteur.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l'Associé unique a décidé de modifier l’article 8 des statuts qui
sera dorénavant rédigé comme suit:
" Art. 8. Le capital émis de la Société est fixé à cent quarante mille trois cent vingt euros (EUR 140.320,-), représenté
par cent quarante mille trois cent vingt (140.320) parts sociales, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune,
chaque part sociale entièrement libérée.”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à mille six cents euros (EUR 1.600,-).
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu’à la demande de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Forster, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 14 mars 2012. Relation: DIE/2012/3094. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Diekirch, le 14 mars 2012.
Référence de publication: 2012036126/142.
(120047843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.
52894
L
U X E M B O U R G
CS Nordic Retail No.2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 129.887.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2012.
Référence de publication: 2012037425/10.
(120050424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
DB Akela Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 114.237.
Le bilan au 30 septembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012037440/10.
(120050217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
Jay Enterprise Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 158.585.
<i>Extrait de la décision des associés adoptée le 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2012i>
Conformément à la cession de parts sociales du 1
er
mars 2012, James Anthony Brian MEULEMANS, demeurant
professionnellement à B-2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/1. a vendu 33 parts sociales détenues dans la Société à
Monsieur Gertjan BOUMA, demeurant professionnellement à B-2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/1;
Conformément à la cession de parts sociales du 1
er
mars 2012, Wilhelmus Adrianus Hildebrandus Jeroenymus Maria
VAN BELKUM, employé, né à Eindhoven (Pays-Bas), le 8 mai 1969, demeurant professionnellement à B-2300 Turnhout,
Everdongenlaan 15/1,a vendu 50 parts sociales détenues dans la Société à Monsieur Gertjan BOUMA, demeurant pro-
fessionnellement à B-2300 Turnhout, Everdongenlaan 15/1;
Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé unique Monsieur Monsieur Gertjan BOUMA et d'enregistrer
la cession de parts sociales dans le registre des associés de la Société.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Pour extrait sincère et conforme
JAY ENTERPRISE SARL
Représenté par Wilhelmus Adrianus Hildebrandus Jeroenymus M. VAN BELKUM / Gertjan BOUMA
<i>Gérantsi>
Référence de publication: 2012037537/22.
(120050127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
CSN Resources S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité 2.
R.C.S. Luxembourg B 148.403.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 March 2012.
CSN Resources S.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012037426/14.
(120050203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.
52895
L
U X E M B O U R G
Rockwell Collins European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 96.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 106.509.
Les comptes annuels audités au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012038217/13.
(120051021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Rockwell Collins International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 96.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 145.840.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012038219/12.
(120050949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
UBS (Lux) Key Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 88.580.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour UBS (Lux) Key Selection SICAV
i>UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mathias Welter / Vitali Schetle
<i>Associate Director / Directori>
Référence de publication: 2012038313/13.
(120050773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Rockwell Collins International Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 96.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 145.775.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012038218/12.
(120050970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
52896
88 St. James Street S.à r.l.
Aldorf & Norbereit Invest S.A.
BAAL Capital S.A.
BRE/Japan NPL 1 S.à r.l.
Capinvest S.à r.l.
Catalyst Buyout I S.à r.l.
CEREP Bedford S.à r.l.
Cherras Investments S.à r.l.
Clinlux S.A. Holding
Consolidated Equipments S.A.
CORNÈR BANQUE (Luxembourg) S.A.
CS Nordic Retail No.1 S.A.
CS Nordic Retail No.2 S.A.
CSN Resources S.A.
DB Akela Sàrl
Eleven Apricot S.à r.l.
EMVF Lux Finance
EMVF Lux Master
Esaress International S.à r.l.
Flux Re S.A.
Fondation Ste Zithe
Happy Goo S.à r.l.
HEPP IV Luxembourg JV S.à r.l.
HEPP IV Management Company S.à r.l.
HMP Beratungsgesellschaft für Telekommunikations- und Sicherheitssysteme GmbH
IBC-Worldwide International Business Consulting & Partner S.à r.l.
Ilix Holding S.A.
Immobilière Livange SA
Immoparko S.A.
Invalda Lux S.à r.l.
Japan Logistics I S.à r.l.
Jay Enterprise Sàrl
Kingberg Immobilière S.A.
Luxlode S.à r.l.
Magritt S.A.
Matterhorn Mobile Holdings S.A.
Mefertrade S.A.
MP Kings Lyric S.à r.l.
Optident S.à r.l.
Project Freedom S.à r.l.
Quilvest & Partners
Revolin S.à r.l.
Rockwell Collins European Holdings S.à r.l.
Rockwell Collins International Financing S.à r.l.
Rockwell Collins International Holdings S.à r.l.
Scientific Games Global Gaming S.à r.l.
Solution Façade Bâtiment Sàrl
Triton Advisers S.à r.l.
TWO4TEK
UBS (Lux) Key Selection SICAV