logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1053

25 avril 2012

SOMMAIRE

26 Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50537

Bisa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50538

Dekra Claims Services Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50515

Gaïa International Financial Investment

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50539

Germalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50520

Geser Holding International S.A.  . . . . . . . .

50523

Granilo Holding B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50542

Gridway S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50542

GS Car Rental Lux II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

50513

Halym SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50543

Hatra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50544

Holding de Diversification Financière Pru-

dentielle S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50543

Jalyne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50506

J. Chahine Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50544

Keravel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50536

King's Cross Asset Funding 39 . . . . . . . . . . .

50544

Kondor Bidco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50513

Leopard S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50520

Lobster Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50524

LSREF2 A. F. Investments S.à r.l.  . . . . . . . .

50516

LSREF2 Star Gate Investments S.à r.l.  . . .

50510

Lux Business Risk Monitoring S.A.  . . . . . . .

50518

Lux-Pipe Tech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50518

Lyma S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50509

MacArthur Investments  . . . . . . . . . . . . . . . .

50539

Morgan Stanley Euro Financing (Luxem-

bourg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50532

Polish Omega Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

50527

Quintiles Luxembourg S. à r.l. . . . . . . . . . . .

50539

RBC Funds (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50498

Reflexes Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50512

Robec SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50524

SAGITTARUS Agency S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

50538

Saint Seba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50539

Samarvest Inc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50519

SCI Pabet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50534

Security Capital European Realty . . . . . . . .

50522

Serafin S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50522

SGEA Immobilier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50532

Signes S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50522

Société Générale Luxembourgeoise d'in-

génierie et de développement . . . . . . . . . .

50521

Syncreon Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50538

TAITAVA Fund SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . . .

50523

The PNC Financial Services Holding Lu-

xembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50522

TransEuropean Property Holdings (Lu-

xembourg) II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50538

Treveria Twenty-Five S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

50523

Treveria Twenty-Nine S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

50543

Turaz Global TRM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

50544

UBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50532

UMP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50532

Valves Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50536

50497

L

U X E M B O U R G

RBC Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 148.411.

In the year two thousand twelve, on the fifth of April,
Before us, Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg City,
Was  held  an  extraordinary  general  meeting  of  shareholders  of  the  Company,  a  public  limited  company  (“société

anonyme”) having its registered office at 14, Porte de France, L-4360, Esch-sur-Alzette, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under section B number 148.411. The Company has been incorporated under the form
of a “société d’investissement à capital variable” by a notarial deed of 2 October 2009 published in the Mémorial C number
2025 of 16 October 2009.

The meeting was opened under the chairmanship of Carole Protin, private employee, professionally residing in Lu-

xembourg,

who appointed as secretary, Sandy Brumberg, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mélanie Rocchi, private employee, professionally residing in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
A. The present meeting has been called pursuant to a convening notice.
B. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, as well as the number of

Shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of
the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached
to the present deed and registered therewith.

C. The quorum of at least one half of the capital is required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of 10 august

1915 on commercial companies, as amended, and the resolution on each item of the agenda has to be passed by the
affirmative vote of at least two thirds of the votes validly cast at the meeting.

D. All the shares being registered shares, convening notices have been sent by registered mail to each registered

shareholders on 27 March 2012.

E. The agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

I. Approval of the following amendments to the Articles in order to reflect the provisions of the UCITS IV Directive

2009/65/EC, which has been transposed in Luxembourg by the law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, as amended from time to time (the “Law of 2010”):

1. Replacement of the references, throughout the Articles, to the law of 20 December 2002 on undertakings for

collective investment, with references to the Law of 2010, and subsequent amendment of articles 1 and 5.

2. Amendment of item 6 of article 11.2.2 by introducing a reference to the “Key Investor Information Document”.
3. Amendments to article 12 in order to reflect inter alia the ability to suspend the calculation of the net asset value

per share and the issue, repurchase and conversion of the shares of a sub-fund of the Company in the event of the
suspension of the calculation of the net asset value per share, or the issue, redemption and/or conversion of the shares
of a master fund in which the relevant sub-fund invests as a feeder fund, so as to read as follows:

“ 12.2.2. during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Directors,

as a result of which disposals or valuation of assets of the Sub-Fund concerned would be impractical;

12.2.3. during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the

price or value of any of the investments attributable to any particular Sub-Fund or the currency price or values on any
such stock exchange in respect of the assets attributable to such Sub-Fund;

12.2.4. during any period when, for any other reason, the prices of any investments owned by the Company attributable

to any Sub-Fund cannot promptly or accurately be ascertained;

12.2.8. following the suspension of the calculation of the net asset value per Share at the level of a master fund in which

any Sub-Fund invests in its capacity as feeder fund of such master fund, to the extent applicable.

12.3. The Company may suspend the issue and redemption of its Shares from its shareholders, as well as the conversion

from and to Shares of each class, following the suspension of the issue, redemption and/or the conversion at the level of
a master fund in which the Company invests in its capacity as feeder fund of such master fund, to the extent applicable.

Investors who have requested the purchase, redemption or conversion of Shares shall be informed of such suspension

when such request is made. In the event such suspension period exceeds the period initially determined by the Company,
all shareholders of the Class of Shares concerned shall be informed.

50498

L

U X E M B O U R G

Such suspension as to any Class of Shares or Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the net asset value

per Share, the issue, redemption and conversion of Shares of any other Class of Shares or Sub-Fund, if the assets within
such other Class of Shares or Sub-Fund are not affected to the same extent by the same circumstances.”

4. Amendment of article 18 of the Articles in order to include the possibility for the Company to invest in shares or

units of other UCITS and UCIs, including shares or units of a master fund qualified as a UCITS, so as to read as follows:

“In particular, such Prospectus may allow the investment in units of a master fund qualifying as a UCITS provided that

the relevant Sub-Fund invests at least 85% of its net asset value in units/Shares of such master fund and that such master
fund shall neither itself be a feeder fund nor hold units/Shares of a feeder fund.”

5. Insertion of a new paragraph under article 18 of the Articles in order to include the possibility for any sub-fund of

the Company to invest in other sub-funds of the Company, so as to read as follows:

“Each Sub-Fund is finally authorised to invest in Shares of another Sub-Fund of the Company (the “Target Sub-Fund”)

provided that:

- A. the Target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this Target Sub-Fund;
- B. no more than 10% of the assets of the Target Sub-Fund whose acquisition is contemplated may be invested in

aggregate in units of other UCIs;

- C. voting rights attached to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned

and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports;

- D. in any event, for as long as such shares are held by the Company, their value will not be taken into consideration

for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets
as set out in Article 5; and

- E. there is no duplication of management, performance, subscription or redemption fees amongst the Target Sub-

Fund and the investing Sub-Fund.”

6. Drafting of a new article 26 and replacement of the current provisions of the Articles regarding mergers, in order

to reflect the new provisions of the Law of 2010 regarding mergers of UCITS. Article 26 shall read as follows:

“ 26.1. Merger of the Company
Mergers decided by the Directors
The Directors may decide to proceed with a merger of the Company (within the meaning of the Law), either as

receiving or absorbed UCITS, with:

- another Luxembourg or foreign UCITS (the “New UCITS”); or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the Shares of the Company concerned as Shares of this New UCITS, or of the

relevant Sub-Fund thereof as applicable.

In case the Company involved in a merger is the receiving UCITS, solely the Directors will decide on the merger and

effective date thereof.

In case the Company involved in a merger is the absorbed UCITS, and hence ceases to exist, the general meeting of

the shareholders, rather than the board of directors, has to approve, and decide on the effective date of, such merger by
a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law, in particular concerning the

merger project and the information to be provided to the shareholders.

26.2. Merger of Sub-Funds
Mergers decided by the Directors
The Directors may decide to proceed with a merger of any Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:
- another existing Sub-Fund within the Company or another sub-fund within a New UCITS (the “New Sub-Fund”); or
- a New UCITS,
and, as appropriate, to redesignate the Shares of the Sub-Fund concerned as Shares of the New UCITS, or of the New

Sub-Fund as applicable.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law, in particular concerning the

merger project and the information to be provided to the shareholders.”

II. Approval of the following minor amendments to the Articles in order to improve the organisational and operational

aspects of the Company:

1. Addition of a second paragraph in article 2 in order to allow the board of directors of the Company (the “Board”)

to transfer the registered office of the Company within the same municipality or to another municipality, to the extent
permitted by Luxembourg laws and regulations, which will read as follows:

“ 2.2. The Directors may decide to transfer the registered office of the Company within the same municipality, or

from a municipality to another municipality within the Grand Duchy of Luxembourg, if and to the extent permitted by
Luxembourg law and practice relating to commercial companies.”

50499

L

U X E M B O U R G

2. Addition of a fourth paragraph in article 5 regarding the creation and the duration of sub-funds and classes of shares

which shall read as follows:

“ 5.4. The Directors may create each Sub-Fund or Class of Shares for an unlimited or limited period of time; in the

latter case, the Directors may, at the expiry of the initial period of time, prorograte the duration of the relevant Sub-
Fund or Class of Shares once or several times. At expiry of the duration of the Sub-Fund or Class of Shares, the Company
shall redeem all the Shares in the relevant Class(es) of Shares, in accordance with the provisions of Article 8 below. At
each prorogation of a Sub-Fund or Class of Shares, the shareholders shall be duly notified.”

3. Addition of a new paragraph in article 6 in relation to the issuance of share certificates which shall read as follows:

“ 6.2.1. The Share certificates, if issued, shall be signed by two Directors. Such signatures shall be either manual, or

printed, or in facsimile. The certificates will remain valid even if the list of authorised signatures of the Company is modified.
However, one of such signatures may be made by a person duly authorised thereto by the Directors; in the latter case,
it shall be manual.”

4. Amendment of paragraph 7.7 of article 7 in order to clarify the provisions relating to the contribution in kind of

securities and so as to read as follows:

“ 7.7. The Company may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance

with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the
independent authorised auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé"). The securities to be delivered by way
of a contribution in kind must correspond to the investment policy and restrictions of the Sub-Fund to which they are
contributed. Any costs incurred in connection with a contribution in kind of securities shall be borne by the relevant
shareholders.”

5. Amendment to the final paragraph of article 8 which shall now read as follows:

“ 8.9. All redeemed shares may be cancelled.”
6. Amendment to the final paragraph of article 9 which shall now read as follows:

“ 9.4. The Shares which have been converted into Shares of another Sub-Fund or Class may be cancelled.”
7. Amendment to section 11.2.1 of article 11 so as to include the utilization of the amortised cost method of valuation

and include additional details on the valuation of certain assets, so as to read as follows:

“2. The value of transferable securities and money market instruments and any other assets which are listed or dealt

in on any stock exchange shall be based on the latest available price. Transferable securities, money market instruments
and any other assets traded on any other regulated market shall be valued in a manner as similar as possible to that
provided for quoted securities.

The value of money market instruments not listed or dealt in on any regulated market, stock exchange, or any other

regulated market and with remaining maturity of less than 12 months may be valued by the amortised cost method, which
approximates market value;

4. The Directors may authorise the use of the amortised cost method of valuation for short-term transferable debt

securities in certain Sub-Funds. This method involves valuing a security at its cost and thereafter assuming a constant
amortisation to maturity of any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market
value of the security or other instrument. While this method provides certainty in valuation, it may result in periods
during which value as determined by amortised cost, is higher or lower than the price the Sub-Fund would receive if it
sold the securities. This method of valuation will only be used in accordance with Committee of European Securities
Regulators (CESR) (now ESMA) guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS and only with respect to
securities with a maturity at issuance or residual term to maturity of 397 days or less or securities that undergo regular
yield adjustments at least every 397 days;

9. Foreign exchange forward contracts shall be valued in the same manner as derivatives contracts which are not traded

on a regulated market or by reference to freely available market quotations;

10. Interest rate swaps shall be valued on the basis of their market value established by reference to the applicable

interest rate curve.

Swaps pegged to indexes or financial instruments shall be valued at their market value, based on the applicable index

or financial instrument. The valuation of the swaps tied to such indexes or financial instruments shall be based upon the
market value of said swaps, in accordance with the procedures laid down by the Directors.

Credit default swaps are valued on the frequency of the net asset value based on a market value obtained by external

price providers. The calculation of the market value is based on the credit risk of the reference party, respectively the
issuer, the maturity of the credit default swap and its liquidity on the secondary market. The valuation method is recognized
by the Directors of the Company and checked by the authorised auditors.

Total return swaps or total rate of return swaps (“TRORS”) shall be valued at fair value under procedures approved

by the Directors. As these swaps are not exchange-traded, but are private contracts into which the Company and a swap
counterparty enter as principals, the data inputs for valuation models are usually established by reference to active mar-
kets. However it is possible that such market data will not be available for total return swaps or TRORS near the Valuation

50500

L

U X E M B O U R G

Day. Where such market inputs are not available, quoted market data for similar instruments (e.g. a different underlying
instrument for the same or a similar reference entity) will be used, provided that appropriate adjustments be made to
reflect any differences between the total return swaps or TRORS being valued and the similar financial instrument for
which a price is available. Market input data and prices may be sourced from exchanges, a broker, an external pricing
agency or a counterparty.

If no such market input data are available, total return swaps or TRORS shall be valued at their fair value pursuant to

a valuation method adopted by the Directors which shall be a valuation method widely accepted as good market practice
(i.e. used by active participants on setting prices in the market place or which has demonstrated to provide reliable
estimates of market prices) provided that adjustments that the Directors may deem fair and reasonable be made. The
Company's authorised auditors will review the appropriateness of the valuation methodology used in valuing total return
swaps or TRORS. In any case, the Company shall always value total return swaps or TRORS on an arm’s-length basis.

All other swaps shall be valued at fair value, as determined in good faith pursuant to procedures established by the

Directors;

11. The value of contracts for differences will be based on the value of the underlying assets and vary similarly to the

value of such underlying assets. Contracts for differences will be valued at fair market value, as determined in good faith
pursuant to procedures established by the Directors;”

8. Addition of a second paragraph to section 11.2.2 of article 11, which shall read as follows:
“2. All accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);”
9. Addition of a new paragraph under section 11.2.3 of article 11 which shall read as follows:
“The Directors may, at their discretion, decide to change the characteristics of any Class of Shares as described in the

Prospectus in accordance with the procedures determined by the Directors from time to time.”

10. Amendment of articles 13, 14, 23 and 24 in order to reflect various amendments to the law of 10 August 1915

relating to commercial companies, as amended (the “Law of 1915”) and to provide for a more comprehensive drafting
of the provisions of the Articles relating to the meetings of shareholders of the Company and functions and meetings of
the Board.

11. Inclusion of an additional paragraph to article 18 of the Articles which shall read as follows:
“The Sub-Fund may further invest in deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right

to be withdrawn and which are maturing in no more than 12 months.”

12. Amendment of article 18 so as to include a reference to Canada as member state of the Organization for Economic

Cooperation and Development (“OECD”) and so as to read as follows:

“Each Sub-Fund is authorised to invest, in accordance with the principle of risk spreading, up to 100% of its net assets

in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a member state of the European Union,
by its local authorities, by any other member state of the Organization for Economic Cooperation and Development
("OECD") such as Canada or the United States or by a public international body of which one or more member state(s)
of the European Union are member(s), provided that (i) such securities are part of at least six different issues and (ii) the
securities from any such issue do not account for more than 30% of the net assets of such Sub-Fund.”

13. Addition of two paragraphs at the end of article 18 in relation to the use of derivatives instruments and techniques

and instruments, which shall read as follows:

“Sub-Funds may also invest in derivative instruments (i) for efficient portfolio management (ii) for hedging purposes in

the context of the management of its assets and liabilities and (iii) for investment purposes.

The Company may also use techniques and instruments relating to transferable securities and money market instru-

ments, to the extent that these techniques and instruments are used in view of efficient portfolio management.”

14. The term “auditor” has been amended throughout the Articles so as to now read “independent authorised auditor”

or “authorised auditor”.

15. Amendment of article 25 of the Articles, in light of the new article 26 on mergers, in order to include the reference

made in the Law of 2010 that the liquidation of the last remaining sub-fund will result in the Fund’s liquidation, so as to
read as follows:

“ 25.3. The liquidation of a Sub-Fund shall have no influence on any other Sub-Fund. The liquidation of the last remaining

Sub-Fund will result in the Company’s liquidation.

25.4. All redeemed shares may be cancelled.”
III. Approval of minor stylistic amendments to articles 5, 7, 11, 12, 17, 19, 21, 30 and 31 of the Articles and amendment

of the numbering of the Articles following the addition of the new Article 26.

IV. Miscellaneous
F. Pursuant to the attendance list, five shareholders, holding together 1,236,002.207 Shares out of 1,612,806.412 shares

outstanding, are present or represented.

G. That pursuant to Article 67-1(2) of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the present

meeting may only validly deliberate on the items of the agenda if at least one half of the capital is represented.

50501

L

U X E M B O U R G

H. Consequently, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
I. After deliberation, the meeting took the following resolutions by unanimous vote:

<i>First Resolution

The Meeting decides to replace the references, throughout the Articles, to the law of 20 December 2002 on under-

takings for collective investment, with references to the Law of 2010, and subsequent amendment of articles 1 and 5.

<i>Second Resolution

The Meeting decides to amend item 6 of article 11.2.2 by introducing a reference to the “Key Investor Information

Document”.

<i>Third Resolution

The Meeting decides to amend article 12 in order to reflect inter alia the ability to suspend the calculation of the net

asset value per share and the issue, repurchase and conversion of the shares of a sub-fund of the Company in the event
of the suspension of the calculation of the net asset value per share, or the issue, redemption and/or conversion of the
shares of a master fund in which the relevant sub-fund invests as a feeder fund, so as to read as follows:

“ 12.2.2. during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Directors,

as a result of which disposals or valuation of assets of the Sub-Fund concerned would be impractical;

12.2.3. during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the

price or value of any of the investments attributable to any particular Sub-Fund or the currency price or values on any
such stock exchange in respect of the assets attributable to such Sub-Fund;

12.2.4. during any period when, for any other reason, the prices of any investments owned by the Company attributable

to any Sub-Fund cannot promptly or accurately be ascertained;

12.2.8. following the suspension of the calculation of the net asset value per Share at the level of a master fund in which

any Sub-Fund invests in its capacity as feeder fund of such master fund, to the extent applicable.

12.3. The Company may suspend the issue and redemption of its Shares from its shareholders, as well as the conversion

from and to Shares of each class, following the suspension of the issue, redemption and/or the conversion at the level of
a master fund in which the Company invests in its capacity as feeder fund of such master fund, to the extent applicable.

Investors who have requested the purchase, redemption or conversion of Shares shall be informed of such suspension

when such request is made. In the event such suspension period exceeds the period initially determined by the Company,
all shareholders of the Class of Shares concerned shall be informed.

Such suspension as to any Class of Shares or Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the net asset value

per Share, the issue, redemption and conversion of Shares of any other Class of Shares or Sub-Fund, if the assets within
such other Class of Shares or Sub-Fund are not affected to the same extent by the same circumstances.”

<i>Fourth Resolution

The Meeting decides to amend article 18 of the Articles in order to include the possibility for the Company to invest

in shares or units of other UCITS and UCIs, including shares or units of a master fund qualified as a UCITS, so as to read
as follows:

“In particular, such Prospectus may allow the investment in units of a master fund qualifying as a UCITS provided that

the relevant Sub-Fund invests at least 85% of its net asset value in units/Shares of such master fund and that such master
fund shall neither itself be a feeder fund nor hold units/Shares of a feeder fund.”

<i>Fifth Resolution

The Meeting decides to insert a new paragraph under article 18 of the Articles in order to include the possibility for

any sub-fund of the Company to invest in other subfunds of the Company, so as to read as follows:

“Each Sub-Fund is finally authorised to invest in Shares of another Sub-Fund of the Company (the “Target Sub-Fund”)

provided that:

- A. the Target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this Target Sub-Fund;
- B. no more than 10% of the assets of the Target Sub-Fund whose acquisition is contemplated may be invested in

aggregate in units of other UCIs;

- C. voting rights attached to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned

and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports;

- D. in any event, for as long as such shares are held by the Company, their value will not be taken into consideration

for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets
as set out in Article 5; and

- E. there is no duplication of management, performance, subscription or redemption fees amongst the Target Sub-

Fund and the investing Sub-Fund.”

50502

L

U X E M B O U R G

<i>Sixth Resolution

The Meeting decides to draft a new article 26 and replace the current provisions of the Articles regarding mergers, in

order to reflect the new provisions of the Law of 2010 regarding mergers of UCITS. Article 26 shall read as follows:

“ 26.1. Merger of the Company
Mergers decided by the Directors
The Directors may decide to proceed with a merger of the Company (within the meaning of the Law), either as

receiving or absorbed UCITS, with:

- another Luxembourg or foreign UCITS (the “New UCITS”); or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the Shares of the Company concerned as Shares of this New UCITS, or of the

relevant Sub-Fund thereof as applicable.

In case the Company involved in a merger is the receiving UCITS, solely the Directors will decide on the merger and

effective date thereof.

In case the Company involved in a merger is the absorbed UCITS, and hence ceases to exist, the general meeting of

the shareholders, rather than the board of directors, has to approve, and decide on the effective date of, such merger by
a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law, in particular concerning the

merger project and the information to be provided to the shareholders.

26.2. Merger of Sub-Funds Mergers decided by the Directors The Directors may decide to proceed with a merger of

any Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:

- another existing Sub-Fund within the Company or another sub-fund within a New UCITS (the “New Sub-Fund”); or
- a New UCITS,
and, as appropriate, to redesignate the Shares of the Sub-Fund concerned as Shares of the New UCITS, or of the New

Sub-Fund as applicable.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law, in particular concerning the

merger project and the information to be provided to the shareholders.”

<i>Seventh Resolution

The Meeting decides to add a second paragraph in article 2 in order to allow the board of directors of the Company

(the “Board”) to transfer the registered office of the Company within the same municipality or to another municipality,
to the extent permitted by Luxembourg laws and regulations, which will read as follows:

“ 2.2. The Directors may decide to transfer the registered office of the Company within the same municipality, or

from a municipality to another municipality within the Grand Duchy of Luxembourg, if and to the extent permitted by
Luxembourg law and practice relating to commercial companies.”

<i>Eighth Resolution

The Meeting decides to add a fourth paragraph in article 5 regarding the creation and the duration of sub-funds and

classes of shares which shall read as follows:

“ 5.4. The Directors may create each Sub-Fund or Class of Shares for an unlimited or limited period of time; in the

latter case, the Directors may, at the expiry of the initial period of time, prorograte the duration of the relevant Sub-
Fund or Class of Shares once or several times. At expiry of the duration of the Sub-Fund or Class of Shares, the Company
shall redeem all the Shares in the relevant Class(es) of Shares, in accordance with the provisions of Article 8 below. At
each prorogation of a Sub-Fund or Class of Shares, the shareholders shall be duly notified.”

<i>Ninth Resolution

The Meeting decides to add a new paragraph in article 6 in relation to the issuance of share certificates which shall

read as follows:

“ 6.2.1. The Share certificates, if issued, shall be signed by two Directors. Such signatures shall be either manual, or

printed, or in facsimile. The certificates will remain valid even if the list of authorised signatures of the Company is modified.
However, one of such signatures may be made by a person duly authorised thereto by the Directors; in the latter case,
it shall be manual.”

<i>Tenth Resolution

The Meeting decides to amend paragraph 7.7 of article 7 in order to clarify the provisions relating to the contribution

in kind of securities and so as to read as follows:

50503

L

U X E M B O U R G

“ 7.7. The Company may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance

with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the
independent authorised auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé"). The securities to be delivered by way
of a contribution in kind must correspond to the investment policy and restrictions of the Sub-Fund to which they are
contributed. Any costs incurred in connection with a contribution in kind of securities shall be borne by the relevant
shareholders.”

<i>Eleventh Resolution

The Meeting decides to amend the final paragraph of article 8 which shall now read as follows:

“ 8.9. All redeemed shares may be cancelled.”

<i>Twelfth Resolution

The Meeting decides to amend the final paragraph of article 9 which shall now read as follows:

“ 9.4. The Shares which have been converted into Shares of another Sub-Fund or Class may be cancelled.”

<i>Thirteenth Resolution

The Meeting decides to amend section 11.2.1 of article 11 so as to include the utilization of the amortised cost method

of valuation and include additional details on the valuation of certain assets, so as to read as follows:

“2. The value of transferable securities and money market instruments and any other assets which are listed or dealt

in on any stock exchange shall be based on the latest available price. Transferable securities, money market instruments
and any other assets traded on any other regulated market shall be valued in a manner as similar as possible to that
provided for quoted securities.

The value of money market instruments not listed or dealt in on any regulated market, stock exchange, or any other

regulated market and with remaining maturity of less than 12 months may be valued by the amortised cost method, which
approximates market value;

4. The Directors may authorise the use of the amortised cost method of valuation for short-term transferable debt

securities in certain Sub-Funds. This method involves valuing a security at its cost and thereafter assuming a constant
amortisation to maturity of any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market
value of the security or other instrument. While this method provides certainty in valuation, it may result in periods
during which value as determined by amortised cost, is higher or lower than the price the Sub-Fund would receive if it
sold the securities. This method of valuation will only be used in accordance with Committee of European Securities
Regulators (CESR) (now ESMA) guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS and only with respect to
securities with a maturity at issuance or residual term to maturity of 397 days or less or securities that undergo regular
yield adjustments at least every 397 days;

9. Foreign exchange forward contracts shall be valued in the same manner as derivatives contracts which are not traded

on a regulated market or by reference to freely available market quotations;

10. Interest rate swaps shall be valued on the basis of their market value established by reference to the applicable

interest rate curve.

Swaps pegged to indexes or financial instruments shall be valued at their market value, based on the applicable index

or financial instrument. The valuation of the swaps tied to such indexes or financial instruments shall be based upon the
market value of said swaps, in accordance with the procedures laid down by the Directors.

Credit default swaps are valued on the frequency of the net asset value based on a market value obtained by external

price providers. The calculation of the market value is based on the credit risk of the reference party, respectively the
issuer, the maturity of the credit default swap and its liquidity on the secondary market. The valuation method is recognized
by the Directors of the Company and checked by the authorised auditors.

Total return swaps or total rate of return swaps (“TRORS”) shall be valued at fair value under procedures approved

by the Directors. As these swaps are not exchangetraded, but are private contracts into which the Company and a swap
counterparty enter as principals, the data inputs for valuation models are usually established by reference to active mar-
kets. However it is possible that such market data will not be available for total return swaps or TRORS near the Valuation
Day. Where such market inputs are not available, quoted market data for similar instruments (e.g. a different underlying
instrument for the same or a similar reference entity) will be used, provided that appropriate adjustments be made to
reflect any differences between the total return swaps or TRORS being valued and the similar financial instrument for
which a price is available. Market input data and prices may be sourced from exchanges, a broker, an external pricing
agency or a counterparty.

If no such market input data are available, total return swaps or TRORS shall be valued at their fair value pursuant to

a valuation method adopted by the Directors which shall be a valuation method widely accepted as good market practice
(i.e. used by active participants on setting prices in the market place or which has demonstrated to provide reliable
estimates of market prices) provided that adjustments that the Directors may deem fair and reasonable be made. The

50504

L

U X E M B O U R G

Company's authorised auditors will review the appropriateness of the valuation methodology used in valuing total return
swaps or TRORS. In any case, the Company shall always value total return swaps or TRORS on an arm’s-length basis.

All other swaps shall be valued at fair value, as determined in good faith pursuant to procedures established by the

Directors;

11. The value of contracts for differences will be based on the value of the underlying assets and vary similarly to the

value of such underlying assets. Contracts for differences will be valued at fair market value, as determined in good faith
pursuant to procedures established by the Directors;”

<i>Fourteenth Resolution

The Meeting decides to add a second paragraph to section 11.2.2 of article 11, which shall read as follows:
“2. All accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);”

<i>Fifteenth Resolution

The Meeting decides to add a new paragraph under section 11.2.3 of article 11 which shall read as follows:
“The Directors may, at their discretion, decide to change the characteristics of any Class of Shares as described in the

Prospectus in accordance with the procedures determined by the Directors from time to time.”

<i>Sixteenth Resolution

The Meeting decides to amend articles 13, 14, 23 and 24 in order to reflect various amendments to the law of 10

August 1915 relating to commercial companies, as amended (the “Law of 1915”) and to provide for a more comprehensive
drafting of the provisions of the Articles relating to the meetings of shareholders of the Company and functions and
meetings of the Board.

<i>Seventeenth Resolution

The Meeting decides to include an additional paragraph to article 18 of the Articles which shall read as follows:
“The Sub-Fund may further invest in deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right

to be withdrawn and which are maturing in no more than 12 months.”

<i>Eighteenth Resolution

The Meeting decides to amend article 18 so as to include a reference to Canada as member state of the Organization

for Economic Cooperation and Development (“OECD”) and so as to read as follows:

“Each Sub-Fund is authorised to invest, in accordance with the principle of risk spreading, up to 100% of its net assets

in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a member state of the European Union,
by its local authorities, by any other member state of the Organization for Economic Cooperation and Development
("OECD") such as Canada or the United States or by a public international body of which one or more member state(s)
of the European Union are member(s), provided that (i) such securities are part of at least six different issues and (ii) the
securities from any such issue do not account for more than 30% of the net assets of such Sub-Fund.”

<i>Nineteenth Resolution

The Meeting decides to add two paragraphs at the end of article 18 in relation to the use of derivatives instruments

and techniques and instruments, which shall read as follows:

“Sub-Funds may also invest in derivative instruments (i) for efficient portfolio management (ii) for hedging purposes in

the context of the management of its assets and liabilities and (iii) for investment purposes.

The Company may also use techniques and instruments relating to transferable securities and money market instru-

ments, to the extent that these techniques and instruments are used in view of efficient portfolio management.”

<i>Twentieth Resolution

The Meeting decides to amend the term “auditor” throughout the Articles so as to now read “independent authorised

auditor” or “authorised auditor”.

<i>Twenty-first Resolution

The Meeting decides to amend article 25 of the Articles, in light of the new article 26 on mergers, in order to include

the reference made in the Law of 2010 that the liquidation of the last remaining sub-fund will result in the Fund’s liquidation,
so as to read as follows:

“ 25.3. The liquidation of a Sub-Fund shall have no influence on any other Sub-Fund. The liquidation of the last remaining

Sub-Fund will result in the Company’s liquidation.

25.4. All redeemed shares may be cancelled.”

50505

L

U X E M B O U R G

<i>Twenty-second Resolution

The Meeting decides to approve minor stylistic amendments to articles 5, 7, 11, 12, 17, 19, 21, 30 and 31 of the Articles

and amend the numbering of the Articles following the addition of the new Article 26.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

This document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to

the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: C. PROTIN, S. BRUMBERG, M. ROCCHI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 avril 2012. Relation: LAC/2012/17048. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 avril 2012.

Référence de publication: 2012046878/450.
(120063092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.

Jalyne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 158.952.

<i>Rectificatif pour le document déposé sous le numéro L110030709 en date du 21 février 2011

L’an deux mille onze, le douze janvier,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

comparaît

CASIMIR S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.104,

ici représentée par Monsieur Noël DIDIER, employé privé, 50, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 janvier 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts

(ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de JALYNE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social la mise à disposition d’administrateurs ainsi que l’acceptation de mandats d’ad-

ministrateurs  au  profit  de  sociétés  tierces,  la  prise  de  participations  dans  le  capital  de  toute  société,  société  de

50506

L

U X E M B O U R G

participation, de tout consortium ou groupement d’entreprises, et peut faire toutes opérations commerciales, financières,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois cent dix mille euros (EUR 310.000) qui sera

représenté par trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période prenant fin le 31 décembre 2015, à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, libérées en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations
comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

existants un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera adapté.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans

comme administrateurs de catégorie A et administrateurs de catégorie B. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à
tout moment par l’assemblée générale.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cédera à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil d’administration est prépondérante. Les administrateurs
peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par le président ou par deux administrateurs.

50507

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de gestion qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration peut confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un
ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’au moins un

administrateur A et d’au moins un administrateur B.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier vendredi du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

<i>Souscription et paiement

CASIMIR S.A., prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les trente et une (31) actions

représentant la totalité du capital social de la société.

Les actions sont intégralement libérées par un versement en espèces de sorte que la somme de trente et un mille

euros (EUR 31.000 se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

50508

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR

1.500).

<i>Résolutions de l’actionnaire unique

La comparante prénommée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Est appelé aux fonctions d'administrateur de catégorie A:
- Monsieur Jacques BONNIER, administrateur de sociétés, né le 4 mai 1949, à Wervik, Belgique, demeurant à B-6791

Athus, 39, rue des Champs.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Joseph WINANDY, administrateur de sociétés, né le 16 février 1946 à Ettelbrück, demeurant à L-5960

Itzig, 92, rue de l’Horizon;

-  Monsieur  Koen  LOZIE,  administrateur  de  sociétés,  né  le  24  juin  1965  à  Deinze,  Belgique,  demeurant  à  L-8510

Redange-sur-Attert, 61, Grand-Rue.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire de la société:
THE CLOVER, une société anonyme avec siège social à 8, rue Haute, L-4963 Clémency, inscrite au Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.293.

<i>Troisième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes clôturés au 31 décembre 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse du siège social de la société est fixée au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. DIDIER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 janvier 2011. LAC/2011/2343. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2011.

Référence de publication: 2012047247/173.
(120063646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.

Lyma S.C.I., Société Civile.

Siège social: L-4430 Belvaux, 28, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg E 1.989.

EXTRAIT

Il découle d’un acte de cession de parts reçu pardevant le notaire Aloyse BIEL, de résidence à Esch-sur-Alzette, en

date du 16 février 2012, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2012, relation: EAC / 2012/2343, que:

Le capital de la société "LYMA SCI", se trouve actuellement réparti comme suit:

1.- Monsieur Christian FASSBINDER, demeurant à L-4412 Belvaux, 23 rue des Alliés, . . . . . . . . . . . . . . .

75 parts

2.- Madame Mara SCHAMMO, demeurant à L-4412 Belvaux, 23 rue des Alliés, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Ensuite l’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé:
- de transférer le siège social de la société à L-4430 Belvaux, 28 rue Grande-Duchesse Charlotte.
- d’accepter à compter du 16 février 2012 la démission:
de Monsieur Guy BIDAINE, salarié, demeurant à L-4412 Belvaux, 25 rue des Alliés, de sa fonction de gérant de la

prédite société.

50509

L

U X E M B O U R G

- de nommer à compter du 16 février 2012 pour une durée indéterminée:
- dans la fonction de gérant: Monsieur Christian FASSBINDER.
- de préciser que vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
POUR EXTRAIT CONFORME, délivré sur papier libre à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2012.

Référence de publication: 2012034004/25.
(120044446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

LSREF2 Star Gate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 102.625,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 164.578.

In the year two thousand and twelve, on the eighth day of March.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796,

here  represented  by  Mrs  Josiane  MEISSENER,  with  professional  address  in  Luxembourg,  by  virtue  of  a  power  of

attorney, given in Luxembourg on 7 March 2012; and

Star Gate Holding, an exempt company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered

office at Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands,

here  represented  by  Mrs  Josiane  MEISSENER,  with  professional  address  in  Luxembourg,  by  virtue  of  a  power  of

attorney, given in Tokyo on 7 March 2012; and

(the Shareholders),
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of

LSREF2 Star Gate Investments S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164.578, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer dated 4 November 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 3094 of 16
December 2011, and amended for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer dated 6 December 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°177 of 21 January 2012.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 87,625 (eighty-seven thousand

six hundred twenty-five euro) by an amount of EUR 15,000 (fifteen thousand euro) to an amount of EUR 102,625 (one
hundred two thousand six hundred twenty-five euro) via the issuance of 120 (one hundred twenty) new ordinary shares,
having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each;

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company; and
3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Luxembourg, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the
Company.

This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 87,625 (eighty-

seven thousand six hundred twenty-five euro), represented by 700 (seven hundred) ordinary shares and 1 (one) preferred
share, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each,

by an amount of EUR 15,000 (fifteen thousand euro),
to an amount of EUR 102,625 (one hundred two thousand six hundred twenty-five euro), represented by 820 (eight

hundred twenty) ordinary shares and 1 (one) preferred share, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-
five euro) each,

50510

L

U X E M B O U R G

via the issuance of 120 (one hundred twenty) new ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and

twenty-five euro) each,

Star Gate Holding expressly waives its right to subscribe to any of the newly issued shares.
All the 120 (one hundred twenty) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash by

Lone Star Capital Investments S.à r.l. so that the amount of EUR 15,000 (fifteen thousand euro) is at the free disposal of
the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of the share capital increase, Lone Star Capital Investments S.à r.l. holds 820 (eight hundred twenty)

ordinary shares and Star Gate Holding holds 1 (one) preferred share.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of

the Company, which shall be henceforth reworded as follows in its English version:

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 102,625 (one hundred two thousand six hundred

twenty-five euro), represented by 820 (eight hundred twenty) ordinary shares and 1 (one) preferred share, having a
nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each."

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empower and authorise any manager of the Company and any lawyer of Allen &amp; Overy Luxembourg, to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to see
to any formalities in connection therewith.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said person appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil douze, le huit mars.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796,

ici représentée par Mme Josiane MEISSENER, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation donnée à Luxembourg le 7 mars 2012; et

Star Gate Holding, une société établie sous le droit des Iles Cayman, ayant son siege social à Cricket Square, Hutchins

Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands,

ici représentée par Mme Josiane MEISSENER, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation donnée à Tokyo le 7 mars 2012,

(les Associés),
lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-

parantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social

de LSREF2 Star Gate Investments S.à r.l. (la Société), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatri-
culée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.578, constituée selon acte
de Maître Martine Schaeffer en date du 4 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en
date du 16 décembre 2011, sous le N° 3094, modifié en dernier lieu par un acte de Maître Martine Schaeffer passé en
date du 6 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21 janvier 2012, sous
le N°177.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital de la Société de son montant actuel de EUR 87.625 (quatre-vingt-sept mille six cent vingt-

cinq euros) par un montant de EUR 15.000 (quinze mille euros) à un montant de EUR 102.625 (cent deux mille six cent
vingt-cinq euros) par voie d'émission de 120 (cent vingt) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125
(cent vingt-cinq euros);

50511

L

U X E M B O U R G

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société; et
3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou tout avocat ou salarié d’Allen &amp; Overy Luxembourg, afin
d’effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l’enregistrement des parts sociales
nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société.

Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel EUR 87.625 (quatre-vingt-sept

mille six cent vingt-cinq euros), représenté par 700 (sept cents) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préfé-
rentielle, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) pour le porter,

par le biais d'une augmentation de EUR 15.000 (quinze mille euros),
à un montant de EUR 102.625 (cent deux mille six cent vingt-cinq euros), représenté par 820 (huit cent vingt) parts

sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq
euros),

par voie d'émission de 120 (cent vingt) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-

cinq euros) chacune.

Star Gate Holding renonce expressément à son droit de souscrire aux parts sociales nouvellement émises.
Toutes les 120 (cent vingt) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites et libérées

en espèces par Lone Star Capital Investments S.à r.l., de sorte que la somme de EUR 15.000 (quinze mille euros) est à la
libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 820 (huit cent vingt) parts sociales

ordinaires et Star Gate Holding détient 1 (une) part sociale préférentielle.

<i>Deuxième résolution

Suite à la première résolution, les Associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version

française aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR 102.625 (cent deux mille six cent vingt-cinq

euros), représenté par 820 (huit cent vingt) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant chacune
une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros)."

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués

ci-dessus et mandatent et autorisent par la présente tout gérant de la Société et tout avocat de Allen &amp; Overy Luxembourg,
afin d'effectuer pour le compte de la Société l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de
parts sociales de la Société et de prendre en charge toute formalité en relation avec ce point.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 mars 2012. LAC/2012/11663. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012033997/148.
(120044335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

Reflexes Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 101.570.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

50512

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012034062/10.
(120044410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

GS Car Rental Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 22.874.427,02.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 154.883.

L'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique, tenue en date du 27 février 2012, a décidé d'accepter:
- la démission de Fabrice Hablot en qualité de gérant de la Société avec effet au 27 février 2012.
- la nomination avec effet au 27 février 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de

Dominique Le Gal, né à Savigny-Sur-Orge (France), le 9 décembre 1971, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 27 février 2012, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Nicole Götz
<i>Gérant

Référence de publication: 2012037076/23.
(120048226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Kondor Bidco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.046.

In the year two thousand and twelve, on the sixth day of February.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Tahoe Holdco S.à r.l.,a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under registration number B 166373,

duly represented by Mr. Carsten Opitz, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 1 February 2012 in Luxembourg.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Kondor Bidco S.à r.l.,a société à responsabilité

limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under registration number
B 164046, incorporated on 21 September 2011 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, aforementioned, published
with the Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations on 2 December 2011 under number 2962 (the “Company”).

The Sole Shareholder then reviewed the following agenda (the “Agenda”):

<i>Agenda

1. Increase of the Company’s share capital by an amount of two million two hundred thousand United States Dollars

and twenty-four Cents (USD 2,200,000.24), in order to bring it from its current amount of twenty million eighty-seven
thousand three hundred fifty-seven United States Dollars (USD 20,087,357) up to a new amount of twenty-two million
two  hundred  eighty-seven  thousand  three  hundred  fifty-seven  United  States  Dollars  and  twenty-four  Cents  (USD
22,287,357.24) through the issuance of two hundred twenty million and twenty-four (220,000,024) new shares with a par
value of one Cent of a United States Dollar (USD 0.01) each;

50513

L

U X E M B O U R G

2. Subsequent amendment of article 5.1. of the Company’s articles of association; and
3. Miscellaneous.
Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, representing the entire share

capital of the Company, requested the notary to act the following resolution:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of two million two hundred

thousand United States Dollars and twenty-four Cents (USD 2,200,000.24),

in order to bring it from its current amount of twenty million eighty-seven thousand three hundred fifty-seven United

States Dollars (USD 20,087,357) up to a new amount of twenty-two million two hundred eighty-seven thousand three
hundred fifty-seven United States Dollars and twenty-four Cents (USD 22,287,357.24)

through the issuance of two hundred twenty million and twenty-four (220,000,024) new shares with a par value of

one Cent of a United States Dollar (USD 0.01) each.

<i>Subscription and Payment

All of the two hundred twenty million and twenty-four (220,000,024) new shares with a par value of one Cent of a

United States Dollar (USD 0.01) each have been subscribed for by the Sole Shareholder and have been fully paid up in
cash, so that the total amount of two million two hundred thousand United States Dollars and twenty-four Cents (USD
2,200,000.24) is as of now at the disposal of the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Company’s

articles of association in order to read as follows:

“ 5.1. The Company’s share capital is set at twenty-two million two hundred eighty-seven thousand three hundred

fifty-seven  United  States  Dollars  and  twenty-four  Cents  (USD  22,287,357.24)  consisting  of  two  billion  two  hundred
twenty-eight million seven hundred thirty-five thousand seven hundred twentyfour (2,228,735,724) shares having a par
value of one US Cent (USD 0.01) each.”

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person,  the  present  deed  is  worded  in  English,  followed  by  a  German  translation.  On  express  request  of  the  same
appearing person, and in case any divergences would arise between the German and the English text, the English text will
prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said

person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundzwölf, den sechsten Februar.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, Notarin mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxem-

burg.

Ist erschienen:

Tahoe Holdco S.à r.l., eine gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende société

en commandite par actions mit eingetragenem Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273, Großherzogtum Luxembourg, einge-
tragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 166373;

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Carsten Opitz, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, kraft einer am 1. Februar 2012 in Luxemburg erteilten Vollmacht.

Nach Unterzeichnung der Vollmacht ne varietur durch den Bevollmächtigten und die unterzeichnete Notarin soll diese

dieser Urkunde beigefügt bleiben, um mit derselben registriert zu werden.

Die erschienene Partei ist die alleinige Gesellschafterin (die „Alleingesellschafterin“) der Kondor Bidco S.à r.l., einer

gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründeten und bestehenden société à responsabilité limitée mit
eingetragenem Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273, Großherzogtum Luxembourg, eingetragen im luxemburgischen Han-
delsregister unter der Nummer B 164046, gegründet am 21. September 2011 entsprechend der Urkunde der Notarin
Martine Schaeffer, vorgenannt, veröffentlicht im Mémorial C Réceuil des Sociétés et Associations am 2. Dezember 2011
unter der Nummer 2962 (die „Gesellschaft“).

Die Alleingesellschafterin erwog sodann die folgende Tagesordnung (die „Tagesordnung“):

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von zweimillionenzweihunderttausend ame-

rikanischen Dollar und vierundzwanzig Cent (USD 2.200.000,24), um dieses von seinem aktuellen Betrag in Höhe von

50514

L

U X E M B O U R G

zwanzigmillionensiebenundachtzigtausenddreihundertsiebenundfünfzig amerikanischen Dollar (USD 20.087.357) auf ei-
nen neuen Betrag von zweiundzwanzigmillionenzweihundertsiebenundachtzigtausenddreihundertsiebenundfünfzig ame-
rikanischen Dollar und vierundzwanzig Cent (USD 22.287.357,24) zu bringen, durch die Ausgabe zweihundertzwanzig-
millionenvierundzwanzig (220.000.024) neuer Anteile der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je einem Cent eines
amerikanischen Dollars (USD 0,01);

2. Anschließende Neuformulierung des Artikels 5.1. der Satzung der Gesellschaft; und
3. Verschiedenes. Nach Erwägung der verschiedenen Tagesordnungspunkte ersuchte die Alleingesellschafterin, die das

gesamte Gesellschaftskapital vertritt, die Notarin Folgendes zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt das Stammkapital der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von zweimillionen-

zweihunderttausend amerikanischen Dollar und vierundzwanzig Cent (USD 2.200.000,24) zu erhöhen,

um dieses von seinem aktuellen Betrag in Höhe von zwanzigmillionensiebenundachtzigtausenddreihundertsiebenund-

fünfzig amerikanischen Dollar (USD 20.087.357) auf einen neuen Betrag von zweiundzwanzigmillionenzweihundertsiebe-
nundachtzigtausenddreihundertsieben undfünfzig amerikanischen Dollar und vierundzwanzig Cent (USD 22.287.357,24)
zu bringen,

durch die Ausgabe von zweihundertzwanzigmillionenvierundzwanzig (220.000.024) neuer Anteile der Gesellschaft mit

einem Nominalwert von je einem Cent eines amerikanischen Dollars (USD 0,01).

<i>Zeichnung und Einzahlung

Sämtliche zweihundertzwanzigmillionenvierundzwanzig (220.000.024) neu ausgegebenen Gesellschaftsanteile wurden

durch die Alleingesellschafterin gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesamtbetrag von zweimillio-
nenzweihunderttausend amerikanischen Dollar und vierundzwanzig Cent (USD 2.200.000,24) nunmehr der Gesellschaft
zur Verfügung steht, wie es der Notarin nachgewiesen wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt Artikel 5.1. der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

„ 5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zweiundzwanzigmillionenzweihundertsiebenundachtzigtausenddrei-

hundertsieben undfünfzig amerikanische Dollar und vierundzwanzig Cent (USD 22.287.357,24) bestehend aus zweimilli-
ardenzweihundertachtunzwanzigmillionensiebenhundertfünfunddreissigtausendsiebenhundertvierundzwanzig
(2.228.735.724) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von je einem Cent eines amerikanischen Dollars (USD 0,01)
pro Geschäftsanteil.“

Die  unterzeichnete  Notarin,  die  Englisch  versteht  und  spricht,  erklärt  hiermit,  dass  die  Urkunde  auf  Anfrage  der

erschienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben er-
schienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische
Fassung vorrangig sein.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Do-

kuments genannten Tag aufgenommen.

Nach Verlesung der Urkunde an die erschienene Partei, der Notarin mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt,

hat der Bevollmächtigte diese Originalurkunde zusammen mit der Notarin unterzeichnet.

Signé: C. Opitz et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 février 2012. LAC/2012/6446. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2012.

Référence de publication: 2012033974/126.
(120044488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

Dekra Claims Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 31.782.

<i>Extrait des décisions prises par l’actionnaire unique en date du 27 février 2012

L’an deux mille douze, le vingt-sept février, l’actionnaire unique de la société DEKRA CLAIMS SERVICES LUXEM-

BOURG S.A., a pris les résolutions suivantes:

1) La démission de l’administrateur Monsieur Carel KUIPER, est acceptée avec effet immédiat.

50515

L

U X E M B O U R G

2) L’actionnaire unique nomme Monsieur Pieter RENSES, né le 20.01.1970 à Heerhugowaard (Pays-Bas) et demeurant

à Middenweg 196, 1701 GG Heerhugowaard, au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Kuiper.

Le mandat de l’administrateur ainsi nommé viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en

2017.

Suite à cette résolution et conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts de la société, l’actionnaire unique

confère désormais au conseil d’administration le pouvoir de signature suivant:

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux administrateurs

dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 27.02.2012.

Référence de publication: 2012036111/21.
(120047875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

LSREF2 A. F. Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 164.561.

In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of March.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg,

THERE APPEARED

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796 (the Sole Share-
holder),

here represented by Ms Emilie Variot, employee, with professional address at 33 avenue John F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 12 March 2012,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF2

A. F. Investments S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 164.561,

incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 4 November 2011, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, n° 3129 of 20 December 2011, amended for the last time pursuant to a deed dated
20 February 2012 of Maître Roger Arrensdorff, acting in replacement of Maître Martine Schaeffer, not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that

it may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Decision to decrease the share capital of the Company from its current amount of EUR 13,500 (thirteen thousand

five-hundred euro) by an amount of EUR 1,000 (one thousand euro) to an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five
hundred euro) via the cancellation of 8 (eight) shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro)
each;

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company; and
3. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Luxembourg, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company to the registration of the cancelled shares in the share register of the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company from its current amount of EUR 13,500

(thirteen thousand five hundred euro), represented by 108 (one hundred eight) shares, having a nominal value of EUR
125 (one hundred twenty-five euro) each,

by an amount of EUR 1,000 (one thousand euro),
to an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 100 (one hundred) shares, having

a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each,

50516

L

U X E M B O U R G

via the cancellation of 8 (eight) shares, having a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, and

by reimbursement to the Sole Shareholder of the said amount of EUR 1,000 (one thousand euro).

As a consequence of the share capital decrease, the Sole Shareholder holds 100 (one hundred) shares of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association

of the Company, which shall be henceforth reworded as follows in its English version:

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), repre-

sented by 100 (one hundred) shares, having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empowers and authorises any manager of the Company and any lawyer of Allen &amp; Overy Luxembourg, to proceed
on behalf of the Company to the registration of the cancelled shares in the share register of the Company and to see to
any formalities in connection therewith.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil douze, le douze mars.
Par-devant Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg,

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796 (l'Associé
Unique),

ici représentée par Mme Emilie Variot, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Luxembourg le 12 mars 2012,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social

de LSREF2 A. F. Investments S.à r.l. (la Société), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.561, constituée selon acte de
Maître Martine Schaeffer en date du 4 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous
le n° 3129 en date du 20 décembre 2011, modifié pour la dernière fois en date du 20 février 2012 selon acte de Maître
Roger Arrensdorff, intervenant en remplacement de Maître Martine Schaeffer, pas encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Réduction du capital de la société de son montant actuel de EUR 13.500 (treize mille cinq cents euros) par un

montant de EUR 1,000 (mille euros) à un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) par voie d'annulation
de 8 (huit) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune;

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société; et
3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou tout avocat ou salarié d’Allen &amp; Overy Luxembourg, afin
d’effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l’enregistrement des parts sociales
annulées dans le registre de parts sociales de la Société.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 13.500 (treize mille

cinq cents euros), représenté par 108 (cents huit) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent
vingt-cinq euros),

50517

L

U X E M B O U R G

par le biais d'une réduction de EUR 1.000 (mille euros)
pour le ramener à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales,

ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros),

par voie d'annulation de 8 (huit) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune,

et par le remboursement de ce montant de EUR 1.000 (mille euros) à l'Associé Unique.

Suite à cette réduction de capital, l'Associé Unique détient 100 (cent) parts sociales de la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version

française aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros),

représenté par 100 (cent) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros)."

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués

ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et tout avocat de Allen &amp; Overy Luxembourg,
afin d'effectuer pour le compte de la Société l’enregistrement des parts sociales annulées dans le registre de parts sociales
de la Société et de prendre en charge toute formalité en relation avec ce point.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: E. Variot et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mars 2012. LAC/2012/12136. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012033994/125.
(120044489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

Lux-Pipe Tech S.A., Société Anonyme,

(anc. Lux Business Risk Monitoring S.A.).

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 151.537.

L'an deux mille douze, le onze janvier.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LUX BUSINESS RISK MONITORING S.A. en

abrégé LUX B.R.M. S.A., établie et ayant son siège à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, Rue du Fossé, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B151.537, constituée suivant acte du notaire Francis KESSELER d'Esch-sur-
Alzette en date du 11 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 710 du 3 avril
2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Messaoud GHODBANE, tuyauteur, demeurant à Thionville (France),
qui désigne comme secrétaire Christelle DEMICHELET, employée privée, demeurant à Hayange (France).
L'assemblée choisit comme scrutateur Benaouda CHAOUCHE, employé privé, demeurant à Thionville (France).
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la dénomination et modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts.

2. Modification de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts.
3. Révocation d'un administrateur et de l'administrateur-délégué.
4. Nomination d'un nouvel administrateur et administrateur-délégué.

50518

L

U X E M B O U R G

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société et par conséquent de modifier l'article 1 

er

 des statuts

comme suit:

 Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de Lux-Pipe Tech S.A."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent l'article 4 des statuts comme suit:

Art. 4. La société a pour objet la réalisation, la fabrication, la pose et l'assemblage de tuyauteries (conduites de gaz,

pétrochimie et transports de fluides en tout genre); la soudure de toute catégorie; la maintenance et les travaux sur
toutes conduites.

Elle aura également pour objet la pose de tuyauteries de chauffage, la géothermie et la pose de panneaux solaires;

l'étude et la réalisation de concepts et matériels d'exploitation d'énergies renouvelables.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement."

<i>Troisième résolution

L'assemblée révoque un administrateur et un des administrateurs-délégués, à savoir:
- Mohammed MANSOURI, demeurant à Terville (France).

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer administrateur et administrateur-délégué, Messaoud

GHODBANE, demeurant à F-57100 Thionville (France), 10, rue Strozzi.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2016.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clement.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: GHODBANE, DEMICHELET, CHAOUCHE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 janvier 2012. Relation: LAC/2012/2184. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 16 mars 2012.

Référence de publication: 2012033998/65.
(120044481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

Samarvest Inc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 163.919.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration en date du 19 Mars 2012

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg

avec effet immédiat.

50519

L

U X E M B O U R G

Le Conseil d'Administration, après avoir pris acte de la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Jean-Marie SCHUL

de son poste d'administrateur de la société, décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Stéphane Weyders né le
2 janvier 1972 à Arlon (Belgique), résidant au 278 route de Bouillon, B-6700 Stockem/Arlon, au poste d'administrateur
de la société pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012035860/15.
(120047710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.

Germalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 100.637.

Date de clôture des comptes annuels 31/12/2009 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DERENBACH, le 26/03/2012.

FRL SA
Signature

Référence de publication: 2012036189/13.
(120048223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Leopard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 154.699.

L'an deux mille douze, le six mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “LEOPARD S.A.”, ayant son

siège social à L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 154.699, constituée originairement suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
26 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1962 du 22 septembre 2010,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 avril 2011, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1458 du 4 juillet 2011

ayant un capital de trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR), représenté par trois cent quinze (315) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé,

demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de catégories d’actions et modification afférente de l’article 5 des statuts.
2.- Suppression des catégories d’administrateurs et modification afférente de l’article 12 des statuts.
3.- Nominations statutaires.
4.- Changement du pouvoir de signature statutaire et modification afférente de l’article 16 des statuts.
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

50520

L

U X E M B O U R G

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de supprimer les catégories d’actions et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts afin de

lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR), représenté

par trois cent quinze (315) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la Société sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire.
La Société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à racheter ses propres actions.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer les catégories d’administrateurs et de modifier en conséquence l’article 12 des statuts

afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 12. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé d’au moins trois (3) membres qui n'ont

pas besoin d'être actionnaires de la Société.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée accepte, par vote spécial, la démission de l’administrateur Monsieur Marcel LEYERS.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée confirme aux fonctions d’administrateurs de la société:
- Monsieur Flavio BECCA, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 18 juin 1962, demeurant à L-3369 Leude-

lange, 1, rue des Prés; administrateur et Président du Conseil

- Monsieur André WILWERT, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 24 février 1951, demeurant à L-2210

Luxembourg, 59, Boulevard Napoléon

- Monsieur Lucien LUX, député, demeurant à L-3899 Foetz, 3, rue du Soleil.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’exercice 2017.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire donne mandat au Conseil d’administration, de procéder à toutes les formalités

nécessaires en relation avec les résolutions ci-dessus adoptées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à huit cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mars 2012. Relation GRE/2012/910. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Junglinster, le 22 mars 2012.

Référence de publication: 2012033991/77.
(120044533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

SGLD, Société Générale Luxembourgeoise d'ingénierie et de développement, Société à responsabilité

limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 145.304.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

50521

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012034074/11.
(120044409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

Security Capital European Realty, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 61.389.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg le 10 février 2012

L'Assemblée a décidé à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:
- L'Assemblée a décidé de clôturer la liquidation et a constaté que la Société a définitivement cessé d'exister;
- L'Assemblée a décidé de procéder à une distribution finale de USD 2,6347 par action;
- L'Assemblée a décidé que les sommes n’ayant pas pu être versées aux actionnaires seront déposés à la Caisse de

Consignation de Luxembourg;

- L'Assemblée a décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq

ans auprès de la société SGG S.A. une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F, route d’Esch,
L-1030 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 65.906 (ou
auprès d’un autre bureau que SGG S.A. peut occuper ponctuellement ou louer pour l’archivage).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2012.

Référence de publication: 2012036417/20.
(120048909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Serafin S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 112.791.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012034086/10.
(120044408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

Signes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 79.475.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012034092/10.
(120044399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

The PNC Financial Services Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 152.923.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012034104/10.
(120044413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

50522

L

U X E M B O U R G

TAITAVA Fund SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 127.048.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012034107/11.
(120044419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

Geser Holding International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 140.571.

Il résulte d’une décision du gérant prise en date du 21 mars 2012 que la convention de domiciliation conclue entre SG

AUDIT Sàrl, 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C.S. Luxembourg B 75 908 et la société GESER
HOLDING INTERNATIONAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 140 571 a été dénoncée avec effet immédiat.

Le siège social de la société GESER HOLDING INTERNATIONAL S.A. fixé jusqu’alors au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg, est par conséquent également dénoncé.

Pour extrait conforme
SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2012036190/13.
(120047957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Treveria Twenty-Five S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 124.918.

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique

En date du 18 mars 2012, l'associé unique de la Société a accepté la résignation de Monsieur Abdelhakim Chagaar, de

Monsieur Nedim Gôrel et de Madame Marjoleine van Oort en tant que gérants de la Société, et ce avec effet immédiat.

En cette même date, l'associé unique a nommé les personnes suivantes en tant que gérants avec effet immédiat et pour

une durée indéterminée:

- Monsieur Olivier Liégeois, comptable, né le 27 octobre 1976 à Bastogne, Belgique, demeurant professionnellement

au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

- Monsieur Luc Gerondal, fiscaliste, né le 23 avril 1976 à Kinshasa, République démocratique du Congo, demeurant au

19 avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

- Madame Sandrine BISARO, juriste, née le 28 juin 1969 à Metz, France, demeurant professionnellement au 12 rue

Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

En cette même date, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société, de l'ancienne adresse 73, Côte

d'Eich, L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg et ce avec effet im-
médiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2012.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012036445/26.
(120048445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

50523

L

U X E M B O U R G

Robec SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 148.610.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale de l’actionnaire unique tenue en date du 22 août 2011.

Lors de ladite assemblée, l’Assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée a ratifié la nomination de Monsieur Filip DE WILDE demeurant professionnellement au 63-65 Rue de

Merl, L-2146 Luxembourg, coopté en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, lors de la réunion du Conseil
d'Administration du 16 juillet 2010, en remplacement de Monsieur Philippe JANSSENS démissionnaire.

2. L’assemblée a accepté la démission de Monsieur Filip DE WILDE demeurant professionnellement au 63-65 Rue de

Merl, L-2146 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué avec effet immédiat.

3. L’assemblée a approuvé la nomination de Monsieur Philippe JANSSENS demeurant professionnellement 25 route

d’Esch, L-1470 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué avec effet immédiat jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2015.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012036403/18.
(120047866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Lobster Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.812.600,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 116.680.

In the year two thousand and twelve, on the fifteenth of March,
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the

"Notary")

There appeared:

1. HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 967482, a private limited liability company incorporated

under the laws of Great-Britain, having its registered office at 8, Canada Square, GB-EH 14 5HQ London, ("HSBC Account
967482") currently holding sixty-seven thousand nine hundred and forty-seven (67,947) shares of the Company; and

2. HSBC Global Custody Nominee (UK) limited, A/C 697892, formerly named HSBC Global Custody Nominee (UK)

Limited Account 914969, a private limited liability company incorporated under the laws of Great-Britain, having its
registered office at 8, Canada Square, GB-EH 14 5HQ London, ("HSBC A/C 697892") currently holding four thousand
five hundred and fifty-five (4,555) shares of the Company.

HSBC Account 967482 and HSBC A/C 697892 are altogether hereafter referred to as the "Appearing Shareholders"

and hold together all of the issued shares of the Company representing all the Company's share capital. Each of the
Appearing Shareholders was represented by Ms Sara Lecomte, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg, as
its proxy (the "Proxy") by virtue of two proxies given under private seal on 8 March 2012.

Each proxy form was signed “ne varietur” by each of the Appearing Shareholders and the Notary.
I. The"Company" is "Lobster Holding S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12F rue Guillaume Kroll – L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 116.680, incor-
porated pursuant to a deed of the Notary dated 7 April 2006, whose articles of incorporation (the "Articles") have been
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 26 July 2006 (number 1436, page 68920) (the
"Company"). The Articles have been amended for the last time pursuant to a deed drawn up by the Notary dated 22
December 2011 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 17 February 2012 (number 432,
page 20722).

II. The agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1. Increase of the Company's share capital by an amount of fifty Euro (EUR 50.-) so as to bring it from its current

amount of one million eight hundred twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 1,812,550.-), to one million eight
hundred twelve thousand six hundred Euro (EUR 1,812,600.-) by creating and issuin two (2) new shares with nominal
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and having the same features as the existing shares (the "New Shares") together
with a share premium amounting to one hundred thirty-five million four hundred and twenty-seven thousand one hundred
and three Euro fifty-eight cents (EUR 135,427,103.58) (the "Share Premium"). Subscription and payment for the New
Shares together with the Share Premium

50524

L

U X E M B O U R G

2. Amendment of article 5 of the Articles of the Company in order to reflect the capital increase.
3. Miscellaneous.
III. After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>Resolutions

<i>First Resolution

The Appearing Shareholders resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of fifty Euro

(EUR 50.-) so as to bring it from its current amount of one million eight hundred twelve thousand five hundred and fifty
Euro (EUR 1,812,550.-) to one million eight hundred twelve thousand six hundred Euro (EUR 1,812,600.-) by creating
and issuing two (2) new shares having the same features as the existing shares, with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each, together with a Share Premium amounting to one hundred thirty-five million four hundred and twenty-
seven thousand one hundred and three Euro fifty-eight cents (EUR 135,427,103.58).

<i>Subscription and Payment

The Appearing Shareholders declared to subscribe for and fully pay in the New Shares together with the Share Premium

as follows:

a) HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 967482, prenamed, declared to subscribe to one (1) New

Share with a Share Premium amounting to one hundred twenty-six million nine hundred and twenty thousand two hundred
and forty-seven Euro and thirty-one cents (EUR 126,920,247.31) for a total issue price of one hundred twenty-six million
nine hundred and twenty thousand two hundred and seventy-two Euro and thirty-one cents (EUR 126,920,272.31) paid
by it by a contribution in kind consisting of claims for an aggregate amount of one hundred twenty-six million nine hundred
and twenty thousand two hundred and seventy-two Euro and thirty-one cents (EUR 126,920,272.31) (the "Contribution
1");

b) HSBC Global Custody Nominee (UK) limited, A/C 697892, prenamed, declared to subscribe to one (1) New Share

with a Share Premium amounting to eight million five hundred and six thousand eight hundred fifty-six Euro and twenty-
seven cents (EUR 8,506,856.27) for a total issue price of eight million five hundred and six thousand eight hundred eighty-
one Euro and twenty-seven cents (EUR 8,506,881.27) paid by it by a contribution in kind consisting of claims for an
aggregate amount of eight million five hundred and six thousand eight hundred eighty-one Euro and twenty-seven cents
(EUR 8,506,881.27) (the "Contribution 2" together with the Contribution 1 the "Contribution").

The amount of fifty Euro (EUR 50.-) is allocated to the share capital of the Company and the amount of one hundred

thirty-five  million  four  hundred  and  twenty-seven  thousand  one  hundred  and  three  Euro  fifty-eight  cents  (EUR
135,427,103.58) is allocated to the share premium account of the Company.

As it appears from the valuation report presented to the Notary, the management of the Company has valued the

above-mentioned aggregate Contribution in kind at one hundred thirty-five million four hundred and twenty-seven thou-
sand one hundred fifty-three Euro fifty-eight cents (EUR 135,427,153.58) which in the reasonable belief of the management
of the Company (i) constitutes a fair and reasonable valuation of the Contribution and (ii) is at least equal to the New
Shares issued in exchange, together with the Share Premium.

<i>Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, the Appearing Shareholders resolved to amend article 5 of the

Articles of the Company to reflect the above resolution so that it now reads as follows:

Art. 5. The issued capital of the Company is set at one million eight hundred twelve thousand six hundred Euro (EUR

1,812,600.-) divided into seventy-two thousand five hundred and four (72,504) shares with a nominal value of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

[....]"
IV. Costs and notarial deed
1. The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

2. The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a

French version, and that at the request of the Appearing Shareholders, in case of divergence between the English and the
French texts, the English version will prevail.

3. This notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
V. This document having been read to the Appearing Shareholders' proxyholder, who is known to the Notary by his

name, first name, civil status and residence, the Appearing Shareholders' proxyholder and the Notary, have together
signed this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le quinze mars,
Devant nous, Maitre Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg (le "Notaire").

50525

L

U X E M B O U R G

ONT COMPARU:

1. HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 967482, une société à responsabilité limitée constituée selon

les lois de Grande-Bretagne, ayant son siège social situé au 8, Canada Square, GB-EH 14 5HQ Londres ("HSBC Account
967782") détenant actuellement soixante-sept mille neuf cent quarante-sept (67.947) parts sociales de la Société; et

2. HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited, A/C 697892, anciennement dénommée HSBC Global Custody No-

minee (UK) Limited Account 914969, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Grande-Bretagne,
ayant son siège social situé au 8, Canada Square, GB-EH 14 5HQ Londres ("HSBC A/C 697892") détenant actuellement
quatre mille cinq cent cinquante-cinq (4.555) parts sociales de la Société.

HSBC Account 967482 et HSBC A/C 697892 sont collectivement dénommés les "Associés Comparants" et détiennent

ensemble toutes les parts sociales émises de la Société représentant l'intégralité du capital social de la Société.

Chacun des Associés Comparants a été représenté par Mlle Sara Lecomte, clerc de notaire, résidant professionnel-

lement à Luxembourg, en tant que mandataire (la "Mandataire") en vertu de deux procurations données sous seing privé
le 8 Mars 2012.

Chaque procuration a été signée "ne varietur" par chacun des Associés Comparants et le Notaire.
I. La "Société" est "Lobster Holding S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social situé 12F rue Guillaume Kroll – L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.680, constituée en vertu d'un acte du
Notaire en date du 7 avril 2006, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations le 26 Juillet 2006 (numéro 1436 page 68920) (la "Société"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois
en vertu d'un acte rédigé par le Notaire le 22 décembre 2011 publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
le 17 février 2012 (numéro 432, page 20722).

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante Euro (EUR 50,-) pour le porter de son montant

actuel d'un million huit cent douze mille cinq cent cinquante Euro (EUR 1.812.550,-) à un million huit cent douze mille
six cents Euro (EUR 1.812.600,-) en créant et en émettant deux (2) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale
de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune et les mêmes caractéristiques que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts
Sociales") avec une prime d'émission d'un montant de cent trente-cinq millions quatre cent vingt-sept mille cent trois
Euro et cinquante-huit centimes (EUR 135,427,103.58) (la "Prime d'Emission").

Souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales avec la Prime d'Emission
2. Modification de l'article 5 des Statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.
3. Divers.
III. Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Résolutions

<i>Première résolution

Les Associés Comparants ont décidé d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de cinquante

Euro (EUR 50,-) pour le porter de son montant actuel d'un million huit cent douze mille cinq cent cinquante Euro (EUR
1.812.550,-) à un million huit cent douze mille six cents Euro (EUR 1.812.600,-) en créant et en émettant deux (2) nouvelles
parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune et les mêmes caractéristiques que les
parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales") avec une prime d'émission d'un montant de cent trente-cinq
millions quatre cent vingt-sept mille cent trois Euro et cinquante-huit centimes (EUR 135.427.103,58) (la "Prime d'Emis-
sion").

<i>Souscription et Paiement

Les Associés Comparants déclarent souscrire et entièrement libérer les Nouvelles Parts Sociales avec la Prime d'Emis-

sion comme suit:

1. HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 967482, susmentionné, déclare souscrire à une (1) Nouvelle

Part Sociale avec une Prime d'Emission d'un montant de cent vingt-six millions neuf cent vingt mille deux cent quarante-
sept Euro et trente et un centimes (EUR 126.920.247,31) pour un prix total d'émission de cent vingt-six millions neuf
cent vingt mille deux cent soixante-douze Euro et trente et un centimes (EUR 126.920.272,31) payé par un apport en
nature consistant en des créances d'un montant total de cent vingt-six millions neuf cent vingt mille deux cent soixante-
douze Euro et trente et un centimes (EUR 126.920.272,31) (l'"Apport 1");

2. HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited A/C 697892, susmentionné, déclare souscrire à une (1) Nouvelle

Part Sociale avec une Prime d'Emission d'un montant de huit millions cinq cent six mille huit cent cinquante-six Euro et
vingt-sept centimes (EUR 8.506.856,27) pour un prix total d'émission de huit millions cinq cent six mille huit cent quatre-
vingt-un Euro et vingt-sept centimes (EUR 8,506,881.27) payé par un apport en nature consistant en des créances d'un
montant total de huit millions cinq cent six mille huit cent quatre-vingt-un Euro et vingt-sept centimes (EUR 8,506,881.27)
(l'"Apport 2" ensemble avec l'Apport 1 l'"Apport").

50526

L

U X E M B O U R G

Le montant de cinquante euros (EUR 50,-) est alloué au capital social de la Société et le montant de cent trente-cinq

millions quatre cent vingt-sept mille cent trois Euro et cinquante-huit centimes (EUR 135.427.103,58) est attribué au
compte de prime d'émission de la Société.

Comme il en ressort du rapport d'évaluation présenté au Notaire, la gérance de la Société a évalué l'Apport en nature

susmentionné à cent trente-cinq millions quatre cent vingt-sept mille cent cinquante-trois Euro et cinquante-huit centimes
(EUR 135.427.153,58), qui selon la croyance raisonnable de la gérance de la Société (i) constitue une évaluation juste et
raisonnable de l'Apport et (ii) est au moins égal aux Nouvelle Parts Sociales émises en échange ainsi qu'à la Prime d'Emis-
sion.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, les Associés Comparants ont décidé de modifier l'article 5 des Statuts

de la Société, afin de refléter la résolution ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le Capital souscrit de la Société est fixé à un million huit cent douze mille six cents Euro (EUR 1.812.600,-),

divisé en soixante-douze mille

cinq cent quatre (72.504) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune toutes

intégralement libérées.

[…]"
IV. Frais et acte notarié
1. Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement EUR 7.000,-(sept mille Euro).

2. Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version

française, et qu'à la demande des Associés Comparants, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fera foi.

3. Cet acte notarié a été préparé à Luxembourg, le jour mentionné au début de ce document.
V. Ce document ayant été lu au mandataire des Associés Comparants, qui est connu par le Notaire par son nom de

famille, prénom, état civil et résidence, le mandataire des Associés Comparants et le Notaire ont ensemble signé cet acte.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 mars 2012. Relation: LAC/2012/12280. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012033983/183.
(120044295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

Polish Omega Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 167.566.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the fourteenth day of March;
Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI, L.P., with its registered office in South Church Street, Ugland House, KY –

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting as General Partner of POLISH ENTERPRISE FUND VI, L.P.,

here represented by Mr Luc HANSEN, “licencié en administration des affaires”, with professional address at 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated 12 March 2012.
Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, has drawn up the following articles of a limited liability company

to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is Polish Omega Group S.à r.l..

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

50527

L

U X E M B O U R G

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided

into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may

only be done in accordance with the law on commercial companies.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by at least two managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one

B signatory manager or by the individual signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In its
current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature
legally commits the company.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on

commercial companies.

Art. 15. The business year begins on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each year.

Art. 16. Every year on December 31 

st

 , the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant

legislation.

50528

L

U X E M B O U R G

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31 

st

 , 2012.

<i>Subscription and Payment

The 500 (five hundred) corporate units have been subscribed to by the sole member, POLISH ENTERPRISE FUND

VI, L.P. acting through its General Partner POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI, L.P., predesignated.

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR

12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

nine hundred Euros.

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as mentioned above, representing the whole of the corporate capital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

Are appointed managers of the company, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:

<i>A signatory manager:

1. Mr. Tadeusz GALKOWSKI, chief financial officer, born on 23 May 1960 in Northampton (United Kingdom), residing

in Financial Center, Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw (Poland);

<i>B signatory managers:

2. Mr. Philippe PONSARD, “ingénieur commercial”, born on 16 March 1967 in Arlon (Belgium), with professional

address at 2, avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg,

3. Mr. Luc HANSEN, “licencié en administration des affaires”, born on 8 June 1969 in Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg), with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them. The managers are elected for an

undetermined period.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the appearing party, known

to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, Notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille douze le quatorze mars;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

A comparu:

POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI, L.P., ayant son siège social à South Church Street, Ugland House, KY – George

Town, Grand Cayman, Iles Cayman, agissant en tant que General Partner de POLISH ENTERPRISE FUND VI, L.P.,

ici représenté par Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 12 mars 2012.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée à constituer.

50529

L

U X E M B O U R G

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de Polish Omega Group S.à r.l..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que

dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par au moins deux gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour
représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

50530

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Paiement

Les 500 (cinq cents) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, POLISH ENTERPRISE FUND

VI, L.P. agissant par l’intermédiaire de son General Partner POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI, L.P., prédésignée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR

12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été
donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ neuf cents euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

L’associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants de la société avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts:

<i>Gérant de catégorie A:

1. Monsieur Tadeusz GALKOWSKI, “chief financial officer”, né le 23 mai 1960 à Northampton (Royaume-Uni), de-

meurant au Financial Center, Emilii Plater 53, 00-113 Varsovie (Pologne),

<i>Gérants de catégorie B:

2. Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, né le 16 mars 1967 à Arlon (Belgique), demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

3. Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: L. HANSEN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mars 2012. LAC/2012/12112. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Luxembourg, le 16 mars 2012.

Référence de publication: 2012034046/220.
(120044558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

50531

L

U X E M B O U R G

UBP, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 146.516.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012034123/10.
(120044415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

UMP, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 146.515.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012034124/10.
(120044416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

SGEA Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.233.

En date du 8 mars 2012, le Conseil d'administration a pris la décision suivante:
- Transfert du siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, avec effet au 8 mars 2012.

En date du 8 mars 2012, le Conseil d'administration a pris note que l'adresse professionnelle des administrateurs

suivants est désormais au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et ce avec effet au 2 janvier 2012:

- Jorge Pérez Lozano
- Xenia Kotoula
- Israel Domingo Basilio
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2012.

<i>Pour la Société
Israel Domingo Basilio
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012036425/20.
(120048075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Morgan Stanley Euro Financing (Luxembourg), Société en nom collectif.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 166.424.

In the year two thousand and twelve, on the second day of March.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. Morgan Stanley Equity Holdings (Ireland), a company established under the laws of Ireland having its registered office

at the Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, registered with the Companies Registration Office
in Ireland under number 416490, here represented by Nuala Doyle, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 1 

st

 March 2012, and

2. Morgan Stanley Grund S.àr.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 1 allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
123.444, here represented by Nuala Doyle, lawyer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on 1 

st

 March 2012.

50532

L

U X E M B O U R G

The aforementioned proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the

undersigned notary shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated above, requested the undersigned notary to record the following:
A) The prenamed entities hold the entire share capital of Morgan Stanley Euro Financing (Luxembourg), an unlimited

company  having  a  share  capital  established  under  the  laws  of  Ireland,  subject  by  analogy  to  the  legal  and  regulatory
provisions applicable to the Luxembourg société en nom collectif, if, and to the extent, applicable, having its place of
management and control (siège de l’administration centrale) at 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 166.424
(the "Company"). The principal place of business and place of management and control of the Company (siège de l’ad-
ministration centrale) has been transferred from Ireland to the Grand Duchy of Luxembourg on 29 December 2011 by
deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

B) The agenda of the present meeting is the following:
- Amendment of article 44 of Section B of the articles of incorporation (les statuts) of the Company to read as follows:

44. The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the Company

in a general meeting. The number of directors shall not be less than two and unless and until otherwise determined by
the Company in a general meeting not more than ten."

After this had been set forth, the appearing parties, represented as above stated, representing the entire share capital

of the Company, now request the undersigned notary to record the following resolution:

<i>Sole resolution

The shareholders resolved to amend article 44 of Section B of the articles of incorporation (les statuts) such that it

shall now read as follows:

44. The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the Company

in a general meeting. The number of directors shall not be less than two and unless and until otherwise determined by
the Company in a general meeting not more than ten."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated approximately at one thousand Euros (EUR 1,000. -).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the appearing parties and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by surname, Christian

name, civil status and residence, said proxyholder, signed together with the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille douze, le deuxième jour de mars.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Morgan Stanley Equity Holdings (Ireland), une société constituée sous les lois d’Irlande ayant son siège sociale à

l’Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande, enregistrée à l’Office de’Immatriculation des Sociétés
en Irlande sous le numéro 416490,

ici représentée par Nuala Doyle, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée en date du 1

er

 mars 2012, et

2. Morgan Stanley Grund S.àr.l., une société à responsabilité limitée Luxembourgeoise, ayant son siège sociale à 1 allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 123.444, ici représentée par Nuala Doyle, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée en
date du 1 

er

 mars 2012.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter

ce qui suit:

A) Les parties comparantes préqualifiées détiennent la totalité du capital de Morgan Stanley Euro Financing (Luxem-

bourg), une société à responsabilité illimitée ayant un capital social (unlimited company having a share capital) constituée
en vertu des lois de l'Irlande soumise par analogie, aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés en

50533

L

U X E M B O U R G

nom collectif luxembourgeoises, si et dans la mesure applicable avec siège de l’administration centrale au 2-8 Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée avec le Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.424 (la «Société»). Le siège de l’administration centrale de la Société,
à l'exclusion de son siège social (registered office tel que défini par le droit irlandais) a été transféré d’Irlande au Grand-
Duché de Luxembourg le 29 décembre 2011 par acte reçu par le notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

B) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- La modification de l’article 44 de Section B des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

« 44. Le nombre de gérants et les noms des premiers gérants seront déterminés par écrit par la Société lors d'une

assemblée générale. Le nombre de gérants ne sera pas inférieur à deux ni, sauf si la Société en convient autrement lors
d'une assemblée générale, supérieur à dix.»

Ceci ayant été exposé, les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, représentant la totalité du capital

social de la Société, ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Les parties comparantes ont décidé de modifier l’article 44 de Section B des statuts de la Société afin de lui donner la

teneur suivante:

« 44. Le nombre de gérants et les noms des premiers gérants seront déterminés par écrit par la Société lors d'une

assemblée générale. Le nombre de gérants ne sera pas inférieur à deux ni, sauf si la Société en convient autrement lors
d'une assemblée générale, supérieur à dix.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte, sont évalués à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des parties

comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, le prédit

mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Doyle, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 5 mars 2012. Relation: DIE/2012/2699. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 5 mars 2012.

Référence de publication: 2012034006/105.
(120044340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

SCI Pabet, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 71, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg E 1.139.

L'an deux mille neuf, le trois août.
Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch

Ont comparu:

1° Monsieur Paul BETTINGEN, notaire, né à Luxembourg, le 25 octobre 1951 (matricule 1951 10 25 330), demeurant

à L-2630 Luxembourg, 117, rue de Trèves;

2° Madame Stéphanie BETTINGEN, étudiante, née à Luxembourg, le 11 août 1982, demeurant à L-2630 Luxembourg,

117, rue de Trèves;

3° Monsieur Charles BETTINGEN, étudiant, né à Wiltz, le 18 novembre 1989, demeurant à L-2630 Luxembourg, 117,

rue de Trèves;

4° Monsieur Jean-François BETTINGEN, administrateur de société, né à Luxembourg, le 4 janvier 1981, demeurant à

L-1747 Luxemburg, 40, Op der Heed;

5° Monsieur Christophe BETTINGEN, hospitality manager, né à Luxembourg, le 17 mai 1984, demeurant à L-2630

Luxembourg, 117, rue de Trèves.

50534

L

U X E M B O U R G

Les prénommés sous 2° à y compris 5° sont ici représentés par Maître Paul BETTINGEN, prénommé sous 1°, en vertu

de quatre procurations sous seing privé, lesquelles, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire
soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Les comparants, représentés et agissant comme dit ci-avant, déclarent être les seuls et uniques associés de la société

civile SCI PABET, avec siège social à L-1638 Luxembourg, 71, rue du Golf, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg sous le numéro E 1.139, matricule 2001 70 02 784, constituée suivant acte sous seing privé en
date du 12 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 381 du 8 mars 2002 (la "Société").

<i>Constatation

Suivant acte de ce jour du notaire instrumentant (numéro 476 de son de son répertoire), la société civile SCI RUE

DU GOLF, avec siège social à L-1638 Senningerberg, 71, rue du Golf, inscrite au Registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg sous le numéro E 1.138, ci-avant propriétaire d'une (1) part sociale de la société SCI PABET, a été dissoute
et tous les actifs et passifs ont été attribués à Maître Paul BETTINGEN, prénommé, qui détient en conséquence deux
mille (2.000) parts sociales de la société SCI PABET.

<i>Résolutions de l'associé

Ensuite les associés déclarent se réunir en assemblée générale et prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des associés décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux mille euros, pour le

porter de son montant actuel de cinquante mille quatre cents euros (EUR 50.400,-) à cinquante-deux mille quatre cents
euros (EUR 52.400,-), par la création de quatre-vingt (80) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription libération

Maître Paul BETTINGEN, prénommé sous 1°, déclare apporter le jardin suivant, situé à Senningerberg, inscrit au

cadastre comme suit:

Commune de Niederanven, section B de Senningen
numéro 1141/4135, lieu-dit "Am Hau", place, d'une contenance de 7 ares 56 centiares.
Cet apport est évalué à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Origine de propriété

Le  bien  prédécrit appartient  à  Maître  Paul  BETTINGEN  aux  termes  d'un  acte  de dissolution, reçu  par le notaire

soussigné en date de ce jour (numéro 476 de son répertoire), lequel acte sera formalisé avant les présentes.

<i>Clauses et Conditions

1. L'immeuble prédésigné est apporté dans son état actuel, avec toutes les appartenances et dépendances, ainsi qu'avec

toutes les servitudes actives et passives pouvant y être attachées, sans garantie pour la contenance du terrain ni pour les
indications cadastrales.

2. De plus il n'est assumé aucune garantie pour les vices soit apparents soit cachés pouvant y être attachés.
3. L'entrée en jouissance de l'immeuble apporté aura lieu à compter de ce jour.
Tous les impôts fonciers et autres charges pouvant le grever sont à la charge de la société à partir de ce jour.
4. Maître Paul BETTINGEN déclare qu'il n'existe aucun obstacle à l'apport de l'immeuble à la présente société.
5. Maître Paul BETTINGEN déclare que l'immeuble est libre de toutes dettes hypothécaires et privilégiées, même

occultes, à l'exception d'une inscription hypothécaire prise au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 15
janvier 2001, volume 793, numéro 153, en faveur de la BGL contre la SCI RUE DU GOLF et à charge du terrain prédécrit,
en voie de radiation, le débit garantit étant remboursé.

6. Maître Paul BETTINGEN déclare expressément renoncer à toute inscription d'office et à l'inscription de toute

hypothèque légale.

7. A la demande expresse du notaire instrumentant, Maître Paul BETTINGEN déclare que l'objet du présent apport

n'est grevé d'aucun droit de préemption au profit d'un tiers.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les apports étant totalement réalisés,

les associés décident de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante-deux mille quatre cents euros (EUR 52.400,-), divisé en deux mille quatre-

vingt-seize (2.096) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, réparties comme suit:

- Maître Paul BETTINGEN, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2080 parts sociales

- Madame Stéphanie BETTINGEN, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 parts sociales

50535

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Jean-François BETTINGEN, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 parts sociales

- Monsieur Christophe BETTINGEN, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 parts sociales

- Monsieur Charles BETTINGEN, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2096 parts sociales"

<i>Pouvoirs

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, dépôts et autres formalités à faire en

vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Dont acte, fait et passé à Mersch, les jours, mois et an qu'en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Paul Bettingen, Urbain Tholl.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 11 août 2009. MER / 2009 / 1452. Reçu 75.- €.

<i>Le Receveur

 (signé): A. MULLER.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012034084/90.
(120044468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

Valves Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 136.012.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012034128/10.
(120044405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

Keravel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 167.173.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 9 mars 2012 que CVC European Equity V Limited, ayant

son siège social à 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Jersey, Iles Anglo-Normandes, inscrite au Jersey Financial Services
Commission sous le numéro 99031 a transféré 1.250.000 parts sociales de la société Keravel S.à r.l. société à responsabilité
limitée, établie à Luxembourg, ayant son siège social à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 167173 (la «Société») de la manière suivante:

1. transfert de 337.165 parts sociales de la Société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme

General Partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners V (A) L.P. un «limited partnership» crée et
organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand
Caïman, Iles Caïmans;

2. transfert de 335.799 parts sociales de la Société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme

General Partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners V (B) L.P. un «limited partnership» crée et
organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand
Caïman, Iles Caïmans;

3. transfert de 353.459 parts sociales de la Société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme

General Partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners V (C) L.P., un «limited partnership» crée
et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House. 87 Mary Street, George Town,
Grand Caïman, Iles Caïmans;

50536

L

U X E M B O U R G

4. transfert de 25.110 parts sociales de la Société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme

General Partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners V (D) L.P. un «limited partnership» crée
et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House. 87 Mary Street, George Town,
Grand Caïman, Iles Caïmans;

5. transfert de 28.012 parts sociales de la Société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme

General Partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners V (E) L.P. un «limited partnership» crée
et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town,
Grand Caïman, Iles Caïmans.

6. transfert de 81.180 parts sociales de la Société à CVC European Equity Tandem GP Limited, ayant son siège social

à 22 Grenville Street, St. Helier, JE4 8PX, Iles Anglo-Normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous
le numéro 94504, agissant comme General Partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners Tandem
Fund (A) L.P. un «limited partnership» crée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker
House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans;

7. transfert de 81.006 parts sociales de la Société à CVC European Equity Tandem GP Limited, préqualifié, agissant

comme General Partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. un «limited
partnership» crée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street,
George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans;

8. transfert de 8.269 parts sociales de la Société à CVC European Equity Tandem GP Limited, préqualifié, agissant

comme General Partner au nom et pour compte de CVG European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. un «limited
partnership» crée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street,
George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans.

Les associés de la société sont désormais:

Associés

Nombre

de parts

sociales

CVC European Equity Partners V (A) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337.165

CVC European Equity Partners V (B) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

335.799

CVC European Equity Partners V (C) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

353.459

CVC European Equity Partners V (D) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.110

CVC European Equity Partners V (E) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.012

CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.180

CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.006

CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.269

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.000

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 16 mars 2012.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012034182/65.

(120044506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

26 Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 120.962.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 mars 2012.

Référence de publication: 2012034144/10.

(120044404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

50537

L

U X E M B O U R G

TransEuropean Property Holdings (Luxembourg) II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 95.628.

En date du 8 mars 2012, l'associé unique a pris la décision suivante:
- Transfert du siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, avec effet au 5 mars 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2012.

<i>Pour la Société
TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Jorge Pérez Lozano / P. Valasuo
<i>Fondé de pouvoir A / Fondé de pouvoir B

Référence de publication: 2012036437/18.
(120048295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Syncreon Luxemburg, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 59.601.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2012.

Référence de publication: 2012035855/10.
(120047681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.

Bisa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 129.497.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 20 mars 2012 à Luxembourg

Il résulte dudit procès-verbal que:
1) L'Assemblée a décidé d'élire en tant qu'administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en

2013:

- M. Andréa Panzieri, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
- M. Bo Foged, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
- Mme. Christina Larsen, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour extrait conforme
BISA S.A.
Johan LINDBERG / Henrietta SCHRÖDER
<i>Directeur Général / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2012037055/20.
(120048217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

SAGITTARUS Agency S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 88.654.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

50538

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2012035856/12.
(120047659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.

Saint Seba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 107.862.

Les comptes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SAINT SEBA S.A.
Gioacchino GALIONE / Jean-Marc HEITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012035859/12.
(120047622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.

Gaïa International Financial Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 94.621.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2012.

Référence de publication: 2012036181/10.
(120048795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

MacArthur Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 141.050.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012036290/9.
(120048505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Quintiles Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 115.379.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of January,
Before Maître Alex WEBER, notary, residing in Bascharage, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his

prevented colleague Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who last named
shall remain depositary of the present deed.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Quintiles Luxembourg S.à r.l.,a société à respon-

sabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share
capital of GBP 226,900,000 and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and
Companies Register) under number B 115.379 (the «Company»).

There appeared

Innovex Merger Corporation, a company duly incorporated and validly existing under the laws of North Carolina,

USA, having its principal office at 4820 Emperor Blvd, Durham, North Carolina, NC 27703, USA, registered with the
Secretary of State of North Carolina under number 0411153 (the «Sole Shareholder»);

here represented by Mr Max MAYER; employee, residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

50539

L

U X E M B O U R G

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration.

The 100 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly

decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder through its proxy holder requests the notary to act that the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decrease of the share capital of the Company to offset the losses of the Company;
2. Second decrease of the share capital of the Company and allocation of the legal reserve;
3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the updated

share capital of the Company;

and
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of GBP 5,996,060 (five million nine hundred

ninety-six thousand sixty Pound Sterling) so as to reduce it from its current amount of GBP 226,900,000 (two hundred
twenty-six million nine hundred thousand Pound Sterling) to GBP 220,903,940 (two hundred twenty million nine hundred
three thousand nine hundred and forty Pound Sterling) to offset the losses of the Company amounting to GBP 5,996,060
(five million nine hundred ninety-six thousand sixty Pound Sterling) as evidenced by an interim balance sheet of the
Company as at December 31, 2011 produced to the notary by way of the reduction of the nominal value of each of the
100 shares representing 100% of the share capital of the Company from GBP 2,269,000 (two million two hundred sixty-
nine thousand Pound Sterling) to GBP 2,209,039.40 (two million two hundred nine thousand thirty-nine Pound Sterling
and forty cents).

<i>Second resolution

It is resolved (i) to decrease the share capital of the Company by an amount of GBP 20,081,070 (twenty million eighty-

one thousand seventy Pound Sterling) so as to reduce it from its current amount of GBP 220,903,940 (two hundred
twenty million nine hundred three thousand nine hundred and forty Pound Sterling) to GBP 200,822,870 (two hundred
million eight hundred twenty-two thousand eight hundred seventy Pound Sterling), by way of the reduction of the nominal
value of each of the 100 shares representing 100% of the share capital of the Company from GBP 2,209,039.40 (two
million two hundred nine thousand thirty-nine Pound Sterling qnd forty cents) to GBP 2,008,228.70 (two million eight
thousand two hundred twenty-eight Pound Sterling and seventy cents) and (ii) to allocate the full amount of the decrease
of capital of GBP 20,081,070 (twenty million eighty-one thousand seventy Pound Sterling) to a non-available accounting
balance sheet item legal reserve, as legal reserve.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions it is resolved to amend article 6 of the articles of association of the

Company to read as follows:

« Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at GBP 200,822,870 (two hundred million eight hundred twenty-

two thousand eight hundred seventy Pound Sterling) divided into 100 (one hundred) shares with a nominal value of GBP
2,008,228.70 (two million eight thousand two hundred twenty-eight Pound Sterling and seventy cents) each, fully paid-
up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.»

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital decrease, have been estimated at about EUR 2,600.-.

The capital decreases are valued at EUR 31,212,500.-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the
same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Bascharage, in the office of notary Alex WEBER, on the day named

at the beginning of this document.

50540

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the attorney of the person appearing, known to the undersigned notary, by his

name, surname, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil douze, le vingt-cinq janvier,
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rem-

placement  de  son  confrère  empêché  Maître  Jean  SECKLER,  notaire  de  résidence  à  Junglinster,  Grand-Duché  de
Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société Quintiles Luxembourg S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C rue Gabriel Lippmann à L-5365
Munsbach, Grand -Duché de Luxembourg, avec un capital social de 226.900.000 GBP et enregistrée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.379 (la «Société»).

A comparu

Innovex Merger Corporation, une société dûment enregistrée et existant valablement selon les lois de la Caroline du

Nord, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse principal au 4820 Emperor Blvd, Durham, Caroline du Nord, NC 27703,
Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du «Secretary of State of North Carolina» sous le numéro 0411153 (l'«Associé
Unique»);

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.
Les 100 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assem-

blée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du
jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informée.

L'Associé Unique, représentée par son mandataire, prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société pour compenser les pertes de la Société;
2. Seconde réduction du capital social de la Société et allocation à la réserve légale;
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter la modification du capital de la

Société; et

4. Divers.
Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 5.996.060 GBP (cinq millions neuf

cent quatre-vingt-seize mille soixante Livres Sterling) pour le réduire de son montant actuel de 226.900.000 GBP (deux
cent vingt-six millions neuf cent mille Livres Sterling) à 220.903.940 GBP (deux cent vingt millions neuf cent trois mille
neuf cent quarante Livres Sterling) afin de compenser les pertes de la Société d'un montant de 5.996.060 GBP (cinq
millions neuf cent quatre-vingt-seize mille soixante Livres Sterling), tel qu'établi par le bilan intérimaire de la Société en
date du 31 décembre 2011 fourni au notaire, par la réduction de la valeur nominale de chacune des 100 parts sociales
représentant 100% du capital social de la Société de 2.269.000 GBP (deux millions deux cent soixante-neuf mille Livres
Sterling) à 2.209.039,40 GBP (deux millions deux cent neuf mille trente-neuf Livres Sterling et quarante centimes).

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de (i) réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 20.081.070 GBP (vingt millions

quatre-vingt-un mille soixante-dix Livres Sterling) pour le réduire de son montant actuel de 220.903.940 GBP (deux cent
vingt millions neuf cent trois mille neuf cent quarante Livres Sterling) à 200.822.870 GBP (deux cent millions huit cent
vingt-deux mille huit cent soixante-dix Livres Sterling), par la réduction de la valeur nominale de chacune des 100 parts
sociales représentant l'intégralité du capital de la Société de 2.209.039,40 GBP (deux millions deux cent neuf mille trente-
neuf Livres Sterling et quarante centimes) à 2.008.228,70 GBP (deux millions huit mille deux cent vingt-huit Livres Sterling
et soixante-dix centimes), et d' (ii) allouer le montant intégral de la réduction de capital de 20.081.070 GBP (vingt millions
quatre-vingt-un mille soixante-dix Livres Sterling) au poste «réserve légale» du bilan de la Société en tant que réserve
légale non disponible.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la

Société comme suit:

50541

L

U X E M B O U R G

« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 200.822.870 GBP (deux cent millions huit cent vingt-deux mille huit cent

soixante-dix Livres Sterling), divisé en 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de 2.008.228,70 GBP (deux millions
huit mille deux cent vingt-huit Livres Sterling et soixante-dix centimes) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui doivent être mis à sa charge en raison de la réduction de son capital, s'élève à environ 2.600,-EUR.

Les réductions de capital ont été évalués à 31.212.500,-EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante

représentée par son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de
cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, passé à Bascharage, en l'étude du notaire Alex WEBER, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Alex WEBER.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 février 2012. Relation GRE/2012/457. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 22 mars 2012.

Référence de publication: 2012034061/151.
(120044320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

Granilo Holding B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 116.802.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 Mars 2012.

Granilo Holding B.V.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Proxyholder

Référence de publication: 2012036193/14.
(120047953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Gridway S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 73.169.

EXTRAIT

- Monsieur Vittorio VENTURA, né le 04 novembre 1975 à Milan (Italie), Administrateur de la société a changé d’adresse

et demeure maintenant Jakubovo Namestie 3, 81109 Bratislava (Slovaquie);

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2012.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2012036194/14.
(120048220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

50542

L

U X E M B O U R G

Halym SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 142.301.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HALYM S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2012036199/11.
(120048767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Treveria Twenty-Nine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 125.666.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 18 mars 2012, l'associé unique de la Société a accepté la résignation de Monsieur Abdelhakim Chagaar, de

Monsieur Nedim Gorel et de Madame Marjoleine van Oort en tant que gérants de la Société, et ce avec effet immédiat.

En cette même date, l'associé unique a nommé les personnes suivantes en tant que gérants avec effet immédiat et pour

une durée indéterminée:

- Monsieur Olivier Liegeois, comptable, né le 27 octobre 1976 à Bastogne, Belgique, demeurant professionnellement

au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

- Monsieur Luc Gerondal, fiscaliste, né le 23 avril 1976 à Kinshasa, République démocratique du Congo, demeurant au

19 avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

- Madame Sandrine BISARO, juriste, née le 28 juin 1969 à Metz, France, demeurant professionnellement au 12 rue

Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

En cette même date, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société, de l'ancienne adresse 73, Côte

d'Eich, L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg et ce avec effet im-
médiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2012.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012036446/26.
(120048307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Holding de Diversification Financière Prudentielle S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.355.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2012.

Damien Nussbaum
<i>Gérant

Référence de publication: 2012036198/12.
(120048098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

50543

L

U X E M B O U R G

Hatra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 12.223.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 février

2012, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2012, LAC/2012/10986.

Qu’a été prononcée la clôture de la liquidation de la société anonyme «HATRA S.A.», ayant son siège social à L-1325

Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 12.223.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 21 décembre 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 728 du 20 mars
2012.

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers
ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2012.

Référence de publication: 2012036200/22.
(120048736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Turaz Global TRM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.587.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2012.

Référence de publication: 2012034106/10.
(120044694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

J. Chahine Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 43, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 100.623.

Statuts coordonnés rectifiés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 20 mars 2012.

Référence de publication: 2012033970/10.
(120044699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2012.

King's Cross Asset Funding 39, Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 124.902.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour King's Cross Asset Funding 39 S.à r.l.

Référence de publication: 2012036249/10.
(120048841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

50544


Document Outline

26 Investments S.A.

Bisa S.A.

Dekra Claims Services Luxembourg S.A.

Gaïa International Financial Investment S.A.

Germalux S.A.

Geser Holding International S.A.

Granilo Holding B.V.

Gridway S.A.

GS Car Rental Lux II S.à r.l.

Halym SA

Hatra S.A.

Holding de Diversification Financière Prudentielle S. à r.l.

Jalyne S.A.

J. Chahine Capital

Keravel S.à r.l.

King's Cross Asset Funding 39

Kondor Bidco S.à r.l.

Leopard S.A.

Lobster Holding S.à r.l.

LSREF2 A. F. Investments S.à r.l.

LSREF2 Star Gate Investments S.à r.l.

Lux Business Risk Monitoring S.A.

Lux-Pipe Tech S.A.

Lyma S.C.I.

MacArthur Investments

Morgan Stanley Euro Financing (Luxembourg)

Polish Omega Group S.à r.l.

Quintiles Luxembourg S. à r.l.

RBC Funds (Lux)

Reflexes Finance S.A.

Robec SA

SAGITTARUS Agency S.à r.l.

Saint Seba S.A.

Samarvest Inc S.A.

SCI Pabet

Security Capital European Realty

Serafin S.A.-SPF

SGEA Immobilier S.A.

Signes S.à r.l.

Société Générale Luxembourgeoise d'ingénierie et de développement

Syncreon Luxemburg

TAITAVA Fund SICAV-FIS

The PNC Financial Services Holding Luxembourg S.à r.l.

TransEuropean Property Holdings (Luxembourg) II

Treveria Twenty-Five S.à r.l.

Treveria Twenty-Nine S.à r.l.

Turaz Global TRM S.à r.l.

UBP

UMP

Valves Investment S.A.