This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 943
12 avril 2012
SOMMAIRE
Adagio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45238
Ahlo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45242
Algemene Nederlandse Beheermaat-
schappij S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45261
Amundi Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45218
Arrowgrass Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
45235
Arrowgrass Special Situations S.à r.l. . . . .
45244
Central European Closures S.à r.l. . . . . . . .
45251
Central European Cotton Holdings (Lu-
xembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45253
Corporate Services Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45258
Discovery Group of Funds . . . . . . . . . . . . . .
45252
DPP Luxembourg Branch . . . . . . . . . . . . . . .
45242
Eurofins Scientific SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45234
Fumilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45236
Goodman Edelweis Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45245
Gopal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45254
Guilbaud S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45243
GVP Immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45236
HaMer Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45255
H.F. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45237
Horinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45249
H.S.F.L. PAR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45248
Immo "Main Nascht" Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
45252
INNCONA S.àr.l. & Cie. Trois cent vingt et
unième (321.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45240
Interactive Creatures Environment Limi-
ted S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45241
Judo Club Stroossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45245
KKR Asia S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45237
Lehnkering HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
45237
LSREF2 Triangle Investments S.à r.l. . . . .
45238
LTP INVEST S.A., société de gestion de
patrimoine familial, en abrégé SPF . . . . .
45255
Lumédia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45259
Lux-World Fund Advisory S.A. Holding . .
45239
Macsteel Holdings Luxembourg S.à r.l. . . .
45239
MAJIMA, Société Civile Immobilière
(S.C.I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45240
Marguerite Wind S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
45240
MEIF II Luxembourg Communications S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45241
Mermaid S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45239
Messer Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45250
MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45251
Montecin Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
45263
Neuheim Lux Group Holding V . . . . . . . . .
45253
Neuheim Lux Group Holding V . . . . . . . . .
45254
Neuheim Lux Group Holding V . . . . . . . . .
45254
New Net Lux Multiservices S.à r.l. . . . . . . .
45258
Noble Drilling (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .
45251
Notre TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45255
OCTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45238
Oven HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45261
PEF V Information Technology II S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45264
Petro Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45262
PIT D Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45245
Play & Win Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45262
Pucchini Debt S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45261
Regina Investment SE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45264
Re Schools S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45264
45217
L
U X E M B O U R G
Amundi Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 68.806.
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of March.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of AMUNDI FUNDS (the “Company”), a “société d'in-
vestissement à capital variable”, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, established in
Luxembourg on 18
th
July 1985 as a fonds commun de placement under Luxembourg law and transformed in a société
d'investissement à capital variable pursuant to a notarial deed passed on 15 March 1999 and published in the Mémorial
des Sociétés et Associations (the “Mémorial”), number 298 of on 28 April 1999 and registered in the Luxembourg Register
of Commerce and Companies (the “RCSL”) under the number B 68.806.
The articles of incorporation of the Company (the “Articles”) were last amended by deed of the undersigned notary
on 14 October 2009, published in the Mémorial number 104 of 15
th
January 2010.
The meeting was opened at 11 a.m., with Mr. Giovanni Notarantonio, private employee, professionally residing in
Luxembourg, as chairman (the “Chairman”),
who appointed Mr. Conrado Vanden Berghe as secretary to the meeting, private employee, professionally residing in
Luxembourg (the “Secretary”).
The meeting elected as scrutineer Mrs Stéphanie Doeblé, private employee, professionally residing in Luxembourg
(the “Scrutineer”).
The bureau of the meeting (the ”Meeting”) having thus been constituted, the Chairman declared and requested the
notary to state:
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. The present Meeting has been convened by notices containing the agenda, sent to the shareholders by registered
mail on February 15, 2012 and published in “Mémorial”, in “Luxemburger Wort” and in “Le Quotidien” on February 9 ,
2012 and February 27, 2012.
II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list, signed by the Chairman, the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.
It appears from the attendance list that out of 146,735,976.6400 shares in circulation, 5,315,006 shares are present or
represented at the present extraordinary general meeting.
A first extraordinary general meeting, called upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as the
agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on January 30, 2012 and could not validly decide on the
items of the agenda for lack of the legal quorum.
According to article 67 and 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to
time, the present meeting is authorized to take resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.
III. That the agenda of the Meeting is the following:
1. To amend the text of a number of articles of the Articles of Incorporation in order to implement the changes as
required by the new law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the “2010 Law”), imple-
menting Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 (the “UCITS IV Directive”),
and in particular to (not exhaustive summary):
- replace any reference to the law dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references
to the law dated 17 December 2010 on undertakings to collective investment;
- allow the Company to adopt master-feeder structure (see article 15);
- allow the Company to perform cross-sub-fund investments (see article 15); and
- amend the provisions regarding merger of the Company or its sub-funds in order to, inter alia, implement the rules
of the 2010 Law with regard to merger of the Company or its sub-funds with other sub-funds of the Company or another
UCITS or sub-funds thereof (see articles 29 and 30).
2. To amend the object of the Company in article 3 in order to update the reference to the fund legislation. The new
text of Article 3 will read as follows:
“The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities of all types and
all other permitted assets such as referred to in Part I of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective
investment or any legislative replacements or amendments thereof (the “2010 Law”) with the purpose of spreading
investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its sub-funds.”
3. To amend article 4 in order to provide the Company's board of directors with the authority to decide on potential
transfer of the register office of the Company within the municipality of the City of Luxembourg.
45218
L
U X E M B O U R G
4. To amend article 7 in order to gives to the Board the responsibility to define the “US persons” status in the
Prospectus of the Company.
5. To amend article 10 by the deletion of the end of the second paragraph to remove the requirement of a quorum
for general meetings of not less than one-half of the issued shares of that sub-fund, class or category in question in order
to be in line with the 2010 Law.
6. To amend the second paragraph of article 12 in order to change the period of the functions of the directors of the
Company from one year to six years.
7. To amend article 13 in order to provide the chairman of the Company's board of directors with the authority to
convene board's meetings at the place indicated in the notice of meeting and to have a casting vote in any circumstances.
8. To amend article 14 in order to foresee the possibility for two directors or any person authorised by the Company's
board of directors with the authority to sign the minutes as well as copies or extracts of such minutes of any meeting of
the board.
9. To amend article 15 in order to be in compliance with the 2010 Law. Notably, there will be the following amend-
ments:
- the board of directors is vested with the broadest powers to appoint a Luxembourg-based management company
or any other management company domiciled in any other EU Member State;
- the addition of the definition of Member State in full compliance with the 2010 Law;
- the flexibility to invest in one or more other sub-funds of the Fund and liquid assets, deposits and other UCITS or
UCIs in full compliance with the 2010 Law;
- the possibility for the Company to adopt master-feeder structure.
10. To amend article 18 in order to foresee the possibility for the chairman of the board, two directors or any
representative(s), delegate(s) to the daily management or any other authorised agent up to the limit of their powers to
represent the Company in acts, including those in which a civil servant or a legal officer involved and in court and to bind
in any circumstances the Company.
11. To amend article 20 in order to align the text of the Articles of Incorporation to the prospectus with regards to
the right, in the case where requests for redemption and conversion for any Dealing Day exceed 10% of the Net Asset
Value or the number of Shares of a Sub-Fund's shares, to postpone redemption and conversion of all or part of such
Shares to the following dealing day.
12. To amend article 20 in order to remove the descriptions on termination/merger of Sub-Funds/Classes, this is now
described in articles 28 and 30 of the Articles.
13. To amend article 21 in order to provide the Company with the authority to suspend the determination of the net
asset value and the issue and redemption of shares as well as the right to convert shares into shares of another sub-fund
of the company in case of a decision to merge the Company or a Sub-fund thereof provided that any such suspension is
justified for the protection of the Shareholders in order to comply with the provisions of the 2010 Law.
14. To amend article 21 in order to precise four events in the items (c), (e), (f) and (h) in which the Company may
suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of Shares in any Sub-fund as well as the
right to convert Shares of any Sub-fund into Shares of another Sub-fund, as follows:
- when the value of an investment of the Company cannot be determined as accurately and rapidly as required;
- when the restrictions on currencies or cash transfers prevent the completion of transactions of the Company or
when the purchases and sales on behalf of the Company cannot be achieved at normal exchange rates;
- when factors related to, among others, the political, economic, military, monetary, and fiscal situation and escaping
the control, the responsibility and the means of action of the Company prevent it from disposing of the assets of one or
more Sub-funds or determining the net asset value of one or more Sub-funds of the Company in a usual and reasonable
way;
- in case of a decision to merge the Company or a Sub-fund thereof provided that any such suspension is justified for
the protection of the Shareholders.
15. To amend article 24 in order to no longer communicate to the shareholders the annual accounts, including the
balance sheet and profit and loss account and the directors' report but to put them at the disposal of the shareholders
upon request annual accounts, including the balance sheet and profit and loss account and the directors' report in order
to comply with the provisions of the 2010 Law.
16. To amend article 26 order to align the text of the Articles of Incorporation to the prospectus with regards to the
right to appoint investment managers and sub-investment managers not belonging to CREDIT AGRICOLE and to appoint
investment advisors.
17. To amend article 27 in order to update it with the 2010 Law concerning the liquidation of the Company and notably
precise that:
- the Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting subject to the quorum and majority
requirements referred to in Article 10 of the Articles;
45219
L
U X E M B O U R G
- the liquidators shall realise the Company's assets in the best interest of the shareholders and shall distribute the net
proceeds.
18. To add article 28 concerning the liquidation of sub-fund/class in order to comply with the 2010 Law and to describe
the related liquidation process separately from the description of the liquidation of the Company as stated in article 27.
19. To add article 29 concerning the merger of the Company in order to comply with the 2010 Law and to state that
the Company may, either as a merging company or as a receiving company, be subject to cross-border or domestic
merger and that the Board of the Company will be competent to decide on such a merger in case the Company is the
receiving company.
20. To add article 30 concerning the merger of sub-fund(s) in order to comply with the 2010 Law and to state that
the sub-funds of the Company may be subject to cross-border and domestic mergers and that the Board of the Company
will be competent to decide on such mergers.
21. To amend article 32 (formerly article 29) as follows: “All matters not governed by these Articles shall be determined
in accordance with the 2010 Law, or subjected to the Law of 10
th
August 1915 on Commercial Companies, as the case
may be. In case of contradiction with the provisions of the Articles, the imperative provisions of the 2010 Law will prevail,
or as the case may be the imperative provisions of the Law of 10
th
August 1915.”
22. To delete the second paragraph of article 32 (formerly article 29) in order to implement the derogation laid down
in Article 26 (2) of the 2010 Law that allow to have only one version of the articles of incorporation of the Company in
French or English with no need of a translation into an official language.
23. To completely restate the Articles of Incorporation with effect as of the date that will be resolved by the extraor-
dinary general meeting in order to reflect the various amendments adopted by the extraordinary general meeting and
resolve that the only version of the Articles of Incorporation will be the English version.
24. To resolve that the effective date of the resolutions of the above agenda shall become effective on the date of the
extraordinary general meeting.
25. Miscellaneous.
This request has been sent to the registered office of the Company by registered mail on February 15, 2012.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to amend the text of a number of articles of the Articles of Incorporation in order to
implement the changes as required by the new law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment
(the “2010 Law”), implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009
(the “UCITS IV Directive”), and in particular to (not exhaustive summary):
- replace any reference to the law dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references
to the law dated 17 December 2010 on undertakings to collective investment;
- allow the Company to adopt master-feeder structure (see article 15);
- allow the Company to perform cross-sub-fund investments (see article 15); and
- amend the provisions regarding merger of the Company or its sub-funds in order to, inter alia, implement the rules
of the 2010 Law with regard to merger of the Company or its sub-funds with other sub-funds of the Company or another
UCITS or sub-funds thereof (see articles 29 and 30).
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to amend the object of the Company in Article 3 in order to update the reference to
the fund legislation.
Article 3 will now read as follows:
“The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities of all types and
all other permitted assets such as referred to in Part I of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective
investment or any legislative replacements or amendments thereof (the “2010 Law”) with the purpose of spreading
investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its sub-funds.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to amend Article 4 in order to provide the Company's board of directors with the
authority to decide on potential transfer of the register office of the Company within the municipality of the City of
Luxembourg. Article 4 shall be read as follows:
“The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the
Company (the “Board”).
45220
L
U X E M B O U R G
In the event that the Board determines that extraordinary political or military developments have occurred or are
imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the Board
of the Company.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 7 in order to gives to the Board the responsibility to define the “US
persons” status in the Prospectus of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 10 by the deletion of the end of the second paragraph to remove the
requirement of a quorum for general meetings of not less than one-half of the issued shares of that sub-fund, class or
category in question in order to be in line with the 2010 Law. The second paragraph of article 10 shall be read as follows:
“As long as the Share capital is divided into different Sub-funds, Classes and Categories of Shares, the rights attached
to the Shares of any Sub-fund, Class or Category (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that
Sub-fund, Class or Category) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the sanction of a
resolution passed at a separate general meeting of the holders of the Shares of that Sub-fund, Class or Category by a
majority of two-thirds of the votes cast at such separate general meeting. To every such separate meeting the provisions
of these Articles relating to general meetings shall mutatis mutandis apply.”
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolves to amend the second paragraph of article 12 in order to change the period of the functions
of the directors of the Company from one year to six years. The second paragraph of article 12 shall be read as follows:
“The directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting for a period not exceeding six (6)
years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or
without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders.”
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 13 in order to provide the chairman of the Company's board of directors
with the authority to convene board's meetings at the place indicated in the notice of meeting and to have a casting vote
in any circumstances.
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 14 in order to foresee the possibility for two directors or any person
authorised by the Company's board of directors with the authority to sign the minutes as well as copies or extracts of
such minutes of any meeting of the board.
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 15 in order to be in compliance with the 2010 Law. Notably, there will
be the following amendments:
- the board of directors is vested with the broadest powers to appoint a Luxembourg based management company
or any other management company domiciled in any other EU Member State;
- the addition of the definition of Member State in full compliance with the 2010 Law;
- the flexibility to invest in one or more other sub-funds of the Fund and liquid assets, deposits and other UCITS or
UCIs in full compliance with the 2010 Law;
- the possibility for the Company to adopt master-feeder structure.
<i>Tenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 18 in order to foresee the possibility for the chairman of the board,
two directors or any representative(s), delegate(s) to the daily management or any other authorised agent up to the limit
of their powers to represent the Company in acts, including those in which a civil servant or a legal officer involved and
in court and to bind in any circumstances the Company. Therefore, article 18 shall be read as follows:
“The Company is represented in acts, including those in which a civil servant or a legal officer is involved and in court:
- either by the Chairman of the Board; or
- jointly by two directors; or
45221
L
U X E M B O U R G
- by the representative(s) or by the delegate(s) to the daily management up to the limit of their powers as determinated
by the Board.
Besides, it is validly committed by specially authorised agents within the limits of their mandates as determinated by
the Board.
Legal actions, in a capacity as either claimant or defendant, shall be followed up in the name of the Company by a
member of the Board or by the representative or by the delegate(s) to the daily management appointed by the Board.
The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of any two Directors or by the signature of
any director or officer to whom authority has been delegated by the Board.“
<i>Eleventh resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 20 in order to align the text of the Articles of Incorporation to the
prospectus with regards to the right, in the case where requests for redemption and conversion for any Dealing Day
exceed 10% of the Net Asset Value or the number of Shares of a Sub-Fund's shares, to postpone redemption and
conversion of all or part of such Shares to the following dealing day.
<i>Twelfth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 20 in order to remove the descriptions on termination/merger of Sub-
Funds/Classes, this is now described in articles 28 and 30 of the Articles.
<i>Thirteenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 21 in order to provide the Company with the authority to suspend the
determination of the net asset value and the issue and redemption of shares as well as the right to convert shares into
shares of another sub-fund of the company in case of a decision to merge the Company or a Sub-fund thereof provided
that any such suspension is justified for the protection of the Shareholders in order to comply with the provisions of the
2010 Law.
<i>Fourteenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 21 in order to precise four events in the items (c), (e), (f) and (h) in
which the Company may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of Shares in
any Sub-fund as well as the right to convert Shares of any Sub-fund into Shares of another Sub-fund, as follows:
- when the value of an investment of the Company cannot be determined as accurately and rapidly as required;
- when the restrictions on currencies or cash transfers prevent the completion of transactions of the Company or
when the purchases and sales on behalf of the Company cannot be achieved at normal exchange rates;
- when factors related to, among others, the political, economic, military, monetary, and fiscal situation and escaping
the control, the responsibility and the means of action of the Company prevent it from disposing of the assets of one or
more Sub-funds or determining the net asset value of one or more Sub-funds of the Company in a usual and reasonable
way;
- in case of a decision to merge the Company or a Sub-fund thereof provided that any such suspension is justified for
the protection of the Shareholders.
<i>Fifteenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 24 in order to no longer communicate to the shareholders the annual
accounts, including the balance sheet and profit and loss account and the directors' report but to put them at the disposal
of the shareholders upon request annual accounts, including the balance sheet and profit and loss account and the di-
rectors' report in order to comply with the provisions of the 2010 Law.
<i>Sixteenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 26 order to align the text of the Articles of Incorporation to the
prospectus with regards to the right to appoint investment managers and sub-investment managers not belonging to
CREDIT AGRICOLE and to appoint investment advisors.
<i>Seventeenth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 27 in order to update it with the 2010 Law concerning the liquidation
of the Company and notably precise that:
- the Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting subject to the quorum and majority
requirements referred to in Article 10 of the Articles;
- the liquidators shall realise the Company's assets in the best interest of the shareholders and shall distribute the net
proceeds.
45222
L
U X E M B O U R G
<i>Eighteenth resolutioni>
The general meeting resolves to add article 28 concerning the liquidation of subfund/class in order to comply with the
2010 Law and to describe the related liquidation process separately from the description of the liquidation of the Company
as stated in article 27.
<i>Nineteenth resolutioni>
The general meeting resolves to add article 29 concerning the merger of the Company in order to comply with the
2010 Law and to state that the Company may, either as a merging company or as a receiving company, be subject to
cross-border or domestic merger and that the Board of the Company will be competent to decide on such a merger in
case the Company is the receiving company.
<i>Twentieth resolutioni>
The general meeting resolves to add article 30 concerning the merger of sub-fund(s) in order to comply with the 2010
Law and to state that the sub-funds of the Company may be subject to cross-border and domestic mergers and that the
Board of the Company will be competent to decide on such mergers.
<i>Twenty-first resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 32 (formerly article 29) as follows: “All matters not governed by these
Articles shall be determined in accordance with the 2010 Law, or subjected to the Law of 10
th
August 1915 on Com-
mercial Companies, as the case may be. In case of contradiction with the provisions of the Articles, the imperative
provisions of the 2010 Law will prevail, or as the case may be the imperative provisions of the Law of 10
th
August 1915.”
<i>Twenty-second resolutioni>
The general meeting resolves to delete the second paragraph of article 32 (formerly article 29) in order to implement
the derogation laid down in Article 26 (2) of the 2010 Law that allow to have only one version of the articles of incor-
poration of the Company in French or English with no need of a translation into an official language.
<i>Twenty-third resolutioni>
The general meeting resolves to completely restate the Articles of Incorporation with effect as of the date that will
be resolved by the extraordinary general meeting in order to reflect the various amendments adopted by the extraor-
dinary general meeting and resolve that the only version of the Articles of Incorporation will be the English version.
On the basis of the above resolutions, the general meeting decides to amend the articles of the Company, so that they
will read under coordinated form as follows:
Articles of Incorporation
Denomination
Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form
of a “société anonyme” qualifying as a “société d'investissement à capital variable” under the name of “AMUNDI
FUNDS” (the “Company”).
Duration
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
Object
Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities of all types
and all other permitted assets such as referred to in Part I of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for
collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the «2010 Law») with the purpose of
spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its sub-funds.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.
Registered office
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of
the Company (the “Board”).
In the event that the Board determines that extraordinary political or military developments have occurred or are
imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
45223
L
U X E M B O U R G
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the Board
of the Company.
Share capital - Shares - Classes of shares
Art. 5. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value (the “Shares”) and shall at any time
be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 22 hereof.
The minimum capital of the Company shall not be less than one million two hundred and fifty thousand EUR (EUR
1,250,000.-).
The Board is authorised without limitation to allot and issue fully paid Shares and, as far as Registered Shares are
concerned, fractions thereof, at any time in accordance with Article 23 hereof, based on the Net Asset Value per Share
of the respective sub-fund determined in accordance with Article 22 hereof, without reserving the existing Shareholders
a preferential right to subscription of the Shares to be issued. The Board may delegate to any duly authorised director
or officer of the Company or to any other duly authorised person the duty of accepting subscriptions and of delivering
and receiving payment for such Shares, however always remaining within the limits imposed by law.
Such Shares may, as the Board shall determine, be of different sub-funds (“Sub-funds”) (which may, as the Board shall
determine, be denominated in different currencies) and the proceeds of the issue of the Shares of each Sub-fund (after
the deduction of any initial charge and notional dealing costs which may be charged to them from time to time) shall be
invested in accordance with the objectives set out in Article 3 hereof in securities or other permitted assets corresponding
to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities,
as the Board shall from time to time determine in respect of each Sub-fund.
Within each Sub-fund, Shares may be divided into several classes (“Classes”) and/or categories (“Categories”) which
may differ, inter alia, in respect of their distribution policy or other special features, as the Board may decide to issue. In
accordance with the above, the Board may decide to issue within the same Sub-fund or Class of Shares two Categories
where one Category is represented by accumulation Shares (“Accumulation Shares”) and the second Category is repre-
sented by distribution Shares (“Distribution Shares”). The Board may decide if and from what date Shares of any such
Categories shall be offered for sale, those Shares to be issued on the terms and conditions as shall be decided by the
Board.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-fund shall in the
case of a Sub-fund not denominated in EUR, be notionally converted into EUR in accordance with Article 24 and the
capital shall be the total of the net assets of all the Sub-funds.
The Company shall prepare consolidated accounts in EUR.
Art. 6. Shares are issued in registered form only.
Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the Dealing Price per Share
as set forth in Article 23 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of a confirmation of his sha-
reholding.
Payments of dividends, if any, will be made to Shareholders at their mandated addresses in the Register of Shareholders
or to such other address as given to the Board in writing.
All issued Shares of the Company shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company
or by one or more persons designated therefor by the Company and such Register shall contain the name of each holder
of Shares, his residence or elected domicile (and in the case of joint holders the first named joint holder's address only)
so far as notified to the Company and the number of Shares and Sub-fund held by him. Every transfer of a Share shall be
entered in the Register of Shareholders upon payment of such customary fee as shall have been approved by the Board
for registering any other document relating to or affecting the title to any Share.
Shares shall be free from any restriction on the right of transfer and from any lien in favour of the Company.
Transfer of Shares shall be effected by inscription of the transfer by the Company in the Register of Shareholders,
upon delivery of the certificate or certificates, if any, representing such Shares, to the Company along with other instru-
ments and preconditions of transfer satisfactory to the Company.
Every Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the
Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders. In the event of joint holders of Shares
(the joint holding of Shares being limited to a maximum of four persons) only one address will be inserted and any notices
will be sent to that address only.
In the event that such Shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to
be entered in the Register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office
of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address
shall be provided to the Company by such Shareholder. The Shareholder may, at any time, change his address as entered
in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other
address as may be set by the Company from time to time.
45224
L
U X E M B O U R G
If payment made by any subscriber results in the issue of a fraction of a Share, such fraction shall be entered into the
Register of Shareholders. Fractions of Shares shall not carry a vote but shall, to the extent the Company shall determine,
be entitled to a corresponding fraction of the dividend.
Restrictions on shareholding
Art. 7. The Board shall have power to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of Shares) as
it may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares in the Company or no Shares of any Sub-fund are
acquired or held by or on behalf of (a) any person in breach of the law or requirements of any country or governmental
or regulatory authority or (b) any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company
incurring any liability to taxation, or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise
have incurred or suffered.
More specifically, the Board may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm or
corporate body, and without limitation, by any “U.S. Person”, as defined from time to time by the Board in the Prospectus
of the Company. For such purposes, the Company may:
(a) decline to issue any Share where it appears to it that such issue would or might result in such Share being directly
or beneficially owned by a person, who is precluded from holding Shares in the Company,
(b) at any time require any person whose name is entered in the Register of Shareholders to furnish it with any
information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not
beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests in a person who is precluded from holding Shares in the Company,
and
(c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding Shares in the Company, either
alone or in conjunction with any other person is a beneficial or registered owner of Shares, compulsorily redeem from
any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the following manner:
(1) the Company shall serve a notice (hereinafter called the “Redemption Notice”) upon the Shareholder holding such
Shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to
be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the Redemption Price (as defined
below) in respect of such Shares is payable. Any such Redemption Notice may be served upon such Shareholder by posting
the same in a prepaid registered envelope addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in
the Register of Shareholders. Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice,
such Shareholder shall cease to be a Shareholder and the Shares previously held by him shall be cancelled. The said
Shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the Share certificate or certificates (if issued)
representing the Shares specified in the Redemption Notice;
(2) the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the “Redemption
Price”) shall be an amount equal to the Dealing Price of Shares in the Company of the relevant Sub-fund, determined in
accordance with Article 20 hereof;
(3) payment of the Redemption Price will be made to the Shareholder appearing as the owner thereof in the currency
of denomination of the relevant Sub-fund and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere
(as specified in the Redemption Notice) for payment to such person but only, if a Share certificate shall have been issued,
upon surrender of the Share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice. Upon deposit of
such price as aforesaid no person interested in the Shares specified in such Redemption Notice shall have any further
interest in such Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right
of the Shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank
as aforesaid;
(4) the exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
(d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Company at any meeting of
Shareholders of the Company.
Powers of the general meeting of shareholders
Art. 8. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of
Shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Company regardless of the
Sub-fund held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts whose fulfilment by the
General Meeting of Shareholders has expressly been provided for in the articles of incorporation of the Company (the
“Articles”)or all acts relating to the operations of the Company, subject in each case to the respect of the applicable
imperative laws.
45225
L
U X E M B O U R G
General meetings
Art. 9. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the last Friday of October of each year at 11.00 a.m.. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual
general meeting shall be held on the next following business day in Luxembourg. The annual general meeting may be held
abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Special meetings of the holders of Shares of any one Sub-fund, Class or Category or of several Sub-funds, Classes or
Categories may be convened to decide on any matters relating to such one or more Sub-funds, Classes or Categories
and/or to a variation of their rights.
Quorum and Votes
Art. 10. Unless otherwise provided herein, the quorum and delays required by law shall govern the notice for and
conduct of the general meetings of Shareholders of the Company.
As long as the Share capital is divided into different Sub-funds, Classes and Categories of Shares, the rights attached
to the Shares of any Sub-fund, Class or Category (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that
Sub-fund, Class or Category) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the sanction of a
resolution passed at a separate general meeting of the holders of the Shares of that Sub-fund, Class or Category by a
majority of two-thirds of the votes cast at such separate general meeting. To every such separate meeting the provisions
of these Articles relating to general meetings shall mutatis mutandis apply.
Each whole Share of whatever Sub-fund and regardless of the Net Asset Value per Share within the Sub-fund is entitled
to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders
by appointing another person as his proxy in writing. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly
authorised officer.
Except as otherwise required by law or as otherwise required herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any
meeting of Shareholders.
Convening notice
Art. 11. Shareholders shall meet upon call by the Board, pursuant to registered notice setting forth the agenda, sent
at least 8 days prior to the meeting to each registered Shareholder at the Shareholder's address in the Register of
Shareholders.
If notices are published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg, in a Luxembourg news-
paper and in such other newspapers as the Board may decide, convening notices may be sent by ordinary mail only.
Directors
Art. 12. The Company shall be managed by the Board composed of not less than three persons. Members of the Board
need not be Shareholders of the Company.
The directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting for a period not exceeding six (6)
years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or
without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders.
Proceedings of directors
Art. 13. The Board shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one
or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders. The Board shall meet upon call by the chairman or
any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and at the Board, but failing a chairman or in his absence
the Shareholders or the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the
time set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or
telefax of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
45226
L
U X E M B O U R G
Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another
director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by cable or conference call or visio-conference,
telegram, telex or telefax.
The directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their
individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.
The Board shall deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting
of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
The chairman of the meeting shall have a casting vote in any circumstances.
Resolutions of the Board may also be passed in the form of a circular resolution in identical terms which may be signed
on one or more counterparts by all the directors.
The Board from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a secretary, and
any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and mana-
gement of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be directors
or Shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the
powers and duties given them by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board. The Board may also delegate certain of its powers, authorities and discretions to any
committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit,
provided that the majority of the members of the committee are directors of the Company and that no meeting of the
committee shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority
of those present are directors of the Company.
Minutes of board meetings
Art. 14. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman who presided over such meeting or
by two Directors or by any person authorised by the Board.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by two directors by any person authorised by the Board.
Determination of investment policies
Art. 15. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the
Company's interest and more specifically to appoint a management company domiciled in Luxembourg in accordance
with Chapter 15 of the 2010 Law or any other management company domiciled in any other EU Member State All powers
not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of Shareholders may be exercised by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board, acting under the supervision of the Board.
The Board has, in particular, power to determine the corporate policy. The course of conduct of the management and
business affairs of the Company shall not effect such investments or activities as shall fall under such investment restrictions
as may be imposed by the 2010 Law or be laid down in the laws and regulations of those countries where the Shares are
offered for sale to the public or as shall be adopted from time to time by resolutions of the Board and as shall be described
in any prospectus relating to the offer of Shares.
In the determination and implementation of the investment policy the Board may cause the assets of the Company to
be invested in transferable securities and/or in other liquid financial assets allowed to undertaking for collective investment
in transferable securities in accordance with Part I of the 2010 Law.
The Company may in particular invest in securities and/or money market instruments:
a) on any Regulated Market as defined in the European directive 2004/39/CEE of the European parliament and of the
Council of April 21
st
, 2004,
b) on another market in a Member State (for the purpose of this Article, Member State shall mean a Member State of
the European Union and States that are contracting parties to the Agreement creating the European Economic Area
other than Member States of the European Union within the limites set forth by this Agreement and related acts) which
is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public,
c) if admitted to official listing on a stock exchange in an Eligible State or dealt in on another regulated market in an
Eligible State which operates regularly and is recognised and open to the public.
- Each of the regulated market referred to in a), b) and c) being a “Regulated Market”.
- “Eligible State” means a member state of the Organisation for the Economic Cooperation and Development, and any
country of Western or Eastern Europe, Africa, Asia, Oceania or the American continents.
d) recently issued, provided that
45227
L
U X E M B O U R G
- the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock
exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public;
- such admission is secured within one year of issue.
Investments may be made in financial derivative instruments, such as equivalent cash-settled instruments, dealt in on
a Regulated Market, and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter (“OTC derivatives”), provided that:
- the underlying consists in transferable securities and/or in other liquid financial assets allowed to undertaking for
collective investment in transferable securities in accordance with Part I of the 2010 Law,
- the counterparties to OTC derivatives transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging
to the categories approved from time to time by the Luxembourg competent authority,
- and the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or
closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Company's initiative.
By way of derogation from the limit laid down in the Article 43 (1) of the 2010 Law (as may amended from time to
time), and as long as the investment policy of the Company or a Sub-fund may be to reproduce the composition of a
stock or a bond index recognised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier: in such cases, the limits
provided by the 2010 Law for investments in transferable securities or money market instruments will be of a maximum
of 20% of the assets for investments in shares and/or debt securities issued by the same body. This limit can be raised to
35% where that proves to be justified by exceptional market conditions in particular in regulated markets where certain
transferable securities or money market instruments are highly dominant. The investment up to this limit is only permitted
for a single issuer.
The States, local authorities or public international bodies issuing or guaranteeing securities in which the Company
may invest more than 35% of its assets may be situated in Europe, America, Africa, Asia and Oceania.
In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorised to invest up to 100% of the net assets
attributable to each Sub-fund in transferable securities or in money market instruments issued or guaranteed by a Member
State, by one or more of its local authorities, by a non-Member State of the European Union or a public international
body of which one or more Member State(s) of the European Union belongs, provided that in the case where the Company
decides to make use of this provision, it shall hold on behalf of the concerned Sub-fund, securities from at least six different
issues, and that securities from any one issue may not account for more than 30% of the total assets attributable to such
Sub-fund.
In order to reduce operational and administrative charges while allowing a wider diversification of the investments,
the Board may decide that part or all of the assets of the Company or one of its Sub-fund will be co-managed with assets
belonging to other collective investment schemes as defined in the prospectus or to other Sub-funds of the Company.
A Sub-fund may subscribe, acquire and hold securities to be issued or issued by one or more Sub-fund(s) of the
Company without being subject to the requirements of the Law of 10
th
August 1915 on commercial companies, as
amended, with respect to the subscriptions, acquisition and or holding by a company of its own shares, under the condition
however that:
- the target Sub-fund does not, in turn, invest in the Sub-fund invested in this target Sub-fund, and
- no more than 10% of the assets of the target Sub-fund whose acquisition is contemplated may be invested in aggregate
in Shares of other target Sub-funds of the Company, and
- voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long they are held by the Sub-fund
concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports, and
- in any event, for as long as these securities are held by the Company, their value will not be taken in to consideration
for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold for the assets
imposed by the 2010 Law, and
- there is no duplication of the management/subscription or repurchase fees between those at the level of the investing
Sub-fund and the target Sub-fund.
The Company is also entitled to invest in liquid assets, deposits and other UCITS or UCIs in full compliance with the
2010 Law. In addition, the Company may also adopt master-feeder investment policy in compliance with the provisions
of the 2010 Law and under the condition that such a policy is specifically allowed by the investment policy of the relevant
Sub-fund that will act as a feeder fund, as published in the prospectus of the Company.
For the purpose of this article, and in accordance with the provisions of the 2010 Law, each Sub-fund shall be regarded
as a separate UCITS, The investment restrictions applicable to the UCITS under management shall consequently be
applicable at Sub-fund level.
Conflict of interests
Art. 16. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is
a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm but subject as hereinafter
45228
L
U X E M B O U R G
provided, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other
business.
In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote
on any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of Shareholders.
The term “personal interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving CREDIT AGRICOLE or any of its affiliates, or such other company or entity
as may from time to time be determined by the Board at its discretion.
Indemnity
Art. 17. The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of
which the Company is a Shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such person shall
be so indemnified in all circumstances, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised
by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Administration
Art. 18. The Company is represented in acts, including those in which a civil servant or a legal officer is involved and
in court:
- either by the Chairman of the Board; or
- jointly by two directors; or
- by the representative(s) or by the delegate(s) to the daily management up to the limit of their powers as determinated
by the Board.
Besides, it is validly committed by specially authorised agents within the limits of their mandates as determinated by
the Board.
Legal actions, in a capacity as either claimant or defendant, shall be followed up in the name of the Company by a
member of the Board or by the representative or by the delegate(s) to the daily management appointed by the Board.
The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of any two Directors or by the signature of
any director or officer to whom authority has been delegated by the Board.
Auditor
Art. 19. The general meeting of Shareholders shall appoint a “réviseur d'entreprises agréé” who shall carry out the
duties prescribed by Article 154 of 2010 Law.
Redemption and conversion of shares
Art. 20. As is more specifically prescribed herein below the Company has the power to redeem its own Shares at any
time within the sole limitations set forth by law.
Any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company provided that
(i) the Company may, if compliance with such request would result in a holding of Shares in the Company of an aggregate
amount or number of Shares as the Board may determine from time to time and disclosed in the prospectus, redeem all
the remaining Shares held by such Shareholder; and
(ii) the Company may, in the interest of the Shareholders, decide to defer all or some of the Share redemption requests
received for a Sub-fund on a single day which represent more than a certain percentage of net assets or Shares of a Sub-
fund determined by the Board (and as may be stated in the prospesctus) until a Dealing Day such as all or certain
investments of the Sub-fund have been sold. On such Dealing Day, such requests for redemptions will be complied with,
with priority to later requests.
For the purpose of this article, conversions are considered as redemptions.
Whenever the Company shall redeem Shares, the price at which such Shares shall be redeemed by the Company shall
be the Dealing Price per Share of the relevant Sub-fund (as determined in accordance with the provisions of Article 22
hereof) determined on the Dealing Day when or immediately after a written and irrevocable redemption request is
received, less a redemption charge, as may be decided by the Board from time to time and described in the then current
prospectus.
The redemption proceeds shall be paid normally within 3 business days (being a day on which the banks in Luxembourg
are open for business) after the date on which the applicable Dealing Price was determined or, if later, on the date the
45229
L
U X E M B O U R G
written confirmation, or as the case may be, Share certificates (if issued) have been received by the Company. Any such
request must be filed or confirmed by such Shareholder in written form at the registered office of the Company in
Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of Shares. Evidence
of transfer or assignment accompanied by the certificate(s) (with redemption requests thereon), representing the sha-
reholding, if issued in certificated form, must be received by the Company or its agent appointed for that purpose before
the redemption monies may be paid. Shares in the capital of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
Any Shareholder may request conversion of the whole or part of his Shares of a given Class into Shares of the same
Class of another Sub-fund, (or within one Sub-fund into another Category) based on a conversion formula as determined
from time to time by the Board and disclosed in the current explanatory memorandum or prospectus of the Company
provided that the Board may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion
subject to payment of such reasonable charge, as it shall determine and disclose in the current explanatory memorandum
or prospectus. Conversions from Shares of one Class of a Sub-fund to Shares of another Class of either the same or a
different Sub-fund are not permitted, except otherwise decided by the Board of Directors and disclosed in the prospectus.
If requests for redemption and conversion for any Dealing Day exceed 10% of the Net Asset Value or the number of
Shares of a Sub-fund, the Company reserves the right to postpone redemption and conversion of all or part of such Shares
to the following Dealing Day. On the following Dealing Day, such requests will be dealt with in priority to any subsequent
requests for redemption and conversion.
Valuations and suspension of valuations
Art. 21. The Net Asset Value of Shares in the Company shall be determined as to the Shares of each Sub-fund by the
Company from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the Board by regulation may direct (every
such day or time for determination thereof being a Dealing Day), but so that no day observed as a holiday by banks in
Luxembourg shall be a Dealing Day.
During the existence of any state of affairs which, in the opinion of the directors, makes the determination of the Net
Asset Value of a Sub-fund in the relevant currency of expression either not reasonably practical or prejudicial to the
Shareholders of the Company, the Net Asset Value and the Subscription Price and Redemption Price may temporarily
be determined in such other currency as the directors may determine.
The Company may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of Shares in any
Sub-fund as well as the right to convert Shares of any Sub-fund into Shares of another Sub-fund during:
(a) During any period when any market or stock exchange, which is the principal market or stock exchange on which
a material part of the Company's investments of the relevant Sub-Fund for the time being are quoted, is closed (otherwise
than for ordinary holidays) or during which dealings are restricted or suspended; or
(b) During the existence of any state of affairs which in the opinion of the Board of Directors constitutes an emergency,
as a result of which disposals or valuation of assets attributable to investments of the relevant Sub-fund is impractical; or
(c) During any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in deter-
mining the prices of any of the investments attributable to such Sub-fund or the current prices or values on any market
or stock exchange, or when, for any reason, the value of an investment of the Company cannot be determined as accurately
and rapidly as required; or
(d) During any period when remittance of monies which will or may be involved in the realisation of, or in the payment
for, any of the Company's investments is not possible;
(e) Any period when the restrictions on currencies or cash transfers prevent the completion of transactions of the
Company or when the purchases and sales on behalf of the Company cannot be achieved at normal exchange rates;
(f) Any period when factors related to, among others, the political, economic, military, monetary, and fiscal situation
and escaping the control, the responsibility and the means of action of the Company prevent it from disposing of the
assets of one or more Sub-funds or determining the net asset value of one or more Sub-funds of the Company in a usual
and reasonable way;
(g) In case of a decision to liquidate the Company or a Sub-fund thereof on or after the day of publication of the first
notice convening the general meeting of the Shareholders for this purpose respectively the notice provided for in the
Articles;
(h) In case of a decision to merge the Company or a Sub-fund thereof provided that any such suspension is justified
for the protection of the Shareholders.
Shareholders having requested redemption or conversion of their Shares shall be notified of any such suspension within
seven days of their request and will be promptly notified of the termination of such suspension. Shares redeemed or
converted after such suspension will be converted or redeemed based on their Net Asset Value on the Valuation Day
immediately following such suspension.
The suspension as to any Sub-fund will have no effect on the calculation of Net Asset Value and the issue, redemption
and conversion of the Shares of any other Sub-fund.
45230
L
U X E M B O U R G
Determination of Net Asset Value
Art. 22. The Net Asset Value of each Sub-fund shall be expressed in EUR or in the currency determined by the Board,
as a per Share figure, and shall be determined in respect of each Valuation Day by dividing the net assets of the Company
corresponding to the relevant Sub-fund, being the value of the assets of the Company corresponding to such Sub-fund
less its liabilities attributable to such Sub-fund, by the number of outstanding Shares of the relevant Sub-fund.
The valuation of the Net Asset Value of each Sub-fund shall be made in the following manner:
(1) The assets of the Company shall be deemed to include:
(i) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
(ii) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not yet
collected);
(iii) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscriptions rights and any other investments and securities
belonging to the Company;
(iv) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company provided
that the Company may adjust the valuation for fluctuations in the market value of securities due to trading practices such
as trading ex-dividend or ex-rights;
(v) all accrued interest on any interest bearing securities held by the Company except to the extent the such interest
is comprised in the principal thereof;
(vi) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and
(vii) all other permitted assets of any kind and nature including prepaid expenses.
(2) The value of assets of the Company shall be determined as follows:
(i) the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be deemed to be the
full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof
shall be arrived at after making such discount as the Board may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof;
(ii) the value of all portfolio securities which are listed on an official stock exchange or traded on any other regulated
market will be valued at the last available price on the principal market on which such securities are traded, as furnished
by a pricing service approved by the Board. If such prices are not representative of the fair value, such securities as well
as all other permitted assets, including securities which are not listed on a stock exchange or traded on a regulated market,
will be valued at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined in good faith by and under the
direction of the Board;
(iii) the swaps will be valued at the net present value of their cash flows.
(iv) At its sole discretion, the Board may permit the use of another valuation method if it believes that it results in a
fairer valuation of an asset held by the Company.
(3) The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(i) all borrowings, bills and other amounts due;
(ii) all administrative expenses due or accrued including the costs of its constitution and registration with regulatory
authorities, as well as legal, audit, management, custodial, paying agency and corporate and central administration agency
fees and expenses, the costs of legal publications, prospectuses, financial reports and other documents made available to
Shareholders, translation expenses and generally any other expenses arising from the administration of the Company;
(iii) all known liabilities, due or not yet due including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of all dividends declared by the Company for which no coupons have been presented and
which therefore remain unpaid until the day these dividends revert to the Company by prescription;
(iv) any appropriate amount set aside for taxes due on the date of the valuation and any other provisions of reserves
authorised and approved by the Board; and
(v) any other liabilities of the Company of whatever kind towards third parties.
(4) The Board shall establish a portfolio of assets for each Sub-fund in the following manner:
(i) the proceeds from the allotment and issue of Shares of each Sub-fund shall be applied in the books of the Company
to that Sub-fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such
Sub-fund, subject to the provisions of the Articles;
(ii) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same Sub-fund as the assets which it was derived and on each valuation of an asset, the increase or diminution in
value shall be applied to the relevant Sub-fund;
(iii) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-fund or to any action taken in
connection with an asset of a particular Sub-fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-fund; the liabilities
shall be segregated on a Sub-fund basis with third part creditors having recourse only to the assets of the Sub-fund
concerned;
45231
L
U X E M B O U R G
(iv) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Sub-fund, such asset or liability shall be allocated by the Board, after consultation with the auditors, in a way considered
to be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances;
(v) upon the record date for the determination of any dividend declared on any Sub-fund, the Net Asset Value of such
Sub-fund shall be reduced by the amount of such dividend, but subject always to the provision relating to the calculation
of the Dealing Price of the Distribution Shares and Accumulation Shares of each Sub-fund set out in the Articles.
(5) For the purpose of valuation under this Article:
(i) Shares of the relevant Sub-fund in respect of which the Board has issued a redemption notice or in respect of which
a redemption request has been received, shall be treated as existing and taken into account until immediately after the
close of business on the relevant Dealing Day, and from such time and until paid, the redemption price therefore shall
be deemed to be a liability of the Company;
(ii) all investments, cash balances and other assets of any Sub-fund expressed in currencies other than the currency of
denomination in which the Net Asset Value of the relevant Sub-fund is calculated, shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of Shares;
(iii) effect shall be given on any Dealing Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company on
such Dealing Day, to the extent practicable, and
(iv) where the Board is of the view that any conversion or redemption which is to be effected will have the result of
requiring significant sales of assets in order to provide the required liquidity, the value may, at the discretion of the Board
be effected at the actual bid prices of the underlying assets and not the last available prices. Similarly, should any purchase
or conversion of Shares result in a significant purchase of assets in the Company, the valuation may be done at the actual
offer price of the underlying assets and not the last available price.
Subscription price
Art. 23. Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such Shares shall be
offered and sold, shall be the Dealing Price as defined herebelow to which a Sales Charge as the Board may from time to
time determine, and as shall be disclosed in the Company's then current prospectus, may be added. The Dealing Price
shall be based on the Net Asset Value of the relevant Sub-fund divided by the number of Units, as adjusted for the number
of Distribution Shares and Accumulation Shares of the relevant Sub-fund expected (in the light of information available
at such time) to be in issue or deemed to be in issue at that time, rounded at a number of decimal as decided by the
Board of directors.
The price so determined shall be payable within a period as determined by the Board which shall not exceed three
business days after the date on which the applicable Dealing Price was determined.
Financial year
Art. 24. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
July of each year and shall terminate on the 30
th
June of the subsequent year.
The accounts of the Company shall be expressed in EUR or in respect of any Sub-fund, in such other currency or
currencies as the Board may determine. Where there shall be different Sub-funds as provided for in Article 5 hereof, and
if the accounts within such Sub-funds are maintained in different currencies, such accounts shall be converted into EUR
and added together for the purpose of determination of the accounts of the Company. The annual accounts, including
the balance sheet and profit and loss account, the directors' report and the notice of the annual general meeting will be
communicated to the Shareholders upon request.
Distribution of income
Art. 25. The general meeting of Shareholders of each Sub-fund shall, upon the proposal of the Board in respect of each
Sub-fund, subject to the other provisions of this article and to any interim dividends having been declared or paid, de-
termine how the annual net investment income shall be disposed of in respect of the relevant Sub-fund.
Without prejudice of the rights and obligations of the General Meeting as provided by the law and the Articles, the
Meeting of the Shareholders will decide, each year and for each Sub-fund authorized for distribution in Belgium, to
distribute to the holders of distribution Shares, the whole of the collected incomes, after deduction of the remunerations,
commissions and expenses that proportionally relates to them.
Dividends may, in respect of any Sub-fund, include an allocation from a dividend equalisation account which may be
maintained in respect of any such Sub-fund and which, in such event, will, in respect of such Sub-fund, be credited upon
issue of Shares to such dividend equalisation account and upon redemption of Shares, the amount attributable to such
Share will be debited to an accrued income account maintained in respect of such Sub-fund.
Interim dividends may, at the discretion of the Board, be declared subject to such further conditions as set forth by
law, and be paid out on the Shares of any Sub-fund out of the income attributable to the portfolio of assets relating to
such Sub-fund upon decision of the Board.
The dividends declared will normally be paid in the currency in which the relevant Sub-fund is expressed or in excep-
tional circumstances in such other currency as selected by the Board and may be paid at such places and times as may
45232
L
U X E M B O U R G
be determined by the Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate
dividend monies into the currency of their payment. Stock dividends may be declared.
No dividends shall be declared in respect of Accumulation Shares.
Investment managers and sub-investment managers
Art. 26. The Company may (i) enter, or may authorised its management company referred to in article 15 to enter;
into investment management agreements with professional investment managers, (ii) to authorise the investment mana-
gers to enter into sub-investment management agreements and / or (iii) to enter into advisory agreements for the
management of the assets of the Company and assistance with respect to its portfolio selection.
Distribution upon liquidation
Art. 27. Liquidation of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 10 of the Articles.
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may
be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation. The liquidators shall realise the Company's assets in the best interest
of the Shareholders and shall distribute the net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-fund to the Sharehol-
ders of each Sub-fund in proportion of their holding of Shares in such Sub-fund. If the capital of the Company falls below
two thirds of the minimum legal capital, the directors must submit the question of the dissolution of the Company to the
general meeting for which no quorum shall be prescribed and which shall decide by simple majority of the Shares present
or represented at the meeting. If the capital falls below one fourth of the minimum legal capital, no quorum shall be also
prescribed but the dissolution may be resolved by Shareholders holding one fourth of the Shares presented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets
have fallen below respectively two thirds or one fourth of the minimum capital.
Liquidation proceeds not claimed by the Shareholders will at the close of liquidation be deposited at the Caisse de
Consignation in Luxembourg pursuant to the 2010 Law.
Art. 28. Liquidation of Sub-fund / Class. In the event that for any reason whatsoever, the value of the assets of a Sub-
fund or Class should fall down to such an amount considered by the Board as the minimum level under which the Sub-
fund or the Class may no longer operate in an economic efficient way, or in the event that a significant change in economic
or political situation impacting the relevant Sub-fund or Class should have negative consequences on the investments of
the relevant Sub-fund or Class or when the range of products offered to clients is rationalized, the Board may redeem
all (but not some) Shares of the Sub-fund or of the Class at a price reflecting the anticipated realisation and liquidation
costs on closing of the relevant Sub-fund or Class, but with no redemption charge.
Termination of a Sub-fund or a Class by compulsory redemption of all relevant Shares for reasons other than those
mentioned in the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval of the Shareholders of the Sub-fund
or Class to be terminated, at a duly convened Sub-fund or Class meeting which may be validly held without a quorum
and decide by a simple majority of the Shares present or represented.
Each Sub-fund may be liquidated separately without that separate liquidation resulting in the liquidation of another
Sub-fund. Only the liquidation of the last remaining Sub-fund of the Company will result in the liquidation of the Company
as referred to in Article 145 (1) of the 2010 Law. In this case and under penalty of nullity, the issue of Shares shall be
prohibited except for the purposes of liquidation/merger.
Liquidation proceeds not claimed by the Shareholders at the close of the liquidation will be deposited at the Caisse
de Consignation in Luxembourg pursuant to the 2010 Law.
Merger of the Company / Sub-Funds
Art. 29. Merger of the Company. The Company may, either as a merging UCITS or as a receiving UCITS, be subject
to cross-border and domestic mergers in accordance with the definitions and conditions set out in the 2010 Law. The
Board of the Company will be competent to decide on such a merger and on the effective date of such a merger in case
the Company is the receiving UCITS.
The general meeting of Shareholders, deciding by simple majority of the votes cast by Shareholders present or re-
presented at the meeting, shall be competent to decide on the merger and on the effective date of merger, in case the
Company is the merging UCITS. The effective date of merger shall be recorded by notarial deed.
Notice of the merger shall be given to the Shareholders of the Company. Each Shareholder shall be given the possibility,
within a period of one month as of the date of the publication, to request either the repurchase of its Shares, free of any
charges, or the conversion of its Shares, free of any charges.
Art. 30. Merger of Sub-Fund(s). Any Sub-Fund may, subject to the conditions set out in the 2010 Law, be merged with
a foreign and / or a Luxembourg fund or sub-fund of a foreign fund and / or Luxembourg fund as defined in the 2010 Law,
in accordance with the definitions and conditions set out in the 2010 Law. The Board of Directors of the Company will
be competent to decide on such a merger as well as on the effective date of such a merger. In addition, any Sub-fund may,
45233
L
U X E M B O U R G
either as a merging Sub-fund or as a receiving Sub-fund, be merged with another Sub-fund of the Company in accordance
with the definitions and conditions set out in the 2010 Law.
Insofar as the effective date of the merger requires the approval of the Shareholders concerned by the merger pursuant
to the provisions of the 2010 Law, the general meeting of Shareholders deciding by simple majority of the votes cast by
Shareholders present or represented at the meeting, is competent to approve such an effective date of the merger. No
quorum requirement will be applicable.
In all cases, notice of the merger will be given to the Shareholders. When the approval of Shareholders is required
each Shareholder of the relevant Sub-funds or Classes shall be given the possibility, within a period of one month as of
the date of the sending, to request either the repurchase of its Shares, free of any charges, or the conversion of its Shares,
free of any charges.
Amendment of Articles
Art. 31. These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and
majority requirements provided by the laws of Luxembourg.
General
Art. 32. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 2010 Law, or subjected
to the Law of 10
th
August 1915 on Commercial Companies, as the case may be. In case of contradiction with the
provisions of the Articles, the imperative provisions of the 2010 Law will prevail, or as the case may be the imperative
provisions of the Law of 10
th
August 1915.
<i>Twenty-fourth resolutioni>
The general meeting resolves to resolve that the effective date of the resolutions of the above agenda shall become
effective on the date of the extraordinary general meeting. Therefore, the general meeting resolves that the date of
effectiveness of the resolutions set out in the agenda will be March 14, 2012.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their name, first name,
civil status and residence, the appearing persons signed, together with the notary, the present original deed.
Signé: G. NOTARANTONIO, C. VANDEN BERGHE, S. DOEBLE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mars 2012. Relation: LAC/2012/13646. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 5 avril 2012.
Référence de publication: 2012041258/921.
(120055348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2012.
Eurofins Scientific SE, Société Européenne.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 167.775.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assembléei>
<i>générale de la Société tenue en date du 11 janvier 2012i>
En date du 11 janvier 2012, l'assemblée générale de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de nommer Monsieur Gilles Gérard Jean Henri MARTIN, né le 20 octobre 1963 à Paris, France, résidant profes-
sionnellement à l'adresse suivante: 455, Chaussée de Malines, 1950 Kraainem, Belgique, en tant qu'administrateur de la
Société avec effet au 30 mars 2012 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se
tiendra en l'année 2016;
- de nommer Monsieur Valérie Anne Marie HANOTE, née le 26 novembre 1966 à Carthage, Tunisie, résidant pro-
fessionnellement à l'adresse suivante: 455, Chaussée de Malines, 1950 Kraainem, Belgique, en tant qu'administrateur de
la Société avec effet au 30 mars 2012 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se
tiendra en l'année 2016;
- de nommer Monsieur Yves-Loïc Jean-Michel MARTIN, né le 1
er
novembre 1966 à Nantes, France, résidant profes-
sionnellement à l'adresse suivante: 455, Chaussée de Malines, 1950 Kraainem, Belgique, en tant qu'administrateur de la
45234
L
U X E M B O U R G
Société avec effet au 30 mars 2012 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se
tiendra en l'année 2016;
- de nommer Monsieur Wicher Rotger Jonkheer WICHERS, né le 30 septembre 1947 à Gravenhage, Pays-Bas, résidant
à l'adresse suivante: 3, Sparrenlaan, 1272 RN Huisen, Pays-Bas, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 30
mars 2012 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2016;
- de nommer Monsieur Stuart Anthony ANDERSON, né le 24 juillet 1942 à Wellington, Royaume-Uni, résidant à
l'adresse suivante: 85, Avenue du Gui, 1180 Bruxelles, Belgique, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 30
mars 2012 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2016;
- de nommer PricewaterhouseCoopers, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477, en tant que réviseur d'en-
treprises agréé de la Société avec effet au 30 mars 2012 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale
de la Société qui se tiendra en l'année 2013.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseili>
<i>d'administration de la Société tenu en date du 28 mars 2012i>
En date du 28 mars 2012, le conseil d'administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de nommer Monsieur Gilles Gérard Jean Henri MARTIN en tant que président du conseil d'administration et Di-
recteur Général en charge de la gestion journalière de la Société avec effet au 30 mars 2012 et ce pour une durée
déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2016;
- de nommer Monsieur Yves-Loïc Jean-Michel MARTIN en tant que Directeur Général Délégué en charge de la gestion
journalière de la Société avec effet au 30 mars 2012 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la
Société qui se tiendra en l'année 2016;
- de nommer Monsieur Hugues Pierre Marie VAUSSY, né le 11 novembre 1966 à Paris, France, résidant profession-
nellement à l'adresse suivante: 455, Chaussée de Malines, 1950 Kraainem, Belgique, en tant que Directeur Général Délégué
en charge de la gestion journalière de la Société avec effet au 30 mars 2012 et ce pour une durée déterminée jusqu'à
l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2016;
- de nommer Monsieur François Marie VIGNEAU, né le 12 septembre 1966 à Toulon, France, résidant à l'adresse
suivante: Site de la Géraudière, rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 Nantes, France, en tant que Directeur Général
Délégué en charge de la gestion journalière de la Société avec effet au 30 mars 2012 et ce pour une durée déterminée
jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2012.
EUROFINS SCIENTIFIC SE
Signature
Référence de publication: 2012039531/54.
(120051670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.
Arrowgrass Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 138.173.
<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil de gérance en date pu 08/03/2012i>
<i>Résolution uniquei>
Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 16/02/2012.
Luxembourg, le 08/03/2012.
Taavi Davies
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2012030260/15.
(120039825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
45235
L
U X E M B O U R G
GVP Immobilier, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 135.661.
Par la présente, je tiens à vous faire part de ma décision de démissionner avec effet immédiat, de mon mandat de gérant
de la Société GVP IMMOBILIER Sàrl avec adresse au 75, parc d’Activités L-8308 Capellen, inscritre au registre de com-
merce sous le numéro B-135661.
Capellen, le 8 mars 2012.
SEREN
Référence de publication: 2012030421/12.
(120039681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Fumilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4485 Soleuvre, 47A, rue de Sanem.
R.C.S. Luxembourg B 151.134.
L'an deux mille onze, le vingt-et-un décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Fumilux S.A.”, ayant son siège
social à L-4485 Soleuvre, 47a, rue de Sanem, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 151.134, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 janvier 2010, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 551 du 15 mars 2010, dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 mars 2011, publié
au Mémorial C, numéro 1225 du 7 juin 2011.
ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur
nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, demeurant profes-
sionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry NOWANKIE-
WICZ, employé, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la société et décision de mettre la société en liquidation volontaire
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée désigne comme liquidateur:
45236
L
U X E M B O U R G
YES Europe, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, Avenue Monterey, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 150.454.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la
loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette auto-
risation est normalement requise.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée révoque l'administrateur unique et le commissaire aux comptes et leur confère, pleine et entière décharge
pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à neuf cent cinquante euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Jean-Luc JOURDAN, Thierry NOWANKIEWICZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2011. Relation GRE/2011/4798. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Ronny PETER.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 7 mars 2012.
Référence de publication: 2012029225/64.
(120038315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
KKR Asia S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 141.775.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 janvier 2012.
Référence de publication: 2012029322/10.
(120038476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Lehnkering HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 121.148.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012029325/10.
(120038470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
H.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 42, rue Poincaré.
R.C.S. Luxembourg B 82.788.
<i>Extrait du PV de l'AGE du 15 février 2012i>
Après avoir acte les démissions de Monsieur Eric Bérard et Madame Elena Novikova en qualité d'administrateurs,
l'Assemblée générale nomme comme administrateurs;
- Monsieur Daniel Petitjean, né le 7 janvier 1947 à Bar Le Duc (F), demeurant à F-54130 Sainte-Max, 33, rue de la Haie
le Comte
- Madame Anne Petitjean, née le 21 août 1973 à Nancy (F), demeurant à F-54610 Nomeny, 14, rue sous les Vignes
Leurs mandats d'administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2014.
45237
L
U X E M B O U R G
L'Assemblée Générale nomme également Monsieur Daniel Petitjean, administrateur délégué de la société.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2014.
L'administrateur-délégué a tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions
par sa seule signature.
Le Conseil d'Administration se présente désormais de la manière suivante:
- Madame Marie Flore Petitjean, demeurant à F-54610 Nomeny, 14, rue sous les Vignes
- Madame Anne Petitjean, demeurant à F-54610 Nomeny, 14, rue sous les Vignes
- Monsieur Daniel Petitjean demeurant à F-54130 Sainte-Max, 33, rue de la Haie le Comte
<i>Administrateur délégué:i>
- Monsieur Daniel Petitjean demeurant à F-54130 Sainte-Max, 33, rue de la Haie le Comte
Référence de publication: 2012030422/24.
(120039604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Adagio S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 138.192.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 9 Mars 2012 que le siège social de la société a été transféré
du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 30
décembre 2011.
De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes est désormais:
- Utility Corporate Services S.à r.l., Liquidateur: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2012.
Utility Corporate Services S.à r.l.
Signature
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2012030254/18.
(120040123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
OCTA, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 93.651.
Au Conseil d'Administration et à Messieurs les Actionnaires de la Société OCTA S.A.
Par la présente, je tiens à vous faire part de ma décision de démissionner avec effet immédiat, de mon mandat d'Ad-
ministrateur ainsi que de mon mandat d'Administrateur délégué de la Société OCTA S.A. avec adresse au 75, parc
d'Activités L-8308 Capellen, inscritre au registre de commerce sous le numéro B-93.651.
Capellen, le 8 mars 2012.
Référence de publication: 2012030529/12.
(120040023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
LSREF2 Triangle Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 164.564.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2012.
Référence de publication: 2012029339/10.
(120038150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
45238
L
U X E M B O U R G
Macsteel Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 159.338.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 30 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 30 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029351/13.
(120038229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Mermaid S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 66.340.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 5 mars 2012i>
1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2163 Luxem-
bourg, 40, avenue Monterey.
2. Mme Virginie DOHOGNE a démissionné de ses mandats d'administrateur et de présidente du conseil d'adminis-
tration.
3. Mme Karoline WILLOT et M. Hugo FROMENT ont démissionné de leur mandat d'administrateur.
4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire.
5. M. Gilles JACQUET, administrateur de sociétés, né à Saint-Mard (Belgique), le 7 février 1964, demeurant profes-
sionnellement à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2013.
6. M. Pieter VAN NUGTEREN, administrateur de sociétés, né à Meppel (Pays-Bas) le 19 avril 1966, demeurant pro-
fessionnellement à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2013.
7. La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 79709, avec siège
social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, représentée par son représentant permanent M. Gérard Alexander
VAN HUNEN, administrateur de sociétés, né à 'S-Gravenhage (Pays-Bas) le 15 septembre 1967, demeurant profession-
nellement à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2013.
8. La société anonyme CO-VENTURES S.A., R.C.S. Luxembourg B 48838, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40,
avenue Monterey, a été nommée comme commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Mermaid S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012031462/31.
(120041132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Lux-World Fund Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 46.535.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 2012i>
I. Nominations statutaires
L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 janvier 2011, le terme du mandat des Ad-
ministrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en janvier 2013:
M. Jean-Claude FINCK, président
45239
L
U X E M B O U R G
M. Ernest CRAVATTE, vice-président
M. Rodolphe BELLI, administrateur
M. Michel BIREL, administrateur
M. Gilbert ERNST, administrateur
M. Guy HOFFMANN, administrateur
M. Guy ROSSELJONG, administrateur
Mme Françoise THOMA, administrateur
II. Nomination du Commissaire aux Comptes
L'Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Frank MOSAR, a été fixé jusqu'à la
présente Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur
Frank MOSAR, pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en janvier 2013.
Luxembourg, le 18 janvier 2012.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Référence de publication: 2012030485/29.
(120040135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Marguerite Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 163.075.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 20 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029353/13.
(120038126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
MAJIMA, Société Civile Immobilière (S.C.I.), Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 94, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg E 3.696.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 janvier 2012.
Référence de publication: 2012029367/10.
(120038480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
INNCONA S.àr.l. & Cie. Trois cent vingt et unième (321.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.
R.C.S. Luxembourg B 165.508.
<i>Gesellschafterbeschluss zur Vorlage beim Luxemburgischen Handelsregisteri>
Name des Versammlungsleiters: Joachim Grote
Name des Protokollführers: Joachim Grote
Name der anwesenden Teilnehmer: Joachim Grote
Name der Teilnehmer, die durch Vollmachten vertreten sind: Marcel Winkens Der Versammlungsleiter stellt fest, dass
- die Gesellschafterversammlung wurde ordnungsgemäß einberufen,
- die Vollmachten für die Teilnehmer, die sich durch Vollmachten vertreten lassen, ordnungsgemäß erteilt worden
sind,
- 100% des stimmberechtigten Gesellschaftskapitals anwesend sind,
- die Abstimmung durch Handzeichen zu erfolgen hat.
45240
L
U X E M B O U R G
Sodann hat die Gesellschafterversammlung ad Tagesordnungspunkt (TOP) 11 und 12 einstimmig (zu 100% des stimm-
berechtigten Kapitals) beschlossen:
TOP 11:
Kapitalherabsetzung der Gesellschaft zum 30.06.2010 von 170.100 € um 138.100 € auf 32.000 € zum Ausgleich der
in der Bilanz zum 30.06.2009 ausgewiesen Bilanzverlustes. Die Herabsetzung soll durch folgende Herabsetzung der
Nennbeträge der einzelnen Geschäftsanteile durchgeführt werden:
a) Der Gesellschaftsanteil der INNCONA Management Sàrl in Höhe von 100 € wird auf 0 € herabgesetzt.
b) Der Geschäftsanteil des Kommanditisten wird von 170.000 € auf 32.000 € herabgesetzt.
TOP 12:
Im Falle des positiven Beschlusses gem. TOP 11 wird § Art. 3 des Gesellschaftsvertrages wie folgt geändert:
„Gesellschafter/Kommanditisten sind:
- INNCONA Management Sàrl mit Sitz in I-5444 Schengen mit einem Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 0 €.
- Der Kommanditist, die TEMTEX Management S.A. hat einen Kommanditanteil von 32.000 €.
<i>Der Versammlungsleiter / Der Schriftführeri>
Référence de publication: 2012031667/31.
(120041412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Interactive Creatures Environment Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 165.981.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique de la société en date du 8 mars 2012:i>
1. TSM Services (Luxembourg) S.à r.l. a démissionné de sa fonction de gérant avec effet au 8 mars 2012.
2. Monsieur Jonathan BAILEY né le 15 avril 1987 à Johannesburg (Afrique du Sud) demeurant 706 Horizon Bay, Blaau-
berg Road, Blaauberg, Cape Town, 7741 (Afrique du Sud) a été nommé gérant administratif avec effet au 8 mars 2012
pour une période indéterminée.
3. Francis FABER né le 7 juin 1950 à Ettelbrück, demeurant à L-9071 Ettelbrück 39, rue des romains a été nommé
gérant technique avec effet au 8 mars 2012 pour une période indéterminée.
4. La société sera valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
5. Le siège social de la société est transféré au 55-57, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg avec effet au 8 mars 2012.
Il résulte du transfert de parts sociales en date du 8 mars 2012 que:
TSM Services (Luxembourg) S.à r.l., avec siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg a transféré cinq cents
parts sociales (500) à DELTA LOGIC S.A., RCS Luxembourg B54357, avec siège social au 55-57, Avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg.
Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012030447/25.
(120040133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
MEIF II Luxembourg Communications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 137.826.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 30 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 30 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029377/13.
(120038225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
45241
L
U X E M B O U R G
Ahlo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 118.209.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de la Société tenue le 6 mars 2012 à Luxembourgi>
1. La démission de Madame Charlotte Lahaije-Hultman, en tant qu'administrateur de la Société, a été acceptée avec
effet au 14 février 2012.
2. Madame Laura Laine, née le 16 janvier 1978 à Rauman mlk (Finlande), avec adresse professionnelle au 121, avenue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommée en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet au 14
février 2012, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle, qui se tiendra en 2015.
Il est également à noter que l'adresse de Monsieur Olaf Lahaije, administrateur de la Société, est désormais 22, rue de
Fischbach, L-7391 Blaschette.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AHLO S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012030255/18.
(120039841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
DPP Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 167.255.
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE
Le dépôt et l'enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, de la succursale lu-
xembourgeoise (la «Succursale») de la société 3260789 Nova Scotia Company (la «Société») constituée sous le droit
canadien,- ont été requis tel que repris ci-après:
Les caractéristiques de la Succursale sont les suivantes:
1- L'adresse de la Succursale est la suivante: L-5365 Munsbach, 6C rue Gabriel Lippmann.
2- Les activités de la Succursale seront le financement intragroupe et l'acquisition de participations au Luxembourg ou
à l'étranger, dans toute société ou entreprise, sous quelque forme que ce soit et la gestion de telles participations. La
Succursale pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute autre manière toutes sortes d'ac-
tions cotées, actions simples et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou autres instruments
de crédit et plus généralement tout titre et instrument financier émis par des entités publiques ou privées. Elle pourra
participer dans la création, le développement, la gestion, le contrôle de n'importe quelle société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l'acquisition et la gestion de portefeuille de brevet et/ou d'autre droit de la propriété intellectuelle
de toute nature ou origine que ce soit.
La Succursale pourra emprunter sous toutes les formes. Elle pourra émettre seulement par voie d'émission privée,
des billets à ordre, des bonds, des obligations et des titres de créance et tout autre type de créance. La Succursale pourra
accorder des prêts comprenant le produit des emprunts et/ou émissions de titre de créance à ses filiales ou entités
affiliées. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder des garanties à l'égard de tiers pour garantir ses obligations
ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou toute autre société. La Succursale pourra de plus gager, transférer,
grever ou créer d'autres types de garanties sur toutes ou une partie de ses actifs et pourra ouvrir un compte bancaire à
son nom.
La Succursale pourra généralement employer toute technique ou instrument en relation avec son investissement en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Succursale contre le risque de
crédit, de variation de taux de change, des taux d'intérêt et tout autre risque.
La Succursale pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines de l'acquisition de
titres ou de biens immobiliers, qui sont directement ou indirectement en relation avec l'objet de la succursale.
De manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et toute opération qu'elle
jugera utile à la réalisation et le développement de son objet.
La succursale pourra exercer toute autre activité spécialement autorisée par la Société ou les administrateurs de la
Société.
3- La Société est enregistrée auprès du «Registry of Joint Stock Companies» sous le numéro 3260789.
4- Aucune limitation n'est imposée à l'objet social de la Société.
5- Le capital social de la Société est de USD 235,974,717.-.
6- La dénomination sociale de la Société est 3260789 Nova Scotia Company.
45242
L
U X E M B O U R G
7- La forme juridique de la Société est Unlimited Liability Company.
8- La dénomination de la Succursale est DPP Luxembourg Branch.
9- Les personnes pouvant valablement engager la Société en leur qualité d'administrateurs dans la limite de ses statuts
et règlements sont:
- Pierre Jetté, né le 21 avril 1965, à Saint-Agapit, Québec, Canada, demeurant professionnellement à 395 boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal, Québec, H3A 1L6;
- Razvan Theodoru, né le 22 septembre 1955, à Bucarest (Roumanie), demeurant professionnellement à 395 boulevard
de Maisonneuve Ouest, Montréal, Québec, H3A 1L6;
- Josée Mireault, née le 26 août 1968 à Montréal, Québec, Canada, demeurant professionnellement à 395 boulevard
de Maisonneuve Ouest, Montréal, Québec, H3A 1L6.
10- La personne ayant pouvoir d'engager individuellement la Succursale est Christine Joly, née le 10 août 1960 à La
Hestre, (Belgique), demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 6C rue Gabriel Lippmann, laquelle a été nommée
gérant de DPP Luxembourg Branch pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 13 février 2012.
<i>Pour DPP, Luxembourg Branch
i>Signature
Référence de publication: 2012029161/57.
(120038541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Guilbaud S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 157.685.
L’an deux mille onze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme OVIALUX S.A., avec siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S.
Luxembourg numéro B 46319;
2.- La société à responsabilité de droit italien AGAVE BLU SRL, avec siège social à I-20123 Milano, 14, Piazza Borromeo,
Italie;
Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement
à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurent annexées aux
présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Les sociétés OVIALUX S.A. et AGAVE BLU SRL, sont les associés de GUILBAUD S.à r.l., une société à responsabilité
limitée ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg numéro B 157685,
constituée à Madère le 29 mai 2000 et transférée au Grand-duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Jean
SECKLER, notaire prénommé, le 17 décembre 2010, publié au Mémorial C numéro 394 en date du 28 février 2011.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christina SCHMIT-VALENT, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé
privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les 200 (deux cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 62,50 (soixante-
deux euros et cinquante cents) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 1.625, pour le porter de son montant actuel
de EUR 12.500 à EUR 14.125, par l'émission de 26 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 62,50 chacune,
avec une prime d’émission de EUR 2.512.029,22;
2. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions et paiement de la prime d’émission.
45243
L
U X E M B O U R G
3. Modification afférente du 1
er
paragraphe de l'article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.625 (mille six cent vingt-cinq Euros) pour le
porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros) à 14.125 EUR (quatorze mille cent vingt-
cinq Euros), par l'émission de 26 (vingt-six) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 62,50 (soixante-deux
euros et cinquante cents) chacune, avec une prime d’émission de EUR 2.512.029,22 (deux millions cinq cent douze mille
vingt-neuf euros et vingt-deux cents).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire majoritaire AGAVE BLU SRL a renoncé à son droit préférentiel de
souscription, décide d'admettre à la souscription des 26 (vingt-six) parts sociales nouvelles l'associé minoritaire la société
anonyme OVIALUX S.A., prédésignée.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
La société anonyme OVIALUX S.A., prénommée, représentée par Monsieur Alain THILL, prénommé, en vertu d’une
procuration dont mention ci-avant;
a déclaré souscrire aux 26 (vingt-six) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, ainsi que de
verser la prime d’émission de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR
2.513.654,22 (deux millions cinq cent treize mille six cent cinquante-quatre euros et vingt-deux cents), ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le 1
er
paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
“ Art. 5. (Paragraphe 1). Le capital social est fixé à quatorze mille cent vingt-cinq euros (EUR 14.125) représenté par
deux cent vingt-six (226) parts sociales d’une valeur nominale de soixante-deux euros et cinquante cents (62,50 euros)
chacune."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cent soixante-quinze euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Alain THILL, Christina SCHMIT-VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2011. Relation GRE/2011/4868. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ronny PETER.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 mars 2012.
Référence de publication: 2012029247/76.
(120038507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Arrowgrass Special Situations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 140.239.
<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil de gérance en date du 08/03/2012i>
<i>Résolution uniquei>
Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et ce avec effet au 16702/2012.
45244
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 08/03/2012.
Taavi Davies
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2012030261/15.
(120039826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
PIT D Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.267.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.006.
En date du 29 février 2012, le Conseil de Gérance a pris la décision suivante:
- Transfert du siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, avec effet au 1
er
février 2012.
En date du 29 février 2012, le Conseil de Gérance a pris note que la nouvelle adresse professionnelle des gérants
suivants
- Robert-Jan Schol,
- Jorge Pérez Lozano,
est désormais au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 2 janvier 2012.
L'associé unique INVESCO PIT (Luxembourg) S.à r.l. a informé la société que son nouveau siège social se trouve
désormais au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2012.
<i>Pour la Société
i>Jorge Pérez Lozano
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012030557/23.
(120039898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Goodman Edelweis Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 161.985.
EXTRAIT
1. En date du 23 décembre 2011, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR a transféré 11,750 parts à
GELF investments (Lux) S.à r.l. ayant son siège social au 28 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,
2. En date du 23 décembre 2011, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR a transféré 750 parts à Blitz
11-609 GmbH & Co KG ayant son siège social a Bavariaring 29, c/o Blitzstart Holding AG, 80336 Munich, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Jesse Verbist
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012030398/17.
(120039888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Judo Club Stroossen, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2410 Strassen, rue de Reckenthal.
R.C.S. Luxembourg F 9.033.
STATUTS
Entre les soussignés:
Bertoli Loic - Fonctionnaire d'état, domicilié à 35, rue de Mersch, L-8293 Keispelt et de nationalité luxembourgeoise;
Mautes Stefan - Gesamtprojektleiter Infrastrukturmaßnahmen Rechenzentren in der Finanz Informatik, domicilié à 28,
rue de Lorraine, 57915 Woustviller / France et de nationalité allemande;
45245
L
U X E M B O U R G
Schüller Sören - Juriste, domicilié à 43, rte d'Eppeldorf, L-6312 Beaufort et de nationalité allemande;
Stelmes Charles - Professeur, domicilié à 22, Haaptstrooss, L-9360 Brandenbourg et de nationalité luxembourgeoise;
il a été convenu de former entre eux une association sans but lucratif conforme à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994
- texte coordonné du 4 mars 1994 sur les associations sans but lucratif et les fondations sans but lucratif, dite ci-après
«la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif».
Les soussignés conviennent de donner à l'association les statuts suivants:
Chapitre I
er
. De la dénomination, du siège social,
de la durée et de l'objet de l'association
Art. 1
er
. Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif, sous la dénomination «Judo Club Stroossen», en abrégé «JC Stroossen».
Art. 2. Le siège est établi dans la commune de Strassen au Grand-Duché de Luxembourg (rue de Reckenthal, L-2410
Strassen). Le siège pourra être transféré en tout endroit de la commune du siège social par simple décision du conseil
d'administration.
Art. 3. Sa durée est illimitée.
Art. 4. L'association a pour objet l'enseignement et la pratique du Judo et de toute discipline connexe comme sport
de loisir ou comme sport de compétition ainsi que toute activité nécessaire au bon accomplissement de l'objet social.
Chapitre II. Des membres
Art. 5. L'association se compose de membres actifs, de membres donateurs et de membres d'honneur. L'association
a au moins cinq membres actifs.
Art. 6.
a) La qualité de membre actif s'acquiert par une demande écrite adressée au conseil d'administration qui statuera à la
majorité simple.
b) Le conseil d'administration peut refuser l'admission à tout postulant sans être tenu de lui faire connaître les motifs
de sa décision. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
c) En cas d'acception de sa demande par le conseil d'administration, l'intéressé n'acquerra la qualité de membre définitif
que par l'obtention du passeport sportif de la Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux («FLAM») et par le paiement
de la cotisation annuelle et de la vignette de FLAM. Nul ne peut être membre actif sans être en possession du passeport
sportif de la FLAM.
d) Uniquement les membres actifs sont éligibles au conseil d'administration.
Art. 6 <i>bisi> . Peut être admis par le conseil d'administration comme membre donateur toute personne qui paie une
cotisation à fixer par l'assemblé générale et qui ne désire pas participer activement à la pratique du sport. Les membres
donateurs peuvent participer avec plein droit de vote à l'assemblée générale. Ils ne sont d'ailleurs pas éligibles au conseil
d'administration.
Art. 6 <i>teri> . Le titre honorifique de membre d'honneur peut être conféré par le conseil d'administration aux membres
de l'association qui ont rendu des services notables ou contribué par donation à celle-ci. Les anciens membres du conseil
d'administration sont de droit membres d'honneur, sauf démission ou exclusion selon la procédure de l'article 8 des
présents statuts.
Les membres d'honneur peuvent assister aux assemblées générales avec voix consultative. Ils ne sont ni électeurs ni
éligibles au conseil d'administration.
Art. 7. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d'administration; ce montant ne pourra pas
dépasser la somme de 500,- EUR (cinq cents euros).
Le paiement de la vignette FLAM (annuelle) et du passeport sportif FLAM est à la charge du membre actif.
Art. 8. La qualité de membre se perd:
a) par démission notifiée par lettre recommandée au conseil d'administration avant la prolongation de la licence FLAM.
b) par exclusion:
i. pour inconduite grave ou contravention grave ou répétée aux statuts et règlements de la FLAM ou de l'association,
ii. pour tout acte préjudiciable à l'objet social ou susceptible de porter atteinte à l'honneur, à la considération ou à la
réputation de l'association,
iii. pour non-paiement des cotisations visées à l'article 7 des présents statuts, 30 jours après réception d'une mise en
demeure unique notifiée par lettre recommandée ou remise en mains propres contre accusé de réception. Si après ce
délai l'intéressé n'a pas payé les cotisations échues, l'exclusion sera automatique; le membre reste tenu de payer la
cotisation échue et la licence émise à son nom.
45246
L
U X E M B O U R G
c) par décès.
L'exclusion visée à l'article 8 b) i et ii est proposée par le conseil d'administration à la l'assemblée générale; la convo-
cation prévoit dans son ordre du jour le vote sur l'exclusion.
Le conseil d'administration prépare pour les membres de l'association un rapport sur la motivation de la proposition
d'exclusion; ce rapport est envoyé par lettre recommandée au membre concerné qui dispose d'un délai de huit jours
pour soumettre au conseil d'administration une prise de position.
Les deux rapports peuvent être consultés par les membres de l'association au moins huit jours avant l'assemblée
générale. Aucune copie n'est délivrée; la convocation informe les membres de la mise à disposition des rapports.
Lors de l'assemblée générale, le membre concerné par l'exclusion est entendu dans ses arguments; il ne prend pas part
au vote, et il n'est pas présent au moment du vote.
L'exclusion est décidée par l'assemblée générale à la majorité simple des membres présents ou représentés.
En cas de perte de la qualité de membre suivant l'article 8, le membre qui a démissionné, qui aura été exclu ou en cas
de décès les héritiers dudit membre n'auront aucun droit sur le fonds social et ne pourront réclamer le remboursement
des frais versés, ni faire valoir des droits à l'encontre de l'association.
Chapitre III. De l'administration de l'association
Art. 9. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins et de quinze
membres au plus, élus à la majorité simple des membres présents à l'assemblée générale pour un terme de quatre ans. Il
est renouvelable par moitié tous les deux ans; la moitié sortante à la fin du premier exercice sera désignée par tirage au
sort.
Le conseil d'administration désigne en son sein un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui
forment le bureau du conseil d'administration.
Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire ou à la demande du tiers
de ses membres, et ce au moins une fois tous les deux mois.
Les convocations sont envoyées par lettre simple ou tout autre moyen approprié au moins trois jours avant la tenue
du conseil d'administration à tous les administrateurs; elles contiendront l'ordre du jour.
La présence de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des déli-
bérations. Si cette proportion n'est pas atteinte, le conseil d'administration est convoqué de nouveau, à dix jours au moins
d'intervalle, et peut cette fois délibérer valablement, quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents: en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre
Art. 11. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale par la loi ou
les présents statuts; il gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget
du prochain exercice. Il établit un rapport sur les activités de l'association pendant l'exercice social.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à une tierce
personne physique ou morale. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés soit aux organes
par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises
dans leur gestion.
Art. 12. L'association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de deux membres du bureau du conseil
d'administration, dont une doit obligatoirement être celle du président ou d'un vice-président.
Néanmoins, le défaut de signature ou l'absence de pouvoir de l'administrateur qui aura contracté avec un tiers au nom
de l'association ne pourront être opposés au tiers de bonne foi qui pouvait légitimement croire en la réalité des pouvoirs
de son cocontractant.
Art. 13. En cas de démission ou de décès d'un membre du bureau du conseil d'administration, les membres restants
désigneront en leur sein son remplaçant.
Art. 13 <i>bisi> . Tout membre du conseil d'administration qui aura manqué sans excuse 3 réunions consécutives, sera
considéré comme démissionnaire.
Chapitre IV. De l'assemblée générale et des comptes de l'association.
Art. 14. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. La première année commence à la constitution
de l'association et se termine au 31 décembre de l'année de constitution.
Art. 15. L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an au cours du troisième trimestre suivant la
fin de l'exercice social, aux fins d'approbation des comptes de l'exercice écoulé, de la lecture du rapport du conseil
45247
L
U X E M B O U R G
d'administration et de la décharge aux administrateurs ainsi que de l'examen du budget de l'exercice en cours. Elle procède
à l'élection des membres sortants du conseil d'administration.
Art. 16. L'assemblée est convoquée par les administrateurs dans les cas prévus dans les statuts et la loi ou lorsqu'un
cinquième des membres en fait la demande.
Art. 17. La convocation aux assemblées ordinaire et extraordinaire se fera par courriel adressée à tous les membres
de l'association au moins quinze jours avant la date de l'assemblée; elle contiendra la date, le lieu et l'heure de l'assemblée
et l'ordre du jour.
A moins que la loi n'en décide autrement, l'assemblée adopte les résolutions à la majorité simple des membres présents
ou représentés. Chaque membre actif et chaque membre donateur dispose d'une voix.
Si l'objet de l'assemblée est de statuer sur une modification des statuts, l'ordre du jour détaillera les modifications
proposées.
Aucune résolution ne pourra être prise en-dehors de l'ordre du jour à moins d'être approuvée par les trois quarts
des membres présents à l'assemblée.
Toute proposition, signée d'un vingtième des membres, doit être portée à l'ordre du jour.
Chaque membre pourra représenter au maximum deux membres associés.
Le président du conseil d'administration préside l'assemblée générale. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance
de poste du président, la présidence est assurée par le vice-président le plus ancien en rang ou, à défaut de vice-présidents,
par le membre du conseil d'administration le plus ancien en rang.
Le président de séance peut à tout moment décider de reporter l'assemblée générale de 30 jours au plus; il fixe la date
de la nouvelle assemblée générale séance tenante et convoque tous les membres de l'association à l'assemblée générale
reportée en donnant l'ordre du jour.
Par un tel report d'une assemblée générale, toute décision déjà adoptée lors de cette assemblée sera annulée.
Art. 18. L'assemblée générale statuant sur la modification des statuts devra être conforme aux dispositions de l'article
8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
En cas de dissolution il est renvoyé aux dispositions, de l'article 20 de la loi susmentionnée.
Art. 19. En cas de dissolution de l'association, le patrimoine social est versé à une oeuvre de bienfaisance à désigner
par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par le liquidateur nommé dans le respect des conditions de la loi du 21 avril
1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
Art. 20. L'association ne pourra recevoir de dons et autres libéralités que dans les conditions prévues aux articles 16
et 17 de la loi.
Loic Bertoli / Stefan Mautes / Sören Schüller / Charles Stelmes.
Référence de publication: 2012030140/150.
(120038358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
H.S.F.L. PAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 57.323.
L'an deux mille onze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme H.S.F.L. PAR S.A. (ci-après "la
Société"), avec siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg
section B numéro 57323, constituée suivant acte reçu par constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 121 du 13 mars 1997, et dont
les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Frank BADEN:
- en date du 24 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 103 du 19 février 1999;
- en date du 6 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 555 du 20 juillet 1999;
- dont le capital social a été converti et augmenté à six cent mille euros (600.000.- EUR), représenté par deux mille
quatre cents (2.400) actions avec une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250.- EUR) chacune, suivant décision
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 25 mai 2001, dont un extrait du procès-verbal
sous seing privé a été publié au Mémorial C numéro 66 du 12 janvier 2002.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 novembre
2004, publié au Mémorial C numéro 169 du 24 février 2005.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christina SCHMITVALENT, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
45248
L
U X E M B O U R G
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé
privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Mise en liquidation de la Société.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et
le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées "ne varietur" par les membres
du bureau et le notaire instrumentant.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.
IV.- Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé liquidateur de la société Monsieur Hervé Gérard DEROY, né le 4 septembre 1934 à Boulogne-Billancourt
(France), demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 19, boulevard Victor Hugo.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles
144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se conformer aux écritures de la société.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille cent cinquante euros, sont à la charge de la
Société.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Christina SCHMIT-VALENT, Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2011. Relation GRE/2011/4872. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ronny PETER.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations..
Junglinster, le 7 mars 2012.
Référence de publication: 2012029249/59.
(120038385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Horinvest S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-8010 Strassen, 210, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 56.563.
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “HORINVEST S.A.”, (ci-après la "Société"),
ayant son siège social à L-3831 Schifflange, 2, rue Dicks, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B,
sous le numéro 56563, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 11 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 657 du 18 décembre
1996,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
en date du 13 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 878 du 8 décembre
2000;
en date du 7 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1319 du 29 mai 2008.
45249
L
U X E M B O U R G
en date du 10 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 530 du 11 mars 2010.
en date du 28 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2230 du 21 septembre
2011.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Jun-
glinster, 3, route de Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jorge RODRIGUES DUARTE,
indépendant, demeurant à L-8010 Strassen, 210, route d’Arlon.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert de l’adresse du siège social vers L-8010 Strassen, 210, route d’Arlon, et modification afférente de l’article
4, alinéa 1
er
, des statuts.
2. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'assemblée décide de transférer l’adresse du siège social vers L-8010 Strassen, 210, route d’Arlon, et de modifier en
conséquence le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 4. (Premier alinéa). Le siège social est établi dans la Commune de Strassen, (Grand-Duché de Luxembourg).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jorge RODRIGUES DUARTE, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2011. Relation GRE/2011/4814. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ronny PETER.
Für gleichlautende Kopie erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 7. März 2012.
Référence de publication: 2012029269/59.
(120038484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Messer Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 81.804.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 26 octobre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45250
L
U X E M B O U R G
Esch/Alzette, le 25 novembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029378/13.
(120038234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 162.071.
Statuts coordonnés, suite à une déclaration rectificative reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à
Esch/Alzette, en date du 14 novembre 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 14 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029379/13.
(120038123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Central European Closures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 104.816.
Il résulte d’une lettre de démission datée du 5 mars 2012 que Monsieur Luc HANSEN a démissionné de son mandat
de gérant de catégorie B de la sociétéà responsabilité limitée CENTRAL EUROPEAN CLOSURES S.à r.l., inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 104 816, avec effet immédiat.
Il résulte d’une lettre de démission datée du 5 mars 2012 que Monsieur Thierry FLEMING a démissionné de son mandat
de gérant de catégorie B de la société à responsabilité limitée CENTRAL EUROPEAN CLOSURES S.à r.l., inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 104 816, avec effet immédiat
Luxembourg, le 8 mars 2012.
CF Corporate Services
Société Anonyme
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Référence de publication: 2012030306/18.
(120040124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Noble Drilling (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 135.475.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012029408/14.
(120038580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
45251
L
U X E M B O U R G
Discovery Group of Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 75.435.
EXTRAIT
Madame Ann-Charlotte Lawyer a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 31 janvier
2012. Il a été décidé de coopter Monsieur Anders Malcolm comme nouvel administrateur et président en remplacement
avec effet au 1
er
février 2012. Le mandat de Anders Malcolm prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2012.
La nomination de Monsieur Anders Malcolm comme nouvel administrateur sera soumise à la ratification lors de la
prochaine assemblée générale.
De ce fait le conseil d'administration de la Société se compose comme suit à partir du 1
er
février 2012:
- M. Anders Malcolm avec adresse professionnelle à 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg;
- M. Johan Sandberg, avec adresse professionnelle à 11, Hamngatan, S- 111 47 Stockholm;
- Mme Lise Merete Jørgensen, avec adresse professionnelle à 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012030352/19.
(120040098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Immo "Main Nascht" Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4422 Belvaux, 2, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 167.238.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-deux février.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
Angel PEPE, contrôleur qualité, né le 16 juillet 1962 à Moyeuvre-Grande/Moselle (France), demeurant à L-3643 Kayl,
18, rue de la Forêt.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-
personnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de IMMO "MAIN NASCHT" SARL.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Sanem.
Art. 3. La société a pour objet:
- toutes opérations immobilières,
- administrateur de biens -Syndic de copropriété,
- promoteur immobilier,
ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-
cinq (125.-) euros chacune.
Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
45252
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts ont été souscrites par Angel PEPE, contrôleur qualité, né le 16 juillet 1962 à Moyeuvre-Grande/Moselle
(France), demeurant à L-3643 Kayl, 18, rue de la Forêt. Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Frais.i>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850.-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire.i>
Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est
réuni en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-4422 Belvaux, 2, rue du Brill.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Angel PEPE, contrôleur qualité, né le 16 juillet 1962 à Moyeuvre-Grande/Moselle (France), demeurant à L-3643 Kayl,
18, rue de la Forêt. La société est engagée par la signature de la gérante unique.
<i>Déclarationi>
L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le béné-
ficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital
social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée
aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Pepe et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 29 février 2012. Relation EAC/2012/2713. Reçu soixante quinze euros 75.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Référence de publication: 2012029288/65.
(120038289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Neuheim Lux Group Holding V, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 137.498.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 28 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 27 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029393/13.
(120038129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Central European Cotton Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 101.750.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 5 mars 2012 que Monsieur Luc HANSEN a démissionné de son mandat
de gérant de catégorie B de la sociétéà responsabilité limitée CENTRAL EUROPEAN COTTON HOLDINGS S.à r.l.,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101 750, avec effet immédiat.
45253
L
U X E M B O U R G
Il résulte d'une lettre de démission datée du 5 mars 2012 que Monsieur Thierry FLEMING a démissionné de son mandat
de gérant de catégorie B de la société à responsabilité limitée CENTRAL EUROPEAN COTTON HOLDINGS S.à r.l.,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101 750, avec effet immédiat
Luxembourg, le 8 mars 2012.
CF Corporate Services
Société Anonyme
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Référence de publication: 2012030307/18.
(120039964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Gopal S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 400.000,00.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 162.960.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire en date du 7 février 2012i>
Nominations statutaires:
L'assemblée générale décide à l'unanimité de porter le nombre des membres du conseil d'administration à quatre
administrateurs.
L'assemblée nomme en qualité de nouvel administrateur pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2017:
- Mademoiselle Jennifer KLEIN
née le 17 août 1986 à Sarreguemines (F)
demeurant à L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012030408/18.
(120039747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Neuheim Lux Group Holding V, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 137.498.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 19 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 19 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029394/13.
(120038130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Neuheim Lux Group Holding V, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 137.498.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 4 janvier 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 3 février 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029395/13.
(120038176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
45254
L
U X E M B O U R G
Notre TV, Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 157.265.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2012.
Référence de publication: 2012029401/10.
(120038275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
HaMer Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 112.296.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 5 mars 2012 que Monsieur Luc HANSEN a démissionné de son mandat
de gérant de catégorie B de la sociétéà responsabilité limitée HAMER HOLDING S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 112 296, avec effet immédiat.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 5 mars 2012 que Monsieur Thierry FLEMING a démissionné de son mandat
de gérant de catégorie B de la société à responsabilité limitée HAMER HOLDING S.à r.l., inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 112 296, avec effet immédiat
Luxembourg, le 8 mars 2012.
CF Corporate Services
Société Anonyme
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Référence de publication: 2012030426/18.
(120039970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
LTP INVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, Société Anonyme - Société
de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 142.779.
In the year two thousand twelve, on the sixth day of February.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of “LTP INVEST S.A., a family asset management company
(société de gestion de patrimoine familial) (SPF for short)”, a société anonyme having its registered office in Luxembourg,
constituted by a deed of the undersigned notary on October 27, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C number 2902 of December, 4, 2008.
The meeting was opened by Mr Patrick AFLALO, company’s director, residing professionally in Luxembourg, being in
the chair,
who appointed as secretary Mrs Marie-Laure AFLALO, company’s director, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Philippe AFLALO, company’s director, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the corporate capital by an amount of two hundred thousand euros (EUR 200.000) to bring it from its
present amount of thirty-one thousand euros (EUR 31.000) to two hundred thirty-one thousand euros (EUR 231.000)
by issuance of twenty thousand (20.000) new shares with a par value of ten euros (EUR10,-) each having the same rights
and obligations as the existing shares.
2. Subscription and payment of the twenty thousand (20.000) new shares by Mr. Ngoc Tu TAO, director of companies,
born on 28/04/1963 in Thanh Hoa (Vietnam), residing at Ul. Marco Polo 9, 83-031 Legowo (Poland), by contribution in
cash.
3. Subsequent Amendment of article 5 Al. 1 of the Articles of Association.
4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed “ne varietur” by the shareholders, the proxy-
45255
L
U X E M B O U R G
holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took, by unanimous vote, the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of TWO HUNDRED THOUSAND
EURO (EUR 200,000) to bring it from its present amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (EUR 31,000) to
TWO HUNDRED THIRTY ONE THOUSAND EURO (EUR 231,000) by the issue of TWENTY THOUSAND (20,000)
new shares with a par value of TEN EURO (10.- EUR) each, having the same rights and advantages as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to accept the subscription and payment of the newly issued shares by the sole current
shareholder:
Mr. Ngoc Tu TAO, director of companies, born on 28 April 1963 in Thanh Hoa (Vietnam), residing at Ul. Marco Polo
9, 83-031 Legowo (Poland),
here represented by Mr Philippe AFLALO, prenamed,
by virtue of a proxy given on 25 January 2012,
who declares to subscribe the TWENTY THOUSAND (20,000) new shares and to fully pay them up by contribution
in cash of a total amount of TWO HUNDRED THOUSAND EURO (EUR 200,000).
The total amount of TWO HUNDRED THOUSAND EURO (EUR 200,000) is from now on at the disposal of the
Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Association, which will hen-
ceforth read as follows:
" Art. 5. (First paragraph). The corporate capital is set at TWO HUNDRED THIRTY ONE THOUSAND EURO (EUR
231,000) represented by TWENTYTHREE THOUSAND ONE HUNDRED (23,100) shares with a par value of TEN
EURO (10.- EUR) each.”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately ONE THOUSAND FOUR
HUNDRED EURO (1,400.-EUR).
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, preceded by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the appearing parties, who are known to the
notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le six février.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «LTP INVEST S.A., Société de Gestion
de Patrimoine Familial, en abrégé SPF», avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en
date du 27 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2902 du 4 décembre 2008.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
45256
L
U X E M B O U R G
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000) en vue de le
porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000) à deux cent trente et un mille euros (EUR 231.000)
par l’émission de vingt mille (20.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, émises au
pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2. Souscription et paiement des vingt mille (20.000) nouvelles actions par M. Ngoc Tu TAO, administrateur de sociétés,
né le 28 avril 1963 à Thanh Hoa (Vietnam), demeurant à Ul. Marco Polo 9, 83-031 Legowo (Pologne) par des versements
en numéraire.
3. Modification subséquente de l’article 5 alinéa 1 des statuts.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés.
III.- Qu’il appert de la liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou dûment représentées
à la présente assemblée, laquelle est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée,
sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de DEUX CENT MILLE EUROS (EUR
200.000,-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000) au montant de DEUX
CENT TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 231.000,-) par l’émission de VINGT MILLE (20.000) nouvelles actions d’une
valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la souscription et la libération des actions nouvellement émises, par l’action-
naire unique actuel de la société:
Monsieur Ngoc Tu TAO, administrateur de sociétés, né le 28 avril 1963 à Thanh Hoa (Vietnam), demeurant à Ul.
Marco Polo 9, 83-031 Legowo (Pologne),
ici représenté par Monsieur Philippe AFLALO, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25
janvier 2012;
lequel déclare souscrire les VINGT MILLE (20.000) actions nouvelles et les libérer entièrement par des versements
en espèces d’un montant total de DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 200.000).
Le montant total de DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 200.000) est dès à présent à la disposition de la société, ce
dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
« Art. 5. Alinéa 1. Le capital social est fixé à DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 231.000) représenté
par VINGT-TROIS MILLE CENT (23.100) actions d’une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de la présente est évalué à environ MILLE QUATRE CENTS EUROS (1.400.- EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau et aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. AFLALO, M.-L. AFLALO, P. AFLALO, G. LECUIT.
45257
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 février 2012. Relation: LAC/2012/6210. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2012.
Référence de publication: 2012029341/142.
(120038274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
New Net Lux Multiservices S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 156.390.
L'an deux mille onze, le vingt-et-un décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Fernand FRANCKEN, homme d'affaires, né à Paliseul (B) le 6 août 1943, demeurant à B-6700 Arlon, 10,
Place de l'Yser, et
2.- Mademoiselle Catherine FRANCKEN, gérante de sociétés, née à Libramont, le 17 mai 1964, demeurant à B-6700
Arlon, 24, rue du Lavoir
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "NEW NET LUX MULTISERVICES S.à r.l.", ayant son siège social à L-8399
Windhof, 11, route des Trois Cantons, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B, numéro 156.390, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 octobre 2010, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2649 du 3 décembre 2010. Les statuts n'ont pas été modifiés
depuis.
- Que le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-quatre euros (124,-EUR) chacune, entièrement libérées.
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social vers L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich et de modifier en consé-
quence le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. (1
er
alinéa). Le siège social est établi dans la Commune de Steinfort."
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 850,-EURs.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par son nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont touts signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Fernand FRANCKEN, Catherine FRANCKEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2011. Relation GRE/2011/4805. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ronny PETER.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 7 mars 2012.
Référence de publication: 2012029405/38.
(120038389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Corporate Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7516 Rollingen, 1, rue Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 136.341.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung der Firma Corporate Services Luxembourg S.à.r.L.i>
In der heute unter Verzicht auf Form- und Fristvorschriften startgefundenen ausserordentlichen Gesellschaflerver-
sammlung wurde von dem anwesenden Gesellschafter folgender Beschluss gefasst:
45258
L
U X E M B O U R G
1. Der Gesellschaftssitz der Corporate Services Luxembourg S.à.r.L. wird ab dem 01.03.2012 von der Adresse 14, Um
Mierschierberg, L-7526 Mersch an die neue Adresse 1, Rue Belle-Vue, L-7516 Rollingen verlegt
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Mersch, den 24. Februar 2012.
Falcon Beheer B.V.
Unterschrift
Référence de publication: 2012030314/16.
(120039851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Lumédia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 83.967.
L'an deux mille onze, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Lumédia S.A.", ayant son siège
social à L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 83.967, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 septembre
2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 919 du 24 octobre 2001. Les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 708 du 6 avril 2006.
La séance est présidée par Monsieur Alvin SOLD, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Monsieur le Président désigne comme secrétaires Monsieur Thierry ZIMBER, et Madame Sabrina GHARBI, employés,
demeurant professionnellement à Woippy, 3, avenue des deux Fontaines.
L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Danièle FONCK, administrateur et directrice générale, demeurant pro-
fessionnellement à Esch-sur-Alzette.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Libération du capital social.
2.- Augmentation de capital à concurrence de 100.000,- EUR pour le porter de son montant actuel à 1.100.000,- EUR,
par la création et l'émission de 100 actions nouvelles sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.
3.- Libération intégrale par conversion de deux avances actionnaires.
4.- Modification afférente de l'article 5, alinéa 1
er
des statuts.
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de libérer totalement le capital social d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) moyennant
un apport en nature constitué par la conversion partielle de deux avances actionnaires à hauteur d'un montant total de
sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR).
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, l'apport en nature ci-dessus décrit a
fait l'objet d'un rapport établi en date du 21 décembre 2011 par PricewaterhouseCoopers, réviseur d'entreprises, ayant
son siège social à Luxembourg, sous la signature de Monsieuir Pierre KRIER, réviseur d'entreprises, demeurant profes-
45259
L
U X E M B O U R G
sionnellement à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
Ledit rapport conclut comme suit:
<i>"Conclusioni>
Sur base de notre examen, aucun fait n'a été porté à notre connaissance qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie augmenté
de la prime d'émission.
Nous comprenons que cet apport servira à apurer une partie des pertes reportées dans un futur proche."
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de cent mille euros (100.000,-
EUR), pour le porter de son montant actuel à un million cent mille euros (1.100.000,- EUR), par la création et l'émission
de cent (100) actions nouvelles sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale constate que l'augmentation de capital prédécrite a été libérée par les actionnaires actuels au
prorata de leur participation actuelle, soit:
a) cinquante (50) actions, pour un montant total de neuf cent vingt-cinq mille euros (925.000,- EUR) par la société
anonyme de droit luxembourgeois EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-4002 Esch-sur-Alzette,
44, rue du Canal, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 5.407; dont cinquante
mille euros (50.000,- EUR) sont alloués au compte capital social de la société et le solde de huit cent soixante-quinze
mille euros (875.000,- EUR) au compte prime d'émission, et
b) cinquante (50) actions, pour un montant total de neuf cent vingt-cinq mille euros (925.000,- EUR) par la société
anonyme de droit français LE REPUBLICAIN LORRAIN S.A., ayant son siège social à F-57140 Woippy, 3, avenue des
deux Fontaines, inscrite au registre de commerce de Metz sous le numéro B 317169134; dont cinquante mille euros
(50.000,-EUR) sont alloués au compte capital social de la société et le solde de huit cent soixante-quinze mille euros
(875.000,- EUR) au compte prime d'émission.
Cette augmentation de capital a été intégralement libérée moyennant un apport en nature, constitué par la conversion
de deux avances actionnaires à hauteur d'un montant total d' un million huit cent cinquante mille euros (1.850.000,- EUR).
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, l'apport en nature ci-dessus décrit a
fait l'objet d'un rapport établi en date du 21 décembre 2011 par PricewaterhouseCoopers, réviseur d'entreprises, ayant
son siège social à Luxembourg, sous la signature de Monsieuir Pierre KRIER, réviseur d'entreprises, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
Ledit rapport conclut comme suit:
<i>"Conclusioni>
Sur base de notre examen, aucun fait n'a été porté à notre connaissance qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie augmenté
de la prime d'émission.
Nous comprenons que cet apport servira à apurer une partie des pertes reportées dans un futur proche."
Copie du rapport après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant resteront
annexées aux présentes.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des trois résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 5, alinéa 1
er
des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million cent mille euros (1.100.000,- EUR) divisé en mille cent (1.100)
actions sans désignation de valeur nominale."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève
approximativement à 4.000,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et
demeures, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Alvin SOLD, Thierry ZIMBER, Sabrina GHARBI, Danièle FONCK, Jean SECKLER.
45260
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2011. Relation GRE/2011/4877. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ronny PETER.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations..
Junglinster, le 7 mars 2012.
Référence de publication: 2012029343/106.
(120038235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Oven HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 143.898.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 janvier 2012.
Référence de publication: 2012029418/10.
(120038468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Algemene Nederlandse Beheermaatschappij S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R.C.S. Luxembourg B 80.766.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg, le 6 mars 2012i>
<i>à 10.00 heures.i>
L’Assemblée Générale a décidé de reconduire les mandats des membres du Conseil d’Administration, Monsieur Marius
Kaskas, 15 rue des Carrefours, L-8124 Bridel, Monsieur Yves Mertz, 15 rue des Carrefours, L-8124 Bridel, Monsieur Jean
Medernach, 10 rue de Pettingen, L-7554 Mersch et Monsieur Alexandros Konnidas, 15 rue Mavromatteon, 10434 Athènes,
Grèce.
L’Assemblée Générale a décidé de reconduire CER INTERNATIONAL SA, Withfield Tower, 4792 Coney Drive, Belize
city, Belize comme Commissaire aux Comptes.
Les mandats des administrateurs ainsi que du Commissaire aux Comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de l’an 2018.
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration de déléguer ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Marius Kaskas, prenommé. Ils sera donc
nommé administrateur-délégué et la société pourra ainsi être engagée par sa signature individuelle.
<i>Conseil d’Administrationi>
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration qui a eu lieu à Luxembourg, le 6 mars 2012 à 11.00 heures:i>
Le Conseil d’Administration délègue ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Marius Kaskas, prenommé. Son mandat prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale statutaire de l’an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2012031205/29.
(120041183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Pucchini Debt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 166.032.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 2 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45261
L
U X E M B O U R G
Esch/Alzette, le 3 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029436/13.
(120038295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Petro Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.127.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 5 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 5 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029445/13.
(120038284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Play & Win Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3487 Dudelange, 4, rue Henri Dunant.
R.C.S. Luxembourg B 167.252.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-deux février.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
Benoît VOGT, analyste financier, né à Noisy-le-Sec/Seine-Saint-Denis (France), le 9 mai 1980, époux de Murielle
BOHN, demeurant à L-3487 Dudelange, 4, rue Henri Dunant.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée
unipersonnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de PLAY & WIN SARL.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Dudelange.
Art. 3. La société a pour objet l'édition de jeux de société ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400.-) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)
parts de cent (100.-) euros chacune.
Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts ont été souscrites par Benoît VOGT, analyste financier, né à Noisy-leSec/Seine-Saint-Denis (France), le 9
mai 1980, époux de Muriellle BOHN, demeurant à L-3487 Dudelange, 4, rue Henri Dunant.
45262
L
U X E M B O U R G
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850.-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-3487 Dudelange, 4, rue Henri Dunant.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérante, pour une durée illimitée:
Murielle BOHN, assistante sociale, née à Sarrebourg/Moselle (France), le 30 septembre 1980, demeurant à L-3487
Dudelange, 4, rue Henri Dunant.
La société est engagée par la signature du gérant unique.
<i>Déclarationi>
L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le béné-
ficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital
social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée
aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, Il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Vogt et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 29 février 2012. Relation EAC/2012/2714. Reçu soixante quinze euros 75.-
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
Référence de publication: 2012029452/64.
(120038534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Montecin Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 161.691.
EXTRAIT
En date du 1
er
mars 2012, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de:
- confirmer le mandat de Madame Danielle (Danièle) Arendt-Michels en tant que présidente du conseil d'administration
avec effet au 22 juin 2011, pour une durée limitée se terminant à la date de l'assemblée générale des associés approuvant
les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2016;
- nommer avec effet immédiat Monsieur Nicolas Paulmier, né le 30 avril 1964 à Nancy (France) résident profession-
nellement à Warwick Court, Paternoster Square, Londres GB-EC4M 7AG membre du conseil d'administration pour une
durée limitée se terminant à la date de l'assemblée générale des associés approuvant les comptes annuels de la Société
au 31 décembre 2016;
- nommer avec effet immédiat Monsieur David Konings né le 26 avril 1977 à Liège (Belgique) résident professionnel-
lement au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, membre du conseil d'administration pour une durée limitée se
terminant à la date de l'assemblée générale des associés approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre
2016; et
- terminer avec effet immédiat le mandat de Monsieur Benoit Valentin en tant que membre du conseil d'administration.
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- Madame Danielle (Danièle) Arendt-Michels (présidente)
- Monsieur Nicolas Paulmier
- Monsieur David Konings
45263
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012031675/29.
(120040923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
Re Schools S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.022.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 5 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 5 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029458/13.
(120038111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Regina Investment SE, Société Européenne.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.880.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 30 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 30 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012029459/13.
(120038221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
PEF V Information Technology II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 110.314.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 5 mars 2012 que Monsieur Luc HANSEN a démissionné de son mandat
de gérant de catégorie A1 de la sociétéà responsabilité limitée PEF V INFORMATION TECHNOLOGY II S.à r.l., inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 110 314, avec effet immédiat.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 5 mars 2012 que Monsieur Guy HORNICK a démissionné de son mandat
de gérant de catégorie A1 de la société à responsabilité limitée PEF V INFORMATION TECHNOLOGY II S.à r.l., inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 110 314, avec effet immédiat
Luxembourg, le 8 mars 2012.
CF Corporate Services
Société Anonyme
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Référence de publication: 2012030548/18.
(120039976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
45264
Adagio S.A.
Ahlo S.A.
Algemene Nederlandse Beheermaatschappij S.A.
Amundi Funds
Arrowgrass Investments S.à r.l.
Arrowgrass Special Situations S.à r.l.
Central European Closures S.à r.l.
Central European Cotton Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Corporate Services Luxembourg S.à r.l.
Discovery Group of Funds
DPP Luxembourg Branch
Eurofins Scientific SE
Fumilux S.A.
Goodman Edelweis Logistics (Lux) S.à r.l.
Gopal S.A.
Guilbaud S.à r.l.
GVP Immobilier
HaMer Holding S.à r.l.
H.F. S.A.
Horinvest S.A.
H.S.F.L. PAR S.A.
Immo "Main Nascht" Sàrl
INNCONA S.àr.l. & Cie. Trois cent vingt et unième (321.) S.e.c.s.
Interactive Creatures Environment Limited S.à r.l.
Judo Club Stroossen
KKR Asia S. à r.l.
Lehnkering HoldCo S.à r.l.
LSREF2 Triangle Investments S.à r.l.
LTP INVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF
Lumédia S.A.
Lux-World Fund Advisory S.A. Holding
Macsteel Holdings Luxembourg S.à r.l.
MAJIMA, Société Civile Immobilière (S.C.I.)
Marguerite Wind S.à r.l.
MEIF II Luxembourg Communications S.à r.l.
Mermaid S.A.
Messer Finance S.A.
MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l.
Montecin Luxembourg S.A.
Neuheim Lux Group Holding V
Neuheim Lux Group Holding V
Neuheim Lux Group Holding V
New Net Lux Multiservices S.à r.l.
Noble Drilling (Luxembourg) S.à r.l.
Notre TV
OCTA
Oven HoldCo S.à r.l.
PEF V Information Technology II S.à r.l.
Petro Lux S.à r.l.
PIT D Lux S.à r.l.
Play & Win Sàrl
Pucchini Debt S.à r.l.
Regina Investment SE
Re Schools S.à r.l.