This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 928
11 avril 2012
SOMMAIRE
AMP Capital Investors (Luxembourg No.
5) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44528
Arkess Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44501
Ayu Holding S.A., société de gestion de pa-
trimoine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44527
Bairlinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44521
Cleome Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44500
COLUPA S.A., Société de Gestion de Pa-
trimoine Familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44518
Confira Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44514
Decopress SA SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44519
Dexia Overseas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44513
E.H.I. Euro Hotel Investments S.A. . . . . . .
44518
EIRSP Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
44530
EnVivo International III S.à r.l. . . . . . . . . . .
44522
EnVivo International I S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
44526
EnVivo (Luxembourg) I S.à r.l. . . . . . . . . . .
44526
Expert Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44525
Expert Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44525
Garden Projektentwicklung GmbH . . . . . .
44540
Gutland Mëllech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44520
Holzbau Henz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44524
INREDE S.A. (International Nippon Real
Estate Development & Finance S.A.) . . .
44517
Jovest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44520
Katrann Private SA SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
44521
Kaupthing Manager Selection . . . . . . . . . . .
44500
MCP III Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
44536
Medicover Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44514
Mutualité d'Aide aux Artisans . . . . . . . . . . .
44515
Orco Property Group . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44501
PARTELL HOLDING (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44521
RAU & RAU Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . .
44521
Rebrifi SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44520
REIL (Real Estate Investments in Luxem-
bourg) S.A. (Soparfi) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44525
Restaurant Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
44523
Restaurant Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
44524
Retail Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44525
Retail Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44525
Rivaty Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44529
Robeco Lux-O-Rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44499
Roberta Di Camerino S.A. . . . . . . . . . . . . . .
44539
Rose Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44539
RS-IC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44540
Saserna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44519
Scanship Environmental Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44540
SEB SICAV 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44499
SHB Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44515
Sisto Armaturen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44534
Société anonyme des Entreprises Minières
S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44499
SPL Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44498
State Street Global Advisors Luxembourg
SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44498
Thryn Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44535
Tokelia S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44518
Tolomei Partenaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
44517
Utopia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44513
Vahina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44519
44497
L
U X E M B O U R G
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.816.
We are pleased to invite the shareholders to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders (the “Meeting”) of State Street Global Advisors Luxembourg Sicav (the “Company”), which will be
held on <i> April 26 i>
<i>thi>
<i> , 2012 i> at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the annual report including the investment manager's and the Réviseur d'entreprises agréé's reports
for the financial year ended December 31
st
, 2011.
2. Allocation of the results.
3. Discharge to be granted to the directors with respect to the performance of their duties during the financial year
ended December 31
st
, 2011.
4. Re-election of Mr. Patrick Armstrong, Mr. Benoit Fally and Ms. Susanne van Dootingh as directors of the Company
until the next annual general meeting to be held in 2013 and election of Mr. John Li-How-Cheong as new director
of the Company until the annual general meeting to be held in 2013 subject to the CSSF approval.
5. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as Réviseur d'entreprises agréé of the Company to hold office until
the next annual general meeting to be held in 2013.
6. Any other business which may be properly brought before the Meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder
may act at any Meeting by proxy.
The annual report including the investment manager's and the Réviseur d'entreprises agréé's reports for the financial
year ended December 31
st
, 2011, can be obtained upon request at the registered office of the Company by fax: + 352
46 40 10 413 or by e-mail at Luxembourg-Finrep3@statestreet.com
A proxy form may be obtained at the registered office's address and has to be returned by fax no later than 48 hours
before the Meeting to the attention of Ms. Candice Mayembo at the fax number +352 46 40 10 413 and by mail to the
registered office's address.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012042813/755/32.
SPL Gestion, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 156.431.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Sicav SPL GESTION à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>30 avril 2012i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé
6. Nominations statutaires
7. Divers.
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs
avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 49 924 2501) de leur intention d'assister à l'Assemblée.
Référence de publication: 2012042814/755/22.
44498
L
U X E M B O U R G
SEB SICAV 3, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 146.761.
Notice of the
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
to be held on <i>30 April 2012i> at 4:00 p.m. at the registered office of the Company for the purpose of considering and
voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the report of the Board of Directors and the Approved Statutory Auditor
2. Approval of the audited annual report as of 31 December 2011
3. Allotment of results
4. Discharge to all Directors in respect of carrying out their duties during the period ending on 31 December 2011
5. Statutory elections
6. Miscellaneous
VOTING
Resolutions will be passed without a quorum, and therefore by the simple majority of the votes cast at the Meeting.
VOTING ARRANGEMENTS
Shareholders who are unable to attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy
form to the registered office of the Company to arrive before 24 April 2012.
<i>THE BOARD OF DIRECTORS.i>
Référence de publication: 2012042815/755/23.
S.A.D.E.M. S.A., SPF, Société anonyme des Entreprises Minières S.A., SPF, Société Anonyme - Société
de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 6.016.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2012i> à 15.00 heures au siège social, 1, rue Joseph Hackin à Luxembourg, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012042816/755/19.
Robeco Lux-O-Rente, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 47.779.
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders to be held on <i>31 May 2012i> at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, at 2 p.m.
<i>Agenda:i>
1. Nomination of the President of the Meeting
2. Report of the board of directors and auditors' report
3. Consideration and approval of the annual accounts for the financial year 2011
4. Consideration and approval of the profit appropriation for each of the sub-funds for the financial year ended 31
December 2011
5. Discharge of the board of directors
44499
L
U X E M B O U R G
6. Statutory appointments
7. Any other business
The Annual report 2011 may be obtained at the registered office of the Corporations. This report is also available via
www.robeco.com. The resolutions on the Agenda will not require a quorum and will be taken at a simple majority of the
votes cast. Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders wishing to attend and/or vote at the respective
meetings should inform the respective Corporations through Mrs. V. Delvael, RBC Dexia Investor Services Bank S.A.,
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg in writing not later than 24 May 2012 (fax: + 352 24603331).
Luxembourg, 11 April 2012.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012042817/755/23.
Kaupthing Manager Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 72.942.
The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of KAUPTHING MANAGER SELECTION to attend
the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Sicav on <i>30 April 2012i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2011
3. Allocation of the results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Independent Auditor
6. Statutory elections
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken by simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the Sicav. Shareholders, who
wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501 -
ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the annual general meeting.
Référence de publication: 2012042818/755/22.
Cleome Index, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 72.234.
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires («l'Assemblée») de CLEOME INDEX aura lieu au siège social de la société, 69, route d'Esch, L-1470
Luxembourg le <i>27 avril 2012i> à 11 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 décembre
2011
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre
2011
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2011
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers
Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les
décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de
s'inscrire avant le 25 avril 2012 auprès de CLEOME INDEX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention de Fund
Corporate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331).
Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
calendaires avant l'Assemblée aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social
de la société ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.
44500
L
U X E M B O U R G
CLEOME INDEX
<i>CONSEIL D'ADMINISTRATIONi>
Référence de publication: 2012042819/755/29.
Arkess Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.873.
Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Fund, to be held on <i>30th April, 2012i> at 2:00 p.m. at the Fund's registered office located 41, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, with the following Agenda :
<i>Agenda:i>
1. Acquaintance with the Board of Director's report and the Independent Auditor's report
2. Approval of the annual report, i.e. balance sheet and profit and loss account, as at 31st December, 2011
3. Allocation of results, as proposed by the Board i.e. carrying forward of the results
4. Discharge of the Directors for the performance of their duties during the financial year ending on 31st December,
2011
5. Statutory nominations i.e:
- Renewal of mandates of Sylvain Feraud, Margherita Balerna Bommartini and Arnaud Bouteiller
6. Nomination of Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée as auditor for the Fund in replacement of the former
for the accounting year ending on 31st December 2012, subject to CSSF approval
7. Miscellaneous
The annual report of the Fund as at 31st December, 2011 is available at the Fund's registered office.
Shareholders are advised that the meeting does not have to be quorate in order to pass valid resolutions. To be
accepted, valid resolutions only require a majority of shareholders actively present or represented.
Shareholders or their proxies wishing to take part in the Meeting are kindly requested to inform the Fund at least five
clear days prior to the holding of the Meeting of their intention to attend. They shall be admitted subject to verification
of their identity and evidence of their shareholding.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the meeting at the registered office of the Fund.
Proxy forms are available at the Fund's registered office.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012042820/755/31.
Orco Property Group, Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 44.996.
A GENERAL MEETING
of the holders of bonds (the "Bondholders") registered under ISIN FR0010333302 (the "Bonds 2013") as described in
the Prospectus (as defined below) issued by the Company in relation to the issue on June 1, 2006 of EUR 149,999,928,
1 per cent convertible bonds, at an issue price: EUR 138, represented by 1,086,956 convertible bonds with a par value
of EUR 145, for which the visa on the prospectus was delivered by the CSSF on May 17, 2006 (the "Prospectus"), will be
held at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>April 27, 2012i> at 9:30 AM Central
European time ("CET") (the "Bondholders Meeting"), in order to consider and resolve on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Decision to appoint, with immediate effect, a new représentant de la masse
1
and to determine its powers, including,
but not limited to, the delegations of powers referred to in 3. and 4. hereafter.
2. Approval of the terms and conditions of the exchange of up to 89.9 % of all Bonds 2013 for a consideration consisting
in newly issued common shares (the "Shares") of the Company ("OPG Conversion"), including but not limited to,
discussion and approval of the terms and conditions of the OPG Conversion (as such terms may be amended),
approval of all steps and actions, and entering into and performance of all the transactions, documents, agreements
contemplated, needed or useful in connection with the OPG Conversion, after presentation to the Bondholders
of (i) interim accounting situation of the Company, reviewed and certified by its auditor and (ii) a report established
by the board of directors of the Company, explaining the reasons of the OPG Conversion.
44501
L
U X E M B O U R G
3. Delegation of power for implementation of the OPG Conversion to one of the représentant de la masse, including,
but not limited to, the power and mandate to finalize the terms and conditions of the OPG Conversion and to
negotiate and agree the final terms and conditions of the OPG Conversion, subject to any non-substantial changes
to such terms and conditions of the OPG Conversion, as approved by the meeting, to negotiate, finalize and sign
any document, (including, but not limited to, any contribution agreement or subscription agreement) in connection
with the OPG Conversion and the subscription of the Shares on behalf of the Bondholders and to redistribute the
Shares to the Bondholders, and power to perform and execute all steps and actions, and entering into and per-
formance of all the transactions, documents, agreements contemplated, needed or useful in connection with the
OPG Conversion, including, but not limited to, informing the Commissaire à l'exécution du Plan of the Bondholders'
approval of the OPG Conversion and the corresponding proposed modifications of OPG's Plan de sauvegarde,
further to the official notification of such proposed modifications to be issued by the Greffe du Tribunal de com-
merce de Paris to the représentant de la masse pursuant to article R. 626-45 of the French Commercial Code, in
the course of OPG's Plan de sauvegarde's modification procedure.
4. Decision (a) to finally and definitively waive and withdraw the current lawsuits against the Company (including the
tierce opposition as well as the appeals against the supervisory judge's orders regarding the requêtes en interpré-
tation, it being specified, for the avoidance of doubt, that the Bondholders' representative shall be instructed to file
"conclusions de désistement d'instance et d'action" in the course of such proceedings according to the French Civil
Procedure Code as soon as all the conditions referred to in clause II. 6. (v) of Annex A of the present convening
notice related to the proposed OPG Conversion shall have been met) and (b) not to further challenge the judgment
dated 19 May 2010 adopting the Plan de Sauvegarde of the Company.
5. Miscellaneous.
Please refer to Annex A attached to the present notice and the Company's website at www.orcogroup.com for further
details pertaining to the proposed OPG Conversion.
Note: The Bondholders Meeting shall not validly deliberate on the agenda mentioned above, unless at least one half
of the total number of the Bonds 2013 outstanding at the time of the Bondholders Meeting is represented.
If such proportion of the total number of the Bonds 2013 is not met, a second meeting may be convened, by means
of notices published twice at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations and in two Luxembourg newspapers. The second meeting shall validly deliberate regardless
of the proportion of the Bonds 2013 represented.
At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two thirds (2/3) of the votes cast
by the Bondholders present or represented.
The Bondholders participation form which is necessary to participate to the Bondholders Meeting is at the disposal
of the Bondholders as from the date of publication of the present notice, at the registered office of the Company upon
request or downloaded from the Company's website at www.orcogroup.com or ultimately upon request to the financial
intermediaries or to the relevant central registration bank.
The auditor's report on review of interim financial information of the Company, to be presented to the Bondholders
Meeting are at the disposal of the Bondholders at the registered office of the Company upon request or downloaded
from the Company's website at www.orcogroup.com or ultimately upon request to the financial intermediaries or to the
relevant central registration bank.
The report of the Company's board of directors, explaining the reasons of the OPG Conversion, to be presented to
the Bondholders Meeting are at the disposal of the Bondholders at the registered office of the Company upon request
or downloaded from the Company's website at www.orcogroup.com or ultimately upon request to the financial inter-
mediaries or to the relevant central registration bank.
The proposed terms and conditions of the OPG Conversion are at the disposal of the Bondholders at the registered
office of the Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogroup.com or ultimately
upon request to the financial intermediaries or to the relevant central registration bank.
Copies of the Prospectus, the articles of association of the Company are available on the Company's website at
www.orcogroup.com and at the registered office of the Company upon request.
The board of directors of the Company would like to point out that for Bondholders whose ownership is directly or
indirectly recorded in the Bond registry of the Company, the conditions for attendance or representation at the Bond-
holders Meeting are as follows:
1. Conditions for personal attendance
<i>(i) Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company
i>Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company and who elect to attend
the Bondholders Meeting in person must use their usual applicable contacting method for informing their financial inter-
mediary, with whom their Bonds 2013 are on deposit, accordingly. They must further request their financial intermediary,
with whom their Bonds 2013 are on deposit, to send a Bondholders blocking certificate (the "Bondholders blocking
certificate") for their Bonds 2013 to the relevant central registration bank no later than 5 business days prior to the
Bondholders Meeting.
44502
L
U X E M B O U R G
Such blocking certificate must indicate clearly the precise identity of the Bondholder, the number of Bonds 2013 being
blocked, the date such Bonds 2013 are being blocked, which must be no later than April 23, 2012 and a statement that
the relevant Bonds 2013 are registered in the local bank or brokers records in the holder's name and shall be blocked
until the close of the Bondholders Meeting.
The Bondholders must bring a copy of the Bondholders blocking certificate to the Bondholders Meeting.
The Bondholders shall also announce their intention to participate at the Bondholders Meeting by completing, signing,
dating and returning on no later than April 23, 2012 at the latest to the relevant central registration bank or to the
Company (ORCO PROPERTY GROUP S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or
Mrs. Françoise de Jongh, département juridique), the Bondholders participation form that can be obtained at the registered
office of the Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogroup.com or ultimately
upon request to the financial intermediaries or the relevant central registration bank.
<i>(ii) Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company
i>Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company, shall announce their intention
to participate to the Bondholders Meeting by completing, signing, dating and returning on April 23, 2012, at the latest to
the relevant central registration bank or to the Company (ORCO PROPERTY GROUP S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique) the Bondholders participation
form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or downloaded from the Company's
website at www.orcogroup.com or ultimately upon request to the financial intermediaries or the relevant central regis-
tration bank.
2. Conditions for proxy voting or granting a mandate
<i>(i) Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company
i>Bondholders whose ownership is indirectly recorded in the bond registry of the Company and who are unable to
attend the Bondholders Meeting in person, may give a voting instruction to a third party that the Bondholder designates.
Prior to giving voting instructions to a proxy, this Bondholder must a) have obtained and delivered to the relevant
central registration bank the Bondholders blocking certificate described above (see "Conditions for personal attendance"),
and b) complete, sign and date the Bondholders participation form that can be obtained at the registered office of the
Company upon request or downloaded from the Company's website at www.orcogroup.com or ultimately upon request
to the financial intermediaries or the relevant central registration bank, indicating the name of the proxy.
The completed, signed and dated Bondholders participation form must be returned to the relevant central registration
bank or to the Company (ORCO PROPERTY GORUP S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe
Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique) no later than April 23, 2012, at the latest, in order to have
that name recorded on the registration list of the Bondholders Meeting.
If a Bondholder wishes to be represented by a proxy other than the Chairman of the Bondholders Meeting, then this
holder must (a) have obtained and delivered to the relevant central registration bank the Bondholders blocking certificate
described above (see "Conditions for personal attendance"), and (b) complete, sign and date the Bondholders participation
form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or downloaded from the Company's
website at www.orcogroup.com or ultimately upon request to the financial intermediaries or the relevant central regis-
tration bank, indicating the name of the proxy. The completed, signed and dated Bondholders participation form must
be returned to the relevant central registration bank or to the Company (ORCO PROPERTY GROUP S.A., 42, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique) no later
than April 23, 2012, at the latest, in order to have that name recorded on the registration list of the Bondholders Meeting.
Bondholders who have obtained the Bondholders blocking certificate and have executed a Bondholders participation
form but who wish to revoke such proxy may do so at any time by timely delivering a properly executed, later dated
participation form no later than April 23, 2012, at the latest, or by properly attending and voting in person at the Bond-
holders Meeting.
Simply attending the Bondholders Meeting without voting will not revoke the proxy.
<i>(ii) Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company.
i>Bondholders whose ownership is directly recorded in the bond registry of the Company must complete, sign and date
the Bondholders participation form that can be obtained at the registered office of the Company upon request or down-
loaded from the Company's website at www.orcogroup.com or ultimately upon request to the financial intermediaries
or the relevant central registration bank.
The completed, signed and dated Bondholders participation form must be returned to the relevant central registration
bank or to the Company (ORCO PROPERTY GROUP S.A., 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, to Mr. Christophe
Le Priol or Mrs. Françoise de Jongh, département juridique) no later than April 23, 2012, at the latest.
3. Request for information and central registration banks
Bondholders looking for more information can do so by:
44503
L
U X E M B O U R G
<i>(i) contacting the Company's services directly:
i>* At the registered office of the Company- Legal Department
Tel.: +352 26 47 67 1
Fax.: +352 26 47 67 67
<i>(ii) contacting one of the central registration banks:
i>* For Bonds 2013 that are included in the Clearstream Banking or Euroclear Bank system and that are admitted to
trading on the Euro MTF:
CACEIS Corporate Trust
Service assemblées
14 rue du Rouget de Lisle F-92889 Issy les Moulineaux
Fax : +33 1.49.08.05.82
Email: CT-Contact@caceis.com
Luxembourg, April 11, 2012.
<i>The Board of Directors of the Company.i>
ANNEX A:
PROPOSED TERMS AND CONDITIONS OF THE OPG CONVERSION
The OPG Bonds: The following bond issues (each a "Tranche"), all of which are subject to the terms and conditions
of the plan de sauvegarde of the Company as approved by the Paris Commercial Court on 19 May 2010 (the "Plan de
Sauvegarde"):
* € 50,272,605.30 OBSAR 1 bonds issued by OPG on 18 November 2005 (ISIN - FR0010249599, "OPG Bonds 2010");
* CZK 300,000,000.00 Czech Bonds issued by OPG on 3 February 2006 (ISIN - CZ0000000195, "OPG Bonds 2011").
As of the date of this document, €11,631,934 of nominal OPG Bonds 2011 remain outstanding;
* € 149,999,928.00 Convertible Bonds issued by OPG on 1 June 2006 (ISIN - FR0010333302 , "OPG Bonds 2013");
* € 175,000,461.60 OBSAR 2 bonds issued by OPG on 28 March 2007 (ISIN - XS0291838992 / XS0291840626, "OPG
Bonds 2014"); and
* € 24,169,193.39 Exchangeable Bonds in Suncani Hvar Shares issued by OPG on 30 June 2005 (ISIN - XS0223586420,
"OPG Bonds 2012").
together, the "OPG Bonds" and holders thereof, "OPG Bondholders".
The OPG Bonds are deemed to correspond to an aggregate amount of €548.5m (the "Claim") for the sole purpose
of the Transaction and only if the Transaction is fully implemented.
The OG Bonds: € 100,100,052 five-year bonds issued by OG as per a prospectus dated 24 May 2007 (ISIN -
XS0302623953, the "OG Bonds" and holders thereof, "OG Bondholders"). The OG Bonds correspond to a global amount
of €129.1 million including accrued interests and reimbursement premium.
Overview of the Transaction: The transaction proposed by an ad-hoc committee of OPG Bondholders representing
approximately 1/3 of the nominal value of the OPG Bonds (the "Transaction") contemplates a restructuring launched by
the Company whereby the OPG Bonds would be exchanged for a consideration consisting of (i) newly issued common
shares of the Company (the "Shares") and (ii) new debt instruments.
In case of scenario 2 as described below, Transaction shall mean a restructuring launched by the Company whereby:
* the OPG Bonds would be exchanged for a consideration consisting of (i) newly issued common shares (the "Shares")
of the Company and (ii) new debt instruments (the "OPG Transaction"); and
* the OG Bonds would be exchanged for a consideration consisting of (i) new bonds to be issued by OPG and
convertible into shares of the Company, OG shares or cash (the "OCA") and (ii) new debt instruments (the "OG Trans-
action").
I. KEY ECONOMIC TERMS
The proposed Transaction shall consist in:
A. Scenario 1 (transaction with OPG Bondholders only, in all cases other than those set out under scenario 3 below) :
(i) The mandatory exchange of 86.3% of the number of the OPG Bonds of each Tranche for new Shares to be issued
upon a decision of the extraordinary general meeting ("EGM") of the shareholders of OPG (the "OPG Equity Consider-
ation 1"),
it being specified that, subject to the conditions set out below, the mandatory exchange will not be carried out for any
Tranche unless it is carried out for the OPG Bonds 2010, the OPG Bonds 2013 and the OPG Bonds 2014 Tranches, and
(ii) The exchange on a voluntary basis of the remaining OPG Bonds of each Tranche, the mandatory exchange of which
as referred to in A.(i) above has been performed, against new bonds to be issued by OPG within the framework of a
public exchange offer (the "New Notes Consideration 1"). Any outstanding OPG Bonds not exchanged on a voluntary
basis shall retain the terms and conditions as per the Plan de Sauvegarde.
44504
L
U X E M B O U R G
(iii) The free allocation to each existing shareholder of OPG of one warrant per OPG share, that would each give right
to the subscription of one new Share at a price of € 4.10, with a 3-month maturity.
(iv) In this scenario, OPG shall not, and procures that OG shall not, offer to the OG Bondholders any consensual
transaction that would provide economic terms and conditions more favorable for the OG Bondholders than those
approved by the OG Bondholders' meeting on 5 April 2012.
B. Scenario 2 (global transaction with both OPG Bondholders and OG Bondholders):
(i) The mandatory exchange of:
a) for the OPG Bonds, 89.9% of the number of the OPG Bonds of each Tranche for new Shares to be issued upon a
decision of the EGM of the shareholders of OPG (the "OPG Equity Consideration 2"); it being specified that, subject to
the conditions set out below, the mandatory exchange will not be carried out for any Tranche unless it is carried out for
the OPG Bonds 2010, the OPG Bonds 2013 and the OPG Bonds 2014 Tranches, and
b) for the OG Bonds, 84.5% of the number of the OG Bonds for new bonds convertible into Shares (the "OCA") to
be issued upon a decision of the board of directors of OPG (the "OG Equity Consideration");
(ii) the exchange on a voluntary basis of :
a) the remaining OPG Bonds of each Tranche, the mandatory exchange of which as referred to in B.(i)(a) above has
been performed, against new bonds to be issued by OPG within the framework of a public exchange offer (the "New
Notes Consideration 2"). Any outstanding OPG Bonds not exchanged on a voluntary basis shall retain the terms and
conditions as per the Plan de Sauvegarde;
b) the remaining OG Bonds, after the mandatory exchange as referred to in B.(i)(b) above has been performed, against
new bonds to be issued by OPG within the framework of an exchange public offer (the "OG New Notes Consideration").
The terms and conditions of any outstanding OG Bonds not exchanged on a voluntary basis shall be amended to have
their maturity postponed to 2050 and their interest rate lowered to 0.5% per annum, with effect immediately after the
closing of the voluntary public exchange offer.
If an agreement on scenario 2 is reached with certain of the OG Bondholders no later than 17 April 2012, then scenario
2 shall prevail.
C. Scenario 3 (transaction with OPG Bondholders only in case the OPG Bond Conversion Condition is fulfilled, as
defined in the terms and conditions of the OCA approved by the OG Bondholders general meeting of April 5, 2012, it
being agreed that under such scenario the OG Bondholders shall convert 100% of their claims under the OG Bonds into
OPG equity instruments for no more than 27.2 million Shares and shall not receive any OG equity instruments nor any
debt consideration):
(i) The mandatory exchange of 73.6% of the number of the OPG Bonds of each Tranche for new Shares to be issued
upon a decision of the extraordinary general meeting ("EGM") of the shareholders of OPG (the "OPG Equity Consider-
ation 3"),
it being specified that, subject to the conditions set out below, the mandatory exchange will not be carried out for any
Tranche unless it is carried out for the OPG Bonds 2010, the OPG Bonds 2013 and the OPG Bonds 2014 Tranches, and
(ii) The exchange on a voluntary basis of the remaining OPG Bonds of each Tranche, the mandatory exchange of which
as referred to in C.(i) above has been performed, against new bonds to be issued by OPG within the framework of a
public exchange offer (the "New Notes Consideration 1"). Any outstanding OPG Bonds not exchanged on a voluntary
basis shall retain the terms and conditions as per the Plan de Sauvegarde.
I-1. OPG Equity Consideration
1. Size of Share Issue:
Under scenario 1:
97,900,000 Shares for a value of € 473.3 million; or
Under scenario 2:
65,000,000 Shares for a value of € 493.3 million; or
Under scenario 3:
45,000,000 Shares for a value of € 403.8 million.
2. Subscribers to the Shares Issue: OPG Bondholders will be reserved the subscription to the Shares by way of exchange
with their OPG Bonds.
For all Tranches, the ratio for the exchange of OPG Bonds for new Shares shall be defined pro rata of the portion of
the Claim allocated to each relevant Tranche taking into account possible rounding differences.
3. Documentation: A documentation shall be established for the purpose of the Share Issue and/or the admission of
the Shares to trading and in particular a prospectus which shall be drafted in accordance with the provisions of Luxembourg
law dated 10 July 2005 on prospectuses for securities (the "Prospectus Law") and approved by the competent authority
(the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the "CSSF").
44505
L
U X E M B O U R G
4. Timing of exchange: The exchange of OPG Bonds for new Shares shall occur on or after the date on which the
CSSF has approved the prospectuses relating to the Shares, the New Notes and, in scenario 1, the Warrants. This
condition is stipulated to the benefit of the OPG Bondholders and may be waived by a decision of the relevant general
meetings of the OPG Bondholders.
I-2. OG Equity Consideration
Under scenario 1 : under scenario 1, OPG shall not, and procures that OG shall not, offer to the OG Bondholders
any consensual transaction that would provide economic terms and conditions more favorable for the OG Bondholders
than those approved by the OG Bondholders' meeting on 5 April 2012.
Under scenario 2: the OG Equity consideration shall consist in the OCA the terms and conditions of which are
described as follows:
1. Main terms of the OCA
84.5% of the number of the OG Bonds shall convert for their total nominal amount, accrued interest and reimburse-
ment premium (EUR 109.1 million) into OCA two business days after the OPG Transaction Approval (as defined below)
and in any case no later than [28 May] 2012 (the "OCA Issue Date") which are convertible as follows:
* First Payment: OCA in an aggregate nominal amount of EUR 76,000,000 are converted into 18,361,548 OPG Shares
no later than [18 June] 2012; this conversion is made at a ratio of 124 OPG Shares for each OCA.
* Second Payment: up to [16 July] 2012 (the "Exchange Date"), the OCA in an aggregate nominal amount of EUR
33,129,067 (the "Second Payment Amount")
(i) can be repaid, at the option of OPG, in full but not in part, by OPG, in cash in immediately available funds in an
amount of EUR 223.73 per one OCA; for the avoidance of doubt, in the event OPG elects to repay in cash but fails to
make such payment, OPG shall be deemed not to have elected to make such cash payment and the OCA shall convert
into shares as provided below; or
(ii) can be converted into 53 OPG shares per one OCA, representing a total number of 7,848,081 OPG shares, as
decided by a meeting of the OCA holders (at a majority vote of 50% plus 1 OCA of all the OCA outstanding).
* On the Exchange Date, and provided they have not already been repaid in cash in immediately available funds or
converted pursuant the paragraph above, the OCA in an aggregate nominal amount equal to the Second Payment Amount,
shall be converted into shares as follows:
(i) if and provided that the OPG Bond Conversion Condition is met three (3) business days prior to the Exchange
Date (the "Longstop Date"), the OCA shall be converted into 53 OPG shares per one OCA, representing a total number
of 7,848,081 OPG Shares;
(ii) if and provided the OPG Bond Conversion Condition is not met on the Longstop Date, the OCA shall, as decided
by the meeting of the OCA holders (at a majority vote of 50% plus 1 OCA of all the OCA outstanding), be converted
into either:
o 53 OPG shares per one OCA representing a total number of 7,848,081 OPG Shares; or
o OG shares in a number representing, on the Exchange Date and after completion of the OG Bond Equitization (as
defined below) and the Nominal Value Reduction (as defined below), 55% of the share capital and voting rights of OG
on a fully diluted basis, it being specified that, in the event OPG elects not to repay the OCA in cash, the election decision
of the OCA holders referred to in this paragraph shall not be required to be made by [9 July] 2012 but can be extended
as necessary to allow for proper notice period, quorum, and majority decision of the OCA holders' meeting to be taken
in accordance with applicable laws (in which case, the Exchange Date shall be postponed accordingly).
If the OCA converts into 55% of OG shares in accordance with the above provisions, only those OCA holders who
have remitted to OPG (i) their OCA and (ii) their remaining OG Bonds shall receive their pro rata number of OG shares
calculated on the basis of the number of OCA and remaining OG Bonds remitted by them, it being specified that the total
of all remaining OCA and OG Bonds shall equal 55% of the OG shares.
* Prior to the Second Payment, OPG shall :
(a) vote at the relevant shareholders' meeting of OG resolving the OG Bonds Equitization in favor of a reduction of
the nominal value of each share issued by OG (the "Nominal Value Reduction");
(b) convert the EUR 109.1 million including the accrued coupons of OG Bonds that OPG holds into additional new
shares of OG in a number which shall be determined on the basis of the volume weighted average price of OG shares
on the main market of the Frankfurt stock exchange over a period of 6 (six) months prior to [12 April] 2012 (the "OG
Bonds Equitization").
The Longstop Date may be extended at the request of OPG provided that such extension has been agreed by a decision
of the OCA holders (taken in accordance with the quorum and majority requirements provided for by law in a meeting
of Bondholders convened and held prior to [9 July] 2012).
2. Listing of the OPG shares / OG shares: OPG and OG shall take all necessary steps and use their best efforts to
obtain, the admission to listing, on the regulated markets on which OPG's and OG ordinary shares are currently listed,
44506
L
U X E M B O U R G
of the shares to be issued or delivered upon conversion of the OCA as soon as possible after the issue of the OCA, and
will use its best efforts to maintain such admission to listing.
3. Condition for the conversion of the OCA under the First Payment: The conversion of the OCA into OPG Shares
under the First Payment shall occur on or after the date on which the CSSF has approved the prospectus relating to such
OPG Shares. This condition is stipulated to the benefit of the OCA holders and may be waived by a decision of the general
meeting of the OCA holders no later than [14 June] 2012.
4. Condition for the conversion of the OCA under the Second Payment: The conversion of the OCA into OPG Shares
under the Second Payment, as the case may be, shall occur on or after the date on which the CSSF has approved the
prospectuses relating to such OPG Shares and the New Notes. This condition is stipulated to the benefit of the OCA
holders and may be waived by a decision of the general meeting of the OCA holders no later than [13 July] 2012
5. The OPG Bond Conversion Condition: "OPG Bond Conversion Condition" means the approval of the OPG Trans-
action as described in this annex A at the relevant majority by the general meetings of the OPG Bondholders holding the
OPG Bonds 2010, OPG Bonds 2013 and OPG Bonds 2014.
6. Transfer Restrictions / Listing of the OCA: The OCA shall not be negotiable on the capital markets and shall not
be offered to the public.
The OCA shall not be listed and/or admitted to trading on any stock exchange within the European Economic Area
nor on a stock exchange outside the European Economic Area.
7. Status of the OCA: The OCA shall constitute direct, general and unconditional obligations of OPG which will at
any time rank pari passu among themselves and at least pari passu with all the other present and future unsecured
obligations of OPG, save for such obligations as may be preferred by provisions of law that are both mandatory and of
general application.
8. Interest: The OCA shall bear an interest per year of 0.01% (the "Interest") from, and including, the issue date until,
and including, the Exchange Date, calculated on the basis of a year of 360 days. The Interest shall be paid by OPG in one
instalment on the date of the Second Payment.
For the avoidance of doubt, the First Payment Amount shall bear no interest.
9. Security: The OCA holders shall benefit, as from the issue date, from a lien over 55% of all shares issued by OG
and held by OPG as collateral in a separate securities account that shall be pledged to the benefit of the OCA holders
for (i) the repayment in cash of the OCA, if any, and (ii) the conversion of the OCA into OG shares, if any, in accordance
with the provisions above.
10. Applicable Law: Luxembourg Law
Under scenario 3: not applicable under these terms and conditions.
I-3. New Notes Consideration 1 under scenarios 1 and 3
1. Issuer: Orco Property Group SA (the "Company" or "OPG").
2. Issue Date of the New Notes: After the granting of the authorisation by the Commercial Court of Paris pursuant
to the Plan de Sauvegarde to proceed to such public exchange offer and promptly after closing of the offer period of the
public exchange offer which shall begin after approval by the CSSF of the terms and conditions of the public exchange
offer, such approval being scheduled to occur upon closing of the OPG Equity Consideration.
3. Nominal Amount:
Scenario 1:
The OPG Bondholders who accept the proposed exchange referred to in under paragraph I.A.(ii) above will receive
new debt instruments (the "New Notes"), in exchange for their residual OPG Bonds post completion of the mandatory
exchange referred to in paragraph I.A.(i) above.
The proposed amount of the New Notes to be issued assuming 100% participation by the OPG Bondholders to the
voluntary exchange offer shall be of up to €75.2 million (such amount shall be adjusted to take into account the final size
of the Share Issue under the Equity Consideration after rounding).
Scenario 3:
The OPG Bondholders who accept the proposed exchange referred to in under paragraph I.C.(ii) above will receive
new debt instruments (the "New Notes"), in exchange for their residual OPG Bonds post completion of the mandatory
exchange referred to in paragraph I.C.(i) above.
The proposed amount of the New Notes to be issued assuming 100% participation by the OPG Bondholders to the
voluntary exchange offer shall be of up to €144.7 million (such amount shall be adjusted to take into account the final
size of the Share Issue under the Equity Consideration after rounding).
4. Security: None.
44507
L
U X E M B O U R G
5. Maturity: 28 February 2018 (the "Maturity Date").
6. Coupon: The New Notes will bear a coupon per annum of
(i) 5% cash plus 5% PIK, as long as more than 75% of the Nominal Amount remain outstanding
(ii) 4% cash plus 4% PIK, as long as more than 50% but no more than 75% of the Nominal Amount remain outstanding
(iii) 4% cash plus 3% PIK, as long as no more than 50% of the Nominal Amount remain outstanding
The PIK element of the coupon shall, subject to the provisions of article 1154 of the Luxembourg civil code, be
compounding annually from the Issue Date until the Maturity Date and remains subject to the issuance by the Company
of a capitalisation notice each year in relation to interest accrued and due for more than 1 year; if such notice is not
refused by the holders of the New Notes within a period to be agreed in the final documentation, then it will be deemed
to be accepted by them.
7. Amortisation Dates:
* 28 February 2015: 25% of the Nominal Amount;
* 28 February 2016: 25% of the Nominal Amount;
* 28 February 2017: 25% of the Nominal Amount;
* 28 February 2018: The outstanding principal amount of the New Notes.
8. Redemption: In cash only at the Amortisation Dates.
9. Mandatory Prepayment on Asset Disposals: In scenario 1, the Company will procure that 25% of the Net Proceeds
(as defined below) received from the earlier of (i) 30 June 2012 onwards and (ii) the Issue Date of the New Notes, by
OPG or any of its subsidiaries as a result of the disposal of the following assets is applied in prepayment of the New Notes
(the "Prepaid Amounts"):
* Fillion Shopping Center
* Radio Free Europe
* Vaci 1
* CEE Hotels (including Pachtuv Palace)
* Na Porici
* Hradcanska
* Diana Office
* Capellen
* Stribro
* Marki
* Vaci 188
* Paris Department Store
* Zlota (only upon completion of project development)
* Molcom (any part of the deferred payment amount in excess of €20m and any earn-out component).
The Prepaid Amounts should reduce the upcoming payments due as per the Amortisation Dates in straight chrono-
logical order and shall be paid within 30 business days from receipt of Net Proceeds by OPG but in any case no earlier
than the Issue Date of the New Notes.
"Net Proceeds" shall mean the gross sale proceeds less (a) liabilities becoming due at disposal including bank cash
sweep, (b) disposal expenses and (c) taxes becoming due at disposal.
In scenario 3, the Prepaid Amounts shall amount to 37.5% of the Net Proceeds.
10. Other Terms and Conditions: The terms and conditions of the New Notes will include customary provisions in
terms of events of default, covenants, negative pledge provisions and applicable law, including the following:
Applicable law: Luxembourg law.
Status of New Notes: direct, unconditional, and unsubordinated obligations ranking pari passu.
Negative Pledge
2
: Only on OPG S.A. level (excluding the share pledge on 55% of all shares issued by OG for the
benefit of the OCA holders)
Incurrence of Financial Indebtedness:
- limitation on the incurrence of new indebtedness by OPG subsidiaries such that LTV is not in excess of 65% (excluding
any refinancing of any existing indebtedness)
- limitation on the incurrence of new indebtedness by OPG S.A. and by OG S.A. in excess of € 5 million (excluding
any refinancing of any existing indebtedness)
Early redemption in case of Event of Default:
Grace periods:
44508
L
U X E M B O U R G
- payment default (principal, interest or any other amount in respect of the New Notes): 5 business days;
- default in relation to any other obligations: 30 days.
Enforcement action provision.
Cross-default : no cross-default provision.
The New Notes shall not be due if the Company remedies the situation no later than the day preceding the general
meeting of the holders of the New Notes resolving on the occurrence of an Event of Default.
Early redemption at Company's discretion: at any time at 100% of the Nominal Amount.
Repurchase of New Notes by the Company on secondary market: at any time at arm's length terms subject to New
Notes repurchased being cancelled as soon as possible thereafter. For the avoidance of doubt, New Notes repurchased
by the Company will not qualify for the Mandatory Prepayment on Asset Disposals referred to above;
Representation of the noteholders: the noteholders will be represented and the general meetings of noteholders will
be organized in accordance with the provisions of articles 86 to 94-8 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
Restrictions on transfer of New Notes: none.
Save as otherwise provided in these Heads of Terms, the terms and conditions of the New Notes will be similar to
those of the OPG Bonds.
11. Documentation:
* A prospectus for the public offer of the New Notes will have to be drafted in accordance with the provisions of the
Prospectus Law. This prospectus will also have to be approved by the CSSF.
* An exchange offer memorandum shall be drafted to inform the OPG Bondholders on the possibility to accept the
public exchange offer and the terms of the public exchange offer.
I-4. OPG and OG New Notes Consideration under scenario 2
Under scenario 2, the OPG and OG New Notes Consideration as referred to in section I.B.(ii) above shall have the
following terms.
1. Issuer: Orco Property Group SA (the "Company" or "OPG").
2. Issue Date of the New Notes: After the granting of the authorisation by the Commercial Court of Paris pursuant
to the Plan de Sauvegarde to proceed to such public exchange offer and promptly after closing of the offer period of the
public exchange offer which shall begin after approval by the CSSF of the terms and conditions of the exchange public
offer, such approval being scheduled to occur upon closing of the OPG Equity Consideration and the OG Equity Con-
sideration transactions.
In the case where the mandatory exchange of the OPG Bonds as referred to in paragraph I.B(i)(a) above has not been
performed on or before [31 July 2012], the voluntary public exchange offer referred to above shall be opened only to
the holders of OG Bonds.
It being specified that the voluntary public exchange offer as referred to above shall not be offered to the OG Bond-
holders in the case where the OCA holders would have elected to obtain OG shares in accordance with the terms and
conditions of the OCA.
3. Nominal Amount: The OPG Bondholders and the OG Bondholders who accept the proposed exchange referred
to in paragraph I.B(ii) above will receive new debt instruments (the "New Notes"), in exchange for their residual OPG
Bonds or OG Bonds, as the case may be, post completion of the mandatory exchange I.B (i) above.
The proposed amount of the New Notes to be issued assuming 100% participation by the OPG Bondholders and the
OG Bondholders to the voluntary exchange offer shall be of up to, respectively:
* as regards the OPG bondholders, € 55.2 million (such amount shall be adjusted to take into account the final size of
the Share Issue under the OPG Equity Consideration after rounding);
* as regards the OG bondholders, € 20 million (such amount shall be adjusted to take into account the final size of
the OCA issue under the OG Equity Consideration after rounding).
4. Security: None.
5. Maturity: 28 February 2018 (the "Maturity Date").
6. Coupon: The New Notes will bear a coupon per annum of
(iv) 5% cash plus 5% PIK, as long as more than 75% of the Nominal Amount remain outstanding
(v) 4% cash plus 4% PIK, as long as more than 50% but no more than 75% of the Nominal Amount remain outstanding
(vi) 4% cash plus 3% PIK, as long as no more than 50% of the Nominal Amount remain outstanding
The PIK element of the coupon shall, subject to the provisions of article 1154 of the Luxembourg civil code, be
compounding annually from the Issue Date until the Maturity Date and remains subject to the issuance by the Company
of a capitalisation notice each year in relation to interest accrued and due for more than 1 year; if such notice is not
44509
L
U X E M B O U R G
refused by the holders of the New Notes within a period to be agreed in the final documentation, then it will deemed
to be accepted by them.
7. Amortisation Dates:
* 28 February 2015: 25% of the Nominal Amount;
* 28 February 2016: 25% of the Nominal Amount;
* 28 February 2017: 25% of the Nominal Amount;
* 28 February 2018: The outstanding principal amount of the New Notes.
8. Redemption: In cash only at the Amortisation Dates.
9. Mandatory Prepayment on Asset Disposals: The Company will procure that 25% of the Net Proceeds (as defined
below) received from the earlier of (i) 30 June 2012 onwards and (ii) the Issue Date of the New Notes, by OPG or any
of its subsidiaries as a result of the disposal of the following assets is applied in prepayment of the New Notes (the "Prepaid
Amounts"):
* Fillion Shopping Center
* Radio Free Europe
* Vaci 1
* CEE Hotels (including Pachtuv Palace)
* Na Porici
* Hradcanska
* Diana Office
* Capellen
* Stribro
* Marki
* Vaci 188
* Paris Department Store
* Zlota (only upon completion of project development)
* Molcom (any part of the deferred payment amount in excess of €20m and any earn-out component).
The Prepaid Amounts should reduce the upcoming payments due as per the Amortisation Dates in straight chrono-
logical order and shall be paid within 30 business days from receipt of Net Proceeds by OPG but in any case no earlier
than the Issue Date of the New Notes.
"Net Proceeds" shall mean the gross sale proceeds less (a) liabilities becoming due at disposal including bank cash
sweep, (b) disposal expenses and (c) taxes becoming due at disposal.
10. Other Terms and Conditions: The terms and conditions of the New Notes will include customary provisions in
terms of events of default, covenants, negative pledge provisions and applicable law, including the following:
Applicable law: Luxembourg law.
Status of New Notes: direct, unconditional, and unsubordinated obligations ranking pari passu.
Negative Pledge
3
: Only on OPG S.A. level (excluding the share pledge on 55% of all shares issued by OG for the
benefit of the OCA holders as referred to above)
Incurrence of Financial Indebtedness:
- limitation on the incurrence of new indebtedness by OPG subsidiaries such that LTV is not in excess of 65% (excluding
any refinancing of any existing indebtedness)
- limitation on the incurrence of new indebtedness by OPG S.A. and OG SA in excess of € 5 million (excluding any
refinancing of any existing indebtedness)
Early redemption in case of Event of Default:
Grace periods:
- payment default (principal, interest or any other amount in respect of the New Notes): 5 business days
- default in relation to any other obligations: 30 days
Enforcement action provision.
Cross-default : no cross-default provision.
The New Notes shall not be due if the Company remedies the situation no later than the day preceding the general
meeting of the holders of the New Notes resolving on the occurrence of an Event of Default.
Early redemption at Company's discretion: at any time at 100% of the Nominal Amount.
Repurchase of New Notes by the Company on secondary market: at any time at arm's length terms subject to New
Notes repurchased being cancelled as soon as possible thereafter. For the avoidance of doubt, New Notes repurchased
by the Company will not qualify for the Mandatory Prepayment on Asset Disposals referred to above;
44510
L
U X E M B O U R G
Representation of the noteholders: the noteholders will be represented and the general meetings of noteholders will
be organized in accordance with the provisions of articles 86 to 94-8 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
Restrictions on transfer of New Notes: none.
Save as otherwise provided in these Heads of Terms, the terms and conditions of the New Notes will be similar to
those of the OPG Bonds.
11. Documentation:
* A prospectus for the public offer of the New Notes will have to be drafted in accordance with the provisions of the
Prospectus Law. This prospectus will also have to be approved by the CSSF.
* An exchange offer memorandum shall be drafted to inform the OPG Bondholders on the possibility to accept the
public exchange offer and the terms of the public exchange offer.
I-5. Warrants under scenario 1
1. Issuer: OPG
2. Description: Warrant giving the right to subscribe for new OPG Shares (the "Warrants"). Each Warrant is allocated
for free.
3. Number of Warrants: 1 Warrant per existing OPG share as of the date hereof, i.e. 17,053,866 Warrants
4. Subscription ratio: Each Warrant gives the right to subscribe for 1 new OPG Share
5. Subscription price: € 4.10 per OPG Share
6. Maturity: The Warrants may be exercised at any time between the date of issuance and a date which is 3 months
after the date of issuance.
7. Listing: Yes.
II. OTHER TERMS
For the avoidance of doubt, all the provisions set forth below in this section "Other Terms" shall be applicable under
scenario 1, scenario 3 and scenario 2, save for certain provisions (where indicated) which shall only be applicable to
scenario 2.
1. Governance: Each member of the board shall have one voting right.
Decisions of the board shall be taken at simple majority.
Majority of the board will be held by non-executive members.
2. Shareholders' meeting: OPG undertakes (i) to convene a shareholders' meeting upon request from one or several
shareholders holding at least, individually or collectively, 10% of the share capital of OPG and (ii) to add to the agenda of
any shareholders' meeting any additional point upon request from one or several shareholders holding at least, individually
or collectively, 5% of the share capital of OPG.
3. Reserved Matters: Decisions to be submitted to the board of directors shall include, among others:
* Capital expenditures in excess of €5m;
* Incurrence of Financial Indebtedness:
- limitation on the incurrence of new indebtedness by OPG subsidiaries such that LTV is not in excess of 55% (excluding
any refinancing of any existing indebtedness);
- limitation on the incurrence of new indebtedness by OPG S.A. in excess of €5m (excluding any refinancing of any
existing indebtedness);
* Any merger/acquisition/disposal/joint venture operations in excess of €10m;
* Any distribution of dividends;
* The issuance of new shares or equity-linked instruments;
* Appointment and removal of Chairman of the board of directors and Company's Chief Executive Officer;
* Any transactions involving OPG or any of its subsidiaries not completed on an arms-length basis.
4. Standstill: The Company shall not implement an issuance of new Shares or equity-linked instruments without pref-
erential subscription rights of the shareholders in excess of € 10 million or with an issue price below € 5.5 per share
within the period from and including 10 April 2012 to and including the date which falls 90 calendar days following the
earlier of (i) the first OPG shareholders meeting to be held following the issuance of the Shares within the framework of
the OPG Equity Consideration and (ii) 15 July 2012 (the "Standstill").
For the avoidance of doubt, the Standstill shall not apply to (i) the OG bond equitization to take place in relation to
the OCA nor (ii) to any share capital issue to be carried out for the purposes of the proposal to other creditors of OPG
as referred to below in this Annex A.
44511
L
U X E M B O U R G
5. Lock-up
* In case of scenario 1 and scenario 3, 30% of new Shares will be subject to a lock-up for a period of 6 months after
completion of the Transaction (the "Lock-up 1");
* In case of scenario 1 and scenario 3, in order to prevent short selling, new Shares to be issued in the framework of
this Transaction cannot be lent or otherwise alienated to third parties as long as they are subject to the Lock-up 1. For
the avoidance of doubt, OPG Bondholders are entitled amongst each other to transact or lend any new Shares that are
the result of the Transaction during the Lock-up 1.
* In case of scenario 2, 30% of new OPG shares to be issued in accordance with the OPG Equity Consideration and
the OG Equity Consideration will be subject to a lock-up for a period of 6 months after completion of the Transaction
(the "Lock-up 2")
* In case of scenario 2, in order to prevent short selling, new OPG shares issued in the framework of this Transaction
cannot be lent or otherwise alienated to third parties as long as they are subject to the Lock-up 2. For the avoidance of
doubt, OPG Bondholders and OG Bondholders are entitled amongst each other to transact or lend any new Shares that
are the result of the Transaction during the Lock-up 2.
6. Conditionality of the Proposed Transaction: Implementation of the Transaction reflecting the terms specified herein
is subject to the following further conditions:
(i) Approval of the Transaction by the board of directors of OPG, and in particular the issuance of the New Notes
upon the closing of the public exchange offer;
(ii) Approval of the Transaction at the relevant majority by the general meetings of the OPG Bondholders holding the
OPG Bonds 2010, OPG Bonds 2013 and OPG Bonds 2014;
(iii) Approval of the Transaction by an OPG EGM deciding in particular the share capital increase of OPG in relation
to the OPG Equity Consideration;
(iv) Approval by the Commercial Court of Paris to amend the terms of the Plan de Sauvegarde following a filing to be
submitted by the Company;
(v) Approval at the relevant majority by the general meetings of the OPG Bondholders holding the OPG Bonds 2010,
OPG Bonds 2013 and OPG Bonds 2014 of a resolution instructing the bondholders' representatives of the OPG Bonds
2010, OPG Bonds 2013 and OPG Bonds 2014 (a) to finally and definitively waive and withdraw the current lawsuits
initiated by the bondholder's representatives of the OPG Bonds 2010, OPG Bonds 2013 and OPG Bonds 2014 (including
the tierce opposition as well as the appeals against the supervisory judge's orders regarding the requêtes en interprétation,
it being specified, for the avoidance of doubt, that the bondholders' representatives of the OPG Bonds 2010, OPG Bonds
2013 and OPG Bonds 2014 shall be instructed to file "conclusions de désistement d'instance et d'action" in the course
of such proceedings according to the French Civil Procedure Code, immediately after conditions (i), (ii), (iii), (iv), (vi),
(vii) and (viii) shall have been fulfilled) and (b) not to further challenge the judgment dated 19 May 2010 adopting the Plan
de Sauvegarde;
(vi) Withdrawal by OPG from any pending action, litigation or recourse against Mr. Luc Leroi in his capacity as bond-
holders' representative of any of the OPG Bonds and undertaking by OPG not to further claim from Mr. Luc Leroi in his
capacity as bondholders' representative of any of the OPG Bonds any compensation, indemnification or damages; it being
agreed that such withdrawal and undertaking are subject to conditions (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vii) and (viii) being fulfilled;
(vii) A réviseur d'entreprise agréé appointed by OPG has issued a report giving a description of the proposed contri-
butions of the OPG Bonds as well as of the methods of valuation used and stating that the values resulting from the
application of these methods correspond at least to the number and accounting par value and the share premium of the
new Shares to be issued within the OPG Equity Consideration;
(viii) Approval by the CSSF of the prospectuses relating to the Shares, the New Notes and, in scenario 1, the Warrants.
This condition is stipulated to the benefit of the OPG Bondholders and may be waived by a decision of the relevant general
meetings of the OPG Bondholders.
In case of scenario 2, the additional conditions need to be fulfilled:
(ix) Approval of the OG Transaction at the relevant majority by the general meeting of the OG Bondholders; in this
respect, the OG Committee shall vote in favour of the OG Transaction as described in this Annex A;
(x) Approval of the OG Transaction at the relevant majority by the general meeting of the OG warrant holders;
(xi) A réviseur d'entreprises agréé appointed by OPG has issued a report giving a description of the proposed con-
tributions as well as of the methods of valuation used and stating that the values resulting from the application of these
methods correspond at least to the number and accounting par value and the share premium of the new OPG shares to
be issued in consideration for the contribution of all of the OG Bonds within the OG Transaction.
7. Existing OPG Warrants: OPG shall hold and maintain that number of OPG Bonds of each of the OPG Bonds 2010
and OPG Bonds 2014 Tranches which are necessary to exercise the OPG warrants of the relevant Tranche (where the
exercise of the OPG warrants can be done by inter alia payment of the exercise price through the remittance of OPG
Bonds) for the duration of the exercise period of the OPG warrants, it being agreed that (i) such provision shall not affect
44512
L
U X E M B O U R G
the economic terms of the Transaction and that (ii) OPG shall not sell any such OPG Bonds 2010 and OPG Bonds 2014
for any purpose other than the exercise of the OPG warrants.
8. Proposal to other creditors of OPG: The other creditors of OPG under the procédure de sauvegarde (suppliers,
banks having exercised their guarantees vis-à-vis OPG, other non bank creditors) shall be offered a transaction identical
to the Transaction. In order to be able to accommodate for this offer, OPG shall propose to its EGM of shareholders
respective adjustments to the authorised capital.
1
Note: OPG Bondholders to nominate a candidate or OPG can nominate one if necessary
2
The Negative Pledge provision shall be similar to the provision 4.1.5.2 of the OPG Bonds 2014 prospectus.
Référence de publication: 2012042373/1273/635.
Dexia Overseas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 156.767.
Notice is hereby given to the shareholders of DEXIA OVERSEAS S.A., société anonyme, (the "Company") that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
shall be held on <i> April 30 i>
<i>thi>
<i> , 2012 i>
at 10 a.m. at the registered office, in order to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgment and acceptance of the resignation of Claude SCHON, Ralph DISEVISCOURT and Joris LAENEN
as directors of the company.
2. Appointment of Johan EVENEPOEL, Yves BIEWER and Rudi PARIDAENS as new directors of the company for a
term which will expire after the annual general meeting of the Company to be held in 2016.
3. Miscellaneous
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012042369/16.
Utopia S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 5.254.090,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 29.756.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu jeudi le <i>3 mai 2012i> , à 10.00 heures au siège social de la société, 45, avenue J.F. Kennedy, à Luxembourg-
Kirchberg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé de l'exercice 2011
2. Lecture des rapports du réviseur d'entreprises
3. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2011
4. Affection du résultat
5. Confirmation de cooptation de trois administrateurs
6. Décharge aux administrateurs
7. Désignation du réviseur d'entreprises
8. Nominations statutaires
9. Prolongation de l'autorisation pour la société d'acquérir ses propres actions
10. Divers
Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l'article 17 des statuts, déposer leurs
titres au porteur pour jeudi, le 26 avril 2012 au plus tard, auprès de la Dexia Banque Internationale à Luxembourg. Les
actionnaires nominatifs doivent également s'annoncer par écrit endéans le même délai.
Les actionnaires peuvent se faire représenter, dans les conditions déterminées par l'article 17 des statuts; par une
autre personne ayant elle aussi un droit de vote, en déposant la procuration correspondante au siège social pour jeudi,
le 26 avril 2012 au plus tard.
44513
L
U X E M B O U R G
Pour le Conseil d'Administration.
Nico SIMON / Christian KMIOTEK
<i>Administrateur-Délégué / Présidenti>
Référence de publication: 2012041774/31.
Confira Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 71.940.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2012i> à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012040012/10/19.
Medicover Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 59.021.
The
ANNUAL GENERAL MEETING
(the "Meeting") of Medicover Holding S.A. (the "Company") will be held at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxem-
bourg on <i>May 8, 2012i> at 11.00 a.m. to transact the following business:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account as of December 31, 2011 and of the consolidated
accounts;
3. Allocation of results;
4. Discharge of the Directors and the Independent Auditor (BDO Audit S.A.) from liability for the year ended De-
cember 31, 2011;
5. Re-election of the present Directors who are: Jonas af Jochnick as President of the Board of Directors, Robert af
Jochnick, Fredrik Rågmark, Margareta Nordenvall, Arno Bohn and Fredrik Stenmo for a period ending at the annual
general meeting of the Company approving the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2012;
and
6. Appointment of Peder af Jochnick, manager, born in Kungsholm, Sweden, on 19 January 1971, residing at Ragnar-
öksvägen 6, 182 64 Djursholm, Sweden, as additional Director of the Company for a period ending at the annual
general meeting of the Company approving the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2012;
7. Re-election of BDO Audit S.A. as Independent Auditor for a period ending at the annual general meeting of the
Company approving the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2012.
<i>Who may attend the Meetingi>
Holders of registered shares in the Company registered with the Company Registrar on April 24, 2012 are entitled
to participate in the Meeting, and to exercise their voting rights either in person or by proxy. Regarding voting by proxy,
see "Voting" below.
<i>Votingi>
Holders of registered shares may vote (i) in person at the Meeting or (ii) appoint a proxy to represent them. Proxies
do not need to be shareholders of the Company. The procedure for voting by a proxy requires that the shareholder
complete a special form (available on the Company's web-site (www.medicover.com) as "Form of Proxy for Registered
44514
L
U X E M B O U R G
Shareholders"). The shareholder shall indicate on the form how (s)he wants to vote on the issues and motions addressed
by the Meeting and deliver it to the Company in accordance with the formalities stated in the Form of Proxy for Registered
Shareholders, not less than two full business days before the day appointed for holding the Meeting.
Medicover Holding S.A.
24, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
Phone: + 352 26 20 31 10
RCS Luxembourg B 59 021
www.medicover.com
Référence de publication: 2012040544/43.
Mutualité d'Aide aux Artisans, Société Coopérative.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 4.556.
Nous prions Mesdames et Messieurs les associés de la MUTUALITE D'AIDE AUX ARTISANS de bien vouloir assister
à
I. l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 58, rue Glesener, le vendredi, <i>27 avril 2012i> à 10.30 heures, pour délibérer
sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale;
2. Reformulation de l'objet social;
3. Suppression de la durée limitée de la société;
4. Modification du capital social minimum;
5. Modification des conditions de présence et de majorité aux assemblées modifiant les statuts;
6. Refonte des statuts pour les adapter aux décisions prises ci-avant et aux exigences actuelles et futures de la société.
Ne sont PAS modifiés les articles 2, 9, 10, 11, 17, 18, 20 à 22 et 24 à 27.
II. l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 58, rue Glesener, le même jour que l'Assemblée Générale Extraordinaire,
à l'issue de celle-ci, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport général du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires aux comptes et du réviseur.
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012040542/30.
SHB Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 153.460.
As the quorum has not been reached during the first Extraordinary General Meeting of Shareholders held on April 10
th
, you are hereby convened to a second
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of the Company which will be held in Luxembourg on <i> May 16 i>
<i>thi>
<i> , 2012 i> at 11.00 a.m. (Luxembourg
time), to deliberate and vote on amendments of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”) as described
in the following agenda:
<i>Agenda:i>
Approval of amendments of the Articles as detailed below:
- Replacement of the reference to the 2002 Law by a reference to the 2010 Law
- Modification of article 10 by inserting the following paragraph:
44515
L
U X E M B O U R G
‘If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting
of shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that
date, time or place to be decided by the Board.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices
of meeting.
Special meetings of the shareholders of any one class or of several classes may be convened to decide on any
matters relating to such one or more classes and/or to a variation of their rights.
The shareholders are authorised to cast their vote by proxy form expressed in the English language.
Any proxy form shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by special courier
service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Corporation or by fax
at the fax number of the registered office of the Corporation.
Any proxy form which does not bear any of the following mentions or indications is to be considered void and
shall be disregarded for quorum purposes:
- name/address or registered office of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Corporation and, if applicable,
number of shares of each class of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Corporation;
- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares
for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorised representative of the relevant shareholder.
Any proxy form shall be received by the Corporation no later than 5 p.m., Luxembourg time on the Luxembourg
bank business day immediately preceding the day of the general meeting of shareholders. Any proxy form received
by the Corporation after such dead line shall be disregarded for quorum purposes.’
- Modification of article 11
- deletion of any reference to cable, telegram or telex
- insertion of a paragraph relating to quorum and majority requirements
* ‘Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any meeting of shareholders
may specify that the quorum and the majority applicable for this meeting of shareholders will be determined by
reference to the shares issued and in circulation at a certain date and time preceding the meeting of shareholders
(the “Record Date”), whereas the rights of a shareholder to attend a meeting of shareholders and to exercise the
voting rights attached to his/its/her shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder
as at the Record Date.’
- Modification of article 14
- deletion of any reference to cable, telegram or telex
- reference to article 19 of the articles of incorporation
- Modification of article 16
- Precision as to the eligible countries under article 45 (1) of the 2010 Law
- Insertion of the two following paragraphs:
* Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board may, at any time it deems appro-
priate and to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with
the provisions set forth in the offering documents of the Corporation, (i) create any class qualifying either as a
feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing class into a feeder UCITS class or (iii) change the
master UCITS of any of its feeder UCITS classes.
* Any class may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in applicable Luxembourg
laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the offering documents of the Corporation,
subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more classes. In such case and subject to
conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these shares
are suspended for as long as they are held by the class concerned. In addition and for as long as these shares are
held by a class, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Corporation
for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law.
- Precision regarding any personal interest of a Director
- Modification of article 22
- 4 paragraphs have been added of cases where the determination of the net asset value may be suspended:
* if the Board has determined that there has been a material change in the valuations of a substantial proportion
of the investments of the Corporation attributable to a particular class of shares in the preparation or use of a
valuation or the carrying out of a later or subsequent valuation;
* during any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Corporation or its
shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or any other detriment
which the Corporation or its shareholders might so otherwise have suffered;
* during any period when the determination of the net asset value per share of and/or the redemptions in the
underlying investment funds representing a material part of the assets of the relevant class is suspended; or
44516
L
U X E M B O U R G
* provided that any such suspension is justified for the protection of the shareholders in accordance with the
provisions on mergers of the 2010 Law, the Corporation may temporarily suspend the subscription, the redemption
or the repurchase of its shares.
- Modification of article 25
- Insertion of a paragraph stating that the Board may also apply a dilution adjustment
- Modification of article 29
- Precision that a class may be dissolved if the net asset value of the class concerned has decreased below an amount
which the Board of Directors considers as being the minimum amount required for the existence of such class.
- Insertion of two paragraphs regarding mergers:
* In accordance with the provisions of the 2010 Law, mergers of classes and as the case may be the merger of the
Corporation with another Luxembourg or foreign collective investment undertaking qualifying as UCITS or class
thereof may be decided by the Board. The Board may however also decide to submit the decision for a merger to
a meeting of shareholders of the class concerned for which no quorum is required and decisions are taken by the
simple majority of the votes cast. In case of a merger of a class where, as a result, the Corporation ceases to exist,
the merger needs to be decided by a meeting of shareholders where the quorum and majority requirements for
changing these Articles of Incorporation are required.
* The Board may decide to consolidate or split shares of a sub-class of any class. The Board may also submit the
question of the consolidation of shares of a sub-class to a meeting of shareholders of such sub-class. Such meeting
will resolve on the consolidation with a simple majority of the votes cast.
The text of the proposed amendments to the articles of incorporation is available free of charge, upon request, at the
registered office of the Company.
There is no quorum required for the Second Meeting and the resolutions will be passed by a majority of 2/3 of the
votes cast.
Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy form may be obtained from the registered office of the company
upon request.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012037178/103.
INREDE S.A. (International Nippon Real Estate Development & Finance S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 36.485.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2012i> à 15:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012034653/696/18.
Tolomei Partenaire S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 101.434.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2012i> à 09.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
44517
L
U X E M B O U R G
3. affectation des résultats au 31 décembre 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012040010/10/18.
COLUPA S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 28.367.
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>27 avril 2012i> à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration
2. Présentation et approbation du Rapport du Commissaire aux comptes
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011
4. Affectation du résultat
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
6. Elections statutaires
7. Divers
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012038864/19.
E.H.I. Euro Hotel Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 72.268.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2012i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2010 et 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012037786/696/18.
Tokelia S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 42.386.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
44518
L
U X E M B O U R G
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Référence de publication: 2012039275/1023/16.
Saserna S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.846.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 avril 2012i> à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations Statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012039265/795/18.
Decopress SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 139.401.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social en date du <i>19 avril 2012i> à 18 heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modifications au sein du Conseil d'Administration;
2. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire;
3. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012039089/1004/14.
Vahina, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 78.166.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>20 avril 2012i> à 13.30 heures, avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012038855/534/16.
44519
L
U X E M B O U R G
Jovest Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 38.919.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>23 avril 2012i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lectures des rapports de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009, au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 et affec-
tation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012038355/755/19.
Rebrifi SPF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 30.188.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2012i> à 10.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012038850/660/15.
Gutland Mëllech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 89.810.
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 15 mars 2012 n'ayant pu délibérer valablement sur le point de
l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés
d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
réunie extraordinairement, qui se tiendra le <i>2 mai 2012i> à 15h00 au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs
avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012034150/755/17.
44520
L
U X E M B O U R G
Bairlinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 94.272.
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 15 mars 2012 n'ayant pu délibérer valablement sur le point de
l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés
d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
réunie extraordinairement, qui se tiendra le <i>2 mai 2012i> à 10h00 au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours
francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012034147/755/17.
RAU & RAU Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 33, Op der Heckmill.
R.C.S. Luxembourg B 114.965.
Der Jahresabschluss vom: 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012030026/10.
(120038964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Katrann Private SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 151.157.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société KATRANN PRIVATE SA SPF, société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 06 mars 2012.
<i>Pour: KATRANN PRIVATE SA SPF
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon
Référence de publication: 2012029640/18.
(120038141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
PARTELL HOLDING (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1343 Luxembourg, 3, Montée de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 45.730.
"CLÔTURE DE LIQUIDATION"
Par jugement rendu en date du 1
er
mars 2012, le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, VI
ème
chambre, siégeant
en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le
44521
L
U X E M B O U R G
Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société
suivante:
- Société anonyme PARTELL HOLDING LUXEMBOURG S.A. dont le siège social à L-1343 Luxembourg, 3, Montée
de Clausen;
Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Me Isabelle FERAND
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012030008/18.
(120038986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
EnVivo International III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 30.000,00.
Siège social: L-1426 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 165.140.
In the year two thousand and twelve on the ninth day of the month of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
EnVivo Pharmaceuticals, Inc., incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having
its registered office at 82 Devonshire St., Boston, MA 02109 USA, registered with the Register of Companies of Massa-
chusetts under number 760680844, being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "EnVivo International III
S.àr.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 2A, rue Albert Borschette, L-1021
Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 165.140 and
incorporated on 17
th
February 2011 under the Laws of the Cayman Islands as an exempted private limited liability
company. The Company has been transferred by way of continuation as a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) to Luxembourg on 5
th
December 2011, pursuant to resolutions of the board of managers of the
Company and the Sole Shareholder recorded by deed of Me Henri Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 120 of 14
th
January 2012. The Sole Shareholder is repre-
sented by Me Susanne Goldacker, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 7
th
February
2012 (which shall remain annexed to the presented deed to be registered therewith).
The Sole Shareholder declared and asked the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all thirty thousand (30,000) shares in issue in the Company.
2. The item on which a resolution is to be passed is as follows:
- Change of the name of the Company into "EnVivo (Luxembourg) III S.à r.l." and consequential amendment of article
1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
" Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "EnVivo (Luxem-
bourg) III S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation"
Thereafter, the Sole Shareholder of the Company passed the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company into "EnVivo (Luxembourg) III S.à r.l." and to
consequentially amend article 1 of the articles of the Company as set forth in the agenda.
There being no further item on the agenda the extraordinary decision of the Sole Shareholder was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the Sole Shareholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille douze, le neuvième jour du mois de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
44522
L
U X E M B O U R G
EnVivo Pharmaceuticals, Inc., constituée sous les lois de l’Etat de Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège
social au 82 Devonshire St., Boston, MA 02109 USA, enregistrée au Register of Companies of Massachusetts, sous le
numéro 760680844, étant l’associé unique (l’ «Associé Unique») de «EnVivo International III S.àr.l.» (la «Société»), une
société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2A, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, et enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.140, et constituée le 17 février 2011
sous les lois des Iles Caïmans comme une exempted private limited liability company. La Société a été transférée par voie
de continuation comme une société à responsabilité limitée au Luxembourg le 5 décembre 2011 conformément aux
résolutions du conseil de gérance de la Société et de l’Associé Unique enregistrées par acte de Me Henri Hellinckx,
prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») sous le numéro 120 du 14 janvier
2012. L’Associé Unique est représenté par Me Susanne Goldacker, Avocat à la Cour, résidant au Luxembourg, sur base
d’une procuration en date du 7 février 2012 (qui restera annexée au présent acte afin d’être enregistrée ensemble avec
ledit acte).
L’Associé Unique a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. L’Associé Unique détient toutes les trente mille (30.000) parts sociales émises dans la Société.
2. L’Associé Unique prend une décision sur le point suivant:
- Changement du nom de la Société en «EnVivo (Luxembourg) III S.à r.l.» et modification de l’article 1 des statuts de
la Société de telle façon à lire ce qui suit:
" Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination «EnVivo (Luxembourg) III S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera
régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Après approbation de ce qui précède, l’Associé Unique de la Société a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Associé Unique a décidé de changer le nom de la Société en «EnVivo (Luxembourg) III S.à r.l.» et de modifier en
conséquence l’article 1 des statuts de la Société tel qu’indiqué dans l’ordre du jour. Plus rien ne figurant à l’ordre du jour,
la décision extraordinaire de l’Associé Unique a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d’une traduction française; à la demande de la même partie comparante en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture du présent acte le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: S. GOLDACKER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2012. Relation: LAC/2012/7805. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 5 mars 2012.
Référence de publication: 2012029173/80.
(120038026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Restaurant Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 351.143,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 143.171.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Référence de publication: 2012030017/11.
(120039292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
44523
L
U X E M B O U R G
Restaurant Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 351.143,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 143.171.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Référence de publication: 2012030018/11.
(120039293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Holzbau Henz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 160.820.
Im Jahre zweitausendzwölf.
Den dreiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Herr Wolf Christian HENZ, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54311 Trierweiler, 11, In der Acht.
Welcher Komparent erklärte dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Holzbau
Henz S.à r.l. ist, mit Sitz in L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 160.820 (NIN 20112416952).
Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 5. Mai
2011, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1549 vom 13. Juli 2011.
Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in einhundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (€ 125.-), welche integral durch Herrn Herr Wolf Christian HENZ, Zim-
merermeister, wohnhaft in D-54311 Trierweiler, 11, In der Acht, übernommen wurden.
Alsdann ersuchte der Komparent den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt das Gesellschaftskapital um ZWEIUNDDREISSIGTAUSENDFÜNFHUNDERT
EURO (€ 32.500.-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (€
12.500.-) auf den Betrag von FÜNFUNDVIERZIGTAUSEND EURO (€ 45.000.-) zu bringen, durch die Schaffung von
ZWEIHUNDERTSECHZIG (260) neuen Anteilen mit einem Nominalwert von je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG
EURO (€ 125.-).
<i>Einzahlung und Zuteilung der Neuen Anteilei>
a) Der alleinige Gesellschafter erklärt achtzig (80) der zweihundertsechzig (260) neu geschaffenen Anteile zu zeichnen.
Die Einzahlung wurde durch Bareinzahlung des Betrages von ZEHNTAUSEND EURO (€ 10.000.-) durch Herrn Wolf
Christian HENZ, vorgenannt, vorgenommen.
b) Der alleinige Gesellschafter erklärt zur Zeichnung von einhundertachtzig Anteilen (180) der zweihundertsechzig
(260) neu geschaffenen Anteile zuzulassen:
Herrn Sven GONDRING, Zimmerermeister, geboren am 24. November 1983 in Trier, wohnhaft in D-54294 Trier,
Schweringstrasse, 34.
Die Einzahlung wurde durch Bareinzahlung des Betrages von ZWEIUNDZWANZIGTAUSENDFÜNFHUNDERT EU-
RO (€ 22.500.-) durch Herrn Sven GONDRING vorgenommen.
Der unterzeichnete Notar erklärt dass der Betrag der Kapitalerhöhung von ZWEIUNDDREISSIGTAUSENDFÜNF-
HUNDERT EURO (€ 32.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie ihm dies mittels Bankbescheinigung
nachgewiesen worden ist.
<i>Zweiter Beschlussi>
Aufgrund der vorhergehenden Kapitalerhöhung wird Artikel 6 der Statuten abgeändert um folgenden Wortlaut zu
erhalten:
44524
L
U X E M B O U R G
„ Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt FÜNFUNDVIERZIGTAUSEND EURO (EUR 45.000,-), aufgeteilt in DREI-
HUNDERTSECHZIG (360) Anteile von je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (EUR 125,-), welche wie folgt
zugeteilt sind:
1.- Herr Wolf Christian HENZ, Zimmerermeister, wohnhaft in D54311 Trierweiler, 11, In der Acht,
einhundertachtzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
2.- Herr Sven GONDRING, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54294 Trier, Schweringstrasse, 34,
einhundertachtzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
TOTAL: dreihundertsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen Herrn Sven GONDRING, vorgenannt, ebenfalls zum Geschäftsführer der Gesellschaft
auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift bis zu dem Betrag von fünftausend Euro
(EUR 5.000,-) rechtsgültig vertreten und verpflichten.
Für alle Verträge, Verpflichtungen oder Anschaffungen im Anlagevermögen, die über diesen Betrag hinausgehen, bedarf
es der gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer.
WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Echternach, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: W. C. HENZ, S. GONDRING, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 01 mars 2012. Relation: ECH/2012/352. Reçu soixante-quinze euros. 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 07. März 2012.
Référence de publication: 2012029254/67.
(120038046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
REIL (Real Estate Investments in Luxembourg) S.A. (Soparfi), Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 52.416.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
24, Rue Léon Kauffman L-1853 Luxembourg
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012030027/11.
(120038864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Retail Real Estate S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. Expert Capital S.A.).
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 57.819.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2012.
Référence de publication: 2012030029/10.
(120038793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Retail Real Estate S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. Expert Capital S.A.).
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 57.819.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
44525
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2012.
Référence de publication: 2012030030/10.
(120038794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
EnVivo (Luxembourg) I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EnVivo International I S.à r.l.).
Capital social: USD 30.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 165.119.
In the year two thousand and twelve on the ninth day of the month of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared
EnVivo Pharmaceuticals, Inc., incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having
its registered office at 82 Devonshire St., Boston, MA 02109 USA, registered with the Register of Companies of Massa-
chusetts under number 760680844, being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “EnVivo International I
S.àr.l.” (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 2A, rue Albert Borschette, L-1021
Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 165.119 and
incorporated on 17
th
February 2011 under the Laws of the Cayman Islands as an exempted private limited liability
company. The Company has been transferred by way of continuation as a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) to Luxembourg on 5
th
December 2011, pursuant to resolutions of the board of managers of the
Company and the Sole Shareholder recorded by deed of Me Henri Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 118 of 14
th
January 2012. The Sole Shareholder is re-
presented by Me Susanne Goldacker, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 7
th
February
2012 (which shall remain annexed to the presented deed to be registered therewith).
The Sole Shareholder declared and asked the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all thirty thousand (30,000) shares in issue in the Company.
2. The item on which a resolution is to be passed is as follows:
- Change of the name of the Company into “EnVivo (Luxembourg) I S.à r.l.” and consequential amendment of article
1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
“ Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “EnVivo (Luxem-
bourg) I S.à r.l.” (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation”
Thereafter, the Sole Shareholder of the Company passed the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company into “EnVivo (Luxembourg) I S.à r.l.” and to
consequentially amend article 1 of the articles of the Company as set forth in the agenda.
There being no further item on the agenda the extraordinary decision of the Sole Shareholder was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the Sole Shareholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède
L'an deux mille douze, le neuvième jour du mois de février,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu
EnVivo Pharmaceuticals, Inc., constituée sous les lois de l’Etat de Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège
social au 82 Devonshire St., Boston, MA 02109 USA, enregistrée au Register of Companies of Massachusetts, sous le
numéro 760680844, étant l’associé unique (l’ “Associé Unique”) de “EnVivo International I S.àr.l.” (la “Société”), une
société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2A, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, et enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.119, et constituée le 17 février 2011
sous les lois des Iles Caïmans comme une exempted private limited liability company. La Société a été transférée par voie
44526
L
U X E M B O U R G
de continuation comme une société à responsabilité limitée au Luxembourg le 5 décembre 2011 conformément aux
résolutions du conseil de gérance de la Société et de l’Associé Unique enregistrées par acte de Me Henri Hellinckx,
prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le “Mémorial”) sous le numéro 118 du 14 janvier
2012. L’Associé Unique est représenté par Me Susanne Goldacker, Avocat à la Cour, résidant au Luxembourg, sur base
d’une procuration en date du 7 février 2012 (qui restera annexée au présent acte afin d’être enregistrée ensemble avec
ledit acte).
L’Associé Unique a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. L’Associé Unique détient toutes les trente mille (30.000) parts sociales émises dans la Société.
2. L’Associé Unique prend une décision sur le point suivant:
- Changement du nom de la Société en “EnVivo (Luxembourg) I S.à r.l.” et modification de l’article 1 des statuts de la
Société de telle façon à lire ce qui suit:
“ Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination “EnVivo (Luxembourg) I S.à r.l.” (la “Société”). La Société sera
régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Après approbation de ce qui précède, l’Associé Unique de la Société a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Associé Unique a décidé de changer le nom de la Société en “EnVivo (Luxembourg) I S.à r.l.” et de modifier en
conséquence l’article 1 des statuts de la Société tel qu’indiqué dans l’ordre du jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la décision extraordinaire de l’Associé Unique a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d’une traduction française; à la demande de la même partie comparante en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture du présent acte le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: S. GOLDACKER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2012. Relation: LAC/2012/7803. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 5 mars 2012.
Référence de publication: 2012029171/81.
(120038024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Ayu Holding S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 90.154.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société AYU HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial, société anonyme: Monsieur
Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 06 mars 2012.
<i>Pour: AYU HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon
Référence de publication: 2012030142/19.
(120038933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
44527
L
U X E M B O U R G
AMP Capital Investors (Luxembourg No. 5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.992.
In the year two thousand twelve on the first day of March.
Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
AMP Capital Investors International Holdings Limited, a company incorporated under the laws of Australia, having its
registered office at Level 24, AMP Building, 33 Alfred Street Sydney NSW 2000 Australia, registered with the Australian
Securities & Investments Commission, under number ACN 114 352 957,
(the “Sole Shareholder”),
hereby represented by Sara Lecomte, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg.
The Sole Shareholder appears in its capacity as sole shareholder of AMP Capital Investors (Luxembourg N° 5) S.à r.l.,
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg with its
registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 155.992 (the “Company”), in order to hold an extraordinary general meeting (the “Meeting”)
of the Sole Shareholder of the Company. The Company was incorporated under Luxembourg law on 8
th
October 2010
pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2507 of 18
th
November 2010.
The proxy from the Sole Shareholder after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the
Sole Shareholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office from L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich to
L-2540 Luxembourg 15, rue Edward Steichen, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the article 2.1 of the articles of incorporation of the Company which shall
forthwith read as follows:
" Art. 2.1.
2.1. The registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately eight hundred Euros (EUR 800.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le premier mars.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
44528
L
U X E M B O U R G
AMP Capital Investors International Holdings Limited, une société constituée selon le droit australien, dont le siège
social se situe à Level 24, AMP Building, 33 Alfred Street Sydney NSW 2000 Australia, inscrite auprès de l'Australian
Securities & Investments Commission, sous le numéro ACN 114 352 957 (l' «Associé Unique»),
ici représentée par Sara Lecomte, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
L' Associé Unique se présente dans sa capacité d'associé unique de AMP Capital Investors (Luxembourg N° 5) S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 33, rue de Gasperich, L-5826
Hespérange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.992 (la
«Société»), afin de tenir une assemblée générale extraordinaire (l' «Assemblée») de l'Associé Unique de la Société. La
Société a été constituée sous la loi Luxembourgeoise le 8 octobre 2010 en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, No 2507 du 18 novembre 2010.
Ladite procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l'Associé
Unique et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès
des autorités compétentes.
L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de L-5826 Hespérange, 33, rue de Gasperich à L-2540 Luxembourg,
15, rue Edward Steichen, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 2.1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 2.1. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré dans la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut
être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 800,-(huit cents Euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: S. Lecomte, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 mars 2012. Relation: LAC/2012/9970. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): C. Frising.
Référence de publication: 2012029039/93.
(120038136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Rivaty Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 156.159.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 mars 2012 que:
1. La démission de «BF CONSULTING S. à r .l.» en tant que commissaire de la société est acceptée.
2. La nomination de la société «REVICONSULT S.à r.l.», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, sous le numéro B139013, ayant son siège social au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, en tant
que commissaire de la société est acceptée.
Il reprendra le mandat de son prédécesseur qui arrivera a échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2015.
44529
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 8 mars 2012.
Référence de publication: 2012030031/18.
(120039398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
EIRSP Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.145.560,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 158.006.
In the year two thousand eleven, the twenty-ninth day of December,
Before Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of EIRSP Investments S.à r.l., a Luxem-
bourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 1, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 158.006 and having a share capital of twelve million nineteen thousand six hundred and ninety-
seven euro (EUR 12,019,697) (the Company). The Company was incorporated on December 15, 2010 pursuant to a
deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated March 28, 2011.
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant
to a deed of Me Kesseler, notary residing in Esch-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg dated September 5, 2011, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of November 28, 2011 with the number 2907.
- There appeared Castle Trust & Management Services Limited acting in its capacity as trustee of The Equus Interna-
tional Retirement Savings Plan No 146 Cell, a limited liability company incorporated under the laws of Gibraltar, having
its registered office at Suite 932, Europort, Gibraltar, registered with Register of Companies, under number 46030, (the
Shareholder 1)
hereby represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
- There appeared Mr Simon Andrew Pearson, Hedge Fund Manager, born on 5 November 1968 in the United Kingdom,
residing at Garden Mews, Ocean Village, Gibraltar (the Shareholder 2, and together with the Shareholder 1, the Share-
holders)
hereby represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred twenty-five thousand eight hundred
sixty-three euro (EUR 125,863), in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve
million nineteen thousand six hundred and ninety-seven euro (EUR 12,019,697) represented by one hundred eighty-seven
thousand five hundred (187,500) ordinary shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each and
eleven million eight hundred thirty-two thousand one hundred ninety-seven (11,832,197) preferred equity share certifi-
cates in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each (the PESCs), to twelve million one hundred forty-
five thousand five hundred sixty euro (EUR 12,145,560) by way of the issuance of one hundred twenty-five thousand eight
hundred sixty-three euro (EUR 125,863) new PESCs, having a par value of one euro (EUR 1), with the same rights and
obligations as the existing PESCs.
2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.
3. Subsequent amendment to articles 5.2 and 5.3. of the articles of association of the Company (the Articles) in order
to reflect the increase of the share capital adopted under item 1. above.
4. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the regis-
tration of the newly issued PESCs in the relevant register of the Company.
5. Miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions:
44530
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred twenty-five
thousand eight hundred sixty-three euro (EUR 125,863), in order to bring the share capital of the Company from its
present amount of twelve million nineteen thousand six hundred and ninety-seven euro (EUR 12,019,697) represented
by one hundred eighty-seven thousand five hundred (187,500) ordinary shares in registered form, having a par value of
one euro (EUR 1) each and eleven million eight hundred thirty-two thousand one hundred ninety-seven (11,832,197)
PESCs having a par value of one euro (EUR 1) each, to twelve million one hundred forty-five thousand five hundred sixty
euro (EUR 12,145,560) by way of the issuance of one hundred twenty-five thousand eight hundred sixty-three euro (EUR
125,863) new PESCs, having a par value of one euro (EUR 1), with the same rights and obligations as the existing PESCs.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Shareholders, pre-named and represented as stated above, declare that Shareholder 1 subscribes to
one hundred twenty-five thousand eight hundred sixty-three euro (EUR 125,863) PESCs of the Company having a par
value of one euro (EUR 1) and fully pays up these PESCs by a contribution in kind consisting of a receivable which
Shareholder 1 holds against the Company (the Receivable), such Receivable having an aggregate accounting value in an
amount of twelve million five hundred eighty-six thousand three hundred thirty-nine euro and fifty-seven cents (EUR
12,586,339.57).
The contribution in kind of the Receivable in an aggregate amount of twelve million five hundred eighty-six thousand
three hundred thirty-nine euro and fifty-seven cents (EUR 12,586,339.57) from the Shareholder 1 to the Company is to
be allocated as follows:
(i) an amount of one hundred twenty-five thousand eight hundred sixty-three euro (EUR 125,863) is to be allocated
to the nominal share capital account of the Company; and
(ii) an amount of twelve million four hundred sixty thousand four hundred seventy-six euro and fifty-seven cents (EUR
12,460,476.57) is to be allocated to the share premium account of the Company linked to the PESCs.
The value of the contribution of the Receivable to the Company has been certified to the undersigned notary by a
certificate dated December 29, 2011 issued by the Shareholder 1 and acknowledged and approved by the management
of the Company which states in essence that:
“1. The Shareholder 1 is the sole owner of the Receivable.
2. The Shareholder 1 is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable.
3. The Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct
on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment.
4. There exists no pre-emption right nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that one or more of the Receivable be transferred to him.
5. All formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Receivable to the Company
will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.
6. Upon the contribution of the Receivable by Shareholder 1 to the Company, the Company will become the full owner
of the Receivable which will be extinguished by way of confusion for the purpose of article 1300 of the Luxembourg civil
code.
7. Based on general accepted accounting principles, the book value of the Receivable is at least equal to twelve million
five hundred eighty-six thousand three hundred thirty-nine euro and fifty-seven cents (EUR 12,586,339.57) as per the
attached balance sheet dated December 29, 2011 and since the valuation was made no material changes have occurred
which would have depreciated the contribution made to the Company.“
Such certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend articles 5.2 and 5.3 of the Articles
which shall henceforth read as follows:
“ 5.2. The Company's corporate capital is also represented by eleven million nine hundred fifty-eight thousand sixty
(11,958,060) preferred equity share certificates with a par value of one Euros (EUR 1,-) each (the PESCs and together
with the Ordinary Shares, the Shares), which are redeemable in accordance with these Articles. The holder(s) of PESCs
are hereinafter individually referred to as a PESC Shareholder and collectively as the PESC Shareholders. The Ordinary
Shareholder(s) and the PESC Shareholder(s) are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.
44531
L
U X E M B O U R G
5.3. The entire corporate capital thus amounts to twelve million one hundred forty-five thousand five hundred sixty
Euro (EUR 12,145,560).”
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes
and empower and authorize any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with
the registration of the newly issued PESCs and above changes in the relevant register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately five thousand three hundred Euros (EUR 5,300.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de EIRSP Investments S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social se situe au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 158.006 et dont le capital social s'élève à douze millions dix-neuf mille six cent quatre-vingt dix-sept Euro (EUR
12,019,697.-) (la Société). La Société a été constituée le 15 décembre 2010 par un acte du notaire instrumentant publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 28 mars 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés
plusieurs fois et pour la dernière fois suivant un acte de Me Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg, daté du 5 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
sous le numéro 2907 du 28 novembre 2011.
- A comparu Castle Trust & Management Services Limited agissant en sa qualité de trustee de The Equus International
Retirement Savings Plan No 146 Cell, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Gibraltar, dont le
siège social se situe au Suite 932, Europort, Gibraltar, immatriculée au Registre des Sociétés sous le numéro 46030,
(l'Associé 1);
ici représenté par Régis Galiotto, employé privé, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé.
- A comparu Mr. Simon Andrew Pearson, gestionnaire de fonds spéculatifs, né le 5 novembre 1968 au Royaume-Uni,
résidant à Garden Mews, Ocean Village Gibraltar (l'Associé 2, et ensemble avec l'Associé 1, les Associés);
ici représenté par Régis Galiotto, employé privé, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les Associés, représentés comme ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent vingt-cinq mille huit cent soixante-trois Euro
(EUR 125.863,-), afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze millions dix-neuf mille six
cent quatre-vingt dix-sept Euro (EUR 12.019.697,-) représenté par cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (187.500) parts
sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune et onze millions huit
cent trente-deux mille cent quatre-vingt dix-sept (11.832.197) certificats de parts sociales privilégiées sous forme nomi-
native, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les PESCs), à douze millions cent quarante-cinq mille cinq
cent soixante Euro (EUR 12.145.560,-) par l'émission de cent vingt-cinq mille huit cent soixante-trois (125.863) nouveaux
PESCs, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) avec les mêmes droits et obligations que les PESCs existants.
2. Souscription et libération de l'augmentation de capital spécifiée au point 1. ci-dessus.
3. Modification subséquente des articles 5.2 et 5.3 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation
de capital adoptée sous le point 1. ci-dessus.
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changement ci-dessus avec pouvoir et autorité
donné à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'inscription des PESCs nouvellement émis dans le registre concerné de la Société.
44532
L
U X E M B O U R G
5. Divers.
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement
des PESCs nouvellement émis dans le registre correspondant de la Société.
5. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent vingt-cinq mille huit cent
soixante-trois Euro (EUR 125.863,-), afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze millions
dix-neuf mille six cent quatre-vingt dix-sept Euro (EUR 12.019.697,-) représenté par cent quatre-vingt-sept mille cinq
cents (187.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune
et onze millions huit cent trente-deux mille cent quatre-vingt dix-sept (11.832.197) PESCs ayant une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1,-), à douze millions cent quarante-cinq mille cinq cent soixante Euro (EUR 12.145.560,-) par l'émission de
cent vingt-cinq mille huit cent soixante-trois (125.863) nouveaux PESCs, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-)
avec les mêmes droits et obligations que les PESCs existants
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation
du capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ce, les Associés, pré-désignés et représentés comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent vingt-cinq mille
huit cent soixante-trois (125.863) PESCs de la Société ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-), et de les libérer
intégralement par un apport en nature consistant en une créance que l'Associé 1 détient envers la Société (la Créance),
cette Créance ayant une valeur comptable globale d'un montant de douze millions cinq cent quatre-vingt-six mille trois
cent trente-neuf Euro et cinquante-sept cents (EUR 12.586.339,57).
L'apport en nature de la Créance d'un montant global de douze millions cinq cent quatre-vingt-six mille trois cent
trente-neuf Euro et cinquante-sept cents (EUR 12.586.339,57) de l'Associé 1 à la Société doit être affecté comme suit:
(i) un montant de cent vingt-cinq mille huit cent soixante-trois Euro (EUR 125.863,-) est affecté au compte de capital
social nominal de la Société; et
(ii) un montant de douze millions quatre cent soixante mille quatre cent soixante seize Euro et cinquante-sept cents
(12.460.476,57) est affecté au compte de prime d'émission de la Société lié aux PESCs.
L'estimation de l'apport de la Créance à la Société a été certifiée au notaire instrumentant par un certificat daté du 29
décembre 2011 émis par l'Associé 1 et approuvé par la gérance de la Société, qui atteste essentiellement que:
«1. L'Associé 1 est le seul propriétaire de la Créance;
2. L'Associé 1 est le seul ayant-droit à la Créance et possède le droit d'en disposer;
3. La Créance n'est grevée d'aucun nantissement ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou un
usufruit sur la Créance et la Créance n'est sujette à aucun attachement;
4. Il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander
que la Créance lui soit remise;
5. Toutes les formalités requises à Luxembourg ou dans une autre juridiction, consécutives à l'apport en nature de la
Créance à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant cet apport en
nature."
6. Au moment de l'apport de la Créance par l'Associé 1 à la Société, la Société deviendra le seul propriétaire de la
Créance qui sera éteinte par confusion en vertu de l'article 1300 du Code civil Luxembourgeois
7. Sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur comptable de la Créance apportée à la Société
est évaluée à au moins douze millions cinq cent quatre-vingt-six mille trois cent trente-neuf Euro et cinquante-sept cents
(EUR 12.586.339,57) d'après le bilan annexé daté du 19 décembre 2011, et depuis cette évaluation, aucun changement
matériel qui aurait déprécié la valeur de l'apport à la Société n'a eu lieu.»
Ce certificat, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,
restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier les articles 5.2 et 5.3 de Statuts de
sorte qu'ils aient désormais la teneur suivante:
5.2. Le capital social de la Société est aussi représenté par onze millions neuf cent cinquante-huit mille soixante
(11.958.060) certificats de parts sociales privilégiées d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacun (les PESCs et
ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires, les Parts Sociales), rachetables conformément aux présents Statuts. Le(s)
44533
L
U X E M B O U R G
détenteur(s) de PESCs est/sont désigné(s) ci-après, individuellement comme un Associé PESC et collectivement comme
les Associés PESC. Le(s) Associé(s) Ordinaire(s) et le(s) Associé(s) PESC sont désigné(s) ci-après collectivement comme
les Associés.
5.3. Par conséquence, le capital social total de la Société s'élève à douze millions cent quarante-cinq mille cinq cent
soixante Euro (EUR 12.145.560). "
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et
donnent pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, de procéder pour le compte de la
Société à l'inscription des PESCs nouvellement émis dans le registre correspondant de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait du présent acte s'élèvent
approximativement à cinq mille trois cents Euro (EUR 5.300.-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2012. Relation: LAC/2012/1499. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Référence de publication: 2012028047/240.
(120036402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2012.
Sisto Armaturen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 20.425.
Im Jahre zweitausendzwölf,
den zweiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,
der Aktiengesellschaft SISTO ARMATUREN S.A., mit Sitz in L-6468 Echternach, Zone Industrielle, eingetragen beim
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 20.425 (NIN 1983 2200 428),
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Camille HELLINCKX, mit dem damaligen Amtswohnsitze in
Luxemburg, am 15. April 1983, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 149 vom 10.
Juni 1983, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:
- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond SCHROEDER, mit dem damaligen Amtssitze zu Mersch, am 1.
März 1988, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 166 vom 18. Juni 1988;
- gemäss Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar Edmond SCHROEDER, am 15. April 1988, veröffentlicht
im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 178 vom 30. Juni 1988;
- gemäss Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar Edmond SCHROEDER, am 21. März 1990, veröffentlicht
im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 342 vom 24. September 1990;
- gemäss Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar Edmond SCHROEDER, am 16. September 1994, veröf-
fentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 12 vom 9. Januar 1995;
- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Urbain THOLL, mit dem Amtssitze in Mersch, am 11. Dezember 2001,
veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 614 vom 19. April 2002.
- gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 24. September 2003, veröffentlicht im Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1102 vom 23. Oktober 2003.
- gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 15. März 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations Nummer 806 vom 16. August 2005.
44534
L
U X E M B O U R G
Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf sechs Millionen Euro (€ 6.000.000.-) und ist eingeteilt in vierundzwanzigtau-
sendzweihundertvier (24.204) Aktien ohne Nennwert.
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Wolfgang LASER, Ingenieur, wohnhaft in Konz.
Er beruft zum Schriftführer und zum Stimmzähler Herrn Markus SCHNEIDER, Betriebswirt, wohnhaft in Irrel.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgenden Punkt:
- Abänderung von Artikel 3 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
IV.) Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der An-
wesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für richtig
befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertretern und den Mit-
gliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu
werden.
V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die vierundzwanzigtausendzweihundertvier (24.204) Aktien ohne
Nennwert, welche das gesamte Kapital von sechs Millionen Euro (€ 6.000.000.-) darstellen, bei der gegenwärtigen Ge-
neralversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt
und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.
Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie
rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgenden
Beschluss gefasst:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 3 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: W. LASER, M. SCHNEIDER, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 février 2012. Relation: ECH/2012/302. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 07. März 2012.
Référence de publication: 2012029518/69.
(120038038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Thryn Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 122.549.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 30 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré
du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes a changée et est désormais:
- Stéphane HEPINEUZE, Gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Matthijs BOGERS, Gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
44535
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2012.
Référence de publication: 2012030076/15.
(120038833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
MCP III Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 75.727,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 154.543.
In the year two thousand and twelve, on the tenth day of February,
Before Maître Henri HELLINCKX, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "MCP III Investment S.à r.l." (the “Company”), a
Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.543,
incorporated by a notarial deed enacted on 6 July 2010, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1828 of 7 September 2010 and lastly amended by a notarial deed enacted on 8 February 2012, not yet published
in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is presided by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Solange Wolter, notary clerk, with professional
address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The chairman acts that:
I.- The sole shareholder is present or represented and the number of shares held by it is shown on an attendance list.
That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 75,726 (seventy-five thousand seven hundred twenty-six) shares of USD
1 (one United States Dollar) each, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting
can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholder expressly states that it has been duly informed
beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one United States Dollar) so as to raise it
from its current amount of USD 75,726 (seventy-five thousand seven hundred twenty-six United States Dollars) to USD
75,727 (seventy-five thousand seven hundred twenty-seven United States Dollars) by the issue of 1 (one) new class P
share with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar), subject to the payment of a global share premium
amounting to USD 50,423 (fifty thousand four hundred twenty-three United States Dollars) to be allocated to the share
premium account of the class P shares;
3. Subscription and payment by MCP-CMC III (Cayman) L.P. of the new class P share under resolution 2. above by
way of a contribution of in cash amounting to USD 50,424 (fifty thousand four hundred twenty-four United States Dollars);
4. Subsequent amendment of article 5 of the Company’s articles of association; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the sole shareholder waives its right to notice of the extraordinary general meeting which should
have been sent to it prior to this meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed of the agenda
and considers the meeting being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the
agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the
shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one United States Dollar) so as
to raise it from its current amount of USD 75,726 (seventy-five thousand seven hundred twenty-six United States Dollars)
to USD 75,727 (seventy-five thousand seven hundred twenty-seven United States Dollars) by the issuance of 1 (one) new
Class P share with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) (the “New Class P Share”), subject to the payment
of a global share premium amounting to USD 50,423 (fifty thousand four hundred twenty-three United States Dollars)
44536
L
U X E M B O U R G
payable on the Class P share premium account (the “Class P Share Premium”), the whole to be fully paid up through a
contribution in cash amounting to USD 50,424 (fifty thousand four hundred twenty-four United States Dollars) (the
“Contribution”) to be made by its sole shareholder, being MCP-CMC III (Cayman) L.P., a Cayman Islands exempted
limited partnership, established under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Mary Street, building
Walker House, KY-KY1-9002 George Town, Cayman Islands (the “Contributor”).
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and payment by the Contributor of the New Class P Share together with the
Class P Share Premium through the Contribution.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Contributor,
here represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to
subscribe the New Class P Share in the Company and to pay it up entirely together with the Class P Share Premium by
the contribution described above.
<i>Evidence of the contribution’s existencei>
A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of resolutions 2. and 3. above it is resolved to amend article 5 of the Company’s current articles of
association to read as follows:
“ Art. 5. Share Capital. The Company's share capital is fixed at USD 75,727 (seventy-five thousand seven hundred
twenty-seven United States Dollars), represented by 75,727 (seventy-five thousand seven hundred twenty-seven) shares,
in registered form, having a par value of USD 1 (one United States Dollar) each, all subscribed and fully paid-up, consisting
of: (i) 15,725 (fifteen thousand seven hundred twenty-five) ordinary shares, having a par value of USD 1 (one United States
Dollar) each (the “Ordinary Shares”) and (ii) 60,002 (sixty thousand two) redeemable shares, having a par value of USD
1 (one United States Dollar) each (the “Redeemable Shares”), distributed in the following classes of shares: a) 15,001
(fifteen thousand one) shares, having a par value of USD 1 (one United States Dollar) each (the “Class M Shares”), b)
15,001 (fifteen thousand one) shares, having a par value of USD 1 (one United States Dollar) (the “Class P Shares”), c)
15,000 (fifteen thousand) shares, having a par value of USD 1 (one United States Dollar) (the “Class K Shares”) and d)
15,000 (fifteen thousand) shares, having a par value of USD 1 (one United States Dollar) (the “Class T Shares”).
The Class M Shares, the Class P Shares, the Class K Shares and the Class T Shares are collectively referred as the
“Classes of Redeemable Shares”, individually referred as a “Class of Redeemable Shares”.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the
extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required by Law or the Articles for amendment of the Articles.”
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would
be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about one thousand five hundred Euros
(1,500.- EUR).
There being no further business, the meeting is declared closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le dixième jour de février,
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique de “MCP-III Investment S.à.r.l.” (la “Société”),
une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2577, Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.543,
constituée par acte notarié du 6 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
1828 du 7 septembre 2010 et dernièrement modifié par acte notarié du 8 février 2012, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
44537
L
U X E M B O U R G
L’assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président élit comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, ayant son
adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.– L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient sont inscrits sur une liste de
présence. Cette liste et la procuration, signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec le présent acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les 75.726 (soixante-quinze mille sept cent vingt-six) parts sociales de
1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte
que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l’ordre du jour, dont l’associé unique re-
connaît expressément avoir été dûment informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 1 USD (un Dollar Américain) pour le porter de son
montant actuel de 75.726 USD (soixante-quinze mille sept cent vingt-six Dollars Américains) à 75.727 USD (soixante-
quinze mille sept cent vingt-sept Dollars Américains) par l’émission de 1 (une) nouvelle part sociale de classe P d’une
valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) et moyennant le paiement d’une prime d’émission globale d’un montant
de 50.423 USD (cinquante mille quatre cent vingt-trois Dollars Américains) qui seront alloués au compte de prime
d’émission des parts sociales de classe P;
3. Souscription et payement par MCP-CMC III (Cayman) L.P. de la nouvelle part sociale de classe P suivant la résolution
2. ci-dessus par un apport en numéraire d’un montant de 50.424 USD (cinquante mille quatre cent vingt-quatre Dollars
Américains);
4. Modification consécutive de l’article 5 of the des statuts de la Société; et
5. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’associé unique de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l’associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée
générale; l’associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour, considère être valablement con-
voqué à la présente assemblée générale extraordinaire et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les
points portés à l’ordre du jour. De plus il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise
à la disposition l’associé unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Seconde résolution:i>
Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 1 USD (un Dollar Américain), afin de le porter
de son montant actuel de 75.726 USD (soixante-quinze mille sept cent vingt-six Dollars Américains) à un montant de
75.727 USD (soixante-quinze mille sept cent vingt-sept Dollars Américains) par l’émission de 1 (une) nouvelle part sociale
de classe P ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) (la “Nouvelle Part Sociale de Classe P”), moyennant
le paiement d’une prime d’émission globale d’un montant de 50.423 USD (cinquante mille quatre cent vingt-trois Dollars
Américains) payable sur le compte de prime d’émission de classe P (la “Prime d’Emission de Classe P”), la totalité devant
être entièrement libérée par voie d’apport en numéraire d’un montant de 50.424 USD (cinquante mille quatre cent vingt-
quatre Dollars Américains) (l’”Apport”), devant être réalisé par son associé unique soit MCP-CMC III (Cayman) L.P., un
“exempted limited partnership” constitué suivant le droit des îles Caïman, ayant son siège social à Mary Street building
Walker House, KY-KY1-9002 George Town, Iles Caïman (l’”Apporteur”).
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par l’Apporteur de la Nouvelle Part Sociale de Class P ensemble
avec la Prime d’Emission de Classe P par voie de l’Apport.
<i>Intervention – Souscription – Paiementi>
Intervient ensuite l’Apporteur, ici représenté par M. Régis Galiotto prénommé, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé, qui déclare souscrire la Nouvelle Part Sociale de Classe P de la Société et de la libérer entièrement
ensemble avec la Prime d’Emission par l’Apport.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée au notaire soussigné.
44538
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence de la résolution 2. et 3. qui précède, il est décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société pour
lui donner la teneur suivante:
“ Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à 75.727 USD (soixante-quinze mille sept cent vingt-sept
Dollars Américains), représentés par 75.727 (soixante-quinze mille sept cent vingt-sept) parts sociales sous forme no-
minative d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées,
consistant en: (i) 15.725 (quinze mille sept cent vingt cinq) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de 1 USD (un
Dollar Américain) chacune (les “Parts Sociales Ordinaires”), et (ii) 60.002 (soixante mille deux) parts sociales rachetables
d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les “Parts Sociales Rachetables”) réparties dans les classes
de parts sociales suivantes: a) 15.001 (quinze mille une) parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Amé-
ricain) chacune (les “Parts Sociales de Classe M”), b) 15.001 (quinze mille une) parts sociales d’une valeur nominale de 1
USD (un Dollar Américain) chacune (les “Parts Sociales de Classe P”), c) 15.000 (quinze mille) parts sociales d’une valeur
nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les “Parts Sociales de Classe K”) et d) 15.000 (quinze mille) parts
sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les “Parts Sociales de Classe T”).
Les Parts Sociales de Classe M, les Parts Sociales de Classe P, les Parts Sociales de Classe K et les Parts Sociales de
Classe T sont collectivement désignées par “Classes de Parts Sociales Rachetables”, et individuellement par “Classe de
Parts Sociales Rachetables”.
Le montant du capital social de la Société peut-être augmenté ou réduit par la voie d’une résolution de l’assemblée
générale extraordinaire des associés ou de l’associé unique (le cas échéant), adoptée dans les conditions requises par la
Loi ou en matière de modification des Statuts.”
<i>Coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à mille cinq cents Euros (1.500.- Euros).
Dont Acte, aucun autre point n’ayant à être traité, l’assemblée a été ajournée.
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu’en tête.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 février 2012. Relation: LAC/2012/7373. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 5 mars 2012.
Référence de publication: 2012029372/195.
(120038012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.
Rose Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 72.226.
Veuillez prendre note que l’administrateur, Madame Ruth BRAND, a changé de nom et se nomme désormais Madame
Ruth VON WYL.
Luxembourg, le 8 mars 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ROSE CAPITAL S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012030034/13.
(120039258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Roberta Di Camerino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 130.219.
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
44539
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ROBERTA DI CAMERINO S.A.
Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012030032/12.
(120039290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2012.
Scanship Environmental Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 117.682.
Les comptes annuels au 7 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Scanship Environmental Luxembourg S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012031024/10.
(120040593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
RS-IC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 112.634.
Les comptes annuels au 31 octobre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012031023/9.
(120040576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.
Garden Projektentwicklung GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 167.209.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzwölf, am einundzwanzigsten Februar.
Vor uns, Notar Roger ARRENSDORFF, mit Amtssitz zu Luxemburg, handelnd in Vertretung seiner verhinderten
Kollegin, Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, welche letztgenannte Bewahrerin der Urkunde
bleibt.
Ist erschienen:
- Peakside European Holdco S.à r.l., mit Sitz in 18-20, rue Edward Steichen, Luxembourg, L-2540, eingetragen im
luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 131.744, hier vertreten durch Frau Szilvia Sari, mit Adresse in
Luxembourg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.
Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch die Vollmachtnehmerin und den amtierenden Notar "ne
varietur" gegengezeichnet wurde, zusammen mit der Satzung der Gesellschaft zur Gründung angenommen.
Die Vollmachtnehmerin, handelnd wie vorstehend, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung der zu grün-
denden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
§1. Firma. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firmenbezeichnung
Garden Projektentwicklung GmbH
(die "Gesellschaft") mit vorliegender Satzung (die "Satzung") gegründet.
§2. Sitz.
(1) Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
(2) Der Firmensitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Geschäftsführerversammlung oder des Einzelgeschäfts-
führer an jeden anderen Ort der Stadt verlegt werden.
(3) Der Firmensitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung oder des Einzelgesellschaf-
ters an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg oder ins Ausland gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in der jeweils aktuellen Fassung verlegt werden.
(4) Falls der Einzelgeschäftsführer oder die Geschäftsführerversammlung der Ansicht ist, dass außergewöhnliche po-
litische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ereignisse stattfinden werden oder unmittelbar bevorstehen, welche die
44540
L
U X E M B O U R G
normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz
und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis
diese außergewöhnlichen Umstände beendet sind. Eine solche vorübergehende Maßnahme berührt die luxemburgische
Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft nicht. Eine solche Maßnahme wird von der Geschäftsführerversammlung oder dem
Einzelgeschäftsführer getroffen, der jeden Betroffenen über diese Maßnahme informieren wird.
§3. Dauer.
(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
(2) Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
§4. Unternehmensgegenstand.
(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen jeder Rechtsform in Luxemburg oder im Ausland
sowie der Kauf von Anteilen und Anteilsscheinen in jeder Form gleich welcher Art sowie die damit zusammenhängende
Verwaltung.
(2) Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und
andere Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Schuldtitel, Zertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere sowie im wei-
testen Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer Gesellschaft gleich welcher Art ausgegeben
wurden.
(3) Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle eines jeglichen Unternehmens beteiligen.
(4) Die Gesellschaft kann des Weiteren den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder
sonstigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft betreiben.
(5) Die Gesellschaft kann Darlehen in jeglicher Form aufnehmen, außer im Wege eines öffentlichen Kaufangebotes.
Sie kann ausschließlich im Wege der Privatplatzierung Wechsel, Anleihen und Schuldtitel sowie Schuldverschreibungen
und/oder Anteilspapiere emittieren.
(6) Die Gesellschaft kann selbst Darlehen an ihre Tochtergesellschaften, an mit ihr verbundene Gesellschaften und/
oder an jede andere Konzerngesellschaft ausreichen, einschließlich der aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten stam-
menden Mittel und/oder Emissionen von Wert- oder Schuldpapieren.
(7) Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen, um deren Verpflichtungen
oder die Verpflichtungen verbundener Unternehmen und/oder jeder anderen Konzerngesellschaft zu besichern.
(8) Die Gesellschaft kann darüber hinaus das Gesellschaftsvermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, be-
lasten oder in sonstiger Weise Sicherheiten dafür bestellen. Die Gesellschaft kann zum Zwecke des effizienten Manage-
ments grundsätzlich alle zur Verfügung stehenden Methoden und Instrumente für ihre Investitionen nutzen, darunter auch
Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert
werden kann.
(9) Die Gesellschaft kann jegliche Handels- und/oder Finanzgeschäfte im Zusammenhang mit dem direkten oder indi-
rekten Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Eigentum tätigen.
(10) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die zur Erreichung dies Gesellschaftszweckes
im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes notwendig und nützlich erscheinen.
(11) Die Gesellschaft kann Filialen, Tochtergesellschaften oder sonstige Niederlassungen sowohl im Großherzogtum
Luxemburg als auch im Ausland errichten.
§5. Stammkapital.
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in 500 (fünfhundert)
Geschäftsanteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).
(2) Das Stammkapital kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung oder des Einzelgesellschafters in
der für Satzungsänderungen geltenden Form erhöht oder herabgesetzt werden.
§6. Geschäftsanteile.
(1) Jeder Geschäftsanteil gibt Anspruch auf einen Bruchteil am Vermögen und Gewinn der Gesellschaft, im Verhältnis
zu der Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.
(2) Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme.
(3) Zwischen Gesellschaftern sind die Geschäftsanteile frei übertragbar. Bei mehreren Gesellschaftern kann die Ab-
tretung von Geschäftsanteile an Nichtgesellschafter nur mit 75% der Stimmen aller Gesellschafter, die mindestens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, beschlossen werden.
(4) Ergänzend wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften in der jeweils aktuellen Fassung verwiesen.
(5) Die Gesellschaft erkennt nur einen Besitzer pro Geschäftsanteil an.
(6) Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile mit Beschluss von 75% der Stimmen aller Gesellschafter, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, zurückkaufen.
44541
L
U X E M B O U R G
§7. Geschäftsführung.
(1) Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt einem Einzelgeschäftsführer oder, bei mehreren Geschäftsführern,
der Geschäftsführerversammlung. Im Fall der Ernennung mehrerer Geschäftsführern bilden diese die Geschäftsführer-
versammlung, welche die juristische Einheit bildet, die für die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft zuständig
ist. Bei mehreren Geschäftsführern wird jeder Geschäftsführer entweder als Kategorie A oder als Kategorie B Ge-
schäftsführer ernannt. Insoweit diese Satzung von der Geschäftsführerversammlung spricht und der Begriff "Einzelge-
schäftsführer" nicht ausdrücklich erwähnt ist, soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf die "Geschäftsführerver-
sammlung" als Verweis auf den "Einzelgeschäftsführer" gelesen werden.
(2) Die Gesellschaft wird nach außen vertreten durch (i) die alleinige Unterschrift des Einzelgeschäftsführers oder bei
mehreren Geschäftsführern, durch die Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäfts-
führer der Kategorie B, oder durch die Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Kategorie B für Geschäfte die einen
bestimmten Wert nicht übersteigen, welcher durch einen Geschäftsführer der Kategorie A und einen Geschäftsführer
der Kategorie B festgelegt wird, oder (ii) durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm ordnungsgemäß erteilten
Vollmachten handelnden Bevollmächtigten. Die Befugnisse, das Entgelt, die Dauer und alle anderen Elemente des Mandats
dieser Bevollmächtigten werden von der Geschäftsführerversammlung festgesetzt.
(3) Der Einzelgesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernennen Geschäftsführer mit einfacher Mehrheit
und legen die Dauer, die Vergütung und den Umfang des Mandats fest.
(4) Geschäftsführer sind ad nutum abberufbar.
(5) Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in der jeweils aktuellen Fassung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der
Geschäftführung.
(6) Die Geschäftsführerversammlung wird aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden bestellen und einen Sekretär, der für
die Protokollierung der Beschlüsse der Geschäftsführerversammlung zuständig ist.
(7) Die Geschäftsführerversammlung kann von jedem Geschäftsführer einberufen werden. Jeder Geschäftsführer erhält
für jede Geschäftsführerversammlung mindestens 2 (zwei) Tage vor dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt
eine mündliche oder schriftliche Mitteilung, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels,
außer im Falle einer Dringlichkeit. In einem solchen Fall wird die Art der Dringlichkeit (und ihre Gründe) in der Ge-
schäftsführerversammlung kurz angegeben.
(8) In jeder Mitteilung werden der Versammlungsort, die Versammlungszeit und die Beratungsgegenstände angegeben.
(9) Auf die Einberufung kann verzichtet werden, wenn das schriftliche Einverständnis jedes Geschäftsführers per Brief,
Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels vorliegt.
(10) Die Geschäftsführerversammlung kann ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden, wenn alle
Geschäftsführer bei der Geschäftsführerversammlung anwesend oder vertreten sind.
(11) Jeder Geschäftsführer kann sich durch schriftliche Bevollmächtigung von einem anderen Geschäftsführer bei Ge-
schäftsführerversammlung vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.
(12) Jeder Geschäftsführer kann an der Geschäftsführerversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder ähn-
licher Kommunikationsmittel teilnehmen, bei denen sämtliche Versammlungsteilnehmer sich hören und miteinander
sprechen können.
(13) Die Teilnahme an der Geschäftsführerversammlung im Wege eines dieser Mittel gilt als der persönlichen Teil-
nahme an der Geschäftsführerversammlung.
(14) Die Geschäftsführerversammlung kann nur rechtsgültig tagen und Entscheidungen treffen, wenn eine Mehrheit
seiner Mitglieder anwesend oder wirksam vertreten ist und mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und der
Kategorie B anwesend ist. Alle Entscheidungen der Geschäftsführerversammlung werden durch einfache Mehrheit ge-
troffen, welche mindestens die Stimmen eines Geschäftsführers der Kategorie A und der Kategorie B umfassen muss.
Das Protokoll der Geschäftsführerversammlung wird von dem Vorsitzenden unterzeichnet.
(15) Beschlüsse der Geschäftsführerversammlung können auch als von allen Geschäftsführern unterzeichnete schrift-
liche Umlaufbeschlüsse gefasst werden. Diese Beschlüsse sind denen einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen
Geschäftsführerversammlung gleich gestellt.
(16) Die Unterschriften der Geschäftsführer können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren, per Brief oder
Telefax verschickten Kopien eines identischen Beschlusses angebracht werden.
Umlaufbeschlüsse können mittels Brief, Fax, E-Mail oder ähnlicher Kommunikationsmittel übermittelt werden.
(17) Die Geschäftsführer übernehmen auf der Grundlage ihres Amtes keine persönliche Haftung für Verpflichtungen,
die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind; als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung ihres Amtes verantwortlich.
§8. Gesellschafterversammlung.
(1) Gesellschafterversammlungen können von der Geschäftsführerversammlung oder durch die Stimme der Gesell-
schafter die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.
44542
L
U X E M B O U R G
(2) Die schriftliche Einberufung über die Gesellschafterversammlung (Ort und Uhrzeit) und ihre Tagesordnung wird
nach den gesetzlichen Voraussetzungen verfasst.
(3) Die Gesellschafterversammlung kann ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden, wenn alle Ge-
sellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die
Gesellschafterversammlung und ihre Tagesordnung informiert worden sind.
(4) Jeder Gesellschafter kann sich bei der Gesellschafterversammlung vertreten lassen, indem er eine andere Person
oder einen anderen Gesellschafter schriftlich entweder per Brief, Fax oder E-Mail zum Vertreter ernennt.
(5) Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie mit 75% der Stimmen aller Gesellschafter vertreten, die mindestens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten, beschlossen werden.
(6) Ein Einzelgesellschafter übt sämtliche der Befugnisse der Gesellschafterversammlung alleine aus.
(7) Der Einzelgesellschafter trifft alle Entscheidungen die über die Befugnisse der Geschäftsführerversammlung hinaus-
gehen.
(8) Am Sitz der Gesellschaft oder an dem anderen Ort, der in der Ladung mitgeteilt wurde, findet eine Gesellschaf-
terversammlung über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft einmal jährlich spätestens innerhalb von
sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt.
§9. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. De-
zember eines jeden Jahres.
§10. Jahresabschluss. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres lässt die Geschäftsführerversammlung einen Jahresabschluss
erstellen, der das Gesellschaftsvermögen einschließlich aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft erfasst und den Gesell-
schaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird.
§11. Buchprüfung.
(1) Im Falle dass die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, soll sie von einem oder mehreren
satzungsgemäßen Buchprüfern ("commissaires") beaufsichtigt werden, die Gesellschafter sein dürfen, aber keine Gesell-
schafter sein müssen.
(2) Die Dauer des Mandats jedes satzungsgemäßen Buchprüfers endet mit der jährlichen Gesellschafterversammlung,
welche dem Jahre seiner Ernennung folgt und die den Jahresabschluss genehmigt.
(3) Am Ende dieses Zeitraums wird ein satzungsgemäßer Buchprüfer mit Beschluss der Gesellschafterversammlung
oder des Einzelgesellschafters erneut bestellt.
Falls die Gesellschaft die Schwelle des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels- und
Gesellschaftsregister überschritten werden, müssen ein oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer ("réviseurs d’en-
treprises agréés") unter den registrierten unabhängigen Wirtschaftsprüfern des Registers der "Commission de Surveil-
lance du Secteur Financier" ernannt werden.
§12. Gewinnverwendung.
(1) Von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Bruttogewinn der Gesellschaft wird der Nettogewinn durch Abzug
der Gemeinkosten, Amortisierungen und Ausgaben ermittelt.
(2) Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Jahresnettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage
zugewiesen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft beträgt.
(3) Aufgrund der Empfehlung der Geschäftsführerversammlung entscheidet die Gesellschafterversammlung über die
Verwendung des verfügbaren jährlichen Gewinns. Sie kann entscheiden, den gesamten Gewinn den Rückstellungen zu-
zuführen, ihn auf neue Rechnung zu übertragen oder ihn in Form von Dividenden an die Gesellschafter auszuschütten.
§13. Zwischendividenden. Ungeachtet der Bestimmungen des vorherigen Artikels, kann die Gesellschafterversammlung
auf Vorschlag der Geschäftsführerversammlung vor dem Ende des laufenden Geschäftsjahres die Ausschüttung von Zwi-
schendividenden genehmigen, soweit aufgrund eines Zwischenabschlusses belegt ist, dass ausreichende finanzielle Mittel
für die Ausschüttung zur Verfügung stehen. Der auszuschüttende Betrag darf die seit Ende des vergangenen Geschäfts-
jahres, für das der Jahresabschluss genehmigt wurde, angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene
Gewinn und Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Beiträge, welche nach den Re-
gelungen dieser Satzung und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils aktuellen
Fassung einer Rücklage zugeführt werden müssen, nicht übersteigen.
§14. Auflösung - Liquidation.
(1) Der Einzelgesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann mit 75% der Stimmen aller Gesellschafter, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, die Auflösung der Gesellschaft beschließen.
(2) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt,
welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen und durch Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterver-
sammlung mit 75% der Stimmen aller Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten,
ernannt werden. In diesem Beschluss werden auch die Befugnisse und die Vergütung festgelegt. Soweit in dem Beschluss
44543
L
U X E M B O U R G
nichts Gegenteiliges vorgesehen ist, sind die Liquidatoren mit den weitestgehenden Befugnissen für die Liquidierung der
Vermögenswerte und die Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausgestattet.
(3) Der nach der Liquidierung der Vermögenswerte und Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende
Überschuss wird an die Gesellschafter im Verhältnis zu den von jedem Gesellschafter an der Gesellschaft gehaltenen
Geschäftsanteile ausgezahlt.
§15. Anwendbares Recht. Diese Satzung soll ausgelegt und interpretiert, sowie von den Regelungen des luxemburgi-
schen Rechtes bestimmt werden. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen der
Gesetze des Großherzogtums Luxemburgs und insbesondere des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in der jeweils aktuellen Fassung.
<i>Übergangsbestimmungi>
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. De-
zember zweitausendzwölf.
<i>Stammeinlageni>
Peakside European Holdco S.à r.l., wie oben beschrieben vertreten, zeichnet die Gesamtheit des Stammkapitals der
Gesellschaft durch die Übernahme der 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile zu einem Gesamtbetrag von zwölftausend-
fünfhundert Euro (EUR 12.500) per vollständiger Barzahlung, so dass der der Gesellschaft das vollständige Stammkapital
zur Verfügung steht, was dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde und was dieser hiermit ausdrücklich beur-
kundet.
<i>Kosteni>
Die erschienene Person hat die Summe der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art, die der
Gesellschaft obliegen oder die sie infolge ihrer Gründung zu tragen hat, auf ungefähr EUR 1.400,- geschätzt.
<i>Beschluss des Einzelgesellschaftersi>
Der Einzelgesellschafter, der das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat sogleich die folgenden Beschlüsse gefasst:
1) Die folgenden Personen werden für einen unbefristeten Zeitraum zu Kategorie A Geschäftsführern der Gesellschaft
ernannt:
- Mr. Mark Fenchelle, geboren in London (England), am 14. Januar 1962 und mit Adresse in 8th Floor, 1 Knightsbridge
Green, SW1X 7NE London, England;
- Mr. Philipp Voswinkel, geboren in Bochum (Deutschland), am 11. Juli 1975 und mit Adresse in Bundesplatz 14,
CH-6300 Zug, Schweiz.
2) Die folgenden Personen werden für einen unbefristeten Zeitraum zu Kategorie B Geschäftsführern der Gesellschaft
ernannt:
- Mr. Jean-Jacques Josset, geboren in Saint-Quentin (Frankreich), am 12. Juni 1974 und mit Adresse in 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Mr. Gérald Welvaert, geboren in Uccle, am 15. Juli 1977 und mit Adresse in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg.
3) Der Sitz der Gesellschaft wird in 18-20, rue Edward Steichen, Luxembourg, L-2540, festgesetzt.
<i>Notarieller Beurkundungshinweisi>
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde in der Sprache des Erschienenen welcher dem Notar namentlich bekannt ist, hat
derselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Signé: S. Sari et R. Arrensdorff.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 février 2012. LAC/2012/8442. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2012.
Référence de publication: 2012028631/246.
(120037705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
44544
AMP Capital Investors (Luxembourg No. 5) S.à r.l.
Arkess Sicav
Ayu Holding S.A., société de gestion de patrimoine familial
Bairlinvest S.A.
Cleome Index
COLUPA S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial
Confira Financière S.A.
Decopress SA SPF
Dexia Overseas S.A.
E.H.I. Euro Hotel Investments S.A.
EIRSP Investments S.à r.l.
EnVivo International III S.à r.l.
EnVivo International I S.à r.l.
EnVivo (Luxembourg) I S.à r.l.
Expert Capital S.A.
Expert Capital S.A.
Garden Projektentwicklung GmbH
Gutland Mëllech S.A.
Holzbau Henz S.à r.l.
INREDE S.A. (International Nippon Real Estate Development & Finance S.A.)
Jovest Holding S.A.
Katrann Private SA SPF
Kaupthing Manager Selection
MCP III Investment S.à r.l.
Medicover Holding S.A.
Mutualité d'Aide aux Artisans
Orco Property Group
PARTELL HOLDING (Luxembourg) S.A.
RAU & RAU Consulting S.à r.l.
Rebrifi SPF S.A.
REIL (Real Estate Investments in Luxembourg) S.A. (Soparfi)
Restaurant Holding II S.à r.l.
Restaurant Holding II S.à r.l.
Retail Real Estate S.A.
Retail Real Estate S.A.
Rivaty Investments S.A.
Robeco Lux-O-Rente
Roberta Di Camerino S.A.
Rose Capital S.A.
RS-IC S.à r.l.
Saserna S.A.
Scanship Environmental Luxembourg S.à r.l.
SEB SICAV 3
SHB Sicav
Sisto Armaturen S.A.
Société anonyme des Entreprises Minières S.A., SPF
SPL Gestion
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV
Thryn Holding S.à r.l.
Tokelia S.A., SPF
Tolomei Partenaire S.A.
Utopia S.A.
Vahina