logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 760

22 mars 2012

SOMMAIRE

2 boulevard Konrad Adenauer S.à r.l.  . . . .

36473

Ampus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36473

Bel Top Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36446

Blue Fish S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36468

CEREP III Investment AA S.à r.l.  . . . . . . . .

36458

CPEX S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36471

Emerlux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36435

Grana Companies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36445

GT Multi Alternative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36475

Hung Top Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36476

IT-House  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36434

IT-Managed Services S.A. (ITMS S.A.)  . . .

36434

Jacoby Neal Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36444

JFC Advanced S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36434

JFC Advanced S.A. SICAR  . . . . . . . . . . . . . .

36434

Kenmore Astoria S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

36444

L'Ecluse Investissements S.à r.l.  . . . . . . . . .

36447

Leony S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36445

LIB Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36445

Logicinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36446

LSP Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36446

Lux Integral Vision Holding S.A.  . . . . . . . . .

36456

LuxMedia-Marketing A.G. . . . . . . . . . . . . . . .

36445

Maclali S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36457

Marlyssa Holding S.A.- SPF  . . . . . . . . . . . . .

36458

Mediq Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

36457

Metastorm (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . .

36476

Mobi.lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36468

Mobi.lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36468

Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36446

Mongolian Coal Corporation S.à r.l.  . . . . .

36457

M.S. Stainless Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

36456

Nineteen Sixty Eight (SPF) S.A.  . . . . . . . . .

36468

Norron SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36434

North REOF Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

36469

North REOF Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

36469

Ode S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36469

One O One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36470

Onex RSI Holdings Limited  . . . . . . . . . . . . .

36470

Patron Alma Holdings S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

36458

Pendekar Holdings (HARIPUR) S.à r.l.  . . .

36469

Pendekar Holdings (Meghnaghat) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36470

Penfret (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36474

Ploquette (SPF) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36474

Porte des Ardennes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

36470

Quaden Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36474

Recupierre S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36475

RentaPLACE (SPF) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

36475

Salvador Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36479

Sammy Jewels S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36479

Simax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36479

Simon Ivanhoe II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

36479

S.K. Investments S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

36475

Soa People Group SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36480

Soa People SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36480

Summit Partners IX, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

36457

Top Collection (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

36480

TRE International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36456

TRE Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36480

36433

L

U X E M B O U R G

Norron SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 158.534.

EXTRAIT

Madame Ann-Charlotte Lawyer a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 31 janvier

2012. Il a été décidé de coopter Monsieur Anders Malcolm comme nouvel administrateur et président en remplacement
avec effet au 1 

er

 février 2012. Le mandat de Monsieur Anders Malcolm prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2012.

La nomination de Monsieur Anders Malcolm comme nouvel administrateur sera soumise à la ratification lors de la

prochaine assemblée générale.

De ce fait le conseil d'administration de la Société se compose comme suit à partir du 1 

er

 février 2012:

- M. Anders Malcolm avec adresse professionnelle à 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg;
- M. Alexander Zetterquist, avec adresse professionnelle à 4, Oxtorgsgatan, S-111 57 Stockholm;
- M. Olivier Scholtes, avec adresse professionnelle à 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012021536/19.
(120027498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

IT-House, Société Anonyme.

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 112.868.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IT-HOUSE SA

Référence de publication: 2012021478/10.
(120027194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

IT-Managed Services S.A. (ITMS S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 96.686.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IT-MANAGED SERVICES S.A. (ITMS S.A.)

Référence de publication: 2012021479/10.
(120027195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

JFC Advanced S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. JFC Advanced S.A. SICAR).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 124.847.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 13 février 2012

1. La société anonyme BDO Audit a démissionné de son mandat de réviseur d'entreprise agrée.
2. La société à responsabilité limitée Kohnen &amp; Associés S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 114190 ayant son siège social

au 62, avenue de la Liberté, L-1930, Luxembourg a été nommé comme commissaire de la société jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2016.

36434

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 14 février 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour JFC Advanced S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012021482/17.
(120027137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Emerlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 164.191.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of January;
Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

1. Permira IV Continuing L.P.2 a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey)

Law, 1995 (as amended), acting by its manager, Permira IV Managers L.P., a limited partnership registered in Guernsey
under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner Permira IV Managers
Limited whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;

2. P4 Co-Investment L.P., acting by its general partner Permira IV G.P. L.P., acting by its general partner Permira IV

GP Limited whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;

3. Permira Investments Limited, acting by its nominee Permira Nominees Limited whose registered office is at Trafalgar

Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;

here represented by Mrs Alexia UHL, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies

given under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, are the shareholders (the "Shareholders") of Emerlux S.à

r.l.., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.191 and, incorporated pursuant to a
deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated 12 October 2011, whose articles of incor-
poration have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Articles") number 2985, page
143272 on 6 December 2011. The Articles have not been amended since then.

The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decision to convert the shares of the Company into different classes of shares, i.e. ordinary shares and classes of

preferred shares (classes A1 to A9 shares), and subsequent reallocation of the existing shares into twenty thousand
(20,000) ordinary shares.

2. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of two million two hundred sixty-nine thousand

two hundred eighty-four Euros (EUR 2,269,284.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand Euros
(EUR 20,000.-) to two million two hundred eighty-nine thousand two hundred eighty-four Euros (EUR 2,289,284.-) by
the issue of two million two hundred sixty-nine thousand two hundred eighty-four (2,269,284.-) new shares with a nominal
value of one Euro (EUR 1.-) (the "New Shares"), subject to the payment of a share premium of a total amount of two
hundred twenty-six million six hundred thirty-eight thousand nine hundred eighteen Euros (EUR 226,638,918.-), to be
divided into:

- seventeen thousand four hundred seventy-five (17,475) ordinary shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A1 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A2 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A3 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A4 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A5 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A6 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A7 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A8 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A9 shares,
3. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of the Company.

36435

L

U X E M B O U R G

4. Decision to insert new articles 8 and 9 in the Articles of the Company and to subsequently renumber the current

articles 8 to 20 into articles 10 to 22 of the Articles.

5. Decision to amend paragraph 9 

th

 of article 13 (previous article 11) of the Articles of the Company.

6. Decision to amend article 20 (previous article 18) of the Articles of the Company.
7. Decision to insert a new article 21 in the Articles of the Company and subsequent renumbering of the articles 21

and 22 into articles 22 and 23.

8. Miscellaneous.
After deliberation, the shareholders have adopted the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to convert the shares of the Company into different classes of shares, i.e. ordinary shares

and classes of preferred shares (classes A1 to A9 shares), and to subsequently reallocate the existing shares into twenty
thousand (20,000) ordinary shares.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two million two hundred

sixty-nine thousand two hundred eighty-four Euros (EUR 2,269,284.-) so as to raise it from its present amount of twenty
thousand Euro (EUR 20,000.-) to two million two hundred eighty-nine thousand two hundred eighty-four Euros (EUR
2,289,284.-)  by  the  issue  of  two  million  two  hundred  sixty-nine  thousand  two  hundred  eighty-four  (2,269,284)  new
ordinary and classes of preferred shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), to be divided into:

- seventeen thousand four hundred seventy-five (17,475) ordinary shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A1 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A2 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A3 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A4 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A5 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A6 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A7 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A8 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A9 shares,
and having the rights and obligations set out in the Articles (the "New Shares"),
subject to the payment of a share premium of a total amount of two hundred twenty-six million six hundred thirty-

eight thousand nine hundred eighteen Euros (EUR 226,638,918.-).

The New Shares shall be subscribed as follows:
- Permira IV Continuing L.P.2, aforementioned, declares to subscribe to the ownership of sixteen thousand seven

hundred forty-one (16,741) ordinary shares, two hundred thirty-nine thousand six hundred ninety-one (239,691) class
A1 shares, two hundred thirty-nine thousand six hundred ninety-one (239,691) class A2 shares, two hundred thirty-nine
thousand six hundred ninety-one (239,691) class A3 shares, two hundred thirty-nine thousand six hundred ninety-one
(239,691) class A4 shares, two hundred thirty-nine thousand six hundred ninety-one (239,691) class A5 shares, two
hundred thirty-nine thousand six hundred ninety-one (239,691) class A6 shares, two hundred thirty-nine thousand six
hundred ninety-one (239,691) class A7 shares, two hundred thirty-nine thousand six hundred ninety-one (239,691) class
A8  shares,  two  hundred  thirty-nine  thousand  six  hundred  ninety-one  (239,691)  class  A9  shares,  to  be  paid  up  by  a
contribution in cash. The global amount of two hundred nineteen million two hundred ninety-three thousand two hundred
and five Euros (EUR 219,293,205.-) relating to the new shares subscribed by Permira IV Continuing L.P.2 is allocated as
follows: two million one hundred seventy-three thousand nine hundred sixty Euros (EUR 2,173,960.-) are allocated to
the share capital of the Company and two hundred seventeen million one hundred nineteen thousand two hundred forty-
five Euros (EUR 217,119,245.-) are allocated to the share premium account of the Company.

- Permira Investments Limited, aforementioned, declares to subscribe to the ownership of five hundred seventy-two

(572) ordinary shares, eight thousand one hundred eighty-six (8,186) class A1 shares, eight thousand one hundred eighty-
six (8,186) class A2 shares, eight thousand one hundred eighty-six (8,186) class A3 shares, eight thousand one hundred
eighty-six (8,186) class A4 shares, eight thousand one hundred eighty-six (8,186) class A5 shares, eight thousand one
hundred eighty-six (8,186) class A6 shares, eight thousand one hundred eighty-six (8,186) class A7 shares, eight thousand
one hundred eighty-six (8,186) class A8 shares, eight thousand one hundred eighty-six (8,186) class A9 shares, to be paid
up by a contribution in cash. The global amount of seven million four hundred eighty-eight thousand nine hundred eighty-
two Euros (EUR 7,488,982.-) relating to the new shares subscribed by Permira Investments Limited is allocated as follows:
seventy-four thousand two hundred forty-six Euros (EUR 74,246.-) are allocated to the share capital of the Company and
seven million four hundred fourteen thousand seven hundred thirty-six Euros (EUR 7,414,736.-) are allocated to the share
premium account of the Company.

36436

L

U X E M B O U R G

- P4 Co-Investment L.P., aforementioned, declares to subscribe to the ownership of one hundred sixty-two (162)

ordinary shares, two thousand three hundred twenty-four (2,324) class A1 shares, two thousand three hundred twenty-
four (2,324) class A2 shares, two thousand three hundred twenty-four (2,324) class A3 shares, two thousand three
hundred twenty-four (2,324) class A4 shares, two thousand three hundred twenty-four (2,324) class A5 shares, two
thousand three hundred twenty-four (2,324) class A6 shares, two thousand three hundred twenty-four (2,324) class A7
shares,  two  thousand  three  hundred  twenty-four  (2,324)  class  A8  shares,  two  thousand  three  hundred  twenty-four
(2,324) class A9 shares, to be paid up by a contribution in cash. The global amount of two million one hundred twenty-
six thousand fifteen Euro (EUR 2,126,015.-) relating to the new shares subscribed by P4 Co-Investment L.P. is allocated
as follows: twenty-one thousand seventy-eight Euro (EUR 21,078.-) are allocated to the share capital of the Company
and two million one hundred four thousand nine hundred thirty-seven Euro (EUR 2,104,937.-) are allocated to the share
premium account of the Company.

<i>Third resolution

Further to the conversion and the capital increase in the resolutions above, the Shareholders resolve to amend article

5 of the Articles which shall now read as follows:

Art. 5. The Company's share capital is set at two million two hundred eighty nine thousand two hundred eighty four

Euros (EUR 2,289,284.-) divided into:

- thirty seven thousand four hundred seventy five (37,475) ordinary shares (the "Ordinary Shares"),
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A1 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A2 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A3 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A4 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A5 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A6 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A7 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A8 shares,
- two hundred fifty thousand two hundred and one (250,201) class A9 shares,
all class A1 to class A9 shares are referred as the "A Shares", together with the Ordinary Shares, the "Shares", having

a nominal value of one euro (EUR 1.-) and fully paid up.

The subscription to, holding or transfer of Ordinary Shares cannot be done without subscribing for, holding or trans-

ferring at the same time A Shares (i.e. stapling of the Ordinary and the A Shares), except redemption and cancellation of
A Shares.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence."

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to insert new articles 8 and 9 in the Articles of the Company and to subsequently renumber

the current articles 8 to 20 into articles 10 to 22 of the Articles.

The new articles 8 and 9 shall be read as follows:

Art. 8. The share capital of the Company may be reduced by the cancellation of one or more entire classes of A Shares

through the repurchase and cancellation of all the A Shares in issue in such class(es), in accordance with the provisions
as set out in this article 8. In the case of repurchases and cancellations of classes of Special Shares such cancellations and
repurchases shall be made in the reverse numerical order (starting with the class A9).

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of A Shares, such

class of A Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with
the limitation however to the Total Cancellation Amount) and the holders of A Shares of the repurchased and cancelled
class of A Shares shall be entitled to an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each A Share of the relevant
class held by them and repurchased and cancelled.

The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of A

Shares in issue in the class of Special Shares to be repurchased and cancelled.

The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Managers on the basis of the relevant

Interim Accounts and in accordance with the provisions of Article 21 of the Articles. The Total Cancellation Amount for
each relevant class of A Shares shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the redemption and
cancellation of the relevant class of A Shares, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than the Available Amount. Upon the repurchase and cancellation of the A Shares of the relevant class of A Shares, the
Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

For the purposes of these Articles, the following words shall have the following definitions:

36437

L

U X E M B O U R G

- "Available Amount" means in relation to the relevant class of A Shares the total amount of net profits attributable

to that class of A Shares (subject to the provisions of Article 21 of the Articles) (including carried forward profits), to
the extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to Article 21 of the Articles,
increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and
(ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of A
Shares to be cancelled to the extent this corresponds to the available amounts in accordance with the law but reduced
by (i) any losses (included carried forward losses), (ii) the fixed dividends on the A Shares other than the class of A Shares
subject to the repurchase and cancellation, the Hurdle Shares and the Unlimited Shares accrued and unpaid and (iii) any
sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or of the Articles or in the reasonable opinion
of the Manager set aside to cover running costs of the Company, each time as set out in the relevant Interim Accounts
(without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

AA = (NP + P+ CR) – (L + LR+ FD+PR)
Whereby:
AA= Available Amount;
NP= net profits attributable to the class of A Shares in accordance with the provisions of Article 21 of the Articles

(including carried forward profits as determined for the relevant class of class of A Shares in accordance with the provi-
sions of Article 21 of the Articles)

P= freely distributable share premium and reserves;
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of A Shares to be

cancelled to the extent this corresponds to the available amounts in accordance with the law;

L= losses (including carried forward losses if any);
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or of the Articles;
FD = the fixed dividend on the Special Shares (other than the class of Special Shares subject to the repurchase and

cancellation), the Hurdle Shares and the Unlimited Shares as determined in article 21 of the Articles;

PR = sums set aside to cover running costs of the Company in the reasonable opinion of the Manager.
-"Cancellation Value Per Share" means the cancellation amount per Special Share within the relevant class to be paid

to the Shareholders.

-"Interim Accounts" means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
-"Interim Accounts Date" means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancel-

lation of the relevant class of Shares.

-"Total Cancellation Amount" means the amount to be paid as the redemption price for the class of Special Shares so

redeemed.

Art. 9. Any amount of share premium paid in addition to the nominal value of any Share shall be allocated to a premium

reserve(s), not reserved to specific class of shares or to the holder of the Shares in relation to which it has been paid.
Such premium reserve(s) shall be freely distributable by the Company."

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend paragraph 9th of article 13 (previous article 11) of the Articles of the Company,

which shall now be read as follows:

Art. 13. [...] Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, such conference

call to be initiated from Luxembourg, or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in
the meeting to hear one another and to communicate with one another. Under exceptional circumstances, a meeting
may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting

[...]".

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to amend article 20 (previous article 18) of the Articles of the Company, which shall now

be read as follows:

Art. 20. Each year, as at the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must

be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into."

36438

L

U X E M B O U R G

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to insert a new article 21 in the Articles of the Company and subsequent renumbering of

the articles 21 and 22 (previous articles 19 and 20) into articles 22 and 23:

Art. 21. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by

the Shareholders in accordance with the following provisions of this article 21.

The holders of the A Shares are entitled to the following annual fixed dividends:
- the holders of class A1 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point ten per

cent (0.10%) of the par value of the class A1 Shares held by them, then,

- the holders of class A2 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point fifteen

per cent (0.15%) of the par value of the class A2 Shares held by them, then,

- the holders of class A3 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point twenty

per cent (0.20%) of the par value of the class A3 Shares held by them, then,

- the holders of class A4 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point twenty-

five per cent (0.25%) of the par value of the class A4 Shares held by them, then,

- the holders of class A5 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point thirty

per cent (0.30%) of the par value of the class A5 Shares held by them, then,

- the holders of class A6 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point thirty-

five per cent (0.35%) of the par value of the class A6 Shares held by them, then

- the holders of class A7 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point forty per

cent (0.40%) of the par value of the class A7 Shares held by them, then,

- the holders of class A8 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point forty five

per cent (0.45%) of the par value of the class A8 Shares held by them, then,

- the holders of class A9 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point fifty per

cent (0.50%) of the par value of the class A9 Shares held by them.

Should any class of shares have been cancelled following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the

distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the next outstanding class of shares to
be redeemed in the reverse numerical order (e.g. initially class A9 Shares).

If the dividends referred to above are not declared or paid during one or more particular years, the fixed dividends

entitlement shall continue to accrue.

In any case, dividends can only be distributed and Shares redeemed to the extent that the Company has distributable

sums within the meaning of the Law and in accordance with the applicable provisions of the Law.

Notwithstanding the preceding provisions, the board of managers is authorized to declare and pay interim dividends

to the shareholder(s) in accordance with the distribution provisions described in the preceding provisions of this Article
21 before the end of the financial year and in accordance with the applicable legal provisions."

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing parties, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille douze, le vingt-septième jour de janvier,
Par-devant le soussigné, Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1. Permira IV Continuing L.P.2 un limited partnership enregistré à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships

(Guernsey) de 1995 (telle que modifiée), agissant par son gérant, Permira IV Managers L.P., un limited partnership enre-
gistré à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995 (telle que modifiée), agissant par son general
partner Permira IV Managers Limited ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey,
îles Anglo-Normandes;

2. P4 Co-Investment L.P., agissant par son general partner Permira IV G.P. L.P., agissant par son general partner Permira

IV GP Limited ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, îles Anglo-Normandes;

3. Permira Investments Limited, agissant par son nominée Permira Nominees Limited ayant son siège social à Trafalgar

Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, îles Anglo-Normandes,

36439

L

U X E M B O U R G

ici représentées par Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu

de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront

attachées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesdites parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, sont les associés (les "Associés") de Emerlux S.à

r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.191 (la "Société") et constituée en vertu
d'un acte rédigé par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 octobre 2011, dont
les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les "Statuts") numéro 2985, page 143272
en date du 6 décembre 2011. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Conversion des parts sociales de la Société en différentes classes de part sociales, c'est à dire en parts sociales

ordinaires et classes de parts sociales privilégiées (classes de parts sociales A1 à A9) et réallocation subséquente des parts
sociales existantes en vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux millions deux cent soixante-neuf mille deux cent

quatre-vingt quatre euros (EUR 2.269.284,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille euros (EUR 20.000,-)
à un montant de deux millions deux cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 2.289.284,-)
par l'émission de deux millions deux cent soixante-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre (2.269.284) nouvelles parts
sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, soumis au paiement d'une prime d'émission d'un montant
total de deux cent vingt-six millions six cent trente-huit mille neuf cent dix-huit euros (EUR 226.638.918,-), qui seront
réparties comme suit:

- dix-sept mille quatre cent soixante-quinze (17.475) parts sociales ordinaires;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A1;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A2;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A3;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A4;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A5;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A6;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A7.
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A8.
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A9.
3. Modification subséquente de l'article 5 des Statuts de la Société.
4. Création de nouveaux articles 8 et 9 dans les Statuts de la Société et renumérotation subséquente des articles

actuels 8 à 20, en articles 10 à 22.

5. Modification du neuvième paragraphe de l'article 13 (précédent article 11) des Statuts de la Société.
6. Modification de l'article 20 (précédent article 18) des Statuts de la Société.
7. Création d'un nouvel article 21 dans les Statuts de la Société et renumérotation subséquente des articles 21 à 22

en articles 22 à 23.

8. Divers.
Après délibération, les Associés ont adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de convertir les parts sociales de la Société en différentes classes de part sociales, c'est à dire

en parts sociales ordinaires et classes de parts sociales privilégiées (classes de parts sociales A1 à A9) et de réallouer de
façon subséquente les parts sociales existantes en vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société de deux millions deux cent soixante-neuf mille deux

cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 2.269.284,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille euros (EUR
20.000,-) à un montant de deux millions deux cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre euros (EUR
2.289.284,-) par l'émission de deux millions deux cent soixante-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre (2.269.284)
nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, qui seront réparties comme suit:

- dix-sept mille quatre cent soixante-quinze (17.475) parts sociales ordinaires;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A1;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A2;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A3;

36440

L

U X E M B O U R G

- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A4;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A5;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A6;
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A7.
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A8.
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A9.
et ayant les mêmes droits et obligations définis dans les Statuts (les "Nouvelles Parts Sociales"), soumis au paiement

d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent vingt-six millions six cent trente-huit mille neuf cent dix-huit
euros (EUR 226.638.918,-).

Les Nouvelles Parts Sociales seront souscrites comme suit:
- Permira IV Continuing L.P.2, susmentionnée, déclare souscrire à la propriété de seize mille sept cent quarante et une

(16.741) parts sociales ordinaires, deux cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-onze (239.691) parts sociales de classe
A1, deux cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-onze (239.691) parts sociales de classe A2, deux cent trente-neuf
mille six cent quatre-vingt-onze (239.691) parts sociales de classe A3, deux cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-
onze (239.691) parts sociales de classe A4, deux cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-onze (239.691) parts sociales
de classe A5, deux cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-onze (239.691) parts sociales de classe A6, deux cent
trente-neuf mille six cent quatre-vingt-onze (239.691) parts sociales de classe A7, deux cent trente-neuf mille six cent
quatre-vingt-onze (239.691) parts sociales de classe A8, deux cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-onze (239.691)
parts sociales de classe A9, payées par un apport en numéraire. Le montant total de deux cent dix-neuf millions deux
cent quatre-vingt-treize mille deux cent cinq euros (EUR 219.293.205,-) relatif aux nouvelles parts sociales souscrites par
Permira IV Continuing L.P.2 est attribué comme suit: deux millions cent soixante-treize mille neuf cent soixante euros
(EUR 2.173.960,-) sont alloués au capital social de la Société et deux cent dix-sept millions cent dix-neuf mille deux cent
quarante-cinq euros (EUR 217.119.245,-) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

- Permira Investments Limited, susmentionnée, déclare souscrire à la propriété de cinq cent soixante-douze (572)

parts sociales ordinaires, huit mille cent quatre-vingt-six (8.186) parts sociales de classe A1, huit mille cent quatre-vingt-
six (8.186) parts sociales de classe A2, huit mille cent quatre-vingt-six (8.186) parts sociales de classe A3, huit mille cent
quatre-vingt-six (8.186) parts sociales de classe A4, huit mille cent quatre-vingt-six (8.186) parts sociales de classe A5,
huit mille cent quatre-vingt-six (8.186) parts sociales de classe A6, huit mille cent quatre-vingt-six (8.186) parts sociales
de classe A7, huit mille cent quatre-vingt-six (8.186) parts sociales de classe A8, huit mille cent quatre-vingt-six (8.186)
parts sociales de classe A9, payées par un apport en numéraire. Le montant total de sept millions quatre cent quatre-
vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-deux euros (EUR 7.488.982,-) relatif aux nouvelles parts sociales souscrites par
Permira  Investments  Limited  est  attribué  comme  suit:  soixante-quatorze  mille  deux  cent  quarante-six  euros  (EUR
74.246,-) sont alloués au capital social de la Société et sept millions quatre cent quatorze mille sept cent trente-six euros
(EUR 7.414.736,-) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

- P4 Co-Investment L.P., susmentionnée, déclare souscrire à la propriété de cent soixante-deux (162) parts sociales

ordinaires, deux mille trois cent vingt-quatre (2.324) parts sociales de classe A1, deux mille trois cent vingt-quatre (2.324)
parts sociales de classe A2, deux mille trois cent vingt-quatre (2.324) parts sociales de classe A3, deux mille trois cent
vingt-quatre (2.324) parts sociales de classe A4, deux mille trois cent vingt-quatre (2.324) parts sociales de classe A5,
deux mille trois cent vingt-quatre (2.324) parts sociales de classe A6, deux mille trois cent vingt-quatre (2.324) parts
sociales de classe A7, deux mille trois cent vingt-quatre (2.324) parts sociales de classe A8, deux mille trois cent vingt-
quatre (2.324) parts sociales de classe A9, payées par un apport en numéraire. Le montant total de deux millions cent
vingt-six mille quinze euros (EUR 2.126.015,-) relatif aux nouvelles parts sociales souscrites par P4 Co-Investment L.P.
est attribué comme suit: vingt et un mille soixante-dix huit euros (EUR 21.078,-) sont alloués au capital social de la Société
et deux millions cent quatre mille neuf cent trente-sept euros (EUR 2.104.937,-) sont alloués au compte de prime d'émis-
sion de la Société.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions concernant la conversion et l'augmentation de capital ci-dessus, les Associés décident de modifier

l'article 5 des Statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions deux cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre

Euros (EUR 2.289.284,-) représenté par:

- trente-sept mille quatre cent soixante-quinze (37.475) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires"),
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A1,
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A2,
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A3,
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A4,
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A5,
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A6,

36441

L

U X E M B O U R G

- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A7,
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A8,
- deux cent cinquante mille deux cent une (250.201) parts sociales de classe A9,
L'ensemble des parts sociales de classe A1 à A9 sont qualifiées de "Parts Sociales A", ensemble avec les Parts Sociales

Ordinaires, ci-après dénommées les "Parts Sociales", ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), et toutes
sont entièrement libérées.

La souscription à, la détention ou le transfert des Parts Sociales Ordinaires ne peut être réalisé sans avoir au même

moment souscrit à, détenu ou transféré des Parts Sociales A (c'est-à-dire que les Parts Sociales Ordinaires et A sont
liées), hors le cas du rachat et de l'annulation de Parts Sociales A.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des

parts existantes."

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident d'insérer un nouvel article 8 et article 9 dans les Statuts de la Société et de renuméroter les

anciens articles 8 à 20 en nouvelles articles 10 à 22 des Statuts.

Les articles 8 et 9 se liront désormais comme suit:

Art. 8. Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation d'une ou plusieurs classes de Parts Sociales A

par le biais du rachat et de l'annulation de toutes les Parts Sociales A émises dans de telle(s) classe(s), et ce conformément
aux dispositions prévues au présent article 8. Dans les cas de rachats et d'annulations de classes de Parts Sociales A, ces
annulations et rachats devront être réalisés dans l'ordre numérique inverse (en partant de la classe A9).

8.1 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe de Parts Sociales A, une telle

classe donne droit à ses détenteurs au pro rata de leur détention dans cette classe au Montant Disponible (dans la limite
cependant du Montant Total d'Annulation) et les détenteurs des Parts Sociales A de la classe de Parts Sociales A rachetée
et annulée auront droit à un montant égal à la Valeur d'Annulation Par Part Sociale pour chaque Part Sociale A de la classe
détenue par eux et rachetée et annulée.

8.2 La Valeur d'Annulation Par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de

Parts Sociales émises dans la classe d'Actions devant être rachetée et annulée.

8.3 Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance sur la base de Comptes

Intérimaires pertinents et conformément aux dispositions de l'Article 21 des Statuts. La Montant Total d'Annulation pour
chaque classe de Parts Sociales A pertinente sera le Montant Disponible de la classe de Parts Sociales A pertinente au
moment du rachat et de l'annulation de la classe de Parts Sociales A pertinente, étant entendu toutefois que le Montant
Total d'Annulation ne devra jamais être supérieur au Montant Disponible.

A compter du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la classe de Parts Sociales A concernée, la Valeur d'An-

nulation Par Action sera due et payable par la Société.

Pour les besoins de cet Article, les mots suivants auront les définitions suivantes:
"Montant Disponible" signifie en relation avec la classe de Parts Sociales A pertinente, le montant total des bénéfices

nets attribuables à la classe de Parts Sociales A (sous réserve des dispositions de l'article 21 des présents Statuts)(y compris
les reports bénéficiaires), dans la mesure où les Associés auraient été en droit de réclamer des distributions de dividende
conformément à l'Article 21 des Statuts, augmenté par (i) toute prime d'émission librement distribuable (y compris pour
éviter tout doute la réserve de prime d'émission) et (ii), le cas échéant, par le montant de la réduction du capital social
et la réduction de la réserve légale liée à la classe de Parts Sociales A devant être annulée dans la mesure où ceci correspond
aux montants disponibles conformément à la loi mais réduit par (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées) (ii) les
dividendes établis à partir des Parts Sociales A autres que celles de la classe de Parts Sociales A sujettes au rachat et à
l'annulation et (ii) toutes sommes devant être mises en réserve(s) conformément aux dispositions légales ou aux Statuts
ou mises à part pour couvrir les coûts de fonctionnement de la Société selon l'opinion raisonnable du conseil de gérance,
à chaque fois comme indiqué dans les Comptes Intérimaires pertinents (pour éviter tout doute, sans double calcul) de
telle façon que:

AA = (NP + P+ CR)-(L + LR + FD + PR)
Où:
AA = Montant Disponible;
NP = bénéfices nets attribuables à la classe d'Actions conformément aux dispositions de l'Article 21 des Statuts (y

compris les profits à reporter ainsi que déterminés pour la classe de Parts Sociales A pertinente conformément aux
dispositions de l'Article 21 des Statuts);

P = toute réserve librement distribuable;
CR = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale lié à la classe de Parts Sociales

A devant être annulée dans la mesure où ceci correspond aux montants disponibles conformément à la loi;

36442

L

U X E M B O U R G

L= pertes (y compris, le cas échéant, les pertes reportées);
LR = toutes sommes devant être mises en réserve(s) conformément aux dispositions légales ou aux Statuts;
FD = Le dividende établi à partir des Parts Sociales A (autres que celles de la classe de Parts Sociales A sujettes au

rachat et à l'annulation), comme défini à l'article 21 des Statuts;

PR = les sommes mises à part pour couvrir les coûts de fonctionnement de la Société selon l'opinion raisonnable du

Gérant.

"Valeur d'Annulation Par Part Sociale" signifie le montant d'annulation par part sociale à payer aux Associés;
"Comptes Intérimaires" signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés;
"Date des Comptes Intérimaires" signifie la date pas avant huit (8) jours avant la date de rachat de la classe de Parts

Sociales concernée;

"Montant Total d'Annulation" signifie le montant à payer comme prix de rachat pour la classe de Parts Sociales A ainsi

rachetée.

Art. 9. Tout montant de prime d'émission versé en plus de la valeur nominale de toute Part Sociale sera alloué à une

ou des réserves de prime d'émission, non réservée(s) à une classe de Parts Sociales spécifique ou au détenteur de Parts
Sociales au titre desquelles il a été payé. Cette ou ces réserves de prime d'émission sera (ou: seront) librement distribuable
(s) par la Société."

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier le neuvième paragraphe de l'article 13 (précédent article 11) des Statuts de la Société

qui se lira désormais comme suit:

Art. 13. [...] Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre, et communiquer entre elles. Une réunion peut ainsi ne se tenir qu'au moyen d'une conférence téléphonique.
La participation par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne. [...]"

<i>Sixième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 20 (précédent article 18) des Statuts de la Société, qui se lira désormais

comme suit:

Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction de tous dépenses, amortissements, charges et

provisions représentent le bénéfice net de la société.

Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pourcent du capital social, étant entendu

que ce prélèvement doit reprendre jusqu'à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et
pour quelque raison que ce soit, il a été entamé.

<i>Septième résolution

Les Associés décident d'insérer un nouvel article 21 dans les Statuts de la Société, et renuméroter les articles 21 et

22 (précèdent articles 19 et 20) en article 22 et 23.

L'article 21 se lira désormais comme suit:

Art. 21. La décision de distribuer des fonds et la détermination du montant d'une telle distribution seront prises par

les Associés conformément aux dispositions suivantes du présent article 21.

Les détenteurs de Part Sociales A ont droit aux dividendes fixes annuels suivants:
- les détenteurs de Parts Sociales de classe A1 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un

montant de zéro virgule dix pourcent (0,10%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe A1 détenus par eux, puis,

- les détenteurs de Parts Sociales de classe A2 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un

montant de zéro virgule quinze pourcent (0,15%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe A2 détenus par eux,
puis,

- les détenteurs de Parts Sociales de classe A3 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un

montant de zéro virgule vingt pourcent (0,20%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe A3 détenus par eux,
puis,

- les détenteurs de Parts Sociales de classe A4 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un

montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe A4 détenus par
eux, puis,

36443

L

U X E M B O U R G

- les détenteurs de Parts Sociales de classe A5 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un

montant de zéro virgule trente pourcent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe A5 détenus par eux,
puis,

- les détenteurs de Parts Sociales de classe A6 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un

montant de zéro virgule trente-cinq pourcent (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe A6 détenus par
eux, puis,

- les détenteurs de Parts Sociales de classe A7 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un

montant de zéro virgule quarante pourcent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe A7 détenus par
eux, puis,

- les détenteurs de Parts Sociales de classe A8 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un

montant de zéro virgule quarante-cinq pourcent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe A8 détenus
par eux, puis,

- les détenteurs de Parts Sociales de classe A9 seront habilités à des distributions de dividendes pour un montant de

zéro virgule cinquante pourcent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de classe A9 détenus par eux.

Si aucune classe de Parts de Sociales a été annulée à la suite de son rachat ou autrement au moment de la distribution,

le reste de toute distribution de dividendes sera ensuite affecté à la classe de Parts Sociales suivante restante devant être
rachetée dans l'ordre numérique inverse (par exemple, d'abord les Parts Sociales de classe A9).

Si les dividendes susmentionnés ne sont pas déclarés ou payés durant une ou plusieurs années en particulier, les

dividendes fixes continueront de produire des intérêts.

Dans tous les cas, les dividendes peuvent seulement être distribués et les Parts Sociales rachetées dans la mesure où

la Société a des sommes distribuables au sens de la Loi et conformément aux dispositions applicables de la Loi.

Nonobstant les dispositions précédentes, le conseil de gérance est autorisé à déclarer et payer des dividendes intér-

imaires au(x) associé(s) conformément aux dispositions relatives à la distribution décrites dans les précédentes disposi-
tions du présent Article 21 avant la fin de l'exercice social et conformément aux dispositions légales applicables."

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties

comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties compa-
rantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 janvier 2012. LAC/2012/4782. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 6 février 2012.

Référence de publication: 2012018243/529.
(120022296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.

Jacoby Neal Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 6, rue Helpert.

R.C.S. Luxembourg B 123.104.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012021481/10.
(120027437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Kenmore Astoria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.847.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

36444

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 14 février 2012.

Référence de publication: 2012021486/10.
(120027214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Leony S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 133.781.

Les comptes annuels pour l'année 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2012.

James Bermingham.

Référence de publication: 2012021491/10.
(120027530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

LuxMedia-Marketing A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1D, Waïstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 151.269.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LuxMedia-Marketing A.G.

Référence de publication: 2012021498/10.
(120027196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Grana Companies, Société Anonyme.

Siège social: L-1937 Luxembourg, 1, rue Auguste Liesch.

R.C.S. Luxembourg B 128.311.

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d' administration tenu au siège social le 2 février 2012

Le Conseil adopte, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1°) le transfert du siège social au Luxembourg à l'adresse suivante: 1 rue Auguste Liesch à L-1937 Luxembourg. Cette

décision prend effet dès ce jour.

2°) la nomination de FMV Consulting SA, 47 boulevard Joseph II L-1840 à Luxembourg, RCS n°B109612 jusqu'à l'as-

semblée ordinaire de 2016. Cette décision prend effet dès ce jour.

Cédric ARGENTO.

Référence de publication: 2012021655/14.
(120027746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

LIB Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 51.507.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 25 janvier 2012,

au siège social que:

1. Les actionnaires prennent acte du nouveau siège social du commissaire aux comptes IAS CONSULTING LIMITED,

à Waterdale, Redmans Hill, Blackford, Wedmore, Somerset, BS28 4 NQ, Royaume Uni.

Luxembourg, le 27 janvier 2012.

<i>Pour Lib Holdings S.A.
Alma Thomas
<i>Administrateur unique

Référence de publication: 2012021499/16.
(120027399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

36445

L

U X E M B O U R G

Logicinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 86.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
LOGICINVEST S.A.

Référence de publication: 2012021500/11.
(120027440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

LSP Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 154.479.

Veuillez être informés du changement d'adresse professionelle des gérants suivants à partir du 19 octobre 2011. Dans

ces conditions, veuillez enregistrer les nouvelles coordonnées des administrateurs ci-dessous:

Dylan DAVIES

Cédric BRADFER

6D, route de Trèves

6D, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

L-2633 Senningerberg

Luxembourg

Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2012.

Référence de publication: 2012021502/15.
(120027173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.205.

<i>Rectificatif de la première version de la publication enregistrée sous référence L120027047 déposé le 14.02.2012

Les comptes annuels rectificatifs au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jorrit Crompvoets.

Référence de publication: 2012021515/12.
(120027449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Bel Top Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 116.775.

<i>Extrait des résolutions prises à l'associé unique de la société tenue en date du 8 février 2012

1.  L'associe  unique a  pris acte  de la  démission  de  Monsieur  Michael Chidiac,  né  le 29 juin 1966  à  Beirut (Liban),

demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société
avec effet au 31 décembre 2011.

Le conseil de gérance de la de Société se compose désormais comme suit:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE (gérant),
2. Monsieur Pii KETVEL (gérant),
3. Monsieur Bernd JANIETZ (gérant)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2012021648/18.
(120027340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

36446

L

U X E M B O U R G

L'Ecluse Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 166.639.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the sixteenth day of January,
Before us, Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Lock One Investments International Ltd., a limited liability company incorporated and organized under the laws of

Ohio, having its registered office at 40 South Washington Street, New Bremen, Ohio 45869 (United States of America)
represented by Me Laurence JACQUES, lawyer, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy given under
private seal in Brussels and dated 12 

th

 January 2012, said proxy, after being signed “ne varietur” by the proxyholder and

the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing party has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a private limited

liability company under the name of L'Ecluse Investissements S.à r.l. which is hereby established as follows:

I. Form, Name, Duration, Registered Office

Art. 1. Form and Name.
1.1. There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») under the name of L'Ecluse

Investissements S.à r.l. which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended
(the “Law”), as well as by these articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Duration.
2.1. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 3. Registered Office.
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
3.2. It may be transferred within the municipality by decision of the sole manager or the board of managers, as the

case may be.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the general meeting of

the shareholders, which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

3.3. Branches or other offices of the Company may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of

the sole manager or the board of managers, as the case may be.

II. Purpose of the Company

Art. 4. Purpose.
4.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, deve-
lopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, management and/or lease of immo-

vable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable
properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal
object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties. In general, the
Company may carry out any real estate operations with the exception of those reserved to real estate agents.

4.2. The Company may also hold, develop, exploit trademarks, patents, concessions, licenses or any other intellectual

property rights, directly or through the exploitation of concessions or licenses.

4.3. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, notes and other debt instruments,

which may be convertible or not, except by way of a public offer.

4.4. The Company may grant any assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or

companies in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or indirectly controlled by the shareholder
of the Company (hereafter referred to as the «Affiliated Company»).

The Company may in particular:
- advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity, with or

without security;

- enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations

of the Company or of any Affiliated Company.

36447

L

U X E M B O U R G

4.5. The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar corporate structures.

4.6. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-

plishment or development of its purpose. It is however understood that the Company will not enter into any transaction,
which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

4.7. The Company is authorized to open branches or offices in the Grand Duchy and in foreign countries.

III. Capital and Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1. The Company's subscribed share capital is set at twenty five thousand euro (EUR 25,000.-) represented by one

hundred (100) shares without nominal value.

5.2. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision

of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles, as the
case may be.

5.3. The Company may redeem its own shares, within the limits set forth by the Law.

Art. 6. Shares.
6.1. All shares are in registered form and recorded in a shareholders' register in accordance with the Law. The ow-

nership of shares is established by inscription in said register. Certificates of these recordings shall be issued and signed
by 2 managers upon request of the relevant shareholder.

The Company will recognize only one holder per share. Co-owners shall appoint a sole person to represent them

towards the Company.

6.2. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder shall

not lead to the dissolution, liquidation or similar termination of the Company.

6.3. Each share entitles its holder to partake in the Company's assets and profits prorata to the number of outstanding

shares.

6.4. Shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares must be recorded by a notarial or private

deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company
or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Luxembourg civil Code.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless a general meeting of the shareholders repre-

senting at least three-quarters of the Company's share capital shall have agreed thereto.

In the event of death, the transfer of the shares of the deceased shareholders to non-shareholders is subject to the

prior approval of the general meeting of shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval
is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

IV. Management

Art. 7. Management.
7.1. The Company is managed by one or several managers appointed by the sole shareholder or the general meeting

of shareholders, as the case may be, which sets the term of its/their office. A manager does not need to be a shareholder.

7.2. A manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or the

general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 8. Decisions of the managers.
8.1. If several managers are appointed, they shall form a board of managers. The board of managers shall be composed

of at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

8.2. The board of managers shall meet as often as the Company's so requires or upon request of any manager, at the

place indicated in the convening notice.

8.3. The board of managers shall choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a

secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the board of managers. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, in his/her/its absence, the
board of managers shall, at the majority of their votes, appoint another manager as chairman pro tempore.

8.4. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the circumstances
of the emergency shall be mentioned in the convening notice.

No convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or repre-

sented at the meeting and if they state to have been duly informed of the agenda of the meeting. The notice may be waived
by the written consent of each member of the board of managers, such consent being given in original, fax or electronic
mail (without electronic signature) or any other communication means. No convening notice shall be required for a
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

36448

L

U X E M B O U R G

8.5. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in

writing, by fax or electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communication.

8.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or other

communication means allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

8.7. The board of managers can deliberate or act only if at least a majority of the managers is present or represented

at the meeting only if at least one Class A Manager and one Class B Manager are present or represented. Decisions shall
be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

8.8. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed either by the chairman, the vice-chairman,

two managers or one Class A Manager and one Class B Manager. Copies or extracts of such minutes, which may be
produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or two managers.

8.9. Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held by the board of managers. Such signatures may appear on a single or several counterpart
(s) in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

Art. 9. Powers of the manager(s).
9.1. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competences of the sole manager or the board of managers, as the case may be. The sole manager or the board of
managers, as the case may be, shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company's purpose.

9.2. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is authorized to delegate the daily management

of the Company to one or several persons, who do not need to be managers.

9.3. Special and limited powers may be delegated by the sole manager or the board of managers, as the case may be,

for determined matters and within a limited period of time to one or several persons, who do not need to be managers.

Art. 10. Representation. The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or by

the joint signature of at least one Class A Manager and one Class B Manager or the signature of any person to whom a
signatory power shall be delegated in accordance with article 9.2. and 9.3. of these Articles.

Art. 11. Manager's liability. A manager assumes, by reason of his mandate, no personal liability in relation to any

commitment validly made by him in the name of the Company, provided such commitment complies with the Law and
the Articles.

V. Shareholding

Art. 12. Voting Rights.
12.1. Each share entitles its holder to one vote.
12.2. Each shareholder may participate in the general meeting of the shareholders irrespective of the number of shares

he owns.

Art. 13. Powers.
13.1. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, assumes all the powers con-

ferred to the general meeting of shareholders by the Law or these Articles.

13.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide that the financial

statements and operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who do not need
to be shareholders. They must appoint one or several statutory auditors if there are more than 25 (twenty-five) share-
holders in the Company. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall fix their remuneration and
term of their mandate.

Art. 14. Decisions of the sole shareholder.
14.1. Decisions of the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes.
14.2. Contracts entered into between the Company and the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or

recorded in minutes, except if such contracts relate to usual business operations of the Company entered into normal
market conditions.

Art. 15. Decisions of the general meeting of shareholders.
15.1. Collective decisions of the shareholders may be taken either by holding a general meeting of shareholders or by

written resolutions, if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25). In such event, each
shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his
vote in writing. Each shareholders' signature may appear on a single or several counterpart(s), in original or copy delivered
by fax, electronic mail or any other communication means.

36449

L

U X E M B O U R G

15.2. The decisions of the general meeting of shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by a

majority of shareholders owning more than half of the share capital. However, an amendment to the articles of incor-
poration requires the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

VI. Financial year, Annual accounts, Allocation of profits

Art. 16. Financial year. The Company's financial year begins on the 1 

st

 of January of each year and ends on the 31 

st

of December of that same year.

Art. 17. Annual accounts. Each year, with reference to the end of the Company's financial year, the Company's accounts

are drawn up, and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities. The inventory and the accounts shall be available for inspection by each
shareholder at the Company's registered office.

Art. 18. Allocation of profits.
18.1. The net profit of the Company is equal to the gross profit as stated in the annual accounts less the general

expenses, amortization and expenses.

18.2. Each year, an amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory

reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

18.3. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding

in the Company by a decision of the general meeting of shareholders.

18.4. Interim dividends may be distributed by the board of managers to the shareholder(s) subject to the following

conditions:

- interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient;
- the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the

annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this
purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Law;

- the decision of the board of managers to distribute such interim dividend may not be taken more than two (2) months

after the date at which the interim accounts referred here above have been drawn up;

- The statutory auditor or an independent auditor, in case no statutory auditor has been appointed, shall verify whether

the above conditions have been fulfilled and shall issue a report to confirm the same to the board of managers.

18.5. Where the payments of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided upon by the

general meeting of shareholders, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account
of the next dividend.

VII. Dissolution, Liquidation

Art. 19. Dissolution - Liquidation.
19.1. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or several liquidators who

do not need to be shareholders, appointed by a decision of the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization
of the assets and payment of the liabilities of the Company.

19.2. The liquidation proceeds may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in

the Company.

VIII. General Provisions

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appeared party

has subscribed and fully paid up the following shares:

Subscriber

Number

of shares

Aggregate

Subscription

price (EUR)

Payment

(EUR)

Lock One Investments International Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

25,000.-

25,000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

25,000.-

25,000.-

of the payment of the total subscription price has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately eleven hundred euros (EUR 1,100.-).

36450

L

U X E M B O U R G

<i>Extraordinary General Meeting

The shareholder has immediately taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company and shall be members of the Board of Managers

of the Company for an undetermined period of time:

<i>a) Class A managers:

- Mr. James Frederick Dicke II, born in Texas, USA, on November 9, 1945, residing at 422 Easthaven Drive, New

Bremen, Ohio 45869 (United States of America); and

- Mr. James Frederick Dicke III, born in Ohio, USA, on August 27, 1971, residing at 04670 Lock Two Road, New

Bremen, Ohio 45869 (United States of America);

<i>b) Class B managers:

- Mr. Denis Van den Bulke, born in Liège (Belgium) on 10 July 1959, residing at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg (Grand-Duchy of Luxembourg); and

- Mrs. Laurence Jacques, born in Verviers (Belgium) on 11 April 1977, residing at 35, avenue Monterey, L-2163 Lu-

xembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahr zweitausend und zwölf, am sechzehnten Tag des Monats Januar,

erschien

vor mir, Maître Léonie GRETHEN , Notar in Luxemburg,
die folgenden Personen
Lock One Investments International Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Ohio mit

eingetragenem Geschäftssitz in 40 South Washington Street, New Bremen, Ohio 45869 (Vereinigte Staaten von Amerika),
vertreten durch Me Laurence Jacques, Anwalt auf der Grundlage einer mit privatem Siegel in Brüssel erteilten Vollmacht
vom zwölften Januar, wobei die genannte Vollmacht nach einer „ne varietur“ Abzeichnung des Bevollmächtigten und des
unterzeichnenden Notars der vorliegenden Urkunde beigefügt wurde.

Die erschienene Partei bat den unterzeichnenden Notar um Protokollierung des Gesellschaftsvertrags einer Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung in Firma L'Ecluse Investissements S.à r.l., die hiermit wie folgt gegründet wird:

I. Rechtsform, Bezeichnung, Dauer, Eingetragener Geschäftssitz

Art. 1. Rechtsform und Bezeichnung.
1.1 Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») mit der Bezeichnung L'Ecluse

Investissements S.à r.l. gegründet, für die das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils
geltenden Fassung (nachstehend „das Gesetz“) sowie der vorliegende Gesellschaftsvertrag (nachstehend „der Gesell-
schaftsvertrag“) maßgeblich sein sollen.

Art. 2. Dauer.
2.1. Die Gesellschaft wird für einen unbefristeten Zeitraum gegründet.

Art. 3. Eingetragener Geschäftssitz.
3.1. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft wird in der Stadt Luxemburg eingerichtet.
3.2.  Er  kann  innerhalb der  Stadtgrenzen  kraft  Beschluss  des einzigen Geschäftsführers  oder  der Geschäftsführung

verlegt werden. Er kann kraft Beschluss der Gesellschafterversammlung, der in der für Änderungen des Gesellschafts-
vertrags vorgesehenen Art und Weise zu verabschieden ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.

3.3. Zweigniederlassungen oder sonstige Geschäftsstellen der Gesellschaft können durch Beschluss des einzigen Ge-

schäftsführers oder der Geschäftsführung entweder in Luxemburg oder im Ausland eingerichtet werden.

II. Zweck der Gesellschaft

Art. 4. Zweck.
4.1. Die Gesellschaft wird für den Zweck der Haltung von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Ge-

sellschaft  in  jeglicher  Weise,  des  Erwerbs  im  Wege  des  Kaufs,  der  Zeichnung  oder  auf  andere  Weise  sowie  der

36451

L

U X E M B O U R G

Übertragung durch Verkauf, Tauschgeschäft oder anderweitig von Aktien, Obligationen, Schuldverschreibungen, Schatz-
wechseln und anderen Wertpapieren jeglicher Art sowie zwecks Inhaberschaft, Verwaltung, Entwicklung und Management
ihres Portfolios gegründet. Die Gesellschaft kann außerdem Anteile an Personengesellschaften halten.

Ziele und Zwecke der Gesellschaft umfassen insbesondere den Erwerb, die Entwicklung, das Management von und/

oder die Vornahme von Miet/Vermietvorgängen mit unbeweglichem Eigentum im Großherzogtum Luxemburg oder im
Ausland sowie die Durchführung jeglicher Tätigkeiten, die sich auf bewegliches Eigentum beziehen, einschließlich der
direkten oder indirekten Haltung von Eigenkapital an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Haupt-
zweck im Erwerb, in der Entwicklung, Förderung, in dem Verkauf, im Management von und/oder in der Vornahme von
Miet/Vermietvorgängen mit beweglichem Eigentum besteht. Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Tätigkeiten in
Zusammenhang mit Immobilien durchführen, außer denen, die Immobilienmaklern vorbehalten sind.

4.2. Die Gesellschaft kann außerdem Warenzeichen, Patente, Konzessionen, Lizenzen oder sonstige geistige Eigen-

tumsrechte direkt oder durch Verwertung von Konzessionen oder Lizenzen halten, entwickeln, und verwerten.

4.3. Die Gesellschaft kann in jedweder Form Gelder aufnehmen und Obligationen, Wechsel und andere Schuldver-

schreibungen ausgeben, die auch umwandelbar sein dürfen; Ausgaben derartiger Schuldverschreibungen dürfen allerdings
nicht im Wege von Angeboten an die Öffentlichkeit erfolgen.

4.4. Die Gesellschaft kann durch Darlehen, Garantien oder anderweitig ihren Tochter/Zweiggesellschaften oder sol-

chen Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt Anteile hält, oder Gesellschaften, die direkt oder indirekt von dem
Gesellschafter der Gesellschaft gehalten werden (nachstehend „verbundene Unternehmen“), Beistand bzw. Unterstüt-
zung erteilen.

Die Gesellschaft kann insbesondere:
- mit oder ohne Erteilung von Sicherheiten Schuldurkunden, die von luxemburgischen oder ausländischen Behörden

ausgegeben wurden, vorstrecken, beleihen, zeichnen oder kaufen;

- Garantien, Bürgschaften oder andere Formen von Sicherheiten für die Erfüllung von Verträgen oder Verpflichtungen

der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens ausgeben.

4.5. Die Gesellschaft kann außerdem als Komplementär oder Kommanditist mit unbeschränkter oder beschränkter

Haftung  für  sämtliche  Schulden  und  Verpflichtungen  von  Personengesellschaften  oder  dementsprechende  Unterneh-
mensformen einstehen.

4.6. Die Gesellschaft kann jegliche kommerziellen, industriellen oder finanziellen Tätigkeiten durchführen, die sie für

die Erfüllung oder Entwicklung ihrer Zwecke als sachdienlich betrachtet. In diesem Zusammenhang gilt allerdings, dass
die Gesellschaft keine Transaktionen vornehmen darf, die dazu führen würden, dass sie sich mit Tätigkeiten befasst, die
in die Kategorie regulierter Tätigkeiten des Finanzsektors fallen.

4.7. Die Gesellschaft hat das Recht, im Großherzogtum und im Ausland Niederlassungen oder Geschäftsstellen ein-

zurichten.

VI. Kapital und Geschäftsanteile

Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfundzwanzigtausend Euro (€ 25.000,-), aufgeteilt

in einhundert (100) Geschäftsanteile ohne Nennwert.

5.2. Das Stammkapital kann durch Beschluss des einzigen Geschäftsführers oder durch Beschluss der Hauptversamm-

lung jederzeit erhöht oder reduziert werden; Gesellschafterbeschlüsse dieser Art sind in der Weise zu verabschieden,
die für Beschlüsse über Änderungen des Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

5.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile unter Einhaltung der kraft Gesetz geltenden Grenzen zurück-

kaufen.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Alle Geschäftsanteile sind auf Namen lautende Anteile, die im Gesellschafterregister unter Einhaltung der Vor-

schriften des Gesetzes eingetragen sind. Die Inhaberschaft von Geschäftsanteilen wird durch Eintragung in jenem Register
manifestiert. Bescheinigungen über derartige Eintragungen werden auf Wunsch eines Gesellschafters von 2 Geschäfts-
führern ausgegeben und unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt pro Geschäftsanteil nur einen Inhaber an. Gemeinschaftsinhaber sind verpflichtet, eine Person

zu ihrem Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu bestellen.

6.2.  Die  Gesellschaft  kann  einen  oder  mehrere  Gesellschafter  haben.  Der  Tod  oder  die  Auflösung  eines  einzigen

Gesellschafters führt nicht zur Auflösung, Liquidation oder zu einer dementsprechenden Beendigung der Gesellschaft.

6.3. Jeder Geschäftsanteil berechtigt den Inhaber in Proportion zur Anzahl der ausstehenden Anteile zur Beteiligung

an den Vermögenswerten und Gewinnen der Gesellschaft.

6.4. Im Kreise der Gesellschafter sind die Geschäftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen sind durch notarielle

oder private Urkunden zu protokollieren. Gegenüber der Gesellschaft oder Dritten sind Übertragungen erst dann be-
standskräftig, wenn sie der Gesellschaft angezeigt oder von ihr gemäß den Bestimmungen des Art. 1690 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs von Luxemburg angenommen worden sind.

36452

L

U X E M B O U R G

Geschäftsanteile dürfen unter Lebenden nicht an andere Personen als an Gesellschafter übertragen werden, es sei

denn, die Gesellschafterversammlung stimmt einem derartigen Vorgang mit mindestens einer Dreiviertelmehrheit des
Stammkapitals der Gesellschaft zu.

Im Falle des Todes unterliegt die Übertragung der Geschäftsanteile von verstorbenen Gesellschaftern an andere Per-

sonen als Gesellschafter der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des
Stammkapitals. Diese Genehmigung ist allerdings nicht erforderlich, wenn die Geschäftsanteile an die Eltern, die Ab-
kömmlinge oder den überlebenden Ehepartner eines verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

VII. Geschäftsführung

Art. 7. Geschäftsführung.
7.1. Die Gesellschaft steht unter der Leitung eines oder mehrerer Geschäftsführer, der/die von dem einzigen Gesell-

schafter  oder  der  Gesellschafterversammlung  bestellt  wird/werden,  der/die  auch  dessen/deren  Amtszeit  festlegt.  Ein
Geschäftsführer muss nicht notwendigerweise Gesellschafter sein.

7.2. Ein Geschäftsführer kann jederzeit mit oder ohne Gründe durch Beschluss des einzigen Gesellschafters oder der

Gesellschafterversammlung aus seinem Amt enthoben werden.

Art. 8. Beschlüsse der Geschäftsführer.
8.1. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt worden, bilden sie zusammen die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung

besteht aus mindestens einem (1) Geschäftsführer der Klasse A und einem (1) Geschäftsführer der Klasse B.

8.2. Die Geschäftsführung trifft an dem in der Einladung genannten Ort so oft zusammen, wie die Gesellschaft es

wünscht, oder aber auf Wunsch eines Geschäftsführers.

8.3. Die Geschäftsführung wählt aus ihrem Kreis einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Sie

kann außerdem einen Schriftführer bestellen, der nicht notwendigerweise Geschäftsführer sein muss und sodann die
Verantwortung für die Führung der Protokolle der Geschäftsführungssitzungen trägt. Der Vorsitzende hält den Vorsitz
sämtlicher Sitzungen der Geschäftsführung, und im Falle seiner Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit der Mehrheit
der Stimmen einen anderen Geschäftsführer als Vorsitzenden pro tempore bestellen.

8.4. Die Geschäftsführer müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für eine Sitzung anberaumten

Datum eine Einladung für eine Sitzung erhalten, es sei denn, es liegt ein Notfall vor; in diesem Fall sind Beschaffenheit und
Umstände des Notfalls in der Einladung zu nennen.

Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn sämtliche Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft bei einer Sitzung

anwesend  oder  vertreten  sind  und  erklären,  dass  Sie  ordnungsgemäß  über  die  Tagesordnung  der  Sitzung  informiert
worden sind. Mitglieder der Geschäftsführung können anhand einer schriftlichen Zustimmung auf Einladungen verzichten,
wobei diese Zustimmung im Original, per Fax oder Email (ohne elektronische Unterschrift) oder anhand anderer Kom-
munikationsmittel erteilt werden kann. Für Sitzungen, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden sollen,
der/die durch vorherigen Beschluss der Geschäftsführung festgelegt wurde, ist keine Einladung erforderlich.

8.5. Jeder Geschäftsführer kann bei Sitzungen der Geschäftsführung tätig werden, indem er einen anderen Geschäfts-

führer schriftlich, per Fax oder Email (ohne elektronische Unterschrift) oder anhand anderer Kommunikationsmittel
schriftlich zu seinem Vertreter bestellt.

8.6. Jeder Geschäftsführer kann per Telefon oder im Rahmen einer Videokonferenz oder anhand anderer Kommuni-

kationsmittel, die es ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer miteinander sprechen und sich gegenseitig hören können,
an Geschäftsführungssitzungen teilnehmen. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht einer Teilnahme durch
persönliche Anwesenheit.

8.7. Die Geschäftsführung kann nur dann beraten oder handeln, wenn bei einer Sitzung mindestens die Mehrheit der

Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist, wenn mindestens eine Geschäftsführer der Klasse A und ein Geschäfts-
führer der Klasse B anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden durch die Mehrheit der Stimmen verabschiedet, die
die anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer bei der Sitzung abgeben.

8.8. Das Protokoll von Geschäftsführungssitzungen ist entweder von dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vor-

sitzenden, zwei Geschäftsführern oder einem Geschäftsführer der Klasse A und einem Geschäftsführer der Klasse B zu
unterzeichnen. Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die bei Gerichtsverfahren oder sonstigen Anlässen vorgelegt
werden können, müssen vom Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführern unterzeichnet worden sein.

8.9. Von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnete schriftliche Beschlüsse sind genauso gültig und verbindlich wie

die Beschlüsse, die im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungssitzung verab-
schiedet werden. Diese Unterschriften können auf einer einzigen oder auf mehreren Ausfertigungen im Original oder auf
Kopien erschienen, die per Fax, Email oder anhand anderer Kommunikationsmittel übermittelt worden sind.

Art. 9. Befugnisse des/der Geschäftsführer.
9.1. Sämtliche Vollmachten bzw. Befugnisse, die kraft Gesetz oder kraft dem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich

der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen dem einzigen Geschäftsführer oder der Geschäftsführung zu. Dem
einzigen Geschäftsführer oder der Geschäftsführung stehen sämtliche Befugnisse zur Durchführung und Genehmigung
aller Handlungen und Vorgänge zu, die mit dem Zweck der Gesellschaft vereinbar sind.

36453

L

U X E M B O U R G

9.2. Der einzige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung hat das Recht, das tägliche Management der Gesellschaft

an eine oder mehrere Personen zu übertragen, die nicht notwendigerweise Geschäftsführer sein müssen.

9.3. Für festgelegte Angelegenheiten und für einen befristeten Zeitraum kann der einzige Geschäftsführer oder die

Geschäftsführung besondere und beschränkte Befugnisse an eine oder mehrere Personen erteilen, die nicht notwendi-
gerweise Geschäftsführer sein müssen.

Art. 10. Vertretung. Die Gesellschaft ist unter jeglichen Umständen an Unterzeichnungen des einzigen Geschäftsführers

oder an gemeinsame Unterzeichnungen von mindestens einem Geschäftsführer der Klasse A und einem Geschäftsführer
der Klasse B oder an Unterzeichnungen anderer Personen gebunden, die gemäß Art. 9.2 und 9.3 dieses Gesellschafts-
vertrags Zeichnungsbefugnis erhalten haben.

Art. 11. Haftung von Geschäftsführern. Ein Geschäftsführer übernimmt aufgrund seines Mandats keine persönliche

Haftung für Verpflichtungen, die er in gültiger Weise im Namen der Gesellschaft eingegangen ist, vorausgesetzt, derartige
Verpflichtungen werden dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag gerecht.

VIII. Inhaberschaft von Geschäftsanteilen

Art. 12. Stimmrechte.
12.1. Jeder Geschäftsanteil verleiht seinem Inhaber eine Stimme.
12.2. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile an Gesellschafterversamm-

lungen teilnehmen.

Art. 13. Befugnisse.
13.1. Der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ist/sind mit sämtlichen Vollmachten und Befug-

nissen ausgestattet, die kraft Gesetz oder gemäß diesem Gesellschaftsvertrag an die Gesellschafterversammlung über-
tragen wurden.

13.2. Der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann/können beschließen, dass die Abschlüsse

und Tätigkeiten der Gesellschaft unter die Aufsicht von einem oder mehreren zugelassenen Abschlussprüfern gestellt
werden, der/die nicht notwendigerweise Gesellschafter sein muss/müssen. Soweit die Gesellschaft mehr als 25 (fünfund-
zwanzig) Gesellschafter hat, muss/müssen ein oder mehrere zugelassene Abschlussprüfer bestellt werden. Das Honorar
und die Laufzeit des Mandats für jene Prüfer werden von dem einzigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung
festgelegt.

Art. 14. Beschlüsse des einzigen Gesellschafters.
14.1. Die Beschlüsse des einzigen Gesellschafters werden entweder schriftlich gefasst oder in einem Protokoll schrift-

lich niedergelegt.

14.2. Verträge zwischen der Gesellschaft und dem einzigen Gesellschafter werden entweder schriftlich abgefasst oder

in einem Protokoll schriftlich niedergelegt, außer wenn derartige Verträge sich auf übliche Geschäftstätigkeiten der Ge-
sellschaft beziehen, die unter üblichen Marktbedingungen abgeschlossen werden.

Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.
15.1. Gemeinsame Beschlüsse der Gesellschafter können entweder im Verlauf abgehaltener Gesellschafterversamm-

lungen oder schriftlich gefasst werden, soweit die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat. Im
letztgenannten Fall erhält jeder Gesellschafter den genauen Wortlaut der jeweils zu verabschiedenden Beschlüsse oder
Entscheidungen und gibt seine Stimme schriftlich ab. Die jeweiligen Unterschriften der Gesellschafter können auf einer
oder auf mehreren Ausfertigungen im Original oder in Form von Kopien per Fax, Email oder anderer Kommunikations-
mittel angebracht werden.

15.2. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann gültig, wenn sie von der Mehrheit der Gesellschafter

angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals hält. Änderungen des Gesellschaftsvertrags bedürfen
allerdings der Zustimmung einer Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals.

VI. Geschäftsjahr, Jahresabschlüsse, Ergebniszuweisungen

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31.

Dezember desselben Jahres.

Art. 17. Jahresabschlüsse. Zum Ende eines jeweiligen Geschäftsjahres werden die Abschlussunterlagen der Gesellschaft

erstellt; in diesem Zusammenhang müssen der einzige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung eine Bestandsaufnahme
vornehmen, durch die der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft festgelegt wird. Die Be-
standsaufnahme und die Abschlussunterlagen stehen jedem Gesellschafter am eingetragenen Geschäftssitz der Gesell-
schaft zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Art. 18. Ergebniszuweisung.
18.1. Der Nettogewinn der Gesellschaft entspricht dem in den Jahresabschlussunterlagen ausgewiesenen Bruttogewinn

abzüglich Gemeinkosten, Abschreibungen und Aufwendungen.

36454

L

U X E M B O U R G

18.2. In jedem Jahr ist ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft solange einer

gesetzlichen Rücklage zuzuweisen, bis die Rücklage sich auf zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft beläuft.

18.3. Der dann verbleibende Betrag des Nettogewinns kann gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung in Pro-

portion zu den jeweils gehaltenen Anteilen an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

18.4.  Vorbehaltlich  der  folgenden  Bedingungen  kann  die  Geschäftsführung  Zwischendividenden  an  den/die  Gesell-

schafter ausschütten:

- es sind Zwischenabschlüsse zu erstellen, aus denen die Hinlänglichkeit der für Ausschüttungen verfügbaren Gelder

hervorgeht;

- der auszuschüttende Betrag darf nicht den Gesamtgewinn überschreiten, der seit dem Ablauf des letzten Geschäfts-

jahres,  für  das  die  Jahresabschlüsse  genehmigt  wurden,  erwirtschaftet  worden  ist,  zuzüglich  etwaiger  vorgetragener
Gewinne und zu diesem Zweck der Rücklage entnommener und aus ihr verfügbarer Gelder, abzüglich etwaiger Beträge,
die kraft Gesetz der Rücklage zuzuweisen sind;

- der Beschluss der Geschäftsführung über die Ausschüttung von Zwischendividenden darf nicht später als zwei (2)

Monate nach dem Datum gefasst werden, zu dem die oben erwähnten Zwischenabschlüsse erstellt wurden;

- der zugelassene Abschlussprüfer oder, soweit eine Person in dieser Funktion nicht bestellt worden ist, ein unabhän-

giger Wirtschaftsprüfer müssen verifizieren, dass die oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind, und werden daraufhin
einen Bericht abfassen, in dem dieser Sachverhalt für die Geschäftsführung bestätigt wird.

18.5. Soweit die Zahlung von Zwischendividenden den Betrag der Dividende überschreiten, der zu späterem Zeitpunkt

von der Gesellschafterversammlung beschlossen wird, gelten die zuviel gezahlten Beträge als Anzahlung auf die nächste
fällige Dividende.

VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Auflösung - Liquidation.
19.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist die Abwicklung von einem oder mehreren Abwicklern vorzunehmen,

der/die nicht notwendigerweise Gesellschafter sein muss/müssen und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung zu
bestellen ist/sind, wobei die Gesellschafterversammlung auch dessen/deren Befugnisse und Honorare festlegt. Soweit
keine anderweitigen Regelungen getroffen werden, stehen den Abwicklern die weitestgehenden Befugnisse für die Flüs-
sigmachung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu.

19.2. Die Liquidationserlöse können in Proportion zu den jeweils gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft an den/die

Gesellschafter ausgeschüttet werden.

VIII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 20. Für sämtliche Angelegenheiten, die in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelt sind, gilt das Gesetz.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft ist somit von der erschienenen Partei erstellt worden, und die erschienene

Partei hat die folgenden Geschäftsanteile gezeichnet und vollständig eingezahlt:

Zeichner

Anzahl von

Geschäftsanteilen

Insgesamt

Zeichnungspreis

(EUR)

Zahlung

(EUR)

Lock One Investments International Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

25.000,-

25.000,-

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

25.000,-

25.000,-

Der unterzeichnende Notar hat den Nachweis der Zahlung des gesamten Zeichnungspreises erhalten.

<i>Ausgaben, Wertfeststellung

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Belastungen jeglicher Art, die infolge dieser Gründung von der Gesellschaft zu

übernehmen sind, werden auf ca. elf hundert Euro (EUR 1.100,-).

<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlung

Der Gesellschafter hat umgehend die folgenden Beschlüsse verabschiedet:
1. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. Die folgenden Personen werden für einen unbefristeten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt und

werden Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft:

<i>a) Geschäftsführer der Klasse A:

- Mr. James Frederick Dicke II, geboren in Texas, USA, am 9. November 1945, wohnhaft in 422 Easthaven Drive, New

Bremen, Ohio 45869 (United States of America); und

- Mr James Frederick Dicke III, geboren in Ohio, USA, am 27. August 1971, wohnhaft in 04670 Lock Two Road, New

Bremen, Ohio 45869 (United States of America);

36455

L

U X E M B O U R G

<i>b) Geschäftsführer der Klasse B:

- Mr. Denis Van den Bulke, geboren in Liège (Belgien) am 10. Juli 1959, wohnhaft in 35, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg); und

- Mrs. Laurence Jacques, geboren in Verviers (Belgien) am 11. April 1977, wohnhaft in 35, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, das die vorliegende Ur-

kunde auf Wunsch der vorgenannten erschienenen Parteien in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Fassung,
erstellt worden ist. Auf Wunsch derselben erschienenen Personen soll im Falle von Unvereinbarkeiten bzw. Abweichun-
gen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgeblich sein.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg am anfangs genannten Tag erstellt.
Dieses Dokument wurde den erschienenen Personen vorgelesen und von ihnen zusammen mit dem Notar unter-

schrieben.

Gezeichnet: Jacques, Grethen.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 janvier 2012. Relation: LAC/2012/2847. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 27. Januar 2012.

Référence de publication: 2012017367/507.
(120021345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.

TRE International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 146.276.

Il résulte de changements d'adresse que la société Ser.com S.à.r.l., (commissaire de la société) ainsi que Madame Valérie

Wesquy, (administrateur de la société) sont désormais domiciliés au 19, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2012.

Référence de publication: 2012021605/12.
(120027191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Lux Integral Vision Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 94.890.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012021505/10.
(120027189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

M.S. Stainless Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9681 Roullingen, 2-3, Reimerwee.

R.C.S. Luxembourg B 57.640.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012021510/10.
(120027500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

36456

L

U X E M B O U R G

Mediq Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 152.563.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2012.

Référence de publication: 2012021511/10.
(120027215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Mongolian Coal Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 154.474.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 26 janvier 2012 que:
1. L'Assemblée confirme la démission de Mr. Francis N. Hoogewerf en tant que gérant de la société
2. L'Assemblée confirme la nomination de Mr. Joao Luis Da Fonseca Ferreira, né le 21 mai 1980 à C Se Nova Coimbra,

Portugal, ayant son adresse professionnelle à 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en tant que gérant catégorie B de
la société.

Fait à Luxembourg, 26 janvier 2012.

<i>Pour Hoogewerf &amp; Cie
Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012021516/16.
(120027470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Summit Partners IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 127.675.

EXTRAIT

Il  résulte  d'un  contrat  de  cession  de  parts  sociales  avec  effet  au  13  février  2012  que  Summit  elnsurance  Pooling

Partnership, GP a cédé les parts sociales qu'elle détenait dans la Société à Summit Partners 360 Cayman LP, une “limited
partnership”, constituée et régie par les lois des Des Cayman, ayant son siège social au South Church Street, Ugland
House, KY1-1104, Grand Cayman, Cayman Islands, et enrégistrée auprès du “Registar of Limited Partnership Cayman
Islands” sous le numéro MC-57164, de telle sorte que les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

- Summit Partners 360 Cayman LP, 500 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2012

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2012021576/19.
(120027175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Maclali S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 702.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.588.

Par résolutions prises en date du 2 février 2012, l’associé unique a transféré le siège social de la société du 1, Allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social du gérant unique a changé et se trouve à présent au:
TMF CORPORATE SERVICES S.A., avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

36457

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 février 2012.

<i>Pour la société
TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2012021518/17.
(120027504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Marlyssa Holding S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 112.812.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MARLYSSA HOLDING S.A.-SPF
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012021519/13.
(120027485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Patron Alma Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 144.225.

Les comptes annuels rectificatifs de la société au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Ces comptes annules remplacent les comptes annuels au 31 décembre 2010, enregistrés et déposés au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 21 décembre 2011 sous la référence L110204059

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012021544/13.
(120027417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

CEREP III Investment AA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles du Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 166.698.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the first day of February.
Before Us Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED

CEREP III UK S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 2 avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 130.447,

here represented by Ms Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxy

given under private seal dated 25 January 2012.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company ("Société à responsabilité limitée"):

ARTICLES OF INCORPORATION

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form – Corporate name. There is hereby formed a private limited liability company under the name "CEREP III

Investment AA S.à r.l.", which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred to as the

36458

L

U X E M B O U R G

"Company"), and in particular by the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies as amended from time to time

(hereafter referred to as the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter referred to as the
"Articles").

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers (as

defined hereafter) of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of
Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however
not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made
by the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers (as defined hereafter).

3. Object.
3.1 The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in any other

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The object of the Company is also to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of real estate and/or of participations in any enterprises in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those investments participations.

3.3 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect
shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the
"Connected Companies"). On an ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative and
marketing assistance to its Connected Companies.

3.4 For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the Company if such

other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control
with, or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other
fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or
indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of
the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or
otherwise.

3.5 The Company may in particular enter into the following transactions:
3.5.1 to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, convertible or
not, or the use of financial derivatives or otherwise;

3.5.2 to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

3.5.3 to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any director,
manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of any applicable law
provision; and

3.5.4 to enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements,

marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements, cooperation agree-
ment and other services contracts, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial
derivative agreements in relation to its object.

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.6 In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions

and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object
in all areas described above.

36459

L

U X E M B O U R G

4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II. - Capital, Shares

5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by five hundred (500)

shares. Each share has a nominal value of thirty British Pounds (GBP 30.-) each (hereafter referred to as a "Share" and
collectively the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

Share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s). The amount of
the premium account may be used to make payment for any Shares, which the Company may redeem from its Shareholder
(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferable to another

Shareholder.

7.3 In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance

with the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

7.4 Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be valid vis-à-

vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with article
190 of the Law.

Chapter III. - Management

8. Management.
8.1  The  Company  is  managed  by  one  manager  (the  "Sole  Manager")  or  managers.  If  several  managers  have  been

appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers", each member individually, a "Manager").
The Sole Manager or the members of the Board of Managers, as the case may be, need not be shareholder.

8.2 The Sole Manager or the members of the Board of Managers may be removed at any time, for legitimate reasons

only, by decision of the extraordinary general meeting of the Shareholders taken in compliance with articles 14 and 15.

8.3 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken by the Sole Manager or, in case

of plurality of managers, collectively by the Board of Managers in compliance with article 12.

8.4 Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to the Sole Manager and

in case of plurality of managers, to any Manager as provided by article 10 of the Articles, and pursuant to article 191 bis
paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or generally any document executed in compliance with articles 8 and 10
of the present Articles are valid and binding vis-à-vis third parties. The exercise of the general power of representation
by any Manager does not require prior approval by the Board of Managers acting collectively.

9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager and in case of plurality of managers, the Board of Managers, without

prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all administration acts (actes d'administration) and disposition acts (actes de
disposition) as well as all operations consistent with the Company's objects.

9.2 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the

competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers.

10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole manager, bound by

the sole signature of the Sole Manager and, in case of plurality of managers, by the signature of any Manager, or by the
signature of any person to whom such power shall be delegated by the Sole Manager or, in case of plurality of managers,
by any Manager individually.

11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or any Manager in case of plurality of managers may delegate its powers for specific tasks to

one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or any Manager in case of plurality of managers will determine any such agent's responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

36460

L

U X E M B O U R G

12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of a Board of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. In case that

all the members of the Board of Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and
formalities.

12.2 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, fax, e-mail

or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be
confirmed in writing at a later stage.

12.3 The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by the majority of the members of the

board of Managers, present or represented.

12.4 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating members of the Board of Managers whether or not
using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by
video or by telephone.

12.5 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the

members of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-
mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers'
meetings, physically held.

12.6 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by phone provided in such latter event such vote is

confirmed in writing.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all the members of the Board of Managers

present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any
Manager or during a meeting of the Board of Managers.

12.8 In case of a Sole Manager, the resolutions of the Sole Manager may be documented in writing.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.
13.1 Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns.

Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

13.2 In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general Shareholders'

meeting and its decisions are recorded in writing.

13.3 If all the Shareholders are present or represented, they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

14. Holding of general meetings.
14.1 Shareholders meetings may always be convened by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any

Manager, failing which by Shareholders representing more than half of the capital of the Company.

14.2 The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

14.3 Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held

each year.

14.4 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the

Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Sole Manager or,
in case of plurality of managers, to the Board of Managers.

15. Majorities.
15.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened
or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless
of the portion of capital represented.

15.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at

least three-quarters of the Company's share capital, in accordance with any provisions of the Law.

15.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Chapter V. - Business year

16. Business year.
16.1 The Company's financial year starts on the first day of July and ends on the last day of June of each year.

36461

L

U X E M B O U R G

16.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or, in case of

plurality of managers, the Board of Managers and the latest prepare an inventory including an indication of the value of
the Company's assets and liabilities.

16.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

17. Distribution right of shares.
17.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, depreciations and

other charges, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

17.2 From the net profit thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's
nominal capital.

17.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

17.4 The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by

the general meeting of the Shareholders.

17.5 The Board of Managers or the Sole Manager may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the Board of Managers or the Sole Manager showing that sufficient funds are available for distri-
bution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last
fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and
sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

Chapter VI. - Liquidation

18. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

19. Liquidation.
19.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing

three-quarters of the Company's share capital.

19.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

19.3 A sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII. - Applicable law

20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is

made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the 30

June 2012.

<i>Subscription – Payment

The capital has been subscribed as follows:

Shares:
CEREP III UK S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Shares

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) corres-

ponding  to  a  share  capital of fifteen thousand British  Pounds  (GBP  15,000.-)  is  forthwith  at  the free disposal  of the
Company, as it has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about Euro one thousand three hundred Euros
(EUR 1,300.-).

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined period:

36462

L

U X E M B O U R G

- CEREP Management S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office at 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 83.246.

In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be, in case of a sole manager, bound by the sole

signature of the Sole Manager and, in case of plurality of managers, by the signature of any Manager, or by the signature
of any person to whom such power shall be delegated by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any
Manager individually.

2) The Company shall have its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le premier février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU

CEREP III UK S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social situé au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 130.447,

ici représentées par Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé le 25 janvier 2012.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

STATUTS

Titre I 

er

 . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Forme - Dénomination. Il est ici formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «CEREP III

Investment AA S.à r.l.» qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après définie comme la «Société»), et en
particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après définie comme la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après définis comme les «Statuts»).

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des Associés (tels que définis ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance (tel

que défini ci-après) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être  transféré  provisoirement  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique (tel que
défini ci-après) ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance (tel que défini ci-après).

3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle

que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport,
de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2 La Société a également pour objet d'effectuer toutes transactions impliquant, directement ou indirectement, l'ac-

quisition d'actifs immobiliers et/ou la prise de participations dans toutes entreprises généralement quelconques, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces investissements participations.

36463

L

U X E M B O U R G

3.3 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»). A titre
accessoire de cette assistance financière, la Société pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assis-
tance administrative ou commerciale.

3.4 Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société

si cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par
ou est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un associé de la Société, que ce soit comme bénéficiaire,
trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient,
directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose
du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention
de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

3.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
3.5.1 conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,

notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de capital, conver-
tibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

3.5.2 avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, à des conditions jugées satisfaisantes;

3.5.3 accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie d'engagements, des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre
de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées, ou par tout
administrateur, gérant ou autre agent de la Société ou de l'une des Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par
une quelconque disposition légale applicable; et

3.5.4 conclure tous contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats

de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration,
des contrats de coopération et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange d'intérêt et/
ou de cours, et autres contrats financiers dérivés en relation avec son objet.

il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités

pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

3.6 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions légales, commerciales, techniques ou financières

et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital, Parts

5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales, ayant une valeur nominale de trente Livres Sterling (GBP 30,-) chacune (ci-après une «Part Sociale» et collecti-
vement les «Parts Sociales»). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission peut être utilisé
pour procéder à des paiements pour toutes Parts sociales que la Société peut racheter à ses Associé(s), pour compenser
toute perte réalisée, pour procéder à des distributions aux Associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part

Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par un des Associés sont librement

transmissibles à un autre Associé.

7.3 En cas de cession à un non-Associé, les Parts Sociales détenues par chaque Associé pourront être cédées confor-

mément aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

7.4 Tout transfert de Parts Sociales doit être enregistré par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera

pas opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément
à l'article 190 de la Loi.

36464

L

U X E M B O U R G

Titre III. - Gérance

8. Gérance.
8.1 La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été

nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance», chacun étant alors désigné comme «Gérant»).
Le Gérant Unique ou les membres du Conseil de Gérance, le cas échéant, ne sont pas nécessairement associés.

8.2 Le Gérant Unique ou les membres du Conseil de Gérance peuvent être révoqués à tout moment, uniquement

pour justes motifs, par une décision d'une assemblée générale extraordinaire des Associés conformément aux articles 14
et 15.

8.3 Toute décision en relation avec la gérance de la Société doit être prise par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité

de gérants, par le Conseil de Gérance agissant collectivement en conformité avec l'article 12.

8.4 Envers les tiers, le pouvoir général de représentation de la Société est conféré au Gérant Unique, ou, en cas de

pluralité de gérants, à un Gérant tel que stipulé à l'article 10 des Statuts, et en vertu de l'article 191 bis paragraphe 5 de
la Loi, tout acte, contrat ou généralement tout document exécuté en conformité aux articles 8 et 10 des présents Statuts
sont valables et créeront des obligations à la charge de la Société vis-à-vis des tiers. L'exercice du pouvoir général de
représentation par un Gérant ne requiert pas l'approbation préalable du Conseil de Gérance agissant collectivement.

9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique et, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans

préjudice des articles 8 et 10 des Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver
tous actes d'administration et tous actes de disposition ainsi que toutes opérations conformes à l'objet social.

9.2 Les compétences non expressément réservées par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des associés

tombent dans la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée, en cas de gérant unique, par

la seule signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un Gérant, ou par la signature
de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par tout
Gérant.

11. Délégation et Mandat du gérant unique ou du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou tout Gérant en cas de pluralité de gérants peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs

agents ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou tout Gérant, en cas de pluralité de gérants, détermine les responsabilités et la rémunération

quelconques (s'il y en a) de tout agent, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un Gérant. Lorsque tous les membres du Conseil de Gérance

sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

12.2 Tout membre du Conseil de Gérance est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance

par un autre membre, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax,
d'un courriel ou d'une lettre. Un membre du Conseil de Gérance pourra également nommer par téléphone un autre
membre pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.3 Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu'elle est approuvée par plus de la moitié

des membres du Conseil de Gérance, présents ou représentés.

12.4 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre  et  d'être  entendu  par  tous  les  membres  du  Conseil  de  Gérance  participant,  utilisant  ou  non  ce  type  de
technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou
la vidéo.

12.5 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées

et approuvées par tous les membres du Conseil de Gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs
documents séparés transmis par fax, courriel, télégramme ou facsimilé. Ces résolutions auront le même effet et la même
validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.

12.6 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen tel que fax, courriel, télégramme, facsimilé ou

par téléphone; dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les membres du Conseil de Gérance

présents ou représentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée par un
Gérant ou lors d'une réunion du Conseil de Gérance.

12.8 En cas de Gérant Unique, les résolutions du Gérant Unique pourront être documentées par écrit.

36465

L

U X E M B O U R G

Titre IV. - Assemblée générale des associés

13. Pouvoirs de l'assemblée des associés - Votes.
13.1 Tout Associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient.

Chaque Associé a un droit de vote proportionnel à sa participation dans le capital social.

13.2 En cas d'Associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés

et ses décisions sont établies par écrit.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement être tenue sans avis préalable.

14. Tenue d'assemblées générales.
14.1 Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de

gérants, par tout Gérant, à défaut par les Associés représentant plus de la moitié du capital de la Société.

14.2 La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-

cinq. Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

14.3 Lorsqu'il y aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale.
14.4 Quel que soit le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des

Associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge à donner au Gérant Unique ou, en cas de pluralité
de gérants, au Conseil de Gérance.

15. Majorités.
15.1 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié

du capital social les adoptent. Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par écrit, les
Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la
majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

15.2 Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité (en nombre)

d'Associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux dispositions de la Loi.

15.3 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent

être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

Titre V. - Exercice social

16. Exercice social.
16.1 L'année sociale de la Société commence le premier jour de juillet et se termine le dernier jour de juin de chaque

année.

16.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou, en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et ce dernier prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

16.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.

17. Droit de distribution des parts.
17.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des amortissements et de

toutes autres charges, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

17.2 Sur le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

17.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts,  le  Gérant  Unique  ou,  en  cas  de  pluralité  de  gérants,  le  Conseil  de  Gérance  pourra  proposer  que  les  fonds
disponibles soient distribués.

17.4 La décision de distribuer des dividendes et d'en déterminer le montant sera prise par l'assemblée générale des

Associés.

17.5 Le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique peut décider de payer des dividendes intérimaires sur la base d'un

relevé de comptes préparé par le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique montrant qu'il existe suffisamment de fonds
disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés
depuis la fin de l'année fiscale précédente, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué
des pertes reportées et sommes allouées à une réserve à établir en vertu de la loi ou des présents Statuts.

Titre VI. - Liquidation

18. Causes de dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,

d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

36466

L

U X E M B O U R G

19. Liquidation.
19.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés représentant les

trois quarts du capital social de la Société.

19.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

19.3 Un Associé unique peut dissoudre la Société et procéder à sa liquidation, en assumant personnellement le paie-

ment de tous les actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.

Titre VII. - Loi applicable

20. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 30 juin 2012.

<i>Souscription – Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

Parts Sociales:
CEREP III UK S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Parts Sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000,-) correspondant à un capital social de quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000,-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.300,-(mille trois cents Euros).

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé comme gérant pour une période indéterminée:
- CEREP Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 83.246.

Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société est valablement engagée, en cas de gérant unique, par la seule

signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un Gérant, ou par la signature de
toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par tout Gérant.

2)  Le  siège  social  de  la  Société  est  établi  au  2,  avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxembourg,  Grand-Duché  de

Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 2 février 2012. Relation: LAC/2012/5179. Reçu soixante-quinze Euros (75,-€).

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la Société sur sa demande.

Luxembourg, le 8 février 2012.

Référence de publication: 2012018804/504.
(120023510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.

36467

L

U X E M B O U R G

Blue Fish S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 131.379.

Le siège social de la société BLUE FISH S.A.R.L., société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, inscrite

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B0131379, jusqu'alors établi au 8-10,
rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 08 février 2012 par le domiciliataire UniCredit
Luxembourg S.A.

Luxembourg, le 08 février 2012.

UniCredit Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2012021647/13.
(120027685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Mobi.lu, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 40, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 144.925.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>La Gérance

Référence de publication: 2012021525/11.
(120027466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Mobi.lu, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 40, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 144.925.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>La Gérance

Référence de publication: 2012021526/10.
(120027467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Nineteen Sixty Eight (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.362.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 09 février 2012

Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Madame Mireille Masson, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, née le 13/06/1966 à Ougrée
Madame Alié Madeleine, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, née le 11/10/1940 à Rendeux
Renouvellement du mandat de l’administrateur délégué pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
Fiduciaire Gallo et Associés (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 61 096, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012021531/17.
(120027520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

36468

L

U X E M B O U R G

Pendekar Holdings (HARIPUR) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.698.

Il résulte que le Gérant unique de la Société a pris la décision suivante en date du 13 février 2012:
1. Le siège de la société est transféré du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg à partir du 13 février 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pendekar Holdings (HARIPUR) S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
Signature
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2012021545/16.
(120027185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

North REOF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.

R.C.S. Luxembourg B 120.564.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012021533/10.
(120027371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

North REOF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.

R.C.S. Luxembourg B 120.564.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012021534/10.
(120027372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Ode S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.773.

Par résolutions du gérant unique, il a été décidé de transférer le siège social de la société du 1, Allée Scheffer, L-2520

Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 1 

er

 janvier 2012.

Le siège social du gérant unique a changé et se trouve à présent au:
TMF Corporate Services S.A., avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2012.

<i>Pour la société
TMF Luxembourg S.A.
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2012021538/17.
(120027503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

36469

L

U X E M B O U R G

Onex RSI Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 9.809.153,12.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 141.515.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2012.

Référence de publication: 2012021541/11.
(120027135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

One O One S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 149, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 87.455.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 15 février 2012

Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans:
Madame Christiane Lallemand, demeurant à 37 avenue du vieux frêne à B-6280 Loverval, née le 03/08/1943 à Angleur.
Monsieur Marc Bossetti, demeurant à rue de Bohan, 95 à B-5550 Orchimont, né le 08/08/1936 à Vilvorde.
Monsieur Jean-Claude Heuysmans, demeurant à rue de Bohan, 95 à B-5550 Orchimont, né le 10/07/1929 à Uccle.
Renouvellement du mandat de l’administrateur délégué pour une durée de 6 ans:
Madame Christiane Lallemand, demeurant à 37 avenue du vieux frêne à B-6280 Loverval, née le 03/08/1943 à Angleur.
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
Fiduciaire et Expertise (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70 909, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012021542/17.
(120027571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Pendekar Holdings (Meghnaghat) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.730.

Il résulte que le Gérant unique de la Société a pris la décision suivante en date du 13 février 2012:
1. Le siège de la société est transféré du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg à partir du 13 février 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pendekar Holdings (Meghnaghat) S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
Signature
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2012021546/16.
(120027184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Porte des Ardennes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 99.509.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PORTE DES ARDENNES SA

Référence de publication: 2012021556/10.
(120027197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

36470

L

U X E M B O U R G

CPEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 151.566.

In the year two thousand and twelve.
On the sixth day of February.
Before us the undersigned notary Jean SECKLER, residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) CPEX

S.A., with registered office in L2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg number B 151566, in-
corporated by deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on the 19 

th

 of February 2010, published

in the Mémorial C number 716 of the 6 

th

 of April 2010. The articles of incorporation have been amended by a deed of

the undersigned notary on the 4 

th

 of April 2011, published in the Mémorial C number 1365 of the 22 

nd

 of June 2011.

The meeting is presided by Mr Jean-Luc JOURDAN, director of companies, residing professionally in Luxembourg, 32,

Avenue Monterey.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Thierry NOWANKIEWICZ, employee,

residing professionally in Luxembourg, 32, Avenue Monterey.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an

attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting

can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads

as follows:

<i>Agenda:

1.- Accept the resignation of all the category B Directors and revoke the statutory auditor.
2.- Transfer of the address of the registered office to L-2163 Luxembourg, 32, Avenue Monterey.
3.- Amend article 1st of the articles of incorporation.
4.- Delete article 12 of the articles of incorporation
5.- Appoint three new category B Directors of the Company and a new statutory auditor.
After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting decides to accept the resignation of all the category B directors and revokes the statutory auditor.

<i>Second resolution

The meeting decides to transfer the address of the registered office to L2163 Luxembourg, 32, Avenue Monterey.

<i>Third resolution

The meeting decides to give paragraph 2 of article 1 the following wording:

Art. 1. (paragraph 2). The registered office is established in Luxembourg."

<i>Fourth resolution

The meeting decides to delete article 12 of the company's articles of incorporation.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to appoint as new:

<i>a.- category B directors:

- Mr Alexey KARPOV, independant, born on the 11 

th

 of March 1987 in Moscow, residing professionally in L-1466

Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

- Mr Vadim ZAREMBA, independant, born on the 9 

th

 of April 1987 in Moscow, residing in L-7391 Blaschette, 4, rue

de l’Ecole, and

- Mr Jean-Luc JOURDAN, director of companies, born on the 12 

th

 of July 1959 in Saint-Mard, residing professionally

in L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey

36471

L

U X E M B O U R G

<i>b.- statutory auditor:

GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l., private limited liabilty company (« société à responsabilité limitée ») having

its registrered office at L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey (R.C.S. Luxembourg B 109939)

The mandates of the category B directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting

of 2015.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at nine hundred and fifty Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the English text and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le six février.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CPEX S.A., avec siège social

à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg numéro B 151566, constituée suivant acte reçu par
Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 février 2010, publié au Mémorial C numéro
716 du 6 avril 2010. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 avril 2011,
publié au Mémorial C numéro 1365 du 22 juin 2011.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de societies, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg, 32, Avenue Monterey.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry NOWANKIE-

WICZ, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 32, Avenue Monterey.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu
comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Accepter les démissions des administrateurs de catégorie B et révoquer le commissaire aux comptes.
2.- Transfert de l’adresse du siège social vers L-2163 Luxembourg, 32, Avenue Monterey.
3.- Modification de l'article 1 

er

 des statuts.

4.- Suppression de l’article 12 des statuts.
5.- Nomination de trois nouveaux administrateurs de catégorie B de la Société et d’un nouvel commissaire aux comptes.
Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée  décide  d’accepter  les  démissions  des  administrateurs  de  catégorie  B  et  révoque  le  commissaire  aux

comptes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social de la société vers L-2163 Luxembourg, 32, Avenue Monterey.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'alinéa 2 de l'article 1 

er

 pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 1 

er

 . (Alinéa 2).  Le siège social est établi à Luxembourg."

36472

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer l’article 12 des statuts.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide nommer comme nouveaux:

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Alexey KARPOV, travailleur indépendant, né le 11 mars 1987 à Moscou, demeurant professionnellement

à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,

- Monsieur Vadim ZAREMBA, travailleur indépendant, né le 09 avril 1987 à Moscou, demeurant à L-7391 Blaschette

4, rue de l’Ecole, et

- Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de sociétés, né le 12 juillet 1959 à Saint-Mard, demeurant professionnel-

lement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

<i>- Commissaire aux comptes:

* GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2163 Luxem-

bourg, 32, avenue Monterey (R.C.S. Luxembourg B.109.939).

Les mandats des administrateurs de catégorie B et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2015.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cent cinquante euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Jean-Luc JOURDAN, Thierry NOWANKIEWICZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 février 2012. Relation GRE/2012/506. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Ronny PETER.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 14 février 2012.

Référence de publication: 2012021405/135.
(120027144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Ampus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 79.486.

Les Comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012021755/9.
(120028437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

2 boulevard Konrad Adenauer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 96.624.

<i>Auszug aus der Beschlussfassung des alleinigen Gesellschafters vom 19. Dezember 2011

Der Rücktritt des folgenden Geschäftsführers wird mit Wirkung zum 1. September 2011 angenommen:
- Herr Ferdinand von Sydow

36473

L

U X E M B O U R G

Die folgende Person wird mit Wirkung zum 1. September 2011 als Geschäftsführer ernannt:
- Frau Irmgard Linker, geboren in Friedberg (Deutschland) am 29.08.1968 mit beruflicher Adresse in: The Squaire 18,

Am Flughafen, D- 60549 Frankfurt am Main, Deutschland, für eine unbegrenzte Zeit

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13.02.2012.

Référence de publication: 2012021625/16.
(120027319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Penfret (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 88.325.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 08 février 2012

Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Madame Mireille Masson, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, née le 13/06/1966 à Ougrée
Madame Alié Madeleine, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, née le 11/10/1940 à Rendeux
Renouvellement du mandat de l’administrateur délégué pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
Fiduciaire Gallo et Associés (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 61 096, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012021554/17.
(120027390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Ploquette (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.359.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 08 février 2012

Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Madame Mireille Masson, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, née le 13/06/1966 à Ougrée
Madame Alié Madeleine, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, née le 11/10/1940 à Rendeux
Renouvellement du mandat de l’administrateur délégué pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
Fiduciaire et Expertise (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70 909, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012021555/17.
(120027393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Quaden Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.484.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Danelli Barbara.

Référence de publication: 2012021558/10.
(120027130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

36474

L

U X E M B O U R G

GT Multi Alternative, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.909.

Suite à la démission de Monsieur Germain Gauthier de son poste d'administrateur de la Société en date du 15 décembre

2011, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Daniel THIERRY
- Monsieur Jean-Bernard QUILLON
- Madame Sybille DENFERT-ROCHEREAU

Luxembourg, le 13 février 2012.

<i>Pour GT MULTI ALTERNATIVE
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Corinne ALEXANDRE / Valérie GLANE
<i>- / Fondé de pouvoir

Référence de publication: 2012021656/18.
(120027369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

RentaPLACE (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 90.329.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 09 février 2012

Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Madame Mireille Masson, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, née le 13/06/1966 à Ougrée
Madame Alié Madeleine, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, née le 11/10/1940 à Rendeux
Renouvellement du mandat de l’administrateur délégué pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
Fiduciaire et Expertise (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70 909, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012021559/17.
(120027518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Recupierre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9415 Vianden, 1, rue de Huy.

R.C.S. Luxembourg B 150.776.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2012.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2012021566/10.
(120027513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

S.K. Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-9964 Huldange, 67, rue de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 95.804.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.K. INVESTMENTS S.C.A.

Référence de publication: 2012021571/10.
(120027198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

36475

L

U X E M B O U R G

Hung Top Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 122.043.

<i>Extrait des résolutions prises à l'associé unique de la société tenue en date du 8 février 2012

1. L'associe unique  a  pris  acte  de la démission  de  Monsieur  Michael  Chidiac,  né le  29  juin  1966 à Beirut  (Liban),

demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société
avec effet au 31 décembre 2011.

Le conseil de gérance de la de Société se compose désormais comme suit:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE (gérant),
2. Monsieur Pii KETVEL (gérant),
3. Monsieur Bernd JANIETZ (gérant)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2012021657/18.
(120027350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Metastorm (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.365.

In the year two thousand and twelve, the thirty-first day of the month of January.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Metastorm (Luxembourg) S.à r.l., a private limited

liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at
26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number
B. 162365, incorporated pursuant to the laws of the State of Delaware, United States of America and whose registered
office, principal establishment and central administration has been transferred from the State of Delaware, United States
of America to the Grand Duchy of Luxembourg, with full corporate and legal continuance, pursuant to a notarial deed
dated July 1, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 29 September 2011 number 2315
(the “Company”).

The meeting was opened at 5.00 p.m., with Dr. Matthias Prochaska, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed

as secretary Mr. Louis-Foulques Servajean-Hilst, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms. Nadia Bonnet, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Approval of merger of the Company into Open Text SA; and
2. Miscellaneous.
II- That the sole shareholder of the Company represented, the proxy of the represented sole shareholder and the

number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the represented sole
shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities. The proxy of the represented sole shareholder, initialled “ne varietur” by the appearing party
will also remain annexed to this deed.

III- That all the twenty thousand (20,000) shares representing the entire share capital of the Company of an amount

of twenty thousand United States dollars (USD 20,000) are represented at the present meeting and so that the meeting
which the sole shareholder has had due notice of can validly decide on all the items of the agenda which are known to
the sole shareholder.

The sole shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolution:

<i>Resolution

WHEREAS, the sole shareholder had due knowledge of all documents listed in article 267 paragraph (1) a), b), c) and

e) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), being:

36476

L

U X E M B O U R G

1. The merger plan dated 22 December 2011, as it has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations as of 30 December 2011, number 3212 and pursuant to which the Company will be merged into Open Text
SA by way of transfer of all assets and liabilities of the Company to Open Text SA and the Company will be dissolved;

2. The annual accounts of the last three financial years of Open Text SA and the Company; and
3. The waiver letter to (i) the management report relating to the merger to be issued respectively by the board of

managers of the Company and by the board of directors of Open Text SA in accordance with article 265 (3) of the Law
and to (ii) the interim accounts in accordance with 267 (1) second indent of the Law, executed by the sole shareholder
of the Company and of Open Text SA on 26 January 2012.

WHEREAS, the sole shareholder confirms that in accordance with articles 266 and 267 of the Law, the documents

listed above were at the disposal of the shareholders at the registered offices of Open Text SA and the Company at least
one (1) month prior to this meeting;

WHEREAS, as regard to the merger exchange ratio, the sole shareholder decides to amend the figures of the merger

plan in order to reflect the par value of the shares of Open Text SA issued in consideration for the transfer by the
Company of all its assets to Open Text SA;

THEREFORE, the sole shareholder resolves to approve the merger and the related merger plan amended as mentioned

above.

The sole shareholder resolves to approve that as from the migration date of Metastorm Delaware Inc. (renamed to

Metastorm (Luxembourg) S.à r.l., being the Company) to Luxembourg in accordance with the migration deed, dated 1
July 2011, all operations and transactions of the Company are considered for accounting and tax purposes as being carried
out on behalf of Open Text SA.

The sole shareholder resolves to approve that the effective date of the merger shall be the date of the publication of

the present resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company approving this merger
project, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The sole shareholder further resolves to approve that, in consideration for the transfer by the Company of all its assets

to Open Text SA, Open Text SA allocates, as of the effective date of the merger, to the sole shareholder of the Company,
a total of four million eight hundred and forty-one thousand five hundred and nineteen (4,841,519) ordinary shares without
par value, a total of five million (5,000,000) class B non-voting mandatory redeemable preferred shares without par value
and a total of ten million (10,000,000) class C non-voting mandatory redeemable preferred shares without par value in
the Company and the registration of such new shares in the share register of the Company.

There being no further business, the meeting is closed.

WHEREOF this deed is drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

This deed having been read and translated to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder signed

together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille douze, le trente-et-unième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.
s’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Metastorm (Luxembourg) S.à r.l., une société

à responsabilité limitée, régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 26 boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158514, constituée
selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique et dont le siège social, principal établissement et administration
centrale ont été transférés de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique vers le Grand-duché de Luxembourg, avec
complète continuité de personnalité morale par un acte notarié en date du 1 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations le 29 septembre 2011 numéro 2315 (ci-après la « Société »).

L’assemblée a été ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Dr. Matthias Prochaska, de résidence à Luxembourg,

lequel a désigné comme secrétaire Monsieur Louis-Foulques Servajean-Hilst, de résidence à Luxembourg.

L’assemblée a élu comme scrutateur Madame Nadia Bonnet, de résidence à Luxembourg.
L’assemblée ayant été constituée, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d’acter:
I- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Approbation de la fusion par absorption de la Société par Open Text SA; et
2. Divers.
II- Que l’associé unique de la Société représenté, le mandataire de l’associé unique représenté, ainsi que le nombre

d’actions qu’il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le

36477

L

U X E M B O U R G

mandataire de l’associé unique représenté ainsi que les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. La procuration de l’associé unique représenté, signée ne
varietur, par la personne comparante restera attachée à cet acte.

III- Que l’ensemble des vingt mille (20.000) parts sociales représentant l’entièreté du capital social de la Société d’un

montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000), sont représentées à la présente réunion de sorte que l'assemblée
au sujet de laquelle l’associé unique a été dûment informé, peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour, dont l’associé unique a été préalablement informé.

L’associé unique a demandé au notaire d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

ATTENDU QUE, l’associé unique a pu prendre dûment connaissance de tous les documents énumérés à l’article 267,

paragraphes (1) a), b), c)et e) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tel que modifiée (la « Loi
»), étant:

1. Le projet de fusion en date du 22 décembre 2011, comme il a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations en date du 30 décembre 2011, numéro 3212 et selon lequel la Société sera absorbée par Open Text SA par
voie de transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la Société à Open Text SA et la Société
sera liquidée;

2. Les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux d’Open Text SA et de la Société; et
3. La lettre de renonciation (i) aux rapports à émettre respectivement par le conseil d’administration de Open Text

SA et par le conseil de gérance de la Société et relatifs à la fusion conformément à l’article 265 (3) de la Loi et (ii) aux
comptes intérimaires conformément à l’article 267 (1) alinéa 2 de la Loi, exécutée par l’associé unique de la Société et
d’Open Text SA en date du 26 janvier 2012.

ATTENDU QUE, l’associé unique confirme que conformément aux articles 266 et 267 de la Loi, les documents énu-

mérés ci-dessus étaient à la disposition des associés aux sièges sociaux d’Open Text SA et de la Société au moins un (1)
mois avant cette assemblée;

ATTENDU QUE, concernant le rapport d’échange de la fusion, l’associé unique décide de modifier les chiffres du

projet de fusion afin de refléter le pair comptable des actions d’Open Text SA émises en contrepartie du transfert par la
Société de l’ensemble de ses actifs à Open Text SA, et non plus leur juste valeur de marché;

PAR CONSEQUENT, l’associé unique décide d’approuver la fusion et le projet de fusion y afférent modifié comme

indiqué ci-dessus.

L’associé unique décide d’approuver qu’à partir de la date de transfert de Metastorm Delaware Inc. (renommée Me-

tastorm (Luxembourg) S.à r.l., s’agissant de la Société) à Luxembourg conformément à l’acte de transfert date du 1 juillet
2011, toutes les opérations et les transactions de la Société sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme
accomplies pour le compte de Open Text SA.

L’associé unique décide d’approuver la date de réalisation de la fusion comme étant la date de publication des présentes

résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société approuvant le projet de fusion, dans le
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’associé unique décide ensuite d’approuver que, en contrepartie du transfert réalisé par la Société de l’ensemble de

ses actifs au bénéfice d’Open Text SA, Open Text SA alloue, à compter de la date effective de la fusion, à l’associé unique
de la Société, un total de quatre millions huit cent quarante-et-un mille cinq cent dix-neuf (4.841.519) actions ordinaires
sans valeur nominale, cinq millions (5.000.000) d’actions préférentielles de catégorie B obligatoirement rachetables sans
valeur nominale et dix millions (10.000.000) d’actions préférentielles de catégorie C obligatoirement rachetables sans
valeur nominale d’Open Text SA et l'inscription de ces actions dans le registre d'actionnaires d’Open Text SA.

L’ordre du jour étant épuisé, les débats sont clos.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes mandataires et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. PROCHASKA, L.F. SERVAJEAN-HILST, N. BONNET, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 février 2012. Relation: EAC/2012/1546. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012021513/145.
(120027094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

36478

L

U X E M B O U R G

Simon Ivanhoe II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 151.823.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2012.

Référence de publication: 2012021573/11.
(120027206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Salvador Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 152.758.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 20 janvier 2012

que:

1. L'Assemblée confirme la démission de Mr. Francis Nicholas Hoogewerf, en tant qu'administrateur de la société.
2. L'Assemblée confirme la nomination de la société ELISTART S.A. ayant son siège social à 19 rue Aldringen, L-1118

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B78380 avec son représen-
tant  permanent  Madame  Judith  Angela  Corcoran,  née  le  25  mai  1947  à  Sussex,  Royaume-Uni,  ayant  son  adresse
professionnelle à 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg en tant qu'administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires en 2015.

Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2012.

<i>Pour Hoogewerf &amp; Cie
Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012021580/19.
(120027469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Sammy Jewels S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 41.636.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 février 2012.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2012021581/10.
(120027127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Simax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.406.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 février 2012.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2012021582/10.
(120027125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

36479

L

U X E M B O U R G

TRE Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 146.281.

Il résulte de changements d'adresse que la société Ser.com S.à.r.l., (commissaire de la société) ainsi que Madame Valérie

Wesquy, (administrateur de la société) sont désormais domiciliés au 19, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2012.

Référence de publication: 2012021607/12.
(120027205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Soa People Group SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 124.305.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012021583/10.
(120027264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Soa People SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 124.521.

<i>Extrait des Procès-verbaux des Assemblées Générales du 08 septembre 2011 et du 10 février 2012

L'assemblée du 8 septembre décide de mettre fin au mandat de commissaire aux comptes de la société READ Sàrl, et

de nommer en lieu et place au poste de commissaire aux comptes, pour une durée de 4 ans venant à échéance à l'assemblée
générale de 2015 statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014, Madame Nadine FREIBERG, Zavelbergstraat
17, 3090 Tombeek (Belgique).

L'assemblée du 10 février 2012 décide de nommer aux fonctions d'administrateur unique pour une durée de 3 ans

venant à échéance à l'assemblée à tenir en 2015 Monsieur Vincent SIMIONI, né le 28 juillet 1964 à Verviers et demeurant
42a, Petit Jonckeu, B-4910 Polleur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012021586/17.
(120027266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Top Collection (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 88.332.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 08 février 2012

Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Madame Mireille Masson, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, née le 13/06/1966 à Ougrée
Madame Alié Madeleine, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, née le 11/10/1940 à Rendeux
Renouvellement du mandat de l’administrateur délégué pour une durée de 6 ans:
Monsieur Aniel Gallo, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer, né le 06/02/1962 à Torre Annunziata
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
Fiduciaire et Expertise (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70 909, 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012021603/17.
(120027389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

36480


Document Outline

2 boulevard Konrad Adenauer S.à r.l.

Ampus S.A.

Bel Top Sàrl

Blue Fish S.à r.l.

CEREP III Investment AA S.à r.l.

CPEX S.A.

Emerlux S.à r.l.

Grana Companies

GT Multi Alternative

Hung Top Sàrl

IT-House

IT-Managed Services S.A. (ITMS S.A.)

Jacoby Neal Sàrl

JFC Advanced S.A.

JFC Advanced S.A. SICAR

Kenmore Astoria S.à r.l.

L'Ecluse Investissements S.à r.l.

Leony S.à r.l.

LIB Holdings S.A.

Logicinvest S.A.

LSP Holding

Lux Integral Vision Holding S.A.

LuxMedia-Marketing A.G.

Maclali S.à r.l.

Marlyssa Holding S.A.- SPF

Mediq Luxembourg S.à r.l.

Metastorm (Luxembourg) S.à r.l.

Mobi.lu

Mobi.lu

Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à r.l.

Mongolian Coal Corporation S.à r.l.

M.S. Stainless Luxembourg S.A.

Nineteen Sixty Eight (SPF) S.A.

Norron SICAV

North REOF Holding S.à r.l.

North REOF Holding S.à r.l.

Ode S.àr.l.

One O One S.A.

Onex RSI Holdings Limited

Patron Alma Holdings S.àr.l.

Pendekar Holdings (HARIPUR) S.à r.l.

Pendekar Holdings (Meghnaghat) S.à r.l.

Penfret (SPF) S.A.

Ploquette (SPF) S.A.

Porte des Ardennes S.A.

Quaden Holding S.A.

Recupierre S.à r.l.

RentaPLACE (SPF) S.A.

Salvador Holding S.A.

Sammy Jewels S.àr.l.

Simax S.A.

Simon Ivanhoe II S.à r.l.

S.K. Investments S.C.A.

Soa People Group SA

Soa People SA

Summit Partners IX, S.à r.l.

Top Collection (SPF) S.A.

TRE International S.A.

TRE Investments S.A.