logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 608

8 mars 2012

SOMMAIRE

4 T Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29155

5 T Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29155

Gilles S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29150

InControl S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29143

Jacmont S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29143

Kauri Cab Arminius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29138

Locarlux SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29182

LRP V Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . . .

29138

LSH CO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29142

LSH II CO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29143

Man Investments (Luxembourg) S.A.  . . . .

29151

MG Concepts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29150

M&M Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29143

Mondi Packaging  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29157

Mongoose Holdings 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29160

Monitor Capital Investors S.à.r.l.  . . . . . . . .

29164

Nacarat Design & Créations  . . . . . . . . . . . .

29150

Paris Luxembourg Participations S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29150

Reco-Med S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29156

Reco-Med S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29156

Relaxation 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29156

Représentations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29157

Rondinara S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29156

Rosetta I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29160

Rothschild S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29154

RSHB Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29160

Sequoia IDF Asset Holdings S.A.  . . . . . . . .

29160

Sirko Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29162

SistemApsys S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29163

S.L.P.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29155

Soparfi Onil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29164

Soparfi Onil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29164

Sotime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29163

Sounoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29167

Sounoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29167

Spanish Security Services I S.à r.l.  . . . . . . .

29164

SSILuxCo II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29167

SSILuxCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29168

Sterifant Finanz Holding A.G.  . . . . . . . . . . .

29182

Strategic Ventures International S.A.  . . . .

29182

Tahoe Manager S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29168

Unit Investments S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . .

29155

West End Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

29154

29137

L

U X E M B O U R G

Kauri Cab Arminius, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 131.585.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2012014106/14.
(120016547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

LRP V Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.463.975,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.375.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of December,
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

LIME ROCK PARTNERS V, L.P., an exempted limited Partnership formed and existing under the laws of Cayman

Islands, having its registered office at P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British
West Indies and registered with the Register of Companies of the Cayman Islands, under number 25110, here represented
by Maître Laetitia BORUCKI, attorney-atlaw, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to her.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain enclosed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed company is the sole partner (the “Partner”) owning 100% of the capital of LRP V Luxembourg Holdings

S.à r.l., a société à responsabilité limitée duly incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 13-15,
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 139375, incorporated by deed dated June 2, 2008 of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven,
published in the Memorial C, on July 5, 2008, number 1660 (the “Company”). The articles of association of the Company
have been amended for the last time by deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, dated De-
cember 17, 2010, published in the Memorial C, on March 22, 2011, number 536.

Which appearing party, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:
I.- The agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the capital of the Company by an amount of one hundred and ninety-eight thousand six hundred Euros

(EUR 198,600.-) so as to bring it from its present amount of one million two hundred and sixty-five thousand three
hundred and seventy-five Euros (EUR 1,265,375.-) to an amount of one million four hundred and sixty-three thousand
nine hundred and seventy-five Euros (EUR 1,463,975.-) by the issue of seven thousand nine hundred and forty-four (7,944)
new shares having a nominal value of twenty five Euros (EUR 25.-) each, for a total subscription price of one hundred
and ninety-eight thousand six hundred Euros (EUR 198,600.-).

2) Subscription for the seven thousand nine hundred and forty-four (7,944) new shares by the Company's sole partner

LIME ROCK PARTNERS V, L.P., prenamed and payment up in full by contribution in kind consisting in a claim held by
LIME ROCK PARTNERS V, L.P., prenamed, against the Company for an amount of one hundred and ninety-eight thousand
six hundred Euros (EUR 198,600.-).

The total contribution of one hundred and ninety-eight thousand six hundred Euros (EUR 198,600.-) shall be entirely

allocated to the share capital account of the Company.

Subsequent cancellation of the contributed claim pursuant to article 1300 (2) of the Luxembourg Civil Code (‘confu-

sion').

3) Amendment of the first sentence of article 6 of the Company's articles of association so as to reflect the increase

of capital.

4) Full restatement of article 12 the Company's articles of association relating to the management of the Company.
II.- After this had been set forth, the following resolutions are taken in conformity with the agenda of the meeting:

29138

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Partner decides to increase the capital of the Company by an amount of one hundred and ninety-eight thousand

six hundred Euros (EUR 198,600.-) so as to bring it from its present amount of one million two hundred and sixty-five
thousand three hundred and seventy-five Euros (EUR 1,265,375.-) to an amount of one million four hundred and sixty-
three thousand nine hundred and seventy-five Euros (EUR 1,463,975.-) by the issue of seven thousand nine hundred and
forty-four (7,944) new shares having a nominal value of twenty five Euros (EUR 25.-) each, for a total subscription price
of one hundred and ninetyeight thousand six hundred Euros (EUR 198,600.-).

<i>Subscription and Payment

The Partner decides to approve the subscription of LIME ROCK PARTNERS V, L.P., prenamed and represented as

stated above, for the seven thousand nine hundred and forty-four (7,944) new shares and payment up in full by a con-
tribution  in  kind  consisting  a  claim  held  by  LIME  ROCK  PARTNERS  V,  L.P.,  prenamed,  against  the  Company  and
surrendered to the Company for an amount of one hundred and ninety-eight thousand six hundred Euros (EUR 198,600.-).

The total contribution of one hundred and ninety-eight thousand six hundred Euros (EUR 198,600.-) is entirely allo-

cated to the share capital account of the Company.

The claim having been surrendered to the Company, it shall be cancelled and no longer outstanding in accordance

with article 1300 (2) of the Luxembourg Civil Code (‘confusion').

Evidence of the value of the contributed claim has been provided through (i) a capitalization certificate issued by the

management of LIME ROCK PARTNERS V, L.P., prenamed, on December 27, 2011 and (ii) a valuation certificate issued
by the management of the Company on December 27, 2011.

<i>Second resolution

The Partner resolves to amend the first sentence of article 6 of the Company's articles of association so as to reflect

the increase of capital as follows:

“ Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at capital is fixed one million four hundred and sixty-three thousand

nine hundred and seventy-five Euros (EUR 1,463,975.-) represented by fifty-eight thousand five hundred and fifty-nine
(58,559) shares of twenty five Euros (EUR 25.-) each, all fully paid up and subscribed.”

<i>Third resolution

The Partner resolves to fully restate the article 12 of the Company's articles of association which will be read as follows:

“ Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of category A manager(s) and category B manager(s). The manager(s) need
not to be shareholders.

The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-

pensation and duration of their mandates. The manager(s) may be revoked ad nutum.

The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs

not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of
the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing by
letter, telefax or email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing by letter, telefax or email

another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing by letter, telefax or email.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having
participated.

29139

L

U X E M B O U R G

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman

pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on

behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of members fall within the

competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members,
to any manager or managers of the board or to any person or to any committee (the members of which need not to be
managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any person who need not to be manager, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Towards third parties the Company is validly bound by the single signature of the sole manager or, in case of several

managers, by the joint signature of one (1) category A manager and one (1) category B manager, or by single signature
of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.”.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the foregoing increase of capital are estimated at approximately two thousand euro (€ 2,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said appearing person signed with the notary the present deed.

Follows the French version

L'an deux mille onze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg),

A comparu:

LIME ROCK PARTNERS V, L.P., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois des Îles Cayman, ayant

son siège social à P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, et immatriculée auprès du Registre des
Sociétés - Iles Cayman, sous le numéro 25110, représentée par Maître Laetitia Borucki, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire représentant la partie comparante et le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins d'enregistrement.

La société préqualifée est l'associé unique (l'«Associé») de LRP V Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à respon-

sabilité  limitée  constituée  selon  le  droit  luxembourgeois,  avec  siège  social  au  13-15,  avenue  de  la  Linerté,  L1931
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.375
(la «Société»), constituée selon acte daté du 2 juin 2008 de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») en date du 5 juillet 2008, numéro 1660.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire
de résidence à Luxembourg le 17 décembre 2010, publié au Mémorial C en date du 22 mars 2011, numéro 536.

La partie comparante, représentée tel que indiqué ci-avant, a invité le notaire à constater que:
I. L'ordre du jour est le suivant:
1) Augmentation du capital de la Société à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents

euros (EUR 198.600,-) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent soixante-cinq mille trois cent
soixante-quinze euros (EUR 1.265.375,-) à un montant de un million quatre cent soixante-trois mille neuf cent soixante-
quinze euros (EUR 1.463.975,-) par l'émission de sept mille neuf cent quarante-quatre (7.944) nouvelles parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), pour une valeur totale de souscription de cent quatre-vingt-dix-
huit mille six cents euros (EUR 198.600,-).

2) Souscription des sept mille neuf cent quarante-quatre (7.944) nouvelles parts sociales émises par l'Associé unique

de la Société, LIME ROCK PARTNERS V, L.P., préqualifiée et paiement de la totalité par un apport en nature consistant
en une créance détenue par LIME ROCK PARTNERS V, L.P., préqualifiée, envers la Société pour un montant de cent
quatre-vingt-dix-huit mille six cents euros (EUR 198.600,-).

29140

L

U X E M B O U R G

Le montant total de l'apport de cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents euros (EUR 198.600,-) sera entièrement

alloué au compte de capital social de la Société.

Annulation subséquente de la créance apportée en vertu de l'article 1300 (2) du Code Civil luxembourgeois («con-

fusion»).

3) Modification de la première phrase de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter la prédite augmentation

de capital.

4) Refonte de l'article 12 des statuts de la Société.
II Ces faits exposés, les résolutions suivantes ont été prises conformément à l'ordre du jour:

<i>Première résolution

L'Associé décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt-dix-huit

mille six cents euros (EUR 198.600,-) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent soixante-cinq mille
trois cent soixante-quinze euros (EUR 1.265.375,-) à un montant de un million quatre cent soixante-trois mille neuf cent
soixante-quinze euros (EUR 1.463.975,-) par l'émission de sept mille neuf cent quarante-quatre (7.944) nouvelles parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), pour une valeur totale de souscription de cent quatre-
vingt-dix-huit mille six cents euros (EUR 198.600,-).

<i>Souscription et Libération

L'Associé décide d'accepter la souscription par LIME ROCK PARTNERS V, L.P., représenté tel qu'indiqué ci-avant et

préqualifié, des sept mille neuf cent quarante-quatre (7.944) nouvelles parts sociales et paiement de la totalité par un
apport en nature consistant en une créance détenue par LIME ROCK PARTNERS V, L.P., préqualifié, envers la Société
pour un montant de cent quatre-vingt-dixhuit mille six cents euros (EUR 198.600,-).

Le montant total de l'apport de cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents euros (EUR 198.600,-) est entièrement alloué

au compte de capital social de la Société.

Annulation subséquente de la créance apportée en vertu de l'article 1300 (2) du Code Civil luxembourgeois («con-

fusion»).

La preuve de la valeur de cette créance a été fournie (i) un certificat de capitalisation émis par les gérants de LIME

ROCK PARTNERS V, L.P., préqualifiée en date du 27 décembre 2011 et par (ii) un certificat d'évaluation émis par les
gérants de la Société en date du 27 décembre 2011.

<i>Deuxième résolution

L'Associé décide de modifier la première phrase de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter la prédite

augmentation de capital comme suit:

« Art. 6. Le capital social est fixé à un million quatre cent soixante-trois mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR

1.463.975,-) représenté par cinquante-huit mille cinq cent cinquante-neuf (58.559) parts sociales d'une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part étant entièrement libérée.”

<i>Troisième résolution

L'Associé décide de modifier et de refondre l'article 12 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 12. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront

un conseil de gérance, composé de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. Les gérant(s) n'ont pas besoin
d'être associés.

Les gérant(s) seront élus et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui déterminera également leurs pouvoirs,

rémunération ainsi que la durée de leur mandat. Les gérant(s) peuvent être révoqués ad nutum.

Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également désigner un secrétaire, qui

n'aura pas besoin d'être gérant et qui aura pour mission de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance
et des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convo-

cation.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

l'heure prévue pour une telle réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence devront
être énoncés dans l'avis de convocation. Cet avis pourra être levée par le consentement écrit par lettre, télécopie ou
courrier électronique de chaque gérant. Avis distinct ne sera pas requis pour les réunions individuelles tenues aux heures
et lieux prescrits dans un calendrier préalablement adopté par résolution du conseil de gérance.

Tout gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit soit par lettre, télécopie ou courrier

électronique un autre gérant comme son mandataire.

Les votes peuvent également être exprimés par écrit soit par lettre, télécopie ou courrier électronique.

29141

L

U X E M B O U R G

Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou

représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants produiront effets au même titre que les résolutions

votées lors des réunions du conseil de gérance.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion au moyen de conférence téléphonique ou par tout autre

moyen de communication similaire initiée à partir de Luxembourg, permettant ainsi à plusieurs personnes y participant
de  communiquer  simultanément  les  unes  avec  les  autres.  Une  telle  participation  sera  réputée  égale  à  une  présence
physique à la réunion. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signée par tous les membres y ayant participé.

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence,

par le président pro tempore qui a présidé à cette réunion.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, qui peuvent être produits dans des procédures judiciaires ou autrement

seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux gérants.

Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la Société ainsi que la repré-

sentation  de  la  société  en  ce  qui  concerne  cette  gestion  journalière,  avec  le  consentement  préalable  de  l'assemblée
générale des associés, à un ou plusieurs gérant du conseil de gérance ou à toute personne ou à tout comité (dont les
membres n'ont pas besoin d'être gérants) délibérant selon les modalités et pouvoirs tels que déterminés par le conseil
de gérance. Il peut également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui n'a pas besoin d'être
gérant, nommer et révoquer tous les agents et employés, et fixer leurs émoluments.

Envers les tiers la Société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe d'un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B, ou par la signature
unique de toute personne (s) à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance. ".

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

s'élève à approximativement deux mille euros (€ 2.000,-).

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénoms

usuels, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire

Signé: Borucki, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 janvier 2012. Relation: EAC/2012/118. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012011129/248.
(120012271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

LSH CO, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 152.026.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2012014127/10.
(120016734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

29142

L

U X E M B O U R G

LSH II CO, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 152.024.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2012014128/10.
(120016733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Jacmont S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 76, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 159.059.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2012014099/14.
(120016574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

InControl S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 158.993.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2012014083/14.
(120016508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

M&amp;M Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 166.329.

STATUTES

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THELVE, ON THE 17 

th

 DAY OF JANUARY.

Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert.

There appeared:

FIDOR SPA - FIDUCIARIA OREFICI, with registered office at Via Agnello, 5 -20121 MILANO (Italy), N.02112190018,

RCS of Milano (Italy),

represented by Xavier MANGIULLO, employee, residing professionally in Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich,
by virtue of a proxy dated 11 

th

 of January, 2012.

The proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock company

to be incorporated.

29143

L

U X E M B O U R G

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A joint stock company is herewith formed under the name of “M&amp;M REAL ESTATE S.A.”.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors or of the sole director.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors or of the sole director.
The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other

companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contribu-
tions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents
and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked
to the said object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, mana-

gement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it

has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly

or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 32,000 (thirty-two thousand Euro) divided into 16,000

(sixteen thousand) shares with a nominal value of EUR 2 (two Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the company must be managed by a board of directors consisting of at least

three members (each a “Director”), who need not be shareholders.

In case the company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it

is established that the company has only one shareholder left, the company can be managed by a board of directors
consisting of either one director until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of
more than one shareholder.

The directors or the sole director are appointed for a term which may not exceed six years by the general meeting

of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can represent more than one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

29144

L

U X E M B O U R G

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors or the sole director is vested with the broadest powers to perform all acts of admi-

nistration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law
of August 10, 1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11.  The  board  of  directors  or  the  sole  director  may  delegate  all  or  part  of  its  powers  concerning  the  daily

management to members of the board or to third persons who need not be shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed, in case of a sole director by the sole

signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two directors

or by the sole signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with

the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General meeting

Art. 14. If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting

of shareholders and takes the decision in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the whole body of shareholders

of the company. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the third Thursday of the month of June at 5 p.m..

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the sole director or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting.

It must be convened at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the 1 

st

 of January of each year and ends on the 31 

st

 of December of the same

year.

The board of directors or the sole director draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors or the sole director in compliance with the legal requi-

rements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

29145

L

U X E M B O U R G

General disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2012.
The first annual general meeting shall be held in 2013.
The first director(s) and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed by the shareholders as follows:

- FIDOR SPA - FIDUCIARIA OREFICI, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,000 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,000 shares

All the shares have been liberated and paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR

32,000 (thirty-two thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

EUR 1.000.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder, prenamed, represented as above mentioned, representing the whole of the share capital passed

the following resolutions:

<i>Resolutions:

1. The number of directors is fixed at 1 (one).
2. has been appointed as director:
- Mr. Xavier MANGIULLO, employee, born on the 8 

th

 of September 1980 in Hayange (France), residing professionally

in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diederich.

3. FINSEV S.A. having its registered office in 5, avenue Gaston Diderich in L-1420 Luxembourg, RCS Luxembourg

B103749, has been appointed as statutory auditor.

4. The registered office of the Company will be established at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diederich.
5. The term of office of the director shall be ending with the general annual meeting to be held in 2017.
6. The term of office of the statutory auditor shall be ending with the general annual meeting to be held in 2017.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by her surnames, Christian

names, civil status and residences, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Follows the french version of the preceding text:

L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE DIX-SEPT JANVIER.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

FIDOR SPA - FIDUCIARIA OREFICI, avec siége social à Via Agnello, 5 - 20121 MILANO (Italie), N. Immatriculation

02112190018, RCS de Milan (Italie),

ici représentée par Monsieur Xavier MANGIULLO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, Ave-

nue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,

29146

L

U X E M B O U R G

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 11 janvier 2012.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «M&amp;M REAL ESTATE S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, la société pourra établir

des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique de à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être
transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de
pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 16.000 (seize

mille) actions d'une valeur nominale de EUR 2.- (deux euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme

qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis, un administrateur peut représenter plus d'un de ses col-
lègues.

29147

L

U X E M B O U R G

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous

les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée
générale.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de

gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12.  Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances,  en  cas  d'administrateur  unique,  par  la

signature individuelle de l'administrateur unique,

ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs,
ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à 17.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

29148

L

U X E M B O U R G

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.
Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les actions ont été souscrites comme suit:

- FIDOR SPA -FIDUCIARIA OREFICI, précitée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 actions

Toutes les actions ont été libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 32.000.- (trente-

deux mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.000.-.

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à UN et celui des commissaires à UN.
2. A été appelé aux fonctions d'administrateur:
-  Monsieur  Xavier  MANGIULLO,  employé,  né  le  08/09/1980  à  Hayange  (France),  résident  professionnellement  à

L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich,

3.  La  société  FINSEV  S.A.  avec  siège  social  à  L-1420  Luxembourg,  5,  avenue  Gaston  Diderich,  RCS  Luxembourg

B103749, est appelée aux fonctions de Commissaire aux Comptes.

4. Le siège de la société est fixé au 5, Avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg.
5. Le mandat de l'administrateur se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2017.
6. Le mandat du commissaire aux comptes se terminera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an

2017.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des sociétés comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: X. MANGIULLO, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 20 janvier 2012. RED/2012/160. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. ELS.

29149

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 20 janvier 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012011138/333.
(120012913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

MG Concepts, Société à responsabilité limitée,

(anc. Gilles S.à r.l.).

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels.

R.C.S. Luxembourg B 124.236.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014157/11.
(120016631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Nacarat Design &amp; Créations, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5626 Mondorf-les-Bains, 12, rue Elise Deroche.

R.C.S. Luxembourg B 137.363.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2012014171/14.
(120016685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Paris Luxembourg Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 108.203.

L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand Duché de Luxembourg),

a comparu:

Monsieur  Emmanuel  LIMIDO,  né  le  5  janvier  1959  à  Paris,  administrateur  de  société,  demeurant  à  Dubai  (UAE),

Shangrila Building, unit 501 B, Sheikh Zayed Road, PO BOX 214617,

ici représenté par Madame Marie-Laurence THILL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2011, laquelle procuration restera, après avoir été

signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, annexée au présent acte.

La partie comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée "Paris Luxembourg Participations S.à

r.l.", ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.203, constituée suivant acte du notaire instrumentant
le 24 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 990 le 5 octobre 2005.

Laquelle comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution

suivante:

<i>Première résolution

L'associé décide d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR

987.500.-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) jusqu'à un million
d'euros (EUR 1.000.000,-) par l'émission de sept mille neuf cents (7.900) parts sociales d'une valeur de cent vingt-cinq
euros (EUR 125,-) chacune.

29150

L

U X E M B O U R G

Les parts sociales nouvelles sont souscrites par Monsieur Emmanuel LIMIDO, prénommé, payées par un apport en

nature consistant en une partie de la créance détenue par Monsieur Emmanuel LIMIDO contre la Société pour un montant
total de neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 987.500,-).

Les documents justificatifs de l'existence de la créance et de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d'un million d'euros -(EUR 1.000.000,-) représentée par huit mille (8.000)

parts sociales, d'une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune."

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à trois mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.L. THILL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17630. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): T. THOMA.

Référence de publication: 2012014188/45.
(120016781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Man Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 142.253.

In the year two thousand and eleven, on the twelfth day of the month of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Man Investments (Luxembourg) S.A. (the "Cor-

poration"), a public limited company ("société anonyme") as defined by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the "Law of 1915"), having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L–1273 Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, on 22 September 2008, which
was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2609 on 24 October 2008. The articles
of incorporation have been amended for the last time on 4 May 2009 by a notarial deed of the undersigned notary and
were published in the Mémorial, number 1137 on 9 June 2009.

The meeting was opened at 2.30 p.m. under the chairmanship of Henning Schwabe, Lawyer, professionally residing in

14, rue Erasme, L–2082 Luxembourg,

who appointed as secretary Michael Kirsch, Lawyer, professionally residing in 14, rue Erasme, L–2082 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Frank Brülin, Lawyer, professionally residing in 14, rue Erasme, L–2082 Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The name of the sole shareholder duly represented by proxy, the proxy of the sole shareholder represented, as well

as the number of shares held by the sole shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the sole shareholder
present, the proxy of the sole shareholder represented, the members of the board of the meeting and the notary. The
aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxy given shall be initialed “ne varietur”
by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document.

II. The quorum of at least one half of the capital is required by Article 67-1 (2) of the Law of 1915 and the resolution

on the items 2 to 5 of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast in the
Corporation.

III. The agenda of the present meeting is the following:
1. Replacement of all references in the articles of incorporation to the Law of 20 December 2002 by references to

the Law of 17 December 2010 and replacement of all references to the Directive 85/611/EEC by references to the
Directive 2009/65/EC.

2. Change of the beginning of the accounting year of the Corporation from 1 April of each year to 1 January of each

year and the end of such accounting year from 30 March of the following year to 31 December of the same year, with
the accounting year 2011 being a short accounting year beginning on 1 April 2011 and ending on 31 December 2011.

29151

L

U X E M B O U R G

3. Change of the date of the annual general meeting of shareholders of the Corporation from the third Friday of August

at 2 p.m. to the third Friday of June of the relevant year at 2 p.m.

4. Subsequent amendment of the articles of incorporation of the Corporation (the “Articles”) to reflect the change

of the financial year of the Corporation as follows:

Article 18 of the Articles is to read as follows: “The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of

January and shall terminate on the last day of December of each year.”

The first paragraph of Article 8 of the Articles is to read as follows: “The annual general meeting of shareholders shall

be held in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at any other
place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Friday of the month of June at 2:00 p.m..”

5. Miscellaneous.
IV.  The  entire  corporate  capital  being  represented  at  the  present  meeting  and  the  sole  shareholder  represented

declaring that is has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were
necessary.

V. Consequently, the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned

items of the agenda.

After deliberation, the general meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to replace all references in the articles of incorporation to the law of 20 December 2002 on

undertakings for collective investment by references to the law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment and to replace all references to the Directive 85/611/EEC by references to the Directive 2009/65/EC.

The meeting resolves to approve the restated articles of incorporation. A copy of the restated articles after having

been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed to
be filed with it with the registration authorities.

<i>Second resolution

The meeting resolves to change the beginning of the accounting year of the Corporation from 1 April of each year to

1 January of each year and the end of such accounting year from 30 March of the following year to 31 December of the
same year, with the accounting year 2011 being a short accounting year beginning on 1 April 2011 and ending on 31
December 2011.

<i>Third resolution

The meeting resolves to change the date on which the annual general meeting of shareholders of the Corporation is

held from the third Friday of August at 2 p.m. to the third Friday of June of the relevant year at 2 p.m.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to amend the Article 18 of the Articles which shall henceforth read as follows:
“The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of

December of each year.”

The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 8 of the Articles which shall henceforth read as follows:
“The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Corporation, or at any other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the third Friday of the month of June at 2:00 p.m.”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the said persons, all of whom are known to the notary by their surnames, first names,
civil status and residences, the said persons appearing together before the notary signed together with the notary, this
original deed.

Follows the french translation:

L'an deux mille onze, le douze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique (l'«Assemblée») de Man Investments (Lu-

xembourg) S.A (la «Société»), une société anonyme au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (la «Loi de 1915»), ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L–1273 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire demeurant à Luxembourg, en date du 22 septembre 2008, publié au Mé-

29152

L

U X E M B O U R G

morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2609 le 24 octobre 2008. Les statuts ont été modifiées la dernière
fois suivant acte reçu par le notaire soussigné le 4 mai 2009 et ont été publiées au Mémorial numéro 1137 du 9 juin 2009.

L'Assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Henning Schwabe, avocat, demeurant professionnelle-

ment 14, rue Erasme, L – 2082 Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Michael Kirsch, avocat, demeurant professionnellement 14, rue Erasme, L-2082 Lu-

xembourg.

L'Assemblée  élit  comme  scrutateur  Frank  Brülin,  avocat,  demeurant  professionnellement  14,  rue  Erasme,  L-2082

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que les noms de l'actionnaire unique représenté, des mandataires de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le

nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
l'actionnaire unique présent, les mandataires de l'actionnaire unique représenté, ainsi que par les membres du bureau et
le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Restera
pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration de l'actionnaire unique représenté,
après avoir été paraphée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Que le quorum d'au moins la moitié du capital est requis par l'Article 67 -1 (2) de la Loi de 1915 et que les résolutions

sur les points 2 à 5 portés à l'ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux tiers des votes
exprimés de la Société.

III. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Remplacement de toutes les références dans les statuts à la Loi du 20 décembre 2002 par des références à la Loi

du 17 décembre 2010 et remplacement de toutes les références à la Directive 85/611/CEE par des références à la Directive
2009/65/CE.

2. Changement du début de l'exercice comptable de la Société du 1 

er

 avril de chaque année au 1 

er

 janvier de chaque

année et la fin d'une telle exercice comptable du 30 mars de l'année suivante au 31 décembre de la même année, l'exercice
comptable 2011 étant une exercice comptable courte commençant le 1 

er

 avril 2011 et terminant le 31 décembre 2011.

3. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du troisième vendredi du

mois d'août à 14.00 heures au troisième vendredi du mois de juin à 14.00 heures.

4. Les modifications suivantes sont apportées aux statuts de la Société (les «Statuts») afin de refléter le changement

de l'exercice comptable:

L'Article 18 des Statuts aura la teneur suivante: «L'exercice comptable de la Société commencera le premier janvier

et se terminera le dernier jour du mois de décembre de chaque année.»

Le premier paragraphe de l'Article 8 des Statuts aura la teneur suivante:
«L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société, ou à tout autre lieu situé à Luxembourg tel que mentionné dans l'avis de convocation, le
troisième vendredi du mois de juin à 14 heures.»

5. Divers
IV. Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée et que l'actionnaire unique représenté

déclare avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'Assemblée, il a donc pu être fait abstraction des lettres
de convocation.

V. Que, par conséquent, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points sus-

mentionnés de l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée a pris à l'unanimité des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de remplacer toutes les références dans les statuts à la loi du 20 décembre 2002 relative aux

organismes de placement collectif par des références à la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement
collectif et remplacement de toutes les références à la Directive 85/611/CEE par des références à la Directive 2009/65/
CE.

L'Assemblée décide d'approuver les statuts coordonnés. Une copie des statuts coordonnés, après avoir été signée ne

varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui
aux formalités de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer le début de l'exercice comptable du 1 

er

 avril de chaque année au 1 

er

 janvier de chaque

année et la fin d'un tel exercice comptable du 30 mars de l'année suivante au 31 décembre de la même année, l'exercice
comptable 2011 étant un exercice comptable raccourci commençant le 1 

er

 avril 2011 et se terminant le 31 décembre

2011.

29153

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du troisième

vendredi du mois d'août à 14.00 heures au troisième vendredi du mois de juin à 14.00 heures

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'Article 18 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:
«L'exercice comptable de la Société commencera le premier janvier et se terminera le dernier jour du mois de dé-

cembre de chaque année.»

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'Article 8 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:
«L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société, ou à tout autre lieu situé à Luxembourg tel que mentionné dans l'avis de convocation, le
troisième vendredi du mois de juin à 14.00 heures.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. KIRSCH, F. BRÜLIN, H. SCHWABE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57318. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur p.d. (signé): T. BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012011140/170.
(120013104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

West End Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 163.272.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 26 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014279/10.
(120016592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Rothschild S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 53, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.618.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 30. April 2010

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschaft "European Audit S.à r.l.", tritt als Rechnungskommissar zurück

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft LUXTAX S.A R.L., DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE BERATERUNION S.A R.L. 38, Grand-Rue in

6630 Wasserbillig, eingeschrieben in Luxembourg im Handelsregister unter der Nummer B 122.744 wird zum neuen
Rechnungskommissar für die Dauer von 6 Jahren ernannt. Das Mandat endet während der Generalversammlung des
Jahres 2016.

Da somit de Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

29154

L

U X E M B O U R G

Wasserbillig, den 30. April 2010.

Herbert Rothschild / LUXTAX S.A R.L., DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE BERATERUNION S.A R.L.
<i>Stimmzähler-Schriftführer / Vorsitzender

Référence de publication: 2012014227/19.
(120017019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Unit Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 30.253.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012014270/9.
(120016468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

5 T Invest S.A., Société Anonyme,

(anc. 4 T Invest S.A.).

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 138.122.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014296/11.
(120016626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

S.L.P.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 119.783.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle

En date du 21 décembre 2011, l'assemblée générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants

avec effet immédiat:

- Monsieur Massimo LONGONI, demeurant professionnellement au 10, Rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2625

Luxembourg en tant qu'administrateur de catégorie A.

- Monsieur Yves FOURCHY, demeurant professionnellement au 22, avenue Montaigne, F-75008 Paris, France en tant

qu'administrateur de catégorie A.

- Monsieur Eric VANDERKERKEN, demeurant professionnellement au 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg en tant

qu'administrateur de catégorie A.

- Monsieur Lorenzo DA PRA GALANTI, demeurant professionnellement au 5, Santa Tecla, I-20122 Milan, Italie en

tant qu'administrateur de catégorie B.

- Monsieur Alberto JASONI, demeurant professionnellement au 9/1, Via Cascina Bianca, I-20142 Milan, Italie en tant

qu'administrateur de catégorie B.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale de 2012.
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Massimo LONGONI. Son mandat expirera

à l'issue de l'assemblée générale de 2012.

L'assemblée prend note du changement d'adresse professionnelle de Eric VANDERKERKEN au 22-24, Rives de Clau-

sen L-2165 Luxembourg.

A cette même date, l'assemblée générale a décidé de ne pas renouveler le mandat de ERNST&amp;YOUNG S.A. en tant

que commissaire aux comptes et de le nommer en tant que réviseur d'entreprises agréé de la société avec effet immédiat.

L'assemblée prend note du changement de siège social de ERNST &amp; YOUNG S.A. au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365

Munsbach. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

29155

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012014350/33.
(120016208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Reco-Med S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 147.790.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012014954/9.
(120017503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Reco-Med S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 147.790.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012014955/9.
(120017504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Relaxation 2000, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5433 Niederdonven, 57, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 55.993.

Les Comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 27/01/2012.

<i>Pour RELAXATION 2000 S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2012014957/12.
(120017348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Rondinara S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.520.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 30 janvier 2012

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Bernard ZEIMET né à Luxembourg, le 05/03/1953 et de-

meurant professionnellement au 67 rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg ainsi que la démission du commissaire aux
comptes, la société READ Sàrl, RCS Luxembourg B 45.083 ayant son siège social au 3A Boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Joël MARECHAL, employé privé, né à Arlon le 12/09/1968 et demeurant professionnellement au 3A Bou-

levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

- Monsieur Etienne GILLET, expert-comptable, né à Bastogne le 19/09/1968 et demeurant professionnellement au 3A

Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

- Monsieur Laurent JACQUEMART, expert-comptable, né à Daverdisse le 19/06/1968 et demeurant professionnelle-

ment au 3A Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

et comme nouveau commissaire:
-  La  société  AUDITEX  SARL  ayant  son  siège  social  au  3A  Boulevard  du  Prince  Henri,  L-1724  Luxembourg,  RCS

Luxembourg B 91.559

Leur mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2018.

29156

L

U X E M B O U R G

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012014963/26.
(120017802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Représentations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 57.784.

L’adresse de Monsieur Laurent DECKER est à changer comme suit:
L-4024 ESCH/ALZETTE, rue de Belval
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012014959/10.
(120017899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Mondi Packaging, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 408.256.750,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 109.760.

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, the undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Mondi Packaging S.à r.l." (the “Company”), a

“Société à responsabilité limitée”, established at 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section
B number 109.760, incorporated by deed of Maître André Schwachtgen, notary, on 27 July 2005, published in the Lu-
xembourg Memorial C number 1383 and whose Articles of Incorporation were for the last time modified by deed enacted
on 1 February 2008 published in Memorial C, number 1579 on 26 June 2008.

There appeared:

Mondi S.à r.l., a “Société à responsabilité limitée”, established at 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg section B number 98.996 (the “sole Shareholder”),

hereby represented by Mr Régis Galiotto, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lu-

xembourg on 12 December 2011, which proxy, after having been signed by the proxyholder acting on behalf of the
appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities.

The sole Shareholder has declared and requested the undersigned notary to record the following:
I. That the sole Shareholder holds all the 7,156,226 (seven million one hundred fifty six thousand two hundred twenty

six) shares in the share capital of the Company;

II. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is as follows:
1. Share capital increase by EUR 50,445,450 so as to raise it from its current amount of EUR 357,811,300 to EUR

408,256,750 by contribution in cash by the issue of 1,008,909 new shares of a per value of EUR 50;

2. Legal reserve increase by EUR 5,044,550 so as to raise it from its current amount of EUR 35,781,130 to EUR

40,825,680;

3. Amendment of article 6.1 of the Articles of Association in order to reflect such action;
4. Miscellaneous.
III. The sole Shareholder hereby passes the following resolutions:

<i>First resolution

It is decided to increase the share capital by the amount of EUR 50,445,450 (fifty million four hundred forty five thousand

four hundred fifty euro) so as to raise it from its present amount of EUR 357,811,300 (three hundred fifty seven million
eight hundred eleven thousand three hundred euro) to EUR 408,256,750 (four hundred eight million two hundred fifty
six thousand seven hundred fifty euro) by the issue of 1,008,909 (one million eight thousand nine hundred nine) new
shares having a par value of EUR 50 (fifty euro) each.

<i>Second resolution

It is decided to increase the legal reserve by the amount of EUR 5,044,550 (five million forty four thousand five hundred

fifty euro) so as to raise it from its present amount of EUR 35,781,130 (thirty five million seven hundred eighty one

29157

L

U X E M B O U R G

thousand one hundred thirty euro) to EUR 40,825,680 (forty million eight hundred twenty five thousand six hundred
eighty euro).

<i>Third resolution

It is decided to admit the sole shareholder "Mondi S.à r.l.", to the subscription of the 1,008,909 (one million eight

thousand nine hundred nine) new shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon "Mondi S.à r.l.", prenamed, represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of the aforementioned

proxy;

declared to subscribe to the 1,008,909 (one million eight thousand nine hundred nine) new shares and to have them

fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR
50,445,450 (fifty million four hundred forty five thousand four hundred fifty euro), as was certified to the undersigned
notary, together with the legal reserve amounting to EUR 5,044,550 (five million forty four thousand five hundred fifty
euro).

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 6.1 of the Articles of Association to read

as follows:

Art. 6.1. The Company's capital is set at EUR 408,256,750 (four hundred eight million two hundred fifty six thousand

seven hundred fifty euro) represented by 8,165,135 (eight million one hundred sixty five thousand one hundred thirty
five) shares of EUR 50 (fifty euro) each."

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany as a result of this deed is estimated at approximately seven thousand Euros (EUR 7,000.-).

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian name,
civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary. The undersigned notary who
understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded
in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between
the English and the French version, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire de l’actionnaire unique de la société anonyme "Mondi Packaging S.à r.l.

(la Société), ayant son siège social au 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 109.760, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître André
Schwachtgen en date du 27 juillet 2005, publié au Mémorial C numéro 1383 et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte reçu le 1 février 2008, publié au Mémorial C, N° 1579 du 26 juin 2008.

A comparu:

Mondi S.à r.l., avec son siège social au 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 98.996 (l’Actionnaire Unique),

Ici représenté par Mr Régis Galiotto, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

à Luxembourg le 13 décembre 2011,

Ladite procuration, après signature par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Actionnaire Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que l’Actionnaire Unique détient toutes les 7,156,226 (sept millions cent cinquante six mille deux cent vingt six)

actions du capital de la Société;

II. l'ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 50,445,450 pour l'amener de son montant actuel de EUR

357,811,300 à EUR 408,256,750 par contribution en numéraire par l’émission de 1,008,909 nouvelles actions d’une valeur
nominale de EUR 50;

29158

L

U X E M B O U R G

2. Augmentation de la réserve légale à concurrence de EUR 5,044,550, pour l’amener de son montant actuel de EUR

35,781,130 à EUR 40,825,680;

3. Modification afférente de l'article 6.1 des statuts;
4. Divers.
III. L’Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 50,445,450 (cinquante millions quatre cent quarante

cinq mille quatre cent cinquante euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 357,811,300 (trois cent cinquante
sept millions huit cent onze mille trois cent euro) à EUR 408,256,750 (quatre cent huit millions deux cent cinquante six
mille sept cent cinquante euro) par l'émission de 1,008,909 (un million huit mille neuf cent neuf) parts sociales nouvelles
d'une valeur nominale de EUR 50 (cinquante euro) chacune, par apport en numéraire.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter la réserve légale à concurrence de EUR 5,044,550 (cinq millions quarante quatre mille cinq

cent cinquante euro) pour la porter de son montant actuel de EUR 35,781,130 (trente cinq millions sept cent quatre vingt
un mille cent trente euro) à EUR 40,825,680 (quarante millions huit cent vingt cinq mille six cent quatre vingt euro).

<i>Troisième résolution

Il est décidé d'admettre l'associé unique, "Mondi S.à r.l." prénommée, à la souscription des 1,008,909 (un million huit

mille neuf cent neuf) parts sociales nouvelles:

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite "Mondi S.à r.l.", prénommée, représentée par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration dont

mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 1,008,909 (un million huit mille neuf cent neuf) parts sociales nouvelles, et les libérer intégra-

lement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 50,445,450
(cinquante millions quatre cent quarante cinq mille quatre cent cinquante euro) ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant, ainsi que la somme de EUR 5,044,550 (cinq millions quarante quatre mille cinq cent cinquante euro)
correspondant à la réserve légale.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 6.1 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6.1. La société a un capital émis de EUR 408.256.750 (quatre cent huit millions deux cent cinquante six mille sept

cent cinquante euro) divisé en 8.165.135 (huit millions cent soixante cinq mille cent trente cinq) parts sociales de EUR
50 (cinquante euro) chacune.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société à

raison du présent acte est estimé à environ sept mille Euros (7.000.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en

langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57594. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur p.d. (signé): T. BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012011145/143.
(120013160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

29159

L

U X E M B O U R G

Rosetta I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 87.836.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 janvier 2012 que:
- le siège social de la Société est transféré à partir du 2 janvier 2012 au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- l'adresse professionnelle des administrateurs se trouve désormais au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Erik van Os
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012014964/15.
(120017880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

RSHB Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 111.968.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 janvier 2012 que:
- le siège social de la Société est transféré à partir du 2 janvier 2012 au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- l'adresse professionnelle des administrateurs se trouve désormais au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Erik van Os
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012014965/15.
(120017893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Sequoia IDF Asset Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 165.989.

Il résulte des décisions de l'Actionnaire Unique prises le 19 janvier 2012 que:
- le siège social de la Société est transféré à partir du 2 janvier 2012 au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- l'adresse professionnelle des administrateurs se trouve désormais au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Erik van Os
<i>Administrateur

Référence de publication: 2012014971/15.
(120017891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Mongoose Holdings 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 160.351.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December, before Us, Maître Francis Kesseler, notary

residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

29160

L

U X E M B O U R G

Mongoose Holdings 1, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered

office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 160.337 and having a share capital of EUR 12,500.- (the Parent),

duly represented by Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing in Esch-sur-Alzette, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting through its proxyholder, has requested the notary to state that:
I. The Parent is the sole shareholder of Mongoose Holdings 2, a Luxembourg private limited liability company (société

à responsabilité limitée) having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duché of
Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 160.351 and
having a share capital of EUR 12,500.- (the Company) and holds all the shares in the share capital of the Company

II. The Company has been incorporated on March 31, 2011, pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Asso-
ciations number 1622 on July 20, 2011. The articles of association of the Company have not been amended since.

III. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all entirely subscribed and fully paid
in.

IV. The Parent has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly knows the financial

situation of the Company.

<i>Resolutions

The Parent, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has decided, to proceed with the dissolution of

the Company with immediate effect; and

(i) to assume the role of liquidator of the Company;
(ii) to grant full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandates;
(iii) as liquidator of the Company to declare (i) that the activity of the Company has ceased, (ii) that, except for

administrative charges for liquidation purposes of the Company, all the known debts have been paid, (iii) that it takes
over all assets, liabilities and commitments (including tax liabilities), known or unknown, of the Company, and (iv) that it
undertakes to assume all outstanding liabilities (if any) of the Company and hence, the Company's liquidation can be
terminated without prejudice;

(iv) consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed; and
(v) to keep the books, documents and records of the Company during a period of five (5) years at 13-15, avenue de

la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with

the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an  deux  mille  onze,  le  vingt-neuvième  jour  de  décembre,  par  devant  Nous,  Maître  Francis  Kesseler,  notaire  de

résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

La soussignée, Moongoose Holdings 1, une société à responsabilité limitée dont le siège social se situe à 13-15, avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.337 et ayant un capital social de EUR 12.500,- (la Mère)

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à

Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a prié le notaire d'acter que:

29161

L

U X E M B O U R G

I. La Mère est la seule associée de Moongoose Holdings 2, une société à responsabilité limitée dont le siège social se

situe à 13-15, avenue de la Liberté, L1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.351 et ayant un capital social de EUR 12.500,- (la
Société) et détient toutes les parts sociales dans le capital de la Société.

II. La Société a été constituée en date du 31 mars 2011 suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence

à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1622 du 20 juillet 2011. La Statuts de
la Société n'ont pas été modifiés depuis.

III. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

IV. La partie comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

La Mère, agissant en qualité d'associée unique de la Société, a décidé, a décidé de procéder à la dissolution de la Société

avec effet immédiat; et

(i) d'assumer le rôle de liquidateur de la Société;
(ii) d'accorder décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats;
(iii) en tant que liquidateur de la Société de noter (i) que l'activité de la Société a cessé, (ii) que, à l'exception des frais

administratifs liés aux besoins de la liquidation de la Société, toutes les dettes connues ont été payées, (ii) elle contrôle
de tous les actifs, passifs et engagements financiers (y compris le passif fiscal), connus ou inconnus, de la Société et (iii)
qu'elle s'engage à assumer tout le passif restant (le cas échéant) de la Société afin d'assurer que la liquidation de la Société
soit effectuée sans préjudice;

(iv) par conséquent la Société est par la présente dissoute et la liquidation est clôturée;
(v) de garder les livres, documents et dossiers de la Société pendant une durée de cinq (5) ans au 13-15, avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ mille cinq cents euros (€ 1,500.-).

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Esch-sur-Alzette.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, a constaté, qu'à la requête de la partie comparante, le présent

procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la
version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 janvier 2012. Relation: EAC/2012/350. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012011146/104.
(120012337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Sirko Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 165.148.

EXTRAIT

Par contrat de transfert de parts sociales du 20 janvier 2012, International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., une

société anonyme établie sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg, Grand Duché de Luxembourg et enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B
46.448, a cédé les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales qu'elle détenait dans la Société à Trans-
com Worldwide S.A., une société anonyme établie sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 45 rue des
Scillas, L-2529 Howald, Grand Duché de Luxembourg et enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le
numéro B 59.528 ("Transcom Worldwide").

En  conséquence,  Transcom  Worldwide  détient,  à  ce  jour,  l'ensemble  des  un  million  deux  cent  cinquante  mille

(1.250.000) parts sociales de la Société, et est son associé unique.

29162

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2012.

<i>Pour Sirko Holding S.à r.l.

Référence de publication: 2012014972/21.
(120017845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

SistemApsys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 10.018.400,00.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 135.488.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 23 janvier 2012:
- que la démission de M. Maurice Bansay en tant que gérant A est acceptée avec effet immédiat;
- que la démission de M. Fabrice Bansay en tant que gérant A est acceptée avec effet immédiat;
- que la démission de M. Olivier Gérard-Coester en tant que gérant A est acceptée avec effet immédiat;
- que la démission de M. Ivo Hemelraad en tant que gérant A est acceptée avec effet immédiat;
- que M. Robin Naudin ten Cate, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est

nommé nouveau gérant A avec effet immédiat et ce pour une durée de deux ans;

- que M. Alan Botfield, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est nommé

nouveau gérant A avec effet immédiat et ce pour une durée de deux ans;

- que Mme Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est nommé

nouveau gérant A avec effet immédiat et ce pour une durée de deux ans;

- que Mme Monica Tiuba, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est nommé

nouveau gérant A avec effet immédiat et ce pour une durée de deux ans;

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014973/24.
(120017228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Sotime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3470 Dudelange, 2, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 126.892.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Dudelange en date du 19 janvier 2012

L’assemblée prend acte de la démission de:
- Madame Sylvie WEISSGERBER en tant qu’administrateur et administrateur-délégué;
- Monsieur Patrick DIETRICH en tant qu’administrateur.
L’assemblée décide de nommer:
- Madame Amandine KOCEVAR née le 14 juillet 1986 à Thionville (France), demeurant 3, Place Anatole France F-57180

Terville (France) comme administrateur.

- Monsieur Jérémy KOCEVAR né le 13 juillet 1983 à Thionville (France), demeurant 21, rue des Jardins F-57190

Florange (France) comme administrateur.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2013.
La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-

xembourg sous le numéro B33849 et ayant son siège social 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée
commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2013.

Dudelange, le 19 janvier 2012.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2012014975/22.
(120017272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

29163

L

U X E M B O U R G

Spanish Security Services I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 84.200,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 100.158.

Par résolutions prises en date du 29 novembre 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Gérard BECQUER, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll

L-1882 Luxembourg, de son mandat de Gérant, avec effet au 17 novembre 2011.

- nomination de Jessie Da Silva, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, au

mandat de Gérant, avec effet au 17 novembre 2011 et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014976/15.
(120017745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Soparfi Onil S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-3857 Schifflange, 34, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 109.100.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012015015/10.
(120017757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Soparfi Onil S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-3857 Schifflange, 34, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 109.100.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012015016/10.
(120017758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Monitor Capital Investors S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.691,38.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.764.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Emergent Properties Limited, a limited company, registered under the laws of Malta, with company registration number

C 50701, with registered office at Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta’ Xbiex Yacht Marina, Ta’ XbiexXBX 1027,
Malta,

hereby represented by Mr. Jérôme Bellini, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

established under private seal.

I. The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

II. The appearing party declares being the sole shareholder (the “ Sole Shareholder”) of Monitor Capital Investors S.à

r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 47, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 135.764, incorporated by a deed of the notary Henri HELLINCKX dated December 12, 2007, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 490 dated February 26, 2008 (the "Company").

29164

L

U X E M B O U R G

III. The Company's articles of incorporation (the “Articles”) have been amended on February 25, 2011 before the

notary Henri HELLINCKX by a deed published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1362 dated
June 22, 2011.

IV. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To convert, with effect as of 1 

st

 January 2011, the share capital of the Company from Euro (EUR) to Pound Sterling

(GBP) in accordance with a 0.83854 EUR/GBP exchange rate as of December 19, 2011 (Oanda average exchange rate).

2. To convert all accounts in the books of the Company from Euro (EUR) to Pound Sterling (GBP) with effect as of

January 1, 2011.

3. Subsequent amendment of article 6 of the Articles of the Company in order to reflect the conversion in Pound

Sterling (GBP);

4. Miscellaneous,
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to convert, with effect as of January 1, 2011, the share capital of the Company from

Euro (EUR) to Pound Sterling (GBP), so that the share capital of TWELVE THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY EURO
(EUR 12,750.-) divided into THIRTY (30,-) Shares, with a nominal value of FOUR HUNDRED TWENTY-FIVE EURO is
converted, in accordance with a 0.83854 EUR/GBP exchange rate with effect as of 1 

st

 January 2011, into TEN THOU-

SAND SIX HUNDRED NINETY-ONE POUND STERLING AND THIRTY-EIGHT PENCE STERLING (GBP 10,691.38),
divided into three hundred and ten (30) Shares, with a nominal value of GBP 356.3793.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to convert all accounts in the books of the Company from Euro (EUR) to Pound

Sterling (GBP) with effect as of January 1, 2011.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder RESOLVES to amend article 6 of the Articles of the Company

which shall forthwith read as follows:

“ Art. 6. The Capital is set at TEN THOUSAND SIX HUNDRED NINETY-ONE POUND STERLING AND THIRTY-

EIGHT PENCE STERLING (GBP 10,691.38) divided into THIRTY (30) shares quotas of GBP 356.3793 each.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company are

estimated at approximately one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

Whereof, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Emergent Properties Limited, une société à responsabilité limitée, établie et existante sous les lois de Malte, enregistrée

sous le numéro 50701, et ayant son siège social au Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta’ Xbiex Yacht Marina, Ta’
XbiexXBX 1027, Malta;

ici représenté par M. Jérôme Bellini, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d’enregistrement.
II. Le comparant déclare qu’il est l’associé unique (l’«Associé unique») de la société Monitor Capital Investors S.à r.l.,

une société à responsabilité, établie et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
47, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.764, constituée par acte du notaire Maître Henri HELLINCKX en

29165

L

U X E M B O U R G

date 12 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 490 du 26 février 2008 (la "So-
ciété").

III. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés en date du 25 février 2011 par devant le notaire Maître

Henri HELLINCKX par un acte publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1354 daté du 22 juin
2011.

IV. Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à

prendre sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion, avec effet au 1 

er

 janvier 2011, du capital social de la Société d’euros (EUR) en Livre Sterling (GBP) au

taux de change de 0.83854 EUR/GBP du 19 décembre 2011 (Oanda taux de change moyen).

2. Conversion de tous les comptes dans les livres de la Société d’euros (EUR) en Livre Sterling (GBP) avec effet au 1

er

 janvier 2011.

3. Modification de l’article 6 des Statuts.
4. Divers
L‘Associé Unique a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique DECIDE de convertir, avec effet au 1 

er

 janvier 2011, le capital social de la Société d’euros (EUR)

en Livres Sterling (GBP) de façon à ce que le capital social de DOUZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (EUR
12,750.-), divisé en TRENTE (30) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 425.- chacune, est converti, au taux
de change de 0.83854 EUR/GBP du 1 

er

 janvier 2011, en DIX MILLES SIX CENT QUATRE VINGT ONZE LIVRE STERL-

ING  ET  TRENTE  HUIT  PENCE  (10,691.38),  divisé  en  TRENTE  (30)  parts  d’une  valeur  nominale  de  GBP  356.3793
chacune.

<i>Deuxième résolution

L‘Associé Unique DECIDE de convertir tous les comptes dans les livres de la Société d’euros (EUR) en Livre Sterling

(GBP) avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’Associé Unique DECIDE de modifier l’article 6 des Statuts qui

aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-ONZE LIVRE STERLING

ET TRENTE-HUIT PENCE (GBP 10,691.38) représenté par TRENTE (30) parts sociales de GBP 356.3793 chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge sont estimés à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette (Grand Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Bellini, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18230. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012011147/118.
(120012211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

29166

L

U X E M B O U R G

Sounoune, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 57.762.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue en date du 27 janvier 2012

<i>à 14h00 heures au siège social de la société

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide d’accepter la démission de l’Alliance Révision Sarl en tant que commissaire avec effet

immédiat (…).

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer Certifica Luxembourg Sarl, avec siège social au 1, rue des Glacis, L-1628

Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B86770, à la fonction de commissaire avec effet immédiat, son
mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Pour extrait sincère et conforme
<i>L’Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012015017/20.
(120017918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Sounoune, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 57.762.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2012015018/10.
(120017925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

SSILuxCo II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 151.400.

<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique et par le conseil d’administration en date du 25 janvier 2012

1. Mme Maike KIESELBACH a démissionné de ses mandats d’administrateur de catégorie A et de présidente du conseil

d’administration.

2. Mme Myriam Odette DELTENRE, née à Arlon (Belgique), le 16 février 1963, demeurant professionnellement à

L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck, a été nommée administrateur de catégorie A jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2016.

3. Mme Myriam Odette DELTENRE, pré-nommée, a été nommée présidente du conseil d’administration jusqu’à l’issue

de l’assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SSILuxCo S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012015019/19.
(120017540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

29167

L

U X E M B O U R G

SSILuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 151.375.

<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 25 janvier 2012

1. Mme Maike KIESELBACH a démissionné de son mandat de gérantE de classe A.
2. Mme Myriam Odette DELTENRE, née à Arlon (Belgique), le 16 février 1963, demeurant professionnellement à

L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck, a été nommée gérante de classe A pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SSILuxCo S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012015020/15.
(120017529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Tahoe Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 166.331.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the sixteenth day of January.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

There appeared:

Tahoe Cayman Ltd., a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered

office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,
registration with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number 265063,

duly represented by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given on 9 January 2012 in San Francisco.

Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité

limitée, which they wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owner of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “Tahoe Manager S.à r.l.” (the
“Company”).

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2. The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

29168

L

U X E M B O U R G

3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 4. Registered office.
4.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg.
4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1.  The  Company's  share  capital  is  set  at  twelve  thousand  five  hundred  euro  (EUR  12,500)  consisting  of  twelve

thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

5.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder. In case of plurality

of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in
the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such preferential
subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a
registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting
of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential
subscription right of the existing shareholder. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment
of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1. The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

6.3. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company's share capital.

6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed

shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6. The Company's shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.
7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and Transfer of shares.
8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

29169

L

U X E M B O U R G

8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3. The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be trans-

ferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor,
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law,
the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or

in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the “sole shareholder”.

9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead

of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in

the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice
of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.

10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Quorum and vote
11.3.1. Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly

passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second

29170

L

U X E M B O U R G

time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.

11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them

to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board
of managers” used in these articles of association is to be construed as being a reference to the “sole manager”.

14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting

alone or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.
16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his own revocation.

16.3. Any manager shall hold office until his successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive

terms.

29171

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his absence, the

board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2. Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least a majority of its members (ii) including one class

A and one class B managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

18.3. Vote
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, including at

least one class A manager and one class B manager. The chairman shall not have a casting vote.

18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his colleagues.

18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7. Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of

the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his resolutions.
19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint

signatures of a class A manager and a class B manager or by the signature of the sole manager or by the joint signatures
or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers
or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the
power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and
the limits of such delegation.

29172

L

U X E M B O U R G

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.

21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7. If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law  of  19  December  2002  regarding  the  Trade  and  Companies  Register  and  the  accounting  and  annual  accounts  of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

Art. 23. Profits.
23.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal

reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

23.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends - Share premium.
24.1. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,

under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions have been satisfied.

24.2. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

29173

L

U X E M B O U R G

<i>Transitional provisions

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31

December 2012.

2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
1) Tahoe Cayman Ltd., aforementioned,
paid twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) in subscription for twelve thousand five hundred (12,500) shares.
Total: twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) paid for twelve thousand five hundred (12,500) shares.
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)

is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1600.

<i>General meeting of shareholders

The incorporating shareholders, representing the Company's entire share capital and considering themselves as duly

convened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. Having first verified that it was regularly
constituted, the general meeting of shareholders has passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of the board of managers is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company:
a) James Morril Ford with professional address 2711, Centerville road, suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United

States of America, as class A manager;

b) Anne Catherine Grave, with professional address 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg as class B manager; and

c) Véronique Nahoé, with professional address 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

as class B manager.

3. The term of the office of the members of the board of managers shall end on the date when the general meeting of

shareholders/sole shareholder shall resolve upon the approval of the Company's accounts of the financial year 2012 or
at any time prior to such date as the general meeting of shareholders/sole shareholder may determine.

4. The address of the Company's registered office is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with

the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes

Im Jahre zweitausendundzwölf, den sechzehnten Januar.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, Zivilrechtsnotarin mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum

Luxemburg.

Ist erschienen:

Tahoe Cayman Ltd, eine gemäß dem Recht der Cayman Islands gegründete und existente Gesellschaft mit eingetra-

genem Sitz in Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,
eingetragen im Handelsregister der Cayman Islands unter der Nummer 265063;

ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzog-

tum Luxemburg, kraft einer am 9. Januar 2012 in San Franzisco erteilten Vollmacht.

Nachdem die Vollmacht durch den Bevollmächtigten und die unterzeichnete Notarin ne varietur unterzeichnet worden

sind, sollen diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.

Solch erschienene Partei hat die Notarin ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée aufzu-

nehmen, welche sie gründen möchte und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:

29174

L

U X E M B O U R G

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die

künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma “Tahoe
Manager S.à r.l.” (die “Gesellschaft”).

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen

Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.
3.1. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus

Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

3.2. Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-

gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in

welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

3.3.  Die  Gesellschaft  kann  jedwede  Transaktionen  vornehmen,  welche  direkt  oder  indirekt  ihrem  Zweck  dienen.

Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-

papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes

beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.

Art. 4. Sitz.
4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg.
4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-

rerrats verlegt werden.

4.3. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxem-

burg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich
ist.

4.4.  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  im  Großherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland

durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Ge-

schäftsanteilen

Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus zwölftau-

sendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.

5.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesell-

schafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erfor-
derlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3. Alle neuen Geschäftsanteile, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden/dem bestehenden

Gesellschafter(n) zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden solche Geschäftsanteile den
Gesellschaftern im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Stammkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Geschäfts-
anteile angeboten. Der Geschäftsführerrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Anteilsbezugs-
recht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines
an die Gesellschafter/den Gesellschafter gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung an-

29175

L

U X E M B O U R G

kündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um
über eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft zu bestimmen, das bevorzugte Anteilsbezugsrecht der bestehen-
den Gesellschafter/des bestehenden Gesellschafters begrenzen oder aufheben. Ein solcher Beschluss muss in der Weise
gefasst werden wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig

(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

6.3. Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl

der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.

6.4. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betref-

fend den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.

6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-

gekauften  oder  zurückgenommenen  Geschäftsanteile  werden  sofort  gelöscht  und  das  Stammkapital  entsprechend
herabgesetzt.

6.6. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-

schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

7.2. Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung

mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1. Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-

schafterverzeichnis  erbracht  werden.  Auf  Ersuchen  und  auf  Kosten  eines  Gesellschafters  werden  Zertifikate  dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-

sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.

8.3. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter

Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4. Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des

Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber
der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Ge-
sellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das
Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.

8.5. Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen

und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1. Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe

der Gesellschaft bildet.

9.2. Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-

terversammlung  aus.  In  einem  solchen  Fall,  soweit  anwendbar  und  wo  der  Begriff  “alleiniger  Gesellschafter”  nicht

29176

L

U X E M B O U R G

ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
“Gesellschafterversammlung” als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter“ gelesen werden.

9.3. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich

verliehenen Befugnisse.

9.4. Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,

statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.

Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die

satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-

sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

10.3. Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit

der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

10.4. Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass

sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1. In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-

denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2. In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3. Quorum und Stimmabgabe
11.3.1. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2. Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-

schafterbeschlüsse  bei der ersten  Abstimmung wirksam  gefasst,  wenn sie von Gesellschaftern angenommen  werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

11.4. Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,

Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5. Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz,

Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesell-
schafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durch-
gehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und
Mehrheit anwesend ist.

11.6. Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-

formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag  drei  Kästchen  enthalten,  die  es  dem  Gesellschafter  ermöglichen,  seine  Stimme  zugunsten  oder  gegen  den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-
sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.

29177

L

U X E M B O U R G

11.7. Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden

müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag

durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.

Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern

sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

13.2. Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Be-

schlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

13.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen

oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein

müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff “alleiniger Geschäftsführer” nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den “Geschäftsführerrat”
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer” gelesen werden.

14.2. Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

14.3. Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts

können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.

14.4. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede

Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten

des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.

Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1. Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit

festlegt.

16.2. Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen

werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.

16.3. Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer

kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1. Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner

Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

17.2. Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung

anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann

29178

L

U X E M B O U R G

nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1. Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner

Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen

18.2. Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mit-

glieder an der Sitzung anwesend oder vertreten ist inklusive einem Kategorie A und einem Kategorie B Geschäftsführer.

18.3. Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder

vertretenen  Mitglieder  gefasst,  inklusive  wenigstens  einem  Kategorie  A  Geschäftsführer  und  einem  Kategorie  B  Ge-
schäftsführer. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

18.4. Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein

anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5. Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-

okonferenz  oder  durch  ein  anderes  Kommunikationsmittel  teilnimmt,  welches  es  ermöglicht,  dass  dieses  Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet,  dass  eine  durch  solche  Kommunikationsmittel  abgehaltene  Sitzung  am  eingetragenen  Sitz  der  Gesellschaft
abgehalten wurde.

18.6. Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in

einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

18.7. Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt

oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss
den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreff-
enden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage
stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat
und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt
ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Inte-
ressenskonflikt  im  Protokoll  über  die  betreffende  Transaktion  aufgenommen  werden.  Dieser  Artikel  18.7  ist  nicht
anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung

des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

19.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden

sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame

Unterschrift eines Kategorie A Geschäftsführers und eines Kategorie B Geschäftsführers oder durch die Unterschrift des
alleinigen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en)
gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer
übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des
Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in
Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.

E. Aufsicht

Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder

mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

29179

L

U X E M B O U R G

21.2. Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und

ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3. Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung

abberufen werden.

21.4. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Ge-

schäfte der Gesellschaft.

21.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten

der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

21.6. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher

aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.

21.7. Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am ein-

unddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Gewinne.
23.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme
der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2. Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage

zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

23.3. Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt

werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

23.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafter-

versammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.

Art. 24. Zwischendividenden - Emissionsagio.
24.1. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Vo-

raussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende
Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der
Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu
diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die
gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesell-
schaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen
erfüllt sind.

24.2. Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei
an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

H. Anwendbares recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-

burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

29180

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddrei-

ßigsten Dezember zweitausendundzwölf.

2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zeichnenden Gesellschafter haben die auszugebenden Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet:
1) Tahoe Cayman Ltd., vorbenannt,
zahlte zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gegen Zeichnung von zwölftausendfünfhundert (12,500) Geschäfts-

anteilen.

Gesamt: zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezahlt für zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile.
Alle Geschäftsanteile sind ganz in bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR

12.500) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf EUR 1600 geschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Die Gründungsgesellschafter, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren und die sich selbst als ord-

nungsgemäß geladen erachten, haben sofort eine Gesellschafterversammlung abgehalten. Nachdem die Gesellschafter-
versammlung zunächst überprüft hat, ordnungsgemäß konstituiert zu sein, hat sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1) Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf drei (3) festgesetzt.
2) Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft ernannt:
a) James Morril Ford, mit beruflicher Adresse 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Ver-

einigte Staaten von Amerika als Kategorie A Geschäftsführer;

b) Anne Catherine Grave, mit beruflicher Adresse 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg als Kategorie B Geschäfts-

führer; und

c) Véronique Nahoé, mit beruflicher Adresse 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg als Kategorie B Geschäftsführer.
3) Die Amtszeit der Mitglieder des Geschäftsführerrats soll zu dem Zeitpunkt enden, an dem die Gesellschafterver-

sammlung/der alleinige Gesellschafter, je nach Lage des Falles, über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2012 bestimmt, oder an jedem anderen, von der Gesellschafterversammlung/vom alleinigen
Gesellschafter, je nach Lage des Falles, festgesetzten Zeitpunkt vor diesem Datum.

4) Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 19, rue de Bitburg, L-1273 Luxemburg.
Die  unterzeichnete  Notarin,  die  Englisch  versteht  und  spricht,  erklärt  hiermit,  dass  die  Urkunde  auf  Anfrage  der

erschienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben er-
schienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische
Fassung vorrangig sein.

Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten

Tag aufgenommen.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat der Bevollmäch-

tigte diese originale Urkunde zusammen mit der Notarin unterzeichnet.

Signé: M. Prochaska et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 janvier 2012. LAC/2012/2852. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Référence de publication: 2012011344/749.
(120013172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

29181

L

U X E M B O U R G

Sterifant Finanz Holding A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 44.989.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 5 janvier 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a

déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société
STERIFANT FINANZ HOLDING A.G., avec siège social à L- 1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Pour extrait conforme
Max Mailliet
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2012015021/15.
(120017443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Strategic Ventures International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 44.132.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012015022/11.
(120017553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Locarlux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 95.423.

L'an deux mille onze, le trente décembre.
Par-devant, Nous, Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

"LOCARLUX SA", [matr.2000 22 09 927], ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen,

constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, alors de résidence à Differdange en date du 2 mai 1990, publié

au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 395 du 24 octobre 1990, modifiée et changée en
société anonyme suivant acte reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg en date du 23 mars
2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 575 du 11 août 2000 à la page 27554,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 95.423

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Max GALOWICH, juriste, né à Luxembourg le

30.7.1965, (matr: 1965 0730 138) demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt

L'assemblée renonce à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur .
Le bureau de l'assemblée générale extraordinaire étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter

ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:
1) - Présentation du projet de fusion daté du 18 novembre 2011, publié au Mémorial C en date du 29.11.2011 Numéro

2910, proposant l'absorption de la société anonyme "MILLENIUM FINANCING S.A." (no. R.C.S. B 75.346) par la société
anonyme "LOCARLUX SA", [matr.2000 22 09 927], ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen .

- Constatation de l'exécution des obligations résultant de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en ce

qui concerne la fusion de sociétés et des dispositions auxquelles elle se réfère.

3) Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par l'absorption de la société anonyme "MILLENIUM

FINANCING S.A." (n 

o

 R.C.S. B 75.346) par la société anonyme "LOCARLUX SA", [matr.2000 22 09 927], ayant son

siège social à L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen aux conditions prévues par le projet de fusion, soit avec création
de 8.160 actions nouvelles de Locarlux S.A. et transmis aux actionnaires de la société anonyme MILLENIUM FINANCING

29182

L

U X E M B O U R G

S.A. à raison de 8,16 actions de LOCARLUX S.A. pour 1 action de MILLENIUM FINANCING S.A. et émission d'une
prime de fusion de 3.586.762,01 €,

avec transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la société anonyme "MIL-

LENIUM FINANCING S.A." (no. RCS B 75.346) à la société absorbante "LOCARLUX SA", [matr.2000 22 09 927] et
dissolution sans liquidation de la société anonyme "MILLENIUM FINANCING S.A." (comme conséquence de la fusion).

4) Formalité de la radiation de la société absorbée au registre de commerce et des sociétés et détermination du lieu

de conservation des documents de la société anonyme “MILLENIUM FINANCING S.A.” pendant le délai légal.

5) Constatation de la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l'assemblée générale de la société anonyme

“MILLENIUM FINANCING SA” approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers.

6) Modification subséquente de l'article 3 premier alinéa des statuts.
7) Divers
II) Participation à l'Assemblée:
La liste de présence à l'assemblée mentionne les actionnaires de la Société et le nombre d'actions émises.
Une fois signée par les actionnaires et par les membres du bureau, la liste sera enregistrée avec le présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il résulte de la liste de présence que les trente-deux mille (32.000) actions émises par la Société sont présentes ou

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III) Constatation de la validité de l'assemblée générale extraordinaire
La liste de présence est reconnue exacte par l'assemblée générale extraordinaire, laquelle décide de renoncer aux

formalités  de  convocation,  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée  et  les  actionnaires  se  considérant  dûment
convoqués déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV) Ordre du jour:
Le Président présente à l'assemblée le projet de fusion daté du 18 novembre 2011, publié au Mémorial C en date du

29.11.2011 Numéro 2910, proposant l'absorption de la société anonyme "MILLENIUM FINANCING S.A." (n 

o

 R.C.S. B

75.346) par la société anonyme "LOCARLUX SA", [matr.2000 22 09 927]

Considérant la prise d'effet au point de vue comptable de la fusion au 30 septembre 2011, et les droits réservés aux

actionnaires par la loi, la tenue de la présente assemblée a été organisée aux fins de consacrer l'approbation de la dite
fusion par l'actionnaire unique de la société absorbée.

<i>Délibération

Ensuite les actionnaires, exerçant les prérogatives dévolues par la loi à l'assemblée générale extraordinaire prennent

les résolutions suivantes:

Ils reconnaissent formellement et expressément avoir pris connaissance au siège social de la société dont il est l'ac-

tionnaire, du projet de fusion, des comptes annuels, ainsi que des rapports de gestion et tous autres documents, tels que
déterminés à l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Ils renoncent formellement
et expressément au droit leur dévolu d'exercer ce droit d'information pendant la période d'un mois au moins précédant
la date de la présente assemblée.

Les actionnaires constatent l'exécution des obligations résultant de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

relatif aux fusions et confirment le respect de leur application.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident à l'unanimité d'approuver le projet de fusion précité et de réaliser la fusion par l'absorption

de la société anonyme "MILLENIUM FINANCING S.A." (n 

o

 R.C.S. B 75.346) par la société anonyme "LOCARLUX SA",

[matr.2000 22 09 927], ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen aux conditions prévues par le
projet de fusion, soit avec création de 8.160 actions nouvelles de Locarlux S.A. et transmis aux actionnaires de la société
anonyme MILLENIUM FINANCING S.A. à raison de 8,16 actions de LOCARLUX S.A. pour 1 action de MILLENIUM
FINANCING S.A.et émission d'une prime de fusion de 3.586.762,01 €,

par transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la société absorbée à la société

anonyme "LOCARLUX SA" et moyennant dissolution sans liquidation de la société absorbée comme conséquence légale
de la fusion avec effet au 30 septembre 2011.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires décident que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal

au siège de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour
requérir la radiation de l'inscription de la société, la dissolution sans liquidation étant définitivement réalisée à la date de
ce jour.

29183

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires constatent la réalisation de la fusion à la date de ce jour, avec effet comptable et fiscal à la date du 30

septembre 2011, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers.

<i>Immeuble

1) La maison d'habitation avec place sise à Strassen, 35, route d'Arlon, inscrite au cadastre de la commune et section

A de Strassen, sous le numéro 801/1733, au lieu dit “Huorgarten” comme maison, place, contenant 8 ares 06 centiares,
propriété de la société absorbée "MILLENIUM FINANCING S.A., devient donc par la présente absorption la propriété
de la société anonyme “LOCARLUX SA”.

<i>Titre de propriété

La société à responsabilité limitée Jacri S.A R.L. est devenue propriétaire de cet immeuble sous sa dénomination

originelle CRILUX SCI suivant un acte passé par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 9 novembre 2001, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg le 23 novembre 2001 Volume 1709 numéro
103.

Par acte du notaire instrumentaire en date du 18 novembre 2011, transcrit le 5.12 2011 au bureau des hypothèques

à Luxembourg 1, volume 2404, numéro 59, documentant la fusion par absorption entre la société à responsabilité JACRI
SARL et la société anonyme MILLENIUM FINANCING S.A. ledit immeuble est devenu la propriété de la société MILLE-
NIUM FINANCING S.A.

2) La maison d'habitation avec place sise à Strassen, route d'Arlon, inscrite au cadastre de la commune et section A

de Strassen, sous le numéro 801/1928, au lieu dit “route d'Arlon” comme maison, place, contenant 12 ares 53 centiares,
propriété de la société absorbée "MILLENIUM FINANCING S.A., devient donc par la présente absorption la propriété
de la société anonyme “LOCARLUX SA”.

<i>Titre de propriété

La société absorbée est devenue propriétaire de cet immeuble suivant acte de vente passé par-devant Maître Emile

Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20.12.2001, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg
I le 15.1.2002 volume 1717 numéro 86.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 alinéa premier des statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus.
Par conséquent, le premier paragraphe de l'article 3 des statuts est remplacé par le texte suivant:
“Le capital social est fixé à un million et quatre mille euros (1.004.000,- €) divisé en quarante mille cent soixante actions

(40.160) de vingt-cinq euros chacune, entièrement libérés.”

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10,15 heures.

<i>Déclaration des comparants

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par nom,

prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: Max GALOWICH, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 6 janvier 2012. Relation: DIE/2012/287. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Ries.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 24 janvier 2012.

Référence de publication: 2012012952/132.
(120015133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

29184


Document Outline

4 T Invest S.A.

5 T Invest S.A.

Gilles S.à r.l.

InControl S.A.

Jacmont S. à r.l.

Kauri Cab Arminius

Locarlux SA

LRP V Luxembourg Holdings S.à r.l.

LSH CO

LSH II CO

Man Investments (Luxembourg) S.A.

MG Concepts

M&amp;M Real Estate S.A.

Mondi Packaging

Mongoose Holdings 2

Monitor Capital Investors S.à.r.l.

Nacarat Design &amp; Créations

Paris Luxembourg Participations S.à r.l.

Reco-Med S.à r.l.

Reco-Med S.à r.l.

Relaxation 2000

Représentations S.A.

Rondinara S.A.

Rosetta I S.A.

Rothschild S.A.

RSHB Capital S.A.

Sequoia IDF Asset Holdings S.A.

Sirko Holding S.à r.l.

SistemApsys S.à r.l.

S.L.P.S. S.A.

Soparfi Onil S.A.

Soparfi Onil S.A.

Sotime S.A.

Sounoune

Sounoune

Spanish Security Services I S.à r.l.

SSILuxCo II S.A.

SSILuxCo S.à r.l.

Sterifant Finanz Holding A.G.

Strategic Ventures International S.A.

Tahoe Manager S.à r.l.

Unit Investments S.A., SPF

West End Investments S.à r.l.