This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 520
28 février 2012
SOMMAIRE
Agri-Top Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24950
Equinix (Luxembourg) Holdings S.à r.l. . .
24945
Fatilu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24923
FC Financing & Consulting S.A. . . . . . . . . .
24939
FuturInvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24923
Ganylux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24943
Garage Kieffer s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24944
G.F.E. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24941
Gilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24944
Global Line S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24941
Global Part S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24944
Global Refund Holdings Three S.à r.l. . . . .
24942
Global Refund Holdings Two S.à r.l. . . . . .
24943
Goodman Property Opportunities (Lux)
S.à r.l., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24943
Granada Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
24945
Graphik und Print-Gap A.G. . . . . . . . . . . . .
24950
Groupe Simtech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24950
Haas TCM of Luxembourg 1 S.àr.l. . . . . . .
24951
Haas TCM of Luxembourg 2 S.àr.l. . . . . . .
24951
Haas TCM of Luxembourg 3 S.àr.l. . . . . . .
24951
Haas TCM of Luxembourg 4 S.àr.l. . . . . . .
24952
Harte Luxembourg Holdings . . . . . . . . . . . .
24952
HCA Luxembourg 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24958
HCA Luxembourg 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24959
HCA Luxembourg Equities . . . . . . . . . . . . .
24943
HCA Luxembourg Investments S.à r.l. . . .
24953
Hedelfingen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24923
HeidelbergCement Holding S.à r.l. . . . . . .
24944
Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .
24952
Hippoline S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24959
Holcim (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . .
24942
Housetech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24959
Howick Card S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24953
Husum S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24958
Hydro Taillandier-Wester S.à r.l. . . . . . . . .
24959
IM International Models Holding S.A. . . . .
24945
Innova Financial Holding BF II S.à r.l. . . . .
24960
Institut de Formation Sectoriel du Bâti-
ment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24953
Interact S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24952
International Company of Services S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24960
John Deere Holding Brazil S.à r.l. . . . . . . . .
24942
John Deere Luxembourg Investment S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24927
L.S.A. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24959
Margyle Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
24952
Oceaneering Holdings Sarl . . . . . . . . . . . . . .
24951
ODE International Publishers Holding S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24939
Placer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24924
RAB UCITS Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24954
St Germain Immobilière S.A. . . . . . . . . . . .
24960
Suki Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24914
24913
L
U X E M B O U R G
Suki Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 166.176.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on the twenty-first day of November.
Before us Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-Sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la
poste R.C.S. Luxembourg B37974,
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/
Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.
The proxy after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to enact the deed of
incorporation of a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), which it declares
organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:
Chapter I. Corporation, Duration, Registered office, Object
Art. 1. Corporation. There is formed by the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares below,
a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining to such
an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as
amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the “Articles”).
Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or
abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or
indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the “Connected Companies”). It
may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets
The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual
property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments
in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing,
draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging
or otherwise encumbering movable or immovable property.
The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name "Suki Finance S.à r.l.”.
Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg City by simple decision
of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
24914
L
U X E M B O U R G
Chapter II. Capital, Shares
Art. 6. Issued capital. The capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12.500.- EUR) divided into
one hundred (100) shares of ONE HUNDRED AND TWENTY-FIVE EURO (125.- EUR) each.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Increase and Reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder
or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 13 of these Articles.
Art. 8. Shares. The capital of the Company is divided into shares, each of them having the same nominal value.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
Articles or by the Laws. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number
of shares held by such shareholder in the capital of the Company.
Each share entitles one (1) vote. The Company may be composed of one single shareholder (“associé”), owner of all
the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, unless authorized by the Laws.
The Company will recognize only one (1) holder per share. In case a share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.
The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer granted in a general meeting by the majority of shareholders,
including the transferor, representing in the aggregate at least three quarter (3/4) of the capital of the Company.
Unless otherwise provided by the Laws, the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders,
except with the approval of shareholders representing in the aggregate at least three quarter (3/4) of the voting rights of
the surviving shareholders.
The Company may acquire its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds
to that effect. The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting
of shareholders.
Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or
any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the
Company's dissolution.
Chapter III. Management
Art. 10. Managers. The Company is managed by one or more managers who need not to be partners.
The managers will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their
number, and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are reeligiblem but they may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the share-
holders' meeting.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several class A manager(s) and one or several
class B manager(s).
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of
votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint
signature of any two managers. However, if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed
one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s), the Company will be bound towards third parties
by the joint signature of one class A manager and one class B manager. The Company will further be bound towards third
parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the manager
(s) but only within the limits of such power.
The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or more ad hoc agents.
24915
L
U X E M B O U R G
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent's responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented
by proxies and provided that at least two managers are physically present. Any decisions by the board of managers shall
be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by the chairman and secretary of the meeting.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. The minutes of the meeting will be signed by
the chairman and secretary of the meeting.
The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 11. Conflicts of interest. If any of the managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such manager shall disclose such personal interest to the other manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case the Company has only one manager, transactions between the Company and the sole manager, who has such
an opposing interest, must be recorded in writing and the records be disclosed to the shareholders.
The foregoing paragraphs of this article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 12. Managers' liability - Indemnification. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of
his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Com-
pany.
Chapter IV. Shareholders
Art. 13. Powers of the shareholders. The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of sha-
reholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.
The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Laws and the Articles.
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of
the shareholders may be passed in writing, instead of holding a general meeting of shareholders. Written resolutions may
be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed
by one or several shareholders.
Should such written resolutions be sent by the manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are
under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed
resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for
the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by
the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders.
Art. 14. Annual general meeting. If the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the annual general
meeting of shareholders of the Company will be held within six (6) months from the end of the financial year.
Art. 15. Place of general meetings. General meetings of shareholders will be held in the municipality of the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
24916
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Notice of general meetings. The general meeting of shareholders may at any time be convened by the manager
(s), or by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than half (1/2) of the
issued capital of the Company.
The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date
and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior
to the date scheduled for the meeting. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate,
describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or
form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 17. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.
Art. 18. Proceeding. A board of the meeting (“bureau”) shall be formed at any general meeting of shareholders,
composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of
shareholders, and who need neither be shareholders, nor managers.
The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in
particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation
of shareholders.
An attendance list shall be kept at any general meeting of shareholders.
Art. 19. Vote. Resolutions of the general meeting of shareholders shall be adopted by shareholders representing more
than half (1/2) of the capital of the Company, except for general meeting convened for the purpose of amending these
Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment
to these Articles.
If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or
consulted) a second time by registered letter, and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares
represented, by a simple majority of votes cast.
Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 20. Financial year. The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of
December the same year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the
Company and shall terminate on the last day of December 2012.
Art. 21. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the manager
(s) draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval within six (6)
months from the end of the related financial year.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 22. Allocation of results. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of
general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the
Company's nominal share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/ their share holding in
the Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
24917
L
U X E M B O U R G
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remune-
ration.
Chapter VII. Matters not provided
Art. 24. Matters not provided. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on the last day of December 2012.
<i>Subscription – Paymenti>
The shares have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is the sole
shareholder of the company.
The shares have been fully paid up in cash, so that the sum of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12.500.-
EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-1653 Luxembourg, 2-8 avenue Charles de Gaulle.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-et-un novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20 rue de la Poste,
R.C.S. Luxembourg B37974, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec
adresse professionnelle à Esch/Alzette, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux
fins d'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter l'acte constitutif
d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme
suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Durée, Siège et Objet
Art. 1
er
. La société. Il est formé par les présentes et par tout ceux qui deviendront détenteurs de parts sociales une
société sous la forme d'une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
“La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après “La
Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”).
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est la prise de participations, d'intérêts et de parts sociales, tant au Luxembourg
qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obli-
gations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières
et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
La Société pourra également apporter toute assistance financière, sauf par le biais d'un appel public à l'épargne. Ce ne
sera possible que sous la forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles
24918
L
U X E M B O U R G
elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou
indirect de la Société, ou encore à toute société appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme
les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté,
que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs),
ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés
Apparentées
La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change,
taux d'intérêt et autres risques.
La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des in-
vestissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la
location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination sociale. La Société aura la dénomination "Suki Finance S.à r.l.”.
Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par simple décision du gérant, ou
en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 6. Capital émis. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR)
représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et Réduction du capital. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé
unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.
Art. 8. Parts sociales. Le capital de la Société est divisé en parts sociales, chacune ayant la même valeur nominale.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
Les droits de associés aux avoirs et bénéfices de la Société sont proportionnels au nombre de parts sociales détenues
par cet associé.
Chaque part sociale donne droit à une (1) voix. La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité
des parts sociales, ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, à moins que les Lois ne l'autorisent.
La Société ne reconnaît qu'un (1) propriétaire par action. Si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux. Entre vifs, les parts
sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation de la majorité des associés réunis en assemblée
générale, en ce compris le cédant, représentant au moins les trois quart (3/4) du capital de la Société.
Saufs dispositions contraires prévues dans les Lois, les parts sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à des
non-associés qu'avec l'autorisation de la majorité des associés représentant au moins les trois quart (3/4) des droits
appartenant aux survivants.
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables
ou des fonds suffisants. L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre
capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale et confor-
mément aux conditions qui seront décidées par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.
Art. 9. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un associé. La mort, l'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire affectant les associés ou, selon les cas, l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
24919
L
U X E M B O U R G
Chapitre III. Gérance
Art. 10. Gérant(s). La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui déterminera leur nombre ainsi
que la durée de leur mandat. Les gérants resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles,
mais sont révocables ad nutum, avec ou sans justification, par une résolution de l'assemblée unique ou de l'assemblée
générale des associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs gérant(s) de classe A
et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) ou le conseil de gérance a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la
Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe
de deux gérants.
Cependant, si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et
un ou plusieurs gérant(s) de classe B, la Société sera engagée envers les tiers par la signature conjointe d'un gérant de
classe A et d'un gérant de classe B. La société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par
la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir spécial de signature aura été délégué par les gérants, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu
parmi les membres présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou
représentés.
Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée
par procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient physiquement présents. Toute décision du conseil
de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par le président et le
secrétaire de la réunion.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Les résolutions
de la réunion seront signées par le président et le secrétaire de la réunion.
Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions
pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé
(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 11. Conflits d'intérêt. Si un ou plusieurs gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de
la Société, ce(s) gérants devra (devront) en aviser les autres gérants et il(s) ne pourra (pourront) ni prendre part aux
délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.
Dans l'hypothèse d'un gérant unique, des opérations intervenues entre la Société et son gérant unique ayant un intérêt
opposé à celui de la Société, doivent être consignées par écrit dans un procès-verbal qui sera communiqué à l'(aux) associé
(s).
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de
24920
L
U X E M B O U R G
la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement em-
pêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.
Art. 12. Responsabilité des gérants - Indemnisation. Les gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,
dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.
Le(s) gérants(s) est (sont) uniquement responsable(s) de l'accomplissement de ses(leurs) devoirs.
Chapitre IV. Des associés
Art. 13. Pouvoir des associés. Les associés exercent leurs droits collectifs en assemblée générale des associés, qui
constitue un organe de la Société.
L'assemblée générale des associés exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. Toute assemblée
générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
Si la Société compte plusieurs associés, mais pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent
être prises par écrit, à la place d'une assemblée générale des associés. Les résolutions écrites peuvent être constatées
dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés.
Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par le(s) gérant(s) aux associés pour approbation, les associés
sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte des résolutions proposées, d'ex-
primer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission
d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale
des associés s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites.
Art. 14. Assemblée générale annuelle des associés. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, l'assemblée
générale annuelle des associés aura lieu dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social.
Art. 15. Lieux des assemblées générales. Les assemblées générales des associés se tiendront dans la municipalité du
siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourront se tenir à l'étranger,
chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le(s) gérant(s), le requièrent.
Art. 16. Convocation aux assemblées générales. Les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, con-
formément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des gérants, ou subsidiairement, du
commissaire aux comptes (s'il en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant ensemble plus de la moitié
(1/2) du capital émis de la Société.
La convocation envoyée aux associés indiquera l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée
générale des associés, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale, et devra être envoyée à chaque associé au moins
huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également,
si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives
à l'objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été
dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 17. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute
assemblée générale des associés.
Un associé peut agir à une assemblée générale des associés en désignant par écrit, transmis par tout moyen de com-
munication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.
Art. 18. Procédure. Un bureau de l'assemblée générale sera constitué à l'occasion de chaque assemblée générale des
associés et sera composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun d'eux n'ayant pas besoin d'être gérant
ou associé eux-mêmes et étant nommés par l'assemblée générale des associés.
Le bureau s'assure en particulier que l'assemblée est tenue conformément aux règles en vigueur, et en particulier
conformément aux règles relatives à la convocation, aux exigences en matière de majorité, à la comptabilisation des votes
et à la représentation des associés.
Une liste de présence sera tenue pour toute assemblée générale des associés.
Art. 19. Vote. Les résolutions de l'assemblée générale des associés seront adoptées par les associés représentant plus
de la moitié (1/2) du capital de la Société, lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale
convoquée en vue de la modification des présents Statuts ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux
conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des présents Statuts.
Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau
convoqués (ou consultés) par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendam-
ment du nombre de parts sociales représentées.
24921
L
U X E M B O U R G
Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices
Art. 20. Exercice social. L'exercice social commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de
décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le dernier jour de
décembre 2012.
Art. 21. Approbation des comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le(s)
gérant(s) dresse(nt) l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément
aux Lois.
Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation dans les six (6) mois
suivant la fin de l'exercice social y relatif.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.
Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours
calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.
Art. 22. Distribution des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction
des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour
cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Chapitre VII. Dispositions générales
Art. 24. Dispositions générales. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts,
il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le dernier jour de décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est
l'associé unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (€
1.300,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.
2) L'adresse du siège social est fixée à L-1653 Luxembourg, 2-8 avenue Charles de Gaulle.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
24922
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/15664. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2012008553/498.
(120009325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2012.
FuturInvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 69.030.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2012.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2012010967/12.
(120012585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Fatilu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 127, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 143.021.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012010968/10.
(120013010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Hedelfingen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 124.850.
<i>Extrait des décisions prises par l’actionnaire unique de la Société en date du 16 janvier 2012i>
1. Mme. Lorna Mackie, avec adresse au 10, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg, a été nommé en qualité de gérant
avec effet au 16 janvier 2012 et pour une durée indéterminée.
2. Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Mr Godfrey Abel
- Monsieur Michael Chidiac
- Monsieur Richard James
- Madame Lorna Mackie
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012011018/20.
(120012449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
24923
L
U X E M B O U R G
Placer S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 500.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 104.713.
In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of December.
Before Us Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Placer S.A.”, a société anonyme, having its registered
office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
section B, under number 104 713, incorporated by a deed of Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich, dated
December 3, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 189 of March 3, 2005.
The meeting is chaired by Mr. Cédric Paulus, employee, with professional address at 44 rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, who is also acting as secretary of the meeting;
The chairman appointed as scrutineer Mrs. Stéphanie Guardini, employee, with professional address at 44, rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be
registered with these minutes.
II. That appears from the said attendance list, that all the five hundred (500) shares in circulation representing the
entire share capital of the Company, presently fixed at five hundred thousand euro (EUR 500,000.-), which shares are
fully paid up, are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Modification of article 13 of the Company's articles of association.
2. Modification of article 14 of the Company's articles of association.
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to amend article 13 of the Company's articles of association, which shall henceforth read as
follows:
“ Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.
All shares are entitled to the same share in the profit. However, regarding the period from January 1
st
, 2011 to
December 31
st
, 2020, in case of distribution of the net profit, the holder of the Shares issued by the Company with
number twenty-six (26) to five hundred (500) will have right, prior to any other dividend distribution, to an annual dividend
corresponding to ninety-two point five percent (92,5%) of the net turnover realized by the Company in relation with its
investments, as the case may be, calculated as follows:
“Any income derived from or in connection with the investments of the Company
Any expenses in direct relation with the investments, such as management fees, custodian fees, interest on the debt
financing these investments”
For the period from January 1
st
, 2011 to December 31
st
, 2020, any extra distribution of the balance of the net profit
by the Company will only benefit the holders of Shares with number one (1) to twenty-five (25), in proportion to his/
their shareholding in the Company, the holder of Shares with number twenty-six (26) to five hundred (500) shall not be
entitled to any other dividend than the dividends described in the second paragraph.
For the period from January 1
st
, 2011 to December 31
st
, 2020, should the Company decide not to distribute
dividends for a given year or to the extent the profits are not distributed to the holders of Shares with number twenty-
six (26) to five hundred (500) in accordance with the second paragraph, the corresponding retained earnings will be
carried forward to the next accounting years until their effective and full distribution to the latter and will be cumulated
with dividends to be distributed to the holders of Shares with number twenty-six (26) to five hundred (500) in accordance
with the second paragraph.
On the maturity date (i.e. December 31
st
, 2020), the General Meeting of shareholders will decide either to redeem
the Shares with number twenty-six (26) to five hundred (500) at nominal value (plus Dividends cumulated and not entirely
paid if any, that would be due to the holders of the latter based on the second paragraph) or to renew them for a new
period of ten years, in the manner such as prescribed in article 6 paragraph 6 hereof.
24924
L
U X E M B O U R G
To the extent the General Meeting of the shareholders would not have taken any decision regarding the redemption
or renewal of the preferred economic rights of the shares with number twenty-six (26) to five hundred (500) at maturity,
their preferred economic rights will be automatically extinct for the future profits of the Company Despite this extinction
of the preferred economic rights for the profits realized as from the year 2021, the Shares with number twenty-six (26)
to five hundred (500) will keep, in case of distribution of dividends, redemption or liquidation, their rights to the profits
realized during the year 2011 to 2020 by application of the second paragraph and that would not have been distributed.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.”
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 14 of the Company's articles of association, which shall henceforth read as
follows:
“ Art. 14. In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
The share capital and the share premium, if any, that would be repaid for the period from January 1
st
, 2011 to
December 31
st
, 2020 will be first repaid to the holder of Shares with number twenty-six (26) to five hundred (500) and
then, pari passu, to the holders of Shares one (1) to twenty-five (25).
For the period from January 1
st
, 2011 to December 31
st
, 2020, the liquidation bonus arising from the liquidation of
the assets after payment of all the Company's debts and undistributed profits to the holders of Shares with number
twenty-six (26) to five hundred (500) as described in the second paragraph of Article 13 will be distributed to the holder
(s) of Shares with number one (1) to twenty-five (25) in proportion to its/their shareholding in the Company.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholders' meeting are estimated at approximately one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt décembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Placer S.A.”, ayant son siège
social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 104.713, constituée suivant acte de Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence
à Remich, reçu en date du 3 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 189
du 3 mars 2005.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Cédric Paulus, employé, ayant adresse professionnelle au 44, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg, qui agira également en tant que secrétaire de l'assemblée; Le président désigne comme
scrutateur Stéphanie Guardini, employée, ayant adresse professionnelle au 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des cinq cents (500) actions, représentant l'intégralité du capital
social actuellement fixé à cinq cent mille euros (EUR 500,000.-) entièrement libéré, sont présentes ou représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à son ordre du jour.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
2. Modification de l'article13 des statuts de la Société.
24925
L
U X E M B O U R G
3. Modification de l'article 14 des statuts de la Société.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents
statuts.
Toutes les actions donnent droit à la même participation dans le bénéfice annuel net de la Société. Cependant, pour
la période du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2020, en cas de distribution du bénéfice annuel net, le détenteur des
Actions portant les numéros vingt-six (26) à cinq cents (500) auront droit, prioritairement à toute autre distribution de
bénéfice, au paiement d'un dividende annuel correspondant à quatre-vingt-douze virgule cinq pour cent (92,5%) du ren-
dement net des investissements de la Société, calculé comme suit:
«Tout revenu découlant de ou en relation avec les investissements de la société
Tout frais en rapport direct avec ces investissements, tels que les frais de gestion, les droits de garde, les intérêts de
la dette finançant les investissements»
Pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2020, toute distribution de dividende supplémentaire par la
société se fera uniquement au porteur d'Actions portant les numéros un (1) à vingt-cinq (25) en proportion avec sa
participation dans le capital de la société, le porteur d'Actions portant les numéros vingt-six (26) à cinq cents (500) n'aura
pas droit à une autre distribution de dividende en dehors du Dividende prévu à l'alinéa 2.
Pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2020, si la Société décide de ne pas distribuer de dividendes pour
une année donnée ou dans l'hypothèse où les bénéfices annuels nets n'auraient pas été entièrement distribués aux porteurs
d'Actions portant les numéros vingt-six (26) à cinq cents (500) conformément à l'alinéa 2, les bénéfices reportés corres-
pondants seront reportés aux années comptables ultérieures jusqu'à leur distribution effective et se cumuleront avec les
dividendes devant être distribués au profit des détenteurs d'Actions portant les numéros vingt-six (26) à cinq cents (500)
en application de l'alinéa 2.
Une fois la date de maturité atteinte (à savoir le 31 décembre 2020), l'assemblée générale se prononcera sur le sort
à réserver aux droits économiques privilégiés des actions numéro vingt-six (26) à cinq cents (500) et décidera soit de
procéder à leur rachat à valeur nominale (plus les dividendes accumulés et non entièrement payés le cas échéant qui leur
seraient encore dus sur base de l'alinéa 2), soit de les reconduire pour une nouvelle période de dix ans; cette décision
sera prise, selon les modalités précisées à l'article 6, alinéa 6 ci-après.
A défaut pour l'assemblée générale de prendre une décision concernant le rachat ou la reconduction des droits éco-
nomiques privilégiés des actions numéro vingt-six (26) à cinq cents (500) à compter de leur maturité, leurs droits
économiques privilégiés de ces dernières seront automatiquement éteints pour les profits futurs de la Société. Malgré
cette extinction des droits économiques privilégiés concernant les profits réalisés à partir de l'année 2021, les actions
portant les numéros vingt-six (26) à cinq cents (500) conserveront, en cas de distributions de dividendes, de rachat ou
de liquidation, leurs droits aux profits réalisés au cours des années 2011 à 2020 en exécution de l'article 13, alinéa 2 et
qui n'auraient pas été distribués.
Dans le cas d'actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de
ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi».
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 14. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Le capital social et le montant de la prime d'émission, si elle existe, qui seraient repayés pendant la période du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 seront en priorité payés au détenteur des Actions portant les numéros vingt-six (26)
à cinq cents (500) puis, pari passu, aux détenteurs d'Actions portant les numéros un (1) à vingt-cinq (25).
Pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2020, le boni de liquidation résultant de la dissolution de la
Société, après que celle-ci se soit acquittée de l'intégralité de ses dettes et des profits non distribués au détenteur d'actions
portant les numéros vingt-six (26) à cinq cents (500) par application de l'alinéa 2 de l'article 13, sera distribué aux seuls
détenteurs d'Actions portant les numéros un (1) à vingt-cinq (25), proportionnellement à leur participation dans le capital
de la Société.»
24926
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents euros (€ 1.400,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Paulus, Guardini, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18059. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Référence de publication: 2012009133/182.
(120010160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
John Deere Luxembourg Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.923.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of October.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary, residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
Deere & Company, a company governed by the laws of United States of America, with registered office at 1209,
Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, United States of America, registered with the Division of
Corporations of the State of Delaware under the number 0522909,
represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy, given in Mannheim on 7 October 2011; such proxy, signed by the proxy-
holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of
Incorporation”).
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of “John Deere Luxembourg Investment S.à r.l.”.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Manager(s).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager(s).
In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or
are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).
24927
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Object. The Company may undertake, in Luxembourg and abroad, financing operations by granting loans and
contributing equity to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans will
be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group
companies or bank loans.
Furthermore, the Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the deve-
lopment of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
develop these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its
purposes or which are liable to promote their development or extension.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set
by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to Article 28 of the Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twenty five thousand euros (EUR 25,000.-) divided
into twenty five thousand (25,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed
amongst them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the “Manager(s)”).
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
24928
L
U X E M B O U R G
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) and
class B Managers (the “Class B Managers”).
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary
or useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of Powers, Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or
proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of any Manager.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers and Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to
whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the “Secretary”).
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two (2) of its members so require.
The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'
written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers
may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers
holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means
of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be
signed by any Manager.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
24929
L
U X E M B O U R G
In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Managers' Liability, Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if
applicable, his successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him
in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been
a Manager, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In
the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settle-
ment as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including in particular
its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors who
need not be shareholders themselves.
The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number
of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may,
as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.
Chapter IV. Shareholders
Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the
Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting
of shareholders.
Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25)
shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 20. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in
a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
24930
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Attendance, Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.
Art. 22. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person
designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 23. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of
amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for
the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements
shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Art. 24. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. Financial Year, Financial Statements, Distribution of Profits
Art. 25. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of November and ends on the last day of
October of each year.
Art. 26. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 27. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 28. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half
(1/2) of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.
24931
L
U X E M B O U R G
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. Applicable Law
Art. 29. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, has been one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholder
Subscribed
capital
Number
of shares
Amount
paid-in
Deere & Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 25,000.-
25,000
EUR 25,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 25,000.-
25,000
EUR 25,000.-
The amount of twenty five thousand euros (EUR 25,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the
Company.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euros (1,700.-
EUR).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of October of 2011.
<i>Shareholders' Resolutionsi>
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to
appoint the following for an unlimited duration as Managers:
(i) Mr. Nils Jaeger, manager, born on 28 May 1969 in Mannheim, (Germany), with professional address at 43, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(ii) Mrs. Nathalie Prevost, manager, born on 27 July 1979 in Valenciennes (France), with professional address at 43,
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(iii) Mrs. Katrin Watkins, manager, born on 15 December 1972 in Frankfurt am Main (Germany), with professional
address at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present
deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette by the undersigned notary, on the day referred to at
the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend und elf, am dreizehnten Oktober.
Vor dem unterzeichnenden Notar Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Deere & Company, eine Gesellschaft amerikanischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 1209, Orange Street, Wilmington,
New Castle County, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister des Staates
Delaware unter der Nummer 0522909,
vertreten durch Frau Sofia Afonso-Da Chao Conde, Notar Schreiber, mit Wohnsitz in 5, Zénon Bernard Strasse,
L-4030 Esch-sur-Alzette, kraft der in Mannheim am Oktober 7. 2011 erteilten Vollmacht.
24932
L
U X E M B O U R G
Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet
wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde beigefügt.
Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:
Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet, die
den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die
„Satzung“) unterliegt.
Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren
Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.
Die Gesellschaft wird unter dem Namen „John Deere Luxembourg Investment S.à r.l.“ firmieren.
Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Stadt Luxemburg haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der
Stadt Luxemburg verlegt werden.
Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) ent-
weder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
Sollte(n) die (der) Geschäftsführer oder die Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse
politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale
Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz
beziehungsweise zwischen der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen
könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen
Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der
Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unter-
liegt. Die genannten vorübergehenden Maßnahmen sind von der Geschäftsführung zu beschließen und den hiervon
betroffenen Dritten mitzuteilen.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Die Gesellschaft kann sowohl in Luxemburg als auch im Ausland Finanzierungsgeschäfte
tätigen, indem sie Darlehen gewährt und Eigenkapitalanteile in Unternehmen einbringt, die demselben internationalen
Konzern angehören wie sie selbst. Diese Darlehen werden u.a., aber nicht ausschließlich durch Finanzmittel und -instru-
mente wie z.B. Darlehen von Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Banken refinanziert.
Zudem kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt das Halten von Beteiligungen an Unter-
nehmen jeglicher Art und Form sowie die Verwaltung, Leitung, Kontrolle und Entwicklung solcher Beteiligungen betreffen.
Die Gesellschaft kann ihre Finanzmittel vor allem für den Errichtung, die Verwaltung, Entwicklung und Veräußerung
eines Portfolios bestehend aus Wertpapieren und Patenten jeglicher Herkunft verwenden, sich an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle eines Unternehmens beteiligen, jegliche Art von Wertpapieren und Patenten durch Beteiligung,
Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption erwerben, diese durch den Verkauf, Transfer, Handel oder auf sonstige Art und
Weise realisieren, diese Werpapiere und Patente entwickeln und Unternehmen, an denen sie über Beteiligungen verfügt,
Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.
Generell kann die Gesellschaft alle finanziellen, kommerziellen, industriellen, persönlichen oder Immobiliengeschäfte
ausführen, Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihren
Zielen verknüpft sind oder zur Förderung der Entwicklung oder Ausweitung dienen.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit dem
nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 28 dieser Satzung.
Kapitel II. Kapital, Anteile
Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzig tausend
Euros (EUR 25,000,-), und ist in fünfundzwanzig tausend (25.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR
1,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und
Pflichten ausgestattet.
Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissions-
aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten, zur Auszahlung an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.
Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
24933
L
U X E M B O U R G
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer von Anteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Be-
vollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.
Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile
können nur dann an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.
Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.
Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser an-
genommen worden ist.
Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-
fenen Beschlüsse mit sich.
Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-
sellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit, der Konkurs
oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der
Gesellschaft zur Folge.
Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer
Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschaf-
ter sein müssen, geführt (die (der) „Geschäftsführer“).
Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat“)
gegründet.
Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats
festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch
einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.
Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)
„Geschäftsführer A“)) und als Geschäftsführer B (die (der) „Geschäftsführer B“)) zu qualifizieren.
Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.
Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,
um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-
prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).
Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle
Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit
bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.
Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift jedes Geschäftsführers gebunden.
Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A und als Geschäftsführer B qualifiziert haben
(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer
B gemeinsam unterzeichnen.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen
gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über
die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.
Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende
Regeln:
Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende“). Er kann auch einen
Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzung der
Geschäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer“).
Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-
rungsrates muss einberufen werden, wenn zwei (2) seiner Mitglieder dies verlangen.
24934
L
U X E M B O U R G
Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit
des Geschäftsführungsrates ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des
Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungs-
gemäß dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort
in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrich-
tigung erforderlich.
Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-
führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-
schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden. Jeder Geschäftsführer kann einen oder
mehrere Geschäftsführer vertreten.
Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit oder Vertretung von mindestens der
Hälfte (1/2) seiner amtierenden Mitglieder, wobei im Falle einer Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer
A oder als Geschäftsführer B außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend
oder vertreten sein muss.
Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrates gefasst.
Ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschaltung
oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellt, teilnehmen.
Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.
Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß
einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in
einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem oder
mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.
Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.
Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.
Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig
übermittelt werden, können von jedem Geschäftsführer unterzeichnet werden.
Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die
(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.
Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem
Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäfts-
führern anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.
Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-
schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.
Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Markt-
bedingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.
Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder
irgend einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder einem solchen
Unternehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmen sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit
einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte
tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu
handeln.
Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung
hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.
Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
24935
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-
lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.
Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-
schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft
der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich insbesondere der Bücher und Konten durch Wirtschafts-
prüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.
Die statutorischen oder unabhängigen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den) Gesellschafter
ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und
können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden außer in
Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der unabhängige Wirtschaftsprüfer nur aufgrund schwerwiegendem Grund
abberufen werden kann.
Kapitel IV. Gesellschafter
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz
zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.
Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.
Art. 19. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-
zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den
Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn
(15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie
der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Be-
stimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.
Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-
halten oder an jedem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg; sie können im Ausland abgehalten werden, wenn
Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Interesse des (der) Geschäftsführer(s) liegt, dies erforderlich
machen.
Art. 20. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die
Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-
schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.
Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über
die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.
Art. 21. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-
und Rederecht.
Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes
Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.
Art. 22. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu
von den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.
Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
24936
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafter-
versammlung anwesend sind, gewählt wird.
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen der Geschäftsführung der Gesellschafter-
versammlung.
Art. 23. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von
Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, werden
Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-
schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der
Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen wird, entsprechen die Mehrheitsverhältnisse den Mehrheit der Anzahl
der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Art. 24. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-
zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.
Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter
unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls
der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden
ist, unterzeichnet werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von Gewinnen
Art. 25. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten November und endet am einunddrei-
ßigsten Oktober eines jeden Jahres.
Art. 26. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die
Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr
als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.
Art. 27. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der
gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-
winn verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste
Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien
an die Aktionäre ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung
berechtigt.
Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-
henden Bestimmungen, können die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Aktionäre auszahlen. Die Geschäfts-
führer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 28. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst
werden, der durch die Hälfte (1/2) der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei viertel (3/4) des Gesellschaftska-
pitals repräsentieren.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-
liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.
Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-
quidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Aktionäre so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.
24937
L
U X E M B O U R G
Kapitel VII. Geltendes Recht
Art. 29. Geltendes Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen
sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt
geltenden Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Satzung der Gesellschaft wurde somit notariell beurkundet, die Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet und der
Nennwert dieser Anteile zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:
Gesellschafter
gezeichnetes
Kapital
Anzahl der
Anteile
eingezahlter
Betrag
Deere & Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR
25.000,-
25.000
EUR
25.000,-
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR
25.000,-
25.000
EUR
25.000,-
Die Summe von fünfundzwanzig tausend Euros (EUR 25.000,-) stand der Gesellschaft daher von dem Moment an zur
Verfügung.
<i>Kosteni>
Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr tausend sieben hundert Euro (EUR 1.700,-) geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Oktober
des Jahres 2011.
<i>Gesellschafterbeschlüssei>
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 43, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit
als Geschäftsführer ernannt:
(i) Herr Nils Jaeger, Manager, geboren am 28. Mai 1969 in Mannheim (Germany), mit beruflicher Anschrift in 43, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg;
(ii) Frau Nathalie Prevost, Manager, geboren am 27. Juli 1979 in Valenciennes (Frankreich), mit beruflicher Anschrift
in 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg;
(iii) Frau Katrin Watkins, Manager, geboren am 15. Dezember 1972 in Frankfurt am Main (Germany), mit beruflicher
Anschrift in 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten
Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.
Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangserwähnten, Datum von dem unterzeichnenden Notar in Esch-sur-Alzette
aufgenommen wurde.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-
nenen Partei vorgelesen worden ist, hat diese vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar
unterzeichnet.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 octobre 2011. Relation: EAC/2011/13989. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012004419/632.
(120003926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
24938
L
U X E M B O U R G
FC Financing & Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 72.241.
<i>Extrait procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 4 juin 2010i>
Il résulte de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au le 4 juin 2010 que:
Les mandats d'administrateur de M. Christophe Fender, M. Luc Sunnen et M. Paolo Dermitzel sont renouvelés jusqu'à
l'assemblée générale de l'année 2016. Le mandat de commissaire aux comptes de la société DMS & Associés S.à r.l. est
renouvelé jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/01/2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012010970/16.
(120013052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
ODE International Publishers Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 123.946.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of December.
Before Us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED
Maître Marie-Claude FRANK, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting in her capacity as attorney-in-fact of Ode International Publishers Holding B.V., a private company with limited
liability (‘besloten vennootschap') organised under the laws of the Netherlands, registered with the Register of the
Chamber of Commerce of Rotterdam under number 24252408, having its registered office at Willem Buytewechstraat
45, 3024 BK, Rotterdam, the Netherlands,
by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxy after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall be attached
to these minutes to be filed with the registration authorities.
The person appearing, acting in her said capacity, declared and requested the notary to state that:
1° Ode International Publishers Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée organised under Luxembourg laws,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 123 946, having its registered
office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (hereinafter referred to as the “Company”) was
incorporated by deed of Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg, on 29 December 2006, published in the
Mémorial C on 4 April 2007, number 532.
2° The corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) divided in five
hundred (500) parts having a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.
3° Ode International Publishers Holding B.V., prenamed, is the sole owner of all the parts of the Company.
4° Ode International Publishers Holding B.V., prenamed, resolves to approve the balance sheet, the profit and loss
account and the accompanying notes for the financial year starting 1
st
January 2011 and ending [22 December] 2011.
5° Ode International Publishers Holding B.V., prenamed, resolves to grant full discharge to the members of the board
of managers of the Company as regards the performance of their duties for and in connection with the financial year
starting 1
st
January 2011 and ending [22 December] 2011.
6° Ode International Publishers Holding B.V., prenamed, declares the anticipated dissolution of the Company with
immediate effect.
7° Ode International Publishers Holding B.V., prenamed, appoints itself as liquidator of the Company with full powers
to carry out its mandate, in particular all the powers provided for by articles 144 and following of the Luxembourg law
of the 10 August 1915 relating to commercial companies (as amended), without having to ask for participant consent in
the cases provided for by law. There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory and the liquidator
may, under its own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one (1) or several agents such
powers it determines and for the period it fixes.
24939
L
U X E M B O U R G
8° Ode International Publishers Holding B.V., prenamed, declares that all known liabilities of the Company towards
third parties, including all liquidation costs, have been entirely paid or are duly accounted for and that it irrevocably
undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the Company.
9° Ode International Publishers Holding B.V., prenamed, subsequently declares that it takes over all the assets and
outstanding liabilities of the Company, together with the profit and loss account of the Company, so that all assets and
liabilities of the Company be transferred to Ode International Publishers Holding B.V., prenamed, with immediate effect.
10° Ode International Publishers Holding B.V., prenamed, further declares, in its capacity as sole participant of the
Company having full knowledge of the Company's articles of association and of the financial situation of the Company,
to waive its right to appoint an auditor to the liquidation in charge of reporting on the liquidation operations carried out
by the Company's liquidator.
11° Ode International Publishers Holding B.V., prenamed, therefore resolves to immediately approve the liquidation
report and accounts.
12° Ode International Publishers Holding B.V., prenamed, resolves that the liquidation of the Company is thereby
closed and that any registers of the Company recording the issuance of parts or any other securities shall be cancelled.
13° The books and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years in Luxembourg at 65, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, given name, civil status and
residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.
Follows the french version:
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg), sous-
signé.
A COMPARU:
Maître Marie-Claude FRANK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire de la société Ode International Publishers Holding B.V., une société à responsabilité
limitée (‘besloten vennootschap') organisée selon le droit néerlandais, immatriculée auprès du Registre de la Chambre
de Commerce de Rotterdam sous le numéro 24252408, ayant son siège social à Willem Buytewechtstraat 45, 3024 BK,
Rotterdam, Pays-Bas,
en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
La personne comparante, agissant en sa qualité susmentionnée, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce
qui suit:
1° Ode International Publishers Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon le droit luxem-
bourgeois, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123 946,
ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (ci-après dénommée la «So-
ciété»), a été constituée selon acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire résidant à Luxembourg, en date du 29
décembre 2006, publié au Mémorial C en date du 4 avril 2007, numéro 532.
2° Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)
parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
3° Ode International Publishers Holding B.V., pré-désignée, est seule propriétaire de toutes les parts sociales de la
Société.
4° Ode International Publishers Holding B.V., pré-désignée, décide d'approuver les comptes avec annexe pour l'exer-
cice social du 1
er
janvier 2011 au [22 décembre] 2011,
5° Ode International Publishers Holding B.V., pré-désignée, décide de donner décharge aux membres du conseil de
gérance de la Société par rapport à l'exercice de leurs fonctions pour et relatif à l'exercice social du 1
er
janvier 2011 au
[22 décembre] 2011.
6° Ode International Publishers Holding B.V., pré-désignée, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet
immédiat.
7° Ode International Publishers Holding B.V., pré-désignée, se nomme liquidateur de la Société avec pleins pouvoirs
pour l'exécution de son mandat, en particulier ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août
24940
L
U X E M B O U R G
1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale dans les cas
prévus par la loi. Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut, sous sa responsabilité, pour des transactions
spéciales et déterminées, déléguer à un (1) ou plusieurs mandataires tels pouvoirs qu'il déterminera et pour la période
qu'il fixera.
8° Ode International Publishers Holding B.V., pré-désignée, déclare que toutes les dettes connues de la Société envers
des tiers, y compris tous les frais de liquidation, ont été entièrement réglées ou provisionnées et s'engage irrévocablement
à régler toute dette actuellement non connue et impayée de la Société.
9° Ode International Publishers Holding B.V., pré-désignée, déclare par conséquent qu'elle reprend la totalité des actifs
et des passifs de la Société, ensemble avec le compte des profits et pertes de la Société, de sorte que tous les actifs et
passifs de la Société sont transférés à Ode International Publishers Holding B.V., pré-désignée, avec effet immédiat.
10° Ode International Publishers Holding B.V., pré-désignée, déclare par la suite, en sa qualité d'associé unique de la
Société ayant pleine connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société, renoncer à son droit
de nommer un commissaire à la liquidation en charge de faire un rapport sur les opérations de la liquidation exécutées
par le liquidateur de la Société.
11° Ode International Publishers Holding B.V., pré-désignée, décide par conséquent d'approuver immédiatement le
rapport et les comptes de liquidation établis par le liquidateur.
12° Ode International Publishers Holding B.V., pré-désignée, décide ensuite de clôturer la liquidation de la Société et
de procéder à l'annulation de tous les registres actant l'émission des parts sociales ou de toute autre valeur mobilière.
13° Les registres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans au 65, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la
présente qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française;
à la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise
fera foi.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile,
ladite personne comparante à signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Frank, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18083. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012009103/129.
(120010105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
G.F.E. Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 63.846.
Les administrateurs, Nathalie PRIEUR, Jeannot DIDERRICH et Brunello DONATI, ainsi que le commissaire aux comp-
tes BENOY KARTHEISER MANAGEMENT Sàrl démissionnent avec effet immédiat.
Luxembourg, le 18 janvier 2012.
Benoy Kartheiser Management Sàrl
Référence de publication: 2012010981/10.
(120012867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Global Line S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 13, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 92.319.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012010985/10.
(120013008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
24941
L
U X E M B O U R G
Global Refund Holdings Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 89.248.
<i>Extrait de la réunion du 18 janvier 2012 tenue par les gérantsi>
La dénomination de Global Refund Korea Limited, gérant, 1402 Sogong-dong, Seoul Center Building, 91-1, Seoul (Jung-
gu), république de Corée, inscrite sous le numéro 170401 au registre Anyang recording office of Anyang Branch of Suwon
District est devenue Global Blue Korea Co. Ltd
La dénomination de Global Refund Argentina S.A, gérant, 15, Florida, Piso Cuarto, Capital Federal, Buenos Aires
(Argentine), inscrite sous le numéro 30-69897975-1 au Ministerio de Justicia est devenue Global Blue Argentina S.A.
Certifié sincère et conforme
GLOBAL REFUND HOLDINGS THREE S.À R.L.
Référence de publication: 2012010987/15.
(120012855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
John Deere Holding Brazil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 35.003,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.743.
EXTRAIT
Il résulte d’une convention sous seing privée signée le 30 novembre 2011, que 7,000 parts sociales de la société John
Deere Holding Brazil S.à r.l., ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B164743, ont été transférées à la société John
Deere Canada ULC, ayant son siège social au 295 Hunter Road, Grimsby, Ontario, L3M 4H5, Canada, enregistrée au
registre des sociétés d’Alberta sous le numéro 2016385813.
Suite à ce transfert, le capital social de la société John Deere Holding Brazil S.à r.l. est détenu comme suit:
28,003 parts sociales détenues par John Deere Canada Investment LP,
7,000 parts sociales détenues par John Deere Canada ULC.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Référence de publication: 2012011074/19.
(120012516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Holcim (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 21, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 140.604.
EXTRAIT
En date du 6 décembre 2010, l’assemblée générale ordinaire de la société a pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée accepte la démission de Mr Dominique Pron de ses fonctions d’administrateur en date du 16 novembre.
2. L’assemblée décide de nommer, jusqu’à l’assemblée générale de 2014, avec effet immédiat, la personne suivante aux
fonctions d’administrateur de la Société:
- Robert Paul Huet, né à Barcelone (Espagne) le 30 janvier 1967, résidant à 40, Amherst road, 02748 Belmont (Etats-
Unis).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012011023/16.
(120012795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
24942
L
U X E M B O U R G
Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Capital social: EUR 15.000.000,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 117.047.
Le bilan au 30 juin 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/01/2012.
Mailys Egan
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012010990/13.
(120012903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
HCA Luxembourg Equities, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 146.992.
EXTRAIT
Les associés de la Société ont décidé d'accepter, en date du 19 janvier 2012 et avec effet immédiat, la démission de
Mr Ronald Lee Grubbs Jr. en tant qu'administrateur de la Société.
Les associés de la Société ont également décidé de nommer, en date du 19 janvier 2012 et avec effet immédiat, Mr
Donald Wayne Stinnett, né le 12 mars 1956 à Louisville, Kentucky, USA et demeurant professionnellement au 2025
Waterstone Drive, Franklin, TN 37069, USA, en tant qu'administrateur de la Société, pour une durée illimitée, en rem-
placement de Mr Ronald Lee Grubbs Jr.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HCA Luxembourg Equitiesi>
Référence de publication: 2012011028/17.
(120013020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Global Refund Holdings Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 89.247.
<i>Extrait de la réunion du 18 janvier 2012 tenue par les gérantsi>
La dénomination de Global Refund Korea Limited, gérant, 1402 Sogong-dong, Seoul Center Building, 91-1, Seoul (Jung-
gu), république de Corée, inscrite sous le numéro 170401 au registre Anyang recording office of Anyang Branch of Suwon
District est devenue Global Blue Korea Co. Ltd
La dénomination de Global Refund Argentina S.A, gérant, 15, Florida, Piso Cuarto, Capital Federal, Buenos Aires
(Argentine), inscrite sous le numéro 30-69897975-1 au Ministerio de Justicia est devenue Global Blue Argentina S.A.
Certifié sincère et conforme
GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO S.À R.L.
Référence de publication: 2012010988/15.
(120012853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Ganylux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 12-14, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 122.183.
Les comptes annuels au 31 mai 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
24943
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012010991/10.
(120012732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Garage Kieffer s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8422 Steinfort, 110, rue de Hobscheid.
R.C.S. Luxembourg B 112.520.
<i>Décision de l'associé unique Jamaca Sàrl prise le 01/01/2012i>
Il résulte de la décision de l'associé unique Jamaca S.à r.l. prise le 01/01/2012 que:
Madame Carole Van Hoven, née le 16/01/1980 à Luxembourg, demeurant au 45A, route de Luxembourg L-4440
Steinfort est nommée gérante de la société Garage Kieffer S.àr.l. avec effet au 01/01/2012
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18/01/2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012010992/15.
(120012306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
HeidelbergCement Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 131.709.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2012.
HeidelbergCement Holding S.à r.l.
Patrick van Denzen
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012011020/14.
(120013192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Gilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 95, Hauptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 91.771.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Heinerscheid, le 20 janvier 2012.
Référence de publication: 2012011003/10.
(120013033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Global Part S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 95.675.
<i>Extrait des résolutions prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 10 janvier 2012i>
- Il est pris acte de la démission de Monsieur Harald CHARBON de son mandat d'Administrateur avec effet à ce jour.
- Monsieur Joseph HOFFMANN, né le 22 octobre 1960, demeurant à Stampfenbachstrasse 119, CH-8006 Zurich, est
coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Harald CHARBON, démissionnaire, avec effet à ce jour,
et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2015.
24944
L
U X E M B O U R G
Fait à Luxembourg, le 10 janvier 2012.
Certifié sincère et conforme
GLOBAL PART S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012011004/18.
(120013116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Granada Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 102.952.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012011006/12.
(120012543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
IM International Models Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 69.953.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2011i>
1. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
2. L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
au moins à l'adresse: L - 1413 Luxembourg, 3, Place Dargent (auprès de la société "C.T.P.").
Roger CAURLA
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2012011053/14.
(120013056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Equinix (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 22.846.660,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.463.
In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of December.
Before Maître Francis Kesseler, notary public established in Eschsur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Equinix, Inc., a company incorporated under the laws of the state of Delaware (United States of America), having its
principal place of business at One Lagoon Drive, 4
th
Floor, Redwood City, California 94065, United States of America
(the “Sole Shareholder”),
hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, rue
Zénon Bernard, L4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under
private seal.
Such power of attorney having been signed “ne varietur” by the power of attorney holder acting on behalf of the
appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the
registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of “Equinix (Luxembourg) Holdings S.à r.l.”, a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 43, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Henri Beck, notary, on 9
24945
L
U X E M B O U R G
December 2010, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (“Memorial C”) number 268 dated
9 February 2011, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.463 (the
“Company”).
The articles of association of the Company have been lastly amended by a deed enacted by Maître Francis Kesseler,
prenamed, on 22 July 2011, published in the Mémorial C, dated 5 October 2011 number 2383.
II.- That the 14,804,090 (fourteen million eight hundred four thousand ninety) shares with a nominal value of USD 1
(one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting
can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed
beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 8,042,570 (eight million forty-two thousand five
hundred seventy United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 14,804,090 (fourteen million
eight hundred four thousand ninety United States Dollars) to USD 22,846,660 (twenty-two million eight hundred forty-
six thousand six hundred sixty United States Dollars) by the issuance of 8,042,570 (eight million forty-two thousand five
hundred seventy) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of
a global share premium amounting to USD 72,382,965.81 (seventy-two million three hundred eighty-two thousand nine
hundred sixty five United States Dollars and eighty-one Cents) out of which USD 804,257 (eight hundred and four
thousand two hundred fifty-seven United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid
up through a contribution in kind;
3. Subscription and payment by Equinix, Inc. of the new shares by way of contributions in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company in order to
reflect such actions; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being
sufficiently informed of the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the
Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 8,042,570 (eight million forty-two
thousand five hundred seventy United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 14,804,090
(fourteen million eight hundred four thousand ninety United States Dollars) to USD 22,846,660 (twenty-two million eight
hundred forty-six thousand six hundred sixty United States Dollars) by the issuance of 8,042,570 (eight million fortytwo
thousand five hundred seventy) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the “New
Shares”), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 72,382,965.81 (seventy-two million three
hundred eighty-two thousand nine hundred sixty-five United States Dollars and eighty-one Cents) payable on the share
premium account of the Company (the “Share Premium”), out of which USD 804,257 (eight hundred and four thousand
two hundred fiftyseven United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through
a contribution in kind consisting of receivables held by the Sole Shareholder in an aggregate amount of USD 80,425,535.81
((eighty million four hundred twenty-five thousand five hundred thirty-five United States Dollars and eighty one Cents)
(the “Contribution”).
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription, the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the payment of
the Share Premium through the Contribution.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by
virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe for the New Shares. The issue of the New Shares is
also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid
up by the Sole Shareholder through the Contribution, which Contribution is at the disposal of the Company.
24946
L
U X E M B O U R G
<i>Valuationi>
The net value of the Contribution amounts to USD 80,425,535.81 (eighty million four hundred twenty-five thousand
five hundred thirty-five United States Dollars and eighty one Cents) which is the USD equivalent of EUR 60,909,978.65
(sixty million nine hundred and nine thousand nine hundred seventy-eight Euros and sixty-five Cents) pursuant to a blended
USD/EUR exchange rate of 1.3204 as at 13 December 2011.
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value,
which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the Contribution’s existencei>
A proof of the Contribution has been given to the Company.
<i>Managers’ interventioni>
Thereupon intervene:
a) Ms. Cathryn Arnell, category A manager, with professional address at One Lagoon Drive, 4th Floor, Redwood City,
California 94065, United States of America;
b) Ms. Brandi Galvin Morandi, category A manager, with professional address at One Lagoon Drive, 4th Floor, Redwood
City, California 94065, United States of America;
c) Ms. Kathryn Herrick, category A manager, with professional address at 51-53 Great Marlborough Street, London
W1F 7JT, United Kingdom;
d) Mr. Luc Sunnen, category B manager, with professional address at 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand
Duchy of Luxembourg; and
e) Mr. Christophe Fender, category B manager, with professional address at 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald,
Grand Duchy of Luxembourg;
all represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement
of contribution value.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed
of:
- Equinix, Inc.: 22,846,660 (twenty-two million eight hundred forty-six thousand six hundred sixty) shares.
The notary acts that the 22,846,660 (twenty-two million eight hundred forty-six thousand six hundred sixty) shares
representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the
resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it
is unanimously resolved to amend the first paragraph of article 6 of the Company’s articles of association so as to read
as follows:
“ Art. 6. Subscribed Capital. The share capital of the Company is set at USD 22,846,660 (twenty-two million eight
hundred forty-six thousand six hundred sixty United States Dollars), represented by 22,846,660 (twenty-two million eight
hundred forty-six thousand six hundred sixty) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”
No other amendment is to be made to this article.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand euro (€ 7,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
24947
L
U X E M B O U R G
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le seizième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire public établi à, Eschsur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.
A comparu:
Equinix, Inc., une société constituée selon les lois de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique), ayant son principal
lieu d’établissement sis à One Lagoon Drive, 4
th
Floor, Redwood City, Californie 94065, Etats-Unis d’Amérique (l’«As-
socié Unique»),
ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, avec adresse professionnelle sise au 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et du
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci auprès des autorités de l’enregistre-
ment.
La partie, représentée tel que mentionné ci-dessus, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l’associé unique de «Equinix (Luxembourg) Holdings S.à r.l.», une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand
Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié dressé en date 9 décembre 2010 par Maître Henri Beck, notaire, le
9 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C»), numéro 268 du 9 février
2011, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 157.463 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître Francis Kesseler,
soussigné, le 22 juillet 2011, publié au Mémorial C, en date du 5 octobre 2011 numéro 2383.
II.- Que les 14.804.090 (quatorze millions huit cent quatre mille quatre-vingt-dix) parts sociales avec une valeur no-
minale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant l’entièreté du capital social de la Société, sont représentées
de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l’ordre du jour dont l’Associé
Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 8.042.570 USD (huit millions quarante-deux mille cinq
cent soixante-dix Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 14.804.090 USD (quatorze millions huit
cent quatre mille quatre-vingt-dix Dollars Américains) à 22.846.660 USD (vingt-deux millions huit cent quarante-six mille
six cent soixante Dollars Américains) par l’émission de 8.042.570 (huit millions quarante-deux mille cinq cent soixante-
dix) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, moyennant le paiement
d’une prime d’émission totale d’un montant de 72.382.965,81 USD (soixante-douze millions trois cent quatrevingt-deux
mille neuf cent soixante-cinq Dollars Américains et quatre-vingt-un cents), dont un montant de 804.257 USD (huit cent
quatre mille deux cent cinquante-sept Dollars Américains) sera alloué à la réserve légale de la Société, le tout devant être
entièrement libéré par voie d’apport en nature;
3. Souscription et libération par Equinix, Inc. des nouvelles parts sociales par voie d’apport en nature;
4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article six des statuts de la société afin de refléter de telles
parts sociales; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par les associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît
avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte
de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que l’ensemble de la docu-
mentation produite lors de l’assemblée a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin
de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société, d’un montant de 8.042.570 USD (huit millions quarante-deux
mille cinq cent soixante-dix Dollars Américains) afin de porter son montant actuel de 14.804.090 USD (quatorze millions
huit cent quatre mille quatre-vingt-dix Dollars Américains) à 22.846.660 USD (vingt-deux millions huit cent quarante-six
mille six cent soixante Dollars Américains) par l’émission de 8.042.570 (huit millions quarante-deux mille cinq cent
soixante-dix) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les «Nouvelles
Parts Sociales»), moyennant le paiement d’une prime d’émission totale d’un montant de 72.382.965,81 USD (soixante
24948
L
U X E M B O U R G
douze millions trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante-cinq Dollars Américains et quatre-vingt-un cents) (la
«Prime d’émission») dont un montant de 804.257 USD (huit cent quatre mille deux cent cinquante-sept Dollars Améri-
cains) sera alloué à la réserve légale de la Société, le tout devant être entièrement libéré par voie d’apport en nature
consistant en des créances détenues par l’Associé Unique, pour un montant total de 80.425.535,81 USD (quatre-vingt
millions quatre cent vingt-cinq mille cinq cent trente-cinq Dollars Américains et quatre-vingt-un cents) (l’«Apport»).
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d’accepter la souscription et la libération par les Apporteurs des Nouvelles Parts Sociales et le paiement
de la Prime d’Emission par voie de l’Apport.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l’Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire les Nouvelles Parts. L’émission des Nouvelles Parts est éga-
lement sujette au paiement de la Prime d’Emission. Les Nouvelles Parts ainsi que la Prime d’Emission ont été entièrement
libérées par l’Associé Unique par voie d’apport en nature tel que décrit ci-dessous, lequel Apport est à la disposition de
la Société.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de l’Apport est de 80.425.535,81 USD (quatre-vingt millions quatre cent vingt-cinq mille cinq cent
trente-cinq Dollars Américains et quatre-vingt-un cents) qui est l’équivalent en Dollars Américains de 60.909.978,65 EUR
(soixante millions neuf cent neuf mille neuf cent soixante-dix-huit Euros et soixante-cinq centimes) suivant le taux
d’échange pondéré USD/EUR de 1,3204 du 13 décembre 2011.
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de valeur de l’apport
qui devra rester annexée à cet acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
<i>Preuve de l’existence des Apportsi>
Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée à la Société.
<i>Intervention des gérantsi>
Ici interviennent:
a) Mme Cathryn Arnell, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle à One Lagoon Drive, 4
th
Floor, Redwood
City, Californie 94065, Etats-Unis d’Amérique;
b) Mme Brandi Galvin Morandi, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle à One Lagoon Drive, 4
th
Floor,
Redwood City, Californie 94065, Etats-Unis d’Amérique;
c) Mme Kathryn Herrick, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle à 51-53 Great Marlborough Street,
Londres W1F 7JT, Royaume-Uni;
d) M. Luc Sunnen, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle à 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand
Duché de Luxembourg; et
e) M. Christophe Fender, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle à 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald,
Grand Duché de Luxembourg;
tous ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration
de valeur d’apport;
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, engagés juridiquement en tant
que gérants de la Société en raison de l’Apport, consentent expressément la description de cet Apport, avec son éva-
luation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l’actionnariat de la Société est désormais composé de:
- Equinix (Luxembourg) Holdings S.à r.l.: 22.846.660 (vingt-deux millions huit cent quarante-six mille six cent soixante)
parts sociales.
Le notaire témoigne que les 22.846.660 (vingt-deux millions huit cent quarante-six mille six cent soixante) parts sociales
représentant le capital social total de la Société, sont représentés de telle sorte que l’assemblée peut valablement décider
de la résolution à prendre ci-dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l’Apport décrit ci-dessus étant totalement réalisé, il
est décidé de modifier le premier paragraphe de l’article six des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6 Capital souscrit. Le capital social de la Société est fixé à 22.846.660 USD (vingt-deux millions huit cent quarante-
six mille six cent soixante Dollars Américains), représenté par 22.846.660 (vingt-deux millions huit cent quarante-six mille
six cent soixante) parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.»
24949
L
U X E M B O U R G
Aucune autre modification ne sera faite à cet article.
<i>Estimation des fraisi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à sept mille euros (€ 7.000,).
Aucun autre point n’ayant été soulevé, l’assemblée a été ajournée.
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour qu’en tête.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la personne présente à l’assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17881. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012009522/253.
(120010378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.
Graphik und Print-Gap A.G., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 84.848.
A décidé de dénoncer le siège avec effet au 18 janvier 2012 de la société
GRAPHIK UND PRINT-GAP A.G.
Société Anonyme
2, avenue Charles de Gaulle
L - 1653 Luxembourg
Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84 848
Luxembourg, le 18 janvier 2012.
CF Corporate Services (issue de la scission de BDO Tax & Accounting)
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2012011008/15.
(120012785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Groupe Simtech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.
R.C.S. Luxembourg B 113.196.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012011010/9.
(120012718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Agri-Top Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 63.113.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 04 janvier 2012i>
Il résulte de l'assemblée générale du 04 janvier 2012 que:
- les démissions des sociétés EXCELIANCE SA, KENNON MANAGEMENT et E-VENTURE CORPORATION de
leurs fonctions d'administrateur sont acceptées;
- la démission de KENNON MANAGEMENT de sa fonction d'administrateur délégué est acceptée;
- Maître Valérie DEMEURE, avocate à la cour, demeurant professionnellement à L-1260 Luxembourg, 1, rue de Bon-
nevoie,. Maître Jean-Marc ASSA, avocat, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains et
24950
L
U X E M B O U R G
Monsieur Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val
Sainte Croix sont nommés administrateurs. Leurs mandats expireront lors de l'assemblée statutaire de 2017.
- Le mandat du commissaire aux comptes la société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA es renouvelé. Son mandat
expirera lors de l'assemblée statutaire de 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jonathan BEGGIATO
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012011409/21.
(120013126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Haas TCM of Luxembourg 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 129.605.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Haas TCM of Luxembourg 1 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012011012/11.
(120012380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Haas TCM of Luxembourg 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 129.609.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Haas TCM of Luxembourg 2 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012011013/11.
(120012381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Haas TCM of Luxembourg 3 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 129.323.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Haas TCM of Luxembourg 3 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012011014/11.
(120012382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Oceaneering Holdings Sarl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 26.525.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 166.091.
EXTRAIT
En date du 28 décembre 2011, la société Oceaneering International, Inc., ayant son siège social sis au 1209 Orange
Street, Wilmington, Etat du Delaware, 19801, Etats-Unis d'Amérique et son principal centre d'intérêt au 11911 FM 529,
Houston, Etat du Texas 77041-3000, Etats-Unis d'Amérique, a transféré 26.525.000 (vingt-six millions cinq cent vingt-
cinq mille) parts sociales à Oceaneering International Holdings LLC SCS, une société en commandite simple constituée
selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 296-298, route de Longwy, L-1940 Luxem-
24951
L
U X E M B O U R G
bourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.777, de
sorte que l'actionnariat de la Société se compose désormais comme suit:
- Oceaneering International Holdings LLC SCS: 26.525.000 (vingt-six millions cinq cent vingt-cinq mille) parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012011443/21.
(120013136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Haas TCM of Luxembourg 4 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 129.322.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Haas TCM of Luxembourg 4 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012011015/11.
(120012383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Harte Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée,
(anc. Margyle Luxembourg S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 132.495.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 3 janvier 2012i>
Il est décidé d’accepter les démissions de Monsieur Olivier Dorier et de Monsieur Stewart Kam-Cheong, gérants, avec
effet au 23 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012011017/12.
(120013123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Interact S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.
R.C.S. Luxembourg B 82.294.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 15 novembrei>
<i>2011 à 16.00 heuresi>
Les actionnaires prennent acte de la démission de Messieurs Camille GROFF et Jean-Luc MINES intervenue séance
tenante.
Ainsi le nombre des administrateurs passe de 6 à 4 membres.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2012011064/14.
(120012524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 418.984.658,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 149.974.
Les comptes annuels pour la période du 1
er
mai 2010 au 27 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
24952
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2012011021/11.
(120013149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Howick Card S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 130.595.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société prises en date du 7 décembre 2011i>
Par les résolutions écrites du 7 décembre 2011, l'associé unique de la société a décidé:
- de prendre acte de la démission de Monsieur François Georges de son mandat de Gérant de la Société avec effet au
24 novembre 2011.
- de nommer Monsieur Guillaume Le Bouar, né à Brignoles (France) le 2 novembre 1971, demeurant professionnel-
lement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1.330 Luxembourg, en tant que gérant unique de la Société, avec
effet au 24 novembre 2011, et pour une durée indéterminée.
- de transférer le siège social de la Société du 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, au
48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
HOWICK CARD S.à r.l.
Référence de publication: 2012011024/20.
(120012257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
HCA Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 217.502,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 146.901.
EXTRAIT
Les associés de la Société ont décidé d'accepter, en date du 19 janvier 2012 et avec effet immédiat, la démission de
Mr Ronald Lee Grubbs Jr. en tant qu'administrateur de la Société.
Les associés de la Société ont également décidé de nommer, en date du 19 janvier 2012 et avec effet immédiat, Mr
Donald Wayne Stinnett, né le 12 mars 1956 à Louisville, Kentucky, USA et demeurant professionnellement au 2025
Waterstone Drive, Franklin, TN 37069, USA, en tant qu'administrateur de la Société, pour une durée illimitée, en rem-
placement de Mr Ronald Lee Grubbs Jr.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HCA Luxembourg Investments S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012011029/17.
(120013019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3290 Bettembourg, 5, Zone d'Activités Economiques Krakelshaff.
R.C.S. Luxembourg B 89.060.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2011i>
L'assemblée générale a pris à l'unanimité la résolution suivante:
Le mandat de Monsieur Marcel SAUBER, demeurant 36 rue des Prés L-7246 WALFERDANGE est renouvelé en qualité
de réviseur de la société.
Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2012.
24953
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 20 janvier 2012.
<i>Pour l'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2012011038/15.
(120012966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
RAB UCITS Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8071 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 159.911.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of RAB UCITS Funds (the Meeting), a Luxembourg
investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable), incorporated in the form of a public
limited liability company (société anonyme) having its registered office at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand
Duchy of Luxembourg, incorporated on 22 March 2011 pursuant to a notarial deed recorded by Maître Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
n°645 on 6 April 2011, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 159911 (the
Company).
The Meeting is chaired by Carole Béninger, private employee, professionally residing in Bertrange as chairman.
The chairman appoints Jean-Yves Corneau, private employee, residing professionally in Bertrange, as secretary and
scrutineer of the Meeting. The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the
Members of the Bureau or as the Bureau.
The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:
I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in
an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed by the shareholders present at
the Meeting and the holders of powers of attorney who represent the shareholders who are not present and the Members
of the Bureau. The said list as well as the powers of attorney will remain attached to these minutes;
II. it appears from the attendance list that all the shares without par value representing the entire subscribed share
capital of the Company are present or duly represented at the Meeting. The shareholders present or represented declare
that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to, the Meeting. The Meeting decides
to waive the convening notices. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on
the agenda, set out below;
III. the agenda of the Meeting is as follows:
(1) waiver of the convening notices;
(2) decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
(3) decision to appoint Fund Solutions SCA, represented by Mr Marek Domagala, with registered address at 2, rue
des Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 154626 (the Liquidator), as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the
Company;
(4) determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
(5) decision to approve the payment of EUR6,000 to Mr Christopher de Mattos and the payment of EUR6,000 to Mr
Ronan Daly, corresponding to their remuneration as directors of the Company for a period of six months as from the
incorporation of the Company;
(6) decision to instruct the Liquidator to realise at the best of his abilities and with regard to the circumstances all the
assets of the Company, to pay the debts of the Company and to issue a report on the liquidation;
(7) decision to instruct KPMG Audit S.à r.l. (the auditor of the Company) to issue an audit report on the liquidation;
(8) acknowledgement that the Liquidator will convene an extraordinary general meeting of shareholders resolving on
the closing of the liquidation; and
(9) miscellaneous.
After deliberation the Meeting passed by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the subscribed share capital of the Company being present or represented at the present Meeting, the
Meeting waives the convening notices, the shareholders present or represented consider themselves as duly convened
and declare having knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
24954
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation vo-
lontaire).
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to appoint the Liquidator as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company.
The Liquidator has the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and the
disposal of the assets of the Company under its sole signature.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg act
dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Companies Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may,
under its sole responsibility, delegate its powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni
de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Companies Act 1915.
In case upon closing of the liquidation of the Company it would appear that the provisions made to cover estimated
costs exceed the actual accrued costs, to the extent not covered by RAB Capital Limited (the Excess Amounts), the
Meeting instructs the Liquidator to distribute Excess Amounts among all shareholders of the Company recorded in the
register of shareholders as at the date of 6 September 2011 in order to ensure a fair and equal treatment amongst all
shareholders of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to approve the payment of EUR6,000 to Mr Christopher de Mattos and the payment of EUR6,000
to Mr Ronan Daly, corresponding to their remuneration as directors of the Company for a period of six months as from
the incorporation of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise at the best of his abilities and with regard to the circumstances
all the assets of the Company, to pay the debts of the Company and to issue a report on the liquidation.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to instruct KPMG Audit S.à r.l. (the auditor of the Company) to issue an audit report on the
liquidation.
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting acknowledges that the Liquidator will convene an extraordinary general meeting of shareholders resolving
on the closing of the liquidation, which shall be held, as soon as practicable after the Liquidator will have performed its
duties, with in substance the following agenda:
(1) waiver of the convening notices;
(2) presentation of the report of Fund Solutions SCA, represented by Mr Marek Domagala, with registered address
at 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 154626 (the Liquidator), as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of
the Company;
(3) presentation of the report of KPMG Audit S.à r.l. on the liquidation of the Company;
(4) release (quitus) to the board of directors of the Company for all its duties during, and in connection with, the
financial year having started on 22 March 2011 and having ended on 29 December 2011, the date of the extraordinary
general meeting deciding to dissolve and liquidate the Company;
(5) release (quitus) to the Liquidator, as liquidator (liquidateur) of the Company, for all his duties during, and in
connection with, the liquidation of the Company;
(6) release (quitus) to KPMG Audit S.à r.l., as auditor of the Company, for all its duties during, and in connection with,
(i) the financial year having started on 22 March 2011 and having ended on 29 December 2011, the date of the extraor-
dinary general meeting deciding to dissolve and liquidate the Company, and (ii) the liquidation of the Company;
(7) decision to close the liquidation of the Company; and
(8) decision that the Company's documents and books shall be kept, for a period of five years from the date of
publication of the closing of the liquidation, at the following address: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy
of Luxembourg.
24955
L
U X E M B O U R G
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand eight hundred Euros (1,800.-
Euro).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appearing
persons, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing
persons, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.
This notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jours du mois de décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de RAB UCITS Funds (l'Assemblée), une société
d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, organisée sous la forme d'une société anonyme, ayant son
siège social au 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée le 22 mars 2011 en
vertu d'un acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°645 du 6 avril 2011, et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159911 (la Société).
L'Assemblée est présidée par Carole Béninger, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange.
Le président désigne Jean-Yves Corneau, employé privé, avec adresse professionnelle à Bertrange, comme secrétaire
et scrutateur de l'Assemblée. Il est collectivement référé au président, secrétaire et scrutateur ci-après comme aux
Membres du Bureau ou au Bureau.
Le Bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter que:
I. les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux
sont inscrits dans une liste de présence qui restera annexée aux présentes et sera signée par les actionnaires présents à
l'Assemblée, par les mandataires représentant les actionnaires non présents et par les Membres du Bureau. Ladite liste,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées aux présentes;
II. il ressort de la liste de présence que toutes les actions sans valeur nominale représentant l'entièreté du capital social
souscrit de la Société sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée. Les actionnaires présents ou représentés
déclarent avoir reçu une convocation dûment adressée et qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour avant l'As-
semblée. L'Assemblée décide de renoncer aux modalités de convocation. De ce fait, l'Assemblée est constituée selon les
règles et peut délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, mentionné ci-après;
III. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
(1) renonciation aux formalités de convocation;
(2) décision de dissoudre et liquider volontairement la Société;
(3) décision de nommer Fund Solutions SCA, représentée par M. Marek Domagala, ayant son siège social au 2, rue
des Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154626 (le Liquidateur), comme liquidateur en relation avec la liquidation de
la Société;
(4) détermination des pouvoirs à attribuer au Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
(5) décision d'approuver le paiement de 6.000EUR à M. Christopher de Mattos et le paiement de 6.000 EUR à M.Ronan
Daly, correspondant à leur rémunération comme administrateurs de la Société pendant une période de six mois à compter
de la constitution de la Société;
(6) décision de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société,
de payer toutes les dettes de la Société et de préparer un rapport sur la liquidation;
(7) décision de charger KPMG Audit S.à r.l. (le réviseur d'entreprises agréé de la Société) de préparer un rapport
d'audit sur la liquidation;
(8) reconnaissance que le Liquidateur convoquera une assemblée générale extraordinaire des actionnaires se pro-
nonçant sur la clôture de la liquidation; et
(9) divers.
Après délibération, l'Assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social souscrit de la Société étant présente ou représentée à cette Assemblée, l'Assemblée
renonce aux modalités de convocation, les actionnaires présents ou représentés se considérant comme dûment convo-
qués et déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
24956
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de dissoudre et procéder à la liquidation volontaire de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer le Liquidateur comme liquidateur en relation avec la liquidation de la Société.
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sous sa seule signature tout acte nécessaire pour la
liquidation de la Société et la réalisation de ses actifs.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d'exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus à l'article
145 de la Loi sur les Sociétés, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra,
sous sa propre responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou
plusieurs personnes physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser discrétionnairement des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de
la Société conformément à l'article 148 de la Loi sur les Sociétés.
Si, à la clôture de la liquidation de la Société, les provisions faites pour couvrir les coûts estimés excèdent les coûts
réels accumulés, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par RAB Capital Limited (les Montants Excessifs), l'Assemblée
charge le Liquidateur de distribuer les Montants Excessifs entre tous les actionnaires de la Société inscrits au registre des
actionnaires à la date du 6 septembre 2011 afin d'assurer un traitement juste et équitable entre tous les actionnaires de
la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver le paiement de 6.000,-EUR à M. Christopher de Mattos et le paiement de 6.000,-EUR
à M. Ronan Daly, correspondant à leur rémunération comme administrateurs de la Société pendant une période de six
mois à compter de la constitution de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la
Société, de payer toutes les dettes de la Société et de préparer un rapport sur la liquidation.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de charger KPMG Audit S.à r.l. (le réviseur d'entreprises agréé de la Société) de préparer un
rapport d'audit sur la liquidation.
<i>Huitième résolutioni>
L'Assemblée reconnaît que le Liquidateur convoquera une assemblée générale extraordinaire des actionnaires se pro-
nonçant sur la clôture de la liquidation, qui devra être tenue, dès que possible après que le Liquidateur a exécuté ses
devoirs, avec, en substance, l'ordre du jour suivant:
(1) renonciation aux modalités de convocation;
(2) présentation du rapport de Fund Solutions SCA, représentée par M. Marek Domagala, ayant son siège social au 2,
rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154626 (le Liquidateur) en sa qualité de liquidateur en rapport avec la
liquidation de la Société;
(3) présentation du rapport de KPMG Audit S.à r.l. sur la liquidation de la Société;
(4) décharge (quitus) à accorder au conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) pour l'exécution
de tous ses devoirs pendant, et en relation avec, l'exercice social commencé le 22 mars 2011 et clôturé le 29 décembre
2011, date de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la dissolution et de la mise en liquidation la Société;
(5) décharge (quitus) à accorder au Liquidateur en sa qualité de liquidateur de la Société, pour l'exécution de tous ses
devoirs pendant et en relation avec la liquidation de la Société;
(6) décharge (quitus) à accorder à KPMG Audit S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société pour
l'exécution de tous ses devoirs pendant, et en relation avec, (i) l'exercice social commencé le 22 mars 2011 et clôturé
au 29 décembre 2011, date de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la dissolution et de la mise en liquidation
la Société et (ii) la liquidation de la Société;
(7) décision de clôture de la liquidation de la Société; et
(8) décision de déposer et conserver les livres et documents sociaux de la Société pendant cinq ans, à partir de la date
de publication de la clôture de liquidation à l'adresse suivante: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of
Luxembourg.
24957
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des fraisi>
Les montants des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille huit cents Euros (1.800,-Euro).
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des personnes com-
parantes, le présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur la demande des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, celles-ci ont signé ensemble avec le notaire
le présent acte.
Signé: C. BENINGER, J.-Y. CORNEAU et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2012. Relation: LAC/2012/1495 Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Référence de publication: 2012009170/228.
(120010198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Husum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 132.405.
<i>Extrait des décisions prises par l’actionnaire unique de la Société en date du 16 janvier 2012i>
1. Mme. Lorna Mackie, avec adresse au 10, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg, a été nommé en qualité de gérant
avec effet au 16 janvier 2012 et pour une durée indéterminée.
2. Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Mr Godfrey Abel
- Monsieur Michael Chidiac
- Monsieur Richard James
- Madame Lorna Mackie
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012011025/20.
(120012508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
HCA Luxembourg 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 217.502,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.526.
EXTRAIT
Les associés de la Société ont décidé d'accepter, en date du 19 janvier 2012 et avec effet immédiat, la démission de
Mr Ronald Lee Grubbs Jr. en tant qu'administrateur de la Société.
Les associés de la Société ont également décidé de nommer, en date du 19 janvier 2012 et avec effet immédiat, Mr
Donald Wayne Stinnett, né le 12 mars 1956 à Louisville, Kentucky, USA et demeurant professionnellement au 2025
Waterstone Drive, Franklin, TN 37069, USA, en tant qu'administrateur de la Société, pour une durée illimitée, en rem-
placement de Mr Ronald Lee Grubbs Jr.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HCA Luxembourg 1i>
Référence de publication: 2012011030/17.
(120013022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
24958
L
U X E M B O U R G
HCA Luxembourg 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.525.
EXTRAIT
Les associés de la Société ont décidé d'accepter, en date du 19 janvier 2012 et avec effet immédiat, la démission de
Mr Ronald Lee Grubbs Jr. en tant qu'administrateur de la Société.
Les associés de la Société ont également décidé de nommer, en date du 19 janvier 2012 et avec effet immédiat, Mr
Donald Wayne Stinnett, né le 12 mars 1956 à Louisville, Kentucky, USA et demeurant professionnellement au 2025
Waterstone Drive, Franklin, TN 37069, USA, en tant qu'administrateur de la Société, pour une durée illimitée, en rem-
placement de Mr Ronald Lee Grubbs Jr.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HCA Luxembourg 2i>
Référence de publication: 2012011031/17.
(120013021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Hippoline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6311 Beaufort, 22, route de Reisdorf.
R.C.S. Luxembourg B 92.471.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 19 janvier 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012011032/10.
(120012541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Housetech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.
R.C.S. Luxembourg B 115.390.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012011034/9.
(120012684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Hydro Taillandier-Wester S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 12, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 71.131.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 19 janvier 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012011036/10.
(120012542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
L.S.A. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 150.182.
Il résulte d’une convention de cession de parts sociales du 2 décembre 2011 entre WEALTH SOLUTIONS ADVISORY
Sagl, société Suisse ayant son siège social à CH-6901 Lugano, Via F. Soave 9 et FENICE INVESTIMENTI S.A., société Suisse
ayant son siège social à CH-6901 Lugano, Via Cattedrale 9, que 1009 (mille et neuf) parts sociales de la Société, d’une
valeur nomimale de 10 EUR (dix euros) chacune, ont été cédées avec effet au 2 décembre 2011 par WEALTH SOLU-
TIONS ADVISORY Sagl à FENICE INVESTIMENTI S.A..
24959
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Référence de publication: 2012011100/14.
(120013076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Innova Financial Holding BF II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.784.146,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 159.412.
Les comptes annuels pour la période du 9 mars 2011 (date de constitution) et arrêtes au 19 juillet 2011 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2012.
Référence de publication: 2012011037/11.
(120013151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
International Company of Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 142.375.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 1
er
janvier 2012 de nommé en tant que gérant
de classe A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée de Monsieur Juan Fernando DEL CASTILLO
CARREON, né le 26 décembre 1972 à Mexico, Mexique, résidant au 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 1
er
janvier 2012 d’accepté la démission en tant
que gérant de classe A de la Société avec effet au 14 Octobre 2011 et pour une durée indéterminée de Monsieur Luis
Manuel JARA ROLLE.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 Janvier 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012011039/18.
(120012202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
St Germain Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 58.725.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie en date du 18 janvier 2012i>
L'assemblée accepte la démission de Madame Marina LYTCHAGUINA, demeurant 6, rue du Moulin à Papier, B-1170
BRUXELLES, Monsieur Kirill LEVSHOV, demeurant 6, rue du Moulin à Papier, B-1170 BRUXELLES, et Monsieur Frédé-
rique COLIN, demeurant 637, Chaussée de Wavre, B-1040 BRUXELLES, de leurs fonctions d'administrateurs et appelle
en remplacement Monsieur Paul OTTOY, Président du Conseil d'Administration, demeurant 110, Mommaertstraat,
B-3090 OVERIJSE, Madame Erica GOEDERT, demeurant 110, Mommaertstraat, B-3090 OVERIJSE, Monsieur Didier OT-
TOY, demeurant 2, place de Strasbourg, L-2562 LUXEMBOURG, et Madame Carmen LEVY SWUSTEN, demeurant 8,
rue Pastourelle, F-75003 PARIS.
Le mandat des administrateurs viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l'exercice clôturant au 31 décembre 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012011481/20.
(120012419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
24960
Agri-Top Holding S.A.
Equinix (Luxembourg) Holdings S.à r.l.
Fatilu S.à r.l.
FC Financing & Consulting S.A.
FuturInvest S.A.
Ganylux S.A.
Garage Kieffer s.à r.l.
G.F.E. Holding S.A.
Gilux S.A.
Global Line S.A.
Global Part S.A.
Global Refund Holdings Three S.à r.l.
Global Refund Holdings Two S.à r.l.
Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR
Granada Properties S.A.
Graphik und Print-Gap A.G.
Groupe Simtech S.A.
Haas TCM of Luxembourg 1 S.àr.l.
Haas TCM of Luxembourg 2 S.àr.l.
Haas TCM of Luxembourg 3 S.àr.l.
Haas TCM of Luxembourg 4 S.àr.l.
Harte Luxembourg Holdings
HCA Luxembourg 1
HCA Luxembourg 2
HCA Luxembourg Equities
HCA Luxembourg Investments S.à r.l.
Hedelfingen S.à r.l.
HeidelbergCement Holding S.à r.l.
Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l.
Hippoline S.à r.l.
Holcim (Luxembourg) S.A.
Housetech S.A.
Howick Card S.à r.l.
Husum S.à r.l.
Hydro Taillandier-Wester S.à r.l.
IM International Models Holding S.A.
Innova Financial Holding BF II S.à r.l.
Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.
Interact S.A.
International Company of Services S.à r.l.
John Deere Holding Brazil S.à r.l.
John Deere Luxembourg Investment S.à r.l.
L.S.A. S.à r.l.
Margyle Luxembourg S.à r.l.
Oceaneering Holdings Sarl
ODE International Publishers Holding S.à r.l.
Placer S.A.
RAB UCITS Fund
St Germain Immobilière S.A.
Suki Finance S.à r.l.