logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 358

10 février 2012

SOMMAIRE

1 Trade S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17177

A.20 S.O.S. Techniques Guy Rollinger  . . .

17161

Aleris Global Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . .

17175

Alternative Property Income Venture

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17170

Barnes Group Luxembourg (No. 2) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17163

BI-Invest Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17179

Biotech Foods S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17179

Brassco Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17155

Calisto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17178

Capitale Ingenium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17165

Caros Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17158

Dolis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17168

Global Motor Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

17180

Graal Soft Limited, succursale de Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17173

Hao Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

17182

Hydrus Investments S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

17183

I.30 Foetz "Avenir"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17161

Indigo Capital V (Walter) S.à r.l.  . . . . . . . .

17180

Invision S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17173

KuponOne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17182

L.C.A. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17163

LOVEL Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17184

Luxembourg Company of Metals & Alloys

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17184

Luxemburger Leben S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

17171

Luxklima S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17184

Maharaja S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17184

Mareblu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17183

MILI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17175

Mobile Shredding Luxembourg  . . . . . . . . . .

17162

Mobius Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17183

Moorea Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17138

Patricia International S.A., SPF . . . . . . . . . .

17158

Perthman International S.A.  . . . . . . . . . . . .

17159

Point Out S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17159

P&S East Growth S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

17157

Sofadem Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17159

Sustainable Energy One S.A.  . . . . . . . . . . . .

17166

Taxcom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17165

TMF Luxembourg Holding S.A.  . . . . . . . . .

17159

TMF Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17159

Triple S S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17165

Triple S S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17171

Triple S S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17170

Truman Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

17171

TV Vertical S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17171

UCXA Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

17172

Unicorp Seeds S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17171

Vantose S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17172

VCS Environment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17172

Venilux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17172

Vratislavia Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

17172

West Group Participations SA  . . . . . . . . . .

17173

White Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17174

Woodpecker Capital S.A,  . . . . . . . . . . . . . . .

17174

WPP Luxembourg Germany Holdings 3

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17174

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17175

Yellowstone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17177

17137

L

U X E M B O U R G

Moorea Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 146.927.

In the year two thousand and twelve, on the eighteenth of January.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of "MOOREA FUND " (the "Company"), a “société d'in-

vestissement à capital variable-” having its registered office at 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 146927, incorporated pursuant to added of the un-
dersigned notary on 26 June 2009, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (the "Mémorial")
number 1430 of July 24, 2009.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Mrs Hélène SUBTIL, employee, professionally residing in Luxembourg, in

the chair,

who appointed as secretary Ms Sabrina LISIAK, employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Nathalie HENDRICKX, employee, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting (the "Bureau") having thus been constituted, the Chairman declared and requested the

notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

- Restatement of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”) by (i) amending articles 3, 4, 5, 7, 13,

18, 19, 26, 30, 31, 34, 36, 37 and 40 of the Articles in order to upgrade the Company under Part I of the law of 17
December 2010 relating to undertakings for collective investment by taking advantage of the new UCITS IV flexibilities
and (ii) making minor wording improvements that will come into force on January 18 

th

 , 2012 where the amended article

3 relating to the object of the Company will be read as follows:

“The sole object of the Company is the collective investment of its assets in shares or units of open-ended or closed-

ended investment funds as well as in transferable securities and/or in money market instruments and in any other securities
or instruments authorised by law, with the purpose of spreading investment risks, within the limits of the investment
policies and restrictions determined by the board of directors, and affording its shareholders the results of the manage-
ment of its portfolio either throught distributions or through accumulation of income of the Company.

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and deve-

lopment of its object in the broadest sense in the frame of the Part I of the Luxembourg law dated 17 

th

 December 2010

relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time.”

2. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares  are  shown  on  an  attendance  list;  this  attendance  list,  signed  by  the  shareholders  present,  the  proxies  of  the
represented shareholders and the board of the meeting will remain annexed to these Minutes.

3. That a convening notice setting forth the agenda of the meeting was sent by registered mail to each of the registered

shareholders of the Company on January 5, 2012.

4. That, according to the attendance list, one hundred and seventy thousand eight hundred and forty-seven point five

five two (170. 847,552) shares in issue, ninety-six thousand four hundred and thirty-one (96,431) shares are present or
represented.

5. That, consequently, the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the items of the

agenda.

After deliberation the general meeting unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

The general meeting decides to restate the articles of incorporation of the Company (the “Articles”) by:
(i) amending articles 3, 4, 5, 7, 13, 18, 19, 26, 30, 31, 34, 36, 37 and 40 of the Articles in order to upgrade the Company

under Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment by taking advantage of
the new UCITS IV flexibilities and

(ii) making minor wording improvements that will come into force on January 18 

th

 , 2012 where the amended article

3 relating to the object of the Company will be read as follows:

“The sole object of the Company is the collective investment of its assets in shares or units of open-ended or closed-

ended investment funds as well as in transferable securities and/or in money market instruments and in any other securities
or instruments authorised by law, with the purpose of spreading investment risks, within the limits of the investment
policies and restrictions determined by the board of directors, and affording its shareholders the results of the manage-
ment of its portfolio either throught distributions or through accumulation of income of the Company.

17138

L

U X E M B O U R G

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and deve-

lopment of its object in the broadest sense in the frame of the Part I of the Luxembourg law dated 17 

th

 December 2010

relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time.

Specifically, the general meeting decides to:
- replace all references to the law of 20 

th

 December, 2002 on undertakings for collective investment in the articles

of incorporation of the Company (the “Articles”) by references to the law of 17 

th

 December, 2010 on undertakings for

collective investment, or any legislative replacements or amendment thereof and to update the references to individual
articles of the law of 17 

th

 December, 2010 on undertakings for collective investment;

- add a second paragraph in article 4 as follows: “To the extend permitted by law, the registered office of the Company

may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the Board of Directors”;

- add a last sentence in the first paragraph of article 5 of the Articles as follows: “Being provided that shares of a target

sub-fund held by another sub-fund (as described in article 26 below) shall not be taken into account for the purpose of
the calculation of the minimum capital requirement.”

- delete the last paragraph of article 7 and replace it by the following: “Each Sub-Fund will be invested in accordance

with the investment objective and policy applicable to that Sub-Fund, the investment objective, policy, as well as the risk
profile and other specific features of each Sub-Fund are set forth in the prospectus of the Company (the “Prospectus”).
Each Sub-Fund may have its own funding, share classes, investment policy, capital gains, expenses and losses, distribution
policy or other specific features. The Board of Directors of the Company may, at any time, establish new Sub-Funds”;

- replace the words Simplified Prospectus by key investor information documents in article 12 of the Articles;
- add in article 13 the information that the board of directors may decide to suspend temporarily the issue of class of

shares;

- in article 18 of the Articles:
(i) to add a second paragraph as follows “The chairman shall preside at all meetings of shareholders, but in his absence

the shareholders or the board of directors may appoint another director to preside at such meetings. For general meetings
of shareholders and in the case no director is present, any other person may be appointed as chairman of the general
meetings of shareholders.”;

(ii) to add a fourth, fifth and sixth paragraphs as follows:
“Shareholders may also vote by means of a dated and duly completed form which must include the information as set

out herein. The board of directors may in its absolute discretion indicate in the convening notice that the form must
include information in addition to the following information: the name of the Company, the name of the shareholder as
it appears in the register of shareholders; the place, date and time of the meeting; the agenda of the meeting; an indication
as to how the shareholder has voted.

In order for the votes expressed by such form to be taken into consideration for the determination of the quorum,

the form must be received by the Company or its appointed agent at least three business days before the meeting or any
other period as may be indicated in the convening notice by the board of directors.

If so decided by the board of directors at its discretion and disclosed in the convening notice for the relevant meeting,

shareholders may take part in a meeting by way of videoconference or by any other means of telecommunication which
allow them to be properly identified and in such case will be considered as present for the quorum and majority deter-
mination.

(iii) To replace the terms “those present or represented and voting “ by “the votes cast”
- add two last paragraphs in article 19 of the Articles as follows:
The Company is not required to send the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor

and the management report, at the same time as the convening notice to the annual general meeting of shareholders.
Unless otherwise provided for in the convening notice to the annual general meeting of shareholders, the annual accounts,
as well as the report of the approved statutory auditor and the management report, will be available at the registered
office of the Company.

The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the

general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on
the fifth day prior to the general meeting of shareholders (referred to as “Record Date”). The rights of a shareholder to
attend a general meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the
shares held by this shareholder at the Record Date.”;

- add the following paragraphs at the end of the article 26 of the Articles to read as follows:
“The board of directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more

classes of shares or Sub-Funds on a pooled basis, where it is appropriate with regard to their respective investment
sectors to do so.

When investments of the Company are made in the capital of subsidiary companies which carry on the business of

management, advice or marketing in the country where the subsidiary is established, with regard to the redemption of
shares at the request of shareholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48 of the 2010 Law do not apply.

17139

L

U X E M B O U R G

The board of directors can decide that a Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued

by one or more other Sub-Funds of the Company without that the Company being subject to the requirements of the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, with respect to the subscription, acquisition and /or the
holding by a company of its own shares, under the condition however that:

- the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in the target Sub-Fund,
- no more than 10% of the assets that the target Sub-Funds may be invested in aggregate in shares of other target Sub-

Funds of the Company,

- the voting rights linked to the shares of the target Sub-Funds are suspended during the period of investment,
- in any event, for as long as these shares are held by the Company, their value will not be taken into consideration

for the calculation of the net asset value for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed
by the 2010 Law; and

- there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund

having invested in the target Sub-Fund and those of the target Sub-Fund.”;

- delete in article 30 the following part “as defined in the Institut Monétaire Luxembourgeois Circular 91/75 of 21 

st

January 1991”;

- add the following sentence at the end of the last paragraph in article 34 of the Articles:
“If amounts deposited remain unclaimed beyond the prescribed time limit, they shall be forfeited”;
- replace the article 36 of the Articles to read as follows:

« Art. 36. Merger of the Company, Sub-Funds or Classes of shares.
(i) The Board of Directors may decide to propose to the shareholders to proceed with a merger (within the meaning

of the law of 17 December 2010) of the Company or of one of the Sub-Funds, either as receiving or absorbed UCITS or
Sub-Fund, subject to the conditions and procedures imposed by the law of 17 December 2010, in particular concerning
the merger project and the information to be provided to the shareholders, as follows:

a. Merger of the Company
The Board of Directors may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving or absorbed UCITS,

with:

- another Luxembourg or foreign UCITS (the “New UCITS”);
or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Company as shares of this New UCITS, or of the relevant sub-

fund thereof as applicable.

In case the Company is the receiving UCITS (within the meaning of the law of 17 December 2010), solely the Board

of Directors will decide on the merger and effective date thereof.

- In case the Company is the absorbed UCITS (within the meaning of the law of 17 December 2010), and hence ceases

to exist, the general meeting of the shareholders has to approve, and decide on the effective date of the merger by a
resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes cast at such meeting by the present
or represented shareholders. Such decision must be recorded by notarial deed.

b. Merger of the Sub-Funds
The Board of Directors may decide to proceed with a merger of any Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-

Fund, with:

- another existing Sub-Fund within the Company or another sub-fund within a New UCITS (the “New Sub-Fund”); or
- a New UCITS,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of the New UCITS, or of the New

Sub-Fund as applicable.

c. Rights of the shareholders and costs to be borne by them
In all the above mentioned merger cases, the shareholders will in any case be entitled to request, without any charge

other than those retained by the Company or the Sub-Fund to meet disinvestment costs, the repurchase or redemption
of their shares, in accordance with the provisions of the 2010 Law. Any applicable contingent deferred sales charges are
not to be considered as redemption charges and shall therefore be due. A notice will be given to the shareholders
concerned by the merger. The shareholders not wishing to participate in the merger may request within a month from
the given notice to redeem their shares. This redemption shall be carried at the relevant net asset value determined the
day when the request of redemption is deemed to have been received.

(ii) The Board of Directors may also decide to merge two (or more) classes of shares from the same Sub-Fund of the

Company if the net asset value of a class of shares is below such amount as determined by the Board of Directors and
disclosed in the Prospectus from time to time or in the event of special circumstances beyond its control, such as political,
economic, or military emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other
conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Class to operate in an economically efficient

17140

L

U X E M B O U R G

manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Class should be merged. A notice will be given
to the shareholders of classes concerned by the merger. The shareholders not wishing to participate in the merger may
request within a month from the given notice to redeem their shares. This redemption shall be carried free redemption
charges at the relevant net set value determined the day when the request of redemption is deemed to have been received.
Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges and shall therefore be
due.”

- refrain from attaching a French translation to the Company's articles of incorporation.
As a consequence, the articles of incorporation will from now on read as follows:

1. Denomination, Duration, Corporate object, Registered office

Art. 1. Denomination. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter

issued, a corporation in the form of a société d'investissement à capital variable with multiple sub-funds under the name
of “Moorea Fund” (hereinafter referred to as the Company).

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period of time. The Company may be dissolved by a

resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 3. Corporate object. The sole object of the Company is the collective investment of its assets in shares or units

of open-ended or closed-ended investment funds as well as in transferable securities and/or in money market instruments
and in any other securities or instruments authorised by law, with the purpose of spreading investment risks, within the
limits of the investment policies and restrictions determined by the board of directors, and affording its shareholders the
results of the management of its portfolio either throught distributions or through accumulation of income of the Com-
pany.

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and deve-

lopment of its object in the broadest sense in the frame of the Part I of the Luxembourg law dated 17 

th

 December 2010

relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices

may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company.

To the extend permitted by law, the registered office of the Company may be transferred within the Grand Duchy of

Luxembourg by resolution of the Board of Directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economical, social or military deve-

lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg company.

2. Share capital, Variations of the share capital, Characteristics of the shares

Art. 5. Share capital. The share capital of the Company shall be at any time equal to the total net assets of the various

sub-funds of the Company, as defined in Article 12 hereof. The capital of the Company must reach one million two
hundred and fifty thousand euro (EUR 1,250,000) within the first six months following its incorporation, and thereafter
may not be less than this amount. Being provided that shares of a target sub-fund held by another sub-fund (as described
in article 26 below) shall not be taken into account for the purpose of the calculation of the minimum capital requirement.

For consolidation purposes, the reference currency of the Company is the Euro (EUR).
The initial share capital of the Company is set at thirty one thousand euro (EUR 31.000.-) represented by three hundred

and ten (310) shares of no par value of the Moorea Fund – Opportunity Class OE Shares.

Art. 6. Variations in share capital. The share capital may be increased or decreased as a result of the issue by the

Company of new fully paid-up shares or the repurchase by the Company of existing shares from its shareholders.

Art. 7. Sub-Funds. The board of directors of the Company may, at any time, establish several portfolios of assets, each

constituting a sub-fund (hereinafter referred to as a “Sub-Fund”), a “compartiment” within the meaning of Article 181 of
the Luxembourg law dated 17 

th

 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as amended from

time to time.

Each Sub-Fund will be invested in accordance with the investment objective and policy applicable to that Sub-Fund,

the investment objective, policy, as well as the risk profile and other specific features of each Sub-Fund are set forth in
the prospectus of the Company (the “Prospectus”). Each Sub-Fund may have its own funding, share classes, investment
policy, capital gains, expenses and losses, distribution policy or other specific features. The Board of Directors of the
Company may, at any time, establish new Sub-Funds.

Art. 8. Classes of shares. The board of directors of the Company may, at any time, within each Sub-Fund, issue different

classes of shares which may differ in, inter alia, their charging structure, the minimum investment requirements, the

17141

L

U X E M B O U R G

management fees or type of target investors, or corresponding to a specific distribution policy, such as giving right to
regular dividend payments (“Distribution shares”) or giving no right to distributions as the earnings will be reinvested
(“Capitalisation shares”).

Art. 9. Form of the shares. Upon their issue, the shares are freely negotiable. In each Sub-Fund, the shares of each

class benefit in an equal manner from the profits of the Sub-Fund and do not benefit from any preferred right or pre-
emption right. At the general meetings of shareholders, one vote is granted to each share, regardless of its net asset value.

Fractions of shares, up to one thousandth, may be issued and will participate in proportion to the profits of the relevant

Sub-Fund but do not carry any voting rights.

The Company may issue shares of each Sub-Fund and of each class of shares in registered form.
Shares are issued in uncertificated form with a confirmation statement, unless a share certificate is specifically requested

at the time of subscription, and in such case, the subscriber will bear the risk and any additional expense arising from the
issue of such certificate. Holders of certificated shares must return their share certificates, duly renounced, to the Com-
pany before conversion or redemption instructions may be effected.

All shares issued by the Company shall be recorded in the register of shareholders which shall be kept at the registered

office of the Company. Such share register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile,
the number of shares held by him, the class of each such share, the amounts paid for each such share, the transfer of
shares and the dates of such transfers. The share register is conclusive evidence of ownership. The Company treats the
registered owner of a share as the absolute and beneficial owner thereof.

Moreover, any registered shareholder shall be bound to provide the Company with an address to which all commu-

nications and information pertaining to the Company may be sent. This address shall also be recorded in the register of
shareholders.

In case any such shareholder shall fail to supply the Company with an address, mention of such failure may be recorded

in the register of shares, and the address of the shareholder shall be deemed to be that of the registered office of the
Company or such other address as may be determined by the Company, until another address is supplied by the concerned
shareholder. The shareholder may have the address inscribed in the register of shares modified at any time by a written
statement sent to the Company at its registered office, or at such other address as may be decided upon by the Company.

The transfer of a registered share shall be carried out (a) in case certificates have been issued, through the delivery to

the Company of the certificate(s) representing such share, together with all transfer documents required by the Company,
and (b) if no certificate(s) have been issued by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,
such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer
satisfactory to the Company.

The Company will recognise only one holder in respect of each share in the Company. In the event of joint ownership,

the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.

The shares are issued, and share certificates if requested are delivered, only upon the acceptance of the subscription

and the receipt of the subscription price under the conditions as set out in the prospectus in force. Subject to all applicable
laws and regulations, payment of the purchase price will be made in the currency in which the shares are denominated
as well as in certain other currencies as may be determined from time to time by the board of directors.

Following acceptation of the subscription and receipt of the relevant purchase price, rights in the subscribed shares

shall be vested in the subscriber and, following his request, he shall forthwith receive final shares certificates in registered
form.

The payment of dividends shall be carried out as regards registered shares at the address of the relevant shareholder

recorded in the register of shareholders.

Art. 10. Loss or Destruction of share certificates. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that

his share certificate has been mislaid or destroyed, then at his request, a duplicate share certificate may be issued under
such conditions and guarantees as the Company may determine, including an indemnity or other verification of title or
claim to title countersigned by a bank, stockbroker or other party acceptable to the Company. Upon the issue of the
new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate shall become null
and void.

Mutilated or defaced share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company.
The mutilated or defaced certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately.
The Company, at its discretion, may charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate,

as well as all costs and reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration
thereof, or in connection with the annulment of the old share certificate.

Art. 11. Limitation to the ownership of shares. The Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership

of shares in the Company by any person, firm, partnership or corporate body, if in the sole opinion of the Company such
holding may be detrimental to the interests of the existing shareholders or of the Company, if it may result in a breach

17142

L

U X E M B O U R G

of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed
to tax disadvantages, fines or penalties that it would not have otherwise incurred (such persons, firms, partnerships or
corporate bodies to be determined by the board of directors).

For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears that such registration or

transfer would or may eventually result in the beneficial ownership of said share by a person who is precluded from
holding shares in the Company;

b) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares in the Company, either

alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any such
shareholder all shares held by such shareholder; or

c) where it appears to the Company that one or more persons are the owners of a proportion of the shares in the

Company which would render the Company subject to tax or other regulations of jurisdictions other than Luxembourg,
compulsorily repurchase all or a proportion of the shares held by such shareholders.

In such cases enumerated at (a) to (c) (inclusive) here above, the following proceedings shall be applicable:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter referred to as the “redemption notice”) upon the holder of shares

subject to compulsory repurchase; the redemption notice shall specify the shares to be repurchased as aforesaid, the
redemption price (as defined here below) to be paid for such shares and the place at which this price is payable. Any such
notice may be served upon such shareholder by registered mail, addressed to such shareholder at his last known address
or at his address as indicated in the share register. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver
to the Company the share certificate, if issued, representing shares specified in the redemption notice. Immediately after
the close of business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be the owner of the
shares specified in the redemption notice and the share certificate, if issued, representing such shares shall be cancelled
in the books of the Company,

2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be purchased (hereinafter referred to as the

“redemption price”) shall be an amount equal to the net asset value per share of the class and the Sub-Fund to which the
shares belong, determined in accordance with Article 12 hereof, as at the date of the redemption notice,

3) Subject to all applicable laws and regulations, payment of the redemption price will be made to the owner of such

shares in the currency in which the shares are denominated as well as in certain other currencies as may be determined
from time to time by the board of directors, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or
elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate, if
issued, representing the shares specified in such redemption notice. Upon deposit of such redemption price as aforesaid,
no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or
any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner
thereof to receive the redemption price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the
share certificate, if issued, as aforesaid,

4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article 11 shall not be questioned or invalidated in

any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person at the date of any
redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is precluded

from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company.

Specifically, the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any

"US person", meaning any natural person resident in the United States, any partnership or corporation organised or
incorporated under the laws of the United States, any estate of which any executor or administrator is a U.S. person,
any trust of which any trustee is a U.S. person, any agency or branch of a foreign entity located in the United States, any
non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust), held by a dealer or other fiduciary for the
benefit or account of a U.S. person, any discretionary account or similar account (other than an estate or trust), held by
a dealer or other fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the United States and any partnership
or corporation if organised or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction, and formed by a U.S. person
principally for the purpose of investing in securities not registered under the Securities Act of 1933 of the United States,
as amended, unless it is organised or incorporated, and owned, by accredited investors who are not natural persons,
estates or trusts.

The Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended) (the

“1933 Act”) or the securities laws of any of the states of the United States. The Shares may not be offered, sold or
delivered directly or indirectly in the United States of America, its territories or possessions including the states and the
federal District of Columbia (the “United States”) or to or for the account or benefit of any “US Person” being any citizen
or resident of the United States, any corporation, partnership or other entity created or organised in or under the laws
of the United States, or any person falling within the definition of the term “US Person” under Regulation S, promulgated
under the 1933 Act (“US Person”) except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the regis-
tration requirements of the 1933 Act and any applicable securities laws. Any re-offer or resale of any of the Shares in the

17143

L

U X E M B O U R G

United States or to US Persons may constitute a violation of US law. Each applicant for Shares will be required to certify
whether it is a “US Person”.

The Shares are being offered outside the United States in reliance on an exemption from registration under Regulation

S under the 1933 Act and if offered in the United States will be offered to a limited number of “accredited investors” (as
defined in Rule 501(a) of Regulation D under the 1933 Act) in reliance on the private placement exemption from the
registration requirements of the 1933 Act provided by section 4(2) of the 1933 Act and Regulation D thereunder.

The Company will not be registered under the United States Investment Company Act of 1940. Based on interpre-

tations of the Investment Company Act by the staff of the United States Securities and Exchange Commission (the “SEC”)
relating to foreign investment companies, if the Company has more than one hundred beneficial owners of its securities
who are US Persons, it may become subject to the registration requirements under the Investment Company Act. The
Directors will not knowingly permit the number of holders of Shares who are US Persons to exceed ninety (or such
lesser number as the Directors may determine). To ensure this limit is maintained the Directors may decline to register
a  transfer  of  Shares  to  or  for  the  account  of  any  US  Person  and  may  require  the  mandatory  repurchase  of  Shares
beneficially owned by US Persons.

3. Net asset value, Issue and Repurchase of shares, Suspension of the calculation of the net asset value

Art. 12. Net asset value. The net asset value per share of each class of shares in each Sub-Fund of the Company shall

be determined periodically by the Company, but in any case not less than twice a month, as the board of directors may
determine (every such day for determination of the net asset value being referred to herein as the “Valuation Day” on
the basis of the last available closing prices. If a day falls on a (legal or bank) holiday in Luxembourg, then the Valuation
Day shall be the first succeeding full business day in Luxembourg.

The net asset value per share is expressed in the reference currency of each Sub-Fund and, for each class of shares

for all Sub-Funds, is determined by dividing the value of the total assets of each Sub-Fund properly allocable to such class
of shares less value of the total liabilities of such Sub-Fund properly allocable to such class of shares by the total number
of shares of such class outstanding on any valuation day.

If since the close of business, there has been a material change in the quotations on the markets on which a substantial

portion of the investments attributable to a particular Sub-Fund are dealt or quoted, the Company may, in order to
safeguard the interests of shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

Upon the creation of a new Sub-Fund, the total net assets allocated to each class of shares of such Sub-Fund shall be

determined by multiplying the number of shares of a class issued in the Sub-Fund by the applicable purchase price per
share. The amount of such total net assets shall be subsequently adjusted when shares of such class are issued or repur-
chased according to the amount received or paid as the case may be.

The valuation of the net asset value per share of the different classes of shares shall be made in the following manner:
a) The assets of the Company shall be deemed to include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stocks, units or shares of undertakings for collective investments,

debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar
assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not
inconsistent with paragraph (i) below with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights, or by similar practices);

4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information

thereon is reasonably available to the Company;

5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of such assets;

6) the preliminary expenses of the Company, including the costs of issuing and distributing shares of the Company,

insofar as the same have not been written off;

7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of such assets shall be determined as follows:
i) The value of any cash on hand or on deposit bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends, interest declared or accrued and not yet received, all of which are deemed to be the full amount thereof, unless
in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making
such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;

ii) Securities listed on a recognised stock exchange or dealt on any other regulated market (hereinafter referred to as

a “Regulated Market”) that operates regularly, is recognised and is opened to the public, will be valued at their last available
closing prices, or, in the event that there should be several such markets, on the basis of their last available closing prices
on the main market for the relevant security;

17144

L

U X E M B O U R G

iii) In the event that the last available closing price does not, in the opinion of the directors, truly reflect the fair market

value of the relevant securities, the value of such securities will be defined by the directors based on the reasonably
foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith;

iv) Securities not listed or traded on a stock exchange or not dealt on another Regulated Market will be valued on the

basis of the probable sales proceeds determined prudently and in good faith by the directors;

v) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other Regulated

Markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the directors, on a basis
consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options contracts
traded on exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these
contracts on exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded
by the Company; provided that if a future, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect
to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such
value as the directors may deem fair and reasonable;

vi) Money market instruments not listed or traded on a stock exchange or not dealt with on another Regulated Market

are valued at their face value with interest accrued;

vii) In case of short term instruments which have a maturity of less than 90 days, the value of the instrument based on

the net acquisition cost, is gradually adjusted to the repurchase price thereof. In the event of material changes in market
conditions, the valuation basis of the investment is adjusted to the new market yields.

viii) Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates

curve. Swaps pegged to indexes or financial instruments shall be valued at their market value, based on the applicable
index or financial instrument. The valuation of the swaps tied to such indexes or financial instruments shall be based upon
the market value of said swaps, in accordance with the procedures laid down by the board of directors.

ix) Credit default swaps are valued on a daily basis founding on a market value obtained by external price providers.

The calculation of the market value is based on the credit risk of the reference party respectively the issuer, the maturity
of the credit default swap and its liquidity on the secondary market. The valuation method is recognized by the board of
directors and checked by the auditors.

x) Investments in open-ended UCIs will be valued on the basis of the last available net asset value of the units or shares

of such UCIs;

xi) all other transferable securities and other permitted assets will be valued at fair market value as determined in good

faith pursuant to procedures established by the board of directors.

Any assets held not expressed in the reference currency of the subfunds will be translated into such reference currency

at the rate of exchange prevailing in a recognised market the day on which the last available closing prices are taken.

The board of directors, in its discretion, may permit some other method of valuation, based on the probable sales

price as determined with prudence and in good faith by the board of directors, to be used if it considers that such valuation
better reflects the fair value of any asset of the Company.

In the event that the quotations of certain assets held by the Company should not be available for calculation of the

net asset value per share of a Sub-Fund, each one of these quotations might be replaced by its last known quotation
(provided this last known quotation is also representative) preceding the last quotation or by the last appraisal of the last
quotation on the relevant Valuation Day, as determined by the board of directors.

The liabilities of the Company shall be deemed to include:
i) all loans, bills and accounts payable;
ii) all accrued or payable administrative expenses (including global management fees, distribution fees, custodian fees,

administrative agent fees, registrar and transfer agent fees, nominee fees and other third party fees);

iii) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or

property;

iv) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from

time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the directors, in particular those
that have been set aside for a possible depreciation of the investments of the Company; and

v) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares of the

Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable by the
Company which shall comprise formation expenses, fees payable to its directors (including all reasonable out of pocket
expenses), investment advisors or investment managers, accountants, custodian bank and paying agent, administrative,
corporate and domiciliary agent, registrar and transfer agent and permanent representatives in places of registration,
nominees and any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, cost of any proposed listings,
maintaining such listings, promotion, printing, reporting and publishing expenses (including reasonable marketing and
advertising expenses and costs of preparing, translating and printing in different languages) of Prospectuses, key investor
information documents, explanatory memoranda or registration statements, annual reports and semi-annual reports, long
form reports, taxes or governmental and supervisory authority charges, insurance costs and all other operating expenses,
including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, and telephone. The Company

17145

L

U X E M B O U R G

may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or
other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

As between the shareholders, each Sub-Fund shall be treated as a separate legal entity.
Vis-à-vis third parties, the Company shall constitute one single legal entity but by derogation from article 2093 of the

Luxembourg Civil Code, the assets of a particular Sub-Fund are only applicable to the debts, engagements and obligations
of that Sub-Fund. The assets, commitments, charges and expenses which cannot be allocated to one specific Sub-Fund
will be charged to the different Sub-Funds proportionally to their respective net assets and pro rata temporis, if appro-
priate due to the amounts considered.

All shares in the process of being redeemed by the Company shall be deemed to be issued until the close of business

on the Valuation Day applicable to the redemption. The redemption price is a liability of the Company from the close of
business on this date until paid.

All shares issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be deemed issued from

the close of business on the Valuation Day applicable to the subscription. The subscription price is an amount owed to
the Company from the close of business on such day until paid.

As far as possible, all investments and divestments chosen and in relation to which action is taken by the Company up

to the Valuation Day shall be taken into consideration in the valuation.

Art. 13. Issue, Redemption and Conversion of shares. The board of directors is authorised to issue further fully paid-

up shares of each class and of each Sub-Fund at any time at a price based on the net asset value per share for each class
of shares and for each Sub-Fund determined in accordance with Article 12 hereof, as of such Valuation Day as is deter-
mined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be
increased by applicable sales charges, as approved from time to time by the board of directors.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duty of accepting subscriptions and of receiving payment for such new shares.

All new share subscriptions shall, under pain of nullity, be entirely liberated within a period as determined by the Board

of Directors which shall not exceed ten business days from the relevant date, and the shares issued carry the same rights
as those shares in existence on the date of the issuance.

The Company may reject any subscription in whole or in part, and the directors may, at any time and from time to

time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of shares of any
class in any one or more Sub-Funds.

The board of directors may, at its discretion and under the provisions of the Prospectus, decide to suspend temporarily

the issue of new shares of any Sub-Fund or class of shares of the Company. The registered shareholders shall be informed
by a notice sent by mail at their address recorded in the shareholders' register. The subscription orders received during
the temporary closing of subscription will not be kept for further treatment.

During the period of suspension, the shareholders will remain free to redeem their shares at any Valuation Day.
The board of directors may decide, at its discretion and under the provisions of the Prospectus, to reopen the issue

of shares. The shareholders and the public will be informed according to the same modalities as mentioned here above.

The board of directors may, at its discretion, decide to accept securities as valid consideration for a subscription

provided that these comply with the investment policy and restrictions of the relevant Sub-Fund. Shares will only be issued
upon receipt of the securities being transferred as payment in kind. Such subscription in kind, if made, will be reviewed
and the value of the assets so contributed verified by the auditor of the Company. A report will be issued detailing the
securities transferred, their respective market values of the day of the transfer and the number of shares issued and such
report will be available at the office of the Company. Exceptional costs resulting from a subscription in kind will be borne
exclusively by the subscriber informed.

The subscription price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not

exceed three business days after the relevant Valuation Day, as it is determined in accordance with such policy as the
board of directors may from time to time determine.

Any  shareholder  may  request  the  redemption  of  all  or  part  of  his  shares  by  the  Company  under  the  terms  and

conditions set forth by the board of directors in the prospectus and within the limits as provided in this Article 13. The
redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not exceed
ten business days from the relevant Valuation Day, as it is determined in accordance with such policy as the board of
directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents have
been received by the Company. The redemption price shall be equal to the net asset value per share relative to the class
and to the Sub-Fund to which it belongs, determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof, decreased
by charges and commissions at the rate provided in the prospectus. Any such request for redemption must be filed by
such shareholder in written form at the registered office of the Company in Luxembourg or with any other legal entity
appointed by the Company for the redemption of shares. The request shall be accompanied by the certificate(s) for such
shares, if issued. The relevant redemption price may be rounded up or down to a maximum of three decimal places of
the reference currency as the board of directors shall determine.

17146

L

U X E M B O U R G

The Company shall ensure that at all times each Sub-Fund has enough liquidity to enable satisfaction of any requests

for redemption of shares.

If as a result of any request for redemption, the aggregate net asset value per share of the shares held by a shareholder

in any class of shares would fall below such value as determined by the board of directors, then the Company may decide
that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder's holding of shares in
such class, as stated in the prospectus.

Further if at any given date redemption requests pursuant to this Article 13 and conversion requests exceed a certain

level to be determined by the board of directors in relation to the net assets of a sub-fund, the board of directors may
decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner the
board of directors considers to be in the best interests of the Company. On the next Valuation Day following that period,
these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.

The Company will have the right, if the board of directors so determines and with the consent of the shareholder

concerned, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder in kind by allocating to such shareholder
investments from the portfolio of assets set up in connection with such classes of shares equal in value (calculated in a
manner as described in Article 12 hereof) as of the Valuation Day on which the redemption price is calculated to the
value of shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a
fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the relevant Sub-Fund, and
the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor. The cost of such transfer shall be borne by the
transferee, as stated in the prospectus.

Shares redeemed by the Company shall be cancelled in the books of the Company.
Any shareholder is entitled to request for the conversion of whole or part of his shares, provided that the board of

directors may, in the Prospectus:

a) set terms and conditions as to the right for and frequency of conversion of shares between Sub-Funds and/or classes

of shares; and

b) subject conversions to the payment of such charges and commissions as it shall determine.
If as a result of any request for conversion, the aggregate net asset value per share of the shares held by a shareholder

in any class of shares would fall below such value as determined by the board of directors, then the Company may decide
that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of shares in such
class, as stated in the prospectus.

Such a conversion shall be effected on the basis of the net asset value of the relevant shares of the different Sub-Funds,

determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof. The relevant number of shares may be rounded up
or down to a maximum of three decimal places as the board of directors shall determine.

The shares which have been converted into another Sub-Fund will be cancelled.
The requests for subscription, redemption and conversion shall be received at the location designated to and for this

effect by the board of directors.

Art. 14. Suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, the redemption and the conversion of

shares. The Company may at any time suspend the calculation of the net asset value of one or more Sub-Funds and the
issue, redemption and conversion of any classes of shares in the following circumstances:

a) during any period when any of the principal stock exchanges or other recognised markets on which a substantial

portion of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed
otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such
restriction or suspension affects the valuation of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund quoted
thereon;

b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency (such as political, military, economic or

monetary events) in the opinion of the directors as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company
attributable to such Sub-Fund would be impracticable;

c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any

of the investments of such Sub-Fund or the current price or value on any stock exchange or other market in respect of
the assets attributable to such Sub-Fund;

d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of
investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the directors, be effected at normal rates
of exchange;

e) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to such Sub-Fund

cannot promptly or accurately be ascertained;

f) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of winding-up the

Company or one of its Sub-Fund

17147

L

U X E M B O U R G

g) when any of the target funds in which the Company invests substantially its assets suspends the calculation of its

net asset value.

The suspension of the net asset value calculation of a Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the net asset

value per share, the issue, redemption and conversion of shares of any other Sub-Fund for which the calculation of the
net asset value is not suspended.

Under exceptional circumstances, the board of directors reserves the right to conduct the necessary sales of trans-

ferable  securities  before  setting  the  share  price  at  which  shareholders  can  apply  to  have  their  shares  redeemed  or
converted. In this case, subscriptions, redemptions and conversion applications in process shall be dealt with on the basis
of the net asset value thus calculated after the necessary sales, which shall have been effected without delay.

Subscribers and shareholders tendering shares for redemption and conversion shall be advised of the suspension of

the calculation of the net asset value.

The suspension of the calculation of the net asset value may be published by adequate means if the duration of the

suspension is to exceed a certain period.

Suspended subscription, redemption and conversion applications may be withdrawn by written notice provided that

the Company receives such notice before the suspension ends.

Suspended subscriptions, redemptions and conversions shall be executed on the first Valuation Day following the

resumption of net asset value calculation by the Company.

4. General shareholders' meetings

Art. 15. General provisions. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent

the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts
relating to the operations of the Company.

Any meeting of shareholders of a given Sub-Fund or of a given class of shares shall be vested with the same powers

as above with regard to any act affecting the sole holders of shares of such Sub-Fund or of such class of shares.

Art. 16. Annual general shareholders' meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance

with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of the meeting, on the last Thursday of the month of April at 10 a.m. If such day is a bank holiday,
then the annual general meeting shall be held on the first succeeding full business day in Luxembourg. The annual general
meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances
so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 17. General meetings of shareholders of a given Sub-Fund and of a given class of shares. The shareholders of any

Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund. In
addition, the shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which
relate exclusively to such class of shares. The general provisions set out in these Articles of Incorporation, as well as in
the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies, shall apply to such
meetings.

Art. 18. Functioning of shareholders' meetings. The quorum and time required by law shall govern the notice for and

conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders, but in his absence the shareholders or the board of directors

may appoint another director to preside at such meetings. For general meetings of shareholders and in the case no
director is present, any other person may be appointed as chairman of the general meetings of shareholders.

Each share, regardless of the class and of the Sub-Fund to which it belongs, is entitled to one vote, subject to the

limitations imposed by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing or by cable, telegram or facsimile transmission. Fractions of shares are not entitled to a vote.

Shareholders may also vote by means of a dated and duly completed form which must include the information as set

out herein. The board of directors may in its absolute discretion indicate in the convening notice that the form must
include information in addition to the following information: the name of the Company, the name of the shareholder as
it appears in the register of shareholders; the place, date and time of the meeting; the agenda of the meeting; an indication
as to how the shareholder has voted.

In order for the votes expressed by such form to be taken into consideration for the determination of the quorum,

the form must be received by the Company or its appointed agent at least three business days before the meeting or any
other period as may be indicated in the convening notice by the board of directors.

If so decided by the board of directors at its discretion and disclosed in the convening notice for the relevant meeting,

shareholders may take part in a meeting by way of videoconference or by any other means of telecommunication which
allow them to be properly identified and in such case will be considered as present for the quorum and majority deter-
mination.

17148

L

U X E M B O U R G

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by simple majority of the votes cast.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

Art. 19. Notice to the general shareholders' meetings. Shareholders shall be convened meet upon call by the board

of directors by a convening notice stating the agenda, time and place of the meeting, to be sent by mail at least eight days
prior to the date set for the meeting to all shareholders at their address recorded in the register of shareholders. To the
extent required by law, the notice shall be published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations of
Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the board of directors may decide.

The Company is not required to send the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor

and the management report, at the same time as the convening notice to the annual general meeting of shareholders.
Unless otherwise provided for in the convening notice to the annual general meeting of shareholders, the annual accounts,
as well as the report of the approved statutory auditor and the management report, will be available at the registered
office of the Company.

The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the

general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on
the fifth day prior to the general meeting of shareholders (referred to as “Record Date”). The rights of a shareholder to
attend a general meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the
shares held by this shareholder at the Record Date.

5. Management of the company

Art. 20. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three

members who need not to be shareholders of the Company.

Art. 21. Duration of the functions of the directors, Renewal of the board of directors. The directors shall be elected

by the general shareholders' meeting for a period not exceeding six years and until their successors are elected and
qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by reso-
lution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy on a provisional basis until the next general
meeting of shareholders.

Art. 22. Committee of the board of directors. The board of directors will choose from among its members a chairman,

and may chose from among its members one or more vicechairmen. It may also chose a secretary, who need not be a
director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the meetings
of the shareholders.

Art. 23. Meetings and Deliberations of the board of directors. The board of directors shall meet upon call by the

chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another director by a majority vote to preside at such meetings. For
general meetings of shareholders and in the case no director is present, any other person may be appointed as chairman.

The board of directors from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, any

assistant managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the
Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors
or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and
duties given to them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least three days in advance

of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram or
facsimile  transmission  of  each  director.  Separate  notice  shall  not  be  required  for  meetings  held  at  times  and  places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meetings of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, or

facsimile transmission another director as his proxy.

Directors may not bind the Company by their individual signature, except as specifically permitted by resolution of

the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least fifty per cent of the directors are present or

represented at a meeting of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. The chairman shall have the casting vote.

17149

L

U X E M B O U R G

Resolutions signed by all members of the board of directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letters, cables, telegrams, facsimile transmission and similar means.

Any Director may participate in a meeting of the Board of Director by conference-call or similar means of commu-

nication equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of directors may delegate, under its responsibility and supervision, its powers to conduct the daily mana-

gement and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose,
to natural persons or corporate entities which need not be members of the board.

Art. 24. Minutes. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman, or in his

absence, by the chairman pro tempore who presides at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

such chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 25. Engagement of the Company vis-à-vis third persons. The Company shall be engaged by the signature of two

members of the board of directors or by the individual signature of any duly authorised officer of the Company or by the
individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the board of directors.

Art. 26. Powers of the board of directors. The board of directors determines the general orientation of the manage-

ment and of the investment policy, as well as the guidelines to be followed in the management of the Company, always
in application of the principle of risk diversification.

The supervisory authority may authorise the Company to invest, in accordance with the principle of risk diversification

and pursuant to the Luxembourg law dated 17th December 2010 relating to undertakings for collective investment as
may be amended from time to time, up to 100 % of its net assets in different transferable securities and money market
instruments.

a) The Board of Directors may in this context decide that investments by the Company shall be made, among others

in:

i) transferable securities and money market instruments officially listed on a stock exchange in any one of the member

States of the European Union;

ii) transferable securities and money market instruments officially listed on a stock exchange recognised in any other

country in Europe, Asia, Oceania, the American continents and Africa;

iii) transferable securities and money market instruments dealt on another Regulated Market in an OECD country

being FATF member should the market operate regularly and be recognised and open to the public;

iv) recently issued transferable securities and money market instruments under the reserve that the conditions of issue

include an undertaking to request an admission on the official listing of a stock exchange or another Regulated Market as
here above defined, such admission being secured within one year of issue;

v) any other transferable securities, money market instruments, debt instruments or other assets within the framework

of the restrictions to be determined by the board of Directors in accordance with applicable law and regulations.

Within the framework of applicable regulations, the Board of Directors shall determine the restrictions to be applied

in the management of the Company's assets.

Such decisions may set forth that:
The Board of Directors of the Company may decide to invest up to 100% of its net assets in various issues of trans-

ferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a member state of the European Union, its
local authorities, by an OECD country being FATF member or by public international bodies of which one or more
member states of the European Union are members, it being understood that if the Company intends to take advantage
of the present provision it must hold securities belonging to at least six different issues, without the value of a single issue
exceeding 30% of the net assets of the Company.

Such authorisation will be granted should the shareholders have a protection equivalent to that of shareholders in

UCITS complying with the investment limits set forth in Luxembourg

b) Each Sub-Fund may invest in deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to

be withdrawn, and maturing in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in a
Member State of the European Union or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member
State, provided that it is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in the
Community law;

c) The board of directors has decided that any Sub-Fund of the Company may invest in units or shares of UCITS

authorised according to Directive 2009/65/EC and/or in other UCIs within the meaning of the first and second indent of
Article 1 paragraph (2) of the Directive 2009/65/EC, should they be situated in a Member State of the European Union
or not, provided that:

17150

L

U X E M B O U R G

(1) such other UCIs are authorised under laws which state that they are subject to supervision considered by the

Luxembourg Supervisory Authority as equivalent as that laid down in Community legislation and that co -operation
between authorities is sufficiently ensured;

(2) the level of protection offered to the unit holders/ shareholders in such other UCIs is equivalent to that provided

for unit holders/ shareholders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowings, lending and
uncovered sales of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive
2009/65/EC;

(3) the activity of the other UCI is reported in semi-annual and annual reports to enable an assessment of the assets

and liabilities, income and operations over the reporting period;

(4) the UCITS or the other UCI in which each Sub-Fund of the Company intends to invest, may not, according to its

constitutive documents, invest more than 10% of its net assets in aggregate, in units/shares of other UCITS or other UCIs;
The limit can be set at 100% for the Sub-Fund provided that:

- no more than 20% of its assets are invested in a single UCITS or other UCI.
- investments made in units of UCIs other than UCITS may not aggregate exceed 30% of the assets of the Sub-Fund.
d) The board of directors may create index Sub-Funds whose objective is to replicate the composition of a certain

financial index which is recognised by the supervisory authority, on the following basis: the composition of the index is
sufficiently diversified, the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers, it is published in
an appropriate manner. These index Sub-Funds will benefit from the diversification limits as stated in the Luxembourg
Law dated 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investment.

Each Sub-Fund is entitled to invest in derivative instruments. By consequences, the Company shall ensure that the

global exposure relating to the use of derivative instruments in one Sub-Fund does not exceed the total net asset value
of its portfolio. The exposure will be calculated taking into account the current value of the underlying assets, the coun-
terparty risk, future market movements and the time available to liquidate the positions.

The board of directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more classes

of shares or Sub-Funds on a pooled basis, where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to
do so.

When investments of the Company are made in the capital of subsidiary companies which carry on the business of

management, advice or marketing in the country where the subsidiary is established, with regard to the redemption of
shares at the request of shareholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48 of the 2010 Law do not apply.

The board of directors can decide that a Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued

by one or more other Sub-Funds of the Company without that the Company being subject to the requirements of the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, with respect to the subscription, acquisition and /or the
holding by a company of its own shares, under the condition however that:

- the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in the target Sub-Fund,
- no more than 10% of the assets that the target Sub-Funds may be invested in aggregate in shares of other target Sub-

Funds of the Company,

- the voting rights linked to the shares of the target Sub-Funds are suspended during the period of investment,
- in any event, for as long as these shares are held by the Company, their value will not be taken into consideration

for the calculation of the net asset value for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed
by the 2010 Law; and

- there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund

having invested in the target Sub-Fund and those of the target Sub-Fund.

Art. 27. Conflict of Interest. No contract or other transaction which the Company and any other corporation or firm

might enter into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the
Company are interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have any interest opposite to the Company in any

transaction of the Company, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest
and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest
therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

The term "interest opposite to the Company", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship

with or interest in any matter, position or transaction involving Société Générale Bank &amp; Trust such company or entity
as may from time to time be determined by the Board of Directors on its discretion.

Art. 28. Indemnification of the directors. The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to

17151

L

U X E M B O U R G

which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.

Art. 29. Allowances to the board of directors. The general meeting of shareholders may allow the members of the

board of directors, as remuneration for services rendered, a fixed annual sum, as directors' remuneration, such amount
being carried as general expenses of the Company and which shall be divided at the discretion of the board of directors
among themselves.

Furthermore, the members of the board of directors may be reimbursed for any expenses engaged in on behalf of the

Company insofar as they are reasonable.

The remuneration of the chairman or the secretary of the board of directors as well as those of the general manager

(s) and officers shall be fixed by the board.

Art. 30. Management Company and Investment Managers, Sub-Investment Managers, Custodian and other contractual

parties. The Company will enter into a Main Delegation Agreement with a Luxembourg Management Company established
in Luxembourg (the “Management Company”) and duly approved pursuant to the Chapter 15 of the Luxembourg Law
dated 17 

th

 December 2010 on Undertakings for Collective Investment as may be amended from time to time. According

to the aforesaid agreement, the Management Company will provide the Company with central administration services
and distribution services and, in respect of the investment policies of the Sub-Funds, with investment management services.

The Management Company may enter into one or more management or advisory agreements with any company based

in Luxembourg or in a foreign country (the “Manager(s)”) by virtue of which the Manager(s) shall provide the Management
Company with advice, recommendations and management services connected with the Sub-Funds' investment policies.

The Managers may enter into investment advisory agreements with any company based in Luxembourg or in a foreign

country (the “Investment Advisor”) in order to be advised and assisted while managing their portfolios.

The Shareholders are informed by the Company's prospectus of the management fees paid out for the investment

services carried out by the Managers and the Investment Advisors.

In addition, the Management Company shall enter into service agreements with other contractual parties, for example

an administrative, corporate and domiciliary agent to fulfil the role of “administration centrale” and a global distributor
having the power to appoint distributors and intermediaries to offer and sell the shares of the Company to investors.

The Company shall enter into a custody agreement with a bank (hereinafter referred to as the “Custodian”) which

shall satisfy the requirements of the Luxembourg law dated 17 

th

 December 2010 relating to undertakings for collective

investment as may be amended from time to time. All assets of the Company are to be held by or to the order of the
Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by law.

In the event of the Custodian desiring to retire the board of directors shall use its best endeavours to find another

bank to be Custodian in place of the retiring Custodian and the board of directors shall appoint such bank as Custodian.
The board of directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and
until a successor Custodian shall have been appointed in accordance with these provisions to act in the place thereof.

6. Auditor

Art. 31. Auditor. The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be

supervised by an auditor who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to respectability and professional
experience and who shall perform the duties foreseen by the Luxembourg law dated 17 

th

 December 2010 relating to

undertakings for collective investment as may be amended from time to time. The auditors shall be elected by the general
meeting of shareholders.

7. Annual accounts

Art. 32. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 

st

 January in each year and shall terminate

on 31 

st

 December of the same year.

The accounts of the Company shall be expressed in EUR. In case different Sub-Funds and several classes of shares

exist, such as provided in Article 7 and 8 of the present Articles of Incorporation, and if the accounts of such Sub-Funds
and classes of shares are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into EUR and added in view
of determining the accounts of the Company.

Art. 33. Distribution Policy. In principle, the Company does intend to distribute neither its investment income nor the

net capital gains realized as the management of the Company is oriented towards capital gains. The board of directors
shall therefore recommend the reinvestment of the results of the Company and as a consequence no dividend shall be
paid to Shareholders.

17152

L

U X E M B O U R G

The board of directors nevertheless reserves the right to propose the payment of a dividend at any time. Also, upon

the board of director's proposal and within legal limits, the general meeting of shareholders of the classes entitled to
distributions issued in the relevant Sub-Funds shall determine how the results of such classes shall be allocated and may
from time to time declare or authorise the board of directors to declare distributions. Furthermore, the board of directors
may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses re-

corded in the register of shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place as the board of directors shall determine.
The board of directors may decide to distribute dividends in the form of new shares in lieu of cash dividends upon

such terms and conditions as may be set forth by the board of directors.

In any case, no distribution of dividends may be made if, as a result, the share capital of the Company would fall below

EUR 1,250,000.

Declared dividends not claimed within five years of the due date will lapse and revert to the relevant class of shares.

The board of directors has all powers and may take all measures necessary for the implementation of this position. No
interest shall be paid on a dividend declared and held by the Company at the disposal of its beneficiary. The payment of
revenues shall be due for payment only if the foreign exchange regulations enable to distribute them in the country where
the beneficiary lives.

8. Dissolution and Liquidation

Art. 34. Dissolution and Liquidation of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution taken

by the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements as defined in Article 39 hereof
and in the Luxembourg law dated 17 

th

 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be

amended from time to time.

Whenever the capital falls below two thirds of the minimum capital as provided by the Luxembourg law dated 17 

th

December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time, the board of
directors has to submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting of shareholders. The
general meeting for which no quorum shall be required shall decide on simple majority of the votes of the shares presented
at the meeting.

The question of the dissolution and of the liquidation of the Company shall also be referred to the general meeting of

shareholders whenever the capital fall below one quarter of the minimum capital as provided by the Luxembourg law
dated 17 

th

 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time. In

such event the general meeting shall be held without quorum requirements and the dissolution or the liquidation may be
decided by the shareholders holding one quarter of the votes present or represented at that meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets

of the Company have fallen below two thirds or one quarter of the legal minimum as the case may be.

The issue of new shares by the Company shall cease on the date of publication of the notice of the general shareholders'

meeting, to which the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.

The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be natural persons or legal entities) named

by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
The appointed liquidator(s) shall realise the assets of the Company, subject to the supervision of the relevant supervisory
authority in the best interest of the shareholders.

The proceeds of the liquidation of each Sub-Fund, net of all liquidation expenses, shall be distributed by the liquidators

among the holders of shares in each class in accordance with their respective rights.

The amounts not claimed by shareholders at the end of the liquidation process shall be deposited, in accordance with

Luxembourg law, with the Caisse de Consignation in Luxembourg until the statutory limitation period has lapsed. If
amounts deposited remain unclaimed beyond the prescribed time limit, they shall be forfeited.

Art. 35. Termination of Sub-Funds or classes of shares. The Board of Directors may decide at any moment of the

termination of any Sub-Fund or Class of Shares. In the case of termination of a Sub-Fund or Class, the Board of Directors
may offer to the Shareholders of such Sub-fund or Class the conversion (if not prohibited) of their Shares into Shares of
another Sub-Fund or Class, under the terms fixed by the Board of Directors.

In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund or Class of shares has decreased to an

amount determined by the board of directors from time to time to be the minimum level for such Sub-Fund or Class of
shares to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economic or political situation would
have material adverse consequences on the Company's investments, the directors may decide (i) to compulsorily redeem
all the shares of the relevant Sub-Fund or Classes at the net asset value per share, taking into account actual realisation
prices of investments and realisation expenses and calculated on the valuation day at which such decision shall take effect
or (ii) to offer to the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class the conversion (if not prohibited) of their shares
into shares of another Sub-Fund or Class.

17153

L

U X E M B O U R G

The Company shall serve a notice to the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class of shares prior to the effective

date of the compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations.
Registered shareholders will be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interest of, or to maintain equal
treatment between, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or Class concerned may continue to request
redemption or conversion of their shares free of charge, taking into account actual realisation prices of investments and
realisation expenses and prior to the date effective for the compulsory redemption.

Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited

with the Custodian of the Company for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited
with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares will be cancelled in the books of the Company.

Art. 36. Merger of the Company, Sub-Funds or Classes of shares.
(i) The Board of Directors may decide to propose to the shareholders to proceed with a merger (within the meaning

of the law of 17 December 2010) of the Company or of one of the Sub-Funds, either as receiving or absorbed UCITS or
Sub-Fund, subject to the conditions and procedures imposed by the law of 17 December 2010, in particular concerning
the merger project and the information to be provided to the shareholders, as follows:

a. Merger of the Company
The Board of Directors of the Company may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving

or absorbed UCITS, with:

- another Luxembourg or foreign UCITS (the “New UCITS”);
or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Company as shares of this New UCITS, or of the relevant sub-

fund thereof as applicable.

In case the Company is the receiving UCITS (within the meaning of the law of 17 December 2010), solely the Board

of Directors will decide on the merger and effective date thereof.

- In case the Company is the absorbed UCITS (within the meaning of the law of 17 December 2010), and hence ceases

to exist, the general meeting of the shareholders has to approve, and decide on the effective date of the merger by a
resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes cast at such meeting by the present
or represented shareholders. Such decision must be recorded by notarial deed.

b. Merger of the Sub-Funds
The Board of Directors may decide to proceed with a merger of any Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-

Fund, with:

- another existing Sub-Fund within the Company or another sub-fund within a New UCITS (the “New Sub-Fund”); or
- a New UCITS,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of the New UCITS, or of the New

Sub-Fund as applicable.

c. Rights of the shareholders and costs to be borne by them.
In all the above mentioned merger cases, the shareholders will in any case be entitled to request, without any charge

other than those retained by the Company or the Sub-Fund to meet disinvestment costs, the repurchase or redemption
of their shares, in accordance with the provisions of the 2010 Law. Any applicable contingent deferred sales charges are
not to be considered as redemption charges and shall therefore be due. A notice will be given to the shareholders
concerned by the merger. The shareholders not wishing to participate in the merger may request within a month from
the given notice to redeem their shares. This redemption shall be carried at the relevant net asset value determined the
day when the request of redemption is deemed to have been received.

(ii) The Board of Directors may also decide to merge two (or more) classes of shares from the same Sub-Fund of the

Company if the net asset value of a class of shares is below such amount as determined by the Board of Directors and
disclosed in the Prospectus from time to time or in the event of special circumstances beyond its control, such as political,
economic, or military emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other
conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Class to operate in an economically efficient
manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Class should be merged. A notice will be given
to the shareholders of classes concerned by the merger. The shareholders not wishing to participate in the merger may
request within a month from the given notice to redeem their shares. This redemption shall be carried free redemption
charges at the relevant net asset value determined the day when the request of redemption is deemed to have been
received. Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges and shall
therefore be due.

Art. 37. Division of Sub-Funds. The Board of Directors may decide, under the same circumstances as provided under

Article 35, at any moment, to divide any Sub-Fund. In the case of division of Sub-Funds, the existing shareholders of the

17154

L

U X E M B O U R G

respective Sub-Funds have the right to require, within one month of notification and enforcement of such event, the
redemption by the Company of their shares without redemption costs.

Any request for subscription, redemption and conversion shall be suspended as from the moment of the announcement

of the division of the relevant Sub-Fund.

Notwithstanding the powers conferred on the Board of Directors by the preceding paragraph, a division of Sub-Funds

within the Company may be decided upon by a general meeting of shareholders of the classes of shares in the Sub-Fund
concerned for which their shall be no quorum requirements and which will decide, upon such division, by resolution
taken by simple majority of those present or represented.

Art. 38. Expenses borne by the Company. The Company bears its initial incorporation costs, including the costs of

drawing up and printing the prospectus, notary public fees, the filing costs with administrative and stock exchange au-
thorities, the costs of printing the certificates and any other costs pertaining to the establishment and launching of the
Company.

The costs are amortised on a period not exceeding the five first accounting years.
The Company bears all its running costs as foreseen in Article 12 hereof.

Art. 39. Amendment of the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to

time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority voting requirements provided by the laws of
Luxembourg.

Any amendment of the terms and conditions of the Company, which has as an effect a decrease of the rights or

guarantees of the shareholders or which imposes on them additional costs, shall only come into force after a period of
one month starting at the date of the approbation of the amendment by the general shareholders' meeting. During this
month, the shareholders may continue to request the redemption of their shares under the conditions in force before
the relevant amendment.

Art. 40. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with  the  Luxembourg  law  dated  10 August  1915 as  amended  from time  to  time  on  commercial companies and  the
Luxembourg law dated 17 

th

 December 2010 relating to undertakings for collective investment as may be amended from

time to time.”

There being no further business on the agenda, the meeting closes.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil

status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Signé: H. SUBTIL, S. LISIAK, N. HENDRICKX, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 janvier 2012. Relation: EAC/2012/929. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012014138/1007.
(120016635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Brassco Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 22.072.

L'an deux mille douze, le vingt janvier,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRASSCO HOLDING S.A. (la «Société»),

avec  siège  social  à  L1746  Luxembourg,  1,  rue  Joseph  Hackin,  inscrite  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg, sous le numéro B 22.072, constituée suivant acte notarié en date du 23 octobre 1984, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 314 du 21 novembre 1984.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 décembre

2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 897 du 4 mai 2011.

L'assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Madame Michela Klemke, emloyée privée, L-1746 Lu-

xembourg, 1, rue Joseph Hackin,

qui désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, emloyée privée, L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

17155

L

U X E M B O U R G

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Manciocchi, emloyé privé, L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph

Hackin.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du projet de fusion du 15 novembre 2011 par absorption de la société PICO FINANCE S.A..
2. Augmentation du capital social à concurrence de cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente euros et trente

centimes (EUR 184.430,30) pour porter le capital social de son montant actuel de huit cent quinze mille cinq cent soixante-
neuf euros et soixante-dix centimes (EUR 815.569,70) à un million d'euros (EUR 1.000.000), par l'émission de cinquante-
deux mille cinq cents (52.500) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, et création d'une prime d'émission
de trois cent deux mille quatre-vingt-onze euros et sept centimes (EUR 352.091,07) et libération par apport de l'ensemble
du patrimoine actif et passif au 20 janvier 2012 de la société PICO FINANCE S.A. à la Société.

3. Affectation de la différence entre la valeur nette comptable de la société PICO FINANCE S.A. et le montant de

l'augmentation de capital comme prime de fusion.

4. Attribution aux actionnaires de la société PICO FINANCE S.A. des actions nouvelles émises avec jouissance à la

date de réalisation définitive de la fusion.

5. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.
6. Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, relatives aux fusions ont été respectées savoir:
1. Publication du projet de fusion du 15 novembre établi par les Conseils d'Administration des sociétés qui fusionnent

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2880 du 25 novembre 2011, soit un mois au moins avant
la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant

et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.

3. Etablissement d'un rapport écrit par un seul réviseur d'entreprises indépendant désigné par ordonnance du 10 janvier

2012 de Monsieur Jean-Paul Hoffmann, 1 

er

 Vice-Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, pour la

société absorbée et pour la société absorbante.

4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un

mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs restera annexée aux présentes.

L'assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L‘assemblée approuve le projet de fusion entre la Société et la société anonyme PICO FINANCE S.A. (ci-après "PICO"),

avec siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, tel que ce projet de fusion a été publié et approuvé par les
conseils d'administration de la Société et de PICO.

Conformément à l'article 266 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, le projet

de fusion a fait l'objet d'un examen et d'un rapport établi en date du 20 janvier 2012.

Ce rapport conclut comme suit:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que:
- Le rapport d'échange retenu dans le projet de fusion ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;
- Les méthodes d'évaluation adoptés pour la détermination du rapport d'échange ne sont pas adéquates en l'espèce.»
Un exemplaire de ce rapport restera annexé au présente acte pour être enregistré en même temps.

17156

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente

euros et trente centimes (EUR 184.430,30) pour porter le capital social de son montant actuel de huit cent quinze mille
cinq  cent  soixante-neuf  euros  et  soixante-dix  centimes  (EUR  815.569,70)  à  un  million  d'euros  (EUR  1.000.000),  par
l'émission de cinquante-deux mille cinq cents (52.500) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale. Les actions
nouvelles sont libérées par la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de PICO à la Société
étant précisé que la Société reprend à son compte toutes les opérations réalisées par PICO au point de vue comptable
à partir du 20 janvier 2012 et qu'elle en supporte tout le passif, ainsi que les frais, impôts et autres charges à résulter de
la fusion.

L'ensemble du patrimoine actif et passif est apporté à la Société pour une valeur totale de cinq cent trente-six mille

cinq cent vingt et un euros et trente-sept centimes (EUR 536.521, 37) ainsi qu'il résulte d'un état comptable intérimaire
non audité au 30 septembre 2011.

Une copie dudit état comptable restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide qu'en échange de l'apport par PICO de l'ensemble de son patrimoine actif et passif, les cinquante-

deux mille cinq cents (52.500) actions nouvellement émises sont attribuées aux actionnaires de PICO proportionnelle-
ment à leur participation actuelle dans le capital de PICO.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide que la différence entre la valorisation de PICO et le montant de l'augmentation de capital de cent

quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente euros et trente centimes (EUR 184.430,30), soit trois cent cinquante-deux
mille quatre-vingt-onze euros et sept centimes (EUR 352.091.07), soit affectée comme prime de fusion inclus dans un
poste des capitaux propres.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée charge le conseil d'administration de la Société de procéder, conformément à l'article 273, alinéa 2, aux

formalités de publicité et autres mesures exigées par la loi et d'inscrire dans le registre des actionnaires les actions
nouvelles de la Société au nom des actionnaires de PICO.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner

désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000), représenté par quatre-vingt-

dix neuf mille cinq cents (99.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Constatation

L'assemblée constate que les actionnaires de PICO ont approuvé la fusion par assemblée générale en date d'aujourd'hui.
Le notaire soussigné, conformément à l'article 27l, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste

par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. KLEMKE, F. ROLLIN, R. MANCIOCCHI et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2012. LAC / 2012 / 4263. Reçu soixante quinze euros € 75,

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME  délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 6 février 2012.

Référence de publication: 2012017716/116.
(120021824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.

P&amp;S East Growth S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 131.958.

Veuillez noter que deux gérantes de la société ont changé leur adresse comme mentionné ci dessous:
1. Mme Biljana KORUZA demeure désormais à 43, Pohorskega Bataljona, SVN-1000, Ljubljana, (Slovenie).

17157

L

U X E M B O U R G

2. Mme Valeria CHESHKO demeure désormais à 22, Resljeva cesta, SVN-1000, Ljubljana (Slovénie).
Veuillez noter que l'associée unique de la société a changé son adresse comme mentionné ci-dessous:
La société P&amp;S CAPITAL d.o.o., de forme juridique étrangère "druzba z omejeno odgovornostjo.", immatriculée auprès

du "District Court of Liubljana" sous le numéro 1/34289/00, est désormais domiciliée à 56, Slovenska cesta, SVN-1000,
Ljubljana (Slovénie).

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour P&amp;S East Growth S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012002584/18.
(120001262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Caros Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 85.358.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 22 décembre 2011,

que:

- L'Assemblée Générale accepte la démission, avec effet à ce jour, de Monsieur Peter VANSANT de ses fonctions

d'administrateur et d'administrateur-délégué.

- L'Assemblée Générale accepte la démission, avec effet à ce jour, de la société «PROGRESS INVEST S.A.» de ses

fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué.

- L'Assemblée Générale accepte la démission, avec effet à ce jour, de la société «RAVELIN' INVESTMENTS S.A.» de

ses fonctions d'administrateur.

- L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, aux fonctions d'administrateur de Monsieur Gabriel EL RHI-

LANI ayant son adresse professionnelle au 25C, Boulevard Royal. Il est élu jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se
tiendra en l'année 2015 et bénéficiera d'un pouvoir de signature conjointe.

- L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, aux fonctions d'administrateur de Monsieur Paulo Jorge DA

COSTA MAGALHÃES ayant son adresse professionnelle au 25C, Boulevard Royal. Il est élu jusqu'à l'Assemblée Générale
Annuelle qui se tiendra en l'année 2015 et bénéficiera d'un pouvoir de signature conjointe.

- L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, aux fonctions d'administrateur, la société «E&amp;A MANAGE-

MENT S.A.» ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et ayant comme représentant permanent
Monsieur Gabriel EL RHILANI demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Elle est
élue  jusqu'à  l'Assemblée  Générale  Annuelle  qui  se  tiendra  en  l'année  2015  et  bénéficiera  d'un  pouvoir  de  signature
conjointe.

- L'Assemblée Générale accepte la démission, avec effet immédiat, de Monsieur René MORIS de sa fonction de com-

missaire aux comptes.

- L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, comme nouveau commissaire aux comptes la société «D.E.

Révision» ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Elle est élue jusqu'à l'Assemblée Générale
Annuelle qui se tiendra en l'année de 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012003471/36.
(120001907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Patricia International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 34.377.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2011.

Référence de publication: 2012002602/10.
(120001126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

17158

L

U X E M B O U R G

Perthman International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 127.695.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002603/9.
(120000938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Point Out S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 66.617.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002606/9.
(120000714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Sofadem Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 108, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 124.784.

Les Comptes Annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFADEM FINANCES S.A.
Signature

Référence de publication: 2012002679/12.
(120001465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

TMF Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. TMF Luxembourg S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 55.728.

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of the month of December.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette,

there appeared

Scorpius Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 103169 (the “Sole Shareholder”), represented by Me François Felten, maître en droit,
residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 20 December 2011 (such proxy to be registered together with the
present deed), being the sole shareholder of TMF Luxembourg S.A., (the “Company”), a société anonyme having its
registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 55728, incorporated on 26 July 1996 by deed of Me Emile Schlesser, notary residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (the “Mémorial”), number 532 of 19
October 1996.

The articles of association of the Company have been amended for the last time on 24 September 2008 pursuant to

a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial 2612 of 25 October 2008.

The Proxyholder declared and requested the notary to state that:
I. The Sole Shareholder holds all the registered shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken

by it on the item on the agenda.

II. The item on which resolution is to be passed is as follow:
- Amendment of the name of the Company into “TMF Luxembourg Holding S.A.” and amendment of article 1 of the

articles of association of the Company as set forth below:

17159

L

U X E M B O U R G

“ Art. 1. Form and Name. There has been formed a joint stock company (société anonyme) under the name of “TMF

Luxembourg Holding S.A.” (the “Company”). The Company will be governed by these articles of association (the “Arti-
cles”) and the relevant legislation.

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.”

Thereafter, the following resolution was passed:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company to "TMF Luxembourg Holding S.A." and to amend

article 1 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at € 1,400.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le trentième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

a comparu

Scorpius Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
103169 (l'«Associé Unique») ici représentée par Me François Felten, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu
d'une procuration datée du 20 décembre 2011 (laquelle sera enregistrée avec le présent acte) , étant l'Associé Unique
de «TMF  Luxembourg S.A.»  (la «Société»), une  société  anonyme ayant  son siège social  au 1,  Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 55728 constituée le 26
juillet 1996 suivant un acte reçu de Me Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le «Mémorial») sous le numéro 532 le 19 octobre 1996.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 24 septembre 2008 en vertu d'un acte du notaire

Henri Hellinckx, résidant à Luxembourg, publié au Mémorial numéro 2612 du 25 octobre 2008.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. L'Associé Unique détient la totalité des parts sociales émises dans la Société, de sorte qu'elle peut valablement

prendre des résolutions sur le point porté à l'ordre du jour.

II. le point sur lequel la résolution doit être passée est le suivant:
- Changement de dénomination de la Société en «TMF Luxembourg Holding S.A.», et modification subséquente de

l'article 1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination et Forme.  Il a été formé une société anonyme sous le nom de "TMF Luxembourg Holding

S.A." (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts (les «Statuts») et la législation pertinente.

La Société peut avoir un seul actionnaire (l' «Actionnaire Unique») ou plusieurs actionnaires. La Société ne sera pas

dissoute par la mort, la suspension des droits civils, l'insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l'Actionnaire Unique.»

Ensuite, les résolutions suivantes ont été passées:

<i>Première résolution

L'Actionnaire Unique a décidé de changer la dénomination de la Société en «TMF Luxembourg Holding S.A.» et de

modifier l'article 1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur indiquée dans la résolution écrite.

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont estimés à € 1.400,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante,
en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

17160

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Felten, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 janvier 2012. Relation: EAC/2012/33. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002718/87.
(120001158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

I.30 Foetz "Avenir", Société à responsabilité limitée,

(anc. A.20 S.O.S. Techniques Guy Rollinger).

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 72.912.

L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

La société anonyme I.01 EURO-IMMO GUY ROLLINGER (RC B67.697), avec siège social à L-3980 Wickrange, 4-6,

rue des Trois Cantons,

ici représentée par son administrateur unique, Guy ROLLINGER, demeurant professionnellement à Wickrange,
nommé à ces fonctions lors d'une assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2009, publié au Memorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 707 du 2 avril 2010, habilité à engager la société par sa seule signature et
agissant sur base de l'article 6 des statuts,

associée unique de la société à responsabilité limitée A.20 S.O.S. TECHNIQUE GUY ROLLINGER, établie et ayant

son siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro B72.912, constituée suivant acte du notaire Jean SECKLER de Junglinster en date du 18 novembre 1999, publié
au Memorial C, numéro 93 du 27 janvier 2000, modifié suivant acte dudit notaire SECKLER en date du 18 février 2003,
publié au Memorial C, numéro 422 du 17 avril 2003.

D'abord, la comparante, représentée comme il est dit, déclare être propriétaire des cent (100) parts sociales de la

société suivant cession de parts sous seing privé datée du 8 décembre 2011,pour les avoir acquises comme suit:

- une (1) part sociale de la société à responsabilité limitée A.03 DATAGLOBAL, et
- quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales de la société à responsabilité limitée A.01 EURO-ARTISAN GUY ROLLIN-

GER,

laquelle cession, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et la comparante, restera annexée au

présent acte pour être formalisée avec lui.

Est intervenu aux présentes, Guy ROLLINGER, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société, qui déclare

accepter au nom de la Société les cessions qui précèdent, conformément à l'article 1690 du Code Civil et dispense la
cessionnaire à faire signifier lesdites cessions à la Société, déclarant n'avoir aucune opposition et aucun empêchement à
faire valoir qui puissent arrêter leur effet.

Ensuite, l'associée unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite aux cessions susmentionnées, l'associée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

- I.01 EURO-IMMO GUY ROLLINGER, cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100."

<i>Deuxième résolution

Elle décide de modifier la dénomination de la société et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

Art. 2. La société prend la dénomination de I.30 Foetz "Avenir"."

<i>Troisième résolution

Elle décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent de modifier l'article 3 des statuts comme suit:

17161

L

U X E M B O U R G

Art. 3. La société a pour objet la gestion de sociétés, l'achat et la vente, la gestion, l’échange, la location, la promotion

et la mise en valeur d’immeubles ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet
social.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société
peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts,  avances  ou  garanties.  La  société  pourra  emprunter  avec  ou  sans  garantie  ou  se  porter  caution  pour  d’autres
personnes morales et physiques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gements en faveur de tiers."

Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: ROLLINGER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 23 décembre 2011. Relation: REM/2011/1777. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 29 décembre 2011.

Référence de publication: 2012002887/71.
(120001715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Mobile Shredding Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 98.183.

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire prises en date du 5 octobre 2010

1. Démission des administrateurs:
L’Associée Unique prend acte de la démission de M. Pierre Anselot, M; Daniel Laurent, Mobile Shredding Belux SA et

de la S.A. Oil Exchange en tant qu’administrateurs de la Société avec effet immédiat. L’Associée Unique prend également
acte de la démission de M. Pierre Anselot de sa fonction d’administrateur-délégué.

2. Nomination des administrateurs
L’Associée Unique décide par écrit de nommer les personnes suivantes en tant qu’administrateurs avec effet immédiat.
1. Monsieur James Rudyk, domicilié à 89 Kenollie Avenue, Missisauga, L5G 2H7, Ontario, Canada, né le 16.06.1966 à

Burlington, Canada;

2. Monsieur Robert Guice, domicilié à Wildside, Heath Ride, Wokingham, Berkshire, RG40 3QJ, Royaume-Uni, né le

19.09.1966 à Royal Leamington SPA, Royaume-Uni; et

3. Mme Brenda Frank, domiciliée à 4 Kings Drive, Old Westbury, 11568 New York, USA, née le 18.12.1969 à New

York, USA;

Leur mandat s’achèvera lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2016.

<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration prises en date du 6 octobre 2010

1. Nomination des nouveaux administrateurs-délégués
Le Conseil décide de nommer (i) Monsieur Robert Guice, domicilié à Wildside, Heath Ride, Wokingham, Berkshire,

RG40 3QJ, Royaume-Uni, né le 19.09.1966 à Royal Leamington SPA, Royaume-Uni et (ii) Monsieur James Rudyk, domicilié
à 89 Kenollie Avenue, Missisauga, L5G 2H7, Ontario, Canada, né le 16.06.1966 à Burlington, Canada, en tant qu’admi-
nistrateurs-délégués de la Société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

17162

L

U X E M B O U R G

<i>Pour MOBILE SHREDDING LUXEMBOURG

Référence de publication: 2012003859/29.
(120003061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Barnes Group Luxembourg (No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.700,00.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 110.187.

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société en date du 30 décembre 2011

En date du 30 décembre 2011, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D’accepter la démission de la personne suivante:
- Madame Christel Angela Damaso en tant que gérante de classe A avec effet au 31 décembre 2011.
De nommer la personne suivante en tant que gérant de classe A de la Société:
- Monsieur Louis Johannes de Lange, né le 23 mai 1969 à Eindhoven, aux Pays-Bas, résidant professionnellement au

69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2012 et pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

<i>Gérants de classe A:

Monsieur Franklin Louis Weidema
Monsieur Louis Johannes de Lange

<i>Gérants de classe B:

Monsieur Christopher J. Stephens JR
Monsieur Gregory A. Marshall
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Barnes Group Luxembourg (No. 1) S.à r.l.

Référence de publication: 2012002980/25.
(120002061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

L.C.A. S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 165.829.

STATUTS

L'an deux mille onze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Madame Paula Cristina OLIVEIRA DA CRUZ SOARES TEIXEIRA, indépendante, demeurant à L-8546 Hostert, 15, rue

de la Citée.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle qu'elle constitue par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet tous travaux de plafonnage, façade, rénovation et peinture avec l'achat et la vente des

articles de la branche.

La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son

objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification
essentielle de celui-ci.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "L.C.A S.à r.l.".

17163

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Le siège social est établi à Steinsel.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400.-) divisé en CENT PARTS

SOCIALES (100) de CENT VINGT-QUATRE EUROS (EUR 124.-) chacune.

Art. 7. L’associé reconnaît que le capital de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400.-) a été intégra-

lement libéré par un apport en nature de même montant ainsi que le constate l’état du matériel dont l’estimation a été
faite par le futur associé sous son unique responsabilité, lequel état après avoir été signé «ne varietur» par le comparant
et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé, de sorte que le montant de
DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2012.

<i>Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ NEUF CENTS EUROS (EUR 900.-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires

en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

<i>Décisions

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Madame Paula Cristina OLIVEIRA DA CRUZ SOARES TEIXEIRA, demeurant à L-8546 Hostert, 15, rue de la Citée.
2.- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
Monsieur Manuel LAGOA DOS SANTOS, indépendant, demeurant à L-1839 Luxembourg, 25, rue Joseph Junck.
3.- La société est valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.
4.- Le siège social est établi à L-7333 Steinsel, 50 rue des Prés.

17164

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Oliveira da Cruz Soares Teixeira, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17654. Reçu: soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2012.

Référence de publication: 2012003202/87.
(120001691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Taxcom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 125.609.

J'ai l'honneur de vous informer que je suis le conseil de Monsieur Michel TROUVAIN, demeurant à F-13530 Trets,

41, route de Gardanne.

Mon mandant me charge de signaler par la présente sa démission avec effet immédiat comme administrateur dans la

société anonyme TAXCOM S.A. (B125609), établie à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Nicky STOFFEL
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2012002706/14.
(120000974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Triple S S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8180 Kopstal, 8, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 118.724.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012002724/11.
(120000814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Capitale Ingenium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 110.618.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 07 Juin 2011 à 11 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- Réélection du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.
Sont réélus Administrateurs:
- Monsieur André HELF, Administrateur de sociétés, né le 18 Novembre 1966 à Essen (D), demeurant Im Ahorngrund,

61 - D-50996 Köln-Hahnwald.

- Monsieur Janko SIEGERT, Administrateur de sociétés, né le 28 Février 1956 à Immenstadt im Allgaü (D), demeurant

Im Schildchen, 17 - D-50259 Pulheim.

- Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, né le 27 Avril 1962 à Blois (F), demeurant 36, Domaine Op

Hals -L-3376 Leudelange.

Est réélu Commissaire aux Comptes:
- I.G. INVESTMENTS S.A., Société de droit luxembourgeois, R.C. B 66.562, avec siège social 63-65, Rue de Merl -

L-2146 Luxembourg.

17165

L

U X E M B O U R G

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée Générale

Ordinaire de 2016.

2 - Conformément à l'Article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'Article 5 des statuts, le Conseil d'Ad-

ministration décide de réélire Monsieur André HELF, aux fonctions d'Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs pour
engager la société par sa seule signature.

3 - Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur.

Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2012004092/29.
(120002937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Sustainable Energy One S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 164.048.

In the year two thousand and eleven, the ninth day of November.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of Sustainable Energy One S.A. (formerly

named Sustainable Energy One S.à r.l.), a public limited company limited by shares (société anonyme) incorporated and
organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Heinrich Heine, L-1720
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 164.048 (the Company). The Company was incorporated on September 29, 2011 under the form of a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary
residing in Esch-sur-Alzette, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of
association of the Company (the Articles) have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on November
7, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints as secretary of the Meeting (the Secretary) and the Meeting elects Torsten Sauer, lawyer,

residing professionally in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The shareholder of the Company represented at the Meeting and the number of shares in the Company held are

indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the repre-
sentative of the shareholder and the members of the Bureau.

The proxy from the shareholder represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxyholder

and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the undersigning notary to enact the following:
I. that thirty-one thousand (31,000) shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each, representing 100% (one

hundred per cent) of the share capital of the Company are represented at the Meeting, which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. that the agenda of the Meeting is the following:
1. increase of the share capital of the Company by an amount of one million euro (EUR 1,000,000) in order to bring

it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) represented by thirty-one thousand (31,000) bearer
shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, to one million thirty-one thousand euro (EUR 1,031,000), by way
of the issuance of one million (1,000,000) new bearer shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each;

2. subscription to and payment for the share capital increase by a contribution in cash;
3. amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) to reflect the above share

capital increase;

4. miscellaneous.
III. Then, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million euro (EUR

1,000,000) in order to bring it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) represented by thirty-
one thousand (31,000) bearer shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, to one million thirty-one thousand

17166

L

U X E M B O U R G

euro (EUR 1,031,000), by way of the issuance of one million (1,000,000) new shares having a nominal value of one euro
(EUR 1) each.

<i>Subscription and Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares that it subscribes for the one million (1,000,000) newly

issued shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each and pays them up by way of a contribution in cash in the
amount of one million euro (EUR 1,000,000), which will be entirely allocated to the nominal share capital account of the
Company.

The aggregate amount of one million euro (EUR 1,000,000) is at the disposal of the Company, evidence of which has

been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, which will

henceforth read as follows:

“5.1. The share capital is set at one million thirty-one thousand euro (EUR 1,031,000) represented by one million

thirty-one thousand (1,031,000) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.”

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately two thousand three hundred Euros (EUR 2,300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and, in case of discrepancies between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the members of the bureau, they signed together with us, the notary, the present

original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

s’est tenue pour une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’actionnaire de Sustainable Energy One S.A.

(anciennement dénommée Sustainable Energy One S.à r.l.), une société anonyme constituée et organisées selon les lois
du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.048
(la Société). La Société a été constituée le 29 septembre 2011 sous la forme d’une société à responsabilité limitée suivant
un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant
un acte du notaire instrumentant le 7 novembre 2011, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.

L’Assemblée est présidée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg (le

Président).

Le Président désigne comme secrétaire de l’Assemblée (le Secrétaire) et l’Assemblée désigne Torsten Sauer, avocat,

de résidence professionnelle à Luxembourg, comme scrutateur de l’Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont ensemble désignés comme le Bureau de l’Assemblée.
L’actionnaire de la Société représenté à l’Assemblée et le nombre d’actions de la Société qu’il détient sont mentionnés

sur la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le mandataire de l’ac-
tionnaire et les membres du Bureau.

La procuration de l’actionnaire représenté à l’Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le

notaire instrumentant restera également annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enre-
gistrement.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président demande au notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que trente et un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, représentant cent

pour cent (100%) du capital social de la Société, sont dûment représentées à l’Assemblée qui est par conséquent vala-
blement constituée et peut délibérer sur tous les points de l’ordre du jour, reproduit ci-après;

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Décision d’augmenter le capital social de la Société d’un montant d’un million d’euros (EUR 1.000.000) afin de le

porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par trente et un mille (31.000) actions

17167

L

U X E M B O U R G

au porteur ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, à un million trente et un mille euros (EUR 1.031.000),
par l’émission d’un million (1.000.000) d’actions au porteur, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;

2. Souscription et libération de l’augmentation du capital social par un apport en numéraire;
3. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin d’y refléter l’augmentation de

capital sociale ci-dessus;

4. Divers.
III. L’Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Actionnaire  Unique  décide  d’augmenter  le  capital  social  de  la  Société  d’un  montant  d’un  million  d’euros  (EUR

1.000.000) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par trente et
un mille (31.000) actions au porteur ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, à un million trente et un mille
euros (EUR 1.031.000), par l’émission d’un million (1.000.000) d’actions, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1)
chacune.

<i>Souscription - Libération

L’Actionnaire Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire au million (1.000.000) d’actions nou-

vellement émises, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune et les libère entièrement par un apport en
numéraire d’un montant d’un million d’euros (EUR 1.000.000), qui sera intégralement affecté au compte de capital social
nominal de la Société.

Le montant d’un million d’euros (EUR 1.000.000) est immédiatement à la disposition de la Société, dont la preuve a

été donnée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’Actionnaire Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts, qui aura

désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social est fixé à un million trente et un mille euros (EUR 1.031.000), représenté par un million trente

et un mille (1.031.000) actions, ayant une valeur d’un euro (EUR 1) chacune.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

raison du présent acte sont estimés approximativement à deux mille trois cents Euros (EUR 2.300,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande de la personne comparante ci-dessus, le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé, ensemble avec le notaire, l’original

du présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, T. SAUER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51353. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2012003335/139.
(120001765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Dolis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 110.785.

L'an deux mille onze, le vingt-huit novembre,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, s'est tenue l'assemblée générale extraor-

dinaire des actionnaires de la société "DOLIS S.A.", société anonyme, avec siège social au 15-17 avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.785,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, résidant à Esch-sur-Alzette, en date du 12 décembre 2005,
publié au Mémorial C le 24 janvier 2006. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un
acte de Maître Joseph Elvinger, en date du 7 août 2011 publié au Mémorial C numéro 1951 du 25 août 2011.

17168

L

U X E M B O U R G

La séance est ouverte sous la présidence de Marcus Peter, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne

comme secrétaire Frédéric Lemoine, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Sandrine Bruzzo, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Qu'en date du 28 octobre 2011, une première assemblée générale extraordinaire a été tenue devant le notaire

instrumentaire. Le mandataire de l'actionnaire minoritaire conformément à l'article 67 alinéa 5 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales tel que modifiée a demandé la prorogation de l'assemblée générale. Les actionnaires ont
marqué leur accord pour se réunir avec le même ordre du jour le lundi 28 novembre 2011 dans les bureaux de l'étude
Bonn Schmitt Steichen, 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg à 13h00.

II. Que les actionnaires ont acté lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2011 que le point 3 de

l'ordre du jour comportait une erreur matérielle. Il devait être lu l'acte notarié en date du 7 juin 2011 et non en date du
25 août 2011.

III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1. Décision d'annuler la résolution relative à l'augmentation de capital adoptée lors de l'acte notarié passé par devant

le notaire Maître Joseph Elvinger en date du 7 juin 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n°
1951 en date du 25 août 2011.

2. Confirmation que suite à l'annulation de la résolution relative à l'augmentation de capital le premier alinéa de l'article

5 des statuts de la société a la teneur suivante:

 Art. 5.1 

er

 . Alinéa.  Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000.- EUR) représenté par cent (100)

actions sans désignation de valeur nominale, chacune disposant d'une voix aux assemblées générales."

3. Confirmation que les autres résolutions adoptées lors de l'acte notarié en date du 7 juin 2011 restent en vigueurs

et inchangées.

IV. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent procès-verbal les procurations des actionnaires représentés après avoir

été paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

V. Qu'il apparaît de cette liste de présence que l'intégralité des cent (100) actions représentant l'entièreté du capital

de quatre cent mille euros (400.000 EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

VI. Que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a

été communiqué par l'envoi par lettre recommandée de convocations datées du 17 novembre 2011.

VII. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

dont les actionnaires ont été informés avant l'assemblée.

Le mandataire de l'actionnaire minoritaire signale à l'assemblée que sa mandante a dû entreprendre des actions judi-

ciaires aux fins de demander la suspension et l'annulation des résolutions prises le 07 juin 2011 et que suite à l'ordonnance
des référés cette assemblée a été convoquée. Le mandataire de l'actionnaire majoritaire fait remarquer qu'il aurait pu
faire droit à l'annulation dès le 28 octobre 2011.

VIII. Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membres du bureau, l'assemblée passe à l'ordre du

jour.

Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'annuler la résolution relative à l'augmentation de capital adoptée lors de l'acte notarié passé par

devant le notaire Maître Joseph Elvinger en date du 7 juin 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association
n°1951 en date du 25 août 2011.

Pour: 100 actions
Contre: 0
Abstention: 0

<i>Seconde résolution

L'assemblée décide de confirmer que suite à l'annulation de la résolution relative à l'augmentation de capital le premier

alinéa de l'article 5 des statuts de la société a la teneur suivante:

 Art. 5.1 

er

 . Alinéa.  Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000.- EUR) représenté par cent (100)

actions sans désignation de valeur nominale, chacune disposant d'une voix aux assemblées générales."

Pour: 100 actions

17169

L

U X E M B O U R G

Contre: 0
Abstention: 0

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de confirmer que les autres résolutions adoptées lors de l'acte notarié en date du 7 juin 2011

restent en vigueurs et inchangées.

Pour: 70 actions
Contre: 30 actions
Abstention: 0

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en

raison du présent acte sont évalués à mille cinq cents euros (€ 1.500,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de diver-
gence entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par

leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Peter, Lemoine, Bruzzo, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16572. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012003667/91.
(120002520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Triple S S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8180 Kopstal, 8, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 118.724.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012002725/11.
(120000815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Alternative Property Income Venture S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 124.359.

EXTRAIT

En date du 14 décembre 2011, les associés de la Société ont pris les décisions suivantes:
- de renommer les membres du Conseil de Surveillance de la Société, avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée général

qui se tiendra en 2017:

* Monsieur Guillaume Spinner, né le 20 décembre 1973 à Clamart, France et domicilié professionnellement au 100,

Esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense, France;

* Monsieur Albert Hasenberg, né le 20 octobre 1959 à Cologne, Allemagne et domicilié professionnellement à Innere

Kanalstrasse 95, 50823 Cologne, Allemagne;

* Monsieur Richard Pinnock, né le 27 décembre 1959 à Enfield, Grande-Bretagne et domicilié professionnellement au

7, Newgate Street, EC1A 7NX London, Grande-Bretagne;

- de nommer PricewaterhouseCoopers, en qualité de réviseur d'entreprise agréée et domiciliée professionnellement

au 400, route d'Esch, 1014 Luxembourg, Luxembourg avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se
tiendra en 2017.

17170

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Alternative Property Income Venture S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2012003458/23.
(120002052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Triple S S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8180 Kopstal, 8, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 118.724.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012002726/11.
(120000816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Truman Properties S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 137.980.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002729/9.
(120000711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

TV Vertical S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean Baptiste Esch.

R.C.S. Luxembourg B 49.576.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002730/9.
(120000936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Unicorp Seeds S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 147.872.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 03 janvier 2012.

Référence de publication: 2012002731/10.
(120001363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Luxemburger Leben S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 145.024.

<i>Auszug aus dem Protokoll 9. Sitzung des Aufsichtsrates der Luxemburger Leben S.A. 38, av. John F. Kennedy L-1855 Luxemburg

<i>am 17.10.2011

1. Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
... bisherigen Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Peter Hanus, ... Niederlegung des Amtes aIs Vorsitzender und

Mitglied des Aufsichtsrates ... Herr Thomas Tenkamp, geboren am 11.06.1963 in Velen, geschaftsansassig in Provinzial-
Allee 1. D-48131 Münster, aIs neues Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.

Référence de publication: 2012002850/13.
(120001495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

17171

L

U X E M B O U R G

UCXA Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 57.840.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration le 20 décembre 2011

En conformité avec l'article 2 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur

de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg au 63-65 rue de
Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
UCXA MANAGEMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012002864/16.
(120001288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Vantose S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.716.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002735/9.
(120001252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

VCS Environment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.

R.C.S. Luxembourg B 163.123.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 23 décembre 2011.

Référence de publication: 2012002738/10.
(120000873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Venilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3324 Bivange, 38, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 151.609.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002739/9.
(120000776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Vratislavia Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 101.882.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 13 décembre 2011:

Le mandat du commissaire aux comptes, à savoir KPMG Audit a été renouvelé jusqu'à la tenue de l'assemblée générale

de 2016.

17172

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012002741/14.
(120000908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Graal Soft Limited, succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-3835 Schifflange, 39, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.424.

<i>Résolution du gérant de Succursale luxembourgeoise de Graal Soft Limited tenue au siège social le 1 

<i>er

<i> Décembre 2011

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Christian Dazzi, qui désigne aux fonctions de

secrétaire Mademoiselle Julie Brack.

L'Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gérard Lusatti.
Monsieur le Président expose et l'Assemblée constate:
- que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Transfert de siège du 2, rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg, au 39, route d'Esch L-3835 Schifflange à partir du

er

 Janvier 2012.

L'Assemblée reconnaît que les faits ci-dessus tels qu'exposés par le Président sont exacts et que l'Assemblée est dès

lors valablement constituée et apte à délibérer.

<i>Résolutions

1. Le gérant décide de transférer le siège social du 2, me du Fort Wallis L-2714 Luxembourg au 39, route d'Esch L-3835

Schifflange à partir du 1 

er

 Janvier 2012.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 11 heures après signature du présent procès-

verbal par les membres du bureau.

<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2012003119/24.
(120001696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

West Group Participations SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 77.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002743/9.
(120000928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Invision S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 95.141.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 22 décembre 2011,

que:

- L'Assemblée Générale accepte la démission, à compter de ce jour, de Monsieur Peter VANSANT de ses fonctions

d'administrateur et d'administrateur-délégué.

- L'Assemblée Générale accepte la démission, avec effet à ce jour, de la société «PROGRESS INVEST S.A.» de ses

fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué.

- L'Assemblée Générale accepte la démission, avec effet à ce jour, de la société «RAVELIN INVESTMENTS S.A.» de

ses fonctions d'administrateur.

- L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, aux fonctions d'administrateur de Monsieur Gabriel EL RHI-

LANI ayant son adresse professionnelle au 25C, Boulevard Royal. Il est élu jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se
tiendra en l'année 2015 et bénéficiera d'un pouvoir de signature conjointe.

17173

L

U X E M B O U R G

- L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, aux fonctions d'administrateur de Monsieur Paulo Jorge DA

COSTA MAGALHÃES ayant son adresse professionnelle au 25C, Boulevard Royal. Il est élu jusqu'à l'Assemblée Générale
Annuelle qui se tiendra en l'année 2015 et bénéficiera d'un pouvoir de signature conjointe.

- L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, aux fonctions d'administrateur, la société «E&amp;A MANAGE-

MENT S.A.» ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et ayant comme représentant permanent
Monsieur Gabriel EL RHILANI demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Elle est
élue  jusqu'à  l'Assemblée  Générale  Annuelle  qui  se  tiendra  en  l'année  2015  et  bénéficiera  d'un  pouvoir  de  signature
conjointe.

- L'Assemblée Générale accepte la démission, à compter de ce jour, de Monsieur René MORIS de sa fonction de

commissaire aux comptes.

- L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, de la société «D.E. Révision» ayant son siège social au 25C,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à la fonction de commissaire aux comptes. Elle est élue jusqu'à l'Assemblée Gé-
nérale qui statuera en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012003490/36.
(120002051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

White Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 113.991.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002744/9.
(120000705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Woodpecker Capital S.A,, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 149.307.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2012002746/14.
(120000773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

WPP Luxembourg Germany Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 38.207.500,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 157.627.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Référence de publication: 2012002747/10.
(120000886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

17174

L

U X E M B O U R G

Aleris Global Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 44.012.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 115.960.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 28 décembre 2011, que:
1. La démission de Monsieur Christopher Robert CLEGG, né le 15 septembre 1957 à Kodiak, Alaska, Etats-Unis, en

tant que Gérant B de la Société, est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La nomination de Monsieur Alasdair David CRAWFORD, né à Paisley, Royaume Uni, 28 juin 1971, avec adresse

professionnelle au 10 Friedhofstrasse, 8048 Zurich, Suisse, en tant que Gérant B de la société est acceptée avec effet à
partir de la date de la réunion,

3. La nomination de Monsieur Julien FRANÇOIS, né à Messancy, Belgique, le 18 juin 1976, avec adresse professionnelle

au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en tant que Gérant de catégorie A de la société est acceptée avec
effet à partir de la date de la réunion.

4. Le siège social de la Société a été transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle de la personne suivante: Monsieur Matthijs BOGERS, gérant de catégorie A de la

Société, a également changé et est désormais située au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enfin, le siège social de Aleris Holding Luxembourg S.à r.l., l'associé de la Société est également désormais situé au

11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Pour extrait sincère et conforme
Aleris Global Luxembourg S.à r.l.
Représenté par M. Matthijs Bogers
<i>Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2012003456/30.
(120002253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 141.420,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.018.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Référence de publication: 2012002748/10.
(120000869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

MILI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 100.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.845.

<i>Rectificatif du dépôt L110169315 déposé le 25/10/2011

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- Intoll International Limited, an exempted company incorporated under the laws of Bermuda, with registered office

address at Penboss Building, 50 Parliament Street, Hamilton HM 12, Bermuda, registered with Bermuda Registrar of
Companies with registration number 35715, represented by Me Toinon Hoss, maitre en droit, residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated 15 November 2011, and

17175

L

U X E M B O U R G

- Intoll Toronto Roads Ltd., a company continued under the laws of Canada, with its registered office at One Queen

Street East, Suite 2600, Toronto, Ontario, M5C 2W5, and registered with Industry Canada under corporation number
775782-4, represented by Me Toinon Hoss, prenamed, pursuant to a proxy dated 11 November 2011,

Being the shareholders of (the "Shareholders") and holding all one hundred thousand (100,000) shares in issue in "MILI

S.àr.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée en liquidation having its registered office at 46, Place Guillaume
II, L-1648 Luxembourg, incorporated by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, on 26 

th

 February 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial")

under number 827 on 4 

th

 April 2008 and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg

under number B.136.845

The appearing parties declared and requested the notary to record as follows:
(A) The Shareholders are the holders of all one hundred thousand (100,000) shares in issue in the Company, so that

decisions can validly be taken on all items of the agenda.

(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:

<i>Agenda

Rectification of a typographical error (erreur matérielle) in the name of the liquidator set forth in the minutes of the

extraordinary general meeting of the shareholders of the Company by deed of notary Hellinckx number 2741/2011 dated
14 September 2011, by modifying and replacing the reference to "Alter Domus" by "Alter Domus Liquidation Services
S.àr.l. (RCS B142.389)" in the agenda and the minutes.

Thereafter the following resolution was passed:

<i>Sole resolution

The Shareholders decided to rectify a typographical error (erreur matérielle) in the name of the liquidator as set forth

in the minutes of the extraordinary general meeting of the Shareholders by deed of notary Henri Hellinckx number
2741/2011  dated  14  September  2011  by  modifying  and  replacing  the  reference  to  "Alter  Domus"  by  "Alter  Domus
Liquidation Services S.àr.l. (RCS B142.389)" in the agenda and the minutes.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed

by a French translation; at the request of the appearing person, the English text shall prevail in case of any discrepancy
between the English and the French texts.

This document having been read to the appearing person, who is known to the notary by its respective name, first

name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le vingt-neuf du mois de novembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Se sont présentées:
- Intoll International Limited, une exempted company de droit des Bermudes, ayant son siège social au Penboss Building,

50 Parliament Street, Hamilton HM 12, Bermudes, enregistrée au Registrar of Companies des Bermudes sous le numéro
35715, représentée par Me Toinon Hoss, maitre en droit, résidant au Luxembourg, conformément à une procuration
datée du 15 novembre 2011, et

- Intoll Toronto Roads Ltd., une société de droit canadien, ayant son siège social au One Queen Street East, Suite

2600, Toronto, Ontario, M5C 2W5, enregistrée au Industry Canada sous le numéro 775782-4, représentée par Me
Toinon Hoss, maitre en droit, résidant au Luxembourg, conformément à une procuration datée du 11 novembre 2011,

Étant associés de (les «Associés») et détenant toutes les cent mille (100.000) parts sociales émises par «MILI S.àr.l.» (la

«Société»), une société à responsabilité limitée en liquidation ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648
Luxembourg, constituée par acte du notaire Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxem-
bourg, le 26 février 2008, publié au mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (le «Mémorial») numéro 827
du 4 avril 2008 et inscrite auprès du RCS sous le numéro B 136.845.

Les parties représentées ont déclaré et ont demandé au notaire d'acter les suivantes:
(A) Les Associés sont détenteurs de toutes les cent mille (100.000) parts sociales dans la Société, de sorte que ses

décisions peuvent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(B) Les points à propos desquels les résolutions vont être prises sont les suivants:

<i>Ordre du jour

Rectification d'une erreur matérielle dans la dénomination du liquidateur telle que mentionnée dans le procès-verbal

de l'assemblée générale des associés de la Société passée par acte du notaire Hellinckx numéro 2741/2011 daté du 14
septembre 2011, en modifiant et remplaçant la référence à «Alter Domus» par «Alter Domus Liquidation Services S.àr.l.
(RCS B142.389)» dans l'ordre du jour et dans le procès-verbal.

17176

L

U X E M B O U R G

Après approbation de ce qui précède, la résolution suivante a été prise:

<i>Résolution unique

Les Associés ont décidé de rectifier l'erreur matérielle dans la dénomination du liquidateur telle que mentionnée dans

le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Associés passée par acte du notaire Henri Hellinckx numéro
2741/2011 daté du 14 septembre 2011, en modifiant et remplaçant la référence à «Alter Domus» par «Alter Domus
Liquidation Services S.àr.l. (RCS B142.389)» dans l'ordre du jour et dans le procès-verbal.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise et

est suivi d'une version française; à la requête de la personne comparante, la version anglaise fera foi en cas de divergences
entre les deux versions.

DONT ACTE
Après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et demeure, la

personne comparante a signé, avec le notaire, le présent procès-verbal.

Signé: T. HOSS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54919. Reçu douze euros (12.-EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2012003845/89.
(120002814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

Yellowstone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 147.041.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

YELLOWSTONE S.A.

Référence de publication: 2012002749/10.
(120001546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

1 Trade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6454 Echternach, 14, rue des Lilas.

R.C.S. Luxembourg B 81.513.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendelf, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz in Niederanven.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft LIRIS S.A. mit Sitz in L-6454 Echternach, 14, rue des Lilas, eingetragen im Handels-und Firmen-

register Luxemburg unter der Nummer B 104182 (ancien numéro RCS D B 40.72), hier vertreten durch Herrn Roland
EBSEN, Angestellter, wohnhaft in L-6745 Grevenmacher, 12, Kuschegässel, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht,
welche, nachdem diese „ne varietur" durch den Erschienenen und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde,
gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt.

Die Erschienene, erklärt:
1) Dass die Gesellschaft 1 TRADE S.à r.l., mit Sitz in L-6454 Echternach, 14, rue des Lilas, eingetragen im Handelsregister

des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B, Nummer 81513 gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch
den instrumentierenden Notar, am 28. März 2001, veröffentlich im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom
7. November 2001, Nummer 969.

2) Dass das Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von zweiunddreissigtausend

Euro (EUR 32.000,-) hat, eingeteilt in zweiunddreissig (32) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-)

3) Dass die Gesellschaft LIRIS S.A., vorbenannt, alleinige Eigentümerin aller Gesellschaftsanteile ist.
4) Dass die vorgenannte Erschienene, als einzige Gesellschafterin ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft mit sofortiger

Wirkung auflösen zu wollen und sich als Liquidator zu bestimmen.

17177

L

U X E M B O U R G

5) Dass die Erschienene sofort die zweite und dritte ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft einberuft,

gemäss Artikel 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, und beide sofort hintereinander
abhalten wird.

6) Dass die Erschienene, in seiner Eigenschaft als Liquidator, genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der

Gesellschaft 1 TRADE S.à r.l. besitzt, dass sämtliche Passiva beglichen wurde und dass die Passiva in Verbindung mit der
Gesellschaftsauflösung eingezahlt ist; des Weiteren verpflichtet er sich unwiderruflich, dass eventuelle Passiva der Ge-
sellschaft, welche am heutigen Tage noch nicht bekannt und nicht beglichen ist, durch ihn begleichen wird; dass somit
sämtliche Passiva der Gesellschaft beglichen ist.

7) Dass die etwaigen Aktiva dem einzigen Gesellschafter zugeteilt werden.
Der Liquidationsbericht, nachdem dieser „ne varietur" durch die Erschienene und den unterzeichnenden Notar un-

terschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde zwecks Einregistrierung beigebogen.

Die Erschienene ernennt zum Prüfungskommissar die Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A., mit Sitz in L-6793

Grevenmacher, 77, route de Trèves, RCS Luxemburg B 70.580, mit Auftrag den Liquidationsbericht zu überprüfen.

Nachdem die Erschienene Kenntnis genommen hat vom Bericht des Prüfungskommissars, stimmt er den Schlussfol-

gerungen des Berichtes zu, heißt die Liquidationskonten und den Liquidationsbericht gut und erteilt der Gesellschaft
ACCOUNT DATA EUROPE S.A. Entlast für die Ausübung ihres Mandates.

Der Bericht des Prüfungskommissars, nachdem dieser „ne varietur" durch die Erschienenen und den unterzeichnenden

Notar unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde zwecks Einregistrierung beigebogen

8) Dass sie in einer dritten ausserordentlichen Generalversammlung die Auflösung dieser Gesellschaft beschliesst,

welche damit definitiv abgeschlossen ist und die Gesellschaft nicht mehr existiert. Somit ist deren Liquidation mit Wirkung
auf den heutigen Tage beendet.

9) Dass sie dem Geschäftsführer Entlastung für die Ausübung ihres Amtes erteilt.
10) Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in L-6454

Echternach, 14, rue des Lilas, aufbewahrt bleiben werden.

Für alle erforderlichen Schritte, wird dem Eigner einer Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde, Vollmacht erteilt.
Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft festgestellt.

<i>Bevollmächtigung

Der Erschienene erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in seinem

Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

WORUEBER URKUNDE, Aufgenommen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Roland Ebsen, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 décembre 2011. LAC / 2011 / 57062. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 27. Dezember 2011.

Référence de publication: 2012002750/63.
(120001009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Calisto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 2, rue de la Grève.

R.C.S. Luxembourg B 108.707.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social Le 20 Décembre 2011 à 10 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1 - L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 2, Rue de la Grève -L- 1643 Luxembourg.
2 - L'Assemblée accepte la démission du Conseil d'Administration:
- Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, né le 27 avril 1962 à Blois (France), demeurant au 36, Domaine

Op Hals - L-3376 Leudelange.

- Madame Corinne MARQUILIE, comptable, née le 06 Août 1963 à Roubaix (France), demeurant au 36, Domaine Op

Hals -L- 3376 Leudelange.

- Madame Jennifer GYSS, comptable, née le 09 Mai 1979 à Thionville (France), demeurant au 7, Rue Saint Jacques -F-

57855 Saint Privat La Montagne.

L'Assemblée élit en remplacement:

17178

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Patrick BRUNCHER, ingénieur, né le 22 Mars 1951 à Neufchâteau (France), demeurant au 9, Rue des

Rougeottis -F- 57140 Saulny (France).

- Madame Muriel EISERLOH, directrice commerciale, née le 12 Novembre 1964 à Metz (France), demeurant au 9, Rue

des Rougeottis -F- 57140 Saulny (France).

- SCOTT INTERNATIONAL S.A., société avec siège social au 63-65, Rue de Merl -L- 2146 Luxembourg, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B82851.

Les mandats des nouveaux Administrateurs expireront à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2017.
3 - L'Assemblée accepte la démission de l'Administrateur-Délégué:
- Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, né le 27 avril 1962 à Blois (France), demeurant au 36, Domaine

Op Hals - L-3376 Leudelange.

L'Assemblée élit en remplacement:
- Monsieur Patrick BRUNCHER, ingénieur, né le 22 Mars 1951 à Neufchâteau (France), demeurant au 9, Rue des

Rougeottis -F- 57140 Saulny (France), avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, soit par la signature
conjointe de l'Administrateur-Délégué et d'un autre membre du Conseil d'Administration.

Le mandat de l'Administrateur-Délégué prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2017.

Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2012004090/35.
(120002910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

BI-Invest Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.921.

EXTRAIT

Les actionnaires de la Société ont décidé en date du 27 Décembre 2011:
- d'accepter la démission de Monsieur Michel Thill né le 8 Juin 1965, Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle

au 51, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme administrateur de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;

- de nommer Monsieur Eckart Vogler, né le 24 Octobre 1970 à Brême (Allemagne), ayant son adresse professionnelle

au 51, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme administrateur de la Société avec effet au 6 Décembre 2011, et jusqu'
après la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2012002753/18.
(120000575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Biotech Foods S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.570.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé en date du 28 Décembre 2011:
- d'accepter la démission de Monsieur Michel Thill né le 8 Juin 1965, Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle

au 51, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;

- de nommer Monsieur Eckart Vogler, né le 24 Octobre 1970 à Brême (Allemagne), ayant son adresse professionnelle

au 51, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 6 Décembre 2011, pour une durée
illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2012002754/18.
(120000440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

17179

L

U X E M B O U R G

Global Motor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.477.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé en date du 28 décembre 2011:
- d'accepter la démission de Monsieur Michel Thill né le 8 juin 1965, Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle

au 51, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;

- de nommer Monsieur Eckart Vogler, né le 24 octobre 1970 à Brême (Allemagne), ayant son adresse professionnelle

au 51, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 6 décembre 2011, pour une durée
illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2012002760/18.
(120000470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Indigo Capital V (Walter) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 151.584.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth of November.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, by virtue of

a power of attorney given under private seal,

acting in her capacity as attorney-in-fact of Indigo Capital V L.P., a limited partnership established and organised under

the laws of England, under registered number LP0012141 and whose principal office is situated at 30 King Street, London
EC2V 8EH, United Kingdom, represented by virtue of a proxy given under private seal, which proxy after having been
signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed to these minutes to be filed with the
registration authorities,

who declared and requested the notary to state that:
1. Indigo Capital V (Walter) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

with  registered  office  at  15,  rue  Edward  Steichen,  L-2540  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and
Companies Register under registration number B 151.584 and having a share capital of EUR 12,500 (hereinafter, the
”Company”), was incorporated on 23 February 2010 by deed of Maître Henry Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C-N° 722 on
7 April 2010.

The articles of association of the Company have not been amended since.
2. The corporate capital of the Company is set at EUR 12,500.- divided into 500 shares having a par value of EUR 25.-

each.

3. Indigo Capital V L.P., aforesaid, is the sole owner of all the shares in the Company (the ”Sole Shareholder”).
4. The Sole Shareholder declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.
5. The Sole Shareholder will act for the purpose of this dissolution as liquidator of the Company (the “Liquidator”);

the Liquidator will have full power to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and
to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of the liquidation of the Company.

6. The Liquidator declares that all liabilities towards third parties known to the Company, including all liquidation costs,

have been entirely paid or are duly accounted for and that it irrevocably undertakes to settle any presently unknown and
unpaid liability of the dissolved Company.

7. The Sole Shareholder subsequently declares that it has taken over all the assets and outstanding liabilities of the

Company, together with the profit and loss account of the Company, so that all assets and liabilities of the Company are
transferred to the Sole Shareholder, with immediate effect.

17180

L

U X E M B O U R G

8. The Sole Shareholder resolves to waive its right to appoint an auditor to the liquidation in charge of reporting on

the liquidation operations carried out by the Liquidator and thus declares that there is no need to hold a second general
meeting and resolves to hold immediately the third and last general meeting.

9. The Sole Shareholder resolves that discharge is given to Mr Ivo Hemelraad and Mr Alan Botfield as A managers and

Vistra (Luxembourg) S.à r.l. as B manager of the Company and any past member of the board of managers of the Company
for the exercise of their respective mandates.

10. The Sole Shareholder resolves that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company

recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

11. The books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at the registered

office of the Company, at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above

mentioned declarations.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by first name, last name, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.

Follows the French version:

L'an deux mille onze, le trente novembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Indigo Capital V L.P., une limited partnership, constituée et opérant

sous le droit du Royaume-Uni, ayant son siège social au 30, King Street, Londres EC2V 8EH, Royaume-Uni, en vertu d'une
procuration sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire
instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement,

qui a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:
1. Que Indigo Capital V (Walter) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 151.584 et ayant un capital social de EUR 12,500 (la Société), a été constituée le 23 février 2010 suivant
un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, publié le 7 avril
2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro C-N° 722. Les statuts de la Société n’ont pas été
modifiés depuis.

2. Que le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,-, divisés en 500 parts sociales d'une valeur nominale de

EUR 25,- chacune.

3. Que Indigo Capital V L.P., préqualifiée, est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de la Société (l'Associé

Unique).

4. Que l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
5. Que l'Associé Unique agira pour les besoins de cette dissolution en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur);

que le Liquidateur aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute
déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6. Que le Liquidateur déclare que tout le passif connu de la Société, y compris les frais de liquidation, a été dûment

réglé ou approvisionné et qu'il s'engage irrévocablement à payer tout passif éventuel non encore connu et non encore
payé de la Société dissoute.

7. Que l'Associé Unique déclare par conséquent reprendre l'intégralité de l'actif et du passif de la Société, ensemble

avec le compte de profits et pertes de la Société, de sorte que l'actif et le passif de la Société sont désormais transférés
à l'Associé Unique avec effet immédiat.

8. Que l'Associé Unique décide de renoncer à son droit de nommer un commissaire à la liquidation en charge de faire

un rapport sur les opérations de la liquidation exécutées par le Liquidateur. N'ayant pas besoin de tenir la deuxième
assemblée générale de liquidation, l'Associé Unique décide de fixer à tout de suite la troisième et dernière assemblée de
liquidation.

9. Que décharge est donnée à M. Ivo Hemelraad et M. Alan Botfield en qualité de gérants A et Vistra (Luxembourg)

S.à r.l., gérant B de la Société, et tout gérant que la Société a eu par le passé, pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

17181

L

U X E M B O U R G

10. Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société

relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.

11. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à Luxembourg à l'ancien siège social

de la Société, au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

En conséquence, le comparant, ès qualité qu'il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivie d'une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,

il a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 9 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16711. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012003748/112.
(120002560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.

KuponOne S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 158.340.

Avec effet au 28 décembre 2011, GLOBAL TRUST ADVISORS SA a dénoncé tout office de domiciliation de la société

KUPONONE S.A., société anonyme, ayant siège social au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B158340.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Référence de publication: 2012002762/11.
(120000246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Hao Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 155.592.

<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 30 décembre 2011

1. M. Christian HEINEN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. M. David SANA a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
3. M. David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gand (Belgique), le 19 janvier 1979, demeurant professionnel-

lement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant de catégorie B pour une
durée indéterminée.

4. M. Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né à Schiltigheim (France), le 23 mai 1978, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant de catégorie A pour
une durée indéterminée.

5. M. Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre

1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé
gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

6. Le nombre des gérants de catégorie B est augmenté de 1 (un) à 2 (deux).

Luxembourg, le 4.1.2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Hao Investments S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012003134/24.
(120001996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

17182

L

U X E M B O U R G

Mareblu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.606.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé en date du 23 Décembre 2011:
- d'accepter la démission de Monsieur Michel Thill né le 8 Juin 1965, Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle

au 51, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;

- de nommer Monsieur Eckart Vogler, né le 24 Octobre 1970 à Brême (Allemagne), ayant son adresse professionnelle

au 51, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 6 Décembre 2011, pour une durée
illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012002766/18.
(120000446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Mobius Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 104.742.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 19 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré

du 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle de la personnes suivante a changée et est désormais:

- Matthijs Bogers, gérant: 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Mobius Capital S.à r.l.
Représentée par Matthijs Bogers
<i>Gérant

Référence de publication: 2012002767/18.
(120000554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.

Hydrus Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.112.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 103.170.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 19 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré

du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle de la personnes suivante a changée et est désormais:
- Matthijs Bogers, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

17183

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Hydrus Investments S.à r.l.
Représentée par Matthijs Bogers
<i>Gérant

Référence de publication: 2012002834/18.
(120001097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Maharaja S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 8, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 111.855.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 janvier 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012004480/14.
(120003805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Luxklima S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 96.224.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012004468/10.
(120003604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Luxembourg Company of Metals &amp; Alloys, Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d'Activité ZARE West.

R.C.S. Luxembourg B 55.567.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012004466/10.
(120003893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

LOVEL Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 147.613.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012004461/14.
(120003801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

17184


Document Outline

1 Trade S.à r.l.

A.20 S.O.S. Techniques Guy Rollinger

Aleris Global Luxembourg S.à r.l.

Alternative Property Income Venture S.C.A.

Barnes Group Luxembourg (No. 2) S.à r.l.

BI-Invest Holdings

Biotech Foods S.à r.l.

Brassco Holding

Calisto S.A.

Capitale Ingenium S.A.

Caros Investments S.A.

Dolis S.A.

Global Motor Holdings S.à r.l.

Graal Soft Limited, succursale de Luxembourg

Hao Investments S.à r.l.

Hydrus Investments S. à r.l.

I.30 Foetz "Avenir"

Indigo Capital V (Walter) S.à r.l.

Invision S.A.

KuponOne S.A.

L.C.A. S.à r.l.

LOVEL Invest S.à r.l.

Luxembourg Company of Metals &amp; Alloys

Luxemburger Leben S.A.

Luxklima S.à r.l.

Maharaja S.à r.l.

Mareblu S.à r.l.

MILI S.à r.l.

Mobile Shredding Luxembourg

Mobius Capital S.à r.l.

Moorea Fund

Patricia International S.A., SPF

Perthman International S.A.

Point Out S.A.

P&amp;S East Growth S.à r.l.

Sofadem Finances S.A.

Sustainable Energy One S.A.

Taxcom S.A.

TMF Luxembourg Holding S.A.

TMF Luxembourg S.A.

Triple S S.à r.l.

Triple S S.à r.l.

Triple S S.à r.l.

Truman Properties S.A.

TV Vertical S.A.

UCXA Management S.A.

Unicorp Seeds S.A.

Vantose S.A.

VCS Environment S.A.

Venilux S.à r.l.

Vratislavia Holdings S.A.

West Group Participations SA

White Investment S.A.

Woodpecker Capital S.A,

WPP Luxembourg Germany Holdings 3 S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings Eight S.à r.l.

Yellowstone S.A.