This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 344
9 février 2012
SOMMAIRE
ACMBernstein Strategies . . . . . . . . . . . . . . .
16477
Amundi Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16467
Andreas Portfolio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
16497
Atos Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16505
Auto Logistic Transport . . . . . . . . . . . . . . . .
16502
AZ FUND Management S.A. . . . . . . . . . . . .
16496
BIL Holding I Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16499
Botulie Invest S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
16470
BRE/Star Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
16478
Calypso Fuchs Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16472
Comptoir Immobilier Luxembourgeois . .
16466
Conafex Holdings Société Anonyme . . . . .
16466
Conafex Holdings Société Anonyme . . . . .
16469
Conceptu'l S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16506
Crebim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16501
Cristina S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16501
D&R IndiGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16475
D&R Multi Asset Strategy . . . . . . . . . . . . . . .
16475
Edalux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16501
ESCF Soparfi A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16493
Euro Motors S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16502
Family Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16511
Farmabios International S.A. . . . . . . . . . . . .
16476
FBP Funds Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16475
Fluglehrer- und Pilotenservice S.à r.l. . . . .
16503
Fu Hua S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16477
Georose 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16505
Georose 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16506
GLL AMB Generali Bankcenter S.à r.l. . . .
16502
i-CAP Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16482
ISPC II LLC Cie. SCS ("société en com-
mandite simple") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16480
Lancelot Ector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16470
LaSalle UK Property Company S.à r.l. . . .
16503
L Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16495
Midgard Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16508
Mirabelle Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
16512
MK Luxinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16497
Murten Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
16507
Murten Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
16507
Novamex - Promotion Industrielle et Fi-
nancière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16472
Riviera Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16466
Rocval S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16510
Royal Bengal S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16510
Sonoco Asia Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
16507
Sörensen-Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16511
Stena Forth Lux 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
16484
The Grande International Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16510
The Grande International Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16510
Tiar Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16512
Tiar Publications S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
16512
Trucks and Trailer Company S.A. . . . . . . .
16512
TÜV Rheinland Luxemburg Gesellschaft
mit beschränkter Haftung . . . . . . . . . . . . .
16476
Vouvray S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16475
V.T.F. 4 Shipping Company S.A. . . . . . . . . .
16510
Zellbios S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16476
16465
L
U X E M B O U R G
Comptoir Immobilier Luxembourgeois, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 13.542.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>29 février 2012i> à 11.30 heures dans les locaux de la société à 12, rue Jean Engling, L-1466
Luxembourg, au quatrième étage.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Président du conseil d'administration
2. Rapport du conseil d'administration concernant l'exercice se clôturant au 31.12.2009
3. Rapport du commissaire aux comptes concernant le même exercice
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Affectation des résultats
6. Elections statutaires
7. Toute question des actionnaires possédant plus de 10% des droits de vote sera ajoutée à l'ordre du jour
8. Divers.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Deux administrateursi>
Référence de publication: 2012017624/535/21.
Riviera Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 52.218.
Les actionnaires sont conviés à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement en date du <i>27 février 2012i> à 8.30 heures avec l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Elections statutaires.
2. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2008, au 31
décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
4. Question de la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012018066/20.
Conafex Holdings Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 17.789.
NOTICE is hereby given of an
ORDINARY GENERAL MEETING
of the Shareholders of the Company to be held at the registered office of the company on <i> 16 i>
<i>thi>
<i> March 2012 i> at 15:00
to consider the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. That representatives of Company and Accounting Services S.A. be appointed as chairman, secretary and scrutineer
of this meeting.
2. To receive and adopt the report of the Liquidator and of the Commissaire-Vérificateur on the liquidation of the
Company.
16466
L
U X E M B O U R G
3. To grant discharge to the Liquidator and to the Commissaire-Vérificateur for the performance of their responsi-
bilities.
4. To pronounce the closure of the liquidation.
5. To authorise Damsor Limited to arrange for the publication of the fact of the closing of the liquidation in necessary
publications.
6. To authorise Damsor Limited to arrange for the cancellation of the registration of the Company with all the
necessary authorities.
7. To authorise the archiving and storage of the books and records of the Company for a period of five years from
the date of the closure of the liquidation with Company and Accounting Services S.A., at 15-17, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg.
Luxembourg, 3 February 2012.
<i>By order of the Board
i>Company and Accounting Services S.A.
<i>Domiciliation Agenti>
Référence de publication: 2012018082/759/29.
Amundi Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 68.806.
Due to the lack of quorum, the extraordinary general meeting of Amundi Funds convened on January 30, 2012 was
not able to validly decide on the items of its agenda. Thus, the Shareholders are hereby convened to attend a new
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
to be held at the offices of AMUNDI LUXEMBOURG, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg on <i>March 14, 2012i> at
11:00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To amend the text of a number of articles of the Articles of Incorporation in order to implement the changes as
required by the new law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "2010 Law"),
implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 (the "UCITS IV
Directive"), and in particular to (not exhaustive summary):
- replace any reference to the law dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references
to the law dated 17 December 2010 on undertakings to collective investment;
- allow the Company to adopt master-feeder structure (see article 15);
- allow the Company to perform cross-sub-fund investments (see article 15); and
- amend the provisions regarding merger of the Company or its sub-funds in order to, inter alia, implement the
rules of the 2010 Law with regard to merger of the Company or its sub-funds with other sub-funds of the Company
or another UCITS or sub-funds thereof (see articles 29 and 30).
2. To amend the object of the Company in article 3 in order to update the reference to the fund legislation. The new
text of Article 3 will read as follows:
"The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities of all types
and all other permitted assets such as referred to in Part I of the law of 17 December 2010 regarding undertakings
for collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the "2010 Law") with the purpose
of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its sub-funds."
3. To amend article 4 in order to provide the Company's board of directors with the authority to decide on potential
transfer of the register office of the Company within the municipality of the City of Luxembourg.
4. To amend article 7 in order to gives to the Board the responsibility to define the "US persons" status in the
Prospectus of the Company.
5. To amend article 10 by the deletion of the end of the second paragraph to remove the requirement of a quorum
for general meetings of not less than one-half of the issued shares of that sub-fund, class or category in question in
order to be in line with the 2010 Law.
6. To amend the second paragraph of article 12 in order to change the period of the functions of the directors of the
Company from one year to six years.
7. To amend article 13 in order to provide the chairman of the Company's board of directors with the authority to
convene board's meetings at the place indicated in the notice of meeting and to have a casting vote in any cir-
cumstances.
8. To amend article 14 in order to foresee the possibility for two directors or any person authorised by the Company's
board of directors with the authority to sign the minutes as well as copies or extracts of such minutes of any
meeting of the board.
16467
L
U X E M B O U R G
9. To amend article 15 in order to be in compliance with the 2010 Law. Notably, there will be the following amend-
ments:
- the board of directors is vested with the broadest powers to appoint a Luxembourg-based management company
or any other management company domiciled in any other EU Member State;
- the addition of the definition of Member State in full compliance with the 2010 Law;
- the flexibility to invest in one or more other sub-funds of the Fund and liquid assets, deposits and other UCITS
or UCIs in full compliance with the 2010 Law;
- the possibility for the Company to adopt master-feeder structure.
10. To amend article 18 in order to foresee the possibility for the chairman of the board, two directors or any repre-
sentative(s), delegate(s) to the daily management or any other authorised agent up to the limit of their powers to
represent the Company in acts, including those in which a civil servant or a legal officer involved and in court and
to bind in any circumstances the Company.
11. To amend article 20 in order to align the text of the Articles of Incorporation to the prospectus with regards to
the right, in the case where requests for redemption and conversion for any Dealing Day exceed 10% of the Net
Asset Value or the number of Shares of a Sub-Fund's shares, to postpone redemption and conversion of all or part
of such Shares to the following dealing day.
12. To amend article 20 in order to remove the descriptions on termination/merger of Sub-Funds/Classes, this is now
described in articles 28 and 30 of the Articles.
13. To amend article 21 in order to provide the Company with the authority to suspend the determination of the net
asset value and the issue and redemption of shares as well as the right to convert shares into shares of another
sub-fund of the company in case of a decision to merge the Company or a Sub-fund thereof provided that any such
suspension is justified for the protection of the Shareholders in order to comply with the provisions of the 2010
Law.
14. To amend article 21 in order to precise four events in the items (c), (e), (f) and (h) in which the Company may
suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of Shares in any Sub-fund as well
as the right to convert Shares of any Sub-fund into Shares of another Sub-fund, as follows:
- when the value of an investment of the Company cannot be determined as accurately and rapidly as required;
- when the restrictions on currencies or cash transfers prevent the completion of transactions of the Company or
when the purchases and sales on behalf of the Company cannot be achieved at normal exchange rates;
- when factors related to, among others, the political, economic, military, monetary, and fiscal situation and escaping
the control, the responsibility and the means of action of the Company prevent it from disposing of the assets of
one or more Sub-funds or determining the net asset value of one or more Sub-funds of the Company in a usual
and reasonable way
- in case of a decision to merge the Company or a Sub-fund thereof provided that any such suspension is justified
for the protection of the Shareholders.
15. To amend article 24 in order to no longer communicate to the shareholders the annual accounts, including the
balance sheet and profit and loss account and the directors' report but to put them at the disposal of the share-
holders upon request annual accounts, including the balance sheet and profit and loss account and the directors'
report in order to comply with the provisions of the 2010 Law.
16. To amend article 26 order to align the text of the Articles of Incorporation to the prospectus with regards to the
right to appoint investment managers and sub-investment managers not belonging to CREDIT AGRICOLE and to
appoint investment advisors.
17. To amend article 27 in order to update it with the 2010 Law concerning the liquidation of the Company and notably
precise that:
- the Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting subject to the quorum and
majority requirements referred to in Article 10 of the Articles
- the liquidators shall realise the Company's assets in the best interest of the shareholders and shall distribute the
net proceeds.
18. To add article 28 concerning the liquidation of sub-fund/class in order to comply with the 2010 Law and to describe
the related liquidation process separately from the description of the liquidation of the Company as stated in article
27.
19. To add article 29 concerning the merger of the Company in order to comply with the 2010 Law and to state that
the Company may, either as a merging company or as a receiving company, be subject to cross-border or domestic
merger and that the Board of the Company will be competent to decide on such a merger in case the Company is
the receiving company.
20. To add article 30 concerning the merger of sub-fund(s) in order to comply with the 2010 Law and to state that the
sub-funds of the Company may be subject to cross-border and domestic mergers and that the Board of the Com-
pany will be competent to decide on such mergers.
21. To amend article 32 (formerly article 29) as follows: "All matters not governed by these Articles shall be determined
in accordance with the 2010 Law, or subjected to the Law of 10th August 1915 on Commercial Companies, as the
case may be. In case of contradiction with the provisions of the Articles, the imperative provisions of the 2010 Law
will prevail, or as the case may be the imperative provisions of the Law of 10th August 1915"
16468
L
U X E M B O U R G
22. To delete the second paragraph of article 32 (formerly article 29) in order to implement the derogation laid down
in Article 26 (2) of the 2010 Law that allow to have only one version of the articles of incorporation of the Company
in French or English with no need of a translation into an official language.
23. To completely restate the Articles of Incorporation with effect as of the date that will be resolved by the extraor-
dinary general meeting in order to reflect the various amendments adopted by the extraordinary general meeting
and resolve that the only version of the Articles of Incorporation will be the English version.
24. To resolve that the effective date of the resolutions of the above agenda shall become effective on the date of the
extraordinary general meeting."
25. Miscellaneous.
The draft text of the restated Articles of Incorporation is available on request at the registered office of the Company.
Shareholders are advised that:
- the rights of shareholders to attend a general meeting and to exercise a voting right are determined according to
their shares held at the fifth day prior the general meeting at midnight (Luxembourg time),
- the meeting does not require any quorum in order to deliberate and that the resolutions shall be passed at the
majority of the two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting.
If you wish to attend the meeting in person, we would be most grateful if you would communicate your intention to
us at latest two business days before the meeting.
If you are unable to attend the meeting in person, a proxy form can be obtained from the registered office of the
Company or from local agent and have to be sent to AMUNDI LUXEMBOURG, 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
(Fax:+352 47 67 37 81) at the latest two business days before the meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012019191/755/127.
Conafex Holdings Société Anonyme, Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 17.789.
NOTICE is hereby given of an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Shareholders of the Company to be held in the presence of Me Martine Schaeffer, notary residing at 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg on <i> 29 i>
<i>thi>
<i> February 2012 i> at 15:00 and at any adjournment thereof to consider the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. That a representative of Company and Accounting Services S.A. be appointed as chairman of this meeting.
2. To receive and approve the financial statements for the year ended 30/09/2011 and from 1/10/2011 to 28/02/2012
of the Company placed before the meeting by the Board.
3. To place the Company into liquidation.
4. To appoint Damsor Limited, with registered office at 40, Woodborough Road, Winscombe, Somerset, BS25 1AG,
United Kingdom as Liquidator of the Company ("the Liquidator") and to confer upon the Liquidator the widest
powers permitted under Luxembourg law for the purposes of winding up the affairs of the Company.
5. That subject to and conditional upon resolutions 3 and 4 set out in the notice convening this Extraordinary General
Meeting having been passed the Liquidator be authorised to realise all the remaining assets and to settle all the
remaining liabilities of the Company, and to appoint an agent for the distribution to specified shareholders, of shares
in Conafex Africa Holdings Ltd in exchange for their shareholdings in Conafex Holdings S.A., and to appoint a paying
agent to pay the remaining shareholders the value of their shares.
6. To appoint IAS CONSULTING LTD, with registered office at Waterdale, Redmans Hill, Blackford, Wedmore,
Somerset, BS28 4 NQ, United Kingdom as Commissaire-Vérificateur to the liquidation.
7. To ratify the notice of the second Extraordinary General Meeting by the Directors despatched with this notice.
Note: the Share Register of the company will be closed for transfers from 27
th
February 2012
Luxembourg, 3 February 2012.
<i>By order of the Board
i>Company and Accounting Services S.A.
<i>Domiciliation Agenti>
Référence de publication: 2012018083/759/32.
16469
L
U X E M B O U R G
Botulie Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 149.649.
Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été
atteint lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire par-devant notaire du 2 février 2012, l'assemblée n'a pas pu statuer
sur ces points de l'ordre du jour.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>12 mars 2012i> à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation
2. Désignation d'un liquidateur et détermination de ses prérogatives
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes jusqu'au jour de la liquidation
4. Divers
Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et
pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012019192/795/21.
Lancelot Ector, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 54.040.
Notice is hereby given that the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company (the "Meeting") will be held on <i>14 March 2012i> at 2:30 p.m. CET (Luxembourg
time) at the registered office of the Company at 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg in front of a
Luxembourg civil law notary for the purpose of voting and deliberating on the items of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To transfer the registered office of the Company to 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald (municipality of Hespe-
range), with effective date on 1st April 2012 and consequently to amend the first sentence in article 2 of the
Company's articles of association (the "Articles) so as to read as from that date as follows:
"The registered office of the Company is established in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg."
2. To amend article 4 of the Company's Articles and any subsequent articles to replace the references to the law of
20th December 2002 and to the "Law of 2002" by references to the Law of 17th December 2010 as may be amended
from time to time and to the " 2010 Law" and the according restatement of the text.
Article 4 of the Company's Articles shall henceforth read as follows:
"Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities
and other liquid financial assets permitted by law with the aim of spreading investment risks and affording its
shareholders the results of the management of its assets.
The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment
and development of its purpose to the largest extent permitted under the Luxembourg law of December 17th,
2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law")."
3. To delete from article 6 of the Articles any references to bearer shares namely by deleting in item 1, the first sub-
paragraph, the fourth and fifth sub-paragraph and the first sentence of item 2 and re-inserting a new first line in
item 1 as follows: "The Company will only issue registered shares."
4. To refer in article 10 item D fifth sub-paragraph of the Articles to US Persons as defined in this article and/or in
the current prospectus, constituting possibly a specific category of Prohibited Persons.
5. To clarify the heading and the second sub-paragraph of article 12 of the Articles by specifying that the Board of
Directors is entitled to suspend the calculation of a respective Sub-Fund's net asset value and the issue, redemption
and conversion (if applicable) of shares and to provide for two further suspension events by adding two further
indents to such paragraph as follows:
"- in the event of the publication (i) of the convening notice to a general meeting of shareholders at which a resolution
to wind up the Company or a Sub-Fund is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors to wind
16470
L
U X E M B O U R G
up one or more Sub-Funds, or (ii) to the extent that such a suspension is justified for the protection of the share-
holders, of the notice of the general meeting of shareholders at which the merger of the Company or a Sub-Fund
is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors to merge one or more Sub-Funds; or
- where in the opinion of the Board of Directors, circumstances which are beyond the control of the Board of
Directors make it impracticable or unfair vis-à-vis the shareholders to continue trading the shares or in any other
circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Company or its shareholders incurring
any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or other detriment to which the Company or
its shareholders might not otherwise have suffered."
6. To delete in Article 14 of the Articles any reference to telegrams as means of communication for any matter
releated to the Board of Directors as such means of communication is outdated and to update sub-paragraph 6 of
such Article as follows: "A Director may attend, and be considered as being present at, a meeting of the Board of
Directors by means of a videoconference or telephone conference or other telecommunication means permitting
their identification and by operation of which all persons participating in the meeting can hear each other and speak
to each other. Such means shall satisfy technical characteristics which ensure an effective participation at the meeting
of the Board of Directors whose deliberations should be online without interruption. Such a board meeting held
at distance by way of such communication means shall be deemed to have taken place at the registered office of
the Company. Directors may also cast their vote in writing, by cable, facsimile, email or any other electronic means
capable of evidencing such vote."
7. To add in Article 18 sub-paragraph 3 of the Articles Singapore and Brazil to the list of issuers / guarantors of
transferable securities and money market instruments into which up to 100% of the assets of each Class of Shares
of the Company can be invested.
8. To add two new sub-paragraphs to Article 18 of the Articles which allow the set-up of master-feeder Sub-Funds
and cross Sub-Fund investments within the Company.
9. To update in article 22 second sub-paragraph of the Articles the thereshold of shareholders which can convene a
general meeting of shareholders at their own request to 1/10 of the capital.
10. To delete in article 22 the sixth sub-paragraph of the Articles and to record the second sentence of the fifth sub-
paragraph as follows: "The giving of such notice to registered shareholders need not be evidenced to the meeting
if the notice of meeting shall in addition be published as provided by law in the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, in one or more Luxembourg newspapers and in such other newspapers as the Board of Directors
may decide."
11. To add in article 22 eight's sub-paragraph of the Articles the specification "namely that ballot papers shall be received
by the Company no later than on the third Luxembourg bank business day preceding the day of the relevant general
meeting of shareholders."
12. To update in article 22 eleventh sub-paragraph of the Articles that "Unless otherwise provided by law or herein,
resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include
votes in relation to shares in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained
or have returned a blank or invalid vote."
13. To adjust the third sub-paragraph of article 23 of the Articles so as to read: "The relevant provisions of article 22
shall apply to such general meetings." and to update the last sub-paragraph of such article so as to read "Unless
otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Sub-Fund or
of a Class of Shares are passed by a simple majority of the votes cast."
14. To delete the second sub-paragraph of article 24 of the Articles and to delete from the third sub-paragraph of the
same article the words "provided that such merger shall, if the other UCITS is in the form of a "fonds commun de
placement" only be binding on those shareholders of the Company who shall have approved such merger."
15. To add in article 24 of the Articles a new fourth and fifth sub-paragraph with respect to merger provisions applicable
to a sub-fund merger and to a merger of the Company, in accordance with the provisions of the 2010 Law.
16. To update the (former) fifth paragraph of article 24 of the Articles so as to read as follows "Any amounts unclaimed
by the shareholders at the closing of the liquidation of a Sub-Fund will be deposited with the Caisse de Consignation
in Luxembourg on behalf of the persons entitled thereto."
17. To add a new third sub-paragraph in article 26 of the Articles so as to read as follows: "No distribution shall be
made if as a result thereof the capital of the Company becomes less than the minimum prescribed by law."
18. To provide that according to article 26(2) of the 2010 Law the restated Articles shall be solely expressed in English
and shall no longer be followed by a translation into French.
The extraordinary general meeting of shareholders of the Company which was held on 7 February 2012 was not able
to validly deliberate on the above agenda as the quorum requirements to amend the Articles were not met. As a con-
sequence, there shall be no quorum requirement for the Meeting to deliberate on the above agenda and the resolutions,
in order to be passed, will require an affirmative vote of two-third of the votes cast at the Meeting.
You may vote in person or by proxy. Proxy forms should be returned to the registered office of the Company for the
attention of SEB Fund Services, Legal Department, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, before 5:00 p.m. (Luxembourg time) on 13 March 2012 as further detailed on the proxy form.
A proxy form for this meeting can be obtained on request from the registered office of the Company.
16471
L
U X E M B O U R G
For further information shareholders can contact the central administration agent, SEB Fund Services S.A., 6A, Circuit
de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, tel. (+35226 23 2424).
Copies of the draft updated articles of incorporation of the Company may be obtained on request from the registered
office of the Company.
Référence de publication: 2012019193/755/102.
Novamex - Promotion Industrielle et Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 71.475.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le <i>21 février 2012i> à 8.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2
ème
étage) avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31.12.2010 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Divers.
Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au
bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.
<i>le Conseil d'Administrationi> .
Référence de publication: 2012013851/693/19.
Calypso Fuchs Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 142.073.
In the year two thousand twelve, on the eleventh of January.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CALYPSO FUCHS INVEST (“The Company”),
société d'investissement à capital variable, with registered office at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, duly registered
with the Luxembourg Trade Register under section B number 142.073, incorporated by a deed of the undersigned notary,
on September 26, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 2563 of October 21, 2008.
The meeting is opened at 3.00 p.m., Mrs. Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, is
elected chairman of the meeting.
Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Solange Wolter, private employee, residing professionally in Lu-
xembourg, is appointed to assume the role of secretary.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- That the present extraordinary general meeting has been convened by registered letter sent to shareholders on
December 27, 2011.
II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-
dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
III.- It appears from the attendance list, that out of 629 shares in circulation, 10 shares are present or represented at
the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.
A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as
the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on December 14, 2011 and could not validly decide on
the items of the agenda for lack of the legal quorum.
According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorised to take
resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:
16472
L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
1. Decision on whether to discharge the directors of the Company for the performance of their duties from January
1, 2011 to the date of appointment of the liquidator.
2. Decision on whether to approve BDO Tax & Accounting S.A., having its registered office at 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
147571 and represented by Sirs Pierre Lentz and Murad Ikhtiar, as liquidator of the Company and to grant to the liquidator
the broadest powers to perform its duties as provided by law.
3. Delegation of powers
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to discharge the directors of the Company for the performance of their duties from
January 1, 2011 to the date of appointment of the liquidator.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to approve BDO Tax & Accounting S.A., having its registered office at 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 147571 and represented by Sirs Pierre Lentz and Murad Ikhtiar, as liquidator of the Company and to grant to the
liquidator the broadest powers to perform its duties as provided by law.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders in
the cases in which it is requested.
It may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
It may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its
powers it determines and for the period it will fix.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le onze janvier.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX , notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable CALYPSO FUCHS
INVEST («La Société»), avec siège social à 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, dûment enregistrée au Registre de
Commerce sous le numéro B 142.073 et constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 sep-
tembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2563 du 21 octobre 2008.
L'Assemblée est ouverte à 15.00 heures, Madame Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à
Luxembourg, est élue président de l'Assemblée.
Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, est nommée scrutateur.
Le Président et le scrutateur s'entendent pour que Madame Solange Wolter, employée privée, résidant profession-
nellement à Luxembourg soit nommée comme secrétaire.
Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par lettres recommandées aux ac-
tionnaires le 27 décembre 2011.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux sont indiqués
sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.
16473
L
U X E M B O U R G
III.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que sur les 629 actions en circulation, 10 actions sont présentes ou
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de
cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 14 décembre 2011
et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.
En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à
prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.
IV.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de donner décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs fonctions du 1
er
janvier
2011 jusqu'à la date de nomination du liquidateur.
2. Décision d'approuver BDO Tax & Accounting S.A., ayant son siège social à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 147571 et représentée
par Messieurs Pierre Lentz et Murad Ikhtiar, comme liquidateur de la Société et d'accorder au liquidateur les pouvoirs
les plus larges pour exécuter ses fonctions comme prévu par la loi.
3. Délégation de pouvoirs.
4. Divers.
Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs fonctions du 1
er
janvier 2011 jusqu'à la date de nomination du liquidateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver BDO Tax & Accounting S.A., ayant son siège social à 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 147571 et re-
présentée par Messieurs Pierre Lentz et Murad Ikhtiar, comme liquidateur de la Société et d'accorder au liquidateur les
pouvoirs les plus larges pour exécuter ses fonctions comme prévu par la loi.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas
où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et anglais, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 janvier 2012. Relation: LAC/2012/2236. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012013932/133.
(120016570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.
16474
L
U X E M B O U R G
FBP Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 97.405.
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on Friday <i>February 17, 2012i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at September 30, 2011
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting at the registered office of the company.
The annual report is available on demand and free of charge at the registered office of the company.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012013171/755/23.
Vouvray S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 26.921.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra le <i>17 février 2012i> à 10 heures au siège de la société
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31/12/2011;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012014361/322/17.
D&R Multi Asset Strategy, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de D&R Multi Asset Strategy coordonné au 16 décembre 2011 a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, décembre 2011.
HANSAINVEST LUX S.A.
Signature
Référence de publication: 2011179763/11.
(110210280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
D&R IndiGO, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de D&R IndiGO coordonné au 16 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
16475
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, décembre 2011.
HANSAINVEST LUX S.A.
Signature
Référence de publication: 2011179764/11.
(110210281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
TÜV Rheinland Luxemburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbruck.
R.C.S. Luxembourg B 9.252.
<i>Gesellschafterversammlung vom 20. Dezember 2011i>
Die TÜV International GmbH - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland ist alleinige Gesellschafterin der TÜV Rheinland
Luxemburg GmbH.
Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ankündigung und Einberufung einer Gesellschafterversammlung
beschließt die Gesellschafterin folgendes:
<i>Beschluss Nr. 1i>
Herr Stephan Michaely, wohnhaft Buchenweg 10, D-66687 Wadern Nunkirchen, wird zum 01.01.2012 zum weiteren
Geschäftsführer der TÜV Rheinland Luxemburg GmbH bestellt.
<i>Beschluss Nr. 2i>
Herr Reinhold Quaden wird zum 31.01.2012 aus seiner Funktion als Geschäftsführer der TÜV Rheinland Luxemburg
GmbH abberufen.
Köln, 20. Dezember 2011
TÜV International GmbH
Gezeichnet: Dr. Manfred Bayerlein, Dr. Manfred Doerges.
Enregistré à Redange/Attert, le 30 janvier 2012. Relation: RED/2012/184. Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
Für gleichlautenden Auszug zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Redange-sur-Attert, den 31. Januar 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012017584/25.
(120020726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Zellbios S.A., Société Anonyme,
(anc. Farmabios International S.A.).
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 153.201.
<i>Dépôt complémentaire L110173394i>
Nous confirmons par les présents que l’acquisition par Zellbios GmbH de toutes les actions de Pharmazell GmbH a
été réalisée le 18 octobre 2011 et que par conséquent la nomination de Monsieur Oliver BOLZERN en tant qu’admi-
nistrateur classe II est devenue effective à partir de cette date jusqu’à l’approbation des comptes annuels 2015 par
l’assemblée générale. Cette confirmation est émise conformément à la délégation de pouvoir reçue en vertu des décisions
extraordinaires de l’actionnaire unique en date du 14 octobre 2011.
<i>Conseil d’administrationi>
Signé: M. LONGONI.
Enregistré à Redange/Attert le 20 octobre 2011. Relation: RED/2011/2199. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 23 janvier 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012017617/20.
(120020705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
16476
L
U X E M B O U R G
ACMBernstein Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 134.520.
<i>CLOSURE NOTICEi>
The Board of Directors of the Fund decided to close the following sub-funds of ACMBernstein Strategies as of 30
December 2011:
- ACMBernstein Strategies -Fixed Income Alpha Portfolio (Euro)
- ACMBernstein Strategies - Fixed Income Alpha Portfolio (Sterling)
- ACMBernstein Strategies - Fixed Income Alpha Portfolio (Dollar)
- ACMBernstein Strategies - Fixed Income Enhanced Alpha Portfolio (Euro)
- ACMBernstein Strategies - Fixed Income Enhanced Alpha Portfolio (Sterling)
- ACMBernstein Strategies- Fixed Income Enhanced Alpha Portfolio (Dollar)
- ACMBernstein Strategies - Currency Alpha Portfolio (Euro)
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012018081/5937/17.
Fu Hua S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 53, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 54.246.
L'an deux mille onze,
Le vingt-sept décembre.
Pardevant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné,
Ont comparu:
1) Monsieur Gao Hua ZHAN, cuisinier, demeurant à L-6630 Wasserbillig, 53, Grand-Rue,
4) Monsieur Feng Quan ZHAN, serveur, demeurant à L-6630 Wasserbillig, 53, Grand-Rue.
Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Les comparants Gao Hua ZHAN et Feng Quan ZHAN sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée
«FU HUA S.à r.l.», ayant son siège social à L-6630 Wasserbillig, 53, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 54.246,
constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 mars 1996,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 284 du 11 juin 1996,
modifiée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, alors notaire de résidence à Grevenmacher en date du 14
septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 160 du 2 mars 2001.
Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatrevingt-quinze Euros (12.395.-) représenté par cent
(100) parts sociales d'une valeur de cent vingt-trois Euros quatre-vingt-quinze Cents (123,95.-) chacune.
Ces parts ont été souscrites, comme suit:
1) Monsieur Gao Hua ZHAN, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Monsieur Feng Quan ZHAN, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.
Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces.
Lesquels comparants ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution.i>
Monsieur Feng Quan ZHAN, préqualifié, déclare céder et transporter en pleine propriété, les cinquante parts sociales,
inscrites au nom de Monsieur Feng Quan ZHAN de la société «FU HUA S.à r.l.»,
prénommée, à Monsieur Gao Hua ZHAN, préqualifié, ici présent et ce acceptant, pour le prix de six mille cent quatre-
vingt-dix-sept euros cinquante cents (6197,50.- €).
La présente cession est faite moyennant le prix de six mille cent quatre-vingt-dix-sept euros cinquante cents (6197,50.-
€), que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la passation des présentes et hors la présence du notaire
instrumentaire, ce dont il consent bonne et valable quittance au cessionnaire.
Le cessionnaire Monsieur Gao Hua ZHAN sera propriétaire des parts cédées à partir des présentes et il aura droit
aux revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à compter de ce jour.
16477
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolution.i>
En conformité de la cession de parts ci-avant faite, l’associé unique Monsieur Gao Hua ZHAN décide de modifier
l’article six des statuts de la société à responsabilité limitée «FU HUA S.à r.l.», pour lui donner dorénavant la teneur
suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (12.395.- €) représenté
par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-trois euros quatre-vingt-quinze cents (123,95.- €) cha-
cune, entièrement souscrites et intégralement libérées par un versement en espèces, attribuées en totalité à l'associé
unique Monsieur Gao Hua ZHAN, cuisinier, demeurant à L-6630 Wasserbillig, 53, Grand-rue, en rémunération de son
apport.
<i>Troisième résolution.i>
L’associé unique Gao Hua ZHAN rappelle que l’assemblée générale des associés tenue le 14 septembre 2000 devant
Maître Joseph GLODEN, alors notaire de résidence à Grevenmacher, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 160 du 2 mars 2001, avait accepté la démission de l’ancien gérant Dafu ZHOU, cuisinier, de-
meurant à L-7513 Mersch, 31, rue d’Arlon, et elle lui avait donné décharge. La même assemblée générale avait nommé
comme gérant unique Monsieur Gao Hua ZHAN pour une durée indéterminée et avec effet immédiat.
Monsieur Gao Hua ZHAN est confirmé dans sa fonction de gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
Il engage la société en toutes circonstances par sa seule signature.
<i>Quatrième résolution.i>
Monsieur Gao Hua ZHAN, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant, déclare accepter la prédite cession de parts
pour compte de la société conformément à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, respectivement à l'article 1690 du code civil, et il déclare dispenser le cessionnaire de la faire signifier à la
société par voie d'huissier et n'avoir entre ses mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter
l'effet.
<i>Frais.i>
Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des
comparants et de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Grevenmacher, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-
taire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G.H. ZHAN, F.Q. ZHAN, C. GOEDERT.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2011. Relation: GRE/2011/4755. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): R. PETER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 30 décembre 2011.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2012003109/74.
(120001661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
BRE/Star Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 165.218.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of November.
Before us Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
BRE/Europe 3-P S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies under number B 129751,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
under private seal in Luxembourg, on 28 November 2011.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
16478
L
U X E M B O U R G
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of BRE/Star Holding S.à r.l., a société à respon-
sabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg with a share capital of EUR 12,500, not yet registered with the Luxembourg
trade and companies register (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 25 No-
vember 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder of the Company takes the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand
five hundred euro (EUR 12,500.-) up to an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) through the issuance of
five hundred (500) shares, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
The five hundred (500) shares are subscribed by the Sole Shareholder and have been paid up through a contribution
in kind consisting of five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, representing a
total value of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) of BRE/French Hotel Holding I S.à r.l., a société à
responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19,
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies under number B 121165.
The total contribution of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the share capital
of the Company.
As a consequence of such contribution, 100% of the share capital of BRE/French Hotel Holding I S.à r.l. is owned by
the Company.
The proof of the existence and value of the contributions has been produced to the Company.
<i>Second Resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 first paragraph (share capital)
of the articles of incorporation, which shall now read as follows:
" Art. 6. The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) represented by one thousand
(1,000) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."
<i>Third Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to authorize any lawyers of the law firm Arendt & Medernach, acting individually, to
make the appropriate amendments in the shareholders' register of the Company in order to reflect the abovementioned
capital increase.
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro
(€ 1,300.-)
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le vingt-huitième jour de novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg,
A comparu:
BRE/Europe 3-P S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant
son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 129751,
Ici représentée par Mlle Carole Noblet, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé
donnée le 28 novembre 2010,
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La comparante est l'associé unique de BRE/Star Holding S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité
limitée constituée et régie selon le droit luxembourgeois, avec son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
non encore enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant un acte
reçu par le notaire soussigné, en date du 25 novembre 2011, non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations
L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
16479
L
U X E M B O U R G
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cent
euros (EUR 12.500,-) à un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) par l'émission de cinq cent (500) parts sociales
avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les cinq cent (500) parts sociales sont souscrites par l'associé unique et ont été libérées par l'apport en nature de
(500) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, pour une valeur totale de douze
mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) de BRE/French Hotel Holding I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par
les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121165,
L'apport total de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) est entièrement alloué au capital social de la Société.
En conséquence, 100% du capital social de BRE/French Hotel Holding I S.à r.l. est détenu par la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été produite au notaire instrumentant.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 paragraphe premier (capital social) des statuts de la Société qui aura
désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.
Chacune des parts sociales donne droit à une voix aux assemblées ordinaires et extraordinaires."
<i>Troisième Résolutioni>
L'Associé Unique décide d'autoriser tout avocat d'Arendt & Medernach, agissant individuellement, de faire toute mo-
dification nécessaire dans le registre des associés de la Société afin de refléter l'augmentation de capital décidée ci-dessus.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Noblet, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 décembre 2011. Relation: EAC/2011/1656. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012003001/108.
(120001777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
ISPC II LLC Cie. SCS ("société en commandite simple"), Société en Commandite simple.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 95.909.
DISSOLUTION
In the year two thousand eleven,
on the nineteenth day of December.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared:
1. ISPC II LLC, a limited liability company established pursuant to the Delaware General Corporation Law with regis-
tered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA, general partner,
2. WHEELABRATOR GROUP INC, a corporation established pursuant to the Delaware General Corporation Law
with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA, limited partner,
16480
L
U X E M B O U R G
3. Surface Preparation (Gibraltar) Limited, a company organized under the Gibraltar Companies Ordinance, with
registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered at the Gibraltar Registrar of Companies under number
88911, limited partner,
"the principal"
here represented by Mrs Silke ROHE, employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg,
"the proxyholder"
by virtue of three (3) proxies given under private seal which, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder
and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The principal, represented as stated hereabove, declares and requests the notary to act:
1. That the company ISPC II LLC & CIE S.C.S., a limited partnership (société en commandite simple), R. C. S. Luxem-
bourg B Nr. 95909, with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, was incorporated on 14
August 2003 by deed of the 2003 21 00172 undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations nr. 1098 of 22 October 2003.
2. That the corporate capital of the company ISPC II LLC & CIE S.C.S. amounts to EUR 22,000.- (twenty-two thousand
Euro) divided into 220 (two hundred twenty) partnership interests of EUR 100.-(one hundred Euro) each, entirely paid-
up, subscribed to as follows:
- ISPC II LLC, general partner: 1 partnership interest,
- WHEELABRATOR GROUP INC, limited partner: 218 partnership interests,
- Surface Preparation (Gibraltar) Limited, limited partner: 1 partnership interest.
3. That the principal hereby expressly declares that he is proceeding to the dissolution of the company with immediate
effect.
4. That the principal has full knowledge of the financial standings of the company and declares that the activity of the
company has ceased, that the liquidation have been carried out in respect of any parties’ rights and that the partners have
agreed to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company, each of them proportionally to the
number of partnership interests they own without prejudice being clearly understood that towards third parties the
general partner and limited partners will assume personally and jointly all the liabilities and commitments), so that the
liquidation of the company is to be considered as done and closed.
5. That the principal grants discharge to the sole manager of the company.
6. That the proxyholder or the notary may proceed to the cancellation of the company's partnership interests.
7. That all the documents of the dissolved company will be kept during a period of five years at the registered office
of BDO Tax & Accounting.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
proxyholder and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder, known to the notary
by his surname, Christian name, civil status and residence, signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze,
le dix-neuf décembre.
Par devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
1. ISPC II LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de l’état du Delaware General, ayant son
siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, associé com-
mandité,
2. WHEELABRATOR GROUP INC, une société constituée selon le droit de l’état du Delaware, ayant son siège social
au 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, associé commanditaire,
3. Surface Preparation (Gibraltar) Limited, une société constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social au
57/63 Line Wall Road, Gibraltar, inscrite au Registre de Commerce de Gibraltar sous le numéro 88911, associé com-
manditaire,
«le mandant»
ici représentées par Madame Silke ROHE, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg,
16481
L
U X E M B O U R G
«le mandataire»
en vertu des trois (3) procurations données sous seing privé lesquelles, après avoir été signées ne varietur par le
mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Le mandant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
1. Que la société ISPC II LLC & CIE S.C.S., R.C.S. Luxembourg B 95909, ayant son siège social au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été constituée en date du 14 août 2003 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1098 du 22 octobre 2003.
2. Que le capital social de la société ISPC II LLC & CIE S.C.S. s'élève actuellement à EUR 22.000.-(vingt-deux mille
euros) représenté par 220 (deux cent vingt) parts d’intérêt de EUR 100.-(cent euros) chacune, entièrement libérées et
souscrites comme suit:
- ISPC II LLC, associé commandité: 1 part d’intérêt,
- WHEELABRATOR GROUP INC, associé commanditaire: 218 parts d’intérêt,
- Surface Preparation (Gibraltar) Limited, associé commanditaire: 1 part d’intérêt.
3. Que le mandant prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
4. Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière de la société et que l’activité de la
société a cessé, que la liquidation a été accomplie en respectant le droit des parties et que les associés prennent à leur
charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute, chacun proportionnellement aux nombres
de parts d’intérêt détenues (sans préjudice étant bien entendu que vis-à-vis des tiers les associés commandité et com-
manditaires répondront personnellement et solidairement de tous les passifs et engagements financiers), de sorte que la
liquidation de la société est considérée définitivement achevée.
5. Que décharge pleine et entière est accordée au gérant unique de la société dissoute pour l'exécution de son mandat
jusqu'à ce jour.
6. Que le mandataire ou le notaire peut procéder à l’annulation des parts d’intérêt de la société.
7. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO Tax &
Accounting.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande du mandataire des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction en français. Sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. ROHE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17506. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012003189/108.
(120001767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
i-CAP Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 108.664.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
APPEARED:
The company “Intertrust Intellectual Property Group Holding S.A.”, with registered office at CH-1207 Geneva (Swi-
tzerland), 1, rue de Jargonnant, registered with the Trade and Companies register of Geneva under the number
CH-660-1453004-2,
here represented by Mr Alain THILL, private employee, residing professionally at Junglinster (Grand Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, duly represented by Mr Alain THILL, pre-named, declared and requested the notary to act:
16482
L
U X E M B O U R G
I.- That the private limited company (société à responsabilité limitée) “i-CAP Luxembourg”, with registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 108.664, was
incorporated by deed of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then notary residing at Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), on June 14, 2005, published in the Mémorial C number 1158 of November 7, 2005.
II.- That the corporate capital of the private limited company “i-CAP Luxembourg”, pre-named, presently amounts to
twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into one hundred and twenty-five (125) shares with a
nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
III.- That the appearing party is the sole shareholder of the private limited company “i-CAP Luxembourg” and that it
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder decides to dissolve the company and to liquidate its assets.
<i>Second resolutioni>
The shareholder, the company Intertrust Intellectual Property Group Holding S.A., pre-named, decides to appoint
itself, as liquidator with the broadest power mentioned in the articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10,
1915.
<i>Third resolutioni>
The shareholder gives discharge to the managers, Mr. Jean-Christophe DAUPHIN and Mr. Georges SCHEUER, for
the performance of their mandate.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand and fifty Euro.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by her surname, Christian name, civil status
and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société «Intertrust Intellectual Property Group Holding S.A.», avec siège social à CH-1207 Genève (Suisse), 1, rue
de Jargonnant, enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Genève sous le numéro
CH-660-1453004-2,
ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, domicilié professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, dûment représentée par Monsieur Alain THILL, préqualifié, a requis le notaire instrumentaire
de documenter comme suit sa déclaration:
I.- Que la société à responsabilité limitée «i-CAP Luxembourg», ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 108.664, a été constituée suivant acte reçu
par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), en date du 14 juin 2005, publié au Mémorial C numéro 1158 du 7 novembre 2005.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée «i-CAP Luxembourg», pré-désignée, s'élève actuellement
à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale
de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
III.- Que la comparante est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée «i-CAP Luxembourg» et
qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée décide de dissoudre la société et de liquider ses actifs.
16483
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée, la société Intertrust Intellectual Property Group Holding S.A., pré-nommée, décide de se nommer comme
liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la Loi sur les Sociétés Commerciales
du 10 août 1915.
<i>Troisième résolutioni>
L’associée donne décharge aux gérants, Monsieur Jean-Christophe DAUPHIN et Monsieur Georges SCHEUER, pour
l'exécution de leur mandat.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille cinquante
Euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2012. Relation GRE/2012/27. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 5 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002886/91.
(120001917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Stena Forth Lux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.636.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the nineteenth of December;
Before the undersigned notary Maître Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
There appeared:
The company Stena Forth Lux 1 S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg
pursuant to a deed of the undersigned notary public dated December 19, 2011, having its registered office at 26B, bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register,
duly represented by Me Pierre METZLER, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on December 12, 2011.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporator and by
the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Such incorporator, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the articles of incorporation
of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the relevant laws and the present
articles:
Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object
Art. 1. Form - Name. There is hereby established a company with limited liability (société à responsabilité limitée)
governed by Luxembourg law, under the name of Stena Forth Lux 3 S.à r.l. (hereinafter referred to as the "Company").
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred
within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the sole manager or, in case of a plurality of managers, by
resolution of the board of managers of the Company.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
16484
L
U X E M B O U R G
If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxem-
bourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the
Company.
Art. 4. Corporate Object. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any com-
mercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through
participation, contribution, option or in any other way.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group of companies the Company
is part of, any assistance of whatever kind including but not limited to financial assistance, loans, advances, securities or
guarantees.
Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,
bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore,
as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-
marks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and
certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.
The Company's purpose is further the buying, the holding and selling, the chartering in and the chartering out, and the
management of seagoing ships, as well as the financial and commercial operations that relate directly or indirectly to such
activities.
In addition, the Company may charter, hold, lease, operate and/or provide vessels and equipment used in contract
drilling services in oil and gas drilling operations; the Company may also acquire, hold, manage, sell or dispose of any such
related equipment, enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions relating to contract
drilling services.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
Title II. Capital - Units
Art. 5. Share Capital. The subscribed corporate capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000) represented
by twenty thousand (20.000) corporate units with a par value of one US Dollar (USD 1) each.
The share capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or by a resolution of the members,
as the case may be.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
units in existence.
Art. 6. Transfer of Units. If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between
the members.
In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a
general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.
In case of a sole member, the units of the Company are freely transferable to nonmembers.
In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members repre-
senting no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval
is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.
For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the
Company.
16485
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Redemption of Units. The Company may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Company of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a
resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).
Title III. General Meetings of Members
Art. 8. Power of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent
the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts
relating to the activity of the Company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Company by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 9. Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one person has been appointed as the sole
owner vis-à-vis the Company.
Art. 10. Single Member. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general
meeting.
The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded
on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered
into under normal conditions.
Title IV. Management
Art. 11. Board of managers. The Company is managed by a board of managers composed of at least two (2) A managers
and one (1) B manager, either members or not.
The managers are appointed by the general meeting of members, which shall determine their number, fix the term of
their office as well as their remuneration. They shall hold office until their successors are elected.
The managers may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting.
In the event of one or more vacancies in the board of managers because of death, retirement or otherwise, the
remaining managers may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.
Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a
secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of managers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of
meeting.
Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four
hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.
This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate
notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the board of managers.
Any manager may be represented at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram,
telex, telefax or by e-mail another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex, telefax or by e-mail.
The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman,
or, in his absence, by the chairman pro tempore, who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
16486
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Powers. The board of managers or the sole manager, as the case may be, is vested with the broadest powers
to perform all acts of administration and disposition on behalf and in the interest of the Company.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board
of managers or the sole manager.
The board of managers or the sole manager may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of
the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general
meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not
to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board or the sole manager shall determine.
It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all
officers and employees, and fix their emoluments.
Art. 15. Representation. The Company will be bound by the joint signatures of either (i) two (2) A managers or (ii)
one (1) A manager plus one (1) B manager, except for the day-to-day management of the Company (for costs and/or
expenses below twenty-five thousand Euro (EUR 25.000,-) where the signature of one (1) A manager will be binding for
the Company.
The Company will be bound by the single or joint signature of any person to whom such signatory power shall have
been delegated by the Board of managers.
Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations
of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.
Title V. Accounts
Art. 17. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall
terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year.
Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers
or the sole manager as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office
of the Company.
The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.
Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the
expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net
profit of the Company.
Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account
of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share
capital of the Company.
The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:
- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or
- (ii) to carry them forward or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve, account of the Company.
Notwithstanding the above, the members may resolve to pay interim dividends on the future net profit of the current
financial year provided that:
(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts
showing that sufficient assets are available for such distribution.
If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general
meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Company towards the members.
The above provisions exist without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any
moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts.
Title VI. Winding up - Liquidation - Miscellaneous
Art. 20. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (who may be physical persons or legal entities), appointed by the meeting of members resolving such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation.
Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring
the Company to an end.
Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally
to the units they hold in the Company.
16487
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the 31
December 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The twenty thousand (20,000) corporate units have been issued with an aggregate premium of eighty thousand US
Dollars (USD 80,000).
All of the twenty thousand (20,000) corporate units have been subscribed by the company Stena Forth Lux 1 S.à r.l.,
predesignated.
All of the twenty thousand (20,000) corporate units as well as the attached premium have been fully paid in by the
subscriber predesignated so that the amount of one hundred thousand US Dollars (USD 100,000) is at the free disposal
of the Company, as certified to the undersigned notary.
<i>Resolutions of the Sole Memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, representing
the entire corporate capital took the following resolutions:
1) The registered office of the Company is set at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
2) The number of managers is fixed at four (4).
3) The following persons are appointed managers for an unlimited duration:
<i>As A managers:i>
- Mr. Stephen Robert CLARKSON, company director, born on 4 January 1957 in Liverpool, United Kingdom, residing
privately at 19, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg;
- Mrs. Annika HULT, managing director, born on 17 April 1973 in Lerum, Sweden, residing privately at 5, Val Ste Croix,
L-1371 Luxembourg;
- Mr. Ernst KRAUSE, company director, born on 24 March 1946 in Sankt Peter-Ording, Germany, residing privately
at 24, Rue des Vignes, L-6765 Grevenmacher;
<i>As B managers:i>
- Mr. Staffan Werner HULTGREN, company director, born on 30 December 1961 in Fagelvik, Sweden, residing pri-
vately at Golfbanevägen 20 SE-436 50 Hovås, Sweden.
4) KPMG AUDIT, with registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under number B 103590, is appointed as the Company’s independent auditor (Réviseur
d’entreprises) for a period which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2013.
5) The amount of two thousand US Dollars (USD 2,000) is allocated out of the share premium account to the legal
reserve account of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred fifty Euro (EUR 1.150).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document, having been read to the person appearing, that person appearing signed together with the notary the
present original deed.
Follows the German version:
Im Jahre Zweitausendelf, am neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
16488
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft Stena Forth Lux 1 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet gemäß den Gesetzen
von Luxemburg laut notarieller Urkunde vom Dezember 19, 2011, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 26B, boulevard
Royal, L-2449 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg,
ordnungsgemäß vertreten durch Me Pierre METZLER, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 12. Dezember 2012.
Die besagte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person, welche den Gründer
vertritt und den unterzeichnenden Notar an dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung anliegend.
Der Gründer, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) welche den geltenden Gesetzen und der folgenden Satzung un-
terliegen wird, aufzunehmen:
Titel I. Form - Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Form - Name. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die
dem Luxemburger Recht unterliegt, unter der Bezeichnung Stena Forth Lux 3 S.à r.l. (nachstehend die "Gesellschaft"),
gegründet.
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft besteht auf unbeschränkte Zeit.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Er kann innerhalb der Stadt Luxemburg
durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführung
verlegt werden.
Er kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gesellschafterversamm-
lung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch
Beschluss der Geschäftsführung eröffnet werden.
Sollten sich Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art zugetragen haben oder imminent werden, die
die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und Personen
im Ausland, wie durch die Geschäftsführung bestimmt, gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur
Beendigung dieser anormalen Zustände, ins Ausland verlegt werden; diese vorübergehenden Maßnahmen beeinflussen in
keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssit-
zes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Diese vorübergehenden Maßnahmen werden von der Geschäftsführung
getroffen und allen betroffenen Parteien mitgeteilt.
Art. 4. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen, unter welcher Form auch immer, in jedem
kaufmännischen, industriellen, finanziellen oder anderen Luxemburger oder ausländischen Unternehmen zu halten; sämt-
liche Wertpapiere und Rechte durch Beteiligung, Einlage, Optionsrecht oder auf sonstige Art und Weise zu erwerben.
Die Gesellschaft kann ihr Vermögen nutzen, um es in Grundbesitz zu investieren, um ihre Aktiva, wie sie von Zeit zu
Zeit zusammengesetzt sind, nämlich aber nicht beschränkt auf ihr Portfolio von Wertpapieren jeglichen Ursprungs, zu
errichten, verwalten, auszubauen und darüber zu verfügen, um sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von
Unternehmen zu beteiligen, um durch Investition, Zeichnung, Unterzeichnung oder Optionsrecht, Wertpapiere und alle
Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, sie durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder sonstwie zu veräußern, um
Lizenzen für Rechte des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren und den Gesellschaften, oder zum Nutzen
der Gesellschaften, in welchen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung hält, sowie der Gruppe von Gesellschaften
der die Gesellschaft angehört, jede Unterstützung jeglicher Art, einschließend aber nicht beschränkt auf finanzielle Un-
terstützung, Darlehen, Vorschüsse, Sicherheiten oder Garantien zu gewähren.
Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit des Gesellschaftsobjektes, kann die Gesellschaft noch folgendes unterneh-
men:
- der Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Tausch, Übertragung, Handel und Investition in und Abtretung von Anteilen,
Anleihen, Fonds, Noten, Schuldtitel und anderen Wertpapieren, die Aufnahme von Darlehen und die Ausgabe von
Schuldscheinen hierfür, sowie Darlehen gewähren;
- der Erwerb von Einkommen als Folge der Verfügung oder Lizenzerteilung von Urheberrechten, Patenten, Mustern,
geheimen Verfahren, eingetragenen Marken oder anderen ähnlichen Interessen;
- die Gewährung von technischer Unterstützung;
- die Beteiligung in und der Geschäftsführung von anderen Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Anleihen, Noten, Wertpapiere, Schuldverschreibungen
und Bescheinigungen privat ausgeben, vorausgesetzt, dass sie nicht frei übertragbar sind und dass sie nur in eingetragener
Form ausgegeben werden.
Ferner besteht der Zweck der Gesellschaft im Kauf, Besitz, Verkauf sowie in der Anmietung und Vermietung und im
Management von Hochseeschiffen, einschließlich der finanziellen und geschäftlichen Tätigkeiten, welche mit oben ge-
nannten Aktivitäten unmittelbar oder mittelbar verbunden sind.
Zusätzlich kann die Gesellschaft Seefahrzeuge sowie die Ausstattung, welche zur Erbringung von Ölbohr-/ und Gas-
bohrdienstleistungen benutzt wird, chartern, besitzen, mieten, betreiben und/oder zur Verfügung stellen; ferner kann die
16489
L
U X E M B O U R G
Gesellschaft dahingehende Ausstattungen erwerben, besitzen, managen, verkaufen oder veräußern, finanzielle, wirtschaft-
liche und andere Transaktionen, welche vertragliche Bohrdienstleistungen betreffen, eingehen, betreuen oder an diesen
teilnehmen.
Die Gesellschaft kann alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Geschäftsvorgänge, welche unmittelbar oder
mittelbar die oben genannten Bereiche betreffen, durchführen, um die Erfüllung des Gesellschaftszwecks zu ermöglichen.
Allgemein kann die Gesellschaft jede Handlung unternehmen, welche sie für die Erfüllung und die Förderung ihres
Gesellschaftszwecks für nötig erachtet.
Titel II. Gesellschaftskapital und Geschäftsanteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000),
eingeteilt in zwanzigtausend (20.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem US Dollar (USD 1).
Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung erhöht oder herabgesetzt werden, wie der Fall auch sein mag.
Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur Zuteilung eines Teils der Aktiva und des erzielten Gewinnes der Gesellschaft
im direkten proportionalen Verhältnis zu der Zahl der bestehenden Gesellschaftsanteile.
Art. 6. Anteilübertragung. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei
unter den Gesellschaftern übertragbar.
Im Falle mehrerer Gesellschafter, ist die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter
abhängig von der in einer Hauptversammlung getätigten Zustimmung der Gesellschafter, die darin mindestens drei Viertel
(3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.
Im Falle eines alleinigen Gesellschafters, sind die Geschäftsanteile frei zugunsten Nicht-Gesellschaftern übertragbar.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter von der Zustim-
mung der Gesellschafter abhängig, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter
vertreten. In diesem Fall jedoch, ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte
oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Ge-
sellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen.
Art. 7. Erwerb der Anteile durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Bedingungen
ihre eigenen Anteile erwerben.
Der Erwerb und die Verfügung durch die Gesellschaft von und über Anteile, die sie in ihrem eigenen Gesellschaftskapital
hält, soll aufgrund eines Beschlusses unter den Fristen und Bedingungen der Gesellschafterversammlung stattfinden.
Titel III. Gesellschafterversammlung
Art. 8. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung wird
die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Hand-
lungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesell-
schafterversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Bestimmungen gegenwärtiger Satzung können jederzeit durch Beschluss des
alleinigen Gesellschafters oder der Mehrheit, der Gesellschafter, welche mindestens 3/4 des Gesellschaftskapitals ver-
treten, abgeändert werden. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft durch einen einstimmigen
Beschluss ändern.
Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 9. Stimmrecht. Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in ordentlichen und außerordentlichen
Gesellschafterversammlungen.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls sich ein Anteil im Besitz von
mehr als einer Person befindet, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils
aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen zu der Gesellschaft benannt wurde.
Art. 10. Alleiniger Gesellschafter. Wenn die Gesellschaft nur über einen Gesellschafter verfügt, so übt dieser alleinige
Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.
Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, die im Bereich des ersten Absatzes gefasst werden, werden protokolliert
oder schriftlich niedergelegt.
Ebenfalls werden die Verträge, welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der von ihm vertretenen Gesellschaft
eingegangen werden, protokolliert oder schriftlich niedergelegt. Dennoch ist diese letzte Vorschrift für laufende Ge-
schäfte, die unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden, nicht anwendbar.
16490
L
U X E M B O U R G
Titel IV. Geschäftsführung
Art. 11. Geschäftsführer / Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch eine Geschäftsführung geleitet, die sich aus
mindestens zwei (2) A Geschäftsführern und einem (1) B Geschäftsführer, die Gesellschafter sein können, zusammensetzt.
Die Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, die ihre Zahl bestimmt, die
Dauer ihres Amtes, sowie ihre Vergütung festlegt. Sie halten das Amt inne, bis ihre Nachfolger gewählt sind.
Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Begründung (ad nutum), durch Beschluss der Hauptversammlung
ihres Amtes enthoben werden.
Im Falle einer oder mehrerer Vakanzen in der Geschäftsführung, aufgrund Todes, Ruhestandes oder dergleichen,
können sich die verbleibenden Geschäftsführer entschließen, eine solche Vakanz, in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Gesetzes, zu besetzen. In diesem Fall bestätigt die Hauptversammlung die Wahl im Rahmen seiner folgenden
Sitzung.
Art. 12. Versammlungen. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie kann
weiterhin einen Sekretär ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Anfertigen der
Sitzungsprotokolle der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer an dem
Ort zusammen, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche oder mündliche Einberufungen zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern min-
destens vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden
Fällen, wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in der Einberufung genannt werden muss. Auf die Einberufung kann
schriftlich oder per Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durch jeden Geschäftsführer verzichtet werden. Gesonderte
Einberufungen sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, welche aus
einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbeschluss genehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Telegramm, Telex,
Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.
Abstimmungen können auch schriftlich oder per Kabeltelegramm, Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durchgeführt
werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern
bei der Sitzung der Geschäftsführung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der,
bei einer Sitzung anwesenden oder vertretenen, Geschäftsführer getroffen.
Art. 13. Protokolle der Sitzungen. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von dem Vorsitzenden
unterzeichnet oder, in dessen Abwesenheit, durch den kommissarischen Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung
übernommen hat.
Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, welche zur Vorlage in Rechtsstreitigkeiten oder in sonstiger Weise
vorgelegt werden können, werden von dem Vorsitzenden und dem Sekretär oder zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Art. 14. Befugnisse. Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer, soweit dies gegeben ist, verfügt über die
weitestgehenden Befugnisse jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft
vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen
in die Zuständigkeit der Geschäftsführung oder des alleinigen Geschäftsführers.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung
und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solcher Geschäftsführung und
Angelegenheiten, mit vorherigem Einverständnis der Gesellschafterversammlung an einen oder mehrere Geschäftsführer
oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen,
welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die von dem alleinigen Geschäftsführer oder von der Geschäftsführung
festgelegt werden, beraten und beschließen. Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung kann ebenfalls jeg-
liche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss,
übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und deren Bezüge festsetzen.
Art. 15. Vertretung. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsamen Unterschriften entweder (i) von zwei (2) A Ge-
schäftsführern oder (ii) einem A Geschäftsführer und einem B Geschäftsführer, verpflichtet, abgesehen von der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft (für Kosten und/oder Ausgaben unter fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) bei
der die Unterschrift von einem (1) A Geschäftsführer die Gesellschaft verpflichten wird.
Die Gesellschaft wird durch die einzelne oder gemeinsame Unterschrift jeder Person verpflichtet, an die solche Zeich-
nungsbefugnis durch die Geschäftsführung delegiert wurde.
Art. 16. Haftpflicht. Die Geschäftsführer sind, in Ausübung ihres Mandats, für die Verpflichtungen der Gesellschaft nicht
persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen
obliegenden Pflichten.
16491
L
U X E M B O U R G
Titel V. Abschlüsse
Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird am ersten Januar eines jeden Jahres beginnen und am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres enden, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres.
Art. 18. Jahresabschluss. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den alleinigen Geschäftsführer oder die
Geschäftsführung ein Jahresabschluss, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und den Gesellschaftern am Sitz
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.
Der Jahresabschluss wird anschließend der jährlichen Gesellschafterversammlung vorgelegt.
Art. 19. Gewinne, Rücklagen und Dividenden. Das Guthaben der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der Kosten,
Ausgaben, Tilgungen und Provisionen, so, wie von der jährlichen Gesellschafterversammlung gebilligt, stellt den Reinge-
winn der Gesellschaft dar.
Jedes Jahr werden wenigstens fünf Prozent (5%) von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft zur Bildung der
gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen Rücklage endet, wenn die
Rücklage einen Betrag erreicht hat, der zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft entspricht.
Die verbleibenden Gewinne werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verwendet, welche beschließen
kann, (i) den Gesellschaftern Dividenden entsprechend den von Ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteilen, auszuzahlen oder
(ii) sie vorzutragen oder (iii) sie zu einem anderen verteilbaren Rücklagenkonto der Gesellschaft zu übertragen.
Ungeachtet des oben angeführten, können die Gesellschafter beschließen, Vorschüsse auf Dividenden auf dem komm-
enden Reingewinn des aktuellen Geschäftsjahres auszuzahlen, vorausgesetzt dass:
(i) der Jahresabschluss des vergangenen Geschäftsjahres ordnungsgemäß durch einen Beschluss der Gesellschafter
gebilligt wurde;
(ii) die Vorschüsse auf Dividenden innerhalb von zwei (2) Monaten nach der Aufstellung des Interimabschlusses durch
die Gesellschafter, welches beurkundet, dass genügend Mittel zur Verfügung stehen, ausgezahlt werden;
Wenn die ausgezahlten Vorschüsse auf Dividenden den laut der jährlichen Gesellschafterversammlung endgültig ver-
teilbaren Betrag übersteigen, wird der Überschuss nicht als ausgezahlte Dividende berücksichtigt, sondern als eine
unverzüglich fällige Forderung der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern.
Die obengenannten Bestimmungen bestehen, unbeschadet des Rechts der Gesellschafterversammlung den Gesell-
schaftern zu jedem Zeitpunkt jeden sich aus den vorigen Geschäftsjahren beziehenden und übertragenen Reingewinn oder
jede, von verteilbaren Rücklagenkonten stammende Beträge auszuzahlen.
Titel VI. Auflösung - Liquidation - Verschiedenes
Art. 20. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator
(en) (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung
ernannt werden, welche über diese Auflösung entscheidet und deren Befugnisse und Vergütungen festlegt.
Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit einer der Gesellschafter, werden
in keiner Weise die Beendigung der Gesellschaft zur Folge haben.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft im Verhältnis, entsprechend den Geschäftsanteilen,
die sie halten, den Gesellschaftern zugeteilt.
Art. 21. Verschiedenes. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung geregelt sind, gelten die Bestimmungen
des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und wird am 31. Dezember 2012 enden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwanzigtausend (20.000) Geschäftsanteile wurden mit einem Gesamtagio in Höhe von achtzigtausend US Dollar
(USD 80.000) ausgegeben.
Sämtliche zwanzigtausend (20.000) Gesellschaftsanteile wurden von der vorbenannten Gesellschaft Stena Forth Lux 1
S.à r.l. gezeichnet.
Sämtliche zwanzigtausend (20.000) Geschäftsanteile sowie das angegliederte Agio wurden vollständig durch den vor-
benannten Zeichner einbezahlt, so dass der Betrag von einhunderttausend US Dollar (USD 100.000) der Gesellschaft,
wie vom unterzeichnenden Notar festgestellt, frei zur Verfügung steht.
<i>Beschluss des alleinigen Gesellschaftersi>
Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, vertreten wie hiervor angegeben, welcher das gesamte Stammkapital vertritt,
folgende Beschlüsse:
1) Der Sitz der Gesellschaft ist in 26B, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg festgelegt;
1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf vier (4) festgelegt;
16492
L
U X E M B O U R G
2) Die nachstehend genannten Personen werden für eine unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern bestimmt:
<i>Als A Geschäftsführer:i>
- Herr Stephen Robert CLARKSON, Gesellschaftsdirektor, geboren am 4. Januar 1957 in Liverpool, Vereinigtes Kö-
nigreich, privat wohnhaft in 19, rue Henri VII, L-1725 Luxemburg;
- Frau Annika HULT, geschäftsführende Direktorin, geboren am 17. April 1973 in Lerum, Schweden, privat wohnhaft
in 5 Val Ste Croix, L-1371 Luxemburg;
- Herr Ernst KRAUSE, Gesellschaftsdirektor, geboren am 24. März 1946 in Sankt Peter-Ording, Deutschland, privat
wohnhaft in 24, Rue des Vignes, L-6765 Grevenmacher;
<i>Als B Geschäftsführer:i>
- Herr Staffan Werner HULTGREN, Gesellschaftsdirektor, geboren am 30. Dezember 1961 in Fagelvik, Schweden,
privat wohnhaft in Golfbanevägen 20 SE-436 50 Hovås, Schweden.
4) KPMG AUDIT, mit Gesellschaftssitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 103590, wird zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft (Réviseur d‘entre-
prises) ernannt für eine Amtszeit, welche auf der jährlichen Gesellschafterversammlung, die im Jahre 2013 stattfinden
wird, enden wird.
5) Der Betrag in Höhe von zweitausend US-Dollar (USD 2.000) wird der gesetzlichen Rücklage aus dem Agiokonto
zugeführt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit, die Erfüllung der im Artikel 183 des Gesetzes vom zehnten August neun-
zehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften aufgezählten Bedingungen überprüft zu haben und bestätigt, dass
sie erfüllt wurden.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass
ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr eintausendeinhundertfünfzig Euro (EUR 1.150) abgeschätzt.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenann-
ten erschienenen Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Version. Gemäß dem Wunsch derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen
Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigter der erschienenen Person vorgelesen worden ist, hat diese Person die
vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Signé: P. METZLER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 décembre 2011. LAC/2011/56891. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Référence de publication: 2011180045/503.
(110209396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
ESCF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 21.006.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 155.720.
In the year two thousand and eleven, on the eighth of December.
Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
"ESCF Soparfi B S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 155.659,
hereby represented by Mr Gianpiero SADDI, notary’s clerk, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 8, 2011.
The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
16493
L
U X E M B O U R G
The appearing party, acting in its capacity as the sole shareholder, has requested the undersigned notary to enact the
following:
The appearing party is the sole shareholder of "ESCF Soparfi A S. à r. l.",a société à responsabilité limitée, with registered
office at L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey, incorporated by deed of Me Martine SCHAEFFER, residing in Lu-
xembourg, on September 22, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2391 of
November 8, 2010. These Articles of Incorporation have been amended for the last time by deed of Me Martine
SCHAEFFER, on November 4, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2936
dated December 1
st
, 2011.
The capital of the company is fixed at ten million twenty thousand euro (10,020,000.- EUR) represented by one hundred
thousand two hundred (100,200) shares, with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid in.
The appearing party takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The appearing sole shareholder resolves to increase the corporate share capital by an amount of ten million nine
hundred eighty-six thousand euro (10,986,000.- EUR),
so as to raise it from its present amount of ten million twenty thousand euro (10,020,000.- EUR) to twenty-one million
six thousand euro (21,006,000.- EUR),
by issuing one hundred nine thousand eight hundred sixty (109,860) new shares with a par value of one hundred euro
(100.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing parts.
<i>Subscription and liberationi>
The appearing sole shareholder declares to subscribe to the one hundred nine thousand eight hundred sixty (109,860)
new shares and to pay them up, fully in cash, at its par value of one hundred (100.-EUR)
together with a total issue premium of forty-nine euro (49.-EUR),
so that the total amount of ten million nine hundred eighty-six thousand forty-nine euro (10,986,049.- EUR) is at the
free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The appearing shareholder resolves to amend article 6 of the Articles of Incorporation, so as to reflect the increase
of capital, which shall henceforth have the following wording:
" Art. 6. The capital is set at twenty-one million six thousand euro (21,006,000.- EUR) represented by two hundred
and ten thousand sixty (210,060) shares of a par value of one hundred euro (100.- EUR) each."
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with
the notary the present original deed.
Suit la version française:
L'an deux mille onze, le huit décembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
"ESCF Soparfi B S.à.r.l.,, une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 155.659, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey,
ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, clerc de notaire avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui
suit:
La société comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée «ESCF Soparfi A S.à r.l.», avec siège
social à L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Me Martine SCHAEFFER, de rési-
dence à Luxembourg, en date du 22 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
2391 du 8 novembre 2010, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine
SCHAEFFER, en date du 4 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2936 du
1
er
décembre 2011.
16494
L
U X E M B O U R G
Le capital social de la société est fixé à dix millions vingt mille euros (10.020.000,- EUR) représenté par cent mille deux
cent (100.200) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
L’associée unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-
six mille euros (10.986.000,- EUR)
afin de le porter de son montant actuel de dix millions vingt mille euros (10.020.000,- EUR) à vingt et un millions six
mille euros (21.006.000,- EUR),
par l’émission de cent et neuf mille huit cent soixante (109.860) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent
euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Et à l'instant, les cent neuf mille huit cent soixante (109,860) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent
euros (100.- EUR) ont été souscrites par l’associé unique et entièrement libérées en espèces ensemble avec une prime
d’émission totale de quarante-neuf euros (49,- EUR),
de sorte que le montant total de dix millions neuf cent quatre-vingt-six mille quarante-neuf euros (10.986.049,- EUR)
se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à vingt et un millions six mille euros (21.006.000,- EUR) représenté par deux cent dix
mille soixante (210,060) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune."
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms,
prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 décembre 2011. LAC/2011/55477. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003081/103.
(120001681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
L Select, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 57.507.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 14 décembre 2011i>
En date du 14 décembre 2011, l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter les démissions de Monsieur Jean-Michel STARCK, Madame Monique ERBEIA et Monsieur Vincent DE
PALMA de leur poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat;
- d'accepter la démission de HSBC PRIVATE BANK FRANCE en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 16
septembre 2011;
- de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet immédiat et ce
pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:
* Monsieur Alexander FARMAN-FARMAIAN, né le 26 août 1965 à Téhéran, Iran, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 350 Park Avenue, 18
th
Floor, New York 10022, Etats-Unis d'Amérique;
* Monsieur Kevin SETH, né le 26 mai 1959 à Baltimore, Maryland, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement
à l'adresse suivante: 350 Park Avenue, 18
th
Floor, New York 10022, Etats-Unis d'Amérique;
16495
L
U X E M B O U R G
* Monsieur Fausto ROTUNDO, né le 23 janvier 1969 à Rome, Italie, résidant professionnellement à l'adresse suivante:
350 Park Avenue, 18
th
Floor, New York 10022, Etats-Unis d'Amérique; et
* Monsieur Jacques ELVINGER, né le 18 juin 1958 à Luxembourg, résidant professionnellement à l'adresse suivante:
2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Depuis cette date, le conseil d'administration de la Société se compose de la manière suivante:
- Monsieur Alexander FARMAN-FARMAIAN
- Monsieur Kevin SETH
- Monsieur Fausto ROTUNDO
- Monsieur Jacques ELVINGER
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2011.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012003201/32.
(120001694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
AZ FUND Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 73.617.
<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration de la société adoptées le 18 mai 2011i>
Il résulte des résolutions que:
1. Monsieur Andrea ALIBERTI peut engager la Société comme suit:
(i) signature individuelle pour tout contrat relatif à la fourniture des biens et des services, utiles à l'administration
ordinaire de la Société, dont le montant est inférieur ou égal à 100.000 euros;
(ii) signature individuelle pour tout ordre de paiement aux distributeurs et autres intermédiaires qualifiés impliqués
dans les activités ordinaires de la Société et de ses fonds (a) dont le montant est inférieur ou égal à 100.000 euros (par
opération), s'il s'agit des tiers qui n'appartiennent pas au groupe Azimut, groupe AMS ou la banque dépositaire d'un des
fonds de la Société, et (b) sans limitation de montant s'il s'agit des sociétés appartenant au groupe Azimut, groupe AMS
ou la banque dépositaire d'un des fonds de la Société;
(iii) signature conjointe avec Monsieur Francesco Carnevale ou Monsieur Filippo Fontana pour tout engagement, con-
trat ou ordre de paiement dont le montant est supérieur à 100.000 euros.
(iv) signature individuelle pour tout contrat ou ordre de paiement entre les sociétés appartenant au groupe Azimut.
2. Madame Raffaella SOMMARIVA peut engager la Société comme suit:
(i) signature individuelle pour tout courrier ordinaire de la Société adressé aux tiers, y compris les autorités de marché,
dans les limites des fonctions qui lui sont déléguées;
(ii) signature individuelle pour tout acte et opération nécessaire afin de respecter la stratégie d'investissement et les
limites opérationnelles spécifiques déterminées par le conseil d'administration de la Société;
(iii) signature individuelle pour tout acte et opération concernant l'activité ordinaire des fonds de la Société;
(iv) signature conjointe avec Monsieur Francesco Carnevale ou Monsieur Filippo Fontana pour tout engagement, con-
trat ou ordre de paiement dont le montant est inférieur ou égal à 100.000 euros;
(v) signature individuelle pour tout contrat ou ordre de paiement entre les sociétés appartenant au groupe Azimut.
3. Monsieur Filippo FONTANA peut engager la Société comme suit:
(i) signature conjointe avec Monsieur Andrea Aliberti ou Monsieur Francesco Carnevale pour tout engagement, contrat
ou ordre de paiement dont le montant est supérieur à 100.000 euros;
(ii) signature conjointe avec Madame Raffaella Sommariva ou Monsieur Francesco Carnevale pour tout engagement,
contrat ou ordre de paiement dont le montant est inférieur ou égal à 100.000 euros;
(iii) signature individuelle pour tout contrat ou paiement entre les sociétés appartenant au groupe Azimut.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Pour extrait conforme
Luc COURTOIS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012001158/39.
(110213351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
16496
L
U X E M B O U R G
Andreas Portfolio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 112.693.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue en date du 2 janvier 2012 que:
- Le siège social de la Société a été transféré du 25C, Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg au 40, avenue Monterey
à L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012002221/15.
(120000897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
MK Luxinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 43.576.
Im Jahre zweitausendelf, den fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichnen Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.
Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "MK LUXINVEST
SA“ Matrikel: 1993 22 03 335), mit Sitz in L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Sektion B unter der Nummer 43.576,
gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond SCHROEDER mit dem damaligen Amtssitz in
Mersch, am 21. Mai 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 236 vom 21. Mai
1993.
Die Generalversammlung wurde eröffnet um 8.30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn
Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmenzählers.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen
Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den amtierenden
Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 10.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital
darstellen, in gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung
somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.
III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Wechsel des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von 4, rue Dicks, L-1417 Luxemburg nach 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg.
2. Änderung des ersten Satzes des Artikels 3 der Satzung der Gesellschaft um die Verlegung des Gesellschaftssitzes
nach Senningerberg widerzuspiegeln, sodass dieser wie folgt lautet: «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich innerhalb der
Gemeinde Niederanven.»
3. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft, so dass Artikel 4 der Satzung wie folgt lautet:
«Der Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und/oder Verwaltung von gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zugelas-
senen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und die zusätzliche Verwaltung anderer Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen (OGA), die nicht unter diese Richtlinie fallen und für die die Verwaltungsgesellschaft
einer Aufsicht unterliegt, deren Anteile jedoch nicht in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß der
Richtlinie 2009/65/EG vertrieben werden können, sowie sonstiger Luxemburger und ausländischen Investmentvehikel
(einschließlich SICARs).
Die Tätigkeit der Verwaltung von Fonds Communs de Placement und Investmentgesellschaften umfasst insbesondere:
- Die Anlageverwaltung. In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft für Rechnung der von ihr verwalteten OGAW
und OGA Benachrichtigungen oder Anweisungen betreffend zu tätigender Anlagen erteilen, Verträge abschließen, alle
Arten von Wertpapieren und andere Vermögensarten kaufen, verkaufen, tauschen und übereignen, für Rechnung der von
ihr verwalteten OGAW und OGA alle im Zusammenhang mit Wertpapieren, die das Vermögen der OGAW und OGA
bilden, stehenden Stimmrechte ausüben. Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Auflistung.
16497
L
U X E M B O U R G
- Administrative Tätigkeiten in Bezug auf OGAW und OGA. Hierbei handelt es sich um die Gesamtheit der in Anhang
II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen aufgeführten Tätigkeiten, d.h.
insbesondere die Bewertung der Portfolios und Preisfestsetzung für die Aktien und/oder Anteile der OGAW und OGA,
die Ausgabe und Rücknahme von Aktien und/oder Anteilen der OGAW und OGA, die Registerführung für die OGAW
und OGA, die Führung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen von Transaktionen. Diese Auflistung ist nicht abschließend.
- Vertrieb der Aktien und/oder Anteile von selbst- oder fremdverwalteten OGAW und OGA in Luxemburg und/oder
im Ausland.
Die MK LUXINVEST S.A. kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle
sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen und des Kapitels 15 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen bleiben»
4. Neufassung von Artikel 14 der Satzung der Gesellschaft.
5. Abänderung des Artikels 2, Artikel 7 und Artikel 20 der Satzung wegen der Bezugnahme auf das Gesetz vom 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
6. Verschiedenes.
Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse einstimmig
gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 01. Januar 2012 nach L-1736 Sennin-
gerberg, 5, Heienhaff, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, im Zusammenhang mit dem ersten Beschluss, Artikel 3 Satz 1 der Satzung mit
Wirkung zum 01. Januar 2012 abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven ".
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftszwecks der Gesellschaft zu ändern, so dass Artikel 4 der Satzung
wie folgt lautet:
« Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und/oder Verwaltung von gemäß der Richtlinie 2009/65/EG
zugelassenen Organsimen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und die zusätzliche Verwaltung anderer
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), die nicht unter diese Richtlinie fallen und für die die Verwaltungsgesellschaft
einer Aufsicht unterliegt, deren Anteile jedoch nicht in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß der
Richtlinie 2009/65/EG vertrieben werden können, sowie sontiger luxemburger und ausländischen Investmentvehikel
(einschließlich SICARs).
Die Tätigkeit der Verwaltung von Fonds Communs de Placement und Investmentgesellschaften umfasst insbesondere:
- Die Anlageverwaltung. In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft für Rechnung der von ihr verwalteten OGAW
und OGA Benachrichtigungen oder Anweisungen betreffend zu tätigender Anlagen erteilen, Verträge abschließen, alle
Arten von Wertpapieren und andere Vermögensarten kaufen, verkaufen, tauschen und übereignen, für Rechnung der von
ihr verwalteten OGAW und OGA alle im Zusammenhang mit Wertpapieren, die das Vermögen der OGAW und OGA
bilden, stehenden Stimmrechte ausüben. Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Auflistung.
- Administrative Tätigkeiten in Bezug auf OGAW und OGA. Hierbei handelt es sich um die Gesamtheit der in Anhang
II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen aufgeführten Tätigkeiten, d.h.
insbesondere die Bewertung der Portfolios und Preisfestsetzung für die Aktien und/oder Anteile der OGAW und OGA,
die Ausgabe und Rücknahme von Aktien und/oder Anteilen der OGAW und OGA, die Registerführung für die OGAW
und OGA, die Führung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen von Transaktionen. Diese Auflistung ist nicht abschließend.
- Vertrieb der Aktien und/oder Anteile von selbst- oder fremdverwalteten OGAW und OGA in Luxemburg und/oder
im Ausland.
Die MK LUXINVEST S.A. kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle
sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen und des Kapitels 15 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen bleiben»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 14 abzuändern durch Einfügen von zwei neuen Passagen, welche folgenden
Wortlaut haben:
16498
L
U X E M B O U R G
„Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenz-
schaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.
Auf Veranlassung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch einstimmig durch
Brief oder Telefax gefasst werden. Schriftliche und von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse stehen
Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Solche Beschlüsse können von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich,
durch Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel gebilligt werden. Eine solche Billigung wird jedenfalls schriftlich bes-
tätigt und die Bestätigung wird dem Beschlussprotokoll beizufügen sein. Die Gesamtheit der Unterlagen erbringt als
Protokoll den Nachweis der Beschlussfassung.“
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt Artikel 2 Satz 3 der Satzung wegen der Bezugnahme auf das Gesetz vom 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 2. Satz 3. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur unter Berücksichtigung des Artikels 21 des Gesetzes von 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen."
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt Artikel 7 Satz 2 der Satzung wegen der Bezugnahme auf das Gesetz vom 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 7. Satz 2. Es kann jedoch nicht weniger als das im Artikel 102 des Gesetzes von 17. Dezember 2010 über
Organismen für gemeinsame Anlagen festgelegte Minimumkapital betragen."
<i>Siebter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt Artikel 20 der Satzung wegen der Bezugnahme auf das Gesetz vom 17. Dezember
2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
« Art. 20. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaft vom 10. August 1915
einschließlich Änderungsgesetzen und das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.»
<i>Kosteni>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, wer-
den geschätzt auf 750,00€.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbruck, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an den Anwesenden, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Jean-Claude MICHELS, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 16 décembre 2011. Relation: DIE/2011/12111. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 2. Januar 2012.
Référence de publication: 2012001857/132.
(120000477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
BIL Holding I Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 163.525.
L'an deux mille onze, le treize décembre.
Par-devant Maître HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU
La société de droit indien «BINANI INDUSTRIES LTD», établie et ayant son siège social à 37/2, Chinar Park, New
Town, Rajarhat Main Road, P.O. Haiara, Kolkata, 700157 (Inde), immatriculée au «Register of Companies West
Bengal» (Inde) sous le numéro 25584 (ci-après la «Comparante» ou l'«Associée unique»), représentée par Monsieur Sunil
SETHY, né le 27 mars 1951 à Dehradum Uttranchal (Inde), demeurant à Flat n°151, 15
th
Floor, Everest Apartments,
Mount Pleasant Road, Mumbai, 400 006 (Inde), agissant en sa qualité de «Managing Director» de la prédite société,
ici représentée par Monsieur Joé Hemes, comptable, né le 22 décembre 1984 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant
à 20, rue de Wiltz, L-9154 Grosbous (Luxembourg),
16499
L
U X E M B O U R G
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le notaire instrumentant et le mandataire de la
Comparante, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle Comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «BIL HOLDING
I SARL», établie et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 163.525, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit,
notaire de résidence à Mersch, en date du 9 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Asso-
ciations du 9 novembre 2011, numéro 2724 (ci-après la «Société»);
- Qu'en sa qualité d'Associée unique de la Société, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de DOUZE MILLIONS
D'EUROS (12.000.000.-EUR) afin de porter son montant actuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR)
à DOUZE MILLIONS DOUZE MILLE CINQ CENT EUROS (12.012.500.-EUR), par l'émission de QUATRE-VINGT-SEIZE
MILLE (96.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT CINQ EUROS (125.-EUR) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associée unique déclare par les présentes souscrire chacune des QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE (96.000) nouvelles
parts sociales et les libérer totalement moyennant apport d'une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit
et à charge de la société à concurrence de DOUZE MILLIONS D'EUROS (12.000.000.-EUR).
La valeur de la Créance a été attestée au notaire instrumentaire par un bilan de la société et au moyen d'un certificat
émis par le management de l'Associé Unique daté du 5 décembre 2011.
Lesdits bilan et certificat resteront, après avoir été signés par les comparants et le notaire instrumentant, annexés aux
présentes pour être formalisés avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'Associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, ayant trait
au capital social, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLIONS DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.012.500.-EUR)
représenté par QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE CENT (96.100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT
CINQ EUROS (125.-EUR) chacune».
<i>Troisième résolutioni>
L'associé décide de continuer le mandat de Monsieur Sunil SETHY, né le 27 mars 1951 à Dehradum Uttranchal (Inde),
demeurant à Flat n°151, 15
th
Floor, Everest Apartments, Mount Pleasant Road, Mumbai, 400 006 (Inde), nommé jusqu'à
maintenant comme gérant à la fonction et le nomme de gérant catégorie A de la société pour une durée indéterminée.
L'associé décide de nommer à la fonction de gérant catégorie A de la société pour une durée indéterminée:
Madame Shradha BINANI, né le 19 septembre 1987 à Londre (Grand-Bretagne), demeurant à Little Gibbs Road 4,
Malabhar Hill, Mumbai, 400 006 (Inde).
L'associé décide de nommer à la fonction de gérant catégorie B de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Nicholas James MARTIN, né le 03 janvier 1974 à Guernsey (Grand-Bretagne), domicilié à 1 rue Neuf Ville,
F-54730 Gorcy (France).
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature d'un gérant de catégorie A et d'un gérant
de catégorie B.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'Associée unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société qui aura
désormais la teneur suivante:
«La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de
gérance. Ils seront désignés comme gérants de catégorie A et de catégorie B.
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.
Le(s) gérant(s) est / sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
16500
L
U X E M B O U R G
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un
gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et leurs rémunération
(s'il en est) de ces mandataires, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées par un gérant catégorie A et un
gérant catégorie B des gérants présents ou représentés.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
à raison des présentes est évalué à environ EUR 4.900.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la Comparante, connu du notaire par nom, prénom,
qualité et demeure, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. HEMES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56978. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002994/90.
(120002088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Crebim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 75.555.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012001637/10.
(120000136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Cristina S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 129, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 99.673.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012001639/9.
(120000555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Edalux, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8011 Strassen, 341, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 152.386.
<i>Constat de cession de parts socialesi>
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales conclue sous seing privé en date du 20 décembre 2011 et
acceptée par les Gérants au nom de la société que le capital social de la société est désormais répartit comme suit:
La société ECELUX S.à r.l., avec siège social à 341, route d'Arlon, L-8011 Strassen,
R.C.S. B 161.513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
16501
L
U X E M B O U R G
Murat MUTLU / Frank BODEN
<i>Gérant administratif / Gérant techniquei>
Référence de publication: 2012001672/16.
(120000520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
GLL AMB Generali Bankcenter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 175.000,00.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 140.618.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la société au 29 décembre 2011:
- qu'a été nommé gérant de la société pour une durée illimitée
GLL Services Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée à Luxembourg, ayant son domicile à
15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, en cours de régistration auprès du Régistre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg;
- qu'ont été accepté les démissions des gérants
Mme. Alexandra BREHM, M. Oliver KÄCHELE et M. Jochen SCHNIER.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 29 décembre 2011.
Jörg FUCHS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012002822/19.
(120001019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Euro Motors S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 139.486.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a décidé en date du 27 décembre 2011:
- d'accepter la démission de Monsieur Michel Thill né le 8 juin 1965, Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle
au 51, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 30 novembre 2011;
- de nommer Monsieur Eckart Vogler, né le 24 octobre 1970 à Brême (Allemagne), ayant son adresse professionnelle
au 51, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 6 décembre 2011, pour une durée
illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012002113/18.
(120000595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Auto Logistic Transport, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 73.983.
L'an deux mille onze, le treize décembre.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
la société anonyme TA EUROPE S.A., établie à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 132096, constituée suivant acte notarié du 27 septembre
2007, publié au Mémorial C numéro 2472 du 31 octobre 2007, représentée par deux de ses administrateurs:
- Monsieur Jacques Duvauchelle, demeurant à Montélimar (F), et
- Monsieur Bernard Grasser, demeurant à Huttendorf (F), lesquels sont ici représentés par Monsieur Jean Kayser,
comptable, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains,
16502
L
U X E M B O U R G
sur base d'une procuration sous seing privé, délivré à Luxembourg, le 4 août 2011, laquelle procuration, après avoir
été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être for-
malisée avec lui.
La société anonyme TA EUROPE S.A., représentée comme dit ci-avant, déclare être le seul et unique associé de la
société AUTO LOGISTIC TRANSPORT, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-5634 Mondorf-les-
Bains, 1, route de Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 13 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 302 du 22 avril 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 4 août
2004, publié au Mémorial C numéro 1145 du 12 novembre 2004.
Le seul associé, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit sa
résolution prise sur ordre du jour conforme:
<i>Résolutioni>
L'associé unique décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société à L-3378 Livange, 251, route de
Luxembourg et de modifier l'article 5, première phrase, des statuts en conséquence qui aura la teneur suivante:
« Art. 5. (Première phrase). Le siège social est établi à Livange.».
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte,
Signé: J. DUVAUCHELLE, B. GRASSER, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 19 décembre 2011. Relation: REM/2011/1710. Reçu soixante-quinze euros 75.-€
<i>Le Receveuri>
(signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 22 décembre 2011.
Patrick SERRES.
Référence de publication: 2012002977/38.
(120001857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Fluglehrer- und Pilotenservice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 148.276.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012001711/9.
(120000493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
LaSalle UK Property Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 95.818.
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of November.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
LaSalle UK COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under
the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, acting in its name and on behalf of LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY
FUND (in liquidation), a mutual investment fund organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
here represented by Mr. Raphaël Poncelet, chartered accountant, professionally residing in Luxembourg, by virtue of
a proxy, given on November 29, 2011.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of LaSalle UK Property Company S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a
société à responsabilité limitée, having its registered office at 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 95.818, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, then residing in Mersch, on 23 September 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1124 of 29 October 2003.
The appearing party representing the whole corporate capital of the Company requires the notary to enact the fol-
lowing resolutions:
16503
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
In compliance with the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law") the sole
shareholder decides to dissolve the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to appoint Signes S.A., a société anonyme,
incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 68-70, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 46.251,
as liquidator.
The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.
The liquidator is empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 without requesting the authori-
sation of the general meeting in the cases in which it is required.
The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all
in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of
all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrances; remove
any outstanding charge in its sole discretion.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
powers as it determines and for the period as it will fix.
The liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash or in kind in its sole discretion.
Subject to the Law, such distribution may take the form of interim payments out of the surplus of the winding-up.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed was drawn up in
English, followed by a French version thereof; on request of the appearing party and in case of discrepancies between the
English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed the present deed together with the notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille onze, le trente novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,
A COMPARU:
LaSalle UK COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.,, une société constituée et existant selon les lois du
Luxembourg, agissant en son nom propre et pour compte de LaSalle UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, (en liqui-
dation) un fonds commun de placement organisé selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Raphaël Poncelet, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 novembre 2011.
La dite procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de LaSalle UK Property Company, S.à r.l. (ci-après la "Société"), une
société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 95.818, constituée selon acte reçu par le notaire
instrumentant, alors de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 septembre 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1124 du 29 octobre 2003.
La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé à toute notification, a
requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), l'associé unique
décide de dissoudre la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-dessus, l'associé unique décide de nommer Signes S.A., une société anonyme, ayant
son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 46.251, en tant que liquidateur.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148bis de la Loi.
Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 sans demander l'autorisation des associés dans les cas
où cette autorisation serait requise.
16504
L
U X E M B O U R G
Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les
droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes
les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements; enlever
toutes charges subsistantes selon sa volonté.
Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire de la Société et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.
Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux associés en numéraire ou en nature selon sa volonté. Sous
réserve des dispositions légales applicables, cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liqui-
dation.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. PONCELET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54928. Reçu douze euros (12.- EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003205/99.
(120002001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Atos Belgium, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 58.145.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de Atos Belgium que le conseil d'administration
a décidé de nommer Monsieur Henk Vandendooren en qualité de délégué à la gestion journalière de Atos Belgium, en
remplacement de Monsieur Frank Geelen.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur Henk Vandendooren occupe désormais les fonctions d'administrateur
et de délégué à la gestion journalière de Atos Belgium.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Tom Storck
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012002090/16.
(120000180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Georose 4, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé.
R.C.S. Luxembourg B 42.586.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012001743/12.
(120000636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
16505
L
U X E M B O U R G
Conceptu'l S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 71, avenue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 114.724.
DISSOLUTION
L’an deux mille onze,
le vingt décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Madame Marie-France Huck, indépendante, née le 17 septembre 1947 à Narbonne, demeurant au 4, rue des Boilettes,
54200-Dommartinlès-Toul, France.
Laquelle comparante, ici personnellement présente, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit
ses déclarations et constatations:
1.- Qu’elle est la seule et unique associée de la société «CONCEPTU’L S.à r.l.» (la «Société»), une société à respon-
sabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 71 avenue de la Libération,
L-3850 Schifflange,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 114 724 et
constituée suivant acte notarié dressé en date du 22 février 2006, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1022 du 24 mai 2006, page 49022;
2.- Que les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis sa date de création.
3.- Que le capital social de la Société s’élève actuellement à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.-EUR) et
se trouve représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.-EUR) chacune,
toutes intégralement libérées et toutes détenues par la comparante prénommée.
4.- Qu’en tant qu’associée unique la comparante prémentionnée déclare dissoudre ladite Société avec effet immédiat.
5.- Que l’associée unique, en sa qualité de détentrice unique des cinq cents (500) parts sociales de la Société déclare
avoir reçu tous les actifs de la Société et qu'elle prendra personnellement en charge tout le passif de la Société qu’il soit
occulte et inconnu à ce moment;
6.- Que partant la Société soit et est par le présent acte liquidée;
7.- Que décharge pleine et entière est accordée la gérante unique de la Société pour l'exercice de son mandat jusqu’à
ce jour;
8.- Que les livres, documents et pièces relatifs à la Société resteront conservés durant cinq ans au 3, Millewee, L-7257
Helmsange.
9.- Que l’associée unique déclare prendre à sa charge tous les frais résultant du présent acte.
Dont acte, fait et passé à Helmsange, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M.F. HUCK, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17801. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012003039/42.
(120001994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Georose 7, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé.
R.C.S. Luxembourg B 75.867.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012001745/12.
(120000634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
16506
L
U X E M B O U R G
Murten Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 79.762.
Par la présente, nous avons le regret de vous informer de notre démission d'administrateur de la société anonyme
MURTEN FINANCIERE SA, enregistrée auprès du R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 79.762, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Jean Bernard ZEIMET.
Référence de publication: 2012001864/10.
(120000258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Sonoco Asia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 41.000,00.
Siège social: L-9657 Harlange, 7B, rue de Bettlange.
R.C.S. Luxembourg B 150.518.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Sociétéi>
- En date du 7 mars 2011, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D’accepter la démission de la personne suivante:
* Monsieur Edward Laurence Smith en tant que gérant de classe B avec effet au 7 mars 2011.
De nommer la personne suivante en tant que gérant de classe B de la Société:
* Monsieur Adam George Wood, né le 8 juillet 1968 à Birmingham au Royaume-Uni, résidant professionnellement au
Eikenlaan 54, 3090 Overijse, Belgique, avec effet au 7 mars 2011 et pour une durée indéterminée.
- En date du 30 septembre 2011, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D’accepter la démission de la personne suivante:
* Madame Christel Damaso en tant que gérante de classe A avec effet au 30 septembre 2011.
De nommer la personne suivante en tant que gérant de classe A de la Société:
* Monsieur Philippe Van Den Avenne, né le 29 avril 1972 à Beloeil, en Belgique, résidant professionnellement au 69,
rue de Merl, L-2146 Luxembourg, avec effet au 1
er
octobre 2011 et pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
<i>Gérants de classe A:i>
Madame Isabelle Flamme
Monsieur Philippe van den Avenne
Monsieur Faruk Durusu
<i>Gérants de classe B:i>
Monsieur Clayton Beck
Monsieur Adam George Wood
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Sonoco Luxembourg S.à r.l.
Référence de publication: 2012003328/32.
(120001735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Murten Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 79.762.
Par la présente, j'ai le regret de vous informer de ma démission d'administrateur de la société anonyme MURTEN
FINANCIERE SA enregistrée auprès du R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 79.762, avec effet immédiat
Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Etienne GILLET.
Référence de publication: 2012001865/10.
(120000258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
16507
L
U X E M B O U R G
Midgard Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 110.996.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the tenth day of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg,
THERE APPEARED:
Breevast Midgard NV, with registered office at Kaya Richard, J.Beaujon Z/N, NL-Curaçao, The Netherlands Antilles,
duly represented by Mrs. Sonia Bidoli, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given
on November 9, 2011 (the Sole Shareholder).
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder, acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration
authorities.
The appearing party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:
the Shareholder holds all the shares in MIDGARD LUXEMBOURG, a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-1610 Luxembourg, 42-44,
Avenue de la Gare, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 110.996 (the
Company)
- the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître André SCHWACHTGEN, then notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated October 4, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, No. 132 of January 19, 2006.
- the Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by 100 (one hundred)
shares, having a par value of EUR 125,-(one hundred and twenty-five euro) each, all entirely subscribed and fully paid up;
the Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, hereby resolves to proceed with the
dissolution of the Company with effect from today;
the Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
the Shareholder has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly knows the financial
situation of the Company;
the closing financial statement of the Company for the period from January 1, 2011 through September 30, 2011 is
approved;
the Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for their respective mandates from the date
of their respective appointments up to the date of the present meeting;
the Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known
liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Shareholder is vested with all the assets and
hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular
those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;
the Shareholder shall perform, register, execute or undertake any other step required in order to transfer to it all
the assets and/or all outstanding liabilities (if any) of the Company;
consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed; and
the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting
at L-1610Luxembourg, 42-44, Avenue de la Gare;
that Luxembourg Finance House SA, with power of substitution, is authorized in the name and on behalf of the sole
shareholder to file any tax declaration, notice to the trade register and any other documents necessary or useful for the
finalization of the liquidation.
The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version shall prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mil onze, le dix novembre.
16508
L
U X E M B O U R G
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Breevast Midgard NV, avec siège social à Kaya Richard, J.Beaujon Z/N, NL-Curaçao, les Antilles Néerlandaises, dûment
représentée par Madame Sonia Bidoli, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration émise le
9 novembre 2011 (l’Associé).
Laquelle procuration après signature «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistre-
ment.
Laquelle partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
l’Associé détient toutes les parts sociales de MIDGARD LUXEMBOURG, une société à responsabilité limitée organisée
selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, Avenue de la Gare, enregistrée au
registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 110.996 (la Société);
- la Société a été constituée en vertu d’un acte de Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 4 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, N°132 du 19 janvier 2006 .
- le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 125,-(cent vingt-cinq euros) chacune, toutes intégra-
lement souscrites et entièrement libérées;
l’Associé, en sa qualité d’associé unique de la Société et bénéficiaire économique finale de l’opération, décide de
procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat;
l’Associé assume le rôle de liquidateur de la Société;
l’Associé a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société;
le bilan de clôture de la Société pour la période du 1
er
janvier 2011 au 30 septembre 2011 est approuvé;
l’Associé accorde décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leurs mandats à compter de la date de
leurs nominations respectives jusqu’à la date de la présente assemblée;
l’Associé, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu de
la Société a été payé ou provisionné, que l’Associé est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expressément à prendre à
sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce
jour avant tout paiement à sa personne;
l’Associé accomplira, enregistrera, exécutera ou entreprendra tout autre étape requise afin de transférer à elle-même
tout l’actif et/ou passif impayé de la Société;
partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée; et
les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de
la présente assemblée à L-1610 Luxembourg, 42-44, Avenue de la Gare;
que Luxembourg Finance House SA, avec pouvoir de substitution, est autorisé au nom et pour le compte de l’Associé
unique de déposer toute déclaration fiscale, réquisition au registre de commerce et tout autre document nécessaire ou
simplement utile pour la finalisation de la liquidation.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, certifie par les présentes qu’à la demande de la partie com-
parante, le présent acte a été créé en anglais suivi d'une traduction française, et en cas de divergences entre les versions
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: S. Bidoli et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 novembre 2011. LAC/2011/51117. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012001855/106.
(120000533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
16509
L
U X E M B O U R G
Rocval S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 109.555.
Le siège social du commissaire, AUDIEX S.A., est désormais le suivant:
9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Référence de publication: 2012001945/11.
(120000199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Royal Bengal S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 161, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 65.875.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012001947/10.
(120000683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
The Grande International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 145.320.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012001998/10.
(120000678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 102.282.
La convention de domiciliation conclue entre TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., 127, rue de Mühlenbach, L-2168
Luxembourg, la société V.T.F. 4 Shipping Company S.A. société anonyme enregistrée au registre de commerce de Lu-
xembourg sous le numéro RCS B 102.282, a été dénoncée avec effet immédiat par le domiciliataire en date du 27 décembre
2011; le siège de la société est ainsi dénoncé.
Trustconsult Luxembourg S.A.
<i>Le Domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2012002026/13.
(120000570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
The Grande International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 145.320.
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012001999/10.
(120000679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
16510
L
U X E M B O U R G
Family Invest S.A., Société Anonyme,
(anc. Sörensen-Finance S.A.).
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 48.468.
L'an deux mille onze,
le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «SÖRENSEN-FINANCE
S.A.» (la «Société»), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 10B rue
des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date 19
juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 487 du 26 novembre
1994, page 23332. La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous
le numéro 48 468. Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné à la
date du 23 septembre 2008, lequel acte fut publié au Mémorial en date du 12 septembre 2009, sous le numéro 1767 et
page 84801.
L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre ANGÉ, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle à Bertrange (Luxembourg).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Emilie BOVRISSE, employée privée, avec adresse professionnelle à
Bertrange (Luxembourg).
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylviane SZUMILAS, employée privée, avec adresse professionnelle
à Bertrange (Luxembourg).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l'Assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de changer la dénomination sociale de la Société de «SÖRENSEN-FINANCE S.A» en celle de «FAMILY
INVEST S.A.»;
2. Décision de modifier l'article premier (1
er
) des statuts de la Société, afin de refléter le changement de nom de la
Société.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée DECIDE de changer la dénomination sociale de la Société de «SÖRENSEN-FINANCE S.A.» en celle de
«FAMILY INVEST S.A.».
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ledit changement de nom de la Société, l'Assemblée DECIDE de modifier l'article premier (1
er
) des
statuts de la Société, pour lui donner désormais la nouvelle teneur qui suit:
Art. 1
er
. «Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «FAMILY INVEST S.A.».»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. ANGÉ, E. BOVRISSE, S. SZUMILAS, J.J. WAGNER.
16511
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18238. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012003366/59.
(120002098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Tiar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 141.123.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002000/9.
(110213315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Tiar Publications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 141.124.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002001/9.
(110213318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Trucks and Trailer Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, Op der Hei.
R.C.S. Luxembourg B 106.114.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2012002006/12.
(110213289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Mirabelle Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 162.648.
EXTRAIT
- Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 17 novembre 2011 que M. Mark Shaw, gérant
B de la Société, a transféré une (1) part sociale de classe B et une (1) part sociale de classe C détenues dans la Société à
M. Alistair Tidey, né le 27 novembre 1964 à Croydon, Royaume-Uni, ayant pour adresse Mount Eagle, Vico Road, Killiney,
County Dublin, Irlande.
- En date du 17 novembre 2011, M. Alistair Tidey, né le 27 novembre 1964 à Croydon, Royaume-Uni, ayant pour
adresse Mount Eagle, Vico Road, Killiney, County Dublin, Irlande a été nommé gérant B de la Société avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002528/18.
(120000750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
16512
ACMBernstein Strategies
Amundi Funds
Andreas Portfolio S.à r.l.
Atos Belgium
Auto Logistic Transport
AZ FUND Management S.A.
BIL Holding I Sàrl
Botulie Invest S.A., SPF
BRE/Star Holding S.à r.l.
Calypso Fuchs Invest
Comptoir Immobilier Luxembourgeois
Conafex Holdings Société Anonyme
Conafex Holdings Société Anonyme
Conceptu'l S.à r.l.
Crebim S.A.
Cristina S.àr.l.
D&R IndiGO
D&R Multi Asset Strategy
Edalux
ESCF Soparfi A S.à r.l.
Euro Motors S.à.r.l.
Family Invest S.A.
Farmabios International S.A.
FBP Funds Sicav
Fluglehrer- und Pilotenservice S.à r.l.
Fu Hua S.à.r.l.
Georose 4
Georose 7
GLL AMB Generali Bankcenter S.à r.l.
i-CAP Luxembourg
ISPC II LLC Cie. SCS ("société en commandite simple")
Lancelot Ector
LaSalle UK Property Company S.à r.l.
L Select
Midgard Luxembourg
Mirabelle Investments S.à r.l.
MK Luxinvest S.A.
Murten Financière S.A.
Murten Financière S.A.
Novamex - Promotion Industrielle et Financière S.A.
Riviera Property S.A.
Rocval S.A.
Royal Bengal S.à.r.l.
Sonoco Asia Holding S.à r.l.
Sörensen-Finance S.A.
Stena Forth Lux 3 S.à r.l.
The Grande International Holdings S.à r.l.
The Grande International Holdings S.à r.l.
Tiar Holdings S.à r.l.
Tiar Publications S.à r.l.
Trucks and Trailer Company S.A.
TÜV Rheinland Luxemburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vouvray S.A. SPF
V.T.F. 4 Shipping Company S.A.
Zellbios S.A.