logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 279

2 février 2012

SOMMAIRE

Alpaga Promotions SA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13390

Alur Constructions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

13391

Atlas Sport S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13379

Beam Holdings (Luxembourg) S.à r.l.  . . . .

13374

Beech Tree S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13372

Carat (Lux) SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13355

Commerzbank International Portfolio Ma-

nagement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13364

Dimaco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13383

Estates Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

13363

F.D.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13356

Field Point PE VII (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13385

Finimmo Holding SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13363

Fonds Direkt Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13355

H & A Lux Wandelanleihen Fonds  . . . . . . .

13378

H & A Lux Wandelanleihen Fonds  . . . . . . .

13378

Health & Safety Systems S.A.  . . . . . . . . . . .

13378

HFB Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

13356

Intelsat (Luxembourg) Finance Company

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13364

JamaicaLux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13362

Julius Baer Multicash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13360

Julius Baer Multicooperation  . . . . . . . . . . . .

13358

Julius Baer Multilabel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13353

Julius Baer Multirange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13357

Konnick Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13348

Le Bon Café  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13384

Logitrans Europ S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13349

LUX. FINANCIAL COMPANY Spf S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13392

Maaskade S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13388

Machilu S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13386

Marketing Control Holding S.A.  . . . . . . . . .

13392

M.S. Lux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13392

MVM Lux Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13369

My Stone Lux s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13392

NKCS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13392

Orco Property Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13351

Orco Property Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13349

Orco Property Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13346

Pelican S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13379

Pet Club Finance S.à.r.l. SICAR  . . . . . . . . .

13382

Pinxton S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13382

Portus Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13390

PWPREF I Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

13383

PWREF I Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

13383

Rafael Productions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

13384

Reflexion Coiffure Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13385

RM2 International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13362

RM2 International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13361

RPFFB Soparfi C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13385

Selfridges Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

13383

Skyscraper S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13387

Société Internationale de Gestion et Con-

trôle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13387

Solway Commodities Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .

13383

Spimelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13363

StarCap SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13367

Swiss Euro Securities SA - Société de Titri-

sation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13386

Thundercat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13391

Trendconcept Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13377

Trendconcept Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13377

Trendconcept Fund Multi Asset Allocator

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13377

Trendconcept Fund Multi Asset Allocator

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13358

Tuvalu Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13386

WBB Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13346

Wert Investment Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

13391

Whysol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13391

13345

L

U X E M B O U R G

WBB Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 134.002.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société WBB INVEST S.A. qui se réunira le <i>20 février 2012 à 10 heures au siège social de la Société, pour délibérer

sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- approbation de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société nonobstant la date statutaire;
- présentation et approbation du rapport établi par le commissaire de la Société concernant les comptes annuels de

la Société au 31 décembre 2009;

- présentation et approbation des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2009;
- affectation des résultats;
- décision à prendre, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle qu'elle a été modifiée, sur la continuation des activités de la Société;

- décharge à donner aux membres du conseil d'administration de la Société et au commissaire de la Société pour

l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clos au 31 décembre 2009;

- pouvoirs à donner;
- divers.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social de la société quinze jours avant la date de l'assemblée générale

ordinaire de la Société.

Si vous deviez ne pas pouvoir être présent à l'Assemblée générale ordinaire de la Société, des procurations sont

disponibles au siège de la Société, elles vous seront adressées sur simple demande écrite pour les actionnaires nominatifs.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012014362/29.

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

At the request of Mr Luc Leroi, bondholders' representative, a

GENERAL MEETING

of the holders of the bonds registered under ISIN code: FR0010333302 (the “Bonds 2013”) as described in the Pros-

pectus (as defined below) issued by the Company in relation to the issue on June 1, 2006 of € 149.999.928, 1 per cent
convertible bonds due May 31, 2013 at an issue price: € 138, represented by 1.086.956 convertible bonds with a par value
of € 145, for which the visa on the prospectus was delivered by the CSSF on May 17, 2006 (the “Prospectus”), will be
held at 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, on <i>February 20, 2012 at 10.45 Central European time (“CET”) (the
“Meeting”). The Meeting will be held in order to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. Continuation of the proceedings before the Paris court of Appeals relating to the admission of the bondholder

claim in Orco Property Group's safeguard proceedings;

2. Funding of the proceedings before the Paris commercial court and the Paris court of Appeals relating to the ad-

mission of the bondholder claim in Orco Property Group's safeguard proceedings, including payment or reimbur-
sement of costs and fees already incurred, in particular out of amounts to be paid to the bondholders by Orco
Property Group under its safeguard plan;

3. Continuation of the proceedings before the Paris commercial court relating to the third party challenge against

Orco Property Group's safeguard plan;

4. Funding of the proceedings before the Paris commercial court relating to the third party challenge against Orco

Property Group's safeguard plan, including payment or reimbursement of costs and fees already incurred, in par-
ticular out of amounts to be paid to the bondholders by Orco Property Group under its safeguard plan;

5. Miscellaneous.

13346

L

U X E M B O U R G

The voting certificate, hereinafter mentioned, necessary to be represented and participate at the Meeting shall be at

the  disposal  of  the  holders  of  Bonds  2013  from  March  28,  2011  on  request  either  with  the  Company  on
www.orcogroup.com or with the Bondholders Representative by email at lleroi@pt.lu.

Copies of the Prospectus and the articles of association of the Company are available on the Company's website at

http://www.orcogroup.com and at the registered office of the Company upon request.

The Bondholder's representative would like to point out that for holders of Bonds 2013 of the Company, the conditions

for attendance or representation at the Meeting are as follows:

1. Authorization to participate
As mentioned in the Prospectus, holders of Bonds 2013 (“Bondholders”), and proxies showing a voting certificate and

register of voting certificates issued by the Paying Agent CACEIS Corporate Trust can attend and vote at any meeting.
The Company and its legal advisors, as well as its respective financial advisors and such other persons as may be accepted
by the meeting, may attend and speak at the meeting. Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy
given by a Beneficial Owner will remain valid and effective for an adjourned Meeting. Beneficial Owner who took no action
in respect of the Meeting can give instructions for the adjourned Meeting by following the same procedure.

2. Participation in and Voting at the Meeting
In accordance with Article 94-2 and 94-3 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended (the

“Law”), the quorum at the general meeting shall be 50% of the outstanding Bonds 2013. The resolutions will be passed
by 2/3 of the votes cast by the Bondholders present or represented at the Meeting.

The attention of Bondholders is particularly drawn to the fact that the Meeting can take resolutions that will validly

bind all the Bondholders (even those not represented at the Meeting). In addition, Article 94-5 of the Law provides that
when a Bondholder representative has been appointed in accordance with the provisions of the Law, Bondholders may
no longer exercise their rights individually.

As is customary for securities such as the Bonds 2013, the Bonds 2013 are generally held through banks or other

financial institutions (“Intermediaries”) which have accounts with the clearing and depositary systems, Euroclear Bank
S.A./N.V., as operator of the Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream
Luxembourg”), through which transactions in the Bonds 2013 are effected.

All of the Bonds 2013 are represented by a bearer global bond (the “Global Bond”). The Global Bond is presently held

by a common depositary for Euroclear and Clearstream Luxembourg.

Each person (a “Beneficial Owner”) who is the owner of a particular principal amount of the Bonds 2013, through

Euroclear, Clearstream Luxembourg or their respective account holders with Euroclear or Clearstream Luxembourg
(the “Accountholders”), should be entitled to attend and vote at the Meeting in accordance with the procedures set out
below.

Voting instructions may be delivered only through direct Accountholders with the type of vote: in favour of / against /

abstain from the proposed resolution mentioned in the Agenda and by stating the Principal Amount of Bonds 2013. A
splitting of the resolutions is not accepted.

In order to obtain a voting certificate or instruct the Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting

(or any adjourned Meeting, as the case may be) in accordance with a Bondholder's instructions, an Accountholder must
procure delivery of an electronic voting instruction, in accordance with the procedures of Euroclear or Clearstream
Luxembourg, to the relevant Paying Agent prior to the Expiration Time on the Expiration Date all of them as defined
below.

If a Bondholder is not wishing to attend and vote at the Meeting or any adjourned such Meeting in person, he can

instruct the Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the meeting or any adjourned such Meeting on his
behalf with the type of vote: in favour of / against / abstain from the proposed resolution. A splitting of the resolutions is
not accepted.

Bondholders may also allow their voting right in the Bondholders meeting to be exercised by an authorized repre-

sentative, e.g. allow another person of their choice to act as proxy. The authorizations must be issued in writing.

Beneficial Owners who are not Accountholders must arrange through their broker, dealer, commercial bank, custo-

dian, trust company or other nominee to contact the Accountholder through which they hold their Bond(s) 2013 in order
to procure delivery of their voting instructions via Euroclear or Clearstream, Luxembourg to the relevant Paying Agent
prior to the Expiration Time on the Expiration Date.

The expiration time shall be 14h30 CET (the “Expiration Time”) of February 16, 2012 (the “Expiration Date”). The

Company has the right to postpone the Expiration Date; in that case, notice of such postponement shall be given to the
Bondholders.

Once the Paying Agent has issued a voting certificate for a meeting in respect of a Bonds 2013, it shall not release the

Bond 2013 until either (i) the meeting has been concluded or (ii) the voting certificate has been surrendered to the Paying
Agent. A vote cast in accordance with a block voting instruction may not be revoked or altered during the 48 hours
before the time fixed for the meeting.

13347

L

U X E M B O U R G

Beneficial Owners should note that they must allow sufficient time for compliance with the standard operating pro-

cedures of Euroclear and Clearstream Luxembourg and, if applicable, such Accountholder in order to ensure delivery of
their voting instructions to the Paying Agent in accordance with the time-frame set out in this Notice. Beneficial Owners
are urged to contact any such person promptly to ensure timely delivery of such voting instructions.

Once instructions to participate in the Meeting or to vote by proxy have been given, the Beneficial Owner's interest

in the Bonds 2013 will be blocked until the conclusion of the Meeting or the adjourned Meeting. This means that it may
not be possible to sell such Bonds 2013 until the conclusion of the Meeting or any adjourned Meeting.

Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid and

effective for the adjourned Meeting. Beneficial Owners who took no action in respect of the Meeting can give instructions
for the adjourned Meeting by following the same procedure set forth above.

For the purposes of this Notice, “48 hours” and “24 hours” shall mean a period of 48 hours or 24 hours, respectively,

including all or part of a day upon which banks are open for business in both the place where the relevant meeting is to
be held and in each of the places where the Paying Agent have their specified offices (disregarding for this purpose the
day upon which such meeting is to be held) and such period shall be extended by one period or, to the extent necessary,
more periods of 24 hours or 48 hours until there is included as aforesaid all or part of a day upon which banks are open
for business as aforesaid.

The period to give instructions is scheduled from February 6, 2012 to February 16, 2012.
Last deadline to receive the Electronic Voting Instruction is February 16, 2012.
Last deadline for revocation, for cancellation or changes is February 16, 2012.

3. Contact

The Bondholder representative

Mr Luc Leroi
13A, rue de Clairefontaine
L-8460 Eischen
Email: lleroi@pt.lu

The Paying Agent

CACEIS Corporate Trust
Service assemblées
14, rue du Rouget de Lisle, F-92889 Issy les Moulineaux
Fax: +33 1.49.08.05.82
Email: CT-Contact@caceis.com

The Company

ORCO PROPERTY GROUP, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
Tel: +352 26 47 67 1
Fax: +352 26 47 67 67

Eischen, February 2, 2012.

Luc Leroi
<i>Bondholder representative

Référence de publication: 2012015694/122.

Konnick Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 32.270.

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le <i>17 février 2012 , à neuf heures, au siège social,

en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sur les comptes des exercices

clos les 31 décembre 2009 et 2010, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire
aux Comptes

13348

L

U X E M B O U R G

- Affectation du résultat
- Examen de la situation des mandats, renouvellement des administrateurs, désignation d'un nouveau commissaire

aux comptes,

- Questions diverses

A l'issue de cette assemblée se tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la dis-

solution ou non de la société conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 modifiée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012014363/20.

Logitrans Europ S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 88.638.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>20 février 2012 à 16h00 au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

- Présentation du rapport intermédiaire du liquidateur relatif à l'exercice clôturé au 30 juin 2011.
- Présentation du bilan arrêté au 30 juin 2011 et du compte de profits et pertes y relatif.
- Divers.

Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq

jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

<i>Le Liquidateur.

Référence de publication: 2012015112/17.

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

At the request of Mr Luc Leroi, bondholders' representative, a

GENERAL MEETING

of the holders of the bonds registered under ISIN code: FR0010249599 (the "Bonds 2010") as described in the Pros-

pectus (as defined below) issued by the Company in relation to the issue on March 28, 2007 of € 50,272,605.30, 4.5 per
cent bonds with redeemable share subscription warrants attached due November 18, 2005 at an issue price: € 686.10,
represented by 73.273 bonds with a par value of € 686.10, for which the visa on the prospectus was delivered by the
CSSF on November 14, 2005 (the "Prospectus"), will be held at 24 rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg, on <i>February
20, 2012 at 10,00 Central European time ("CET") (the "Meeting"). The Meeting will be held in order to consider the
following agenda:

<i>Agenda:

1. Continuation of the proceedings before the Paris court of Appeals relating to the admission of the bondholder

claim in Orco Property Group's safeguard proceedings;

2. Funding of the proceedings before the Paris commercial court and the Paris court of Appeals relating to the ad-

mission of the bondholder claim in Orco Property Group's safeguard proceedings, including payment or reimbur-
sement of costs and fees already incurred, in particular out of amounts to be paid to the bondholders by Orco
Property Group under its safeguard plan;

3. Continuation of the proceedings before the Paris commercial court relating to the third party challenge against

Orco Property Group's safeguard plan;

4. Funding of the proceedings before the Paris commercial court relating to the third party challenge against Orco

Property Group's safeguard plan, including payment or reimbursement of costs and fees already incurred, in par-
ticular out of amounts to be paid to the bondholders by Orco Property Group under its safeguard plan,

5. Miscellaneous.

The voting certificate, hereinafter mentioned, necessary to be represented and participate at the Meeting shall be at

the disposal of the holders of Bonds 2010 from February 6, 2012 on request with the Company on www.orcogroup.com
or with the bondholders representative (contact lleroi@pt.lu)

13349

L

U X E M B O U R G

Copies of the Prospectus and the articles of association of the Company are available on the Company's website at

http://www.orcogroup.com. and at the registered office of the Company upon request.

The Bondholder's representative would like to point out that for holders of Bonds 2010 of the Company, the conditions

for attendance or representation at the Meeting are as follows:

1. Authorization to participate
As mentioned in the Prospectus, holders of Bonds 2010 ("Bondholders"), and proxies showing a voting certificate and

register of voting certificates issued by the Paying Agent CACEIS Corporate Trust can attend and vote at any meeting.
The Company and its legal advisors, as well as its respective financial advisors and such other persons as may be accepted
by the meeting, may attend and speak at the meeting. Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy
given by a Beneficial Owner will remain valid and effective for an adjourned Meeting. Beneficial Owner who took no action
in respect of the Meeting can give instructions for the adjourned Meeting by following the same procedure.

2. Participation in and Voting at the Meeting
In accordance with Article 94-2 and 94-3 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended (the

"Law"), the quorum at the general meeting shall be 50% of the outstanding Bonds 2010. The resolutions will be passed
by 2/3 of the votes cast by the Bondholders present or represented at the Meeting.

The attention of Bondholders is particularly drawn to the fact that the Meeting can take resolutions that will validly

bind all the Bondholders (even those not represented at the Meeting). In addition, Article 94-5 of the Law provides that
when a Bondholder representative has been appointed in accordance with the provisions of the Law, Bondholders may
no longer exercise their rights individually.

As is customary for securities such as the Bonds 2010, the Bonds 2010 are generally held through banks or other

financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with the clearing and depositary systems, Euroclear Bank
S.A./N.V., as operator of the Euroclear System ("Euroclear") and Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream,
Luxembourg"), through which transactions in the Bonds 2010 are effected.

All of the Bonds 2010 are represented by a bearer global bond (the "Global Bond"). The Global Bond is presently held

by a common depositary for Euroclear and Clearstream Luxembourg.

Each person (a "Beneficial Owner") who is the owner of a particular principal amount of the Bonds 2010, through

Euroclear, Clearstream Luxembourg or their respective account holders with Euroclear or Clearstream Luxembourg
(the "Accountholders"), should be entitled to attend and vote at the Meeting in accordance with the procedures set out
below.

Voting instructions may be delivered only through direct Accountholders with the type of vote: in favour of / against /

abstain from the proposed resolution mentioned in the Agenda and by stating the Principal Amount of Bonds 2010. A
splitting of the resolutions is not accepted.

In order to obtain a voting certificate or instruct the Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting

(or any adjourned Meeting, as the case may be) in accordance with a Bondholder's instructions, an Accountholder must
procure delivery of an electronic voting instruction, in accordance with the procedures of Euroclear or Clearstream
Luxembourg, to the relevant Paying Agent prior to the Expiration Time on the Expiration Date all of them as defined
below.

If a Bondholder is not wishing to attend and vote at the Meeting or any adjourned such Meeting in person, he can

instruct the Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the meeting or any adjourned such Meeting on his
behalf with the type of vote: in favour of / against / abstain from the proposed resolution. A splitting of the resolutions is
not accepted.

Bondholders may also allow their voting right in the Bondholders meeting to be exercised by an authorized repre-

sentative, e.g. allow another person of their choice to act as proxy. The authorizations must be issued in writing.

Beneficial Owners who are not Accountholders must arrange through their broker, dealer, commercial bank, custo-

dian, trust company or other nominee to contact the Accountholder through which they hold their Bond(s) 2010 in order
to procure delivery of their voting instructions via Euroclear or Clearstream, Luxembourg to the relevant Paying Agent
prior to the Expiration Time on the Expiration Date.

The expiration time shall be 14h30 CET (the "Expiration Time") of February 16, 2012 (the "Expiration Date"). The

Company has the right to postpone the Expiration Date; in that case, notice of such postponement shall be given to the
Bondholders.

Once the Paying Agent has issued a voting certificate for a meeting in respect of a Bonds 2010, it shall not release the

Bond 2010 until either (i) the meeting has been concluded or (ii) the voting certificate has been surrendered to the Paying
Agent. A vote cast in accordance with a block voting instruction may not be revoked or altered during the 48 hours
before the time fixed for the meeting.

Beneficial Owners should note that they must allow sufficient time for compliance with the standard operating pro-

cedures of Euroclear and Clearstream Luxembourg and, if applicable, such Accountholder in order to ensure delivery of
their voting instructions to the Paying Agent in accordance with the time-frame set out in this Notice. Beneficial Owners
are urged to contact any such person promptly to ensure timely delivery of such voting instructions.

13350

L

U X E M B O U R G

Once instructions to participate in the Meeting or to vote by proxy have been given, the Beneficial Owner's interest

in the Bonds 2010 will be blocked until the conclusion of the Meeting or the adjourned Meeting. This means that it may
not be possible to sell such Bonds 2010 until the conclusion of the Meeting or any adjourned Meeting.

Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid and

effective for the adjourned Meeting. Beneficial Owners who took no action in respect of the Meeting can give instructions
for the adjourned Meeting by following the same procedure set forth above.

For the purposes of this Notice, "48 hours" and "24 hours" shall mean a period of 48 hours or 24 hours, respectively,

including all or part of a day upon which banks are open for business in both the place where the relevant meeting is to
be held and in each of the places where the Paying Agent have their specified offices (disregarding for this purpose the
day upon which such meeting is to be held) and such period shall be extended by one period or, to the extent necessary,
more periods of 24 hours or 48 hours until there is included as aforesaid all or part of a day upon which banks are open
for business as aforesaid.

The period to give instructions is scheduled from February 6, 2012 to February 16, 2012
Last deadline to receive the Electronic Voting Instruction is February 16, 2012
Last deadline for revocation, for cancellation or changes is February 16, 2012

3. Contact
The Bondholder representative
Mr Luc Leroi
13a rue de Clairefontaine
L-8460 Eischen
Email: lleroi@pt.lu
The Paying Agent
CACEIS Corporate Trust
Service assemblées
14 rue du Rouget de Lisle F-92889 Issy les Moulineaux
Fax : +33 1.49.08.05.82
Email: CT-Contact@caceis.com
The Company
ORCO PROPERTY GROUP, 42, rue de la vallée, L-2661 Luxembourg
Tel: +352 26 47 67 1
Fax: +352 26 47 67 67

Eischen February 2, 2012.

Luc Leroi
<i>Bondholder representative

Référence de publication: 2012015695/123.

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

At the request of Mr Luc Leroi, bondholders' representative, a

GENERAL MEETING

of the holders of the bonds registered under ISIN code: XS0291838992 and XS0291840626 (the "Bonds 2014") as

described in the Prospectus (as defined below) issued by the Company in relation to the issue on March 28, 2007 of €
175.000.461,60, 2.5 per cent bonds with redeemable warrants attached due March 28, 2014 at an issue price: 97,10 per
cent, represented by 119.544 bonds of € 1421,45 each, for which a visa on the prospectus was delivered by the CSSF
(the "Prospectus"), will be held at 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg, on <i>February 20, 2012 at 11.30 Central
European time ("CET") (the "Meeting"). The Meeting will be held in order to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. Continuation of the proceedings before the Paris court of Appeals relating to the admission of the bondholder

claim in Orco Property Group's safeguard proceedings;

2. Funding of the proceedings before the Paris commercial court and the Paris court of Appeals relating to the ad-

mission of the bondholder claim in Orco Property Group's safeguard proceedings, including payment or reimbur-
sement of costs and fees already incurred, in particular out of amounts to be paid to the bondholders by Orco
Property Group under its safeguard plan;

13351

L

U X E M B O U R G

3. Continuation of the proceedings before the Paris commercial court relating to the third party challenge against

Orco Property Group's safeguard plan;

4. Funding of the proceedings before the Paris commercial court relating to the third party challenge against Orco

Property Group's safeguard plan, including payment or reimbursement of costs and fees already incurred, in par-
ticular out of amounts to be paid to the bondholders by Orco Property Group under its safeguard plan,

5. Miscellaneous.

The voting certificate, hereinafter mentioned, necessary to be represented and participate at the Meeting shall be at

the  disposal  of  the  holders  of  Bonds  2014  from  February  6,  2012  on  request  either  with  the  Company  on
www.orcogroup.com, with the Bondholders Representative by email at lleroi@pt.lu.

Copies of the Prospectus, the Safeguard Plan and the articles of association of the Company are available on the

Company's website at http://www.orcogroup.com. and at the registered office of the Company upon request.

The Bondholder's representative would like to point out that for holders of Bonds 2014 of the Company; the conditions

for attendance or representation at the Meeting are as follows:

1. Authorization to participate
As mentioned in the Prospectus, holders of Bonds 2014 ("Bondholders"), and proxies showing a voting certificate and

register of voting certificates issued by the Paying Agent (Bank of New York Mellon, Brussels Branch, Avenue des Arts
35, B-1040 Brussels (Belgium)) can attend and vote at any meeting. The Company and its legal advisors, as well as its
respective financial advisors and such other persons as may be accepted by the meeting, may attend and speak at the
meeting. Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid
and effective for an adjourned Meeting. Beneficial Owner who took no action in respect of the Meeting can give instruc-
tions for the adjourned Meeting by following the same procedure.

2. Participation in and Voting at the Meeting
In accordance with Article 94-2 and 94-3 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended (the

"Law"), the quorum at the general meeting shall be 50% of the outstanding Bonds 2014. The resolutions will be passed
by 2/3 of the votes cast by the Bondholders present or represented at the Meeting.

The attention of Bondholders is particularly drawn to the fact that the Meeting can take resolutions that will validly

bind all the Bondholders (even those not represented at the Meeting). In addition, Article 94-5 of the Law provides that
when a Bondholder representative has been appointed in accordance with the provisions of the Law, Bondholders may
no longer exercise their rights individually.

As is customary for securities such as the Bonds 2014, the Bonds 2014 are generally held through banks or other

financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with the clearing and depositary systems, Euroclear Bank
S.A./N.V., as operator of the Euroclear System ("Euroclear") and Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream
Luxembourg"), through which transactions in the Bonds 2014 are effected.

All of the Bonds 2014 are represented by a bearer global bond (the "Global Bond"). The Global Bond is presently held

by a common depositary for Euroclear and Clearstream Luxembourg.

Each person (a "Beneficial Owner") who is the owner of a particular principal amount of the Bonds 2014, through

Euroclear, Clearstream Luxembourg or their respective account holders with Euroclear or Clearstream Luxembourg
(the "Accountholders"), should be entitled to attend and vote at the Meeting in accordance with the procedures set out
below.

Bondholders may also allow their voting right in the Bondholders meeting to be exercised by an authorized repre-

sentative, e.g. allow another person of their choice to act as proxy. The authorizations must be issued in writing.

Beneficial Owners who are not Accountholders must arrange through their broker, dealer, commercial bank, custo-

dian, trust company or other nominee to contact the Accountholder through which they hold their Bond(s) 2014 in order
to procure delivery of their voting instructions if any via Euroclear or Clearstream, Luxembourg to the relevant Paying
Agent prior to the Expiration Time on the Expiration Date.

The expiration time shall be 14h30 CET (the "Expiration Time") of February 16 (the "Expiration Date"). The Company

has the right to postpone the Expiration Date; in that case, notice of such postponement shall be given to the Bondholders.

Once the Paying Agent has issued a voting certificate for a meeting in respect of a Bonds 2014, it shall not release the

Bond 2014 until either (i) the meeting has been concluded or (ii) the voting certificate has been surrendered to the Paying
Agent. A vote cast in accordance with a block voting instruction may not be revoked or altered during the 48 hours
before the time fixed for the meeting.

Beneficial Owners should note that they must allow sufficient time for compliance with the standard operating pro-

cedures of Euroclear and Clearstream Luxembourg and, if applicable, such Accountholder in order to ensure delivery of
their voting instructions if any to the Paying Agent in accordance with the time-frame set out in this Notice. Beneficial
Owners are urged to contact any such person promptly to ensure timely delivery of such voting instructions.

Once instructions to participate in the Meeting or to vote by proxy have been given, the Beneficial Owner's interest

in the Bonds 2014 will be blocked until the conclusion of the Meeting or the adjourned Meeting. This means that it may
not be possible to sell such Bonds 2014 until the conclusion of the Meeting or any adjourned Meeting.

13352

L

U X E M B O U R G

Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid and

effective for the adjourned Meeting. Beneficial Owners who took no action in respect of the Meeting can give instructions
for the adjourned Meeting by following the same procedure set forth above.

For the purposes of this Notice, "48 hours" and "24 hours" shall mean a period of 48 hours or 24 hours, respectively,

including all or part of a day upon which banks are open for business in both the place where the relevant meeting is to
be held and in each of the places where the Paying Agent have their specified offices (disregarding for this purpose the
day upon which such meeting is to be held) and such period shall be extended by one period or, to the extent necessary,
more periods of 24 hours or 48 hours until there is included as aforesaid all or part of a day upon which banks are open
for business as aforesaid.

The period to give instructions is scheduled from February 6, 2012 to February 16, 2012
Last deadline to receive the Electronic Voting Instruction is February 16, 2012
Last deadline for revocation, for cancellation or changes is February 16, 2012

3. Contact
The Bondholder representative
Luc Leroi
13a rue de Clairefontaine
L-8460 Eischen
Email: lleroi@pt.lu
The Paying Agent
Bank of New York Mellon, Brussels Branch,
Avenue des Arts 35, B-1040 Brussel
Tel: +32 2 326 12 11
Email: latoya.austin@bnymellon.com
The Company
ORCO PROPERTY GROUP, 42, rue de la vallée, L-2661 Luxembourg
Tel: +352 26 47 67 1
Fax: +352 26 47 67 67

Eischen March 22, 2011.

Luc Leroi
<i>Bondholder representative

Référence de publication: 2012015696/109.

Julius Baer Multilabel, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 149.126.

Eine ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre (die "Generalversammlung") der Julius Baer Multilabel (die "Gesellschaft") wird in 69, route d'Esch,

L-1470 Luxemburg am <i>5. März 2012 um 10.10 Uhr (Luxemburger Zeit) stattfinden.

<i>Tagesordnung:

Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
- Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlage ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
- Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als ge-
setzliche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der
Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
- Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
- Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer General-
versammlung

13353

L

U X E M B O U R G

- Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
- Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
- Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
- Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
- Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
- Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
- Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
- Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
- Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
- Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im
Rechtsprospekt zu regeln
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
- Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
- Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge
und im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
- Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
- Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
- Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
- (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
-  (B)  Verbindlichkeiten  lit.  b)  ausdrückliche  Erwähnung  der  Anlageverwalter  als  Empfänger  von  Gebühren  und
Dienstleister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
- Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre am

1. Februar 2012 vor einem Notar am Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde, welche nicht wirksam über die Punkte der
Tagesordnung beschließen konnte, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über
die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde, dass für Beschlüsse der zweiten außerordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre an der zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre gefasst werden.

Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-

nisatorischen Gründen bis zum 27. Februar 2012 bei Julius Baer Multilabel, 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg c/o 69,
route d'Esch, L-1470 Luxemburg, zu Händen von Herrn Gerard Pirsch (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2012016283/755/84.

13354

L

U X E M B O U R G

Carat (Lux) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 73.244.

Die Aktionäre der CARAT (LUX) SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>21. Februar 2012 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September

2011 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die ein-

fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der CARAT (LUX) SICAV (DZ PRIVATBANK

S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025, Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4506 oder E-Mail directors-
office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Luxembourg, im Februar 2012.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2012016284/755/29.

Fonds Direkt Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 70.709.

Die Aktionäre der Fonds Direkt Sicav werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>22. Februar 2012 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September

2011 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

13355

L

U X E M B O U R G

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Fonds Direkt Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.)

unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4506 oder unter eMail
directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Luxembourg, im Februar 2012.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2012016290/755/29.

HFB Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.740.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>21 février 2012 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012016287/795/18.

F.D.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.171.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>20 février 2012 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2011,

4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur la

législation des sociétés;

5. Nomination d'un Réviseur d'entreprises agréé pour l'opération d'augmentation de capital;
6. Suppression de la valeur nominale des actions;
7. Réduction du capital social à concurrence d'EUR 1.600.000,- (un million six cents mille euros) pour le porter de

son montant actuel d'EUR 1.600.000,- (un million six cents mille euros) à EUR 0,- (zero euros), pour l'apurement
des pertes d'exercice d'EUR 1.399.521,32 (un million trois cents quatre-vingt-dix-neuf mille cinq-cents vingt-et-un
virgule trente deux euros) et couverture partielle des résultats reportés négatifs à concurrence d'Eur 200.478,68
(deux cents mille quatre cents soixante-dix-huit virgule soixante huit euros) afin de ramener le montant des résultats
reportés négatifs d'Eur 4.912.295,42 (quatre millions neuf cents douze mille deux cents quatre-vingt-quinze virgule
quarante deux euros) à un montant résiduel d'Eur 4.711.816,74 (quatre millions sept cents onze mille huit cents
seize virgule soixante-quatorze euros), et annulation des 16.000 actions représentatives du capital social;

8. Contextuelle augmentation du capital social par conversion partielle de la créance de l'actionnaire majoritaire pour

un montant d'Eur 5.808.816,74 (cinq millions huit cents huit mille huit cents seize virgule soixante-quatorze euros)
pour le porter de son montant actuel de Eur 0,- (zéro euros) à un montant d'Eur 5.808.816,74 (cinq millions huit
cents huit mille huit cents seize virgule soixante-quatorze euros), et émission de 10.970 actions nouvelles sans
valeur nominale, à libérer par l'actionnaire majoritaire par incorporation partielle de l'avance;

9. Réduction de capital social, sans annulation d'actions, d'un montant d'Eur 4.711.816,74 (quatre millions sept cents

onze mille huit cents seize virgule soixante-quatorze euros) pour apurement des résultats reportés négatifs d'un
montant résiduel d'Eur 4.711.816,74 (quatre millions sept cents onze mille huit cents seize virgule soixante-quatorze
euros), pour ramener le capital social de son montant actuel d'Eur 5.808.816,74 (cinq millions huit cents huit mille

13356

L

U X E M B O U R G

huit cents seize virgule soixante-quatorze euros) à un montant d'Eur 1.097.000,- (un million quatre-vingt-dix-sept
mille euros), représenté par 10.970 (dix mille neuf cents soixante-dix) actions sans valeur nominale;

10. Modification afférentes de l'article 5 des Statuts;
11. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012016291/1023/40.

Julius Baer Multirange, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 152.081.

Eine ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre (die "Generalversammlung") der Julius Baer Multirange (die "Gesellschaft") wird in 69, route d'Esch,

L-1470 Luxemburg am <i>5. März 2012 um 10.00 Uhr (Luxemburger Zeit) stattfinden.

<i>Tagesordnung:

Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
- Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlage ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
- Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als ge-
setzliche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der
Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
- Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
- Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer General-
versammlung
- Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
- Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
- Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
- Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
- Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
- Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
- Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
- Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
- Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
- Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im
Rechtsprospekt zu regeln
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
- Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann

13357

L

U X E M B O U R G

Verschmelzung:
- Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge
und im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
- Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
- Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
- Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
- (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
-  (B)  Verbindlichkeiten  lit.  b)  ausdrückliche  Erwähnung  der  Anlageverwalter  als  Empfänger  von  Gebühren  und
Dienstleister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
- Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre am

1. Februar 2012 vor einem Notar am Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde, welche nicht wirksam über die Punkte der
Tagesordnung beschließen konnte, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über
die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde, dass für Beschlüsse der zweiten außerordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre an der zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre gefasst werden.

Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-

nisatorischen Gründen bis zum 27. Februar 2012 bei Julius Baer Multirange, 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg c/o 69,
route d'Esch, L-1470 Luxemburg, zu Händen von Herrn Gerard Pirsch (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2012016285/755/84.

Trendconcept Fund Multi Asset Allocator, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 11. Januar 2012 in Kraft trat. Das Allgemeine

Verwaltungsreglement wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Januar 2012.

TRENDCONCEPT FUND S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2012007926/11.
(120008411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Julius Baer Multicooperation, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 44.963.

Eine ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre (die  "Generalversammlung")  der  Julius  Baer  Multicooperation (die "Gesellschaft") wird am Sitz  der

Gesellschaft in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg am <i>5. März 2012 um 10.30 Uhr (Luxemburger Zeit) stattfinden.

<i>Tagesordnung:

Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
- Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlage ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:

13358

L

U X E M B O U R G

- Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als ge-
setzliche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der
Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
- Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
- Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer General-
versammlung
- Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
- Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
- Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
- Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
- Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
- Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
- Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
- Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
- Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
- Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im
Rechtsprospekt zu regeln
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
- Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
- Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge
und im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
- Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
- Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
- Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
- (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
-  (B)  Verbindlichkeiten  lit.  b)  ausdrückliche  Erwähnung  der  Anlageverwalter  als  Empfänger  von  Gebühren  und
Dienstleister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
- Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre am

1. Februar 2012 vor einem Notar am Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde, welche nicht wirksam über die Punkte der
Tagesordnung beschließen konnte, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über
die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde, dass für Beschlüsse der zweiten außerordentlichen Generalversammlung

13359

L

U X E M B O U R G

der Aktionäre kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre an der zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre gefasst werden.

Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-

nisatorischen Gründen bis zum 27. Februar 2012 bei Julius Baer Multicooperation, 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg,
zu Händen von Herrn Gerard Pirsch (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2012016288/755/84.

Julius Baer Multicash, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 36.405.

Eine ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre (die "Generalversammlung") der Julius Baer Multicash (die "Gesellschaft") wird am Sitz der Gesellschaft

in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg am <i>5. März 2012 um 10.20 Uhr (Luxemburger Zeit) stattfinden.

<i>Tagesordnung:

Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im We-
sentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
- Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlage ("Gesetz von 2010")
Gesellschaftskapital Artikel 5:
- Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als ge-
setzliche Folge der Änderung von Artikel 17 lit. f) (siehe unten) betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der
Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
- Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 13:
- Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer General-
versammlung
- Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 15:
- Neuregelung betr. die Beschlussfähigkeit
- Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
- Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 17:
- Lit. a) und c) Bezugnahme auf die geänderte rechtliche Grundlage
- Artikel 17 lit. f) Darstellung der gesetzlichen Möglichkeiten betr. Investition in OTC-Derivate
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010
aufzulegen, sofern auch im Prospekt zugelassen
- Artikel 17 lit. f) Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der
Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 18:
- Klarstellende Beschreibung der Verfahrensweise
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 19:
- Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 21:
- Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 23
Rücknahme:
- Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im
Rechtsprospekt zu regeln

13360

L

U X E M B O U R G

- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
- Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
- Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge
und im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
- Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 24:
- Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
- Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 26:
- (A) Aktiva lit. h) 4) Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
-  (B)  Verbindlichkeiten  lit.  b)  ausdrückliche  Erwähnung  der  Anlageverwalter  als  Empfänger  von  Gebühren  und
Dienstleister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 27:
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
Namensgebung der Gesellschaft Artikel 30:
- Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre am

1. Februar 2012 vor einem Notar am Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde, welche nicht wirksam über die Punkte der
Tagesordnung beschließen konnte, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über
die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde, dass für Beschlüsse der zweiten außerordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre an der zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre gefasst werden.

Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-

nisatorischen Gründen bis zum 27. Februar 2012 bei Julius Baer Multicash, 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, zu Händen
von Herrn Gerard Pirsch (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2012016292/755/84.

RM2 International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 132.740.

The shareholders of the Company are hereby convened to the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at the registered office 5, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, on <i> February 10 

<i>th

<i> , 2012  at 3.00

p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Remove of the nominal value of the shares of the Company;
2. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of 55.164.140,- USD so as to raise it from

its current amount of 122.860,- USD to the amount of 55.287.000,- USD by the issuance of 55.164.140 new shares,
equivalently distributed in each class of shares, having same rights than the existing shares and to be provided to
the shareholders in accordance with the prorate of their shareholding in the Company, by partial conversion of
the share premium in share capital;

3. Decrease of the par value of the shares of the Company from 1,- USD per share to 0,45 USD per share, by increase

of the number of the shares representing the share capital of the Company from 55.287.000 shares to 122.860.000
shares by issuance of 67.573.000 new shares, equivalently distributed in each class of shares, having same rights
than the existing shares and to be provided to the shareholders in accordance with the prorate of their shareholding
in the Company;

4. Reintroduction of the nominal value of the shares of the Company at 0,45 USD per share;
5. Renewal of the existing authorized share capital of the Company for a period of five years;
6. Increase of the authorized share capital of the Company by an amount of 67.340.143,5 USD so as to raise it from

its current amount of 232.860,- USD to the amount of 67.573.003,5 USD;

13361

L

U X E M B O U R G

7. Authorization to the board of directors for a period of five years (i) to increase from time to time the issued capital

within the limits of the authorized capital in one or several issues with or without issue premium by contribution
in kind or cash, (ii) for the purpose of (a) the exercise of warrants issued over shares of the Company up to the
amount of 6.757.303,5 USD (b) and the exercise of warrants or other instruments of equivalent nature or options
to be issued over shares of the Company in the frame of the employee share option scheme up to the amount of
5.528.700,- USD and to proceed to such issues without reserving to the existing shareholders a preferential right
to subscribe to the capital being issued;

8. Amendment of article 5 of the by-laws of the Company so as to reflect the decisions taken;
9. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2012009912/317/36.

JamaicaLux S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 128.026.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la Société JamaicaLux SA (en liquidation) qui se tiendra le <i>10 février 2012 à 14.00 heures à L-1420 Luxembourg, 5,

Avenue Gaston Diderich pour délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport des liquidateurs concernant les exercices se clôturant au 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31

décembre 2011;

2. Approbation du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe aux comptes sociaux arrêtés au 31 décembre

2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011;

3. Décharge aux liquidateurs;
4. Affectation des résultats;
5. Divers.

Luxembourg, le 17 janvier 2012.

<i>Les liquidateurs .

Référence de publication: 2012008661/19.

RM2 International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 132.740.

The shareholders of the Company are hereby convened to the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held extraordinary at the registered office 5, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, on <i> February 10

<i>th

<i> , 2012  at 2.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Director's annual report and the Auditor's report relating to the company only and the conso-

lidated accounts for the business of the Company and its subsidiaries for the year as per December 31 

st

 , 2010;

2. Approval of the annual statutory financial statements of the Company as per December 31 

st

 , 2010 in accordance

with Luxembourg accounting standards and allocation of the results as per December 31 

st

 , 2010;

3. Approval of the consolidated financial statements of the Company as per December 31 

st

 , 2010 in accordance

with international financial reporting standards;

4. Special vote on the discharge to the members of the board of directors for their duties performed as of December

31 

st

 , 2010;

5. Special vote on the discharge to the auditor for his duties performed as of December 31 

st

 , 2010;

6. Question of an eventual dissolution of the company, according to article 100 of the commercial company law of

August 10, 1915;

7. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2012009913/317/24.

13362

L

U X E M B O U R G

Finimmo Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 97.691.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu extraordinairement le <i>9 février 2012 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Démission de Monsieur Miguel REYNDERS.
2. Nomination de Mademoiselle Séverine DESNOS.
3. Transfert du siège social.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012012041/16.

Spimelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 68, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 108.285.

Le conseil d'administrateur de la société convoque

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société anonyme "Spimelux S.A.", ayant son siège social à L-4119 Esch-sur-Alzette, 68, rue Romain Fandel, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 108.825, qui se tiendra en l'étude
du notaire Jean SECKLER, (3, route de Luxembourg à Junglinster), le vendredi, le <i>10 février 2011 à 11.30 heures et ayant
pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social vers L-4394 Pontpierre, 2A, rue de l'Ecole et modification afférente du premier alinéa de

l'article 4 des statuts.

N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires.

<i>Pour La société
Pour le Conseil d'administration
Benvindo MENDES

Référence de publication: 2012010622/19.

Estates Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 133.012.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu extraordinairement le <i>9 février 2012 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Démission de Monsieur Miguel REYNDERS.
2. Nomination de Mademoiselle Séverine DESNOS
3. Transfert du siège social.
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012012572/16.

13363

L

U X E M B O U R G

Commerzbank International Portfolio Management, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 41.022.

<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des Absolute Return Euro Bond Portfolio

Der Verwaltungsrat der Commerzbank International Portfolio Management (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass mit

Ablauf des 30. November 2011 (der "Stichtag") die folgenden Teilfonds der Gesellschaft verschmolzen wurden:

ISIN

WKN

Fondsname

Status

LU0360457872 A0QYL1

Commerzbank International Portfolio Management -
Absolute Return Euro AT (EUR)

untergegangener
Fonds

LU0178431259 592694

Allianz Global Investors Fund - Allianz PIMCO Treasury
Short Term Plus Euro A (EUR)

aufnehmender
Fonds

LU0087745443 974053

Commerzbank International Portfolio Management -
Bond Portfolio AT (EUR)

untergegangener
Fonds

LU0165915058 263262

Allianz Global Investors Fund - Allianz PIMCO Euro
Bond AT(EUR)

aufnehmender
Fonds

Aufgrund der Verschmelzung wurden die untergehenden Teilfonds Absolute Return Euro und Bond Portfolio aufgelöst.

Senningerberg, Februar 2012.

<i>Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2012016286/755/22.

Intelsat (Luxembourg) Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 312.423.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 117.304.

In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of the month of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Intelsat (Gibraltar) Limited, a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Gibraltar

having its registered office at Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar and registered with the Gibraltar Trade
and Companies Register under the number 96556 (the "Sole Shareholder"),

being the Sole Shareholder of, and holding all the three million one hundred twenty-four thousand two hundred thirty-

five  (3,124,235)  shares  in  issue  in,  Intelsat  (Luxembourg)  Finance  Company  S.à  r.l.  (the  "Company"),  a  société  à
responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered
office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, and registered with the Registre du Commerce et des Sociétés
in Luxembourg under number B 117.304, incorporated on 14 June 2006 by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
"Mémorial") number 1596 of 23 August 2006, the articles of association of which have been amended several times and
for the last time on 29 December 2010 pursuant to a deed of Me Joseph Gloden, notary then residing in Grevenmacher,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial number 48 of 11 January 2011,

represented by Me Sascha Nolte, maître en droit, pursuant to a proxy dated 19 January 2012, which proxy will be

registered together with the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned
notary.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record as follows:
I.  The  Sole  Shareholder  holds  all  the  three  million  one  hundred  twenty-four  thousand  two  hundred  thirty-five

(3,124,235) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on the items set forth below.

II. On 25 October 2011, the board of managers of the Company has approved the common draft terms of merger

(the  "Merger  Proposal")  established  in  accordance  with  Article  261  of  the  law  of  10th  August  1915  on  commercial
companies, as amended (the "Law"), and has confirmed the Company's interest in the merger through the absorption of
its wholly owned subsidiary, Intelsat (Poland) sp. z o.o., a company incorporated and existing under the laws of Poland,
having its registered office at Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warsaw, registered with the register of entrepreneurs main-
tained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Divison of the National Court
Registry, under no. KRS 0000253418 (the "Absorbed Company" and together with the Company, the "Companies").

13364

L

U X E M B O U R G

III. The Merger Proposal embodied in a deed of the undersigned notary of 25 October 2011 has been published in the

Memorial number 2677 on 4 November 2011.

IV. The Sole Shareholder confirmed, in accordance with Article 267 and 278 of the Law, that the Merger Proposal,

the annual accounts and management statements of the last three (3) financial years of each of the merging Companies,
as well as the interim accounting statement of the Absorbed Company of 30 September 2011, have been made available
to the Sole Shareholder (respectively the Company as sole shareholder of the Absorbed Company) at least one (1) month
before the date of the present deed and that the interim accounting statements as well as the report of the board of
managers of the Company have been waived as provided for in article 267(1) of the Law by the Sole Shareholder on 25
October 2011.

V. The items on which resolutions were to be passed were as follows:
1. Acknowledgement and approval of the Merger Proposal regarding the merger through the absorption of the Ab-

sorbed Company by the Company and approval of such merger, in accordance with article 261 and seq. of the Law (the
"Merger");

2. Acknowledgement that the articles of association of the Company will not be subject to any amendments in con-

nection with the Merger;

3. Acknowledgement and approval that no new shares will be issued by the Company in consideration of the transfer

of all and any assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company, since the Company is the sole shareholder
thereof;

4. Acknowledgement and approval of the date as from which the transactions of the Absorbed Company will be treated

for accounting purposes as being those of the Company.

Thereafter, the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:

<i>First resolution

The Sole Shareholder acknowledged and resolved to approve the Merger Proposal regarding the Merger through the

absorption by the Company of the Absorbed Company.

The Sole Shareholder resolved to approve such Merger in accordance with the Merger Proposal without exception

or reserve.

The Sole Shareholder noted that the Merger is realised by the transfer by the Absorbed Company following its dis-

solution without liquidation of any and all its assets and liabilities to the Company.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder acknowledged that the articles of association of the Company will not be subject to any amend-

ments in connection with the Merger.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder acknowledged and resolved to approve that pursuant to article 278 of the Law providing for a

simplified merger procedure, the Company being the sole shareholder of the Absorbed Company, no shares will be issued
in consideration of the transfer of all and any assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder acknowledged and resolved to approve that the transactions of the Absorbed Company will be

treated for accounting purposes as being those of the Company as from 1 

st

 December 2011.

<i>Statements

The undersigned notary received and verified the certificate delivered by the Polish competent authority stating in a

satisfactory way the correct accomplishment of the prior deeds and formalities required under Polish law for the part of
the merger procedure relating to the Absorbed Company.

The undersigned notary verified and stated the existence and the legality of the deeds and formalities required from

the Company under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg in view of the Merger.

The undersigned notary received the Merger Proposal approved by the Absorbed Company and stated that the Ab-

sorbed Company and the Company approved the Merger Proposal in the same terms.

The undersigned notary therefore stated that all deeds and formalities required for the Merger have been legally and

validly accomplished.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this Merger are estimated at approximately

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing

party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation and that in case of discrepancies
between the English and French text, the English version will be prevailing.

13365

L

U X E M B O U R G

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes, the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingtième jour du mois de janvier,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Intelsat (Gibraltar) Limited, une société à responsabilité limitée constituée et existante sous le droit du Gibraltar ayant

son siège social au Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar, et inscrite auprès du Gibraltar Trade and Companies
Register sous le numéro 96556 (l'«Associé Unique»),

étant l'Associé Unique de et détenant toutes les trois millions cent vingt-quatre mille deux cent trente-cinq (3.124.235)

parts sociales émises par Intelsat (Luxembourg) Finance Company S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité
limitée constituée et existante sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 4 rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.304, constituée le 14 juin 2006 par un acte de Me Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (le «Mémorial») numéro 1596 du 23 août 2006.Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la
dernière fois le 29 décembre 2010, par un acte de Me Joseph Gloden, notaire de résidence à cette époque à Greven-
macher, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro 48 du 11 janvier 2011,

représentée par Me Sascha Nolte, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation datée du 19 janvier 2012 qui restera annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur par le comparant
et le notaire soussigné.

L’Associé Unique a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient toutes les trois millions cent vingt-quatre mille deux cent trente-cinq (3.124.235) parts

sociales émises par la Société de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur tous les points portés à
l'ordre du jour tels qu’énoncés ci-dessous.

II. Le 25 octobre 2011, le conseil de gérance de la Société a approuvé le projet commun de fusion (le «Projet de

Fusion») établi en conformité avec l'article 261 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'amendée
(la «Loi») et a confirmé l'intérêt de la Société dans la fusion par l'absorption de sa filiale entièrement détenue par elle,
Intelsat (Poland) sp. z o.o., une société constituée et existante sous le droit polonais, ayant son siège social à Al. Jerozo-
limskie 56C, 00-803 Varsovie, inscrite auprès du registre d’entrepreneurs tenu par le tribunal d’arrondissement de la
capitale de Varsovie à Varsovie, XII Division commerciale de la greffe de la Cour nationale (XII Commercial Division of
the National Court Registry), sous le numéro KRS 0000253418 (la «Société Absorbée» et ensemble avec la Société les
«Sociétés»).

III. Le Projet de Fusion tel qu'acté par le notaire soussigné le 25 octobre 2011 a été publié au Mémorial numéro 2677

le 4 novembre 2011.

IV. L'Associé Unique a confirmé, conformément aux articles 267 et 278 de la Loi, que le Projet de Fusion, les comptes

annuels ainsi que les rapports de gestion des trois (3) derniers exercices des Sociétés qui fusionnent, ainsi que l’état
comptable de la Société Absorbée du 30 septembre 2011, ont été mis à la disposition de l'Associé Unique (respectivement
la Société en tant que l’associé unique de la Société Absorbée) au moins un (1) mois avant la date du présent acte et que
le 25 octobre 2011, l’Associé Unique a renoncé, conformément à l’article 267 (1) de la Loi, à l’état comptable et au
rapport du conseil de gérance de la Société.

V. Les points sur lesquels des résolutions devaient être passées étaient les suivants:
1. Reconnaissance et approbation du Projet de Fusion relatif à la fusion par l'absorption de la Société Absorbée par la

Société et approbation de cette fusion, conformément aux articles 261 et suiv. de la Loi (la «Fusion»);

2. Reconnaissance du fait que les statuts de la Société ne feront pas l'objet de changements en relation avec la Fusion;
3. Reconnaissance et approbation du fait qu'aucune nouvelle part sociale ne sera émise par la Société en contrepartie

du transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société, dans la mesure où la Société est l'associé
unique de cette dernière;

4. Reconnaissance et approbation de la date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront traitées,

d’un point de vue comptable, comme étant celles de la Société.

Ensuite, les résolutions suivantes ont été prises par l'Associé Unique de la Société:

<i>Première résolution

L'Associé Unique a reconnu et a décidé d'approuver le Projet de Fusion relatif à la Fusion par l'absorption de la Société

Absorbée par la Société.

L'Associé Unique a décidé d'approuver cette Fusion en conformité avec le Projet de Fusion sans exception ni réserve.

13366

L

U X E M B O U R G

L'Associé Unique a noté que la Fusion est réalisée par le transfert par la Société Absorbée, à la suite de sa dissolution

sans liquidation, de l'ensemble de ses actifs et passifs à la Société.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a reconnu que les statuts de la Société ne feront pas l'objet de changements en relation avec la

Fusion.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique a reconnu et a décidé d'approuver conformément à l’article 278 de la Loi prévoyant une procédure

de fusion simplifiée, la Société étant l'actionnaire unique de la Société Absorbée, le fait qu'aucune nouvelle part sociale
ne sera émise en contrepartie du transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique a reconnu et décidé d'approuver que les opérations de la Société Absorbée seront traitées, d’un

point de vue comptable, comme étant celles de la Société à partir du 1 

er

 décembre 2011.

<i>Constatations

Le notaire soussigné a reçu et vérifié le certificat délivré par l'autorité polonaise compétente attestant d'une manière

concluante l'accomplissement correct des actes et formalités préalables à la Fusion requis par le droit polonais pour la
partie de la procédure de fusion relative à la Société Absorbée.

Le notaire soussigné a vérifié et a constaté l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société

conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg en vue de la Fusion.

Le notaire soussigné a reçu le Projet de Fusion approuvé par la Société Absorbée et a constaté que la Société Absorbée

et la Société ont approuvé le Projet de Fusion dans les mêmes termes.

Le notaire soussigné a dès lors constaté que tous les actes et formalités préalables à la Fusion ont été légalement et

valablement remplis.

<i>Dépenses

Les coûts, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de

cette fusion sont estimés à approximativement EUR 3.000,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, le mandataire signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: S. NOLTE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3740. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014093/181.
(120016923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2012.

StarCap SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 72.359.

Im Jahre zweitausendundelf, am neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxemburg,
Sind  die  Aktionäre  der  Investmentgesellschaft  mit  variablem  Kapital  („société  d’investissement  à  capital  variable")

"StarCap SICAV", mit Sitz in L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison, eingetragen im Handels-und Gesell-
schaftsregister  von  Luxemburg  unter  der  Nummer  B  72359,  zu  einer  außerordentlichen  Gesellschafterversammlung
zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 5. November 1999, veröffentlicht im Mémorial C

Nummer 973 vom 17. Dezember 1999. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des Notars Henri Hel-
linckx vom 30. Juni 2011, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1679 vom 26. Juli 2011.

13367

L

U X E M B O U R G

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Ursula BERG, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-

Strassen, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zur Protokollführerin Frau Manuela NEUMANN, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Lu-

xembourg-Strassen.

Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Gisela WENZ, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Lu-

xembourg-Strassen.

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und
dem unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben
gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Einladungen mit der hiernach angegebenen Tage-

sordnung veröffentlicht:

- im Mémorial C, vom 26. November 2011 und vom 13. Dezember 2011
- in der Tageszeitung „Tageblatt" am 26. November 2011 und am 13. Dezember 2011
- in der Tageszeitung Luxemburger Wort am 26. November 2011 und am 13. Dezember 2011
- in der Börsenzeitung am 26. November 2011 und am 13. Dezember 2011
- im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 28. November 2011 und am 14. Dezember 2011
- auf Fundinfo am 28. November 2011 und am 14. Dezember 2011
III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1. Änderung von Artikel 10 der Satzung per 31. Dezember 2011
Verschmelzungen von Teilfonds und Anteilklassen können zukünftig durch den Verwaltungsrat beschlossen werden
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich
2. Verschmelzung der Aktienklasse A-CHF des Teilfonds StarCap SICAV Starpoint in die Aktienklasse A-EUR des

gleichen Teilfonds StarCap SICAV Starpoint zum 30. Dezember 2011 auf der Grundlage des Verschmelzungsplans

IV.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 457.180 sich im Umlauf befindenden Aktien,

1.688 Aktien anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung vertreten sind.

Die Vorsitzende teilt der Versammlung mit, dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung mit derselben

Tagesordnung für den 25. November 2011 einberufen worden war und dass diese Generalversammlung nicht beschluss-
fähig war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht war.

Gegenwärtige Generalversammlung ist gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften beschlussfä-

hig, gleich wie viele Anteile anwesend oder vertreten sind.

Alsdann fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 10 der Satzung per 31. Dezember 2011 wie folgt abzuändern:

Art. 10. Die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds.
1. Der Verwaltungsrat kann gemäß den nachfolgenden Bedingungen beschließen, einen Teilfonds in einen anderen

OGAW, der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird oder der von einer anderen Verwaltungsgesellschaft
verwaltet wird, zu übertragen. Die Verschmelzung kann insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden:

- sofern das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindest-

betrag erscheint, um den Fonds bzw. den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten. Die Verwaltungsge-
sellschaft hat diesen Betrag mit 5 Mio. Euro festgesetzt.

- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirt-

schaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Fonds bzw. den Teilfonds zu verwalten.

Bei Verschmelzungen, bei denen die übertragende Investmentgesellschaft durch die Verschmelzung erlischt, muss das

Wirksamwerden der Verschmelzung notariell beurkundet werden

2.  Der  Verwaltungsrat  der  Investmentgesellschaft  kann  beschließen  einen  anderen  Fonds  oder  Teilfonds,  der  von

derselben oder von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, in die Investmentgesellschaft bzw. einen Teil-
fonds der Investmentgesellschaft aufzunehmen.

3. Verschmelzungen sind sowohl zwischen zwei Luxemburger Fonds bzw. Teilfonds (inländische Verschmelzung) als

auch zwischen Fonds bzw. Teilfonds die in zwei unterschiedlichen Mitgliedsstaaten niedergelassen sind (grenzüberschrei-
tende Verschmelzung) möglich.

4. Eine Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik der einzubringenden Investmentgesellschaft

bzw. des Fonds oder Teilfonds nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden OGAW verstößt.

13368

L

U X E M B O U R G

5. Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden Fonds oder Teilfonds

und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden Fonds bzw. Teilfonds. Die
Anleger des einbringenden Fonds erhalten Anteile des aufnehmenden Fonds, deren Anzahl sich auf der Grundlage des
Anteilwertverhältnisses der betroffenen Fonds zum Zeitpunkt der Einbringung errechnet und gegebenenfalls einen Spi-
tzenausgleich.

6. Sowohl der aufnehmende Fonds bzw. Teilfonds als auch der übertragende Fonds bzw. Teilfonds informieren die

Anleger in geeigneter Form über die geplante Verschmelzung im Rahmen einer Publikation in einer Luxemburger Tages-
zeitung  und  entsprechend  den  Vorschriften  der  jeweiligen  Vertriebsländer  des  aufnehmenden  oder  einzubringenden
Fonds bzw. Teilfonds.

7. Die Anleger des aufnehmenden und des übertragenden Fonds bzw. Teilfonds haben während dreißig Tagen das

Recht, ohne Zusatzkosten die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert oder, soweit
möglich, den Umtausch in Anteile eines anderen Fonds mit ähnlicher Anlagepolitik, der von derselben Verwaltungsge-
sellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame
Verwaltung oder Kontrolle oder durch wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, zu verlangen. Das
Recht wird ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Aktionäre des übertragenden und des aufnehmenden Fonds über die
geplante Verschmelzung unterrichtet werden, und erlischt fünf Bankarbeitstage vor dem Zeitpunkt der Berechnung des
Umtauschverhältnisses.

8. Bei einer Verschmelzung zwischen zwei oder mehreren Fonds bzw. Teilfonds können die betroffenen Fonds bzw.

Teilfonds die Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtäusche von Anteilen zeitweilig aussetzen, wenn eine solche Aussetzung
aus Gründen des Anteilinhaberschutzes gerechtfertigt ist.

9. Die Durchführung der Verschmelzung wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und bestätigt. Den

Anlegern des übertragenden und des übernehmenden Fonds bzw. Teilfonds sowie der jeweils zuständigen Aufsichtsbe-
hörde wird auf Anfrage kostenlos eine Kopie des Berichts des Wirtschaftsprüfers zur Verfügung gestellt.

10. Das vorstehend Gesagte gilt gleichermaßen für die Verschmelzung zweier Teilfonds innerhalb der Investmentge-

sellschaft sowie für die Verschmelzung von Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung stimmt der Verschmelzung der Aktienklasse A-CHF des Teilfonds StarCap SICAV Starpoint

in die Aktienklasse A-EUR des gleichen Teilfonds StarCap SICAV Starpoint zum 30. Dezember 2011 auf der Grundlage
des Verschmelzungsplans zu.

Das Datum des Wirksamswerdens der Verschmelzung ist somit der 30. Dezember 2011.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxembourg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. BERG, M. NEUMANN, G. WENZ und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2012. Relation: LAC/2012/388. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 23. Januar 2012.

Référence de publication: 2012011926/110.
(120013383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2012.

MVM Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 83.256.

Im Jahre zweitausendundelf, am neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxemburg,
Sind  die  Aktionäre  der  Investmentgesellschaft  mit  variablem  Kapital  („société  d’investissement  à  capital  variable")

„MVM LUX SICAV", mit Sitz in L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison, eingetragen im Handels-und Ge-
sellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 83256, zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung
zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 9. August 2001, veröffentlicht im Mémorial C

Nummer 743 vom 10. September 2001. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten
Notars vom 30. Juni 2011, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1693 vom 27. Juli 2011.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Ursula BERG, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-

Strassen, eröffnet.

13369

L

U X E M B O U R G

Die Vorsitzende beruft zur Protokollführerin Frau Manuela NEUMANN, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Lu-

xembourg-Strassen.

Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Gisela WENZ, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Lu-

xembourg-Strassen.

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und
dem unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben
gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Einladungen mit der hiernach angegebenen Tage-

sordnung veröffentlicht:

- im Mémorial C, vom 26. November 2011 und vom 13. Dezember 2011
- in der Tageszeitung „Tageblatt" am 26. November 2011 und am 13. Dezember 2011
- in der Tageszeitung „Luxemburger Wort" am 26. November 2011 und am 13. Dezember 2011
- in der Börsenzeitung am 26. November 2011 und am 13. Dezember 2011
- III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1. Änderung der Satzung per 31. Dezember 2011
Zustimmung zur Änderung von Artikel 6 und 9 der Satzung der MVM LUX SICAV. Aus Vereinfachungsgründen soll

zukünftig der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft die Verschmelzung von Teilfonds und Anteilklassen beschließen
können.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
2. Zustimmung zur Fusion des Teilfonds MVM LUX SICAV – frontrunner earth mit dem MVM LUX SICAV – fron-

trunner global am 30. Dezember 2011 und damit auch zum Verschmelzungsplan des Verwaltungsrates.

IV.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 8125.935 sich im Umlauf befindenden

Aktien, 13.117 Aktien anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung vertreten sind.

Die Vorsitzende teilt der Versammlung mit, dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung mit derselben

Tagesordnung für den 25. November 2011 einberufen worden war und dass diese Generalversammlung nicht beschluss-
fähig war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht war.

Gegenwärtige Generalversammlung ist gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften beschlussfä-

hig, gleich wie viele Anteile anwesend oder vertreten sind.

Alsdann fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 wie folgt abzuändern:
Artikel 6 wird wie folgt abgeändert:

Art. 6. Die Verschmelzung der Investmentgesellschaft.
1. Die Investmentgesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung gemäß den nachfolgenden Bedingungen

beschließen, die Investmentgesellschaft in einen anderen OGAW, der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet
wird oder der von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, zu übertragen.

Die Generalversammlung stimmt ebenfalls über den gemeinsamen Verschmelzungsplan ab. Die Beschlüsse der Gene-

ralversammlung im Rahmen einer Verschmelzung bedürfen mindestens der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden
oder vertretenen Aktionäre. Bei Verschmelzungen, bei denen die übertragende Investmentgesellschaft durch die Versch-
melzung erlischt, muss das Wirksamwerden der Verschmelzung notariell beurkundet werden.

2.  Ein  Teilfonds  der  Investmentgesellschaft  kann  durch Beschluss des  Verwaltungsrates der  Investmentgesellschaft

durch Einbringung in einen anderen Teilfonds der Investmentgesellschaft oder einen anderen OGAW bzw. einen Teilfonds
eines anderen OGAW verschmolzen werden.

In den Fällen, in denen ein Teilfonds mit einem Teilfonds eines fonds commun de placement verschmolzen wird, gilt,

dass dieser Beschluss nur die Aktionäre verpflichten darf, die sich zugunsten der Einbringung ausgesprochen haben.

Die Verschmelzung kann insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden:
- sofern das Netto-Fondsvermögen bzw. ein Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag

gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Fonds bzw. den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu
verwalten. Die Verwaltungsgesellschaft hat diesen Betrag mit 5 Mio. Euro festgesetzt.

- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirt-

schaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Fonds bzw. den Teilfonds zu verwalten.

13370

L

U X E M B O U R G

3.  Der  Verwaltungsrat  der  Investmentgesellschaft  kann  beschließen  einen  anderen  Fonds  oder  Teilfonds,  der  von

derselben oder von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, in die Investmentgesellschaft bzw. einen Teil-
fonds der Investmentgesellschaft aufzunehmen.

4. Verschmelzungen sind sowohl zwischen zwei Luxemburger Fonds bzw. Teilfonds (inländische Verschmelzung) als

auch zwischen Fonds bzw. Teilfonds die in zwei unterschiedlichen Mitgliedsstaaten niedergelassen sind (grenzüberschrei-
tende Verschmelzung) möglich.

5. Eine Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik der einzubringenden Investmentgesellschaft

bzw. des Fonds oder Teilfonds nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden OGAW verstößt.

6. Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden Fonds oder Teilfonds

und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden Fonds bzw. Teilfonds. Die
Anleger des einbringenden Fonds erhalten Anteile des aufnehmenden Fonds, deren Anzahl sich auf der Grundlage des
Anteilwertverhältnisses der betroffenen Fonds zum Zeitpunkt der Einbringung errechnet und gegebenenfalls einen Spi-
tzenausgleich.

7. Sowohl der aufnehmende Fonds bzw. Teilfonds als auch der übertragende Fonds bzw. Teilfonds informieren die

Anleger in geeigneter Form über die geplante Verschmelzung im Rahmen einer Publikation in einer Luxemburger Tages-
zeitung  und  entsprechend  den  Vorschriften  der  jeweiligen  Vertriebsländer  des  aufnehmenden  oder  einzubringenden
Fonds bzw. Teilfonds.

8 Die Anleger des aufnehmenden und des übertragenden Fonds bzw. Teilfonds haben während dreißig Tagen das Recht,

ohne Zusatzkosten die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert oder, soweit möglich,
den Umtausch in Anteile eines anderen Fonds mit ähnlicher Anlagepolitik, der von derselben Verwaltungsgesellschaft
oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung
oder Kontrolle oder durch wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, zu verlangen. Das Recht wird
ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anteilinhaber des übertragenden und des aufnehmenden Fonds über die geplante
Verschmelzung  unterrichtet  werden,  und  erlischt  fünf  Bankarbeitstage  vor  dem  Zeitpunkt  der  Berechnung  des  Um-
tauschverhältnisses.

9. Bei einer Verschmelzung zwischen zwei oder mehreren Fonds bzw. Teilfonds können die betroffenen Fonds bzw.

Teilfonds die Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtäusche von Anteilen zeitweilig aussetzen, wenn eine solche Aussetzung
aus Gründen des Anteilinhaberschutzes gerechtfertigt ist.

10. Die Durchführung der Verschmelzung wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und bestätigt. Den

Anlegern des übertragenden und des übernehmenden Fonds bzw. Teilfonds sowie der jeweils zuständigen Aufsichtsbe-
hörde wird auf Anfrage kostenlos eine Kopie des Berichts des Wirtschaftsprüfers zur Verfügung gestellt.

11. Das unter den vorstehenden Ziffern 2. bis 10. Gesagte gilt gleichermaßen für die Verschmelzung zweier Teilfonds

innerhalb der Investmentgesellschaft sowie für die Verschmelzung von Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds.

Artikel 9 wird wie folgt abgeändert:

Art. 9. Dauer der einzelnen Teilfonds.
1. Ein oder mehrere Teilfonds können auf bestimmte Zeit errichtet werden. Die Dauer eines Teilfonds ergibt sich für

den jeweiligen Teilfonds aus dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt.

2. Ein oder mehrere Teilfonds können gemäß Artikel 6 verschmolzen oder gemäß Artikel 7 der Satzung liquidiert

werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst der Fusion des Teilfonds MVM LUX SICAV – frontrunner earth mit dem Teilfonds

MVM LUX SICAV – frontrunner global zum 30. Dezember 2011 sowie dem Verschmelzungsplan des Verwaltungsrates
zuzustimmen.

Das Datum des Wirksamswerdens der Fusion der beiden Teilfonds ist somit der 30. Dezember 2011.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxembourg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. BERG, M. NEUMANN, G. WENZ und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2012. Relation: LAC/2012/387. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 23. Januar 2012.

Référence de publication: 2012011830/125.
(120013379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2012.

13371

L

U X E M B O U R G

Beech Tree S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 85.327.

L'an deux mille onze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de «Beech Tree S.A» (ci-après la «Société»), une société

anonyme ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal, constituée par acte notarié en date du 13
décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 609 du 19 avril 2002.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Martine Schaeffer, notaire de
résidence à Luxembourg en date du 7 juillet 2009, publié au Mémorial numéro 1782 du 15 septembre 2009.

L'assemblée est présidée par Me Elisabeth Adam, avocate, résidant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Me Claire Braun, avocate, résidant à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Me Claire Braun, avocate, résidant à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a demandé le notaire instrumentant d'acter

que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:
A) Approbation des comptes intérimaires de la Société;
B) Réduction du capital social de la Société actuellement en émission d’un montant de trente-cinq millions six cent

quarante huit mille deux cent soixante-quinze euros (€ 35.648.275) afin de le ramener de son montant actuel de deux
cent soixante et onze millions cinq cent seize mille huit cent vingt-cinq euros (€ 271.516.825) à deux cent trente-cinq
millions huit cent soixante-huit mille cinq cent cinquante euros (€ 235.868.550) par le rachat et l’annulation de un million
quatre cent vingt-cinq mille neuf cent trente et une (1.425.931) actions de classe C d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (€ 25,-) chacune détenues par Altawin S.à r.l.; Imputation du prix de rachat de ces actions d’un montant total de
quatre-vingt-dix-neuf  million  quatre-vingt-deux  mille  deux  cent  quatre-vingt-six  euros  et  soixante-sept  cents  (€
99.082.286,67); Paiement du prix de rachat par compensation; En conséquence, modification de l’article 5.1 des statuts
de la Société;

C) Autorisation au conseil d’administration pour une période de cinq (5) ans d’acquérir en une ou plusieurs fois, jusqu’à

deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000) actions de classe C de la Société d’une valeur nominale de vingt cinq
euros (€ 25,-) chacune, pour une valeur égale à la valeur de marché desdites actions à la date de leur rachat sans que
cette valeur ne puisse être inférieure à la valeur nominale des actions rachetées; Paiement du prix de rachat des actions
en espèce, par compensation, en nature pour un montant égal à la valeur de rachat;

D) Modification du taux de conversion des obligations convertibles en émission en actions préférentielles sans droit

de vote rachetable de la classe correspondante de telle sorte à le fixer à deux obligations pour une action préférentielle
sans droit de vote et allocation du solde du prix de conversion à la prime d’émission; en conséquence modification de la
dernière phrase de 5.2 des statuts de la Société;

E) Modification de l’article 22 des statuts de la Société relative à la surveillance de la Société.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations délivrées par les actionnaires représentés et le nombre

d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par le(s)
mandataire(s) des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte.

III. L'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée et les actionnaires déclarent avoir été pré-

alablement informés de l'ordre du jour de la présente assemblée.

IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend unanimement les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver les comptes intermédiaires de la Société du 12 décembre 2011 et d’allouer un montant

de neuf cent cinquante-quatre mille soixante-cinq euros et cinquante cents (€ 954.065,50) du bénéfice à la réserve légale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social de la Société de trente-cinq millions six cent quarante-huit mille deux

cent soixante-quinze euros (€ 35.648.275) afin de le ramener de son montant actuel de deux cent soixante et onze millions
cinq cent seize mille huit cent vingt-cinq euros (€ 271.516.825) à deux cent trente-cinq millions huit cent soixante-huit
mille cinq cent cinquante euros (€ 235.868.550) par le rachat et l’annulation de un million quatre cent vingt-cinq mille
neuf cent trente et une (1.425.931) actions de classe C d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune détenues
par Altawin S.à r.l.

13372

L

U X E M B O U R G

Pour autant que de besoin, les autres actionnaires de la Société déclarent renoncer à participer au rachat de leurs

participations.

Le prix de rachat est à imputer à hauteur de trente-cinq millions six cent quarante-huit mille deux cent soixante-quinze

euros (€ 35.648.275) sur le compte capital social suite à la réduction de capital décidée ci-avant, à hauteur de soixante-
trois  millions  quatre  cent  trente-quatre  mille  onze  euros  et  soixante-sept  cents  (€  63.434.011,67)  sur  les  réserves
distribuables de la Société.

Il est décidé de payer le prix de rachat de ces actions d’un montant total de quatre-vingt-dix-neuf millions quatre-vingt-

deux  mille  deux  cent  quatre-vingt-six  euros  et  soixante-sept  cents  (€  99.082.286,67)  par  compensation  de  dettes
réciproques entre la Société et Altawin S.à r.l. également liquides et exigibles.

En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à deux cent trente-cinq millions huit cent soixante-huit mille cinq cent cinquante

euros (€ 235.868.550) représenté par

(i) trois millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois cent soixante et onze (3.592.371) actions de classe A1;
(ii) trois millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois cent soixante et onze (3.592.371) actions de classe A2 et
(iii) deux millions deux cent cinquante (2.250.000) actions de classe C
chacune d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25)»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration de la Société, pour une période de cinq (5) ans à partir de

la présente résolution, d’acquérir en une ou plusieurs fois, jusqu’à deux millions deux cent cinquante (2.250.000) actions
de classe C de la Société d’une valeur nominale de vingt cinq euros (€ 25,-) chacune, pour une valeur égale à la valeur de
marché desdites actions à la date de leur rachat sans que cette valeur ne puisse être inférieure à la valeur nominale des
actions rachetées. Le prix de rachat des actions ainsi rachetées pourra être payé en espèce, par compensation, par le
transfert d’actifs de la Société d’une valeur égale à la valeur de rachat des actions rachetées.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le taux de conversion des obligations en émission convertibles en actions préférentielles

sans droit de vote rachetables de la classe correspondante de telle sorte à le fixer à deux obligations pour une action
préférentielle sans droit de vote et allocation du solde du prix de conversion à la prime d’émission.

L’assemblée décide en conséquence de modifier la dernière phrase de l’article 5.2 des statuts de la Société comme

suit:

«Ces obligations peuvent être converties en actions préférentielles sans droit de vote à un taux de deux obligations

pour une action préférentielle sans droit de vote rachetable de la classe correspondante, le solde étant alloué à la prime
d’émission».

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 22 des statuts de la Société comme suit:
«La société est surveillée par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, ou dans les cas requis par la loi, par un

réviseur d’entreprise agrée.

Le(s) commissaire(s) aux comptes sont nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires, pour un temps ne dé-

passant pas la prochaine assemblée générales des actionnaires.

Le(s) commissaire(s) aux comptes mandaté peut être révoqué à tout moment par les actionnaires avec ou sans raison.
L’assemblée désignera également un réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés de la Société»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.400.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: E. ADAM – C. BRAUN – H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58991. Reçu soixante-quinze euros

(75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

13373

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le vingt-trois janvier de l’an deux mille douze.

Référence de publication: 2012011541/112.
(120013548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2012.

Beam Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.367.552,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 165.799.

In the year two thousand and eleven on the ninth of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

JIM BEAM BRANDS CO., a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware,

having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA and registered with
the Secretary of State of the State of Delaware under file number 0649808 (hereafter the "Sole Shareholder") here
represented by Mr. Regis Galiotto, notary’s clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by the Sole Shareholder on December 7, 2011;

and
FULHAM ACQUISITION LLC, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of the

State of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA
and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 3960037 (hereafter the "Contri-
butor")  here  represented  by  Mr.  Regis  Galiotto,  aforementioned,  by  virtue  of  a  proxy  given  by  the  Contributor  on
December 7, 2011.

Said proxies signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, represented by its proxyholder, have requested the notary to enact the following:
I. JIM BEAM BRANDS, CO., aforementioned, is the sole shareholder of the private limited liability company (société

à responsabilitié limitée) existing in Luxembourg under the name of BEAM HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.À R.L., having
its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated by a deed of the undersigned notary, dated December 5, 2011, not yet published in the Luxembourg official
gazette and which registration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending (the "Company"). The
Articles of Association of the Company (the "Articles") have not yet been amended.

II.  The  Company’s  share  capital  is  set  at  eight  million  six  hundred  fifty  thousand  five  hundred  eighty  Euros  (EUR

8,650,580) represented by eight million six hundred fifty thousand five hundred eighty (8,650,580) shares with a par value
of one Euro (EUR 1.-) each.

III. The Contributor currently holds one hundred nine million three hundred twelve thousand one hundred eleven

(109,312,111) common shares of CANADIAN CLUB CANADA INC., an Ontario corporation with registered office at
67 Mowat Avenue, Suite 200, Toronto, Ontario, M6K 3E3, Canada and registered with the local commercial register
under number 001687318 (collectively the "Canada Shares");

IV. The Contributor wishes to contribute one million ninety three thousand one hundred twenty two (1,093,122)

Canada Shares (hereafter the "Contributed Shares") to the Company.

V. The Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of two million seven hundred

sixteen thousand nine hundred seventy two Euros (EUR 2,716,972) so as to raise it from its present amount of eight
million six hundred fifty thousand five hundred eighty Euros (EUR 8,650,580) to eleven million three hundred sixty seven
thousand five hundred fifty two Euros (EUR 11,367,552) by the issue of two million seven hundred sixteen thousand nine
hundred seventy two (2,716,972) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and an aggregate par value of
two million seven hundred sixteen thousand nine hundred seventy two Euros (EUR 2,716,972), vested with the same
rights and obligations as the existing shares (the "New Shares").

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Sole Shareholder renounces to the possibility to subscribe to the New Shares. Thereafter the Contributor through

its proxyholder declares to subscribe to the New Shares and to fully pay them up by means of a contribution in kind
consisting in the Contributed Shares.

13374

L

U X E M B O U R G

<i>Valuation

The Contributed Shares are valued at two million seven hundred sixteen thousand nine hundred seventy two Euros

(EUR 2,716,972) such value has been decided by the Contributor by way of a declaration of value (the "Declaration of
Value"), with effective date on December 9, 2011 (the "Effective Date") and accepted by the managers of the Company
by way of a valuation statement (the "Valuation Statement") executed by all the managers of the Company and dated as
of the Effective Date.

<i>Evidence of the contribution's existence

Evidence of the transfer of the Contributed Shares and of their value has been given to the undersigned notary by the

following documents:

- the Declaration of Value; and
- the Valuation Statement.
Said Declaration of Value and Valuation Statement shall remain attached hereto.

<i>Effective implementation of the contribution

The Contributor, through its proxyholder, declares that:
- it is the sole beneficial owner of the Contributed Shares and has the power to dispose of them, they being legally

and conventionally freely transferable;

- the contribution of such Contributed Shares is effective as of today without restriction, proof thereof having been

given to the undersigned notary;

- all further formalities are in course in the country of location of the Contributed Shares in order to duly carry out

and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

The Sole Shareholder and the Contributor are hereafter referred to as the "Shareholders".

<i>Second resolution

Further to the above increase of capital, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of Article 6.1 of the

Articles, which shall henceforth read as follows:

Art. 6.1. Paragraph 1. The Company's share capital is set at eleven million three hundred sixty seven thousand five

hundred fifty two Euros (EUR 11,367,552) represented eleven million three hundred sixty seven thousand five hundred
fifty two (11,367,552) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up."

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately three thousand Euros (EUR 3,000.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

JIM BEAM BRANDS, CO., une société de capitaux dûment constituée et existant valablement selon les lois du Dela-

ware, Etats-Unis, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis et
inscrite auprès du Secrétariat d’Etat de l’Etat du Delaware, Etats-Unis, sous le matricule 0649808 (ci-après l’ «Associé
Unique») ici représentée par M. Regis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 101, rue Cents,
L-1319 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée par l’Associé Unique le 7 dé-
cembre 2011;

Et
FULHAM ACQUISITION LLC, une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant valablement selon

les lois du Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis et inscrite auprès du Secrétariat d’Etat de l’Etat du Delaware, Etats-Unis, sous le matricule 3960037 (ci-après
l’ «Apporteur») ici représentée par M. Regis Galiotto, susmentionné, en vertu d’une procuration donnée par l’Apporteur
le 7 décembre 2011;

13375

L

U X E M B O U R G

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Les comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. JIM BEAM BRANDS CO., précitée, est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg

sous la dénomination de BEAM HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A R.L., ayant son siège social au 9, rue Gabriel Lippmann,
Parc d’Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, constituée aux termes d’un acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 5 décembre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions et dont l’inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours (la «Société»).
Les statuts de la Société n’ont pas encore été amendés (les «Statuts»).

II. Le capital social de la Société est de huit millions six cent cinquante mille cinq cent quatre-vingt Euros (EUR 8.650.580)

représenté par huit millions six cent cinquante mille cinq cent quatre-vingt (8.650.580) parts sociales d’une valeur nominale
d’un Euro (EUR 1,-) chacune.

III. L’Apporteur détient actuellement cent neuf millions trois cent douze mille cent onze (109.312.111) parts sociales

ordinaires de CANADIAN CLUB CANADA INC., une société de l’Etat d’Ontario (Canada) dont le siège social est situé
au 67 Mowat Avenue, Suite 200, Toronto, Ontario, M6K 3E3, Canada et inscrite auprès du registre commercial local
sous le matricule 001687318 (les "Parts Sociales Canadiennes").

IV. L’Apporteur souhaite apporter un million quatre-vingt-treize mille cent vingt-deux (1.093.122) Parts Sociales Ca-

nadiennes (les "Parts Sociales Apportées") à la Société.

V. L’Associé Unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions sept cent seize

mille neuf cent soixante douze Euros (EUR 2.716.972) afin de le porter de son montant actuel de huit millions six cent
cinquante mille cinq cent quatre-vingt Euros (EUR 8.650.580) à un montant de onze millions trois cent soixante-sept mille
cinq cent cinquante-deux Euros (EUR 11.367.552) par l’émission de deux millions sept cent seize mille neuf cent soixante
douze (2.716.972) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale d’une Euro (EUR 1,-) chacune et d’une valeur nominale
totale de deux millions sept cent seize mille neuf cent soixante douze Euros (EUR 2.716.972), disposant des mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes (les «Nouvelles Parts Sociales»).

<i>Intervention - Souscription - Payment

L’Associé Unique renonce à la possibilité de souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. Puis, l’Apporteur, par le biais de

son mandataire, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et de les libérer entièrement par un apport en nature des
Parts Sociales Apportées.

<i>Evaluation

Les Parts Sociales Apportées sont évaluées à deux millions sept cent seize mille neuf cent soixante douze Euros (EUR

2.716.972), cette valeur a été décidée par l’Apporteur par la voie d’une déclaration de valeur (la «Déclaration de Valeur»)
avec une date d’effet au 9 décembre 2011 (la «Date d’Effet») et acceptée par les gérants de la Société par la voie d’une
certification de valeur (la «Certification de Valeur») datée à la Date d’Effet.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

La preuve du transfert des Parts Sociales Apportées et de leur valeur a été donnée au notaire par les documents

suivants:

- la Déclaration de Valeur; et
- la Certification de Valeur.
Lesdites Déclaration de Valeur et Certification de Valeur demeureront annexées aux présentes.

<i>Effectivité de l’apport

L’Apporteur, par le biais de son mandataire, déclare que:
- il est le seul détenteur des Parts Sociales Apportées, et a le pouvoir d’en disposer, étant légalement et contractuel-

lement librement transférables;

- l’apport de telles parts sociales est effectif aujourd’hui sans restriction, preuve ayant été donnée au notaire instru-

mentaire;

- toutes les formalités restantes sont en cours dans le pays des Parts Sociales Apportées dans le but d’effectuer et de

formaliser le transfert et de le rendre effectif partout et envers tout tiers.

L’Apporteur et l’Associé Unique sont dénommés ci-après les «Associés».

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’Associés décident de modifier le premier paragraphe de l’article 6.1 des

Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

13376

L

U X E M B O U R G

« Art. 6.1. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à de onze millions trois cent soixante-sept mille cinq cent

cinquante-deux Euros (EUR 11.367.552) et représenté par onze millions trois cent soixante-sept mille cinq cent cinquante-
deux (11.367.552) parts sociales d’une valeur nominale d‘un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et
libérées.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à environ trois mille Euros (EUR 3.000,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56653. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012010814/178.
(120012995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Trendconcept Fund Multi Asset Allocator, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Sonderreglement, welches am 11. Januar 2012 in Kraft trat. Das Sonderreglement wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Januar 2012.

TRENDCONCEPT FUND S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2012007925/11.
(120008410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Trendconcept Fund, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 11. Januar 2012 in Kraft trat. Das Allgemeine

Verwaltungsreglement wurde einregistriert wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Januar 2012.

TRENDCONCEPT FUND S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2012007924/11.
(120008396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Trendconcept Fund, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Sonderreglement, welches am 11. Januar 2012 in Kraft trat. Das Sonderreglement wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Januar 2012.

TRENDCONCEPT FUND S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2012007923/11.
(120008395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

13377

L

U X E M B O U R G

H &amp; A Lux Wandelanleihen Fonds, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 5. Januar 2012 in Kraft trat. Das Verwaltungs-

reglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 5. Januar 2012.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2012005760/11.
(120005324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2012.

H &amp; A Lux Wandelanleihen Fonds, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Sonderreglement, welches am 5. Januar 2012 in Kraft trat. Das Sonderreglement wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 5. Januar 2012.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2012005759/11.
(120005323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2012.

Health &amp; Safety Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 1, rue Siggy vu Lëtzebuerg.

R.C.S. Luxembourg B 62.818.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend elf, den fünften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

«CAPRICORNUS S.A., SPF», Aktiengesellschaft qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, («société

de patrimoine familial», abgekürzt "SPF") mit Sitz in L-1933 Luxembourg, 1, rue Siggy vu Lëtzebuerg, eingetragen beim
Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 104.457, hier rechtskräftig vertreten
durch zwei (2) ihrer Verwaltungsratsmitglieder, nämlich

- Herrn Renier Johannes Lambertus Cornelis GOOSSENS, Wirtschaftsberater, geboren in Tilburg, (Niederlande), am

19. November 1956, beruflich wohnhaft in L-1933 Luxemburg, 1, rue Siggy vu Lëtzebuerg, handelnd in ihrem eigenen
Namen und als Vertreter des zweiten Verwaltungsratsmitlgliedes

-  "Drs.  Goossens  en  Partners  B.V.",  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  niederländischen  Rechtes,  mit  Sitz  in

NL6413BA Heerlen, Litscherveldweg, 5, eingetragen bei der «Kamer van Koophandel voor Limburg» unter der Nummer
14029969

Die Komparentin ersucht, durch ihren Bevollmächitgten, den amtierenden Notar seine Erklärungen und Feststellungen

zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Aktiengesellschaft " Health &amp; Safety Systems S.A.", mit Sitz in L-1933 Luxembourg, 1, rue Siggy vu Lëtze-

buerg,  eingetragen  beim  Handels-und  Gesellschaftsregister  von  Luxemburg,  Sektion  B,  unter  der  Nummer  62.818,
gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, am 8. Januar 1998, veröffentlicht im Mé-
morial C Nummer 295 vom 30. April 1998,

dass deren Gesellschaftskapital in Euro umgewandelt worden ist,
und dass deren Statuten abgeändert worden sind gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am

9. Juni 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer .

II.- Dass das Gesellschaftskapital auf einunddreißigtausendzweihundertvierunddreissig Euro und achtundfünfzig Cents

(31.234,58 EUR), eingeteilt in eintausendzweihundertsechzig (1.260) Aktien ohne Nennwert.

III.- Dass die Komparentin alleinige Aktieninhaberin der Gesellschaft ist.
IV.- Dass die Komparentin beschließt die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.
V.- Dass die Komparentin die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.

13378

L

U X E M B O U R G

VI.- Dass die Komparentin, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben

und dass sie persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht
bekannt sind, gewährleistet.

VII.- Dass dem Alleinverwalter und dem Aufsichtskommissar volle Entlast für die Ausübung ihrer Mandate erteilt wird.
VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
IX.- Dass die Inhaberaktien annulliert worden sind.
X.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren in L-1933

Luxembourg, 1, rue Siggy vu Lëtzebuerg, aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen,

unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor-und Zunamen,

Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Renier Johannes Lambertus Cornelis GOOSSENS, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2011. Relation GRE/2011/4461. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 28. Dezember 2011.

Référence de publication: 2011180744/54.
(110210754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Pelican S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 112.790.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2011179979/12.
(110209479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Atlas Sport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.050,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.081.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of the month of November.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

Atlas Venture Fund V, L.P., a Limited Partnership established under the laws of Delaware having its registered seat at

25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, represented by its general partner Atlas Venture Associates V
L.P., a Limited Partnership established under the laws of Delaware having its registered seat at 25 First Street, Suite 303,
Cambridge, MA 02141, USA, itself represented by its general partner Atlas Venture Associates V, Inc., with its registered
seat at 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA,

hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/

Alzette, by virtue of a proxy, given under private seal.

Said power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Atlas Sport S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

13379

L

U X E M B O U R G

registered with the Luxembourg Trade and companies registry under number B 109081 with a share capital of EUR
31,050.-, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, on 22 June 2005,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of 18 November 2005, number 1229 and which articles
of association have been amended for the last time on 29 June 2005 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx (the
Company).

II. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the

basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 Discharge (quitus) to the managers of the Company for the performance of their respective mandates from the date

of their appointment until the date of the present meeting.

2 Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
3 Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator).
4 Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company.
5 Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all

the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

6 Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.
7 Miscellaneous.
has requested the notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to grant full discharge to the members of the board of managers of the Company

for the performance of their duties for the period from the date of their appointment until the date of the present meeting.

<i>Second resolution

In compliance with the Law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended (the Law), the Sole Share-

holder RESOLVES with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation
(liquidation volontaire).

<i>Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to appoint Fides (Luxembourg) S.A., having its registered office at 46A, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, as liquidator (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation of the Company.

The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal

of the assets of the Company under his sole signature for the performance of his duties.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to confer to the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of

the Law.

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility,
delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the

Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best

possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

<i>Sixth resolution

The  Sole Shareholder  RESOLVES  that  the  Liquidator  will  be entitled  to  a  specific compensation of  EUR  3,500 in

compensation of his mission as Liquidator of the Company.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

Whereof, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, recognized that at the request of the party hereto, these

minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancy between the English
and the French versions, the English version shall prevail.

13380

L

U X E M B O U R G

The documents having been read and translated to the representative of the person appearing, he signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le vingt-deuxième jour du mois novembre,
par devant Me Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg,

ONT COMPARU

Atlas Venture Fund V, L.P., une société (limited partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège social

est établi au 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, représentée par son associé commandité Atlas
Venture Associates V L.P., une société (limited partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège social
est établi à 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA, elle-même représentée par son associé commandité
Atlas Venture Associates V, Inc., dont le siège social est établi à 25 First Street, Suite 303, Cambridge, MA 02141, USA,

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/

Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l’enregistrement.

Ladite partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. La partie comparante déclare être l’unique associé (l’Associé Unique) de Atlas Sport S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée de droit Luxembourgeois, dont le siège social est établi au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.081 et disposant d’un
capital social de trente-et-un mille cinqante euros (EUR 31.050), constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire
de résidence alors à Mersch, en date du 22 juin 2005, publié le 18 novembre 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, sous le numéro 1229 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 29 juin 2005 suivant un
acte de Maître Henri Hellinckx (la Société).

II. La partie comparante, valablement représentée, déclare être pleinement informée des résolutions à prendre sur

base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décharge (quitus) aux gérants de la Société pour l’exécution de leur mandat respectif à compter de la date de leur

nomination jusqu’à la date de la présente assemblée.

2. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire.
3. Nomination du liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur).
4. Fixation des pouvoirs du Liquidateur et fixation de la procédure de liquidation de la Société.
5. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes

de la Société dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles.

6. Décision d’accorder une compensation spéciale au Liquidateur.
7. Divers.
a prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique DECIDE d’accorder pleine et entière décharge aux membres du conseil de gérance de la Société

pour l’exécution de leur mandat à compter de la date de leur nomination jusqu’à la date de la présente assemblée.

<i>Deuxième résolution

Conformément à la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), l’Associé Unique

DECIDE de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire avec effet immédiat.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique DECIDE de nommer Fides (Luxembourg) S.A., dont le siège social est établi au 46A, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société.

Le Liquidateur est autorisé à accomplir toutes les démarches nécessaires à la liquidation de la Société et à la réalisation

des actifs de la Société sous sa seule signature pour l’exécution de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique DECIDE d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi.
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus

à l’article 145 de la Loi, sans l’autorisation préalable de l’Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule
responsabilité, certains de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour des opérations ou tâches
spécifiquement définies.

13381

L

U X E M B O U R G

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation en nature ou en numéraire à l’Associé

Unique conformément à l’article 148 de la Loi.

<i>Cinquième résolution

L’Associé Unique DECIDE de confier au Liquidateur la mission de réaliser tous les actifs de la Société et de payer

toutes les dettes de la Société dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles.

<i>Sixième résolution

L’Associé Unique DECIDE d’accorder au Liquidateur une compensation spéciale de EUR 3.500 en contrepartie de sa

mission de Liquidateur de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. En cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la version
anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16246. Reçu douze euros 12,00€

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011180496/148.
(110210398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Pet Club Finance S.à.r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investis-

sement en Capital à Risque.

Capital social: EUR 4.215.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 124.225.

Par contrat de cession daté du 16 décembre 2011, les sociétés Cambresio International S.A, Panna-Corn Invest S.A

Trustfid S.a.g.l.. ont cédé les 421.500 parts sociales de la Société à la société de droit néerlandais VACCARI HOLDING
N.V., ayant son siège social Collseweg 21, 5674TR Nuenen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2011179981/17.
(110210178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Pinxton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 56.270.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2011179985/10.
(110209850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

13382

L

U X E M B O U R G

PWREF I Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PWPREF I Holding S.à r.l.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 132.917.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63417 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011179995/11.
(110210158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Selfridges Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.002,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 165.093.

<i>Résolution prise par le conseil de gérance de la société en date du 20 décembre 2011

Il a été décidé de transférer le siège social de la Société de L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur à L-1130 Luxem-

bourg, 37, rue d’Anvers avec effet au 20 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180033/12.
(110209733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Solway Commodities Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 155.934.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les- Bains, le 27 décembre 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2011180040/11.
(110209986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Dimaco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.213.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le vingt et un décembre.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné.

A COMPARU:

Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à L1446 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (le

«mandataire»),

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société Wesholding S.à r.l., ayant son siège social à Suite 13, First

Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, République des Seychelles, (le «mandant»),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signé signée ne varietur par le man-

dataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme DIMACO S.A. (la «Société»), ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 60, avenue de

la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 139.213, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Me Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 mai 2008, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1600 du 30 juin 2008;

13383

L

U X E M B O U R G

II.- Que le capital social de la Société s’élève actuellement à EUR 31.000, (TRENTE ET UN MILLE EURO), représentés

par 310 (TROIS CENT DIX) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (CENT EURO) chacune;

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite Société;
IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite Société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société;

V.- Que le mandant, en sa qualité de liquidateur de la susdite Société, déclare que les dettes connues ont été payées

et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la Société
dissoute et que la liquidation de la Société est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les
engagements sociaux;

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société dissoute;
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs

de la Société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour;

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la Société

dissoute.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état

civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2011. LAC/2011/57523. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2011179652/46.
(110210654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Rafael Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 155.436.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2011180002/10.
(110209974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Le Bon Café, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 140.533.

La société à responsabilité limitée LE BON CAFE SARL , établie et ayant son siège social au 21 avenue de la liberté

L-1931 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140533
ayant pour associés:

Monsieur AL BANDAKJI Mahmoud demeurant au 125 rue de bonnevoie L-1261 Luxembourg
propriétaire de quarante (40) parts sociales de la Société
Madame BEN HAMOUDA Aouatef demeurant 28 rue de Paris, TN- 4000 Sousse propriétaire de soixante (60) parts

sociales de la Société

D'abord: Monsieur AL BANDAKJI déclare
céder ces parts sociales de la Société aux nombres de quarante (40) à
Madame SAMMAN Souad demeurant 127 rue Michel Ange 75016 Paris - France, pour le prix de (4000 euros).
Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales à compter de ce jour.
Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
Ensuite: Mahmoud AL BANDAKJI, Aouatef BEN HAMOUDA acceptent au nom de la Société
Que Souad SAMMAN succède à Monsieur ALBANDAKJI Mahmoud en qualité de gérante, à partir de la date de

démission de Monsieur AL BANDAKJI.

13384

L

U X E M B O U R G

La Société, déclarant n'avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter son effet.

Fait à Luxembourg, en trois exemplaires, le 15/11/2011.

AL BANDAKJI MAHMOUD / BEN HAMMOUDA

AOUATEF / SAMMAN SOUAD.

Référence de publication: 2011180325/25.
(110210588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Reflexion Coiffure Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5559 Remich, 5, rue du Pont.

R.C.S. Luxembourg B 164.449.

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Bertrange, en date du 21 novembre 2011, enre-

gistrée à Esch/Alzette A.C., le 24 novembre 2011; Relation: EAC/2011/15750, que l’AGE a pris les décisions suivantes:

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Verpflichtung der Gesellschaft abzuändern wie folgt:
„Die Gesellschaft wird Drittpersonen gegenüber verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Wirtschaftsgeschäfts-

führers und dies unter allen Umständen, sämtliche Bankgeschäfte eingeschlossen."

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011180003/14.
(110210137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Field Point PE VII (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 119.325.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

La dénomination et le siège social de l'associé de la Société, FIELD POINT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l. (B114.791),

doivent désormais se lire comme suit:

- Field Point II 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg
Les sièges sociaux des gérants de catégorie A de la Société, Monsieur Lewis SCHWARTZ et Monsieur James VARLEY,

doivent se lire désormais comme suit:

- 100, West Putnam Avenue 06830 Connecticut, Greenwich, Etats-Unis d'Amérique
Le siège social du gérant de catégorie A de la Société, Monsieur Nicholas Alec Geoffrey BUTT, doit se lire désormais

comme suit:

- 5, Savile Row, W1S 3PD Londres, Royaume-Uni

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 novembre 2011

En date du 24 novembre 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes;
- d'accepter la démission de Madame Sandra EHLERS de son mandat de gérant de catégorie B de la Sociétés avec effet

immédiat;

- de nommer Monsieur Christoph TSCHEPE, né le 6 avril 1979 à Trier, Allemagne, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: 22, Grand-Rue, 1660 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Field Point PE VII (Luxembourg) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011180683/30.
(110210853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

RPFFB Soparfi C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.513.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

13385

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2011180022/10.
(110209498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Swiss Euro Securities SA - Société de Titrisation, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.940.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2011180049/12.
(110209846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Tuvalu Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 34.957.

L'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2011 a ratifié la décision prise par le Conseil d'administration du 06

mai 2011 de coopter Madame Marie BOURLOND au poste d'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur
Jean BODONI.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

<i>Pour: TUVALU HOLDING S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2011180120/17.
(110210215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Machilu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.887.

DISSOLUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE, LE VINGT-DEUX DECEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

La société «Dike Trust Trustee – Serviços de Consultadoria e Investimentos S.A.», en tant que trustees de «Trust

Vis» avec siège social à Madeira – Funchal, Rua da Carreira n°115/117,

ci-après nommée "l'actionnaire unique",
représentée par:
- Monsieur Giorgio BIANCHI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procu-

ration donnée le 19 décembre 2011,

laquelle procuration, après avoir été signée NE VARIETUR par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- que la société dénommée MACHILU S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21 bd du Prince Henri, inscrite

au R.C.S. Luxembourg, sous la Section B et le numéro B107887,

ci-après dénommée "la Société",
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Paul BETTINGEN du 9 mai 2005, publié au Mémorial C de

2005, page 45.982,

13386

L

U X E M B O U R G

que le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000.-, représenté par 31 actions d'une valeur nominale de EUR

1.000.- chacune.

- Que sa mandante, l'actionnaire unique, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la

Société;

- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme ac-

tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l'actionnaire unique désigne comme liquidateur de la Société, la société «Morwell Limited», avec siège social à

Tortola, laquelle a rédigé son rapport de liquidation, lequel reste annexé au présent acte. L’actionnaire unique tel que
représenté déclare reprendre tout le passif et l’actif de la société et il déclare encore que par rapport à d'éventuels passifs
de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout
ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé;

- Que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont été vérifiées par la société «ICS (Overseas) Limited», avec siège social à

Hertfordshire, désignée "commissaire à la liquidation" par l'actionnaire unique de la Société;

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française au comparant, ès-qualité qu'il agit, lequel a signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: G. BIANCHI, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 23 décembre 2011. Relation: RED/2011/2892. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 27 décembre 2011.

Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2011179892/55.
(110209546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Skyscraper S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 147.543.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2011180079/10.
(110209519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Société Internationale de Gestion et Contrôle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 82.003.

<i>Rectificatif du bilan enregistré et déposé le 23/07/2010, et accepté au registre sous le N: L100110757

Le bilan modifié au 31 Décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011180084/11.
(110210371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

13387

L

U X E M B O U R G

Maaskade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 67.495.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven.
On the twenty-third day of November.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

APPEARED:

Nowa Onroerend Goed 1 B.V., a private limited company registered with the "Kamer van Koophandel" of The Ne-

therlands under number 20146660, with registered office at NL-4811 NR Breda (The Netherlands), Nieuwe Ginnekens-
traat 20D,

here represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing at Esch-sur-

Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
1) That the private limited company (société à responsabilité limitée) MAASKADE S.à r.l. (hereinafter referred to as

the "Company"), having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S.
Luxembourg section B number 67495, incorporated under the Netherlands Antilles Laws by deed executed before notary
Johannes Wilhelmus Maria Thesseling, a civil law notary residing in Curaçao, on May 2, 1997, and whose articles of
association have been amended for the last time by deed under private seal documenting the conversion of the capital
into Euro on December 14, 2001, published in the Mémorial C number 631 of April 23, 2002.

2) That the Company's capital is fixed at eighteen thousand five hundred and twenty Euro (EUR 18,520.-) represented

by forty (40) shares with a nominal value of four hundred and sixty three Euro (EUR 463.-) each.

3) That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
5) That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company

has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

6) That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle

any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.

7) That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing

debt of the Company even if unknown at present.

8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated.
9) That full and entire discharge is granted to the managers for the performance of their assignment.
10) That all the shares of the dissolved Company have been cancelled.
11) That the corporate documents of the dissolved Company shall be kept for the duration of five years at least at the

former registered office in L1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the Company as a result of the present deed, is approximately one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze.
Le vingt-trois novembre.

13388

L

U X E M B O U R G

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé.

A COMPARU:

Nowa Onroerend Goed 1 B.V., une société à responsabilité limitée enregistrée auprès du "Kamer van Koophandel"

des Pays-Bas sous le numéro 20146660, avec siège social à NL-4811 NR Breda (Pays-Bas), Nieuwe Ginnekenstraat 20D,

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à

Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société à responsabilité limitée MAASKADE S.à r.l. (ci-après la "Société"), ayant son siège social à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 67495, a été constituée
sous le droit des Antilles Néerlandaises suivant acte du notaire Johannes Wilhelmus Maria Thesseling, notaire de résidence
à Curaçao, en date du 2 mai 1997, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing-privé
documentant la conversion du capital en Euro, en date du 14 décembre 2001, acte publié au Mémorial C numéro 631 du
23 avril 2002.

2) Que le capital de la Société est fixé à dix-huit mille cinq cent vingt Euros (EUR 18.520,-), représenté par quarante

(40) parts sociales d'une valeur nominale de quatre cent soixante-trois Euro (EUR 463,-) chacune.

3) Que la comparante est l'associée unique de la Société.
4) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter

et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif

connu et inconnu actuellement de la Société dissoute.

7) Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de

la Société et tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle.

8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales de la Société dissoute.
11) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social de la Société à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents euros (€
1.200,-).

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la

personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, ce dernier a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16285. Reçu soixante-quinze euros

75,00€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011179891/104.
(110210288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

13389

L

U X E M B O U R G

Alpaga Promotions SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 130.510.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2011.

<i>1 

<i>er

<i> résolution

L'assemblée décide de manière unanime de nommer pour une période de 6 ans les administrateurs suivants:
- Monsieur Jean-Paul Duarte, agent immobilier, demeurant à L-4804 Rodange, 10, rue Maribor,
- Monsieur Edouardo DE OLIVEIRA, employé privé, demeurant à L-7432 Gosseldange, 95b, route de Mersch.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Président de l'assemblée générale ordinaire

Référence de publication: 2011180178/15.
(110209882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Portus Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 165.181.

L'an deux mille onze, le seize novembre.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Portus Equity S.A., établie et ayant son siège à

L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en voie d'inscription au Registre de Commerce et des
Sociétés, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 20 octobre 2011, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Luc LESIRE, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Christelle DEMICHELET, employée privée, demeurant à Hayange (France).
L'assemblée choisit comme scrutateur Koen VAN HUYNEGEM, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de la société.
2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société avec effet au 2 novembre 2011, à concurrence de la

somme de QUATRE MILLIONS QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (4.092.600,-€) pour le porter de
son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-€) à un montant de QUATRE MILLIONS CENT VINGT-
TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (4.123.600,-€), par l'émission, la création et la souscription de QUARANTE MILLE
NEUF CENT VINGT-SIX (40.926) actions nouvelles, sans valeur nominale, qui jouiront des mêmes droits et avantages
que  les  actions  existantes,  libérées  par  un  apport  en  nature  consistant  en  la  totalité  des  actions  de  la  société  belge
FISCOPAN  BVBA,  ayant  son  siège  social  à  B-2012  Antwerp  (Belgique),  Hoveniersstraat  40  box  2,  d'un  montant  de
QUATRE MILLIONS QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENT VINGT-HUIT EUROS (4.092.528,-€) et par un
apport en espèces d'un montant de SOIXANTE-DOUZE EUROS (72,-€), suivant un rapport du réviseur d'entreprises
agréé CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN &amp; C° S.A.R.L., daté du 2 novembre 2011, qui conclut comme suit:

13390

L

U X E M B O U R G

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."

Une copie de ce rapport, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et par les comparants, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

<i>Souscription

Les quarante mille neuf cent vingt-six (40.926) nouvelles actions ont été souscrites par la société Realty Corporation

Limited, avec siège social à Gibraltar.

Il résulte d'un certificat du conseil d'administration de la société Portus Equity S.A. daté du 16 novembre 2011, lequel

restera annexé aux présentes, que les actions de la société FISCOPAN BVBA lui ont été transmises.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à QUATRE MILLIONS CENT VINGT-TROIS MILLE SIX CENTS

EUROS (4.123.600,-€), représenté par QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE-SIX (41.236) actions sans
valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: LESIRE, DEMICHELET, VAN HUYNEGEM, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 29 novembre 2011 REM 2011 / 1580. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 27 décembre 2011.

Référence de publication: 2011179959/66.
(110209385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Thundercat S.A., Société Anonyme Unipersonnelle,

(anc. Whysol S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 136.903.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63398 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011180097/11.
(110209390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Wert Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 132.726.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2011180148/10.
(110209814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Alur Constructions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 121.052.

La société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA (RCS B83527) démissionne de ses fonctions de commissaire aux

comptes de la société ALUR CONSTRUCTIONS SA (RCS B121052) avec effet immédiat.

13391

L

U X E M B O U R G

Le vendredi 16 décembre 2011.

COMITUM INTERNATIONAL SA
31, Val Sainte Croix L-1371 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011180169/13.

(110209398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.

NKCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 2, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 115.546.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011180888/9.

(110210790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

My Stone Lux s.à.r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. M.S. Lux Sàrl).

Siège social: L-7661 Medernach, 10, rue de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 59.853.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011180858/9.

(110211738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

LUX. FINANCIAL COMPANY Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 73.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011180832/9.

(110211299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Marketing Control Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 42.234.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011180862/9.

(110211300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

13392


Document Outline

Alpaga Promotions SA

Alur Constructions S.A.

Atlas Sport S.à r.l.

Beam Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Beech Tree S.A.

Carat (Lux) SICAV

Commerzbank International Portfolio Management

Dimaco S.A.

Estates Management S.A.

F.D.M. S.A.

Field Point PE VII (Luxembourg) S.à r.l.

Finimmo Holding SA

Fonds Direkt Sicav

H &amp; A Lux Wandelanleihen Fonds

H &amp; A Lux Wandelanleihen Fonds

Health &amp; Safety Systems S.A.

HFB Investissements S.A.

Intelsat (Luxembourg) Finance Company S.à r.l.

JamaicaLux S.A.

Julius Baer Multicash

Julius Baer Multicooperation

Julius Baer Multilabel

Julius Baer Multirange

Konnick Invest S.A.

Le Bon Café

Logitrans Europ S.A.

LUX. FINANCIAL COMPANY Spf S.A.

Maaskade S.à r.l.

Machilu S.A.

Marketing Control Holding S.A.

M.S. Lux Sàrl

MVM Lux Sicav

My Stone Lux s.à.r.l.

NKCS S.A.

Orco Property Group

Orco Property Group

Orco Property Group

Pelican S.A.

Pet Club Finance S.à.r.l. SICAR

Pinxton S.A.

Portus Equity S.A.

PWPREF I Holding S.à r.l.

PWREF I Holding S.à r.l.

Rafael Productions S.à r.l.

Reflexion Coiffure Sàrl

RM2 International S.A.

RM2 International S.A.

RPFFB Soparfi C S.à r.l.

Selfridges Investments S.à r.l.

Skyscraper S.à r.l.

Société Internationale de Gestion et Contrôle S.A.

Solway Commodities Sàrl

Spimelux S.A.

StarCap SICAV

Swiss Euro Securities SA - Société de Titrisation

Thundercat S.A.

Trendconcept Fund

Trendconcept Fund

Trendconcept Fund Multi Asset Allocator

Trendconcept Fund Multi Asset Allocator

Tuvalu Holding S.A.

WBB Invest S.A.

Wert Investment Holdings S.à r.l.

Whysol S.A.