logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 204

25 janvier 2012

SOMMAIRE

30 Lopes S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9778

Aer Leit A.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9790

Joh. A. Benckiser s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9746

LBK Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

9746

LBK Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9746

Les Olliviers Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9746

Liljefors & Linde S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9746

Linorca S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9766

Linorca S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9766

Litrade International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

9767

Machal II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9768

Madidi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9768

Madidi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9773

Magfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9773

Maisons du Monde Luxembourg, S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9773

Malafin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9773

Mangon Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

9774

Mangon Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

9774

Marrow Asset Management S.A.  . . . . . . . .

9774

Martis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9777

Martis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9777

Martis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9777

Marussia Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9777

MCI Holding SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9778

Medici s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9778

Medici s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9781

Mère Nature S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9777

Metallic S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9781

Metalltechnik Aktiengesellschaft  . . . . . . . .

9781

Metalltechnik Aktiengesellschaft  . . . . . . . .

9780

MexSpa Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9767

MexSpa Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

9767

MexSpa Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

9767

MGB International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

9782

MGix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9782

MGix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9781

MH Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9782

Millennium European Holdings S.à r.l.  . . .

9768

Minny S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9785

MIP II Gateway Investment S.à rl.  . . . . . . .

9785

MIP II Luxembourg Investments S.à r.l.  . .

9786

MIP II Luxembourg Investments S.à r.l.  . .

9778

Mon Jardin - Gardencenter Sàrl  . . . . . . . . .

9785

Mon Jardin - Nouvelles Créations S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9785

Morsa Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9782

MosliB Holdings Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9768

MPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9786

MTEL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9784

MWH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9786

New CV Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9785

New Millennium Advisory S.A.  . . . . . . . . . .

9788

New Millennium Advisory S.A.  . . . . . . . . . .

9789

Nico BACKES S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9789

PEP Fund Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9792

PEP Fund Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9792

P+M Montage GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9789

PSL Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9792

QE Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9792

Tate & Lyle European Finance, S.à r.l.  . . .

9783

Temeraire S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9774

Terold S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9769

Vélizy Rose Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . .

9787

9745

L

U X E M B O U R G

LBK Finance S.A., Société Anonyme,

(anc. LBK Finance Holding S.A.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 82.138.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LBK FINANCE S.A.
I. DONADIO / P. MESTDAGH
<i>Director / Director

Référence de publication: 2011175540/12.
(110203906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Les Olliviers Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 68-70, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 149.454.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011175541/14.
(110205102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Liljefors &amp; Linde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 90.565.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un gérant

Référence de publication: 2011175542/11.
(110203896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Joh. A. Benckiser s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 6.327.198,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 164.586.

In the year two thousand and twelve, on the ninth day of January, at 14:50
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Joh. A. Benckiser s.à r.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Maître Elvinger dated 8 November 2011, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.586 and having a share capital amounting to
USD 5,342,200.-(the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended once since
its incorporation on 9 January 2012 by virtue of a deed of Maître Elvinger, not yet published.

THERE APPEARED

9746

L

U X E M B O U R G

Joh. A. Benckiser SE, a company incorporated under the laws of Austria, having its registered office at Rooseveltplatz

4-5/Top 10, A-1090 Vienna, Austria, registered with the Commercial Court of Vienna, under number FN 288590 y (the
Sole Shareholder),

hereby represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. increase of the share capital of the Company by an amount of nine hundred eighty-four thousand nine hundred and

ninety-eight United States dollars (USD 984,998.-) in order to bring the share capital of the Company from its present
amount of five million three hundred forty-two thousand two hundred United States dollars (USD 5,342,200.-) to six
million three hundred twenty-seven thousand one hundred and ninety-eight United States dollars (USD 6,327,198.-) by
way of the issuance of nine hundred eighty-four thousand nine hundred and ninety-eight (984,998) new shares, having a
nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each (the Share Capital Increase);

2. subscription for and payment of the share capital increase specified under item 1 above by several contributions in

cash;

3. approval of the amendment and full re-statement of the Articles;
4. resignation, with immediate effect and with full discharge, from their respective positions as managers of the Com-

pany of Constantin Thun-Hohenstein and Elke Demuth-Steiner;

5. amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes, with power and

authority given to any manager of the Company, each acting individually, to (i) register, in the name and on behalf of the
Company, the newly issued shares in the register of shareholders of the Company, and (ii) complete any formalities in
connection with the Share Capital Increase (including, for the avoidance of doubt, the signing of the said registers) and
the resignation of the managers of the Company;

6. approval of a share transfer;
7. approval of share pledges; and
8. miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions.

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of nine hundred eighty-four

thousand nine hundred and ninety-eight United States dollars (USD 984,998.-) in order to bring the share capital of the
Company from its present amount of five million three hundred forty-two thousand two hundred United States dollars
(USD 5,342,200.-) represented by five million three hundred forty-two thousand two hundred (5,342,200) shares having
a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) to six million three hundred twenty-seven thousand one hundred
and ninety-eight United States dollars (USD 6,327,198.-) by way of issuance of nine hundred eightyfour thousand nine
hundred and ninety-eight (984,998) new shares, having a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each (the
Share Capital Increase).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscriptions for and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription – Payment

At this point in time, HFS S.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Trade and Companies
Register under number B 165.525, represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333)

new class B1 Ordinary Shares by a payment of forty million United States dollars (USD 40,000,000.) in cash.

The contribution in cash to the Company made by HFS S.à r.l. shall be allocated as follows:
-  an  amount  of  one  hundred  thirty-three  thousand  three  hundred  and  thirty-three  United  States  dollars  (USD

133,333.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of thirty-nine million eight hundred sixty-six thousand six hundred sixty-seven United States dollars (USD

39,866,667.-) is allocated to the share premium account of the Company.

9747

L

U X E M B O U R G

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which

each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

At this point in time, Bansk s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Trade and
Companies Register under number B 165.349, represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333)

new class S1 Shares and to five hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-two (533,332) new class S2 Shares
by a payment of six hundred sixty-six thousand six hundred sixty-five United States dollars (USD 666,665.-) in cash fully
allocated to the share capital account of the Company.

At this point in time, 1998 Grat s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of

Luxembourg, having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Trade
and Companies Register under number B 165.604, represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to thirty thousand (30,000) new class B2 Ordinary Shares by a payment of thirty

million United States dollars (USD 30,000,000.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by 1998 Grat s.à r.l. shall be allocated as follows:
- an amount of thirty thousand United States dollars (USD 30,000.-) is allocated to the share capital account of the

Company; and

- an amount of twenty-nine million nine hundred seventy thousand United States dollars (USD 29,970,000.-) is allocated

to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which

each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

At this point in time, AC Revocable Trust s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the
Trade and Companies Register under number B 165.629, represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address
in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to twenty thousand (20,000) new class B2 Ordinary Shares by a payment of

twenty million United States dollars (USD 20,000,000.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by AC Revocable Trust s.à r.l. shall be allocated as follows:
- an amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-) is allocated to the share capital account of the

Company; and

- an amount of nineteen million nine hundred eighty thousand United States dollars (USD 19,980,000.-) is allocated to

the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which

each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

At this point in time, Olivier Goudet, with professional address at 9302 Lee Highway, Suite 1100, Fairfax 22030, USA,

represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to one hundred twenty thousand (120,000) new class BN Ordinary Shares by a

payment of ten million United States dollars (USD 10,000,000.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by Olivier Goudet shall be allocated as follows:
- an amount of one hundred twenty thousand United States dollars (USD 120,000.-) is allocated to the share capital

account of the Company; and

- an amount of nine million eight hundred eighty thousand United States dollars (USD 9,880,000.-) is allocated to the

share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which

each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

9748

L

U X E M B O U R G

At this point in time, Dr Renate Reimann-Haas, with professional address at Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090,

Vienna, Austria represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe to fifteen thousand (15,000) new class B3 Ordinary Shares by a payment of fifteen

million United States dollars (USD 15,000,000.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by Dr Renate Reimann-Haas shall be allocated as follows:
- an amount of fifteen thousand United States dollars (USD 15,000.-) is allocated to the share capital account of the

Company; and

- an amount of fourteen million nine hundred eighty-five thousand United States dollars (USD 14,985,000.-) is allocated

to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which

each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

Overall, the Contributions in cash to the Company shall be allocated as follows:
- an amount of nine hundred eighty-four thousand nine hundred and ninety-eight United States dollars (USD 984,998.-)

is allocated to the share capital account of the Company; and

- an amount of one hundred fourteen million six hundred eighty-one thousand six hundred and sixty-seven United

States dollars (USD 114,681,667.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall remain attached to each share to which

each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

Evidence of full payment of these contributions in cash has been provided to the undersigned notary.
All the above contributors join the meeting as shareholders and are collectively referred to, together with the Sole

Shareholder, as the Shareholders.

<i>Third resolution

The Shareholders (including for the avoidance of doubt those parties that have become shareholders of the Company

by virtue of the above contributions) resolve to amend and fully restate the Articles as follows:

I. Name – Registered office – Object – Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Joh. A. Benckiser s.à.r.l.” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the Board. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of
Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment
of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such tem-
porary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management and sale of those participations. The Company may in particular
acquire and dispose of, by subscription, purchase, sale and exchange or in any other manner, any stock, shares and other
participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any
securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of, and
dispose of, a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations

9749

L

U X E M B O U R G

and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments and other business

efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital – Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at six million three hundred twenty-seven thousand one hundred and ninety-eight United

States Dollars (USD 6,327,198), represented by six million three hundred twentyseven thousand one hundred and ninety-
eight (6,327,198) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, divided in
several classes as follows: five million three hundred forty-two thousand two hundred (5,342,200) class A ordinary shares
(the Class A Ordinary Shares), one hundred thirtythree thousand three hundred and thirty-three (133,333) class B1
ordinary shares (the Class B1 Ordinary Shares), fifty thousand (50,000) class B2 ordinary Shares (the Class B2 Ordinary
Shares), one hundred twenty thousand (120,000) class BN ordinary Shares (the Class BN Ordinary Shares), fifteen thou-
sand (15,000) class B3 ordinary Shares (the Class B3 Ordinary Shares; the Class B1 Ordinary Shares, the Class B2 Ordinary
Shares, the Class BN Ordinary Shares and the Class B3 Ordinary Shares are collectively referred to as the Class B Ordinary
Shares; the Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares are collectively referred to as the Ordinary Shares),
one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) special 1 shares (S1 Shares) and five hundred
thirty-three thousand three hundred and thirty-two (533,332) special 2 shares (the S2 Shares, the S1 Shares and the S2
Shares are collectively referred to as the Special Shares). The rights attached to each category of shares are further defined
in these Articles. One Class S1 Share and one Class S2 Share together carry the rights of one Ordinary Share subject to
the limitations set forth in Articles 17.2, 18.1, 18.2, 20.3 and 20.4.

5.2. Contributions to the share premium and special equity reserve account of the Company shall remain attached to

each share to which each contribution relates and shall not form a pool evenly spread over all shares.

5.3.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-

quarters of the shares held by the other shareholders. In case such approval is not granted, the shares of the deceased
shareholder shall be acquired by the Company for a price equalling the net asset value of the shares of the deceased
shareholder as at the end of the calendar quarter during which the approval was refused.

6.6. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.7. A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company and may be examined by any

shareholder on request.

6.8. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

III. Management – Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers (gérants) appointed by a resolution of the shareholders,

which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

9750

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which

in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented, provided that the failure to comply with such recording requirement shall not affect the validity of the
respective resolution.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers. If

the shareholders have appointed different classes of managers, namely class A and class B managers, the Company will
be bound by the joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers

have been delegated by the Board in accordance with the rules applicable to such delegations of authority as approved
by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law. The managers shall further be liable only for wilful breaches of their duties involved in the conduct of their
office. The Company shall, in accordance with any indemnity agreement entered into, from time to time, by and between
the managers and the Company, and without prejudice to any other indemnity to which the managers may otherwise be
entitled, indemnify the managers on a full indemnity basis and to the fullest extent permitted by law against all liabilities
losses, damages, penalties, costs, expenses and disbursements (including, without limitation, reasonable and documented
out-ofpocket costs and expenses) (the “Charges”) incurred or suffered by the managers due to, arising out of, or in
connection with, the actual or purported execution of their mandate as managers of the Company, in particular, but
without limitation, where any such Charges (i) arise out of any claim, action, demand, investigation or proceeding (whether
civil, criminal or regulatory) made, brought or threatened against the managers or (ii) result from any applicable Luxem-
bourg or foreign legal provision or regulation (including without limitation any applicable tax provision or regulation). No
indemnification shall be provided to the managers against any liability to the Company or of any of its direct or indirect
subsidiary or its shareholders by reason of wilful breach of the duties involved in the conduct of their office or fraud. The
managers shall continue to be indemnified under the terms of the indemnities provided in any indemnity agreement
entered into, from time to time, by and between the managers and the Company even after they have ceased to be
managers of the Company or any affiliated entity of the Company. Expenses in connection with the preparation and
representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be
advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the managers

9751

L

U X E M B O U R G

to repay such amount if and to the extent it is ultimately determined that they are not entitled to indemnification under
this Article.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with Article 11.1(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted

at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders

may be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) (i.e. 10%) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-

holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than half (i.e. 50%)

of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by
registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a
majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

threequarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and

shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

Art. 13. Shareholders’ Committee.
13.1. The shareholders may, from time to time, appoint by a simple majority vote a Shareholders’ Committee, com-

posed as the shareholders deem fit to facilitate the information flow between the Company and the shareholders.

13.2.  The  Shareholders  Committee  shall  also  deal  with  matters  that  may  be  entrusted  to  it  by  any  shareholders

agreement that may be entered into among the shareholders from time to time.

V. Annual accounts - Allocation of profits – Supervision

Art. 14. Financial year and Approval of annual accounts.
14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
14.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory

stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the
debts owed by its managers, other members of the Company’s management team and shareholders to the Company.
The annual accounts shall be drawn up in USD.

14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

9752

L

U X E M B O U R G

(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following

the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders’ Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twentyfive (25), at the annual General Meeting.

Art. 15. Auditors.
15.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external

auditors  (réviseurs  d’entreprises  agréés).  The  shareholders  shall  appoint  the  approved  external  auditors,  if  any,  and
determine their number and remuneration and the term of their office.

15.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be

supervised by one or more statutory auditors (commissaires), unless the Law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The statutory auditors are subject to reappointment at the
annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 16. Allocation of profits – General principles.
16.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

16.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

16.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend.

16.4. Shares issued in the course of a calendar year shall be entitled to share in the dividend distribution during that

year only on a pro rata temporis basis, i.e. only for that portion of the year for which the shares have been outstanding.

16.5. If shares are issued at a price which is less than the per share value at the time of issuance, but with a contractual

commitment of the subscriber to pay the difference to the per share value into the special equity reserve of the Company,
then that shall be treated for the dividend entitlement as if, on the basis of the per share value at the time of issuance of
those shares, not all of those shares have been issued at that time, but these shares had been issued only over time in
proportion to the extent that the payments (issue price and additional payment into the equity reserve) equal the per
share value of the issued shares at the time of the issuance.

16.6. For purposes of Articles 16 and 19, the issue of shares and the payment for shares, if made in the first half of a

calendar month, shall be deemed to have taken place at the beginning of the month and otherwise shall be deemed to
have taken place at the beginning of the next following month.

Art. 17. Special dividend entitlements of Class BN Shares.
17.1. The Class BN Shares shall receive a priority interest in dividend distributions (PPI) in addition to their dividend

entitlements which are identical to those of the Ordinary Shares and the Special Shares.

17.2. The PPI shall apply to dividend distributions made at any time after the issue of the Class BN shares. That priority

shall not affect the dividend entitlement of shares of other subclasses of Class B Ordinary Shares, the normal dividend
entitlement of Class BN Shares and/or the dividend rights of Class S1 Shares and Class S2 Shares. The PPI shall be taken
exclusively from the dividend which otherwise would be distributable on Class A Ordinary Shares. It shall be in addition
to the normal dividend entitlement of Class BN Shares.

17.3. The priority distributions pursuant to this Article 17 shall not exceed the aggregate sum of net long-term capital

gains and “qualifying dividend income” within the meaning of section 1(h)(11) of the US Internal Revenue Code of 1986
(as amended) (“QDI”) that has been recognized by the Company for U.S. federal income tax purposes after January 1,
2012 (the “Applicable Profits”). The following income items shall be regarded as Applicable Profits

(a) Proceeds from a sale of investments with a long-term holding period for U.S. federal income tax purposes to the

extent they exceed the original value of such investments in the books of the Company;

(b) QDI received by the Company other than dividends whose expected amount was included in the original book

value of the underlying portfolio company; dividends received by the Company in 2012 for periods preceding January 1,

9753

L

U X E M B O U R G

2012 shall be deemed not to have been included in the original book value of the underlying portfolio company if and to
the extent

(i) the market value of the underlying portfolio company immediately after the distribution of such dividend, or
(ii) the sum of the highest market value of the underlying portfolio company in the period from January 1, 2012 to the

date of the distribution and the market value immediately after the distribution less the market value immediately before
the distribution

is at least equal to the value that (if applicable on conversion into US Dollars) was the basis of the original book value.

Dividends received for periods after December 31, 2011 shall be deemed not to have been included in the original book
value.

17.4. The initial amount of the priority interest shall be equal to USD 90 million, increased for interest at the rate to

be determined; such amount of USD 90 million increased for interest as aforesaid (the “Accrued Priority”) shall be further
grossed up for all taxes payable by the holder of the Class BN Shares (whether withholding taxes or taxes payable by
assessments in Luxembourg or the country of the holder of the Class BN Shares’s residence, including without limitation
a gross-up for any taxes payable on such grossed up taxes) on account of the distribution of and entitlement to such
priority interest, such that the total amount payable hereunder (the “Total Profit Allocation”) shall be (i) the Accrued
Priority divided by (ii) a number, expressed as a decimal, equal to 100% minus the applicable tax rate. The applicable taxes
and the effective tax rate shall be determined jointly by the holders of the Class BN Shares and Class A Ordinary Shares.
If it should turn out later that the taxes are higher, the rights under the PPI shall increase so as to cover these additional
taxes (if applicable on grossed up basis) as well, including any interest or penalties imposed by the taxing authorities that
are not attributable to acts or omissions of the holder of the Class BN Shares. If they are lower, the holders of the Class
BN shares shall turn over the excess to the holders of the Class A Ordinary Shares.

Art. 18. Dividend entitlements of Class S1 Shares and Class S2 Shares.
18.1. Each Class S1 Share and each Class S2 Share is entitled to 1/5 

th

 (one-fifth) of the dividend distributed on an

Ordinary Share (other than the PPI of Class BN shares) provided that Class S1 Shares do not participate in that part of
a dividend by which the distributions in any given calendar year in aggregate exceed 0.7% of the net asset value of the
Company as at the beginning of such calendar year, and

18.2. Class S2 Shares participate each with 25% of the dividend attributable to an Ordinary Share out of that part of

the distribution of the dividends in which Class S1 Shares do not participate according to Article 18.1 but subject to
Article 19.2.

Art. 19. Regular distributions.
19.1. Unless otherwise decided by the shareholders, the Company shall make annual distributions of 0.7% of the

Company’s own net asset value as at the beginning of the then current year. These distributions shall be made in addition
to the distribution on the PPI. To the extent necessary, such distributions shall be made from reserves.

19.2.  If  the  Company  resolves  to  make  a  distribution  of  dividends  in  any  calendar  year  in  excess  of  0.7%  of  the

Company’s own net asset value but such that the amount of the dividend does not exceed 0.7% of the net asset value of
a Virtual Pool (as may be defined from time to time) as at the beginning of the year, then the amount by which this dividend
exceeds the amount of 0.7% of the net asset value of the Company’s own net assets up to the amount of 0.7% of the net
asset value of such Virtual Pool as at the beginning of the year shall be distributed exclusively to the holders of the Class
A1 Ordinary Shares.

19.3. The first general distribution of dividends shall be made in October 2012 and shall be measured against the

Company’s own net asset value as at January 1, 2012; for this purpose, the contributions made with respect to the shares
referred to in Article 5.1 prior to July 2012 shall be regarded as part of the Company’s net assets as at January 1, 2012.

19.4. To the extent a shareholder is subject to pass-through income taxation on profits of the Company or its subsi-

diaries allocated to him/her by the relevant tax authorities and such taxable income allocations for any year exceed the
amount of cash distributed to such shareholder for such year (in each case, not taking into account any allocations or
distributions pursuant to the PPI), that shareholder shall be entitled to an additional distribution (each such distribution:
a “Tax Distribution”) in the amount of his, her or its tax liability attributable to such excess taxable income allocation.
For purposes of calculating the net asset value of the Company (whether in connection with the issue of shares or in
connection with redemption of shares) and for the determination of the proceeds of liquidation available for distribution
the amount of all such Tax Distributions made to any shareholders shall be added to the net asset value of the Company
as if it were a loan to the recipients of the relevant Tax Distributions. The amount of such Tax Distributions shall be
regarded as a prepayment of the recipient’s share in the liquidation proceeds and accordingly shall reduce the amount
the holder of the shares concerned receives in the liquidation.

VI. Dissolution – Liquidation

20.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,

9754

L

U X E M B O U R G

powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company’s assets and pay its liabilities.

20.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them except for what is provided in Articles 20.3 and 20.4.

20.3. Class S1 Shares participate in liquidation proceeds only up to the amount of a distribution of 120% of the per

share value at the time of their issue (which would be the Full Issue Price for Ordinary Shares, as may be defined from
time to time, issued at the same time) (the “Ordinary Issue Price”), as it may be adjusted from time to time pursuant to
anti-dilution provisions in option or similar agreements.

20.4. Class S2 Shares do not participate in the distribution of liquidation proceeds up to an amount of 120% of the

Ordinary Issue Price (as adjusted, if applicable), but they participate in the distribution of liquidation proceeds to the
extent they exceed 120% of the Ordinary Issue Price (as adjusted, if applicable). However, the holder of a Class S2 Share
is entitled to this participation in liquidation proceeds in excess of 120% of the Ordinary Issue Price (as adjusted, if
applicable) only to the extent the holder has a corresponding number of Class S1 Shares in such a way that rights of a
Class S2 Share in respect of liquidation proceeds can be exercised only in conjunction with the exercise of the rights
under an existing Class S1 Share held by the same holder to participate in the liquidation proceeds up to 120% of the
Ordinary Issue Price.

VII. General provisions

21.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

21.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described in Article 21.1 above. Powers of attorney in

connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted
by the Board.

21.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.

21.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.

<i>Fourth resolution

The Shareholders acknowledge that Constantin Thun-Hohenstein and Elke Demuth-Steiner have resigned with im-

mediate effect from their respective positions as managers of the Company on 5 January 2012. Each of them is granted
full discharge.

The Shareholders acknowledge that as a result of the above resignations the Company’s board of managers is composed

of Markus Hopmann and Joachim Creus since 5 January 2012.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes,

with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to (i) register, in the name and
on behalf of the Company, the newly issued shares in the register of shareholders of the Company, and (ii) complete any
formalities in connection with the Share Capital Increase (including, for the avoidance of doubt, the signing of the said
registers) and the resignation of the managers of the Company.

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to approve the transfer of one hundred twenty thousand (120,000) new class BN Ordinary

Shares by Olivier Goudet to Platin Investments S.à r.l., a private limited liability company organized and existing under
the laws of Luxembourg, having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with
the Trade and Companies Register under number B 165.345.

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to approve the pledge of (i) one hundred twenty thousand (120,000) new class BN Ordinary

Shares by Platin Investments S.à r.l. in accordance with any pledge agreement that may be entered into from time to time
by Platin Investments S.à r.l. and (ii) one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) new
class B1 Ordinary Shares by HFS S.à r.l. in accordance with any pledge agreement that may be entered into from time to
time by HFS S.à r.l., as well as the transfer of these shares upon enforcement of these pledges in accordance with applicable
provisions.

9755

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euros (EUR 7,000.-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed. The meeting was closed at 15:00.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes

Im Jahr zweitausendzwölf fand am 9. Januar um 14.50 Uhr vor Maître Elvinger, Notar in Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg,

eine außerordentliche Generalversammlung (die Versammlung) des Alleingesellschafters von Joh. A. Benckiser s.à r.l.

statt, einer privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
burg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß einer Urkunde des Notars Maître Elvinger vom 8. November 2011,
eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 164.586, mit einem Stammkapital
von 5.342.200,--USD (die Gesellschaft). Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde seit deren Gründung einmal
am 9. Januar 2012 durch eine noch nicht veröffentlichte Urkunde von Maître Elvinger geändert.

ES ERSCHIEN

Joh. A. Benckiser SE, eine Gesellschaft gegründet nach österreichischem Recht, mit Gesellschaftssitz in Rooseveltplatz

4-5/Top 10, A-1090 Wien, Österreich, eingetragen beim Handelsgericht Wien unter der Nummer FN 288590 y (der
Alleingesellschafter),

hier vertreten durch Rechtsanwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

Besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne

varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigefügt.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar um Inkraftsetzung des Fol-

genden ersucht:

I. Dass der Alleingesellschafter alle Geschäftsanteile des Stammkapitals der Gesellschaft hält;
II. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von neunhundertvierundachtzigtausendneunhunder-

tachtundneunzig US-Dollar (984.998,--USD), um das Stammkapital der Gesellschaft von seiner gegenwärtigen Höhe von
fünf Millionen vierhundertzweiundvierzigtausendzweihundert US-Dollar (5.342.200,--USD) auf sechs Millionen dreihun-
dertsiebenundzwanzig US-Dollar (6.327.198,--USD) anzuheben, durch Ausgabe von neunhundertvierundachtzigtausend-
neunhundertachtundneunzig (984.998) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--USD) (die
Erhöhung des Stammkapitals);

2. Zeichnung und Einzahlung der im vorstehenden Punkt 1 angegebenen Erhöhung des Stammkapitals durch mehrere

Bareinlagen;

3. Genehmigung der Änderung und vollständigen Neufassung der Satzung;
4. Rücktritt von Constantin Thun-Hohenstein und Elke Demuth-Steiner mit sofortiger Wirkung und voller Entlastung

von ihren jeweiligen Positionen als Geschäftsführer der Gesellschaft;

5. Änderung des Gesellschafterverzeichnisses der Gesellschaft zur Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen,

wobei jedem Manager der Gesellschaft die Befugnis und Vollmacht erteilt wird, jeweils einzeln handelnd, (i) für und im
Namen der Gesellschaft den neu ausgegebenen Geschäftsanteil in das Gesellschafterverzeichnis der Gesellschaft einzu-
tragen und (ii) alle Formalitäten in Verbindung mit der Erhöhung des Stammkapitals abzuschließen (zur Vermeidung von
Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Unterzeichnung der genannten Verzeichnisse gehört), sowie der Rück-
tritt der Geschäftsführer der Gesellschaft;

6. Genehmigung einer Anteilsübertragung;
7. Genehmigung von Anteilsverpfändungen; und
8. Verschiedenes.
III. Dass der Alleingesellschafter die nachstehenden Beschlüsse gefasst hat.

9756

L

U X E M B O U R G

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von neunhun-

dertvierundachtzigtausendneunhundertachtundneunzig  US-Dollar  (984.998,--USD),  um  das  Stammkapital  der  Gesell-
schaft  von  seiner  gegenwärtigen  Höhe  von  fünf  Millionen  dreihundertzweiundvierzigtausendzweihundert  US-Dollar
(5.342.200,--USD),  repräsentiert  durch  fünf  Millionen  dreihundertzweiundvierzigtausendzweihundert  (5.342.200)  Ge-
schäftsanteile im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--USD) auf sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausen-
deinhundertachtundneunzig  US-Dollar  (6.327.198,--USD)  anzuheben,  durch  Ausgabe  von  neunhundertvierundachtzig-
tausendneunhundertachtundneunzig (984.998) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,--USD)
(die Erhöhung des Stammkapitals);

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Annahme und Eintragung der nachstehenden Zeichnungen und vollständigen

Einzahlung der Erhöhung des Stammkapitals wie folgt:

<i>Zeichnung – Zahlung

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die HFS S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, eingetragen im
Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.525, vertreten durch Rechtsanwalt Thierry
Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwalts-
vollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne

varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigefügt.

und erklärt, einhundertdreiunddreißigtausenddreihundertdreiunddreißig (133.333) neue Stammanteile Klasse B1 durch

Einzahlung von vierzig Millionen US-Dollar (40.000.000 USD) in bar zu zeichnen.

Die von der HFS S.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
-  ein  Betrag  von  einhundertdreiunddreißigtausenddreihundertdreiunddreißig  US-Dollar  (133.333,--USD)  wird  dem

Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und

-  ein  Betrag  von  neununddreißig  Millionen  achthundertsechsundsechzigtausendsechshundertsiebenundsechzig  US-

Dollar (39.866.667,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die

jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die Bansk s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende

private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 13-15 avenue de la Liberté, L1931 Luxembourg,
eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.349, vertreten durch Rechts-
anwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen
Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne

varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigefügt.

und erklärt, einhundertdreiunddreißigtausenddreihundertdreiunddreißig (133.333) neue Stammanteile Klasse B1 und

fünfhundertdreiunddreißigtausenddreihundertzweiunddreißig (533.332) neue Stammanteile Klasse S1 durch Einzahlung
von sechshundertsechsundsechzigtausendsechshundertfünfundsechzig US-Dollar (666.665 USD) in bar zu zeichnen, die
in voller Höhe dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen werden.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die 1998 Grat s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende

private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 13-15 avenue de la Liberté, L1931 Luxembourg,
eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.604, vertreten durch Rechts-
anwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen
Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne

varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigefügt.

und erklärt, dreißigtausend (30.000) neue Stammanteile Klasse B2 durch Einzahlung von dreißig Millionen US-Dollar

(30.000.000,--USD) in bar zu zeichnen.

Die von der 1998 Grat s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von dreißigtausend US-Dollar (30.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen;

und

- ein Betrag von neunundzwanzig Millionen neunhundertsiebzigtausend US-Dollar (29.970.000,--USD) wird dem Agi-

okonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die

jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

9757

L

U X E M B O U R G

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die AC Revocable Trust s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und

bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 13-15 avenue de la Liberté, L1931
Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.629, vertreten
durch Rechtsanwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der pri-
vatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne

varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigefügt.

und erklärt, zwanzigtausend (20.000) neue Stammanteile Klasse B2 durch Einzahlung von zwanzig Millionen US-Dollar

(20.000.000,--USD) in bar zu zeichnen.

Die von der AC Revocable Trust s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von zwanzigtausend US-Dollar (20.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen;

und

- ein Betrag von neunzehn Millionen neunhundertachtzigtausend US-Dollar (19.980.000,--USD) wird dem Agiokonto

der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die

jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert Olivier Goudet mit Geschäftsadresse in 9302 Lee Highway, Suite 1100, Fairfax 22030,

USA, vertreten durch Rechtsanwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne

varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigefügt.

und erklärt, einhundertzwanzigtausend (120.000) neue Stammanteile Klasse BN durch Einzahlung von zehn Millionen

US-Dollar (10.000.000,--USD) in bar zu zeichnen.

Die von Oliver Goudet geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von einhundertzwanzigtausend US-Dollar (120.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft

zugewiesen; und

- ein Betrag von neun Millionen achthundertachtzigtausend US-Dollar (9.880.000,--USD) wird dem Agiokonto der

Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die

jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert Dr. Renate Reimann-Haas mit Geschäftsadresse in Rooseveltplatz 4-5 TOP 10,

A-1090 Wien, Österreich, vertreten durch Rechtsanwalt Thierry Lohest mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertretender der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne

varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegende Urkunde zur Registrierung beigefügt.

und erklärt, fünfzehntausend (15.000) neue Stammanteile Klasse B3 durch Einzahlung von fünfzehn Millionen US-Dollar

(15.000.000,--USD) in bar zu zeichnen.

Die von Dr. Renate Reimannn-Haas geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von fünfzehntausend US-Dollar (15.000,--USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen;

und

- ein Betrag von vierzehn Millionen neunhundertfünfundachtzigtausend US-Dollar (14.985.000,--USD) wird dem Agi-

okonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die

jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Insgesamt werden die Bareinlagen in die Gesellschaft wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von neunhundertvierundachtzigtausendneunhundertachtundneunzig US-Dollar (984.998,--USD) wird dem

Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und

- ein Betrag von einhundertvierzehn Millionen sechshunderteinundachtzigtausendsechshundertsiebenundsechzig US-

Dollar (114.681.667,--USD) wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen.

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag ist weiterhin mit jedem Anteil verbunden, auf den sich die

jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

Der Nachweis der vollen Einzahlung dieser Bareinlagen wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.
Alle vorgenannten Einleger nehmen als Gesellschafter an der Versammlung teil und werden zusammen mit dem Al-

leingesellschafter als die Gesellschafter bezeichnet.

9758

L

U X E M B O U R G

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter (zur Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Parteien gehören, die durch

die vorgenannten Einlagen Gesellschafter der Gesellschaft geworden sind) beschließen, die Satzung wie folgt zu ändern
und neun zu fassen:

I. Firma – Gesellschaftssitz – Gesellschaftszweck – Dauer

Art. 1. Firma. Der Firma der Gesellschaft lautet „Joh. A. Benckiser s.à.r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft

kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt
werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Wenn der Geschäftsführungsrat feststellt, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die fraglichen Entwick-
lungen oder Ereignisse vollständig beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die
Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg
gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an inoder ausländischen Gesellschaften oder Unter-

nehmen jeder Art, sowie die Verwaltung und Verkauf solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien,
Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch
Zeichnung, Kauf, Verkauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben und veräußern, und im Allgemeinen alle Wert-
papiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines
jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung eines Pa-
tentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie

kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt, die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die
erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Techniken, Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen und

anderen Geschäfte effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz-und andere
Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt alle gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug

auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschafts-
zweck beziehen lässt oder diesen fördert.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft soll nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, In-

solvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital wird auf sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendeinhundertachtundneunzig US-

Dollar (6.327.198 USD) festgesetzt, repräsentiert durch sechs Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendeinhun-
dertachtundneunzig (6.327.198) Anteile in Form von Namensanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1 USD 1),

9759

L

U X E M B O U R G

unterteilt in mehrere Klassen wie folgt: fünf Millionen dreihundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.342.200) Stamm-
anteile  Klasse  A  (die  Stammanteile  Klasse  A),  einhundertdreiunddreißigtausenddreihundertdreiunddreißig  (133.333)
Stammanteile Klasse B1 (die Stammanteile Klasse B1), fünfzigtausend (50.000) Stammanteile Klasse B2 (die Stammanteile
Klasse B2), einhundertzwanzigtausend (120.000) Stammanteile Klasse BN (die Stammanteile Klasse BN), fünfzehntausend
(15.000) Stammanteile Klasse B3 (die Stammanteile Klasse B3; die Stammanteile Klasse B1, die Stammanteile Klasse B2,
die Stammanteile Klasse BN und die Stammanteile Klasse B3 werden zusammen als Stammanteile Klasse B bezeichnet;
die Stammanteile Klasse A und die Stammanteile Klasse B werden zusammen als die Stammanteile bezeichnet), einhun-
dertdreiunddreißigtausend  (133.333)  Sonderanteile  1  (Anteile  S1)  und  fünfhundertdreiunddreißigtausenddreihundert-
zweiunddreißig  (533.332)  Sonderanteile  2  (die  Anteile  S2;  die  Anteile  S1  und  die  Anteile  S2  werden  zusammen  als
Sonderanteile bezeichnet). Die mit den einzelnen Anteilskategorien verbundenen Rechte werden in dieser Satzung fest-
gelegt. Ein Anteil Klasse S1 und ein Anteil Klasse S2 gemeinsam haben vorbehaltlich der in Artikel 17.2, 18.1, 18.2, 20.3
und 20.4 aufgeführten Beschränkungen die Rechte eines einzigen Stammanteils.

5.2. Einlagen in das Agiokonto und das Kapitalreserve-Sonderkonto der Gesellschaft sind weiterhin mit jedem Anteil

verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, und bildet keinen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.

5.3. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-

stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.
6.3. Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.
6.4. Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen (inter vivos) an

Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Ge-
sellschaft vertreten müssen.

6.5. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten. Wird eine solche Zustimmung nicht erteilt,
werden die Anteile des verstorbenen Gesellschafters von der Gesellschaft zu einem Preis in Höhe des Nettoinventar-
wertes  der  Anteile  des  verstorbenen  Gesellschafters  am  Ende  des  Kalendervierteljahrs,  in  dem  die  Zustimmung
verweigert wurde, erworben.

6.6. Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel

1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.

6.7. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden

Gesellschafters eingesehen werden kann.

6.8. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt,:
(i) die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven; oder
(ii) falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals beruht.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern (gérants) verwaltet. Diese werden durch einen

Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine
Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen

werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat.  Wurden  mehrere  Personen  zum  Geschäftsführer  ernannt,  so  bilden  diese  den  Ge-

schäftsführungsrat (der Rat). Die Gesellschafter können beschließen, Geschäftsführer von zwei verschiedenen Klassen zu
ernennen, dass heißt einen oder mehrere Klasse A Geschäftsführer und einen oder mehrere Klasse B Geschäftsführer.

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung den Gesellschaftern vorbehalten

sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnisse zustehen, jegliche Handlungen und Tätigkeiten
auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Der Rat kann besondere oder eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere

Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch von zwei (2) Geschäftsführern findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung

genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

9760

L

U X E M B O U R G

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-

zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder

vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des

Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs-und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse  des Rates  sind wirksam,  wenn  sie von  der  Mehrheit  der Stimmen der  anwesenden  und vertretenen  Ge-
schäftsführer gefasst werden, vorausgesetzt dass, wenn die Gesellschafter einen oder mehrere Klasse A Geschäftsführer
und einen oder mehrere Klasse B Geschäftsführer ernannt haben, mindestens ein (1) Klasse A Geschäftsführer und ein
(1) Klasse B Geschäftsführer den Beschlüssen zugestimmt haben. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen
festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei
der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden, unter der Bedingung, dass die Nicht-
einhaltung dieser Vorschrift der Aufzeichnung die Gültigkeit des jeweiligen Beschlusses nicht berührt.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon-oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommuni-

kationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Schriftliche Beschlüsse der

Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abge-
haltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von

mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden. Wenn die Gesellschafter verschiedene Klassen von Geschäftsführern,
nämlich die Klasse A und die Klasse B Geschäftsführern, ernannt haben wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche
Unterschrift eines Klasse A Geschäftsführer und eines Klasse B Geschäftsführer gebunden sein.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichung der Personen gebunden welchen vom

Rat durch den Rat genehmigte Spezialvollmachten in Übereinklang mit den für Bevollmächtigungen anwendbaren Regeln
erteilt wurden.

Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer. Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, ist jede oben

genannte Bestimmung welche für den Geschäftsführungsrat gilt, auch auf den einzelnen Geschäftsführer sinngemäß an-
zuwenden.

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften auf Grund ihres Amtes nicht persönlich für Ver-

pflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft rechtsgültig eingegangen sind, sofern diese Verpflichtungen der Satzung
und dem Gesetz entsprechen. Die Geschäftsführer haften darüber hinaus nur für eine vorsätzliche Verletzung der mit
ihrer Amtsführung verbundenen Pflichten. Die Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit einem jeweils durch und zwi-
schen den Geschäftsführern und der Gesellschaft geschlossenen Freistellungsvertrag und unbeschadet sonstiger Freistel-
lungen, auf die die Geschäftsführer anderweitig Anspruch haben können, die Geschäftsführer mit voller Entschädigung
und im weitesten gesetzlich zulässigen Umfang von allen Verbindlichkeiten, Verlusten, Schäden, Strafen, Kosten, Aufwen-
dungen und Auslagen (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, angemessener und dokumentierter Barauslagen)
(die „Kosten“) freistellen, die den Geschäftsführern auf Grund, aus oder in Verbindung mit der tatsächlichen oder ange-
blichen  Ausübung  ihres  Amtes  als  Geschäftsführer  der  Gesellschaft  entstanden  sind  oder  die  sie  zu  tragen  hatten,
insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf solche Fälle, in denen diese Kosten (i) aus einem Anspruch, einer Klage, For-
derung, Ermittlung oder einem (zivilrechtlichen, strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen) Verfahren entstehen, das
gegen die Geschäftsführer geltend macht oder geführt oder ihnen angedroht wird, oder (ii) sich aus einer anwendbaren
luxemburgischen oder ausländischen Rechtsvorschrift oder Verordnung ergeben (einschließlich, ohne darauf beschränkt
zu sein, anwendbare Steuervorschriften oder -verordnungen). Eine Freistellung von einer Haftung gegenüber der Gesell-
schaft oder einer ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder ihren Gesellschaftern wird den Geschäfts-
führern bei vorsätzlicher Verletzung der mit ihrer Amtsführung verbundenen Pflichten oder bei Betrug nicht gewährt.
Die Geschäftsführer werden auch dann, wenn sie nicht mehr Geschäftsführer der Gesellschaft oder eines verbundenen
Unternehmens der Gesellschaft sind, weiterhin gemäß den Bestimmungen der Freistellungen in einer jeweils durch und
zwischen den Geschäftsführern und der Gesellschaft geschlossenen Freistellungsvereinbarung freigestellt. Aufwendungen
in Verbindung mit der Vorbereitung und Vertretung einer Abwehr gegen eine Klage, Forderung, Ermittlung oder ein
Verfahren der in diesem Artikel beschriebenen Art werden von der Gesellschaft vorgestreckt bis zur endgültigen Ver-
fügung  über  dieselbe,  gegen  Erhalt  einer  Verpflichtungserklärung  durch  oder  im  Namen  der  Geschäftsführer  zur

9761

L

U X E M B O U R G

Rückzahlung des betreffenden Betrages, falls und insoweit endgültig entschieden wird, dass sie keinen Anspruch auf Frei-
stellung gemäß diesem Artikel haben.

IV. Gesellschafter

Art. 11. Hauptversammlung und Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Sofern Beschlüsse in Übereinstimmung mit Artikel 11.1. (ii) getroffen werden, werden Beschlüsse der Gesellschafter

in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) gefasst.

(ii) Wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft nicht fünf und zwanzig (25) überschreitet, können Beschlüsse

der Gesellschafter in schriftlicher Form (die Schriftliche Beschlüsse) erlassen werden.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative des Rates, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen. Der Rat muss eine Haupt-

versammlung einberufen auf Antrag der Gesellschafter, welche mehr als ein zehntel (1/10) (d.h. 10%) des Gesellschafts-
kapitals vertreten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im

Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Wenn Beschlüsse schriftlich angenommen werden sollen, soll der Rat den Text dieser Beschlüsse an alle Gesell-

schafter  schicken.  Die  Gesellschafter  stimmen  schriftlich  ab  und  sollen  ihre  Stimme  der  Gesellschaft  innerhalb  der
Zeitachse, die durch den Rat festgelegt wurde, zurückkehren. Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, die Stimmen zu zählen.

(iv) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten

Zeit statt.

(v) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-

tretenen  Gesellschafter  erklären,  dass  ihnen  die  Tagesordnung  bekannt  ist  und  sie  sich  selbst  als  ordnungsgemäß
einberufen betrachten.

(vi) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss,

eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vii) Die in den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern

getroffen, welche mehr als die Hälfte (d.h. 50%) des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der
ersten Hauptversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung
geladen und die Beschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst,
unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(viii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(ix) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters

gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

(x) Schriftliche Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der oben genannten Beschlussfähigkeit und der Mehrheit

Anforderungen bestanden und tragen das Datum der letzten Unterschrift erhalten vor Ablauf der durch den Rat festge-
legten Zeitachse.

Art. 12. Alleingesellschafter. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird:
(i) übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden;
(ii) bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter

innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse; und

(iii) die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

Art. 13. Gesellschafterausschuss.
13.1. Die Gesellschafter können von Zeit zu Zeit mit einfacher Mehrheit einen Gesellschafterausschuss mit einer

Zusammensetzung bilden, die den Gesellschaftern zur Erleichterung des Informationsflusses zwischen der Gesellschaft
und den Gesellschaftern geeignet erscheint.

13.2. Der Gesellschafterausschuss behandelt ferner Angelegenheiten, mit denen er durch einen jeweils zwischen den

Gesellschaftern geschlossenen Gesellschaftervertrag betraut werden kann.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 14. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
14.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember jeden Jahres.
14.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn-und Verlustkonten der Gesellschaft gemeinsam mit einer

Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt mit einem Anhang welcher alle Verpflichtungen
der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der/des Geschäftsführer(s), von anderen Angehörigen des Geschäftsführungsteams

9762

L

U X E M B O U R G

der Gesellschaft und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst. Der Jahresabschluss wird in USD
erstellt werden.

14.3. Ein jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
14.4. Die Bilanz und die Gewinn-und Verlustkonten müssen in der folgenden Weise genehmigt werden:
(i) wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft nicht fünf und zwanzig (25) überschreitet, innerhalb von sechs

(6) Monaten nach dem Jahresabschluss des jeweiligen Geschäftsjahres entweder (a) bei der jährlichen Hauptversammlung
(soweit vorhanden) oder (b) durch Schriftliche Beschlüsse; oder

(ii) wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünf und zwanzig (25) übersteigt, auf der jährlichen Hauptver-

sammlung.

Art. 15. Wirtschaftsprüfer (auditeurs).
15.1. Sofern dies vom Gesetz vorgeschrieben ist, wird der Betrieb der Gesellschaft von einem oder mehreren externen

Wirtschaftsprüfer(n) (réviseur d’ entreprises) kontrolliert. Die Gesellschafter ernennen die zugelassenen externen Wirt-
schaftsprüfer, wenn überhaupt, und bestimmen ihre Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Amtes.

15.2. Wenn die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünf und zwanzig (25) übersteigt, wird die Geschäftstätigkeit

der Gesellschaft durch eine oder mehrere Abschlussprüfer (commissaires), überwacht werden, sofern das Gesetz nicht
die Ernennung eines oder mehrerer zugelassenen externen Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agrées) verlangt.
Die Abschlussprüfer können bei der jährlichen Hauptversammlung wieder ernannt werden. Sie können oder können nicht
Gesellschafter sein.

Art. 16. Gewinnausschüttung – Allgemeine Grundsätze.
16.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-

lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

16.2.  Die  Gesellschafter  bestimmen  die  Verteilung  des  Überschusses  des  jährlichen  Nettogewinns.  Sie  können,  in

Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vor-
nehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

16.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-

schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und auszuschüttenden Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten

ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und

(iv) unter Berücksichtigung der Vermögenswerte der Gesellschaft, dürfen die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft

durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet werden.

16.4. Im Laufe eines Kalenderjahres ausgegebenen Anteile haben nur zeitanteilig Anspruch auf Beteiligung an der Di-

videndenausschüttung im betreffenden Jahr, d.h. nur für den Teil des Jahres, in dem die Anteile in Umlauf waren.

16.5. Werden Anteile zu einem Preis ausgegeben, der unter dem Wert je Anteil zum Zeitpunkt der Ausgabe liegt,

jedoch  mit  einer  vertraglichen  Verpflichtung  des  Zeichners,  die Differenz zum  Wert  je Anteil in  das  Kapitalreserve-
Sonderkonto der Gesellschaft einzuzahlen, wird dies im Zusammenhang mit dem Dividendenanspruch so behandelt, als
wären auf der Grundlage des Wertes je Anteil zum Zeitpunkt der Ausgabe dieser Anteile nicht alle diese Anteile zum
betreffenden Zeitpunkt ausgegeben worden, sondern als seien diese Anteile erst im Laufe der Zeit ausgegeben worden,
jeweils im Verhältnis der Höhe der Zahlungen (Ausgabepreis und zusätzliche Einzahlung in die Kapitalreserve) zum Wert
je Anteil der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt der Ausgabe.

16.6. Im Sinne von Artikel 16 und 19 gelten die Ausgabe von Anteilen und die Einzahlung für Anteile dann, wenn sie

in der ersten Hälfte eines Kalendermonats vorgenommen wurden, als am Monatsanfang erfolgt und ansonsten gelten sie
als am Anfang des nächsten Monats erfolgt.

Art. 17. Sonderdividendenansprüche von Anteilen Klasse BN.
17.1. Die Anteile Klasse BN erhalten eine Vorzugsbeteiligung an Dividendenausschüttungen (PPI) zusätzlich zu ihren

Dividendenansprüchen, die denen der Stammanteile und der Sonderanteile entsprechen.

17.2. Die PPI gelten für Dividendenausschüttungen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ausgabe der Anteile Klasse

BN  erfolgen.  Diese  Vorzugsbeteiligung  berührt  nicht  den  Dividendenanspruch  von  Anteilen  anderer  Teilklassen  der
Stammanteile Klasse B, des normalen Dividendenanspruchs von Anteilen Klasse BN und/oder der Dividendenansprüche
von Anteilen Klasse S1 und Anteilen Klasse S2. Die PPI sind ausschließlich den Dividenden zu entnehmen, die andernfalls
an Stammanteile Klasse A auszuschütten wären. Sie gilt zusätzlich zu dem normalen Dividendenanspruch von Anteilen
Klasse BN.

9763

L

U X E M B O U R G

17.3. Die Vorzugsausschüttungen gemäß diesem Artikel 17 dürfen nicht höher sein als die Gesamtsumme aus lang-

fristigen Nettokapitalgewinnen und „qualifizierten Dividendenerträgen” im Sinne von Abschnitt 1(h)(11) des US Internal
Revenue Code von 1986 (in der jeweils gültigen Fassung) („QDI“), der von der Gesellschaft für die Zwecke der US-
Bundeseinkommensteuer nach dem 1. Januar 2012 anerkannt wurde (die „anwendbaren Gewinne“). Die nachstehenden
Ertragsposten werden als anwendbare Gewinne betrachtet:

(c) Erlös aus dem Verkauf von Anlagen mit einer langen Haltefrist im Sinne der US-Bundeseinkommensteuer, soweit

dieser den ursprünglichen Wert dieser Anlagen in den Geschäftsbüchern der Gesellschaft übersteigen;

(d) Von der Gesellschaft erhaltene QDI außer Dividenden, deren erwarteter Betrag im ursprünglichen Buchwert der

zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft enthalten war; von der Gesellschaft im Jahr 2012 erhaltene Dividenden für Zei-
träume vor dem 1. Januar 2012 gelten nicht als im ursprünglichen Buchwert der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft
enthalten, falls und insoweit:

(iii) der Marktwert der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft unmittelbar nach der Ausschüttung dieser Dividende

oder

(iv) der Betrag des höchsten Marktwerts der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaft in dem Zeitraum vom 1. Januar

2012 bis zum Datum der Ausschüttung und der Marktwert unmittelbar nach der Ausschüttung, abzüglich des Marktwerts
unmittelbar vor der Ausschüttung,

mindestens dem Wert entspricht, der (falls bei Umrechnung in US-Dollar zutreffend) die Grundlage des ursprünglichen

Buchwerts war. Für Zeiträume nach dem 31. Dezember 2011 erhaltene Dividenden gelten nicht als im ursprünglichen
Buchwert enthalten.

17.4. Der Erstbetrag der Vorzugsbeteiligung ist gleich 90 Millionen USD zuzüglich Zinsen in einer zu ermittelnden

Höhe; dieser Betrag von 90 Millionen USD zuzüglich Zinsen wie vorgenannt (der „aufgelaufene Vorzugsbetrag“) wird
weiter erhöht um alle Steuern, die vom Inhaber der Anteile Klasse BN auf die Ausschüttung und den Anspruch auf diese
Vorzugsbeteiligung zu zahlen sind (gleich ob Quellensteuern oder auf Grund von Veranlagungen in Luxemburg oder im
Domizilland des Inhabers der Anteile Klasse BN zu entrichtende Steuern, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein,
einer  Erhöhung  um  Steuern,  die  auf  diese  wegen  der  Ausschüttung  und  des  Anspruchs  auf  diese  Vorzugsbeteiligung
erhöhten Steuern zu zahlen sind), so dass der gemäß diesem Artikel zu zahlende Gesamtbetrag (die „gesamte Gewinn-
verteilung“) sich auf (i) den aufgelaufenen Vorzugsbetrag beläuft, dividiert durch (ii) eine als Dezimale angegebene Zahl in
Höhe von 100% abzüglich des anwendbaren Steuersatzes. Die anwendbaren Steuern und der effektive Steuersatz werden
gemeinsam von den Inhabern der Anteile Klasse BN und der Stammanteile Klasse A ermittelt. Sollte sich später heraus-
stellen, dass die Steuern höher sind, erhöhen sich die Rechte aus der Vorzugsbeteiligung in der Weise, dass sie auch diese
zusätzlichen Steuern (falls nach der Erhöhung zutreffend) abdecken, einschließlich Zinsen oder Bußgeldern, die von den
Finanzbehörden erhoben wurden und nicht auf Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers der Anteile Klasse BN
entfallen. Sind die Steuern niedriger, übergeben die Inhaber der Anteile Klasse BN den Überschussbetrag an die Inhaber
der Stammanteile Klasse A.

Art. 18. Dividendenansprüche von Anteilen Klasse S1 und Anteilen Klasse S2.
18.1. Jeder Anteil Klasse S1 und jeder Anteil Klasse S2 hat Anspruch auf 1/5 (ein Fünftel) der an einen Stammanteil

ausgeschütteten Dividende (außer der Vorzugsbeteiligung von Anteilen Klasse BN), vorausgesetzt, dass Anteile Klasse S1
nicht an dem Teil einer Dividende beteiligt sind, um den die Ausschüttungen in einem bestimmten Kalenderjahr insgesamt
0,7% des Nettoinventarwertes der Gesellschaft zu Anfang dieses Kalenderjahres übersteigen, und

18.2.  Anteile  Klasse  S2  sind  jeweils  mit  25%  der  Dividende  beteiligt,  die  auf  einen  Stammanteil  aus  dem  Teil  der

Dividendenausschüttung entfällt, an dem Anteile Klasse S1 gemäß Artikel 18.1 nicht beteiligt sind, jedoch vorbehaltlich
Artikel 19.2.

Art. 19. Regelmäßige Ausschüttungen.
19.1. Sofern nicht von den Gesellschaftern anders entschieden, nimmt die Gesellschaft jährliche Ausschüttungen von

0,7% des eigenen Nettoinventarwertes der Gesellschaft am Anfang des dann laufenden Jahres vor Diese Ausschüttungen
erfolgen zusätzlich zur Ausschüttung der Vorzugsbeteiligung. Soweit erforderlich, werden diese Ausschüttungen aus den
Reserven vorgenommen.

19.2. Wenn die Gesellschaft beschließt, in einem bestimmten Kalenderjahr eine Dividendenausschüttung von mehr als

0,7% des eigenen Nettoinventarwertes der Gesellschaft vorzunehmen, jedoch so, dass der Dividendenbetrag sich auf
nicht mehr als 0,7% des Nettoinventarwertes eines virtuellen Fundus (nach der jeweils geltenden Definition) am Anfang
des Jahres beläuft, wird der Betrag, um den diese Dividende die Höhe von 0,7% des Nettoinventarwertes des eigenen
Nettovermögens der Gesellschaft übersteigt, bis zur Höhe von 0,7% des Nettoinventarwertes dieses virtuellen Fundus
am Jahresanfang ausschließlich an die Inhaber der Stammanteile Klasse 1 der Gesellschaft ausgeschüttet.

19.3. Die erste allgemeine Dividendenausschüttung erfolgt im Oktober 2012 und wird anhand des eigenen Nettoin-

ventarwertes der Gesellschaft am 1. Januar 2012 bemessen; zu diesem Zweck werden die Einlagen für die in Artikel 5.1
genannten Anteile vor Juli 2012 als Teil des Nettovermögens der Gesellschaft per 1. Januar 2012 betrachtet.

19.4. Soweit ein Gesellschafter einer Verlagerung der Steuerlast für Gewinne der Gesellschaft oder ihrer Tochterge-

sellschaften  unterliegt,  die  ihm  von  den  zuständigen  Finanzbehörden  zugewiesen  werden,  und  diese  Zuweisungen  zu
versteuernden Einkommens für ein bestimmtes Jahr den Barbetrag übersteigt, der für dieses Jahr an diesen Gesellschafter

9764

L

U X E M B O U R G

ausgeschüttet worden war (in jedem Falle ohne Berücksichtigung von Gewinnverteilungen oder Ausschüttungen gemäß
der Vorzugsbeteiligung), hat dieser Gesellschafter Anspruch auf eine zusätzliche Ausschüttung (jeweils: eine „steuerbe-
zogene Ausschüttung“) in Höhe seiner auf diese überschüssige Zuweisung zu versteuernden Einkommens entfallenden
Steuerlast. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes der Gesellschaft (gleich ob in Verbindung mit der Ausgabe von
Anteilen oder in Verbindung mit der Rücknahme von Anteilen) und zur Ermittlung des zur Ausschüttung verfügbaren
Liquidationserlöses wird der Betrag dieser gesamten an Gesellschafter vorgenommenen steuerbezogenen Ausschüttun-
gen dem Nettoinventarwert der Gesellschaft so hinzugerechnet, als handele es sich um ein Darlehen an die Empfänger
dieser jeweiligen steuerbezogenen Ausschüttungen. Der Betrag dieser steuerbezogenen Ausschüttungen wird als An-
zahlung auf den Anteil des Empfängers am Liquidationserlös betrachtet und mindert daher den Betrag, den der Inhaber
der betreffenden Anteile bei der Liquidation erhält.

VI. Auflösung – Liquidation

20.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche min-

destens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder
mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung
und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesell-
schafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu
erfüllen.

20.2. Der Überschuss nach der Veräußerung der Vermögenswerte und der Erfüllung der Verbindlichkeiten wird (sofern

vorhanden) unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen jeweils gehaltenen Anteilen aufgeteilt, außer soweit
in den Artikeln 20.3 und 20.4 anders vorgesehen.

20.3. Anteile Klasse S1 sind am Liquidationserlös nur bis zu einem Ausschüttungsbetrag von 120% des Wertes je Anteil

zum  Zeitpunkt  ihrer  Ausgabe  dieses  Anteils  beteiligt  (der  der  volle  Ausgabepreis  für  Stammanteile  in  der  jeweiligen
Definition wäre, die zum gleichen Zeitpunkt ausgegeben werden) (der „Stammausgabepreis”), jeweils berichtigt gemäß
den Verwässerungsschutzbestimmungen in Options-oder ähnlichen Verträgen.

20.4. Anteile Klasse S2 sind an der Ausschüttung des Liquidationserlöses bis zur Höhe von 120% des Stammausgabe-

preises (gegebenenfalls berichtigt) nicht beteiligt, sind jedoch an der Ausschüttung des Liquidationserlöses in dem Umfang
beteiligt, in dem dieser 120% des Stammausgabepreises (gegebenenfalls berichtigt) übersteigt. Der Inhaber eines Anteils
Klasse S2 hat jedoch Anspruch auf diese Beteiligung am Liquidationserlös von mehr als 120% des Stammausgabepreises
(gegebenenfalls berichtigt) nur insoweit, als der Inhaber eine entsprechende Anzahl von Anteilen Klasse S1 besitzt, so
dass Rechte eines Anteils Klasse S2 in Bezug auf den Liquidationserlös nur in Verbindung mit der Ausübung der Rechte
aus einem vorhandenen Anteil Klasse S1, den der gleiche Inhaber besitzt, auf Beteiligung am Liquidationserlös bis zu 120%
des Stammausgabepreises ausgeübt werden kann.

VII. Allgemeine Bestimmungen

21.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Schriftliche

Beschlüsse der Geschäftsführer und Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telefax, E-Mail
oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

21.2. Vollmachten können auf eine der im vorstehenden Artikel 21.1 beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten

im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den
vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden

21.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-

den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Schriftliche
Beschlüsse der Geschäftsführer, Beschlüsse die in einer Telefon-oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise
Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen
desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

21.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden

Regelungen des Gesetzes und vorbehaltlich gesetzlicher Vorschriften, auf die nicht verzichtet werden kann, gemäß einer
jeweils von den Gesellschaftern getroffenen Vereinbarung entschieden.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt von Constantin Thun-Hohenstein und Elke Demuth-Steiner mit sofortiger

Wirkung von ihren jeweiligen Positionen als Geschäftsführer am 5. Januar 2012 zur Kenntnis. Jedem der Geschäftsführer
wurde vollständige Entlastung erteilt.

Die Gesellschafter nehmen zur Kenntnis, dass als Folge der obigen Rücktritte die Geschäftsführung der Gesellschaft

ab dem 5. Januar 2012 aus Markus Hopmann und Joachim Creus besteht.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen eine Änderung des Gesellschafterverzeichnisses der Gesellschaft zur Berücksichtigung

der vorstehenden Änderungen, wobei jedem Geschäftsführer der Gesellschaft die Befugnis und Vollmacht erteilt wird,
jeweils einzeln handelnd, (i) für und im Namen der Gesellschaft die neu ausgegebenen Anteile in das Gesellschafterver-

9765

L

U X E M B O U R G

zeichnis  der  Gesellschaft  einzutragen  und  (ii)  alle  Formalitäten  in  Verbindung  mit  der  Erhöhung  des  Stammkapitals
abzuschließen (zur Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Unterzeichnung der genannten
Verzeichnisse gehört), sowie den Rücktritt der Geschäftsführer der Gesellschaft.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Übertragung von einhundertzwanzigtausend (120.000) neuen Stammaktien Klasse

BN von Olivier Goudet auf Platin Investments S.à r.l. zu genehmigen, eine nach luxemburgischem Recht gegründete und
bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 13-15 avenue de la Liberté, L1931
Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.345.

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Verpfändung von einhundertzwanzigtausend (120.000) neuen Stammaktien Klasse

BN durch Platin Investments S.à r.l. gemäß einer Verpfändungsvereinbarung, die jeweils von Platin Investments S.à r.l.
geschlossen  werden  kann,  und  (ii)  von  einhundertdreiunddreißigtausenddreihundertdreiunddreißig  (133.333)  neuen
Stammanteilen Klasse B1 durch HFS S.à r.l. gemäß einer Verpfändungsvereinbarung, die jeweils von HFS S.à r.l. geschlossen
werden kann, sowie die Übertragung dieser Anteile nach Vollstreckung dieser Verpfändungen gemäß den anwendbaren
Bestimmungen zu genehmigen.

<i>Veranschlagung der kosten

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Abgaben gleich welcher Art, die von der Gesellschaft auf Grund der vor-

liegenden Urkunde zu tragen sind, werden auf ca. siebentausend Euros (7.000,--EUR) veranschlagt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der des Englischen aktiv und passiv mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde

auf Wunsch der erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Wunsch
der  gleichen  erschienenen  Partei  ist  bei  Widersprüchen  zwischen  dem  englischen  und  dem  deutschen  Wortlaut  die
englische Fassung maßgebend.

Urkundlich dessen wird die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem eingangs angegebenen Datum er-

richtet.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden war, unterzeichnete der

Bevollmächtigte der erschienenen Partei gemeinsam mit mir, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde.

Die Versammlung wurde um 15.00 Uhr geschlossen.
Signé: T. Lohest, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2012. Relation: LAC/2012/1665. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur

 (signé): I. Thill.

Référence de publication: 2012011072/1111.
(120012628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Linorca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 16.165.

Les comptes annuels au 30.06.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011175543/11.
(110203934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Linorca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 16.165.

Les comptes annuels au 30.06.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

9766

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011175544/11.
(110203935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Litrade International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 117.392.

Date  de  clôture  des  comptes  annuels  au  31/12/2010  a  été  déposée  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DERENBACH, le 21/12/2011.

FRL SA
Signature

Référence de publication: 2011175545/13.
(110204815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MexSpa Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 90.568.

Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Porma S.à r.l. / Lux Business Management S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011175566/13.
(110205003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MexSpa Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 90.569.

Le bilan de la société au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011175567/12.
(110203746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MexSpa Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 90.569.

Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011175568/12.
(110204985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

9767

L

U X E M B O U R G

Millennium European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.797.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 Décembre 2011.

Saphia Boudjani
<i>Gérant B

Référence de publication: 2011175569/12.
(110203737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Madidi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 81.330.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 12 décembre 2011

Le nouveau siège social de la société est fixé à L-1219 Luxembourg, 11 rue Beaumont.

Luxembourg, le 12.12.2011.

Pour extrait sincère et conforme
MADIDI S.A.
Robert REGGIORI
<i>Administrateur

Référence de publication: 2011175575/14.
(110204302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Machal II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 160.424.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175573/10.
(110204055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MosliB Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 158.592.

EXTRAIT

<i>Dépôt rectificatif du transfert de part déposé le 19 décembre 2011 avec le numéro L110201250

Il  résulte  d'un  contrat  de  transfert  de  parts  du  14  décembre  2011  que  la  société  Perth  Holdings  S.à  r.l.  (société

enregistrée à Luxembourg sous le numéro de Registre des Sociétés B 136505), ayant son siège social à 64 rue Principale,
L-5367 Schuttrange, Luxembourg, a cédé les 680,000 parts sociales qu'elle détenait dans MosliB Holdings S.à r.l. à la
société Celmus Investments Limited (société enregistrée à Chypre sous le numéro de Registre des Sociétés HE 194010),
ayant son siège social au 15 Agiou Pavlou, Ledra House, Agios Andreas, CY-1105 Nicosie, Chypre.

Suite à ce transfert, les parts sociales de la Société MosliB Holdings S.à r.l. sont reparties comme suit:
- Celmus Investments Limited détient 1,530,000 parts sociales
- Randal kin Holdings Ltd. détient 170,000 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

9768

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2011175571/21.
(110204867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Terold S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 85.394.

In the year two thousand and eleven,
on the sixth day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary

general meeting of the shareholders of "Terold S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its
registered office at 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, incorporated as a Netherlands Antilles company on August 28

th

 , 1989 which transferred its registered office and principal establishment to Luxembourg/Grand-Duchy of Luxembourg

pursuant to a deed of Me Réginald Neuman, notary, residing in Luxembourg on December 28 

th

 , 2001, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 619 of April 20 

th

 , 2002. The articles of

association of the Company have been amended several times and for the last time pursuant to a notarial deed of the
undersigned notary dated March, 25 

th

 2011, published in the Mémorial number 1416 of June, 29 

th

 2011.

The meeting was presided by Mrs Mathilde LATTARD, lawyer, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer of the meeting Mr Frederic CLASEN, lawyer, residing in Luxem-

bourg.

The chairman declared and requested the notary to state that the shareholders represented and the number of shares

held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and
the undersigned notary. The said attendance list will remain attached to these minutes to be filed with the registration
authorities. All shareholders confirm having had full knowledge of the agenda ahead of the meeting.

The Chairman stated that the agenda for the meeting was as follows:
As it appears from said attendance list, all the one million (1,000,000) shares in issue in the Company are represented

at the present general meeting so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all items of the agenda.

A. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of two million five hundred and one thousand

three hundred and ten United States Dollars (USD 2,501,310) so as to bring it from its current amount of thirty-five
million United States Dollars (USD 35,000,000) to thirty-seven million five hundred and one thousand three hundred and
ten United States Dollars (USD 37,501,310) by the issue of seventy-one thousand four hundred and sixty-six (71,466)
new shares each with a nominal value of thirty-five United States Dollars (USD 35) against a contribution in kind consisting
of one thousand (1,000) shares in Setersi, a company having its registered office at P.O Box 71, Craigmuir Chambers,
Tortola, British Virgin Islands and with registration number 3992 (“Setersi”) representing 100% of all shares in Setersi
(the “Contribution in Kind”);

- subscription to, and payment for, all the 71,466 new shares by Corporacion Financiera Guadalmar, Los Manantiales

SA, Isabel de Viel Castel, Stanislas Poniatowski and Global Titanium Inversiones SCA (together the “Contributing Sha-
reholders”)  in  proportion  to  their  respective  contribution  and  payment  of  the  subscription  price  by  way  of  the
Contribution in Kind;;

- acknowledgement and approval of the valuation of the Contribution in Kind;
- allocation of an amount of two million five hundred and one thousand three hundred and ten United States Dollars

(USD 2,501,310) to the share capital of the Company and of an amount of sixteen million two hundred ninety-eight
thousand six hundred and ninety United States Dollars (USD 16,298,690) to the share premium reserve of the Company.

B. Consequential amendment of Article 5 of the articles of association of the Company.
C. Appointment of Messr Serge de Ganay and Stanislas Poniatowski as additional managers of the Company for an

undetermined period.

After the foregoing was approved by the general meeting of shareholders, the following resolutions were adopted:

<i>First resolution

It was unanimously resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of two million five

hundred and one thousand three hundred and ten United States Dollars (USD 2,501,310) so as to bring it from its current
amount of thirty-five million United States Dollars (USD 35,000,000) to thirtyseven million five hundred and one thousand
three hundred and ten United States Dollars (USD 37,501,310) by the issue of seventy-one thousand four hundred and
sixty-six (71,466) new shares with a nominal value of thirty-five United States Dollars (USD 35) each (the “New Shares”)
against the Contribution in Kind.

9769

L

U X E M B O U R G

It was resolved to approve the subscription to, and payment for, all the seventyone thousand four hundred and sixty-

six (71,466) new shares by the Contributing Shareholders in proportion to their respective contribution and payment of
the subscription price by way of the Contribution in Kind. All existing shareholders of the Company have expressly
accepted the subscription to the New Shares in the Company by the persons referred to above.

It was resolved to acknowledge and approve the report of the board of managers dated 06 December 2011 (a copy

of which is annexed to the present deed to be registered therewith) the conclusion of which reads as follows:

“The board of managers is of the opinion that the value of Contribution in Kind, corresponds at least to the nominal

value of the New Terold Shares to be issued by the Company increased by the amount allocated to the share premium
account of the Company and that, accordingly, the Company may issue 71,466 New Terold Shares and allocate an amount
of USD 2,501,310 to the share capital of the Company and an amount of USD 16,298,690 to the share premium account
of the Company. Therefore it is proposed by the board of managers to the shareholders’ meeting to value the Contri-
bution in Kind at USD 18,800,000.”

It was resolved to acknowledge and approve the valuation of the Contribution in Kind to eighteen million eight hundred

thousand United States Dollars (USD 18,800,000) and to realise the subscription in the following proportions:

Name of the Contributing Shareholder

Net Value of

the assets

contributed

(in USD)

Number of

Setersi Sha-

res

contributed

Number of

NewTerold

Shares

subscribed

Capital

Subscription

(in USD)

Amount

allocated to

the share

premium

account

(in USD)

Corporacion Financiera Guadalmar . . . . .

2,350,000

125

8,933

312,655

2,037,345

Los Manantiales SA . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,400,000

500

35,733

1,250,655

8,149,345

Isabel de Viel Castel . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,175,000

62.5

4,467

156,345

1,018,655

Stanislas Poniatowski . . . . . . . . . . . . . . . .

1,175,000

62.5

4,467

156,345

1,018,655

Global Titanium Inversiones SCA . . . . . .

4,700,000

250

17,866

625,310

4,074,690

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,800,000

1,000

71,466

2,501,310

16,298,690

Thereupon, the New Shares have been subscribed by the Contributing Shareholders represented by Mrs Mathilde

LATTARD,  prenamed,  pursuant  to  proxies  given  to  her  (copies  of  which  shall  remain  with  the  present  deed  to  be
registered therewith).

It was resolved that an amount of two million five hundred and one thousand three hundred and ten (USD 2,501,310)

paid thereon was allocated to the share capital of the Company and an amount of sixteen million two hundred ninety-
eight thousand six hundred and ninety (USD 16,298,690) paid thereon was allocated to the share premium reserve of
the Company.

Proof of the existence and the transfer of the Contribution in Kind to the Company and consequently payment of the

subscription price to the Company by the Contributing Shareholders was shown to the undersigned notary.

All the above resolutions were approved unanimously.

<i>Second resolution

As a consequence to the first resolution, it was unanimously resolved to amend article 5 of the articles of association

of the Company so as to read as follows:

“The issued share capital of the Company is set at thirty-seven million fivehundred and one thousand three hundred

and ten United States Dollars (USD 37,501,310) divided into one million and seventy-one thousand four hundred and
sixty-six (1,071,466) ordinary shares each with a nominal value of thirty-five United States Dollars (USD 35). The share
capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of association”

<i>Third resolution

It was unanimously decided to appoint the following persons as additional managers of the Company with effect as

from the date hereof and for an undetermined period:

- Mr Stanislas Poniatowski, born on May 21 

st

 , 1952 in Boulogne-Billancourt, France, financial adviser and company

director, with professional address at 243, Boulevard Saint Germain F-75007 Paris, France.

- Mr Serge de Ganay, born on November 9 

th

 , 1949, in Rouen, France, company director, with professional address

at 243, Boulevard Saint Germain F-75007 Paris, France.

There being no further items on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at five thousand five hundred euro.

9770

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading the present deed the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille onze,
le sixième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg, s’est tenue une

assemblée générale extraordinaire des associés de «Terold S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 84, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, constituée le 28 août 1989 selon le droit des Antilles
néerlandaises et ayant transféré son siège social et principal établissement à Luxembourg (Grand-Duché) en date du 28
décembre 2001 suivant acte reçu de Me Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 619 du 20 avril 2002. Les statuts de la Société ont été
modifiés à plusieurs reprises et ce pour la dernière fois en date du 25 mars 2011 en vertu d’un acte notarié publié au
Mémorial numéro 1416 du 29 juin 2011.

L’assemblée était présidée par Madame Mathilde LATTARD, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Frederic CLASEN, avocat, demeurant à Luxembourg a été désigné en tant que secrétaire et scrutateur de

l’assemblée.

Le président a déclaré et prié le notaire d’acter que les associés représentés et le nombre de parts sociales soient

indiqués sur la liste de présence signée par le fondé de pouvoir, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire
soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent procès-verbal afin d’être soumis ensemble aux formalités
d’enregistrement. Tous les associés confirment avoir été pleinement informés de l’ordre du jour avant l’assemblée.

Le président a déclaré que l’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
Il ressort de ladite liste de présence que l’intégralité des un million (1.000.000) de parts sociales émises dans la Société

sont représentées à la présente assemblée générale, de sorte que l’assemblée est dûment constituée et peut valablement
prendre des décisions sur tous les points figurants à l’ordre du jour.

A. Augmentation du capital de la Société par l’émission d’un montant de deux millions cinq cent un mille trois cent

Dollars  Américains  (2.501.310  USD)  de  sorte  à  le  porter  de  son  montant  actuel  de  trente-cinq  millions  de  Dollars
Américains (35.000.000 USD) à trente-sept millions cinq cent un trois cent dix Dollars Américains (37.501.310 USD) par
l’émission de soixante-et-onze mille quatre cent soixante-six (71.466) nouvelles parts sociales ayant chacune une valeur
nominale de trente-cinq Dollars Américains (35 USD) en contrepartie d’un apport en nature composé de mille (1.000)
parts sociales dans Setersi, une société ayant son siège social aux Îles Vierges britanniques, boîte postale 71, Craigmuir
Chambers, Tortola, immatriculée sous le numéro 3992 («Setersi»), représentant 100% de l’intégralité des parts sociales
dans Setersi;

- souscription à et paiement de l’intégralité des 71.466 nouvelles parts sociales par Corporacion Financiera Guadalmar,

Los Manantiales S.A., Isabel de Viel Castel, Stanislas Poniatowski et Global Titanium Inversiones SCA (les «Associés
Contributeurs») proportionnellement à leur apport et paiement respectifs du prix de souscription par le biais d’un apport
en nature;

- reconnaissance de la valorisation de l’apport en nature;
- allocation d’un montant de deux millions cinq cent mille trois cent dix Dollars Américains (2.501.310 USD) au capital

social de la Société et d’un montant de seize millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix Dollars
Américains (16.298.690 USD) à la réserve de la prime d’émission.

B. Par conséquent, modification de l’article 5 des statuts de la Société.
C. Election de Messieurs Serge de Ganay et Stanislas Poniatowski en tant qu’administrateurs supplémentaires de la

Société pour une durée indéterminée.

Après approbation de ce qui précède par l’assemblée générale des associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il a été décidé à l’unanimité d’augmenter le capital social émis de la Société d’un montant de deux millions cinq cent

un mille trois cent dix Dollars Américains (2.501.310 USD), de sorte à le porter de son montant actuel de trente-cinq
millions de Dollars Américains (35.000.000 USD) à trente-sept millions cinq cent un mille trois cent dix Dollars Américains
(37.501.310 USD) par l’émission de soixante et onze mille quatre cent soixante-six (71.466) nouvelles parts sociales ayant
chacune une valeur nominale de trente-cinq Dollars Américains (35 USD) (les «Nouvelles Parts Sociales») en contrepartie
d’un apport en nature valorisé à hauteur du prix total de souscription s’élevant à dix-huit millions huit cent mille Dollars
Américains (18.800.000 USD);

Il a été décidé d’approuver la souscription à et le paiement de l’intégralité des soixante et onze mille quatre cent

soixante-six (71.466) nouvelles parts sociales par les Associés Contributeurs proportionnellement à leur apport et paie-

9771

L

U X E M B O U R G

ment respectifs du prix de souscription par le biais d’un apport en nature composé de 1.000 parts sociales dans Setersi,
représentant 100% de l’intégralité des parts sociales dans Setersi, soit une valeur totale de dix-huit millions huit cent mille
Dollars Américains (18.800.000 USD) (l’«Apport en Nature»). ‘Tous les associés actuels de la Société acceptent expres-
sément la souscription aux soixante et onze mille quatre cent soixante-six (71.466) nouvelles parts sociales dans la Société
par les personnes auxquelles il est fait référence ci-dessus.

Il a été décidé de reconnaitre et d’approuver le rapport du conseil d’administration daté du 06 décembre 2011 (une

copie duquel est annexée au présent acte afin d’être soumise ensemble avec lui), dont la conclusion a la teneur suivante:

«Le conseil d’administration est de l’avis que la valeur de l’Apport en Nature décrit ci-dessus correspond au moins à

la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales Terold à émettre par la Société, augmentée par le montant alloué au
compte de la prime d’émission de la Société et, par conséquent, la Société peut émettre 71.466 Nouvelles Parts Sociales
Terold et allouer un montant de 2.501.310 USD au capital social de la Société ainsi qu’un montant de 16.298.690 USD
au compte de la prime d’émission de la Société. Il a donc été proposé par le conseil d’administration de l’assemblée des
associés de valoriser l’Apport en Nature à 18.800.000 USD.»

Il est décidé de reconnaitre et d’approuver la valorisation de l’Apport en Nature à hauteur de dix-huit millions huit

cent mille Dollars Américains (USD 18.800.000) et d’effectuer la souscription de sorte qu’elle ait les proportions suivant

Nom de l’associé contributeur

Valeur

nette des

actifs de

l’apport

(en USD)

Nombre

de parts

sociales

Setersi

apporté

Nombre de

nouvelles

parts

sociales

Terold

souscrites

Souscription

de capital
(en USD)

Montant

alloué au

compte de la

prime

d’émission

(en USD)

Corporacion Financiera Guadalmar . . . . . . . .

2.350.000

125

8.933

312.655

2.037.345

Los Manantiales SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.400.000

500

35.733

1.250.655

8.149.345

Isabel de Viel Castel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.175.000

62,5

4.467

156.345

1.018.655

Stanislas Poniatowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.175.000

62,5

4.467

156.345

1.018.655

Global Titanium Inversiones SCA . . . . . . . . .

4.700.000

250

17.866

625.310

4.074.690

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.800.000

1.000

71.466

2.501.310

16.298.690

Sur ce, les Nouvelles Parts Sociales ont été souscrites par les Associés Contributeurs représentés par Madame Mathilde

LATTARD, prénommée, en vertu de procurations lui données (des copies de celles-ci devront rester avec le présent
acte afin d’être enregistré avec lui).

Il a été décidé qu’un montant payé de deux millions cinq cent un mille trois cent dix Dollars Américains (2.501.310

USD) a été alloué au capital social de la Société et un montant payé de seize millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille
six cent quatre-vingt-dix Dollars Américains (16,298,690 USD) a été alloué à la réserve de la prime d’émission de la
Société.

Une preuve témoignant du transfert de l’apport en nature et, par conséquent, du paiement du prix de souscription à

la Société par les Associés Contributeurs, a été montrée au notaire soussigné.

L’ensemble des résolutions qui précèdent ont été approuvées à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, il a été décidé à l’unanimité de modifier l’article 5 des statuts de la Société,

de sorte qu’il ait la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à trente-sept millions cinq cent un mille trois cent dix Dollars Américains

(37.501.310 USD) divisé en un million soixante-et-onze mille quatre cent soixante-six (1.071.466) parts sociales ordinaires
ayant chacune une valeur nominale de trente-cinq Dollars Américains (35 USD). Le capital social de la Société peut être
augmenté ou réduit par le biais d’une résolution des associés adoptée de la manière prévue pour la modification de ces
statuts»

<i>Troisième résolution

Il a été décidé à l’unanimité de nommer les personnes suivantes en qualité d’administrateurs supplémentaires de la

Société, avec prise d’effet à la date du présent document et pour une durée indéterminée:

- M. Stanislas Poniatowski, né le 21 mai 1952 à Boulogne-Billancourt, France, conseiller financier et directeur de société,

demeurant professionnellement au 243, Boulevard Saint Germain F-75007, Paris, France.

- M. Serge de Ganay, né le 9 novembre 1949 à Rouen, France, directeur de société, demeurant professionnellement

au 243, Boulevard Saint Germain F-75007, Paris, France.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société sont évalués

à cinq mille cinq cents euros.

9772

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu’à la requête des parties comparantes,

le présent acte a été rédigé en langue anglaise et est suivi d’une traduction en langue française. A la requête des mêmes
parties comparantes, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre la version anglaise et la version française.

Fait à Luxembourg à la même date qu’en tête des présentes.
Après lecture du présent acte, le fondé de pouvoir a signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: M. LATTARD, F. CLASEN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16661. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011172704/231.
(110200550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Madidi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 81.330.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MADIDI S.A.
Angelo DE BERNARDI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011175576/12.
(110204883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Magfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 125.705.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAGFINS.A.
Régis DONATI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011175579/12.
(110204879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Maisons du Monde Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 144.360.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MARIE Xavier
<i>Gérant

Référence de publication: 2011175580/11.
(110203725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Malafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.092.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175581/9.
(110203789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

9773

L

U X E M B O U R G

Mangon Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 106.225.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MANGON INVESTMENTS S.A.
En liquidation

Référence de publication: 2011175582/11.
(110204632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Mangon Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 106.225.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 9 décembre 2011

L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société MANGON INVESTISSEMENT S.A. (en liquidation) qui

cessera d’exister.

L’Assemblée décide que les documents sociaux seront conservés, au minimum pendant 5 années, au siège social de

HRT FIDALUX S.A., actuellement situé au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 21 décembre 2012.

Référence de publication: 2011175583/15.
(110205069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Marrow Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbusch.

R.C.S. Luxembourg B 89.872.

EXTRAIT

Le siège social du commissaire aux comptes, à savoir ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, est désormais situé au:
- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

<i>Pour MARROW ASSET MANAGEMENT S.A.
Société anonyme

Référence de publication: 2011175584/13.
(110203684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Temeraire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.402.

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth of November.
Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the un-

dersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the partners (the “Meeting”) of "Temeraire S.à r.l." (the “Company”), a

“Société à responsabilité limitée”, established at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section
B number 127.402, incorporated by deed of Maitre Henri HELLINCKX, notary, on March 27, 2007, published in the
Luxembourg Memorial C number 1256 on June 25, 2007.

The Meeting is presided by Mrs Sara Lecomte, private employee, professionally residing at 15, Côte d'Eich, L-1450

Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mrs Flora Gibert, private employee, pro-

fessionally residing at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

9774

L

U X E M B O U R G

The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the partners present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an

attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be registered with these minutes.

II.- As appears from the attendance list, 500 shares out of the 500 shares, representing 100% of the capital of the

company (with an amount of EUR 12.500,-) are present or duly represented so that the Meeting can validly decide on all
the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of Liam Finance S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company with registered office at 43,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg registered with the Trade and Companies Registry_Luxembourg under number
B 124814 as liquidator (the “Liquidator”);

3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
5. Miscellaneous.
IV. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liqui-

dation).

<i>Second resolution

The Meeting resolves to appoint Liam Finance S.à r.l., prenamed, as liquidator (The “Liquidator”).

<i>Third resolution

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 and seq. of the amended Lu-

xembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including

those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the shareholders/
partners. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks,
to one or several persons or entities.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator, acting individually under its sole signature on

behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required
for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance pay-

ments of the liquidation proceeds to the shareholders/partners of the Company, in accordance with article 148 of the
Law.

<i>Fourth resolution

The  Meeting  decides  to  grant  full  and  total  discharge  to  the  board  of  managers  for  the  accomplishment  of  their

respective mandates until today.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le trente novembre
Par-devant Maître Joseph ELVINGER , notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés (l'“Assemblée”) de la société à responsabilité limitée "Te-

meraire S.à r.l." (la “Société”), ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le N° 127.402, constituée suivant acte reçu par le notaire
Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mars 2007, publié au Mémorial C N° 1256
du 25 juin 2007.

9775

L

U X E M B O U R G

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement

15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert, employée

privée, demeurant professionnellement 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires/associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregis-
trement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que 500 actions des 500 actions de la société, représentant 100 % du capital

social (d'un montant de EUR 12,500), sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Liam Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège

au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés_Lu-
xembourg sous le numéro B 124814 en tant que liquidateur (le “Liquidateur”);

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs; et
5. Divers.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volon-

taire).

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer Liam Finance S.à r.l., précitée, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août

1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la “Loi”).

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en

ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des action-
naires/associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou
tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature

au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation
de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances

sur le solde de liquidation aux actionnaires/associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à

ce jour. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute. Le notaire soussigné

qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi
d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: S. LECOMTE, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53537. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

9776

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 9 décembre 2011.

Référence de publication: 2011172692/125.
(110200855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Martis Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 52.160.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21.12.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011175585/10.
(110204908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Martis Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 52.160.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21.12.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011175586/10.
(110204911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Mère Nature S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 55, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 20.198.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011175592/14.
(110205079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Martis Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 52.160.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21.12.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011175587/10.
(110204913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Marussia Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 146.816.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011175588/10.
(110204964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

9777

L

U X E M B O U R G

MCI Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 43.892.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175589/9.
(110205048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Medici s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 100.664.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21.12.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011175590/10.
(110204914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MIP II Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 20.000,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 138.244.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de 17 December 2011

L'Associé Unique décide d'accepter la démission do Monsieur Mark Wong et de nommer Madame Stéphanie Pautot-

Martinache, 37, rue du Saint-Esprit. L-1475 Luxembourg, comme gérant A de la société pour une période indéterminée.

Pour copie conforme
C. ROEMERS / S. PAUTOT-MARTINACHE
<i>Gérant A / Gérant A

Référence de publication: 2011175603/14.
(110204304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

30 Lopes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 6, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 165.324.

STATUTS

L'an deux mil onze, le huit décembre.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Madame Regina Paula TRINTA LOPES, salariée, née le 12 juillet 1976 à Alvite/Moimenta da Beira (Portugal), de-

meurant à L-8081 Bertrange, 51, Rue de Mamer

2) Monsieur Hélder Carlos PEREIRA LOPES, salarié, né le 4 octobre 1974 à Alvite/Moimenta da Beira (Portugal),

demeurant à L-8081 Bertrange, 51, Rue de Mamer

lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.

Art. 1 

 

  

er

  

 

 . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'établissement de restauration.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles

et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement et
au développement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de «30 LOPES S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

9778

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Pétange.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,00) représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés. L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des
gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil onze

<i>Souscription et Libération

Les cent parts sociales sont souscrites comme suit:

1) Madame Regina Paula TRINTA LOPES, salariée, née le 12 juillet 1976 à Alvite/Moimenta
da Beira (Portugal), demeurant à L-8081 Bertrange, 51, Rue de Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
2) Monsieur Hélder Carlos PEREIRA LOPES, salarié, né le 4 octobre 1974 à Alvite/Moimenta
da Beira (Portugal), demeurant à L-8081 Bertrange, 51, Rue de Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,00.-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent expressément.

9779

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s)/actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par

la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille cinq cent euros (1.500.-euros).
A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paiement
des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du

capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et,
après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Hélder Carlos PEREIRA LOPES, salarié, né le 4 octobre 1974 à Alvite/Moimenta da Beira (Portugal), de-

meurant à L-8081 Bertrange, 51, Rue de Mamer

La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du

gérant.

3. L'adresse de la société est fixée à L-4760 Pétange, 6, Route de Luxembourg

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale

peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société pré-
sentement constituée.

Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: TRINTA LOPES, PEREIRA LOPES, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 9 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16747. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Pétange, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011172737/111.
(110200656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Metalltechnik Aktiengesellschaft, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 127.518.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 6 décembre 2011:

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Rémy MENEGUZ, Administrateur;
L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'Administrateur, Monsieur Roland DE CILLIA, Expert-Comptable, de-

meurant professionnellement au 45-47, route d’Arlon, L- 1140 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur
jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice de l’année 2012;

L’Assemblée prend acte de l’adresse professionnelle de Monsieur Giovanni VITTORE, Administrateur, né le 29.05.1955

à Turi (Italie), au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;

L’Assemblée décide de nommer à la fonction de Commissaire, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT

S.à.r.l., inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg n° B 33849, établie au 45-47 route d’Arlon, L-1140 Luxembourg,
en remplacement de la Fiduciaire Mevea S.à.r.l., qui terminera le mandat de son prédécesseur jusqu’à l’Assemblée Générale
statuant sur l’exercice de l’année 2012;

9780

L

U X E M B O U R G

L’Assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 4, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,

au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

METALLTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT

Référence de publication: 2011175594/22.
(110204780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Medici s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 100.664.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21.12.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011175591/10.
(110204917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Metallic S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 2A, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 99.036.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 Décembre 2011.

Référence de publication: 2011175593/10.
(110204771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MGix, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 138.454.

<i>Extrait de cessions de parts sociales

Il résulte d'une convention de cession de parts sous seing privé du 30 avril 2011 entre M. Thierry Guy Marie MERGAUX,

né le 2 mai 1969 à Arlon, Belgique, demeurant à L-8410 Steinfort, 55, Route d'Arlon et Mme Nathalie MERGAUX, née
le 24 août 1972 à Arlon, Belgique et domiciliée à B-6720 HABAY-LA-NEUVE, 39 Rue du Neufchateau.

Depuis le 01/05/2011, les associés de la société MGIX SARL sont composés comme suit:

- M.Thierry Guy Marie MERGAUX né le 2 mai 1969 à Arlon Belgique domicilié à
55 Route d'Arlon, L-8410 STEINFORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts sociales
- Mme Nathalie MERGAUX née le 24 août 1972 à Arlon, Belgique domiciliée à
39 Rue du Neufchateau, B-6720 HABAY-LA-NEUVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts sociales
- M. Robert Joseph GOFFIN né le 1 

er

 février 1951 à Bras-Haut, Belgique

29, rue de la Faloise, B-6840 NEUFCHATEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

(100 parts sociales d'une valeur nominale de 125,-€ chacune soit un capital de 12.500,- €.)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175597/21.
(110204472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Metalltechnik Aktiengesellschaft, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 127.518.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

9781

L

U X E M B O U R G

METALLTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT

Référence de publication: 2011175595/10.
(110205053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MGix, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 138.454.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011175596/10.
(110204467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MGB International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2322 Luxembourg, 18, rue Henri Pensis.

R.C.S. Luxembourg B 47.822.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Auszug

Es erhellt aus einer Urkunde von Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 7. Dezember

2011, einregistriert in Luxemburg A.C., am 12. Dezember 2011, LAC/2011/55205, dass der alleinige Gesellschafter der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MGB INTERNATIONAL S.à r.l.", in Liquidation, mit Sitz in L-2322 Luxemburg,
18, rue Henri Pensis, die gegründet wurde gemäss notarieller Urkunde vom 20. Mai 1994, veröffentlicht im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 382 von 1994. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des
unterzeichneten Notars vom 9. Juni 2005, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
1229 vom 18. November 2005.

Die Gesellschaft wurde in Liquidation gesetzt gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 5. Dezember 2011.
Die Bücher der Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren ab den 7. Dezember 2011, am Gesell-

schaftssitz der aufgelösten Gesellschaft in L-2322 Luxemburg, 18, rue Henri Pensis, hinterlegt bleiben.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. Dezember 2011.

Référence de publication: 2011175598/21.
(110204549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MH Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 133.323.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2011175600/10.
(110205173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Morsa Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.890.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MORSA CAPITAL S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011175607/11.
(110204537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

9782

L

U X E M B O U R G

Tate &amp; Lyle European Finance, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 97.343.

DISSOLUTION

In the year two thousand eleven, on the fifth of December.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr. Enzo LIOTINO, director, with professional address at Luxembourg,
acting as a special proxy holder of:
the company “Tate &amp; Lyle PLC.”, established and having its registered office AT Sugar Quay Lower Thames Street,

EC3R 6DQ London,

here after referred to as "the principal",
by virtue of a proxy given on October 25, 2011, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing

proxy holder and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The same proxy holder declared and requested the notary to act:
I.- That the company “Tate &amp; Lyle European Finance, S.à r.l.“, a “société à responsabilité limitée”, established and having

its registered office at 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered in the “Registre de Commerce et des
Sociétés” in Luxembourg, section B number 97343, has been incorporated under Luxembourg Law, pursuant to a notarial
deed on 28 October 2003, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 6 of 3 January 2004. The articles of
incorporation have been amended pursuant to a notarial deed on 30 July 2004, published in the Mémorial, Recueil Spécial
C number 1089 of 28 October 2004.

The Articles of Association of said company have not been amended since.
II.- That the subscribed capital of the company is fixed at five million twelve thousand five hundred euro (5,012,500.-

EUR) represented by two hundred thousand five hundred (200,500) shares with a par value of twenty-five euro (25.-
EUR) each, fully paid up.

III.- That the principal is the sole owner of all the shares of said company.
IV.- That the principal, being sole partner of the Company has decided to proceed to the dissolution of said company.
V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the

Company.

VI.- That the principal, in its activity as liquidator of the company, declares that the business activity of the company

has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved company
committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company as well as to be personally
charged with any presently unknown liability.

VII.- That the principal fully grants discharge to the current manager of the dissolved company, for the due performance

of his duty up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at its former registered

office.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the proxy holder of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
proxy holder and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read to the proxy holder of the appearing person, known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, said person signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Enzo LIOTINO, directeur, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:
la société “Tate &amp; Lyle PLC.”, ayant son siège social Sugar Quay Lower Thames Street, EC3R 6DQ Londres,
ci-après dénommé: «le mandant»,
en vertu d'une procuration lui donnée le 25 octobre 2011,

9783

L

U X E M B O U R G

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:
I.- Que la société «Tate &amp; Lyle European Finance, S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son

siège social au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 97343, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte notarié en date du
28 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 6 du 3 janvier 2004. Les statuts de la société ont été modifiés suivant
acte notarié en date du 30 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 1089 du 28 octobre 2004.

II.- Que le capital social souscrit de la société est fixé à CINQ MILLIONS DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS

(5'012'500.-EUR) représenté par deux cent mille cinq cents (200'500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-
CINQ EUROS (25.-EUR) chacune, chaque part sociale étant intégralement libérée.

III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de ladite société.
IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la Société a décidé de procéder à la dissolution de ladite société.
V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
VI.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la société, déclare que l'activité de la société a cessé, que lui, en tant

qu'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle
obligation inconnue à l'heure actuelle.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant actuel de la société dissoute, pour l'exécution de son

mandat jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire du

comparant le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en
cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: E. LIOTINO, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 8 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16539. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011172691/87.
(110200835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

MTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 154.124.

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2011, toutes les résolutions suivantes ont été

prises à l’unanimité:

<i>Résolution 1

- Est acceptée avec effet immédiat la démission de la société «MYSAMA Sàrl» avec siège sociale 2, rue Pletzer - L-8080

Bertrange - RC Luxembourg B147046 en tant que administrateur.

- Est acceptée avec effet immédiat la démission de monsieur Alain, Thomas, Vincent Cheurlin demeurant 22, Grand-

Rue, F-10110 Celles-sur-Ource en tant que administrateur.

<i>Résolution 2

- Est acceptée avec effet immédiat la démission de Co-Invest Holding SA, une société constituée et existant sous les

lois de la République du Panama, établie et ayant son siège social Plaza 2000, 10 

th

 Floor, 50 

th

 Street, Panama-City

(République du Panama en tant que Commissaire aux comptes.

- Est décidée avec effet immédiat la nomination de Fiduciary &amp; Accounting Services S.A., une société constituée et

existante sous les lois des Îles Vierges Britanniques établie et ayant son siège social Lake Building, 2 

nd

 Floor, P.O. Box

3161, Road Town, Tortola en tant que commissaire aux Comptes reprenant le mandat en cours jusqu’à l’Assemblée
Générale en 2015.

9784

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 31 octobre 2011.

<i>Pour MTEL SA

Référence de publication: 2011175609/25.
(110204089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Mon Jardin - Gardencenter Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.

R.C.S. Luxembourg B 45.012.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175605/9.
(110203927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Mon Jardin - Nouvelles Créations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3853 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.

R.C.S. Luxembourg B 64.438.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175606/9.
(110203920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Minny S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9972 Lieler, 4, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 100.564.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011175601/10.
(110204604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MIP II Gateway Investment S.à rl., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 138.246.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011175602/10.
(110204332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

New CV Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.396.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2011175613/14.
(110204355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

9785

L

U X E M B O U R G

MIP II Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 138.244.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011175604/10.
(110204331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MPL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 149.390.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011175608/10.
(110204471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

MWH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.538.550,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 118.278.

En date du 31 juillet 2006, les transferts de parts suivants ont eu lieu:
- l'associé Palamon European Equity, L.P., avec siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ London, Royaume Uni, a

transféré 42 parts à l'associé Palamon European Equity "B", L.P., avec siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ London,
Royaume Uni, qui les acquiert.

- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 74 parts à l'associé Palamon European Equity "C", L.P.,

avec siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ London, Royaume Uni, qui les acquiert.

- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 6 parts à l'associé Palamon European Equity "D", L.P.,

avec siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ London, Royaume Uni, qui les acquiert.

- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 39 parts à l'associé Palamon European Equity GmbH &amp;

Co Beteiligungs KG, avec siège social au 27, Pienzenauerstrasse, 81679, Munich, Allemagne, qui les acquiert.

- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 28 parts à l'associé Morgan Stanley Private Markets Fund

1 LP, avec siège social au 100, Front Street, 19428-2881 West Conshohocken, Etats Unis, qui les acquiert.

- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 71 parts à l'associé Weyerhaeuser Company Master

Retirement Trust, avec siège social au 33663, Weyerhaeuser Way, 98003 Seattle, Etats Unis, qui les acquiert.

- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 16 parts à l'associé Aurora Cayman Limited, avec siège

social à Ugland House, Grand Caïman, Iles Caïmans, qui les acquiert.

- l'associé Palamon European Equity, L.P., précité, a transféré 35 parts à l'associé Morgan Stanley AIP Global Diversified

Fund LP, avec siège social au 100, Front Street, 19428-2881 West Conshohocken, Etats Unis, qui les acquiert.

En conséquence, les associés sont les suivants:
- Palamon European Equity "B", L.P., précité, avec 15 047 parts
- Palamon European Equity "C", L.P., précité, avec 26 680 parts
- Palamon European Equity "D", L.P., précité, avec 1 984 parts
- Palamon European Equity GmbH &amp; Co Beteiligungs KG, précité, avec 14 429 parts
- Morgan Stanley Private Markets Fund 1 LP, précité, avec 10 068 parts
- Weyerhaeuser Company Master Retirement Trust, précité, avec 25 891 parts
- Aurora Cayman Limited, précité, avec 5 756 parts
- Morgan Stanley AIP Global Diversified Fund LP, précité, avec 12 943 parts
- Palamon European Equity, L.P., précité, avec 68 744 parts

9786

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175611/38.
(110203813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Vélizy Rose Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 157.048.

In the year two thousand and eleven, on the fifteenth of November.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER,

notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depositary of the present deed.

There appeared:

DEWNOS INVESTMENTS S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, having its

registered office in L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 116.983, here represented by its Manager Mr. Eric GILSON, private employee, with professional
address at 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

The appearing party is the sole shareholder of Vélizy Rose Investment S.à r.l.,a société à responsabilité limitée incor-

porated under the denomination of Gennevilliers Finance S.à r.l. and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register, under Section B number 157.048, incorporated following a deed of Maître Martine
SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on 26 

th

 November 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés

et Associations under number 2690, dated 8 December 2010.

The Articles of Incorporation have been amended lastly by a deed of the same notary on 17 

th

 October 2011, not yet

published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party, representing the entire share capital of the Company, then reviewed the following agenda:

<i>Agenda

1. Change of the nominal value of the shares of the Company from 10 € to 1€ and consequently increase of the number

of shares from 1,250 to 12,500.

2. Subsequent restatement of the Company's articles of association.
3. Miscellaneous.
Further to the review of the different items composing the agenda, the sole shareholder, representing the entire share

capital of the Company, requested the notary to act the following resolution:

<i>Resolution:

The  sole  shareholder  resolves  to  change  the  nominal  value  of  the  shares  of  the  Company  from  10  €  to  1€  and

consequently increase the number of share from 1,250 to 12,500.

As a consequence article 6, first paragraph, is amended and shall have the following wording:

“ Art. 6. First paragraph. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12.500.- EUR) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares quotas of a par value of one euro (1.- EUR) each.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the said person appearing signed together

with the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quinze novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Martine

SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera dépositaire du
présent acte.

A comparu:

DEWNOS INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

9787

L

U X E M B O U R G

sous le numéro B 116.983, ici représentée par son gérant Monsieur Eric GILSON, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

La comparante est l'associée unique de Vélizy Rose Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par

les lois du Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 157.048, dont le siège social est sis 29, Avenue Monterey, constituée sous la dénomination de
Gennevilliers Finance S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 26 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 8 décembre 2010 sous le
numéro 2690 (ci-après la «Société»).

Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu par un acte du même notaire en date du 17 octobre 2011,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social de la Société,a considéré l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Changement de la valeur nominale des parts de la Société de 10 € à 1€ et augmentation subséquente du nombre

des parts de 1.250 à 12.500.

2. Modification subséquente des statuts.
3. Divers.
Après avoir considéré les différents éléments portés à l'ordre du jour, l'associé unique, représentant l'intégralité du

capital social de la Société, a requis du notaire instrumentaire d'acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L'associé unique décide de changer la valeur nominale des parts de la Société de 10 € à 1€ et d'augmenter en consé-

quence le nombre des parts de 1.250 à 12.500.

En conséquence, l'article 6, alinéa 1 

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

“  Art. 6. Alinéa 1 

er

 .  Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.”

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date à la date susmentionnée.
L'acte ayant été lu au représentant de la comparante, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Gilson et P. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 novembre 2011. LAC/2011/51303. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Référence de publication: 2011172720/86.
(110200996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

New Millennium Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.257.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère conforme
<i>Pour NEW MILLENNIUM ADVISORY S.A. (en liquidation)
Marco Petronio
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2011175614/13.
(110204953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

9788

L

U X E M B O U R G

New Millennium Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.257.

Les comptes pour la période du 17 décembre 2009 au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère conforme
<i>Pour NEW MILLENNIUM ADVISORY S.A. (en liquidation)
Marco Petronio
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2011175615/14.
(110204971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Nico BACKES S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5544 Remich, 7, op der Kopp.

R.C.S. Luxembourg B 48.966.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175616/9.
(110204130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

P+M Montage GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 159.991.

Im Jahre zweitausendelf, den neunten Dezember;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1. Herr Dr. Szabolcs MOLNAR, Arzt, geboren in Budapest (Ungarn), am 10. April 1975, wohnhaft in HU-2084 Piliss-

zentivan, Hatar u. 48, und

2.  Herr  József  MOLNÁR,  Zimmermannmeister,  geboren  in  Jászladány  (Ungarn),  am  1.  Januar  1954  wohnhaft  in

HU-2085 Pilisvörösvar Iskola u. 4/A.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung “P+M MONTAGE GmbH”, mit Sitz in L-5863 Alzingen, 30, Allée de

la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945, eingetragen in Handels-und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
159991 (die "Gesellschaft"), gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 24. März
2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1277 vom 14. Juni 2011;

- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft zu sein und dass sie den amtierenden

Notar ersuchen, den von ihnen in außerordentlicher Generalversammlung gefassten Beschluss zu dokumentieren wie
folgt:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Alzingen nach L-2132 Luxemburg, 36, avenue Marie-

Thérèse, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 4 der Satzungen abzuändern wie folgt:

Art. 4. (erster Absatz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxem-

burg)."

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

achthundertneunzig Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit Uns dem Notar ge-
genwärtige Urkunde unterschrieben.

9789

L

U X E M B O U R G

Signé: S. MOLNAR, J. MOLNÁR, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2011. LAC/2011/55249. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175653/38.
(110204364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Aer Leit A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-7395 Hunsdorf, 70, rue de Steinsel.

R.C.S. Luxembourg F 8.942.

STATUTS

Entre les soussignés membres fondateurs:
Bach, Paul, instituteur, 40, rue du Grunewald, L-7392 Asselscheuer, né le 20 mars 1965, Ettelbruck, luxembourgeoise
Geisen, Marc, employé privé, 6, op Reilend, L-7391 Blaschette; 24 septembre 1974, Luxembourg, luxembourgeoise
Hirtt, Marguy, professeur, 70, rue de Steinsel L-7395 Hunsdorf, 02 septembre 1961, Grevenmacher, luxembourgeoise
Kemp Roby, électricien, 5A, Route de Wormeldange, L-7390 Blaschette, 05 février 1957 Luxembourg, luxembour-

geoise

Linckels, Sven, ingénieur, 5, rue de Blaschette, L-7353 Lorentzweiler, 25 mai 1978, Luxembourg, luxembourgeoise
Marrasant Marie, Indépendante, 64 route de Steinsel, L-7395 Hunsdorf, 11.12.1970 à Steinfort, luxembourgeoise
Meintz, Georges, employé privé, 11, rue Robert Schuman, L-7382 Helmdange, 02 juillet 1962, Luxembourg, luxem-

bourgeoise

Mersch Arnold, employé privé, 2, rue Belle Vue, L-7350 Lorentzweiler, 13.09.1951, Lorentzweiler, luxembourgeoise
Roller Joseph, instituteur e. r. ,11, rue Noppeney, L-7378 Bofferdange, 16.03.1948 à Luxembourg, luxembourgeoise
Weis Jean-Pierre, employé privé e.r., 24, rue de Steinsel, L-7395 Hunsdorf, 18.05.1943 à Roodt/Ell, luxembourgeoise
Wolff, Claude, employé privé, 18a, op den Iessen L-7363 Lorentzweiler, 31 janvier 1970, Luembourg, luxembourgeoise
et ceux qui seront admis par la suite, une association sans but lucratif est créée, régie par les présents statuts et par

la loi du 21 avril 1928 (modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994) sur les associations et les fondations
sans but lucratif.

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1 

er

 .  L'association sans but lucratif est constituée sous le nom de «Aer Leit a.s.b.l.», désignée ci-après par les

termes «l'association».

L'association est constituée pour une durée illimitée et son siège est fixé à Hunsdorf. Pour atteindre ces objectifs

l'association pourra se rallier à des associations nationales ou internationales.

Art. 2. L'association a pour objet:
- de favoriser l’éducation culturelle, sociale et politique des habitants de Lorentzweiler
- de mettre en actions des projets et structures dans la commune
- d’élaborer des projets et actions qui incitent le développement communal
- de favoriser des échanges dans les domaines culturels et éducatifs
- la collaboration avec toutes les associations publiques ou privées, nationales ou internationales visant les mêmes

objectifs

Titre II. Composition, Admission, Exclusion, Démission, Cotisation

Art. 3. L'association se compose de membres actifs.

Art. 4. Peut devenir membre actif de l'association toute personne qui paie sa cotisation de membre actif et qui s'engage

à respecter les buts de l'association et à travailler à leur réalisation. Seuls les membres actifs ont droit de vote à l'assemblée
générale. Le nombre de membres actifs ne peut être inférieur à trois.

Art. 5. L'association peut admettre des délégués d'organisations associées, ayant le statut d'observateur à l'assemblée

générale.

Art. 6. L'admission d'un membre actif ou d'une organisation associée se fait avec l'accord majoritaire du conseil d'ad-

ministration.  La  cotisation  annuelle  est  fixée  par  l’assemblée  générale.  La  cotisation  annuelle  que  doivent  payer  les

9790

L

U X E M B O U R G

membres actifs est fixée par l’assemblée générale. La cotisation annuelle pour membres actifs est fixée à minimum 1 euro
et ne pourra dépasser 5.000 euros.

Art. 7. Tout membre actif et toute organisation associée peut démissionner en adressant sa démission écrite au conseil

d’administration. En outre le conseil d'administration a le droit de prononcer l'exclusion de tout membre qui ne paie pas
sa  cotisation  ou  qui  ne  respecte  pas  les  objets  et  les  règlements  de  l'association.  Toutefois  le  membre  expulsé  a  la
possibilité de recours à l'assemblée générale suivante. Toute décision d'exclusion requiert une majorité de deux tiers des
voix.

Art. 8. Un membre démissionnaire ou démissionné n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le rem-

boursement de cotisations versées.

Titre III. Administration

Art. 9. L'association est administrée par le conseil d'administration, respectivement par l'assemblée générale.

Art. 10. Les articles 4 et 12 de la loi du 21 avril 1928 (modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994)

régissent  les  attributions  de  l'assemblée  générale.  Les  articles  5  et  6  de  la  loi  précitée  régissent  la  convocation  aux
assemblées générales.

Cette convocation sera faite par le président du conseil d'administration et sera envoyée aux membres actifs par avis

postal quinze jours au moins à l'avance.

La convocation contiendra l'ordre du jour. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre

du jour de celle-ci, sauf urgence admise à la majorité des deux tiers des voix. Tout associé peut se faire représenter à
l'assemblée par un autre membre ayant pour lui droit de vote. Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule
procuration.

Art. 11. Le conseil d'administration fixe chaque année avant fin mars la date de l'assemblée générale ordinaire, à l'ordre

du jour de laquelle figurent, conformément au deuxième alinéa de l'art. 13. de la loi précitée, l'approbation du compte
de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L'assemblée procède à l'examen des comptes des recettes et des dépenses effectuées pendant l'exercice écoulé et

prévues pour le suivant. Après l'approbation des comptes, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge
des administrateurs.

Art. 12. L'exercice financier commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre. Chaque année une liste actualisée

indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l'association sera déposée
avant fin mars auprès du greffe du tribunal civil du siège de l'association.

Art. 13. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou par celui qui le remplace.

Les délibérations des assemblées générales sont réglées par les art. 7 et 8 de la loi du 21 janvier 1928 (modifiée par les
lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994), notamment pour tout ce qui concerne les modifications des statuts. En cas
de partage des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Art. 14. Une délibération de l'assemblée générale est indispensable pour:
a) toute modification des statuts;
b) la nomination et la révocation des administrateurs;
c) l'approbation des budgets et des comptes;
d) la nomination et révocation de deux commissaires aux comptes;
e) la fixation des cotisations;
f) la décharge de la gestion des administrateurs;
g) la dissolution de l'association.

Art. 15. Les résolutions de l'assemblée générale dont la loi ne prescrit pas la publication au Mémorial, sont consignées

dans un rapport, signé par le président et le secrétaire et conservées au siège de l'association où tous les associés peuvent
en prendre connaissance.

Art. 16. L'association est dirigée par un conseil d'administration de 3 membres au moins et 17 membres au plus. Les

membres du conseil d'administration sont le ou la président(e), le ou la vice-président(e), le ou la secrétaire, le ou la
secrétaire adjoint(e) et le ou la responsable des finances et les membres ordinaires. Les membres du conseil d'adminis-
tration  sont  désignés  chaque  année  par  l'assemblée  générale  en  session  ordinaire.  Les  fonctions  au  sain  du  conseil
d’administration seront fixées lors de la première réunion du conseil d’administration après l’assemblée générale.

Art. 17. Le conseil d'administration s'occupe de la gestion de l'association et de toutes les activités qui ne relèvent pas

de la compétence spéciale de l'assemblée générale. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux et
déterminés à un ou plusieurs de ses membres.

Art. 18. Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois administrateurs. Le président

dirige les séances du conseil d'administration. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président ou par un autre

9791

L

U X E M B O U R G

membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois membres au
moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des suffrages
exprimés, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Art. 19. Les fonctions des membres au conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, le conseil d'administration

pourra rembourser ses membres les frais occasionnés par leurs activités.

Art. 20. Le/la responsable des finances ne peut dépenser que l’argent dont il/ elle dispose.

Art. 21. L'A.s.b.l. est engagée par la signature d'un membre du conseil d’administration.

Titre IV. Dispositions finales

Art. 22. En cas de dissolution de l'association, la liquidation est faite par le conseil d'administration en fonction. L'actif

net est attribué à l’office social Steinsel/Lorentzweiler.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas autrement réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril

1928 (modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994) sur les associations sans but lucratif.

Ainsi fait à Lorentzweiler, le 06.12.2011.

Signatures
<i>Les membres fondateurs

Référence de publication: 2011172950/115.
(110201820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

PSL Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 94.693.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175724/9.
(110204423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

QE Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 156.580.

Par la présente, Maitre Arsène KRONSHAGEN démissionne de son mandat de gérant de la société QE FINANCE

SARL et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 08/12/11.

A. KRONSHAGEN.

Référence de publication: 2011175726/10.
(110203864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

PEP Fund Advisors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.622.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175686/9.
(110203613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

PEP Fund Advisors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.622.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175687/9.
(110203614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

9792


Document Outline

30 Lopes S.à r.l.

Aer Leit A.s.b.l.

Joh. A. Benckiser s.à.r.l.

LBK Finance Holding S.A.

LBK Finance S.A.

Les Olliviers Sàrl

Liljefors &amp; Linde S.à r.l.

Linorca S.A.

Linorca S.A.

Litrade International S.à r.l.

Machal II S.A.

Madidi S.A.

Madidi S.A.

Magfin S.A.

Maisons du Monde Luxembourg, S.à r.l.

Malafin S.A.

Mangon Investments S.A.

Mangon Investments S.A.

Marrow Asset Management S.A.

Martis Holding S.A.

Martis Holding S.A.

Martis Holding S.A.

Marussia Lux S.A.

MCI Holding SPF S.A.

Medici s.à r.l.

Medici s.à r.l.

Mère Nature S.àr.l.

Metallic S.àr.l.

Metalltechnik Aktiengesellschaft

Metalltechnik Aktiengesellschaft

MexSpa Invest S.A.

MexSpa Participations S.A.

MexSpa Participations S.A.

MGB International S.à r.l.

MGix

MGix

MH Participations S.A.

Millennium European Holdings S.à r.l.

Minny S.A.

MIP II Gateway Investment S.à rl.

MIP II Luxembourg Investments S.à r.l.

MIP II Luxembourg Investments S.à r.l.

Mon Jardin - Gardencenter Sàrl

Mon Jardin - Nouvelles Créations S.à r.l.

Morsa Capital S.A.

MosliB Holdings Sàrl

MPL

MTEL S.A.

MWH S.à r.l.

New CV Luxco S.à r.l.

New Millennium Advisory S.A.

New Millennium Advisory S.A.

Nico BACKES S.à.r.l.

PEP Fund Advisors S.A.

PEP Fund Advisors S.A.

P+M Montage GmbH

PSL Management S.A.

QE Finance S.à r.l.

Tate &amp; Lyle European Finance, S.à r.l.

Temeraire S.à r.l.

Terold S.à r.l.

Vélizy Rose Investment S.à r.l.