This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 194
24 janvier 2012
SOMMAIRE
Amrego Kapitalförvaltning AB, Luxem-
bourg Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9311
Annen Plus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9267
Aparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9267
Aquarelle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9267
Aquarelle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9267
Armacom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9284
Asari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9291
Assisteo International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
9292
Association N. Arend & C. Fischbach S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9293
Atelier Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9297
Athor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9297
Automobiles Pierri Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
9297
Autopol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9297
Avanza S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9290
Aviation Hodling S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9298
Badie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9310
Bargo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9298
Bargo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9298
Bertelsmann Digital Media Investments
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9298
Bonaria et Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9266
Boyar Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9312
Brandenburg Archie 24 Acquico 3 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9307
Brandenburg Archie 24 Acquico 4 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9307
B.R.E.S. Investigations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
9298
Brink's Security Luxembourg S.A. . . . . . . .
9310
Bureau d'Architecture Paul GZELLA S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9307
Fairfield Exeter Luxembourg S.C.A. . . . . .
9286
French Property HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . .
9274
Gavilon Luxembourg HoldCo S.à r.l. . . . . .
9293
Grand Duchy L.F. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9298
Guardian Eastern Europe Investments S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9307
Iguane S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9310
Immo-Center S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9310
Landmark S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9311
LOPHIRA, Société de Gestion de Patri-
moine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9312
MSEOF Park Tower S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
9272
MSEOF Pascal Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
9272
MSEOF Quattro Fixture-Co S.à r.l. . . . . . .
9272
MSEOF Quattro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9284
MSEOF Stempelfabrik S.à r.l. . . . . . . . . . . .
9285
MSEOF Trianon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9285
Net Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9274
New Café In S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9273
New Media Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9267
N-Media Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
9285
Papilux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9273
ProLogis Poland LXIV S.à r.l. . . . . . . . . . . .
9286
ProLogis Poland LX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
9284
ProLogis Poland LXXIII S.à r.l. . . . . . . . . . .
9286
ProLogis Poland LXXIX S.à r.l. . . . . . . . . . .
9290
ProLogis Poland LXXX S.à r.l. . . . . . . . . . .
9291
ProLogis Poland XIX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
9291
ProLogis UK CCLXVI S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
9285
ProLogis UK CCXLV S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
9291
Quartal Financial Solutions AG, succursale
de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9268
Quartal Financial Solutions AG, succursale
de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9269
Share Link 11 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9274
Sherwin-Williams Coatings S.à r.l. . . . . . . .
9266
Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l. . . .
9266
Siman-Fass S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9273
Sintonia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9272
SKVG.Com S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9273
W2005/W2007 Vernal Asset 1 Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9292
9265
L
U X E M B O U R G
Sherwin-Williams Coatings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.053.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 148.412.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Suite à une erreur administrative dans le texte de la réquisition déposée le 8 juin 2010 sous le numéro L100079786.05,
le nom de Mr. Lawrence Jérôme Boron a erronément été mentionné comme Lawrence James Boron.
Le quatrième paragraphe du texte de la réquisition aurait dû lire:
"de nommer Lawrence Jérôme Boron, employé, né le 12 février 1959 à Ohio, Etats-Unis d'Amérique, demeurant
professionnellement au 648 Treeside Lane, Avon Lake, Ohio 44012, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant A de la
Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat."
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011173801/20.
(110202849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.056.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 148.400.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Suite à une erreur administrative dans le texte de la réquisition déposée le 8 juin 2010 sous le numéro L100079774.05,
le nom de Mr. Lawrence Jérôme Boron a erronément été mentionné comme Lawrence James Boron.
Le quatrième paragraphe du texte de la réquisition aurait dû lire:
"de nommer Lawrence Jérôme Boron, employé, né le 12 février 1959 à Ohio, Etats-Unis d'Amérique, demeurant
professionnellement au 648 Treeside Lane, Avon Lake, Ohio 44012, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant A de la
Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat."
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011173802/20.
(110202853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Bonaria et Fils, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 91, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 146.889.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2011175054/13.
(110204270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
9266
L
U X E M B O U R G
New Media Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 118.134.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Charles Ruppert
<i>Président / Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2011174837/11.
(110203376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Annen Plus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6850 Manternach, route de Schorenshof.
R.C.S. Luxembourg B 143.953.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
24, Rue Léon Kauffman L-1853 Luxembourg
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011175010/11.
(110203734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Aparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R.C.S. Luxembourg B 51.264.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
24, Rue Léon Kauffman L-1853 Luxembourg
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011175014/11.
(110203730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Aquarelle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 98.275.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175020/10.
(110204007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Aquarelle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 98.275.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175021/10.
(110204016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
9267
L
U X E M B O U R G
Quartal Financial Solutions AG, succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2550 Luxembourg, 146, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 165.355.
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE
1. Generell.
1.1. Ort und Zeit.
Verwaltungsrats-Sitzung der Quartal Financial Solutions AG vom 14. Juni 2011, über das Telefon.
1.2. Anwesend.
- Simon Pfändler, Präsident
Aarne Aktan, Mitglied
Reto Käser, Sekretär
...
1.3. Sitzeröffnung in Luxemburg.
Die Eröffnung des Sitzes in Luxemburg wurde gemäss Anhang 1 genehmigt.
...
Den 14. Juni 2011.
Simon Pfändler / Reto Käser
<i>Präsident / Sekretäri>
<i>Anhang 1 zum QFS Verwaltungsrats-Sitzung vom 14. Juni 2011i>
<i>Verwaltungsratsbeschluss vom 14. Juni 2011 über die Eröffnung einer Niederlassung in Luxembourg und die Ernennung vomi>
<i>zuständigen Manageri>
"Quartal Financial Solutions AG, succursale de Luxembourg
Adresse der Zweigniederlassung: 146, avenue du 10 septembre, L-2550 Luxemburg
Gründung einer Niederlassung
Der Verwaltungsrat der Quartal Financial Solutions AG, hat am 14. Juni 2011 beschlossen eine Zweigniederlassung in
Luxemburg zu eröffnen und die Eintragung dieser Zweigniederlassung beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
zu beantragen.
Informationen hinsichtlich der Gesellschaft:
Quartal Financial Solutions AG, Aktiengesellschaft (AG) schweizerischem Rechts, mit Gesellschaftssitz in Mürtschen-
strasse 39, 8048 Zürich, Schweiz, eingetragen beim Handelsregister des Kanton Zürich, Schweiz, unter der Nummer
CH-020.3.022.595-7.
Informationen hinsichtlich des Zweigniederlassung:
Quartal Financial Solutions AG, succursale de Luxembourg, mit Sitz in 146, avenue du 10 septembre, L-2550 Luxem-
burg.
Tätigkeit: Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für die Finanzindustrie in den Bereichen Informatik und Organi-
sation.
Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft:
Als Geschäftsführer:
- Herr Thierry Zuppinger, geboren am 10.08.1983 in Zürich, Schweiz
- Reto Käser, geboren am 20.11.1965 in Huttwil BE, Schweiz
- Mauro Godinho, geboren am 21.9.1975 in Salvadore, Brasilien
Als ständiger Vertreter für die Aktivitäten der Zweigniederlassung:
- Herr Philippe Herremans, geboren am 06/06/1973 in Luxemburg, Luxemburg.
Die Gesellschaft wird wirksam vertreten durch zwei Geschäftsführer.
Die Zweigniederlassung wird wirksam vertreten durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers und eines
weiteren Geschäftsführers oder des Niederlassungsleiters.
9268
L
U X E M B O U R G
Luxemburg, den 2. Dezember 2011.
Quartal Financial Solutions AG
Thierry Zuppinger / Reto Käser
<i>CEO / COOi>
Référence de publication: 2011173792/54.
(110202124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Quartal Financial Solutions AG, succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2550 Luxembourg, 146, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 165.355.
STATUTEN
I. Firma, Sitz, Zweck und Dauer
Art. 1. Firma, Sitz und Dauer. Unter der Firma Quartal Financial Solutions AG, Quartal Financial Solutions SA, Quartal
Financial Solutions Inc. besteht für unbestimmte Zeit eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und den
Bestimmungen der Art. 620 ff des Schweizerischen Obligationrechtes mit Sitz in Zürich.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für die Finanzindustrie in den Bereichen
Informatik und Organisation.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft
zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In-und Ausland
errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
II. Aktienkapital, Aktien, Aktionaere
Art. 3. Aktienkapital. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 251'010.-. Es ist eingeteilt in 25'101 Namenaktien
von je CHF 10.-- nominal. Das Aktienkapital wurde voll liberiert.
Die Gesellschaft kann den Aktionären anstelle von Aktien Zertifikate ausgeben, welche vom Präsidenten des Verwal-
tungsrates zu unterzeichnen sind.
Art. 3a. Sacheinlage. Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung von der Quartal Oy, mit Sitz in Helsinki, SF,
1'600 Namenaktien der Quartal Financial Solutions Oy, mit Sitz in Helsinki, SF, im Wert von Fr. 234'026.--. Als Gegen-
leistung dafür kommen der Sacheinlegerin 9'001 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft mit dem Nennwert von 10.-
und zum Ausgabepreis von je Fr. 26.-- zu.
Art. 4. Uebertragungsbeschränkungen. Die Uebertragung von Namenaktien bedarf der Bewilligung der Gesellschaft.
Die Bewilligung kann verweigert werden, wenn die Gesellschaft, andere Aktionäre oder vom Verwaltungsrat vorgeschla-
gene Dritte dem übertragungswilligen Aktionär die Aktien zum wirklichen Wert abkaufen.
Die Bewilligung kann ferner verweigert werden, wenn der Erwerber nicht eine Erklärung abgibt, dass er die Aktien im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung erwirbt. Sie kann überdies aus wichtigem Grund verweigert werden. Als solcher
gilt:
a) Wenn der Erwerber direkt oder indirekt eine die Gesellschaft konkurrierende Tätigkeit ausübt;
b) Wenn die Eintragung des Erwerbers im Aktienbuch objektiv unvereinbar ist mit der Zwecksetzung der Gesellschaft
oder wenn sie deren wirtschaftliche Selbständigkeit gefährden würde.
Beim Erwerb von Aktien kraft Güter- oder Erbrecht oder Zwangsvollstreckung kann das Gesuch um Eintragung ins
Aktienbuch nur abgelehnt werden, sofern dem Erwerber die Aktien zum wirklichen Wert abgekauft werden.
Art. 5. Aktienbuch. Als Aktionär gilt, wer im Aktienbuch als Aktionär eingetragen ist. Die Eigentümer und Nutzniesser
der Aktien werden mit Namen und Adresse in das Aktienbuch eingetragen.
Ist die Eintragung eines Erwerbers aufgrund falscher Angaben erfolgt, kann dieser nach Anhörung im Aktienbuch ge-
strichen werden.
Jeder Aktionär hat der Gesellschaft sein Domizil und allfällige Domizilwechsel zur Eintragung ins Aktienbuch zu melden.
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztge-
meldete Adresse der Aktionäre.
III. Organe der gesellschaft
Art. 6. Organe. Organe der Gesellschaft sind:
a) Die Generalversammlung
b) Der Verwaltungsrat
c) Die Revisionsstelle
a) Die Generalversammlung
9269
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Ordentliche und Ausserordentliche Generalversammlung. In die Kompetenz der Generalversammlung fällt die
Behandlung aller Geschäfte, die ihr durch Gesetz und Statuten zugewiesen sind.
Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich einmal innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Ge-
schäftsjahres statt.
Ausserordentliche Generalversammlungen finden auf Beschluss des Verwaltungsrates statt oder wenn Aktionäre, die
mindestens zehn Prozent des Aktienkapital vertreten, vom Verwaltungsrat die Durchführung einer ausserordentlichen
Generalversammlung verlangen.
Art. 8. Einberufung. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder im Gesetz bezeichnete Organe
und Personen einberufen.
Die Einberufung hat spätestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag durch eingeschriebenen Brief an die im Ak-
tienbuch verzeichneten Aktionäre zu erfolgen.
In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrats und der Aktionäre be-
kanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegen-
standes verlangt haben.
Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung haben den Hinweis zu enthalten, dass der Geschäfts- und Revi-
sionsbericht sowie die Anträge der Verwaltung über die Verwendung des Bilanzgewinns den Aktionären am Sitz der
Gesellschaft und bei allfälligen Zweigniederlassungen zur Einsicht aufliegen.
Art. 9. Universalversammlung. Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch er-
hoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften
abhalten.
In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig
verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind.
Art. 10. Stimmrecht und Vertretung. An der Generalversammlung sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre
stimmberechtigt. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Ein Aktionär kann sich durch einen andern Aktionär mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.
Art. 11. Beschlussfassung. Die Generalversammlung wählt und fasst ihre Beschlüsse mit Zweidrittel-Mehrheit aller
Aktienstimmen, sofern das Gesetz oder diese Statuten nicht zwingend etwas anderes bestimmen.
Wahl und Beschlussfassung geschehen in der Regel in einer offenen Abstimmung . Die Versammlung kann jedoch auf
Antrag für einzelne Geschäfte geheime Abstimmung beschliessen.
Art. 12. Durchführung. Die Versammlung wird durch den Präsidenten oder Vizepräsidenten des Verwaltungsrates
geleitet. Bei deren Verhinderung wählt die Versammlung einen Tagespräsidenten.
Der Verwaltungsrat sorgt für die ordnungsgemässe Führung des Protokolls.
Der Vorsitzende bestimmt aus den Reihen der Anwesenden den Protokollführer und die Stimmenzähler, die nicht
Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.
b) Der Verwaltungsrat
Art. 13. Zusammensetzung, Amtsdauer. Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Als Ver-
waltungsräte sind nur Aktionäre der Gesellschaft wählbar.
Die Amtsdauer beträgt 3 Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig.
Art. 14. Konstituierung. Besteht der Verwaltungsrat aus mehreren Mitgliedern, so konstituiert er sich selbst und wählt
seinen Präsidenten sowie einen Sekretär. Der Sekretär braucht nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein.
Art. 15. Vertretung. Die Befugnis der Verwaltungsräte zur Vertretung der Gesellschaft nach aussen richtet sich nach
dem Eintrag im Handelsregister.
Art. 16. Sitzung, Protokoll. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Präsidenten oder auf Verlangen eines Mitgliedes
zusammen, mindestens jedoch 1 mal pro Jahr.
Verlangt ein Mitglied die Einberufung einer Sitzung, stellt es dem Präsidenten den Antrag unter Angabe der Gründe,
weshalb eine Sitzung einberufen werden soll. Der Präsident ruft diesfalls innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Antrages
eine Sitzung ein.
Ueber die Sitzung ist ein Protokoll zu führen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär zu unterzeichnen ist.
Art. 17. Beschlussfassung. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den
Stichentscheid.
Zirkularbeschlüsse sind zulässig, sofern kein Mitglied mündlich Beratung verlangt.
Art. 18. Aufgaben und Befugnisse. Der Verwaltungsrat hat die Oberleitung der Gesellschaft inne und übt die Aufsicht
und Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Er legt die Organisation fest und erlässt Richtlinien für die Geschäftspolitik.
9270
L
U X E M B O U R G
In die Kompetenz des Verwaltungsrates fallen alle Geschäfte, die nicht durch das Gesetz und die Statuten einem andern
Organ vorbehalten sind. Insbesondere kommen dem Verwaltungsrat folgende Aufgaben zu:
- Die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern und soweit diese für
die Führung der Gesellschaft notwendig sind;
- Die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und Vertretung betrauten Person;
- Die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung
der Gesetze, Statuten,
Reglemente und Weisungen;
- Die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer
Beschlüsse;
- Die Benachrichtigung des Richters im Falle der Ueberschuldung
- Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht voll liberierte Aktien;
- Beschlüsse zur Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statutenänderungen;
- Ernennung der zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen.
Art. 19. Kompetenzdelegation. Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung ganz oder zum Teil an einen Ausschuss,
an einzelne Mitglieder oder an Dritte übertragen. Er erlässt in diesem Fall ein Organisationsreglement, in welchem die
delegierten Aufgaben, die zuständigen Stellen und die Berichterstattung geregelt sind.
Art. 20. Rechte und Pflichten der Verwaltungsräte. Jedes Mitglied hat das Recht, nach Massgabe von Art. 715a des
Obligationenrechts Auskunft über die Angelegenheit der Gesellschaft zu verlangen.
Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung mit der gebotenen Sorgfalt wahrzunehmen und die Interessen der Ge-
sellschaft in guten Treuen zu wahren.
c) Die Revisionsstelle
Art. 21. Zusammensetzung, Amtsdauer. Die Generalversammlung wählt einen oder mehrere Revisoren als Revisions-
stelle.
Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. Eine Wiederwahl ist zulässig.
Art. 22. Aufgaben. Die Revisionsstelle obliegen die Ihr durch das Gesetz übertragenen Aufgaben.
Die Generalversammlung kann die Aufgaben und Befugnisse der Revisionsstelle jederzeit erweitern, doch dürfen der
Revisionsstelle keine Aufgaben des Verwaltungsrates übertragen werden, oder solche die die Unabhängigkeit der Revi-
sionsstelle beeinträchtigen.
IV. Geschaeftsjahr, Rechnungswesen
Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr wird jährlich per 31. Dezember abgeschlossen, erstmals per 31. Dezember
2000.
Art. 24. Rechnungswesen. Die Bücher der Gesellschaft sind nach bewährten kaufmännischen Grundsätzen zu führen.
Die Bilanz und die Erfolgsrechnung sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufzustellen.
Die Generalversammlung kann auf Antrag des Verwaltungsrates ausser den gesetzlichen Re
serven die Bildung ausserordentlicher Reserven beschliessen.
V. Statutenaenderung und Liquidation
Art. 25. Statutenänderung. Wenn eine Statutenänderung beantragt wird, so ist in der Einladung zur Generalversamm-
lung der Text der beantragten Aenderung aufzuführen.
Art. 26. Liquidation. Sofern von der Generalversammlung, die den Liquidationsbeschluss fasst, nicht besondere Liqui-
datoren bestellt werden, wird die Liquidation durch den zuletzt bestellten Verwaltungsrat durchgeführt.
VI. Publikationsorgan
Art. 27. Bekanntmachungen. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen
Handelsamtsblatt.
Zürich, den 30. März 2009.
Simon Pfändler / Ulrich Jacobi
<i>Der Vorsitzende / Der Sekretäri>
Référence de publication: 2011173793/151.
(110202124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
9271
L
U X E M B O U R G
Sintonia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 77.504.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63314 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011174493/10.
(110202829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
MSEOF Park Tower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 128.984.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 30 novembre 2011i>
L'associé unique de MSEOF Park Tower S.àr.l. (la "Société") a décidé comme suit:
- d'accepter la démission du M. Martijn Bosch comme gérant de la Société avec effet immédiat.
- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:
* M. Stefan Koch, né le 15 octobre 1978 à Berlin (Allemagne) demeurant professionnellement au 64, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Stefan Koch.
Référence de publication: 2011174826/14.
(110203525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
MSEOF Pascal Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 151.200,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 108.947.
<i>Extrait des résolutions des associés du 30 novembre 2011i>
Les associés de MSEOF Pascal Lux S.àr.l. (la "Société") ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission du M. Martijn Bosch comme gérant de la Société avec effet immédiat.
- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:
* M. Stefan Koch, né le 15 octobre 1978 à Berlin (Allemagne) demeurant professionnellement au 64, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Stefan Koch.
Référence de publication: 2011174827/15.
(110203215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
MSEOF Quattro Fixture-Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 146.324.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 30 novembre 2011i>
L'associé unique de MSEOF Quattro Fixture-Co S.àr.l. (la "Société") a décidé comme suit:
- d'accepter la démission du M. Martijn Bosch comme gérant de la Société avec effet immédiat.
- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:
* M. Stefan Koch, né le 15 octobre 1978 à Berlin (Allemagne) demeurant professionnellement au 64, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Stefan Koch.
Référence de publication: 2011174828/15.
(110203527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
9272
L
U X E M B O U R G
Papilux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 125.542.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011174859/10.
(110204141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Siman-Fass S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3492 Dudelange, 25, rue Mont Saint Jean.
R.C.S. Luxembourg B 41.239.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
i>13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature
Référence de publication: 2011174889/14.
(110203577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
SKVG.Com S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 22, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 89.145.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
i>13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature
Référence de publication: 2011174890/14.
(110203574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
New Café In S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 14, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 65.694.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
i>13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature
Référence de publication: 2011174833/14.
(110203596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
9273
L
U X E M B O U R G
Net Soparfi S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1477 Luxembourg, 37, rue des Etats-Unis.
R.C.S. Luxembourg B 26.938.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
i>13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature
Référence de publication: 2011174836/14.
(110203583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Share Link 11 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 80.164.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011174887/10.
(110204252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
French Property HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.335.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twelfth day of December.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
The Arden Trust, a trust organised under the laws of Prince Edward Island (Canada), represented by LOTA Fiduciary
(Canada) Inc., an incorporation organised under the laws of Prince Edward Island, having its registered office at 15, Queen
Street, Charlottetown, C1A 7K7, Prince Edward Island, Canada, acting as trustee and registered under number 11184
here duly represented by Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing at 5 rue Zénon Bernard, L-4030
Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal (the “Sole Shareholder”).
The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association (the "Articles") of a "société à responsabilité limitée" which such party declares to incorporate.
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed
by the present Articles and by current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law of 10 August 1915 on Com-
mercial Companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés à
responsabilité limitée" (the "Commercial Companies Law").
Art. 2. The Company's name is "French Property HoldCo S.à r.l.".
Art. 3. The Company's purpose is:
(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other,
Luxembourg or foreign companies or enterprises;
(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other
way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall
deem fit;
9274
L
U X E M B O U R G
(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the
Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;
(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same
group of companies than the Company (the "Affiliates") any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case,
even in favour of a third-party lender of the Affiliates);
(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; and
(7) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment
of the above objects or any of them.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board
of managers or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required by the Law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Shares
Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 12,500
(twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the
extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three quarter
of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders
or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
9275
L
U X E M B O U R G
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of Articles.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The manager(s) shall be appointed, and her/his/its/their remuneration determined, by a resolution of the general
meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The
remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any manager.
The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate her/his/its
powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall have a casting
vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board
of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
electronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly
represented thereto.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or any two managers of the Company. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman
or any two managers of the Company.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
managers' meeting.
9276
L
U X E M B O U R G
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-
five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted
in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each sha-
reholder shall vote in writing.
If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the
shareholders. In such a case 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months
of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand Duchy of
Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.
Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half
of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up
the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders' number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)
days preceding the annual general meeting of shareholders.
Supervision of the company
Art. 20. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to
one or more statutory auditor(s) (“commissaire”), who may or may not be shareholder(s).
9277
L
U X E M B O U R G
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function
by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
Where the thresholds of article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register
are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (“réviseurs d'entreprises
agréés”) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the list
of the Luxembourg financial regulator (“Commission de surveillance du secteur financier”).
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The appearing party hereby declares to subscribe to the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares issued by the
Company as follows:
- The Arden Trust, prenamed, subscribes to 12,500 (twelve thousand five hundred) shares.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro),
is at the disposal of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).
<i>Resolutions of the Sole Shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed capital, passed the following resolutions:
9278
L
U X E M B O U R G
1) Are appointed as managers:
- Mrs. Pamela Valasuo, with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and
- Mr. Robert van't Hoeft, with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The managers shall serve for an undetermined duration.
According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of one of its managers.
2) The Company shall have its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proy holder signed with us, the notary,
the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le douzième jour de décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg
soussigné.
Comparaît:
The Arden Trust, un trust organisé selon les lois des Iles du Prince Edouard (Canada), représenté par LOTA Fiduciary
(Canada) Inc. une société organisée selon les lois des Iles du Prince Edouard (Canada), ayant son siège social sis au 15,
Queen Street, Charlottetown, C1A 7K7, Iles du Prince Edouard, Canada, agissant comme trustee et enregistré sous le
numéro 11184, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant à 5 rue Zénon Bernard,
L-4030 Eschsur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé (l'«Associé Unique»).
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeureront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire instrumentant de dresser les statuts suivants (les
«Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.
Dénomination - Objet - Siège- Durée
Art. 1
er
. Il est constitué une société à responsabilité limitée (la «Société»), régis par les présents Statuts et par les
lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à
responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).
Art. 2. La dénomination de la société est «French Property HoldCo S.à r.l.».
Art. 3. L'objet de la Société est:
1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;
2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation
et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et
intérêts, comme la Société le jugera utile;
3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix
que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
5) D'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou
toute société appartenant au même groupe de sociétés (les «Sociétés Affiliées»), tout concours, prêts, avances ou ga-
ranties (dans ce dernier cas, même en faveur d'un prêteur tiers de Sociétés Affiliées);
6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute
somme empruntée; et
7) De manière générale faire toute chose apparaissant à la Société comme étant favorable à l'accomplissement de
l'objet de la Société, tel que susmentionné.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré-décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. La Société a son siège social dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
9279
L
U X E M B O U R G
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance
ou par le gérant unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger
par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises par la Loi.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-
duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de
gérance ou par le gérant unique (selon le cas) de la Société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euro), représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.
Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décision et chaque associé a un
nombre de droit de vote proportionnel aux nombre des parts qu'il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique
(selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été proposé à
chaque associé de la même classe en proportion de leur participation dans le capital social ou de la classe de parts sociales
concernée représentés par leurs parts sociales.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues des
réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément
aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés
prise à la majorité simple des voix ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s)
peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.
Le(s) gérant(s) peut/peuvent être révoqué(s) ou remplacé(s) ad nutum à tout moment avec ou sans justification par
une résolution de l'assemblée générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas)
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
9280
L
U X E M B O U R G
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec
l'objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un de ses
gérants.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant
(s) de la Société.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (s'il
y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité de voix, aura un vote prépon-
dérant. Le président présidera toutes réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance
sera présidé par un gérant présent et nommé dans cette intention. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est
pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance
ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)
jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de
la réunion du conseil de gérance.
Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé
précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant de la Société peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion
de communiquer à un même moment.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou
représentée.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement repré-
sentés.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par
deux gérants de la Société. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par deux gérants
de la Société.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents
ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques
ou tout autre moyen de communication approprié.
Art. 14. Tout gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou
9281
L
U X E M B O U R G
par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque
associé émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des
associés. Dans ce cas, 1 (une) assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du
dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-duché de Luxembourg à
l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et les résolutions écrites des associés sont proposées
par le conseil de gérance, ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la
moitié du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié, un tiers qui peut ne pas
être associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la
Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui
contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du/des gérant(s), du/des commissaire(s) (s'il en existe) et du/des associé(s) envers la
Société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)
jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la société
Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale
annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.
A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renou-
velé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique
(selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'approbation
des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le Registre de Commerce et des Sociétés seront
atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommé
(s) par l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) à partir de la liste de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier.
9282
L
U X E M B O U R G
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé peut/
peuvent être nommé(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide
des termes et conditions de son/leurs mandat.
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, 5% (cinq pourcent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais seront à nouveau obligatoire si la réserve légale redevient inférieure à ce seuil
de 10% (dix pourcent).
L'assemblée des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout
moment qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au
prorata de leur participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou le gérant
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance,
desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à
distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve
en vertu de la Loi ou des Statuts.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé
unique (selon le cas) peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts
du capital social, devra désigner un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) et déterminer la
méthode de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs ainsi que leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata des parts sociales qu'ils
détiennent.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Libérations - Apportsi>
La partie comparante déclare par la présente souscrire aux 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales comme suit:
- The Arden Trust, prénommé, souscrit à 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales.
Les parts sociales ont été entièrement payés en numéraire, de sorte que le montant de 12.500 EUR (douze mille cinq
cents Euro) est à la disposition de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros (€ 1.400,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital souscrit, a pris
les résolutions suivantes:
1) Sont nommés en tant que gérants:
- Mme. Pamela Valasuo, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et
- M. Robert van't Hoeft, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article 12 des statuts, la Société est engagée par la signature d'un de ses gérants.
2) Le siège social de la Société est établi au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de Luxem-
bourg.
9283
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente, le présent acte
de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16880. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011172434/527.
(110201012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
ProLogis Poland LX S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 113.542.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 octobre 2011.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011174849/14.
(110204079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Armacom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4181 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.
R.C.S. Luxembourg B 103.983.
<i>Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2011.i>
Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue Romain Fandel, L-4149 Esch-
sur-Alzette au 7, rue Portland, L-4281 Esch-sur-Alzette et ceci avec effet au 2 janvier 2012.
Signature.
Référence de publication: 2011175023/11.
(110204384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
MSEOF Quattro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 46.111.300,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.266.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 30 novembre 2011i>
L'associé unique de MSEOF Quattro S.àr.l. (la "Société") a décidé comme suit:
- d'accepter la démission du M. Martijn Bosch comme gérant de la Société avec effet immédiat.
- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:
* M. Stefan Koch, né le 15 octobre 1978 à Berlin (Allemagne) demeurant professionnellement au 64, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Stefan Koch.
Référence de publication: 2011174829/15.
(110203530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
9284
L
U X E M B O U R G
MSEOF Stempelfabrik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.707.425,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 125.214.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 30 novembre 2011i>
L'associé unique de MSEOF Stempelfabrik S.àr.l. (la "Société") a décidé comme suit:
- d'accepter la démission du M. Martijn Bosch comme gérant de la Société avec effet immédiat.
- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:
* M. Stefan Koch, né le 15 octobre 1978 à Berlin (Allemagne) demeurant professionnellement au 64, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Stefan Koch.
Référence de publication: 2011174830/15.
(110203222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
N-Media Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7795 Bissen, 2, Z.A.C. Klengbousbierg.
R.C.S. Luxembourg B 105.651.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
i>13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature
Référence de publication: 2011174832/14.
(110203559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
ProLogis UK CCLXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 140.511.
<i>Rectification du dépôt No L110193858.04 du 06/12/2011i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011174855/10.
(110204104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
MSEOF Trianon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.711.300,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 126.206.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 30 novembre 2011i>
L'associé unique de MSEOF Trianon S.àr.l. (la "Société") a décidé comme suit:
- d'accepter la démission du M. Martijn Bosch comme gérant de la Société avec effet immédiat.
- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:
* M. Stefan Koch, né le 15 octobre 1978 à Berlin (Allemagne) demeurant professionnellement au 64, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Stefan Koch.
Référence de publication: 2011174831/15.
(110203210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
9285
L
U X E M B O U R G
ProLogis Poland LXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 113.546.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 octobre 2011.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011174850/14.
(110204077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
ProLogis Poland LXXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 113.535.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2011.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011174851/14.
(110204082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Fairfield Exeter Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.493.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of November,
Before Us, Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. Exeter Luxembourg S.à r.l., a company incorporated as a société à responsabilité limitée under the laws of Luxem-
bourg, having a share capital set at CAD 35,001.-, with registered office at 46A, Avenue J.-F. Kennedy, L1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B
156.563 (the "Unlimited Shareholder" and the "Limited Shareholder 1"); and
2. Otis Canada, Inc., a corporation incorporated under the laws of Ontario (Canada), with registered office at 4475
North Service Road, Suite 200 Burlington ON L7L 4X7 Canada, registered with the Enterprise Register of Canada under
the number 001442734 (the "Limited Shareholder 2" and "MRPS Shareholder", together with the Unlimited Shareholder
and the Limited Shareholder 1, the "Shareholders"),
each represented by Alexander Koch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,
which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will be
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as above mentioned, declare that they are the shareholders of Fairfield Exeter
Luxembourg S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions), with registered office at 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under the number B 156.493, incorporated by a notarial deed of Maître Léonie Grethen, notary
residing in Luxembourg, dated 5 November 2010 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 2688 of 7 December 2010 (the "Company"). The Company's articles of association (the "Articles of Association")
have been amended the last time by a deed of Maître Léonie Grethen, prenamed, dated 3 December 2010, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 379 of 25 February 2011.
The appearing parties, represented as above mentioned, have been fully informed of the resolutions to be taken on
the basis of the following agenda:
9286
L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
1. To increase the Company’s share capital by an amount of two million seven hundred and forty-five thousand fifty-
four Canadian Dollar ninety cents (CAD 2,745,054.90), so as to raise the subscribed capital from its present amount of
fifty thousand one Canadian Dollars (CAD 50,001.-) divided into twenty thousand (20,000) shares of the Unlimited
Shareholder, thirty thousand (30,000) shares of the Limited Shareholders and one (1) Class A mandatory redeemable
preferred share, with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each, to two million seven hundred and ninety-
five thousand fiftyfive Canadian Dollar ninety cents (CAD 2,795,055.90), divided into twenty thousand (20,000) shares of
the Unlimited Shareholder, thirty thousand (30,000) shares of the Limited Shareholders and one (1) Class A mandatory
redeemable preferred share, with a nominal value of fifty-five Canadian Dollar ninety cents (CAD 55.90) each, without
the issue of new shares.
2. To increase the nominal value of the existing twenty thousand (20,000) shares of the Unlimited Shareholder, thirty
thousand (30,000) shares of the Limited Shareholders and one (1) Class A mandatory redeemable preferred share from
one Canadian Dollar (CAD 1.-) each by an amount of fifty-four Canadian Dollars ninety cents (CAD 54.90) each to fifty-
five Canadian Dollars ninety cents (CAD 55.90) each.
3. To accept the contribution in cash by Exeter Luxembourg S.à r.l. of a total one million nine hundred and twenty-
one thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 1,921,500.-) relating to the increase of the nominal value of the twenty
thousand (20,000) shares of the Unlimited Shareholder and fifteen thousand (15,000) shares of the Limited Shareholders
held by Exeter Luxembourg S.à r.l.
4. To accept the contribution in cash by Otis Canada, Inc. of a total amount of eight hundred twenty-three thousand
five hundred and fifty-four Canadian Dollars ninety cents (CAD 823,554.90) relating to the increase of the nominal value
of the fifteen thousand (15,000) shares of the Limited Shareholders and one (1) Class A mandatory redeemable preferred
share held by Otis Canada, Inc.
5. To amend article 5.1 of the articles of Association of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted
under the preceding items.
6. Miscellaneous. The appearing parties, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to
document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders RESOLVED to increase the Company’s share capital by an amount of two million seven hundred
and forty-five thousand fifty-four Canadian Dollar ninety cents (CAD 2,745,054.90), so as to raise the subscribed capital
from its present amount of fifty thousand one Canadian Dollars (CAD 50,001.-) divided into twenty thousand (20,000)
shares of the Unlimited Shareholder (the "Unlimited Shares"), thirty thousand (30,000) shares of the Limited Shareholders
(the "Limited Shares") and one (1) Class A mandatory redeemable preferred share (the "Class A MRPS"), with a nominal
value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each, to two million seven hundred and ninety-five thousand fifty-five Canadian
Dollar ninety cents (CAD 2,795,055.90), divided into twenty thousand (20,000) shares of the Unlimited Shareholder,
thirty thousand (30,000) shares of the Limited Shareholders and one (1) Class A mandatory redeemable preferred share,
with a nominal value of fifty-five Canadian Dollar ninety cents (CAD 55.90) each, without the issue of new shares.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders RESOLVED to increase the nominal value of the Limited Shares, the Unlimited Shares and the Class
A MRPS of the Company from one Canadian Dollar (CAD 1.-) each by an amount of fifty-four Canadian Dollars ninety
cents (CAD 54.90) each to fifty-five Canadian Dollars ninety cents (CAD 55.90) each.
<i>Paymenti>
Thereupon, now appears Alexander Koch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney in
fact of the Unlimited Shareholder and Limited Shareholder 1, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
The person appearing declared to make in the name and on behalf of the Unlimited Shareholder and Limited Share-
holder 1 payment in full for the increase of the nominal value of the twenty thousand (20,000) Unlimited Shares and fifteen
thousand (15,000) Limited Shares held by the Unlimited Shareholder and Limited Shareholder 1 from one Canadian Dollar
(CAD 1.-) each by an amount of fifty-four Canadian Dollars ninety cents (CAD 54.90) each to fifty-five Canadian Dollars
ninety cents (CAD 55.90) each, by a contribution in cash in the total amount of one million nine hundred and twenty-
one thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 1,921,500.-).
Thereupon, now appears Alexander Koch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney in
fact of the Limited Shareholder 2 and MRPS Shareholder, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
The person appearing declared to make in the name and on behalf of the Limited Shareholder 2 and MRPS Shareholder
payment in full for the increase of the nominal value of the fifteen thousand (15,000) Limited Shares and one (1) Class A
MRPS held by the Limited Shareholder 2 and MRPS Shareholder from one Canadian Dollar (CAD 1.-) each by an amount
of fifty-four Canadian Dollars ninety cents (CAD 54.90) each to fifty-five Canadian Dollars ninety cents (CAD 55.90) each,
by a contribution in cash in the total amount of eight hundred twenty-three thousand five hundred and fifty-four Canadian
Dollars ninety cents (CAD 823,554.90).
9287
L
U X E M B O U R G
Proof of these payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in Article
27 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly
bears witness to their fulfilment.
<i>Third resolutioni>
The shareholders RESOLVED to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company which shall forthwith
read as follows:
" 5.1. The share capital is equal to two million seven hundred and ninetyfive thousand fifty-five Canadian Dollar ninety
cents (CAD 2,795,055.90) represented by twenty thousand (20,000) shares of the Unlimited Shareholder (herein defined
as "Unlimited Shares"), thirty thousand (30,000) shares of the Limited Shareholders (herein defined as "Limited Shares",
together with the Unlimited Shares, herein defined as the "Ordinary Shares") and one (1) Class A mandatory redeemable
preferred share of the MRPS Shareholder ("Class A MRPS"), all in registered form with a nominal value of fifty-five Canadian
Dollars ninety cents (CAD 55.90) each, all subscribed and fully paid-up. "
<i>Valuation - Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately three thousand euro (3,000.EUR).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre,
Par devant Nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
1. Exeter Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son
siège social à 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de
CAD 35.001,-, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro R.C.S. B
156.563 (l'"Actionnaire Commanditaire" et l'"Actionnaire Commandité 1"); et
2. Otis Canada, Inc., une société constituée selon les lois d'Ontario (Canada), ayant son siège social à 4475 North
Service Road, Suite 200 Burlington ON L7L 4X7 Canada, enregistrée auprès du Registre des Sociétés canadien sous le
numéro 001442734 (l'"Actionnaire Commandité 2" et l'"Actionnaire MRPS", ensemble avec l'Actionnaire Commanditaire
et l'Actionnaire Commandité 1, les "Actionnaires")
représentée par Alexander Koch, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg) en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui, après avoir été paraphée et signée «ne varietur» par le
mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Les parties comparantes, mentionnées ci-dessus, agissant en leur qualité d'actionnaires Fairfield Exeter Luxembourg
S.C.A.., une société en commandite par actions constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 46A,
avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Société de Luxembourg sous le numéro R.C.S. B 156.493 suivant acte notarié de Maître Léonie Grethen, notaire
résidant à Luxembourg, en date du 5 novembre 2010 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2688 du 7 décembre 2010 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifié pour la dernière
fois par Maître Léonie Grethen, précité, le 3 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 379 du 25 février 2011.
Lesquelles parties, représentés comme mentionné ci-dessus, ont été informées des résolutions prises selon l'agenda
suivant:
<i>Agendai>
1. L'augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux millions sept cent quarante-cinq mille cinquante-
quatre dollars canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 2.745.054,90), afin d'augmenter le capital souscrit de son
montant actuel de cinquante mille un dollars canadiens (CAD 50.001,-) représenté par vingt mille (20.000) actions de
l'Actionnaire Commanditaire, trente mille (30.000) actions des Actionnaires Commandités et une (1) classe A action
préférentielle obligatoirement rachetable, ayant une valeur nominale d'un dollar canadien (CAD 1,-) chacune, à deux
millions sept cent quatrevingt-quinze mille cinquante-cinq dollars canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD
2.795.055,90) divisé en vingt mille (20.000) actions de l'Actionnaire Commanditaire, trente mille (30.000) actions de
9288
L
U X E M B O U R G
l'Actionnaire Commandité et une (1) classe A action préférentielle obligatoirement rachetable, ayant une valeur nominale
de cinquante-cinq dollars canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 55,90) chacune, sans émettre de nouvelles actions.
2. Augmenter la valeur nominale des vingt mille (20.000) actions de l'Actionnaire Commanditaire, trente mille (30.000)
actions des Actionnaires Commandités et d'une (1) classe A action préférentielle obligatoirement rachetable d'un montant
d'un dollar canadien (CAD 1,-) chacune, pour augmenter la valeur nominale actuelle d'un montant de cinquante-quatre
dollars canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 54,90) à un montant de cinquante-cinq dollars canadiens et quatre-
vingt-dix centimes (CAD 55,90) chacune.
3. Accepter l'apport en numéraire d' Exeter Luxembourg S.à r.l. d'un montant d'un million neuf cent vingt et un mille
cinq cent dollars canadiens (CAD 1.921.500,-) pour augmenter la valeur nominale des vingt mille (20.000) actions de
l'Actionnaire Commanditaire et des quinze mille (15.000) actions de l'Actionnaire Commandité détenues par Exeter
Luxembourg S.à r.l.
4. Accepter l'apport en numéraire d' Otis Canada, Inc. d'un montant de huit cent vingt-trois mille cinq cent cinquante-
quatre dollars canadiens et quatre-vingtdix centimes (CAD 823.554,90) pour augmenter la valeur nominale des quinze
mille (15.000) actions de l'Actionnaire Commandité et d'une (1) classe A action préférentielle obligatoirement rachetable
détenues par Otis Canada, Inc.
5. Modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions adoptées sous les précédents points.
Divers. Les comparants, représentés comme susmentionné, ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires DECIDENT d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux millions sept cent
quarante-cinq mille cinquante-quatre dollars canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 2.745.054,90), afin d'augmenter
le capital souscrit de son montant actuel de cinquante mille un dollars canadiens (CAD 50.001,-) représenté par vingt
mille (20.000) actions de l'Actionnaire Commanditaire (les "Actions Commanditaires"), trente mille (30.000) actions des
Actionnaires Commandités (les "Actions Commanditées") et une (1) classe A action préférentielle obligatoirement ra-
chetable (la "Classe A APOR"), ayant une valeur nominale d'un dollar canadien (CAD 1,-) chacune, à deux millions sept
cent quatre-vingt-quinze mille cinquante-cinq dollars canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 2.795.055,90) divisé
en vingt mille (20.000) actions de l'Actionnaire Commanditaire, trente mille (30.000) actions de l'Actionnaire Commandité
et une (1) classe A action préférentielle obligatoirement rachetable, ayant une valeur nominale de cinquante-cinq dollars
canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 55,90) chacune, sans émettre de nouvelles actions.
<i>Seconde résolutioni>
Les Actionnaires DECIDENT d'augmenter la valeur nominale des Actions Commanditées, des Actions Commanditaires
et de la Classe A APOR, d'un montant d'un dollar canadien (CAD 1,-) chacune, pour augmenter la valeur nominale de
chacune d'un montant de cinquante-quatre dollars canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 54,90) chacune, à cin-
quante-cinq dollars canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 55,90) chacune.
<i>Paiementi>
Ensuite a comparu Alexander Koch, susmentionné, agissant ès qualité de mandataire dûment autorisé de l'Associé
Unique, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Actionnaire Commandité 1 et de l'Actionnaire Com-
manditaire, à la libération intégrale du montant nécessaire à l'augmentation de la valeur nominale des vingt mille (20.000)
Actions Commanditaires et aux quinze mille (15.000) Actions Commanditées détenues par l'Actionnaires Commanditaire
et l'Actionnaire Commandité 1, d'un montant d'un dollar canadien (CAD 1,-) chacune, d'un montant de cinquante-quatre
dollars canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 54,90) chacune, à un montant de cinquante-cinq dollars canadiens
et quatre-vingt-dix centimes (CAD 55,90) chacune, par à un apport en numéraire d'un montant total d'un million neuf
cent vingt et un mille cinq cent dollars canadiens (CAD 1.921.500,-).
Ensuite a comparu Alexander Koch, susmentionné, agissant ès qualité de mandataire dûment autorisé de l'Actionnaire
Commandité 2 et l'Actionnaire MRPS, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Actionnaire Commandité 2 et l'Actionnaire MRPS, à
la libération intégrale du montant nécessaire à l'augmentation de la valeur nominale des quinze mille (15.000) Actions
Commanditées et d'une (1) Classe A APOR, détenues par l'Actionnaire Commandité 2 et l'Actionnaire MRPS d'un mon-
tant d'un dollar canadien (CAD 1,-) chacune, d'un montant de cinquante-quatre dollars canadiens et quatre-vingt-dix
centimes (CAD 54,90) chacune, à un montant de cinquante-cinq dollars canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD
55,90) chacune, par à un apport en numéraire d'un montant total de huit cent vingt-trois mille cinq cent cinquante-quatre
dollars canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 823.554,90).
La preuve desdits paiements en numéraire a été donnée au notaire instrumentant qui énonce que les conditions définies
à l'article 27 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, modifiée depuis, ont été
respectées et se porte témoin du respect de ces conditions.
9289
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés DECIDENT de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui devra désormais être lu de la manière
suivante:
" Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à deux millions sept cent quatre-vingt-quinze mille cinquante-cinq dollars
canadiens et quatre-vingt-dix centimes (CAD 2.795.055,90), représenté par vingt mille (20.000) actions de l'actionnaire
commanditaire (définies ci après comme les "Actions Commanditaires"), trente mille (30.000) actions des actionnaires
commandités (définies ci après comme les "Actions Commanditées", et ensemble avec les Actions Commanditaires, ci
après définies les "Actions Ordinaires") et une (1) classe A action préférentielle obligatoirement rachetable (la "Classe A
APOR"), toutes étant des actions nominatives, avec une valeur nominale de cinquante-cinq dollars canadiens et quatre-
vingt-dix centimes (CAD 55,90) chacune".
<i>Evaluation - Fraisi>
Les frais, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ trois mille euros
(3.000,-EUR).
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu'à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Et après lecture faite au comparant, le comparant susmentionné a signé avec Nous, le notaire instrumentant le présent
acte.
Signé: Koch, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53582. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172435/223.
(110200617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Avanza S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 544.252,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.744.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175033/11.
(110203673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
ProLogis Poland LXXIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 126.986.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2011.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011174852/14.
(110204072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
9290
L
U X E M B O U R G
ProLogis Poland LXXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 126.999.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2011.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011174853/14.
(110204075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
ProLogis Poland XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 84.435.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 octobre 2011.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011174854/14.
(110204076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Asari S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 72.957.
EXTRAIT
Il résulte d’un changement d’adresse que CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., commissaire en charge du contrôle de
nos comptes, est désormais domicilié 1, rue des Glacis à L-1628 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175024/12.
(110203805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
ProLogis UK CCXLV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.971.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2011.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011174856/14.
(110204097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
9291
L
U X E M B O U R G
W2005/W2007 Vernal Asset 1 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 127.368.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 31 décembre 2010, a décidé d'accepter:
Rectificatif suite au dépôt du 12/01/20011 n° L 110006986.05 aux fins d'inscription au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg et de publication au Mémorial C:
La démission de:
- Marcus Vennekens, en qualité de gérant de la Société avec effet au 1
er
janvier 2011;
- Nicole Götz, en qualité de gérant de la Société avec effet au 1
er
janvier 2011;
- Maxime Nino, en qualité de gérant de la Société avec effet au 1
er
janvier 2011;
- Véronique Menard, en qualité de gérant de la Société avec effet au 1
er
janvier 2011;
- Fabrice Hablot, en qualité de gérant de la Société avec effet au 1
er
janvier 2011;
- Michael Furth, en qualité de gérant de la Société avec effet au 1
er
janvier 2011.
La nomination avec effet au 1
er
janvier 2011 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de:
- Whitehall European RE 4 S.à r.l., ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.511;
- Whitehall European RE 5 S.à r.l., ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.509;
- Whitehall European RE 6 S.à r.l., ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B128.510;
- Facts Services S.A., ayant son adresse professionnelle au 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg et enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 98.790.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1
er
janvier 2011, composé comme suit:
- Whitehall European RE 4 S.à r.l., gérant
- Whitehall European RE 5 S à r.l., gérant
- Whitehall European RE 6 S.à r.l., gérant
- Facts Services S.A., gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Whitehall European RE 4 S.à r.l.
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011174948/37.
(110204234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Assisteo International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 139.839.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2011.i>
- est nommé au poste d'administrateur unique la société EASTMAN EUROPE S.A., sise au 24, rue Saint Mathieu L-2138
Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101.658, avec comme
représentant permanent Monsieur Frédéric MONCEAU, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu L-2138
Luxembourg.
Le mandat de l'administrateur unique viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
Pour extrait sincère et conforme
Eastman Europe S.A.
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011175026/16.
(110204589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
9292
L
U X E M B O U R G
Association N. Arend & C. Fischbach S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 122.596.
Les documents de clôture de l'année 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch.
<i>Pour ASSOCIATION N.AREND & C.FISCHBACH S.A.
i>Arend Consult S.à r.l., Mersch
Signature
Référence de publication: 2011175027/13.
(110205067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Gavilon Luxembourg HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.841.916,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 138.880.
In the year two thousand and eleven, on the ninth of December.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Gavilon International HoldCo, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of the Dela-
ware, the United States of America, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808, the United States of America, and registered with the Delaware Secretary of State’s office under number 4541229
(hereafter the “Appearing Company”), here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address
at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 8
th
, 2011.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the Appearing Company and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Appearing Company, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The Appearing Company is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg
under the name of Gavilon Luxembourg HoldCo S.à r.l. (hereafter the “Company”), registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 138.880, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and incorporated by a deed of notary Maître Martine
Schaeffer dated May 19
th
, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial C”)
number 1508 of June 18
th
, 2008, and whose bylaws have been lastly amended pursuant to a deed of the undersigned
notary dated August 26
th
, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial C”)
number 2558 of October 21
st
, 2011.
II. The Company’s share capital is set at nineteen million, nine hundred and sixty-four thousand, two hundred and
three Euro (EUR 19,964,203.-) represented by nineteen million, nine hundred and sixty-four thousand, two hundred and
three (19,964,203) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, in registered form, all subscribed and fully
paid-up.
III. The Appearing Company, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Appearing Company resolved to increase the share capital of the Company to the extent of ten million, eight
hundred and seventy-seven thousand, seven hundred and thirteen Euro (EUR 10,877,713.-) in order to raise it from its
present amount of nineteen million, nine hundred and sixty-four thousand, two hundred and three Euros (EUR
19,964,203.-) to thirty million, eight hundred and forty-one thousand, nine hundred and sixteen Euro (EUR 30,841,916.-),
by creation and issue of ten million, eight hundred and seventy-seven thousand, seven hundred and thirteen (10,877,713)
new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, to be divided in the different Company’s classes of shares
as follows:
- six thousand, nine hundred and thirty-one (6,931) class A shares (the “Class A Shares”), with a nominal value of one
Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- one million, two hundred and seven thousand, eight hundred and sixtyfour (1,207,864) class B shares (the “Class B
Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
9293
L
U X E M B O U R G
- one million, two hundred and seven thousand, eight hundred and sixtyfour (1,207,864) class C shares (the “Class C
Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- one million, two hundred and seven thousand, eight hundred and sixtyfour (1,207,864) class D shares (the “Class D
Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- one million, two hundred and seven thousand, eight hundred and sixtyfour (1,207,864) class E shares (the “Class E
Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- one million, two hundred and seven thousand, eight hundred and sixtyfour (1,207,864) class F shares (the “Class F
Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- one million, two hundred and seven thousand, eight hundred and sixtyfour (1,207,864) class G shares (the “Class G
Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- one million, two hundred and seven thousand, eight hundred and sixtyfour (1,207,864) class H shares (the “Class H
Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- one million, two hundred and seven thousand, eight hundred and sixtyfour (1,207,864) class I shares (the “Class I
Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up; and
- one million, two hundred and seven thousand, eight hundred and seventy (1,207,870) class J shares (the “Class J
Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
<i>Subscription - Paymenti>
The Appearing Company, prenamed, declared to subscribe to the entirety of the ten million, eight hundred and seventy-
seven thousand, seven hundred and thirteen (10,877,713) new Class A, B, C, D, E, F, G, H, I and J Shares for ten million,
eight hundred and seventy-seven thousand, seven hundred and thirteen Euro (EUR 10,877,713.-), along with the allocation
of six Euro and forty-two cents (EUR 6.42) to the legal reserve account of the Company, and have them fully paid up
along with the allocation to the legal reserve by a contribution in cash in the amount of ten million, eight hundred and
seventy-seven thousand, seven hundred and nineteen Euro and forty-two cents (EUR 10,877,719.42), so that from now
on the Company has at its free and entire disposal this amount, as was certified to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
Pursuant to the above resolution, article 5.1 of the Company’s articles of incorporation is amended and shall henceforth
read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty million, eight hundred and forty-one thousand, nine hundred and sixteen Euro
(EUR 30,841,916.-), represented thirty million, eight hundred and forty-one thousand, nine hundred and sixteen
(30,841,916) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, which are divided into:
- nineteen thousand, six hundred and fifty-three (19,653) class A shares (the “Class A Shares”), with a nominal value
of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- three million, four hundred and twenty-four thousand, six hundred and ninety-four (3,424,694) class B shares (the
“Class B Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- three million, four hundred and twenty-four thousand, six hundred and ninety-four (3,424,694) class C shares (the
“Class C Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- three million, four hundred and twenty-four thousand, six hundred and ninety-four (3,424,694) class D shares (the
“Class D Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- three million, four hundred and twenty-four thousand, six hundred and ninety-four (3,424,694) class E shares (the
“Class E Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- three million, four hundred and twenty-four thousand, six hundred and ninety-four (3,424,694) class F shares (the
“Class F Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- three million, four hundred and twenty-four thousand, six hundred and ninety-four (3,424,694) class G shares (the
“Class G Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- three million, four hundred and twenty-four thousand, six hundred and ninety-four (3,424,694) class H shares (the
“Class H Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
- three million, four hundred and twenty-four thousand, six hundred and ninety-four (3,424,694) class I shares (the
“Class I Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up; and
- three million, four hundred and twenty-four thousand, seven hundred and eleven (3,424,711) class J shares (the “Class
J Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
(hereafter each referred to as the “Class of Shares” and collectively as the “Classes of Shares”)."
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above Appearing
Company, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same Appearing Company and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
9294
L
U X E M B O U R G
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the Appearing Company, who is known to the notary by her
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L’an deux mille onze, le neuf décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Gavilon International HoldCo, LLC, une société constituée et régie par les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis
d’Amérique, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle, 19801 Delaware, les
Etats-Unis d’Amérique, et enregistrée auprès du Département de l’Etat du Delaware, Division des Sociétés, sous le
numéro 4541229 (ci-après la «Comparante»), représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, ayant son adresse
professionnelle au 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing
privé donnée le 8 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire de la Comparante et le notaire instru-
mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
La Comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La Comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie au Luxembourg sous la dénomination
de Gavilon Luxembourg HoldCo S.à r.l. (ci-après la «Société»), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.880, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Martine Schaeffer, daté du 19 mai 2008, publié au
Mémorial C «Recueil des Sociétés et Associations» numéro 1508 du 18 juin 2008, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 aout 2011, publié au Mémorial C
«Recueil des Sociétés et Associations» numéro 2558 du 21 octobre 2011.
II. Le capital social de la Société est fixé à dix-neuf millions, neuf cent soixante-quatre mille, deux cent trois Euros (EUR
19.964.203,-) représenté par dix-neuf millions, neuf cent soixante-quatre mille, deux cent trois (19.964.203) parts sociales
ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.
III. La Comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La Comparante a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de dix millions, huit cent soixante-dix-sept mille,
sept cent treize Euros (EUR 10.877.713,-) pour le porter de son montant actuel de dix-neuf millions, neuf cent soixante-
quatre mille, deux cent trois Euros (EUR 19.964.203,-) à trente millions, huit cent quarante-et-un mille, neuf cent seize
Euros (EUR 30.841.916,-) par la création et l’émission de dix millions, huit cent soixante-dix-sept mille, sept cent treize
(10.877.713) nouvelles parts sociales, devant être divisées en différentes classes de parts sociales comme suit:
- Six mille, neuf cent trente-et-une (6.931) «Parts Sociales de Classe A» d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-)
chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Un million, deux cent sept mille, huit cent soixante-quatre (1.207.864) «Parts Sociales de Classe B» d’une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Un million, deux cent sept mille, huit cent soixante-quatre (1.207.864) «Parts Sociales de Classe C» d’une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Un million, deux cent sept mille, huit cent soixante-quatre (1.207.864) «Parts Sociales de Classe D» d’une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Un million, deux cent sept mille, huit cent soixante-quatre (1.207.864) «Parts Sociales de Classe E» d’une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Un million, deux cent sept mille, huit cent soixante-quatre (1.207.864) «Parts Sociales de Classe F» d’une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Un million, deux cent sept mille, huit cent soixante-quatre (1.207.864) «Parts Sociales de Classe G» d’une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Un million, deux cent sept mille, huit cent soixante-quatre (1.207.864) «Parts Sociales de Classe H» d’une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Un million, deux cent sept mille, huit cent soixante-quatre (1.207.864) «Parts Sociales de Classe I» d’une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées; et
- Un million, deux cent sept mille, huit cent soixante-dix (1.207.870) «Parts Sociales de Classe J» d’une valeur nominale
d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.
9295
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription - Libérationi>
La Comparante, prénommée, a déclaré souscrire à l’entièreté des dix millions, huit cent soixante-dix-sept mille, sept
cent treize (10.877.713) nouvelles parts sociales de classe A, B, C, D, E, F, G, H, I et J d’une valeur de dix millions, huit
cent soixantedix-sept mille, sept cent treize Euros (EUR 10.877.713,-) ainsi qu’à une allocation de six Euros et quarante-
deux centimes (EUR 6,42) à la réserve légale de la Société, et les libérer intégralement, ensemble avec l’allocation à la
réserve légale, par apport en numéraire de dix millions, huit cent soixante-dix-sept mille, sept cent dix-neuf Euros et
quarante-deux centimes (EUR 10.877.719,42), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition
cette somme ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions ci-dessus, l’Article 5.1 des statuts de la Société est modifié et dorénavant se lit comme suit:
« Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à trente millions, huit cent quarante-et-un mille, neuf cent seize Euros (EUR 30.841.916,-)
représenté par trente millions, huit cent quarante-et-un mille, neuf cent seize (30.841.916) parts sociales ayant une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, divisées de la manière suivante:
- Dix-neuf mille, six cent cinquante-trois (19.653) «Parts Sociales de Classe A» d’une valeur nominale d’un Euro (EUR
1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Trois millions, quatre cent vingt-quatre mille, six cent quatre-vingtquatorze (3.424.694) «Parts Sociales de Classe B»
d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Trois millions, quatre cent vingt-quatre mille, six cent quatre-vingtquatorze (3.424.694) «Parts Sociales de Classe C»
d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Trois millions, quatre cent vingt-quatre mille, six cent quatre-vingtquatorze (3.424.694) «Parts Sociales de Classe D»
d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Trois millions, quatre cent vingt-quatre mille, six cent quatre-vingtquatorze (3.424.694) «Parts Sociales de Classe E»
d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Trois millions, quatre cent vingt-quatre mille, six cent quatre-vingtquatorze (3.424.694) «Parts Sociales de Classe F»
d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Trois millions, quatre cent vingt-quatre mille, six cent quatre-vingtquatorze (3.424.694) «Parts Sociales de Classe G»
d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Trois millions, quatre cent vingt-quatre mille, six cent quatre-vingtquatorze (3.424.694) «Parts Sociales de Classe H»
d’une valeur nominale d’un Euro (1,-EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- Trois millions, quatre cent vingt-quatre mille, six cent quatre-vingtquatorze (3.424.694) «Parts Sociales de Classe I»
d’une valeur nominale d’un Euro (1,-EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées; et
- Trois millions, quatre cent vingt-quatre mille, sept cent onze (3.424.711) «Parts Sociales de Classe J» d’une valeur
nominale d’un Euro (1,-EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées.
(Ci-après désignées chacune comme la Classe de Parts Sociales ou collectivement comme les Classes de Parts Socia-
les).»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la Comparante le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même Comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des
présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la Comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 12 décembre 2011. Relation: ECH/2011/2165. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 15 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172452/204.
(110200572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
9296
L
U X E M B O U R G
Atelier Nord, Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 20, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 109.330.
Le Bilan au 30 septembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175029/9.
(110204654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Athor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 154.258.
<i>Extrait des résolutions prises lors du l'assemblée générale extraordinaire tenu au siège social le 09 décembre 2011:i>
1) L'Assemblée décide de transférer avec effet au 09 décembre 2011 le siège social de la société au 60, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg.
2) L'Assemblée décide d'accepter les démissions, avec effet au 09 décembre 2011, des administrateurs suivants:
- Monsieur Daniel GALHANO, demeurant professionnellement au 54, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Laurent TEITGEN, demeurant professionnellement au 54, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Mike ABREU PAIS, demeurant professionnellement 54, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
3) L'Assemblée décide d'accepter les nominations, avec effet au 09 décembre 2011, de son poste d'administrateur de
la société pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
des Actionnaires de la Société devant se tenir en 2016:
- Monsieur Vincenzo Beniamino L Tutino, demeurant professionnellement au 60, Avenue de la Liberté, L-1930 Lu-
xembourg;
- Monsieur Tim Marc Florent Hubar, demeurant professionnellement au 60, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Mademoiselle Elisa Lessard, demeurant professionnellement au 60, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
4) L'assemblée décide de nommer à la fonction d'administrateur-délégué, Monsieur Vincenzo Beniamino L Tutino, né
le 17 mai 1967 à Positano, Italie et résidant professionnellement au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Ad-
ministrateur délégué de la Société avec effet au 09 décembre 2011 pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire statutaire devant se tenir en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ATHOR S.A.
Référence de publication: 2011175030/27.
(110204996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Automobiles Pierri Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5811 Fentange, 134, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 105.548.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175031/10.
(110204281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Autopol S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9011 Ettelbruck, 170A, rue de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 93.119.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175032/10.
(110203998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
9297
L
U X E M B O U R G
Aviation Hodling S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 143.780.
Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175034/9.
(110205156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
B.R.E.S. Investigations S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-8094 Bertrange, 36, rue de Strassen.
R.C.S. Luxembourg B 148.048.
Le bilan approuvé au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175041/10.
(110204400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Bargo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 122.769.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175042/9.
(110204483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Bargo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 122.769.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011175043/9.
(110204484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Bertelsmann Digital Media Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 10.088.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011175049/12.
(110204629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Grand Duchy L.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1645 Luxembourg, 6, Montée du Grund.
R.C.S. Luxembourg B 165.319.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the eighth of December,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
9298
L
U X E M B O U R G
there appeared
Mr Paul Mousel, licencié en droit, born on 15 October 1953 in Luxembourg, residing professionally at L-1468 Lu-
xembourg, 14, rue Erasme,
duly represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given in Luxembourg on 7 December 2011.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party, represented as stated above, has drawn up the following articles of incorporation of a société
anonyme, which they declare organised among themselves as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. There exists a company in the form of a société anonyme, under the name of “Grand Duchy L.F. S.A.”.
Art. 2. The company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The purpose of the company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
The company may further guarantee, grant loans, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which
it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the company.
The company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. Within the same municipality, the
registered office of the company may be transferred by resolution of the board of directors. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at two hundred and fifty thousand euro (EUR 250,000) consisting of two hundred
and fifty (250) shares having a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of share-
holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. The company may, to the
extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder (or
any other shareholder) shall not lead to the dissolution of the company.
Art. 7. The shares of the company are in registered form.
A shareholders’ register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.
This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing commercial
companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register. Certificates of
these recordings shall be issued and signed by two directors upon request of the relevant shareholder.
The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company.
The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated
as the sole owner in relation to the company.
C. General meetings of shareholders
Art. 8. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-
holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of
the company. If the company has only one single shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general
meeting of shareholders.
The general meeting is convened by the board of directors.
It must be convened following the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the company's
share capital. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the company's share capital may request the
adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be addressed
to the company’s registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.
Art. 9. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the company,
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of the month of
9299
L
U X E M B O U R G
May at 3.00 p.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting. The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings
of shareholders of the company, unless otherwise provided herein.
Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing
their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.
Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the company’s registered office or to
the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the company and
which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the
decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against,
or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void.
The company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.
Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the votes validly cast,
regardless of the portion of capital present or represented, unless the item to be resolved upon relates to an amendment
of the articles of incorporation, in which case the resolution will be passed with a majority of the two thirds of the votes
validly cast at the meeting where at least half of the share capital is present or represented on first call. On second call,
the resolution will be passed with a majority of the two thirds of the votes validly cast at the meeting, regardless of the
portion of capital present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
D. Board of directors
Art. 10. The company shall be managed by a board of directors consisting of three members at least (who need not
be shareholders of the company). However, if the company is incorporated by one single shareholder or if it is noted at
a shareholders’ meeting that all the shares issued by the company are held by one single shareholder, the company may
be managed by one single director until the first annual shareholders’ meeting following the moment where the company
has noted that its shares are held by more than one shareholder. The directors shall be elected by the general meeting
of shareholders, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director
may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors may be re-elected
for successive terms.
The directors are elected by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast. Any
director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority
of the votes validly cast.
If a legal entity is appointed as director of the company, such legal entity must designate a permanent representative
who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its
permanent representative if it appoints his successor at the same time.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.
Art. 11. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature), except
in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This
notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile or by any other means of communication,
a copy being sufficient. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.
9300
L
U X E M B O U R G
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,
by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may represent one or more of
his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or video-conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held through such means of com-
munication is deemed to be held at the registered office of the company.
The board of directors can deliberate or act validly only if half of the directors are present or represented at a meeting
of the board of directors.
Decisions shall be taken only with the approval of a majority of the directors present or represented at the meeting.
The chairman does not have a casting vote.
The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of an original signature by mail,
facsimile or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the
signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the
passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
Art. 12. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman, or by two directors.
Art. 13. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the company's interest. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of
shareholders fall within the powers of the board of directors.
In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the daily
management of the company, as well as the representation of the company in relation with this management may be
delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their
appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.
The company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 14. The company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily management) by (i) the
joint signatures of any two directors of the company or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the sole
director or (iii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has
been granted by the board of directors or the sole director, but only within the limits of such power
E. Supervision of the company
Art. 15. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be sha-
reholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. The statutory auditor(s) may be re-appointed
for successive terms.
F. Financial year - Profits
Art. 16. The accounting year of the company shall begin on the 1
st
of January of each year and shall terminate on the
31
st
of December of the same year.
Art. 17. From the annual net profits of the company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article
5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by the board of directors by observing the terms and conditions provided for by
law.
The share premium is freely distributable to the shareholders by the shareholders' meeting in accordance with article
72-1 or by the board of directors in accordance with article 72-2 of the law of 10 August 1915 governing commercial
companies.
9301
L
U X E M B O U R G
G. Liquidation
Art. 18. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
H. Amendment of the articles of incorporation
Art. 19. These articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
under the conditions of quorum provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies,
as amended.
I. Final clause - Applicable law
Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the company and shall terminate on 31
December 2012.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
Mr Paul Mousel, aforementioned, here represented by Mr Frank Stolz-Page, aforementioned, declares to subscribe all
the two hundred and fifty (250) shares and to fully pay them up in cash so that the amount of two hundred and fifty
thousand euro (EUR 250,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been
fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800).
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at one (1) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following person is appointed as sole director of the Company:
Mr Christiaan Joseph Maria van den Ameele, born on 7 June 1966 in Bergen op Zoom, The Netherlands, residing
professionally at 6, Montée du Grund, L-1645 Luxembourg;
3. The following person is appointed as statutory auditor of the Company:
Mr Henricus Marinus Thijssen, born on 11 March 1961 in Breda, The Netherlands, residing professionally at 6, Montée
du Grund, L-1645 Luxembourg.
4. The registered address of the company is set at 6, Montée du Grund, L1645 Luxembourg.
5. The term of office of the sole director and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve
the accounts of the accounting year 2016 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may
determine.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing person, this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be
prevailing.
Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, said proxyholder appearing signed to-
gether with the notary this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes
Im Jahre zweitausendelf, den achten Dezember,
9302
L
U X E M B O U R G
vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,
ist erschienen
Herr Paul Mousel, Rechtsanwalt, geboren am 15. Oktober 1953 in Luxemburg, geschäftsansässig in 14, rue Erasme,
L-1468 Luxemburg,
rechtmäßig vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, geschäftsansässig in 14, rue Erasme, L-1468
Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht mit Untervollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 7. Dezember 2011.
Die Vollmacht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft,
die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
A. Name - Sitz - Dauer - Zweck
Art. 1. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft welche die Bezeichnung „Grand Duchy L.F. S.A.“ führt.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit errichtet.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in-und ausländischen Gesellschaften und
sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann ferner Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche
der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Kredite gewähren, für diese Gesellschaften bürgen, zu ihren
Gunsten Garantien geben und Sicherheiten stellen oder sie auf andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann ferner als Kommanditär oder Komplementär mit beschränkter oder unbeschränkter Haftung
gegenüber allen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen von Personengesellschaften oder ähnlichen Gesellschaftsformen
handeln.
Die Gesellschaft kann für sich selbst oder für Dritte alle Tätigkeiten vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke
förderlich erscheinen oder direkt oder indirekt mit diesen in Verbindung stehen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb
der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates
können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, ge-
gründet werden.
B. Kapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000) und ist in zweihundert-
fünfzig (250) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000) eingeteilt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, ent-
sprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft
kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Der Tod oder die Auflösung des alleinigen Akti-
onärs (oder von einem anderen Aktionär) führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.
Art. 7. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses
Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie
abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.
Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im Register be-
stätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an den Aktien aufgeteilt sein, müssen
diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 8. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat
jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft. Wenn die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übt dieser die Rechte der Hauptversammlung aus.
Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.
9303
L
U X E M B O U R G
Sie muss auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals vertreten, einberufen
werden. Aktionäre, die wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, können einen oder meh-
rere Punkte der Tagesordnung hinzufügen. Eine solche Anfrage muss wenigstens fünf (5) Tage vor der Versammlung per
Einschreibebrief an den Sitz der Gesellschaft gesendet werden.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der
Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am letzten Freitag des Monat Mai um 15.00 Uhr.
Wen dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet die jährliche Generalversammlung, am nächsten darauf folgenden Werktag
statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten
einberufen werden. Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft
werden von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, sofern diese Satzung keine ander-
weitigen Bestimmungen trifft.
Aktionäre können an der Versammlung durch Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunika-
tionsmittel teilnehmen. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Kommunikationsmittel müssen allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlauben, sich durchgehend
untereinander zu hören, sowie effektiv an der Sitzung teilzunehmen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per
Faksimileübertragung oder durch jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Drit-
ten vertreten lassen.
Jeder Aktionär kann durch Wahlformulare wählen, die per Post oder per Faksimileübertragung an den Sitz der Ge-
sellschaft oder an eine andere im Einberufungsschreiben angegebene Adresse zu senden sind. Die Aktionäre können dabei
nur die von der Gesellschaft ausgestellten Wahlformulare benutzen, die zumindest den Ort, das Datum, die Uhrzeit, die
Tagesordnung und den der Versammlung zum Beschluss vorgelegten Vorschlag enthalten. Für jeden Vorschlag soll das
Wahlformular drei Felder enthalten, die es dem Aktionär erlauben, durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes für oder gegen
den Vorschlag zustimmen, beziehungsweise sich der Stimme zu enthalten.
Wahlformulare, die weder eine Stimmabgabe für den Vorschlag, gegen den Vorschlag, noch eine Stimmenthaltung
enthalten, sind ungültig. Die Gesellschaft nimmt nur Wahlformulare an, die sie vor der Versammlung erhalten hat, auf die
sich das betreffende Wahlformular bezieht.
Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden unabhängig von dem auf der Haupt-
versammlung anwesenden oder vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital durch die einfache Mehrheit der gültigen
Stimmen gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen, die eine Abänderung der Satzung mit sich bringen und in diesem Fall
durch eine Mehrheit von zwei Dritteln der gültigen Stimmen auf einer ersten Hauptversammlung gefasst werden, bei der
wenigstens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist. Bei einer zweiten Hauptversammlung, wird
der Beschluss durch eine Mehrheit von zwei Dritteln der gültigen Stimmen gefasst unabhängig von dem anwesenden oder
vertretenen Anteil des Gesellschaftskapitals.
Der Geschäftsführer kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,
um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.
Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu ken-
nen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
D. Verwaltungsrat
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen
muss (die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen). Falls die Gesellschaft jedoch durch einen einzigen Aktionär
gegründet wird oder falls in einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass ein Aktionär sämtliche Aktien der Gesellschaft
hält, kann die Gesellschaft durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geführt werden; dies gilt bis zu dem Zeitpunkt der
jährlichen Hauptversammlung, die stattfindet, nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien durch mehr als
einen Aktionär gehalten werden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre
gewählt, welche ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates festsetzt.. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden
für die Dauer eines Mandates, welches sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung
des Nachfolgers endet, gewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Aktionäre gewählt.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann zu jeder Zeit ohne Grund durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der
Hauptversammlung abberufen werden.
Für den Fall, dass eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied bestellt wird, muss diese juristische Person einen
ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juris-
tische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann widerrufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger bestellt.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so
kann das freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt
werden.
9304
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,
einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des
Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist.
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat
mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen
zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift) ein Einberufungsschrei-
ben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungs-
schreiben angegeben werden müssen. Bei einer schriftlichen, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebenen Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates
kann auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für
Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faksi-
mileübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein
anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungs-
ratsmitglieder vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenzschaltung oder
durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung
kann alle anderen verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an
dieser Sitzung. Eine mit derartigen Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft durch-
geführt angesehen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse werden nur durch die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst. Dem Vorsitzenden steht keine
entscheidende Stimme zu.
Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen
gefasst werden; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt und als
Datum dieser Beschlüsse gilt das Datum der letzten Unterschrift.
Art. 12. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge
der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 13. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs-und Verfü-
gungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse,
welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.
Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können gemäß
Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein oder mehrere Mitglieder
des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche nicht Aktio-
näre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung,
Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt.
Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Voll-
macht übertragen.
Art. 14. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten (inklusive die täglichen Geschäftsführung) verpflichtet
durch: (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder (ii) im Falle eines alleinigen
Verwaltungsrates, durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Verwaltungsrates oder (iii) die alleinige Unterschrift des
von dem Verwaltungsrat ernannten Alleinvertretungsbevollmächtigten oder die gemeinsame Unterschrift der von dem
Verwaltungsrat ernannten vertretungsbevollmächtigten Personen.
E. Überwachung der Gesellschaft
Art. 15. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre
der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre
Vergütung und die Dauer ihres Mandates, das sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer können
mehrmals hintereinander ernannt werden.
9305
L
U X E M B O U R G
F. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen
Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie
gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.
Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des rest-
lichen Betrages des Reingewinns.
Die Hauptversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.
Die Emissionsprämie kann den Aktionären durch die Hauptversammlung gemäß Artikel 72-1 oder durch den Verwal-
tungsrat gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, frei ausgeschüttet werden.
G. Auflösung der Gesellschaft
Art. 18. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversamm-
lung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.
H. Satzungsänderung
Art. 19. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beachtung
der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 bestimmend über Handelsgesellschaften,
wie abgeändert.
I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 20. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2013 stattfinden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Die Gründer haben die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:
Herr Paul Mousel, vorgenannt, hier vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, vorgenannt, zeichnet alle zweihundert-
fünfzig (250) Aktien zu einem Gesamtpreis von zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000).
Alle Aktien werden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen
Betrag von zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000) wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr tausendachthundert Euro (EUR 1.800).
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der Zu-
sammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer wird auf einen
(1) festgelegt.
2. Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt Herr Christiaan Joseph Maria van den Ameele, geboren am 7.
Juni 1966 in Bergen op Zoom, Niederlande, geschäftsansässig in 6, Montée du Grund, L-1645 Luxemburg;
3. Zum Rechnungsprüfer wird Herr Henricus Marinus Thijssen, geboren am 11. März 1961 in Breda, Niederlande,
geschäftsansässig in 6, Montée du Grund, L-1645 Luxemburg, ernannt.
4. Die Sitz der Gesellschaft befindet sich in 6, Montée du Grund L1645 Luxemburg.
5. Die Mandate des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds und des Rechnungsprüfers enden mit der Hauptversammlung,
die über die jährliche Konten für das Rechnungsjahr 2016 entscheidet oder zu dem von der Hauptversammlung be-
schlossenen Zeitpunkt.
9306
L
U X E M B O U R G
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am Datum wie
eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Vertreters der vor-
genannten Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der vorgenannten Partei, hat dieser mit dem
Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2011. LAC / 2011 / 54977. Reçu soixante quinze euros € 75,
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172455/454.
(110200548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Bureau d'Architecture Paul GZELLA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7435 Hollenfels, 17, Um Wandhaff.
R.C.S. Luxembourg B 89.837.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175068/10.
(110204637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Brandenburg Archie 24 Acquico 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 135.030.
Les comptes annuels au 31 Mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011175063/11.
(110205035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Brandenburg Archie 24 Acquico 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 135.038.
Les comptes annuels au 31 Mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011175064/11.
(110205034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Guardian Eastern Europe Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R.C.S. Luxembourg B 81.944.
In the year two thousand and eleven,
On the seventh day of December,
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Appeared:
9307
L
U X E M B O U R G
"Guardian Europe S.à r.l.", a “société à responsabilité limitée” under Luxembourg Law, having its registered offices in
L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under
section B and number 23.829,
represented here by Mrs Malgorzata McELFRESH, Assistant Corporate Counsel, residing in Strassen,
by virtue of a proxy given in Dudelange on 5 December 2011,
which proxy, initialed "ne varietur", shall remain attached to the present deed to be filed with the registration autho-
rities.
Such appearing party declared to be the sole shareholder of "Guardian Eastern Europe Investments S.à r.l.", a limited
liability company under Luxembourg Law, having its registered offices in L3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser,
incorporated by deed of the undersigned notary on 7 May 2001, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C", number 1071 on 27 November 2001, modified by deed of the undersigned notary on 3 October 2003,
published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 1185 on 12 November 2003, modified by
deed of the undersigned notary on 5 December 2003, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C", number 140 of 22 January 2009, modified by deed of the undersigned notary on 16 January 2009 published in the
"Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 920 of 30 April 2009, modified by deed of the undersigned
notary on 15 December 2010, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 720 of 14
April 2011, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 81,944,
hereafter "the Company".
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The sole partner decides to increase the share capital by sixtyfive million euro (EUR 65,000,000.00) in order to raise
it from the current amount of seventy-nine million twelve thousand five hundred euro (EUR 79,012,500.00) to one
hundred forty-four million twelve thousand five hundred euro (EUR 144,012,500.00) through the issue of two million six
hundred thousand (2,600,000) new shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.00) each.
All of the two million six hundred thousand (2,600,000) new shares have been subscribed by “Guardian Europe S.à
r.l.”.
All the new shares have been entirely paid up by contribution in cash, so that the amount of sixty-five million euro
(EUR 65,000,000.00) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the foregoing, the sole partner decides to amend Article five of the Articles of Incorporation of
the Company and to replace the current text by the following:
« Art. 5. The Company's share capital is set at one hundred forty-four million twelve thousand five hundred euro (EUR
144,012,500.00) represented by five million seven hundred sixty thousand five hundred (5,760,500) shares with a par
value of twentyfive euro (EUR 25.00) each.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, are estimated at about seven thousand six hundred euro (EUR
7,600.00).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of the document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze,
Le sept décembre,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
"Guardian Europe S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-3452
Dudelange, Zone Industrielle Wolser, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la
section B et le numéro 23.829,
ici représentée par Madame Malgorzata McELFRESH, «Assistant Corporate Counsel», demeurant à Strassen
en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Dudelange le 5 décembre 2011,
9308
L
U X E M B O U R G
laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare être la seule associée de la société à responsabilité
limitée "Guardian Eastern Europe Investments S.à r.l." ayant son siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wol-
ser, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 1071 du 27 novembre 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 3 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1185 du 12 novembre 2003,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 140 du 22 janvier 2009, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 16 janvier 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 920 du 30 avril 2009, modifiée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 720 du 14 avril 2011, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
sous la section B et le numéro 81.944,
ci-après" la Société".
La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-cinq millions d’euros (EUR
65.000.000,00), pour le porter de son montant actuel de soixante-dix-neuf millions douze mille cinq cents euros (EUR
79.012.500,00) à cent quarante-quatre millions douze mille cinq cents euros (EUR 144.012.500,00), par la création et
l'émission de deux millions six cent mille (2.600.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
L’intégralité des deux millions six cent mille (2.600.000) nouvelles parts sociales ont été souscrites par «Guardian
Europe S.à r.l.».
Toutes les parts sociales nouvelles ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de soixante-cinq millions d’euros (EUR 65.000.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Seconde résolution:i>
Comme conséquence de ce qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article cinq des statuts de la société
dont la teneur sera dorénavant la suivante:
" Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent quarante-quatre millions douze mille cinq cents euros (EUR
144.012.500,00), représentée par cinq millions sept cent soixante mille cinq cents (5.760.500) parts sociales d'une valeur
de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune."
<i>Estimation des frais:i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ sept mille six cents euros (EUR
7.600,00).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande de la comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivie d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre les textes français anglais, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante de la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle
a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. McElfresh, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 09 décembre 2011. Relation: LAC / 2011 /54788. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Pour expédition conforme.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172457/112.
(110200395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
9309
L
U X E M B O U R G
Brink's Security Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 8, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 10.427.
En date du 28.11.2011, l’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Michael J. Cazer de son mandat
d’administrateur et de nommer Monsieur Michael Beech, né le 1
er
aout 1961 à Massachusetts (USA), administrateur,
avec adresse professionnelle à L-1273 Luxembourg, 8, rue de Bitbourg en son remplacement comme administrateur pour
la durée d’un an.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2011175065/15.
(110204843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Badie, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 127.215.
Le bilan au 31/03/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011175069/10.
(110204494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Iguane S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 34, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 89.834.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 17 novembre 2011i>
Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
Chambre, siégeant en matière com-
merciale que les opérations de liquidation de la société IGUANE S.A. (jugement n° 1272/11), avec siège social à L-2132
Luxembourg 24 Avenue Marie-Thérèse, de fait inconnue à cette adresse, ont été déclarées closes pour absence d'actif.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Pour extrait conforme
M
e
Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011173241/16.
(110202001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Immo-Center S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 75.123.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 24 novembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société
IMMO-CENTER S.A., dont le siège social à L-3378 Livange, Centre d'Affaires " Le 2000 ", a été dénoncé en date du
29 avril 2003, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75123;
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg, et liquidateur Maître Nathalie WEBER-FRISCH, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 15 décembre 2011 au greffe de la sixième
Chambre de ce Tribunal.
9310
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Pour extrait conforme
Maître Nathalie WEBER-FRISCH
1, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011173243/23.
(110201995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Landmark S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.905.
Bestellung von Herrn Broer Kalow und Herrn Andreas Katzur in den Verwaltungsrat der Landmark S.A.
Durch die außerordentliche Generalversammlung der Landmark S.A. am 12. Dezember 2011 wurden Herr Broer
Kalow und Herr Andreas Katzur mit sofortiger Wirkung zu Verwaltungsratsmitgliedern bestellt. Die Amtszeit endet mit
der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2013, die über den Jahresabschluss 2012 beschließt. Die Berufsadresse
von Herrn Kalow und Herr Katzur lautet Valentinskamp 70 / EMPORIO, D-20355 Hamburg.
Wahl von Frau Cathrin Schwartz zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates
In seiner Sitzung vom 29. November 2011 hat der Verwaltungsrat der Landmark S.A. Frau Cathrin Schwartz zur neuen
Vorsitzenden gewählt. Herr Lutz Kandzia wird weiterhin Verwaltungsratsmitglied bleiben. Herr Matthias Gerloff bleibt
weiterhin stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender.
Rücktritt von Herrn Dr. Leinemann aus dem Verwaltungsrat
Herr Dr. Leinemann hat in der Verwaltungsratssitzung am 29. November 2011 seinen Rücktritt aus dem Verwal-
tungsrat der Landmark S.A. erklärt.
Änderung der Berufsadressen
Die Berufsadressen von Frau Cathrin Schwartz, Herrn Matthias Gerloff, Herrn Lutz Kandzia und Herrn Alexander
Eggert ändern sich von Caffamacherreihe 8, D-20355 Hamburg auf Valentinskamp 70 / EMPORIO, D-20355 Hamburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Landmark S.A.
Maria Löwenbrück / Petra Hauer
Référence de publication: 2011173726/25.
(110202261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Amrego Kapitalförvaltning AB, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 165.432.
OUVERTURE DE SUCCURSALE
<i>Extraiti>
En vertu des résolutions prises en date du 23 novembre 2011 par le conseil d'administration de la société de droit
suédois Amrego Kapitalförvaltning AB, ayant son siège social à Regeringsgatan 45, S-103 96 Stockholm, Suède, dûment
immatriculée auprès du «Bolagsverket» sous le numéro 556646-8483 (ci-après la «Société»), il a été décidé:
- d'approuver la formation d'une succursale au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «Amrego Kapi-
talförvaltning AB, Luxembourg Branch» (la «Succursale»);
- de fixer le siège de la Succursale au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;
- que les activités de la Succursale seront les services et activités d'investissement de (i) réception et transmission
d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; (ii) exécution d'ordres au nom de clients (iii) gestion de
portefeuille concernant les instruments financiers suivants: (i) valeurs mobilières et (ii) parts d'organismes de placement
collectif, conformément à la Directive 2004/39/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les
marchés d'instruments financiers, telle que modifiée et toute autre activité conforme à l'objet social de la Société allouée
spécifiquement à la Succursale;
- de nommer Monsieur Carl-Adam Högberg, avec adresse professionnelle à 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
né le 4 février 1979 à Taby, Suède, comme représentant permanent de la succursale à partir de la date d'établissement
de la Succursale et pour une durée illimitée;
9311
L
U X E M B O U R G
- que le représentant permanent de la Succursale dispose de tous les pouvoirs pour accomplir sa mission en tant que
représentant permanent unique de la Succursale;
- que le représentant permanent a le pouvoir d'engager individuellement la Succursale à l'égard des tiers et de la
représenter en justice;
- que les données concernant la Société sont les suivantes:
* Dénomination: Amrego Kapitalförvaltning AB,
* Forme: Aktiebolag
* Siège social: à Regeringsgatan 45, S-103 96 Stockholm, Suède,
* Registre: Bolagsverket
* Numéro d'immatriculation: 556646-8483
* Personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice
- par la signature conjointe de deux membres du conseil d'administration, i.e. (i) Erik Rosengren, avec adresse pro-
fessionnelle à Regeringsgatan 45, 111 56 Stockholm, Suède, né le 6 mai 1975 à Huddinge, Suède, (ii) Karl Peter Arrhenius,
avec adresse professionnelle à Neptunivägen 6, 181 63 Lidingö, Suède, né le 11 juin 1967 à Stockholm, Suède, (iii) Jan Erik
Bruneheim, avec adresse professionnelle à Heimdalsvägen 10, 182 63 Djursholm, Suède, né le 22 juillet 1954 à Kobe,
Japon, (iv) Joakim Strandberg, avec adresse professionnelle à Regeringsgatan 45, 111 56 Stockholm, Suède, né le 14
septembre 1977 à Huddinge, Suède; ou
- par la signature individuelle du directeur général i.e. Mikael Ljungberg, avec adresse professionnelle à Regeringsgatan
45, 111 56 Stockholm, Suède, né le 26 juin 1974 à Nacka, Suède.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011177014/46.
(110204618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
LOPHIRA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 46.981.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2011 a reconduit le mandat d'administrateur de Messieurs Luciano
DAL ZOTTO, Guy SCHOSSELER et Nico BECKER, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale
ordinaire annuelle de 2012.
L'Assemblée a également reconduit le mandat de Commissaire aux comptes de Madame Nathalie THUNUS, son
mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2012.
Pour extrait conforme
LOPHIRA,
Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2011173733/19.
(110202322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Boyar Estates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 81.300.
Le bilan de la société au 31/03/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011175057/12.
(110204976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
9312
Amrego Kapitalförvaltning AB, Luxembourg Branch
Annen Plus S.A.
Aparfi S.A.
Aquarelle S.A.
Aquarelle S.A.
Armacom S.A.
Asari S.A.
Assisteo International S.A.
Association N. Arend & C. Fischbach S.A.
Atelier Nord
Athor S.A.
Automobiles Pierri Sàrl
Autopol S.A.
Avanza S.à r.l.
Aviation Hodling S.A.
Badie
Bargo S.à r.l.
Bargo S.à r.l.
Bertelsmann Digital Media Investments S.A.
Bonaria et Fils
Boyar Estates S.A.
Brandenburg Archie 24 Acquico 3 S.à r.l.
Brandenburg Archie 24 Acquico 4 S.à r.l.
B.R.E.S. Investigations S.A.
Brink's Security Luxembourg S.A.
Bureau d'Architecture Paul GZELLA S.à r.l.
Fairfield Exeter Luxembourg S.C.A.
French Property HoldCo S.à r.l.
Gavilon Luxembourg HoldCo S.à r.l.
Grand Duchy L.F. S.A.
Guardian Eastern Europe Investments S.à r.l.
Iguane S.A.
Immo-Center S.A.
Landmark S.A.
LOPHIRA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
MSEOF Park Tower S.à r.l.
MSEOF Pascal Lux S.à r.l.
MSEOF Quattro Fixture-Co S.à r.l.
MSEOF Quattro S.à r.l.
MSEOF Stempelfabrik S.à r.l.
MSEOF Trianon S.à r.l.
Net Soparfi S.A.
New Café In S.à r.l.
New Media Lux S.A.
N-Media Solutions S.à r.l.
Papilux
ProLogis Poland LXIV S.à r.l.
ProLogis Poland LX S.à r.l.
ProLogis Poland LXXIII S.à r.l.
ProLogis Poland LXXIX S.à r.l.
ProLogis Poland LXXX S.à r.l.
ProLogis Poland XIX S.à r.l.
ProLogis UK CCLXVI S.à r.l.
ProLogis UK CCXLV S.à r.l.
Quartal Financial Solutions AG, succursale de Luxembourg
Quartal Financial Solutions AG, succursale de Luxembourg
Share Link 11 S.A.
Sherwin-Williams Coatings S.à r.l.
Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l.
Siman-Fass S.à r.l.
Sintonia S.A.
SKVG.Com S.à r.l.
W2005/W2007 Vernal Asset 1 Luxembourg S.à r.l.