logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 141

18 janvier 2012

SOMMAIRE

Algeco/Scotsman Group S.à r.l.  . . . . . . . . .

6744

Alpha DB Lindsell Limited S.C.S.  . . . . . . . .

6745

Althelia Climate Fund GP, S.à r.l. . . . . . . . .

6722

Artal Holdings Sp. z o.o., Succursale de Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6746

Artal International Management S.A.  . . . .

6747

Artal International S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .

6744

Artal Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6747

Artal Participations & Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6751

BelGerAs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6768

Beta DB Lindsell Limited S.C.S.  . . . . . . . . .

6745

Bilton Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6749

Citadelle Trust & Management Services

S.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6764

Comptoir de Valeurs de Banque . . . . . . . . .

6751

Création Coiffure Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6741

Dermal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6752

ECP Galaxy Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

6743

Electa Capital Partners S.A. . . . . . . . . . . . . .

6752

FR Galaxy Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

6753

FR Plasco Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

6749

Global Brands S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6736

Greenhill B6-32 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6741

Greenhill B6-36 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6750

Herculon Investholding S.à r.l. . . . . . . . . . . .

6749

Hornblower S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6754

Hôtel Restaurant de la Station S.à r.l.  . . . .

6748

Immobilière du Hameau  . . . . . . . . . . . . . . . .

6754

Inesia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6749

Interlock Investholding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

6762

International Holding Affairs S.A. . . . . . . . .

6748

Jean-Paul Grand S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6748

Lglobal Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6744

Lobelia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6753

Lombard Odier Selection  . . . . . . . . . . . . . . .

6729

Longbow Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

6754

Lubrizol (Gibraltar) Limited Luxembourg

S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6746

Lumination S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6754

Melucta Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

6762

MidOcean Finco (Bezier) S.à r.l.  . . . . . . . . .

6750

MidOcean Holdco (Bezier) S.à r.l.  . . . . . . .

6762

MidOcean Holdco (EPL) S.à r.l.  . . . . . . . . .

6762

New Star Global Property Management

(Luxembourg Five) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

6763

New Star Global Property Management

(Luxembourg Four) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

6763

New Star Global Property Management

(Luxembourg Three) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

6763

New Star Global Property Management

(Luxembourg Two) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

6767

OXEA Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6742

P&S Machines de Construction S.à r.l.  . . .

6745

Realtour Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6767

RL Private Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

6767

Sautic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6742

Socom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6741

Tersicore Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6742

TMT II Luxco S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6743

Toproof S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6752

Unlimited Fun S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6743

Weatherford European Holdings (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6768

Weatherford HCC Holdings (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6768

6721

L

U X E M B O U R G

Althelia Climate Fund GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 166.097.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twelfth day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Sylvain Goupille, born on 6 April 1970 in Paris, France, whose private address is at 2, rue de Florence, F-75008

Paris, France;

here represented by Mr Yannick Arbaut, lawyer, residing in 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given by private seal;

2. Mr Christian del Valle, born on 17 August 1968 in Houston, USA, whose private address is at 41, Brookville Road,

London, SW6 7BH, United Kingdom;

here represented by Mr Yannick Arbaut, lawyer, residing in 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given by private seal.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder(s) of the appearing parties and the under-

signed notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its capacity as representative of the shareholders, has requested the notary to record

as follows the articles of association of a company to be established as a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), which they form between themselves:

1. Art. 1. Form and Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the

name of “Althelia Climate Fund GP, S.à r.l.” (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder or one of
the shareholders of the Company.

Any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to

the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.

2. Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a
resolution of the general meeting of shareholders of the Company (the General Meeting), deliberating in the manner
provided for amendments to the Articles. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg
(or elsewhere in the Grand Duchy of Luxembourg if and to the extent permitted under the Luxembourg act of 10 August
1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act)) by a resolution of the board of managers of the
Company.

Where the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have oc-

curred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such tempo-
rary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of
its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

3. Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for amendments of the Articles, as prescribed in article 11 below.

4. Art. 4. Corporate objects. The Company may act as general partner of, and take general partner interests in, any

Luxembourg corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions). In particular, the Company
may subscribe shares in and act as general partner of investment companies organised as fonds d'investissement spécialisés
subject to the Luxembourg act of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended.

The Company may manage vehicles formed to invest in parallel and on a pro rata basis with the undertakings for

collective investment established as Luxembourg corporate partnerships limited by shares (sociétés en commandite par
actions) for which the Company acts as general partner.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment and development of its purpose.

5. Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR12,500 (twelve thousand five hundred Euro) repre-

sented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a par value of EUR1 (one Euro) per share.

6722

L

U X E M B O U R G

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 11 below.

6. Art. 6. Distribution. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

7. Art. 7. Indivisible shares . Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is

admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

8. Art. 8. Transfer of shares. In case of a Sole Shareholder, the Company's shares held by the Sole Shareholder are

freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the General

Meeting who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required
for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent at least

three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Companies Act will apply.

9. Art. 9. Redemption of shares. The Company shall have the power to acquire shares in its own capital provided that

the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the Sole Shareholder or the General Meeting.
The quorum and the majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply in accordance with
article 11 of these Articles.

10. Art. 10. General meetings of the shareholders of the company. In the case of a Sole Shareholder, the Sole Share-

holder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by
the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the
Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the
operations of the Company.

The  annual  General  Meeting  may  be  held  abroad  if,  in  the  absolute  and  final  judgment  of  the  board  of  managers

exceptional circumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at General Meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (email) transmission).

11. Art. 11. Shareholders' voting rights, quorum and majority. In case of plurality of shareholders, each shareholder

may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting
rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by
shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning

at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by una-
nimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

12. Art. 12. Management. The Company is managed by a board of managers. The managers need not to be shareholders.

The managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the General Meeting, adopted by shareholders owning
more than half of the share capital.

The General Meeting may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace any manager.
Each manager shall be assigned either an A or a B signatory power.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in

all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the General Meeting fall within the power of the

board of managers.

The Company shall be bound by the joint signatures of any manager with an A signatory power and any manager with

a B signatory power.

6723

L

U X E M B O U R G

Any manager with an A signatory power and any manager with a B signatory power may subdelegate their powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents. The delegating managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

13. Art. 13. Meetings of the board of managers. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the

majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the
majority of its members having an A signatory power is present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or

electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circums-
tances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived
if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the

minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

14. Art. 14. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company

needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor
needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December
2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

15. Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December

of each year.

16. Art. 16. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the board of managers will draw up the annual

accounts of the Company in the form required by the Companies Act and prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

17. Art. 17. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s)
on a pro rata basis in proportion of to his (their) shareholding in the Company.

The board of managers may decide to pay interim dividends.

18. Art. 18. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General

Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event
of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

19. Art. 19. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance

with the Companies Act.

<i>Transitional provisions

The first business year begins today and ends on 31 December 2012.

6724

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe the shares as follows:

Sylvain Goupille: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,875 (six thousand eight hundred seventy five) shares; and
Christian del Valle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,625 (five thousand six hundred twenty five) shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500 (twelve thousand five hundred) shares

All these shares have been fully paid up by the above named parties by payment in cash, so that the sum of EUR 12,500

(twelve thousand five hundred Euro) is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been
given to the officiating notary.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).

<i>Extraordinary general meeting of the shareholders

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly conve-

ned, have proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. the number of managers is set at four (4);
2. the following persons are appointed as managers for a renewable period of one year, with the following signatory

powers:

- Mr Sylvain Goupille, manager, Althelia Climate Fund GP, S.à r.l., born on 6 April 1970 in Paris, France, whose private

address is at 2, rue de Florence, F-75008 Paris, France, with an A signatory power;

- Mr Christian del Valle, manager, Althelia Climate Fund GP, S.à r.l., born on 17 August 1968 in Houston, USA, whose

private address is at 41, Brookville Road, London, SW6 7BH with an A signatory power;

- Mr Alan Dundon, Director, Alter Domus, born on 18 April 1966 in Dublin, Ireland, whose professional address is at

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, with a B signatory power;

- Mr Fabrice Meeuwis, Senior Manager, Alter Domus, born on 7 July 1970 in Metz, France, whose professional address

is at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, with a B signatory power;

3. PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg is appointed as external auditor of the

Company for a period ending on the date of the annual general meeting of shareholders to be held in 2013; and

4. the address of the registered office of the Company is established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing persons
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, which are known to the notary by their surnames, names,

civil status and residences, the said persons appearing signed the present deed together with the notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le douzième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. M. Sylvain Goupille, né le 6 avril 1970 à Paris, France, ayant son adresse privée au 2, rue de Florence, F-75008 Paris,

France;

ici représenté par M. Yannick Arbaut, avocat, résidant au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2. M. Christian del Valle, né le 17 août 1968 à Houston, Etats-Unis, ayant son adresse privée au 41, Brookville Road,

Londres, SW6 7BH, Grande-Bretagne;

ici représenté par M. Yannick Arbaut, avocat, résidant au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de représentant des associés, a requis le notaire instrumentant de dresser

comme suit les statuts d'une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée qu'ils forment entre eux.

6725

L

U X E M B O U R G

1. Art. 1 

er

 . Forme et Nom.  Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de «Althelia Climate

Fund GP, S.à r.l.» ( la Société).

La Société peut n'avoir qu'un seul et même associé (l'Associé Unique) ou plusieurs associés. La société ne sera pas

dissoute par le décès, la suspension des droits civils, la faillite, la liquidation ou la déconfiture de l'Associé Unique ou d'un
des associés de la Société.

Toute référence aux associés dans les statuts de la Société (les Statuts) sera une référence à l'Associé Unique si la

Société n'a qu'un seul et même associé.

2. Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée
générale des associés de la Société (une Assemblée Générale) délibérant de la manière prévue pour la modification des
Statuts. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg (ou ailleurs au sein du Grand-Duché de
Luxembourg si et dans la mesure permise par la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi sur les Sociétés)) par une résolution du conseil de gérance de la Société.

Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements politiques ou militaires extraordinaires

de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée entre le siège social
et des personnes à l'étranger se produisent ou sont imminents, le siège social peut être provisoirement transféré à
l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Cette mesure provisoire n'aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert provisoire du siège social, restera une société
luxembourgeoise.

3. Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'Assemblée Générale prise de la manière prévue

pour la modification des Statuts, tel que prescrit par l'article 11 ci-dessous.

4. Art. 4. Objet social. La Société peut agir en tant qu'associé gérant commandité de, et prendre des participations

d'associé commandité dans toute société en commandite par actions luxembourgeoise. La Société peut en particulier
souscrire à des actions et agir en tant qu'associé gérant commandité de sociétés d'investissement organisées sous la forme
de fonds d'investissement spécialisés soumis à la loi luxembourgeoise modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds
d'investissement spécialisés.

La Société peut gérer des véhicules établis pour investir en parallèle et sur une base proportionnelle avec les organismes

de placements collectifs établis en tant que sociétés en commandite par actions luxembourgeoises pour lesquelles la
Société agit en tant qu'associé gérant commandité.

La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle ou financière estimée utile pour l'accom-

plissement et le développement de son objet.

5. Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à la somme de 12.500 EUR (douze mille cinq cent Euros)

représenté par 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) par part sociale.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou diminué par une résolution adoptée par l'Assemblée

Générale de la manière requise pour modifier les Statuts, comme prescrit à l'article 11 ci-dessous.

6. Art. 6. Distributions. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes,

de l'actif social ainsi que des bénéfices de la Société.

7. Art. 7. Parts indivisibles. Les parts de la Société sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul

propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sont tenus de se faire représenter auprès de la
Société par une seule et même personne.

8. Art. 8. Cession de parts. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'Associé Unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'Assemblée

Générale représentant au moins trois quarts du capital libéré de la Société. Une telle autorisation n'est pas requise pour
une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent au moins

trois-quarts des droits appartenant aux associés survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés sont d'application.

9. Art. 9. Rachat de parts. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose de

réserves et de fonds distribuables suffisants à cette fin.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux termes et conditions qui seront décidés par l'Associé Unique
ou par l'Assemblée Générale. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts sont
d'application conformément à l'article 11 de ces Statuts.

6726

L

U X E M B O U R G

10. Art. 10. Assemblées générales des associés de la Société. Dans le cas où la Société a un Associé Unique, celui-ci

assume tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans les présents Statuts, les décisions prises ou les pouvoirs
exercés par l'Assemblée Générale font référence aux décisions prises et aux pouvoirs conférés par l'Associé Unique aussi
longtemps que la Société n'a qu'un seul et même associé. Les décisions prises par l'Associé Unique sont documentées
par les biais de procès-verbaux.

En cas de pluralité d'associés, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représentera l'entièreté des asso-

ciés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour effectuer ou ratifier les actes relatifs à toutes les opérations
de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle peut être tenue à l'étranger si, dans le jugement absolu et définitif du conseil de gérance,

des circonstances exceptionnelles l'exigent.

D'autres assemblées des associés de la Société peuvent être tenues au lieu et aux heures spécifiées dans les convo-

cations respectives des assemblées.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises

lors d'Assemblées Générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la
résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes
devant être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

11. Art. 11. Droits de vote des associés, quorum et majorité. En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut

participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre
de  voix  proportionnel  au  nombre  de  parts  qu'il  possède  ou  représente.  En  cas  de  pluralité  d'associés,  les  décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la
moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts ne pourront être prises que par accord de la majorité en nombre des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que
de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi sur les Sociétés.

12. Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Les

gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'Assemblée Générale, par une résolution adoptée par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer tout gérant.
Tout gérant se verra assigner un pouvoir de signature A ou un pouvoir de signature B.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société

en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'Assemblée Générale sont de la

compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un

pouvoir de signature B.

Un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B pourront conjointement

déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Les gérants qui dé-
lèguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la
période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

13. Art. 13. Réunions du conseil de gérance. Les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix

des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la
majorité de ses membres ayant un pouvoir de signature A est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de
gérance.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du

conseil de gérance de la Société. Si un président est nommé, il présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Si président pro tempore est nommé, il sera désigné par le conseil de gérance à la majorité des gérants
présents ou représentés lors de la réunion du conseil de gérance.

Toute réunion du conseil de gérance sera signifiée à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail) au

moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de
gérance peut être convoquée par tout gérant. On peut passer outre cette convocation si tous les gérants sont présents
ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de la réunion. Une convocation
séparée ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à une réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie

ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de
gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant
à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion

6727

L

U X E M B O U R G

du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication
mentionné ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion, et la réunion sera considérée
comme ayant été tenue au siège social de la Société. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un
procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou
par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, le cas échéant, seront jointes au
procès-verbal de la réunion.

Nonobstant ce qui précède, une résolution du conseil de gérance peut également être prise par écrit au moyen d'un

seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par chacun des gérants. La date d'une telle résolution
circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée
comme ayant été tenue à Luxembourg.

14. Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi sur les Sociétés,

la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un
réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ne s'applique
pas.

15. Art. 15. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de

chaque année.

16. Art. 16. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le conseil de gérance dresse les comptes

annuels de la Société dans la forme requise par la Loi sur les Sociétés et prépare un inventaire comprenant l'indication
des valeurs des actifs et du passif de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire ci-dessus et du bilan au siège social de la Société.

17. Art. 17. Distribution des bénéfices, réserves. Les profits bruts de la Société constatés dans les comptes annuels,

déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société. Le solde du bénéfice net sera distribué aux associés sur base proportionnelle de leurs détentions
de parts sociales dans la Société.

Le conseil de gérance pourra décider de verser des dividendes intérimaires.

18. Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'Assemblée

Générale prise de la manière requise pour modifier ces Statuts, comme prescrit par l'article 11 ci-dessus. Dans le cas
d'une dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes
physiques ou des entités légales) nommé(s) par l'Assemblée Générale décidant d'une telle liquidation. Cette Assemblée
Générale déterminera également les pouvoirs et les émoluments du (des) liquidateur(s).

19. Art. 19. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas réglé par les Statuts sera réglé conformément à la Loi sur les Sociétés.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.

<i>Souscription

Les Statuts de cette Société ayant ainsi été établis, les parties comparantes déclarent qu'elle souscrivent les parts

sociales comme suit:

Sylvain Goupille: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et

6.875 (six mille huit cent soixante quinze) actions;

Christian del Valle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.625 (cinq mille six cent vingt cinq) actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500 (douze mille cinq cents) actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par les parties susmentionnées par paiement en numéraire, de sorte

que la somme de EUR12.500 (douze mille cinq cent euros) est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en
ayant été donnée au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant, au moins approximativement, des coûts, dépenses, salaires et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui puisse être engagé ou mis à la charge de la Société en conséquence de sa constitution est évalué approximativement
à mille cinq cents euros (€ 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire des associés

Les parties susmentionnées, représentant l'entièreté du capital souscrit, se considérant dûment convoquées, on décidé

de tenir une assemblée générale des associés et, ayant déclaré être valablement constitués, ils ont adopté les résolutions
suivantes par vote unanime:

6728

L

U X E M B O U R G

1. le nombre de gérants est fixé à quatre (4);
2. les personnes suivantes sont nommées gérants pour une période renouvelable d'un an, avec les pouvoirs de signature

suivants:

- M. Sylvain Goupille, gérant, Althelia Climate Fund GP, S.à r.l., né le 6 avril 1970 à Paris, France, ayant son adresse

privée au 2, rue de Florence, F75008 Paris, France, avec un pouvoir de signature A;

- M. Christian del Valle, gérant, Althelia Climate Fund GP, S.à r.l., né le 17 août à Houston, Etats-Unis, ayant son adresse

privée au 41, Brookville Road, Londres, SW6 7BH, Grande-Bretagne, avec un pouvoir de signature A;

- M. Alan Dundon, Directeur, Alter Domus, né le 18 avril 1966 à Dublin, Irlande, ayant son adresse professionnelle au

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec un pouvoir de signature B;

- M. Fabrice Meeuwis, Senior Manager, Alter Domus, né le 7 juillet 1970 à Metz, France, ayant son adresse profes-

sionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec un pouvoir de signature B;

3. PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, est nommée réviseur d'entreprises agréé

de la Société pour une période se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle devant être tenue en 2013; et

4. l'adresse du siège social de la Société est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes,

le présent acte est établi en anglais, suivi d'une traduction française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et
en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaut.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, qui sont connues du notaire par leurs prénom,

nom, état et demeure, lesdites parties comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Arbaut, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17680. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Thoma

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012007476/409.
(120007960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Lombard Odier Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 71.379.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of December,
before us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of shareholders of LOMBARD ODIER SELECTION in short LO Selection

(the "Company" or "LO Selection"), a "Société d’Investissement à Capital Variable" with its registered office at 5, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by notarial deed on August 31, 1999, published in the Mé-
morial Recueil des Sociétés et Associations C (the “Mémorial”), number 717 of 27 September 1999. The articles of
incorporation of the Company have been amended for the last time by a notarial deed on August 20, 2010, published in
the Mémorial number 1822 of 7 September 2010.

The meeting was opened with Mrs. Christelle Vaudémont, employee, professionally residing in Luxembourg, in the

chair, who appointed as secretary to the meeting Mrs. Laetitia Boeuf, employe, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Yan Dhuicque, employee, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

A. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1 Article 3 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles"), relating to its corporate object, shall be

amended in order to refer to the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment (the "Law")
and shall read as follows:

"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all

other permitted assets such as referred to in Part I of the law of 17 December 2010 regarding collective investment
undertakings or any legislative replacements or amendment thereof (the “Law”) with the purpose of spreading investment
risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by the Law. The Company is authorised to delegate to third
parties one or several of its functions."

6729

L

U X E M B O U R G

2 The references to the articles of the law dated 20 December 2002 regarding undertakings for collective investment

shall be replaced with references to the corresponding articles of the Law.

3 Article 4 of the Articles, first paragraph, shall be amended to read as follows:
"The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. If and

to the extent permitted by Luxembourg law and regulations, the Board of Directors (the "Board") may decide to transfer
the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board."

4 Article 10 of the Articles shall be amended to add the following new paragraphs, to be inserted as paragraph two

and four, respectively:

“If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting

of shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date,
time or place to be decided by the Board.”

“Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the convening notice of a general meeting of

shareholders may provide that the quorum and majority rules of such meeting will be determined according to the Shares
issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right
of a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/its/her
Shares shall be determined by reference to the Shares held by this shareholder as at the Record Date.”

5 Article 11 of the Articles, second paragraph, shall be amended to read as follows:
“Each Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles and by applicable Luxembourg

laws and regulations. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy
in writing or by facsimile or any other electronic means capable of evidencing the proxy.”

6 Article 16 of the Articles, third paragraph, shall be amended to read as follows:
“The Board has, in particular, power to determine the corporate policy. The course of conduct of the management

and business affairs of the Company shall not effect such investments or activities as shall fall under such investment
restrictions as may be imposed by the Law and be laid down in the laws and regulations of those countries where the
Shares are offered for sale to the public and as shall be adopted from time to time by resolution of the Board and as shall
be described in any prospectus relating to the offer of Shares.”

7 In article 16 of the Articles, fourth paragraph and paragraph (v), references to Directive 85/611/EEC and references

to Article 1, paragraph (2), first and second indents of Directive 85/611/EEC shall be replaced by references to Directive
2009/65/EC and by references to Article 1, paragraph (2), letters (a) and (b) of Directive 2009/65/EC respectively.

8 Article 16 of the Articles shall be amended to add the following two paragraphs at the end of paragraph (v):
“Under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations, any Sub-Fund of the Company may subscribe

and hold Shares of any other Sub-Fund of the Company. In this case and subject to conditions set forth in applicable
Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attached to these shares are suspended for as long as they are
held by the Sub-Fund concerned. In addition and for as long as these shares are held by a Sub-Fund, their value will not
be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum
threshold of the net asset imposed by the Law.

The Sub-Funds may hold up to 10% of their net assets in units of UCITS or other UCIs, unless otherwise provided for

in the prospectus of the Company. The Sub-Funds qualifying as feeder UCITS, shall invest at least 85% of their assets in
another UCITS or a sub-fund of a UCITS, under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations and as
provided for in the prospectus of the Company.”

9 Article 16 of the Articles, (currently) third-to-last paragraph shall be amended to read as follows:
The Company may invest up to 100 per cent of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of

risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State,
by its local authorities or by an OECD Member State, Brazil or Singapore or by a public international body of which one
or more Member State(s) are member(s), provided the relevant Sub-Fund holds securities from at least six different issues
and securities from one issue do not account for more than 30 per cent of the total net assets of such Sub-Fund.

10 The following paragraph shall be added at the end of Article 16:
“Under the conditions set forth by the Law and any applicable Luxembourg regulations, and in accordance with the

provisions set forth in the current prospectus of the Company, the Board has the power (i) to create any new Sub-Fund
of the Company qualifying as a feeder UCITS (i.e. a Sub-Fund investing at least 85% of its asset in another UCITS or sub-
fund of a UCITS) or as master UCITS (i.e. a Sub-Fund which accepts to be a master fund to another UCITS or sub-fund
of a UCITS),

(ii) to convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS or a master UCITS in compliance with the Law, (iii) to convert

a Sub-Fund qualifying as feeder UCITS or master UCITS into a standard UCITS Sub-Fund which is neither a feeder UCITS
nor a master UCITS; or (iv) to replace the master UCITS of any of its Sub-Funds qualifying as feeder UCITS with another
master UCITS.”

11 Article 22 of the Articles, first paragraph, shall be amended to read as follows:

6730

L

U X E M B O U R G

“The net asset value per Share (the "Net Asset Value") and of the Issue and Redemption Prices of Shares of any class

shall be determined by the Company not less than twice monthly, as the Board by regulation may direct (every such day
or time for determination thereof being referred to herein as a "Valuation Day"), but so that no day observed as a holiday
or half-closed day by banks in Luxembourg be a Valuation Day.”

12 Article 22 of the Articles, paragraphs (a), (b) and (i) shall be amended to read as follows:
“(a) during any period when the dealing of units/shares of an investment vehicle in which any substantial portion of

assets of the relevant Sub-Fund is invested or the calculation of the net asset value of such investment vehicle is restricted
or suspended;”

“(b) during any period when any market or stock exchange, which is the principal market or stock exchange on which

a material part of a Sub-Fund's investments for the time being are quoted, is closed, otherwise than for ordinary holidays,
or during which dealings or the calculation of the net asset value of such investments are substantially restricted or
suspended;”

“(i)  upon  publication  of  notice  convening  the  general  meeting  of  shareholders  for  the  purpose  of  winding-up  the

Company or a Sub-Fund, or of the publication of the decision of the Board to wind up one or more Sub-Funds;”

13 In article 22 of the Articles, the following paragraphs shall be added after paragraph (i):
“(j) during any relevant period when a Sub-Fund merges with another Sub-Fund or with another UCITS (or a Sub-

Fund of such other UCITS) provided any such suspension is justified for the protection of the Shareholders;

(k) in case of a feeder Sub-Fund, during any relevant period when the determination of the net asset value of the master

UCITS is suspended;

(l) where in the opinion of the Board, circumstances which are beyond the control of the Board make it impracticable

or unfair vis-à-vis the Shareholders to continue trading the Shares or any other circumstance(s) where a failure to do so
might result in the Shareholders of the Company, a Sub-Fund or category of Shares incurring any liability to taxation or
suffering other pecuniary disadvantages or other detriment which the Shareholders of the Company, a Sub-Fund or a
category of Shares might not otherwise have suffered.”

14 In article 23 of the Articles, the following paragraph (a) shall be added under section C. and the paragraphs (a), (b)

and (c) shall be renumbered (b), (c) and (d), respectively:

“Shares of the Company in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received

shall be deemed to be existing as from the close of business on the Valuation Day on which they have been allotted and
the price therefore, until received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;”

15 In article 25 of the Articles, the last sentence of the second paragraph shall be deleted.
16 Article 26 of the Articles, second paragraph, shall be amended to read as follows:
“Dividends may further, in respect of distribution shares in any class, include an allocation from an equalisation account

which may be maintained in respect of such distribution shares, be credited upon issue of shares and debited upon
redemption of shares, in amount calculated by reference to the accrued income attributable or any other assets decided
by the Board to such distribution shares.”

17 Article 27 of the Articles shall be amended to read as follows:
(a) “The Company can be liquidated by a shareholders’ decision in accordance with the provisions of the law of 10

August 1915 on commercial companies as amended. The same quorum and majority requirements for the shareholders’
decision shall apply in case of merger, if as a result of such merger the Company will cease to exist.

(b) In the event that the Net Asset Value of the Company falls below EUR 50 million or in case the Board deems it

appropriate because of changes in the economical or political situation affecting the Company, or if the Board deems it
to be in the best interests of the shareholders, the Board may, by giving notice to all shareholders, redeem on the Valuation
Date indicated in such notice all (but not some) of the Shares not previously redeemed, at the Net Asset Value without
any dealing or redemption charges. The Board shall, after the end of the notice period, forthwith convene an extraordinary
shareholders’ meeting to appoint a liquidator to the Company.

(c) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below EUR 20 million or the equivalent in

the Dealing Currency of a Sub-Fund or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund’s assets to fall
under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors, or
in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant
Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving
notice to the shareholders concerned, to the extent required by Luxembourg laws and regulations, redeem all (but not
some) of the Shares of that Sub-Fund on the Valuation Date provided in such notice at the Net Asset Value without any
dealing  or  redemption  charges.  Unless  the  Board  decides  otherwise  in  the  interest  of,  or  in  order  to  ensure  equal
treatment of, the shareholders, the shareholders of the relevant Sub-Fund may continue to request redemption or con-
version of their Shares free of any redemption or conversion charge, but taking into account actual realisation prices of
investments and realisation expenses.

(d) Termination of a Sub-Fund with compulsory redemption of all relevant Shares for other reasons than set out in

the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be termi-

6731

L

U X E M B O U R G

nated at a duly convened general meeting of the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and
decided by a simple majority of the Shares present or represented.

Liquidation proceeds not claimed by shareholders at the close of liquidation of a Sub-Fund will be deposited at the

Caisse de Consignation in Luxembourg and shall be forfeited after thirty years.

(e) If a Sub-Fund qualifies as a feeder UCITS of another UCITS or of one of its sub-funds, the merger, split or liquidation

of such master UCITS, triggers liquidation of the feeder Sub-Fund, unless the Board decides, in accordance with Article
16 and the Law, to replace the master UCITS with another master UCITS or to convert a Sub-Fund into a standard
UCITS Sub-Fund.

(f) The provision for anticipated realisation and liquidation costs will be accounted for in the Net Asset Value from

such date as may be defined by the Board and at the latest on the date of dispatch of the notice mentioned subparagraphs
(b), (c), (d) and (e).

(g) Any merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund of the Company or with another UCITS (whether subject to

Luxembourg law or not) shall be decided by the Board unless the Board decides to submit the decision for a merger to
a meeting of shareholders of the Sub-Fund concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken
by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Sub-Fund where, as a result, the Company ceases to
exist, the merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority
requirements for changing these Articles.

(h) In case of a merger of a Sub-Fund decided by the Board, the Board will give notice to shareholders concerned, as

required by Luxembourg laws and regulations. Such notice shall be provided to the shareholders concerned at least thirty
days before the last date for exercising their right to request the repurchase or redemption or conversion of their Shares
without any charge other than those retained to meet disinvestment costs; such right shall cease to exist five working
days before the date for calculating the exchange ratio referred to in Article 75, paragraph (1) of the Law.

(i) If the Board determines that it is in the interests of the shareholders of the relevant Sub-Fund or that a change in

the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred which would justify it, the reorga-
nisation of one Sub-Fund, by means of a division into two or more Sub-Funds, may take place. This decision will be notified
to shareholders as required. The notification will also contain information about the two or more new Sub-Funds. The
notification will be made at least one month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to
enable the shareholders to request the redemption of their shares, free of any dealing or redemption charge, before the
operation involving the division into two or more Sub-Funds becomes effective.”

18 To resolve to refrain from attaching a French translation to the Articles.
19 To decide that items 1 to 18, if approved by the Shareholders, will come into force on 30 December 2011 or any

other date as decided by the extraordinary general meeting upon proposal of the chairman of the meeting.

B. All the shareholders being registered, the meeting has been convened by notices containing the agenda of the meeting

to the shareholders on 25 November 2011.

C. The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the

attendance list initialled "ne varietur" by the shareholders present, by the proxies of the shareholders represented and
by the members of the bureau. The said list and proxies will be annexed to this deed, to be registered therewith.

D. As appeared from the said attendance list, out of 13,317,521.306 shares in issue, 12,443,628.3390
shares are present or duly represented at the Extraordinary General Meeting.
E. Considering that the minimum quorum of fifty (50) percent of the shares present or represented required to validly

deliberate on items of the agenda of the extraordinary general meeting has been reached, as detailed in the attendance
list, the meeting is regularly constituted and may validly decide on all the items of the agenda.

F. The shareholders have adopted, by more than two third majority vote as regards the items on the agenda of the

meeting, the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend Article 3 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles"), relating to

its corporate object, so as to read as follows:

"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all

other permitted assets such as referred to in Part I of the law of 17 December 2010 regarding collective investment
undertakings or any legislative replacements or amendment thereof (the “Law”) with the purpose of spreading investment
risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by the Law. The Company is authorised to delegate to third
parties one or several of its functions."

<i>Second resolution

The meeting decides to replace the references to the articles of the law dated 20 December 2002 regarding under-

takings for collective investment with references to the corresponding articles of the Law.

6732

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The meeting decides to amend Article 4 of the Articles, first paragraph, so as to henceforth read as follows:
"The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. If and

to the extent permitted by Luxembourg law and regulations, the Board of Directors (the "Board") may decide to transfer
the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board."

<i>Fourth resolution

The meeting decides to amend Article 10 of the Articles by adding the following new paragraphs, to be inserted as

paragraph two and four, respectively:

“If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting

of shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date,
time or place to be decided by the Board.”

“Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the convening notice of a general meeting of

shareholders may provide that the quorum and majority rules of such meeting will be determined according to the Shares
issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right
of a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/its/her
Shares shall be determined by reference to the Shares held by this shareholder as at the Record Date.”

<i>Fifth resolution

The meeting decides to amend Article 11 of the Articles, second paragraph, so as to henceforth read as follows:
“Each Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles and by applicable Luxembourg

laws and regulations. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy
in writing or by facsimile or any other electronic means capable of evidencing the proxy.”

<i>Sixth resolution

The meeting decides to amend Article 16 of the Articles, third paragraph, so as to henceforth read as follows:
“The Board has, in particular, power to determine the corporate policy. The course of conduct of the management

and business affairs of the Company shall not effect such investments or activities as shall fall under such investment
restrictions as may be imposed by the Law and be laid down in the laws and regulations of those countries where the
Shares are offered for sale to the public and as shall be adopted from time to time by resolution of the Board and as shall
be described in any prospectus relating to the offer of Shares.”

<i>Seventh resolution

The meeting decides to replace in article 16 of the Articles, fourth paragraph and paragraph (v), references to Directive

85/611/EEC and references to Article 1, paragraph (2), first and second indents of Directive 85/611/EEC by references
to Directive 2009/65/EC and by references to Article 1, paragraph (2), letters (a) and (b) of Directive 2009/65/EC res-
pectively.

<i>Eighth resolution

The meeting decides to amend Article 16 of the Articles by adding the following two paragraphs at the end of paragraph

(v):

“Under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations, any Sub-Fund of the Company may subscribe

and hold Shares of any other Sub-Fund of the Company. In this case and subject to conditions set forth in applicable
Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attached to these shares are suspended for as long as they are
held by the Sub-Fund concerned. In addition and for as long as these shares are held by a Sub-Fund, their value will not
be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum
threshold of the net asset imposed by the Law.

The Sub-Funds may hold up to 10% of their net assets in units of UCITS or other UCIs, unless otherwise provided for

in the prospectus of the Company. The Sub-Funds qualifying as feeder UCITS, shall invest at least 85% of their assets in
another UCITS or a sub-fund of a UCITS, under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations and as
provided for in the prospectus of the Company.”

<i>Nineth resolution

The meeting decides to amend Article 16 of the Articles, (currently) third-tolast paragraph so as to henceforth read

as follows:

The Company may invest up to 100 per cent of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of

risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State,
by its local authorities or by an OECD Member State, Brazil or Singapore or by a public international body of which one

6733

L

U X E M B O U R G

or more Member State(s) are member(s), provided the relevant Sub-Fund holds securities from at least six different issues
and securities from one issue do not account for more than 30 per cent of the total net assets of such Sub-Fund.

<i>Tenth resolution

The meeting decides to amend Article 16 by adding at the end of Article 16:
“Under the conditions set forth by the Law and any applicable Luxembourg regulations, and in accordance with the

provisions set forth in the current prospectus of the Company, the Board has the power (i) to create any new Sub-Fund
of the Company qualifying as a feeder UCITS (i.e. a Sub-Fund investing at least 85% of its asset in another UCITS or sub-
fund of a UCITS) or as master UCITS (i.e. a Sub-Fund which accepts to be a master fund to another UCITS or sub-fund
of a UCITS), (ii) to convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS or a master UCITS in compliance with the Law,
(iii) to convert a Sub-Fund qualifying as feeder UCITS or master UCITS into a standard UCITS Sub-Fund which is neither
a feeder UCITS nor a master UCITS; or (iv) to replace the master UCITS of any of its Sub-Funds qualifying as feeder
UCITS with another master UCITS.”

<i>Eleventh resolution

The meeting decides to amend Article 22 of the Articles, first paragraph, so as to henceforth read as follows:
“The net asset value per Share (the "Net Asset Value") and of the Issue and Redemption Prices of Shares of any class

shall be determined by the Company not less than twice monthly, as the Board by regulation may direct (every such day
or time for determination thereof being referred to herein as a "Valuation Day"), but so that no day observed as a holiday
or half-closed day by banks in Luxembourg be a Valuation Day.”

<i>Twelfth resolution

The meeting decides to amend Article 22 of the Articles, paragraphs (a), (b) and (i) shall so as to henceforth read as

follows:

“(a) during any period when the dealing of units/shares of an investment vehicle in which any substantial portion of

assets of the relevant Sub-Fund is invested or the calculation of the net asset value of such investment vehicle is restricted
or suspended;”

“(b) during any period when any market or stock exchange, which is the principal market or stock exchange on which

a material part of a Sub-Fund's investments for the time being are quoted, is closed, otherwise than for ordinary holidays,
or during which dealings or the calculation of the net asset value of such investments are substantially restricted or
suspended;”

“(i)  upon  publication  of  notice  convening  the  general  meeting  of  shareholders  for  the  purpose  of  winding-up  the

Company or a Sub-Fund, or of the publication of the decision of the Board to wind up one or more Sub-Funds;”

<i>Thirteenth resolution

The meeting decides to add the following paragraphs after paragraph (i) of article 22 of the Articles:
“(j) during any relevant period when a Sub-Fund merges with another Sub-Fund or with another UCITS (or a Sub-

Fund of such other UCITS) provided any such suspension is justified for the protection of the Shareholders;

(k) in case of a feeder Sub-Fund, during any relevant period when the determination of the net asset value of the master

UCITS is suspended;

(l) where in the opinion of the Board, circumstances which are beyond the control of the Board make it impracticable

or unfair vis-à-vis the Shareholders to continue trading the Shares or any other circumstance(s) where a failure to do so
might result in the Shareholders of the Company, a Sub-Fund or category of Shares incurring any liability to taxation or
suffering other pecuniary disadvantages or other detriment which the Shareholders of the Company, a Sub-Fund or a
category of Shares might not otherwise have suffered.”

<i>Fourteenth resolution

The meeting decides to add in article 23 of the Articles, the following paragraph (a) under section C. and to renumber

the paragraphs (a), (b) and (c) as (b), (c) and (d), respectively:

“Shares of the Company in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received

shall be deemed to be existing as from the close of business on the Valuation Day on which they have been allotted and
the price therefore, until received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;”

<i>Fifteenth resolution

The meeting decides to delete in article 25 of the Articles, the last sentence of the second paragraph.

<i>Sixteenth resolution

The meeting decides to amend Article 26 of the Articles, second paragraph, so as to henceforth read as follows:
“Dividends may further, in respect of distribution shares in any class, include an allocation from an equalisation account

which may be maintained in respect of such distribution shares, be credited upon issue of shares and debited upon

6734

L

U X E M B O U R G

redemption of shares, in amount calculated by reference to the accrued income attributable or any other assets decided
by the Board to such distribution shares.”

<i>Seventeenth resolution

The meeting decides to amend Article 27 of the Articles so as to henceforth read as follows:
(j) “The Company can be liquidated by a shareholders’ decision in accordance with the provisions of the law of 10

August 1915 on commercial companies as amended. The same quorum and majority requirements for the shareholders’
decision shall apply in case of merger, if as a result of such merger the Company will cease to exist.

(k) In the event that the Net Asset Value of the Company falls below EUR 50 million or in case the Board deems it

appropriate because of changes in the economical or political situation affecting the Company, or if the Board deems it
to be in the best interests of the shareholders, the Board may, by giving notice to all shareholders, redeem on the Valuation
Date indicated in such notice all (but not some) of the Shares not previously redeemed, at the Net Asset Value without
any dealing or redemption charges. The Board shall, after the end of the notice period, forthwith convene an extraordinary
shareholders’ meeting to appoint a liquidator to the Company.

(l) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below EUR 20 million or the equivalent in the

Dealing Currency of a Sub-Fund or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund’s assets to fall
under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors, or
in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant
Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving
notice to the shareholders concerned, to the extent required by Luxembourg laws and regulations, redeem all (but not
some) of the Shares of that Sub-Fund on the Valuation Date provided in such notice at the Net Asset Value without any
dealing  or  redemption  charges.  Unless  the  Board  decides  otherwise  in  the  interest  of,  or  in  order  to  ensure  equal
treatment of, the shareholders, the shareholders of the relevant Sub-Fund may continue to request redemption or con-
version of their Shares free of any redemption or conversion charge, but taking into account actual realisation prices of
investments and realisation expenses.

(m) Termination of a Sub-Fund with compulsory redemption of all relevant Shares for other reasons than set out in

the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be termi-
nated at a duly convened general meeting of the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and
decided by a simple majority of the Shares present or represented.

Liquidation proceeds not claimed by shareholders at the close of liquidation of a Sub-Fund will be deposited at the

Caisse de Consignation in Luxembourg and shall be forfeited after thirty years.

(n) If a Sub-Fund qualifies as a feeder UCITS of another UCITS or of one of its sub-funds, the merger, split or liquidation

of such master UCITS, triggers liquidation of the feeder Sub-Fund, unless the Board decides, in accordance with Article
16 and the Law, to replace the master UCITS with another master UCITS or to convert a Sub-Fund into a standard
UCITS Sub-Fund.

(o) The provision for anticipated realisation and liquidation costs will be accounted for in the Net Asset Value from

such date as may be defined by the Board and at the latest on the date of dispatch of the notice mentioned subparagraphs
(b), (c), (d) and (e).

(p) Any merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund of the Company or with another UCITS (whether subject to

Luxembourg law or not) shall be decided by the Board unless the Board decides to submit the decision for a merger to
a meeting of shareholders of the Sub-Fund concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken
by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Sub-Fund where, as a result, the Company ceases to
exist, the merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority
requirements for changing these Articles.

(q) In case of a merger of a Sub-Fund decided by the Board, the Board will give notice to shareholders concerned, as

required by Luxembourg laws and regulations. Such notice shall be provided to the shareholders concerned at least thirty
days before the last date for exercising their right to request the repurchase or redemption or conversion of their Shares
without any charge other than those retained to meet disinvestment costs; such right shall cease to exist five working
days before the date for calculating the exchange ratio referred to in Article 75, paragraph (1) of the Law.

(r) If the Board determines that it is in the interests of the shareholders of the relevant Sub-Fund or that a change in

the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred which would justify it, the reorga-
nisation of one Sub-Fund, by means of a division into two or more Sub-Funds, may take place. This decision will be notified
to shareholders as required. The notification will also contain information about the two or more new Sub-Funds. The
notification will be made at least one month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to
enable the shareholders to request the redemption of their shares, free of any dealing or redemption charge, before the
operation involving the division into two or more Sub-Funds becomes effective.”

<i>Eighteenth resolution

The meeting decides to refrain from attaching a French translation to the Articles.

6735

L

U X E M B O U R G

<i>Nineteenth resolution

The meeting decides that items 1 to 18, if approved by the Shareholders, will come into force on 30 December 2011

or any other date as decided by the extraordinary general meeting upon proposal of the chairman of the meeting.

Nothing else being on the Agenda, the present meeting was adjourned and the minutes were signed by the members

of the bureau and by the notary at 11.45 a.m.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present

deed is worded in English.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed on the above mentioned date.

Signé: C. VAUDEMONT, Y. DHUICQUE, L. BOEUF et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58322. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012003210/384.
(120001902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Global Brands S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 70.673.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Me Frédéric Paget, with professional address in Luxembourg,
acting by virtue of a power of attorney given on 28 December 2011in the name and on behalf of the board of directors

(the Board) of Global Brands S.A., a public limited liability company (société anonyme) organized under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 9, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Registry under number B 70673 (the Company), pursuant to resolutions respectively taken by the
Board on 19 December 2011 and 23 December 2011 (the Resolutions).

A copy of the Resolutions and the power of attorney, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, representing the Board pursuant to the Resolutions, requested the notary to record the fol-

lowing statements:

1. The Company was incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Alex Weber, notary

residing in Bascharage, Grand Duchy of Luxembourg, dated 6July1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 723 of 29September1999. The articles of incorporation of the Company (the Articles) have been
amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, dated 13May2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1725 dated
29July 2011.

2. Article 5 of the Articles, which provides for an authorized share capital, reads as follows:

“ Art. 5.1. The corporate subscribed capital is set at four million eighty-three thousand four hundred and seventy-four

Swiss francs and thirty-six cents of Swiss francs (CHF 4,083,474.36) divided into two hundred and four million one hundred
and seventy-three thousand seven hundred and eighteen (204,173,718) shares having a nominal value of two cents of
Swiss francs (CHF 0.02) each.

Art. 5.2. In addition to the corporate subscribed share capital, the authorized share capital of the Company is set at

ten million Swiss francs (CHF 10,000,000) divided in five hundred million (500,000,000) shares having a nominal value of
two cents of Swiss francs (CHF 0.02) each.

Art. 5.3. The Board is authorized and empowered to:
- realize any increase of the corporate capital within the limits of the authorized corporate capital in one or several

successive tranches, by the issuance of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or con-

6736

L

U X E M B O U R G

vertible  securities,  upon  the  exercise  of  warrants  or  stock  options,  incorporation  of  (distributable)  reserves  of  the
corporation or in any other manner;

- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the

subscription of and paying up on the new shares; and

- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in

cash.

Art. 5.4. This authorization is valid for a period of five (5) years from 25 September 2009 and may be renewed by the

General Meeting.

Art. 5.5. Following each increase of the corporate capital realized and duly stated in the form provided for by the

Company Law, Article 5.1 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in
authentic form by the Board of Directors or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.”

3. The Board resolved pursuant to the Resolutions and by virtue of article 5 of the Articles to inter alia increase the

share capital in several tranches as follows:

(i) increase the share capital of the Company by a first tranche of ordinary shares so as to raise it from its current

amount  of  four  million  eighty-three  thousand  four  hundred  and  seventy-four  Swiss  francs  and  thirty-six  cents  (CHF
4,083,474.36) to an amount of four million two hundred twenty eight thousand four hundred and seventy-four Swiss
francsand thirty-six cents (CHF 4,228,474.36) by the issuance ofseven million two hundred fifty thousand (7,250,000) new
shares at a price of CHF 0.02 (equivalent to GBP 0.013783103 based on exchange rate of GBP 1 equaling CHF 1.450 as
of 19 December 2011) each in the share capital of the Company (the “Shares of Tranche 1”), to those subscribers having
subscribed for and fully paid up by contribution in cash such Shares of Tranche 1 as detailed in the Resolutions (the
Subscribers 1), without reserving any preferential subscription rights to the existing shareholders;

(ii) further increase the share capital of the Company by issuing a second tranche of ordinary shares fully subscribed

and paid-up in kind so as to raise it from the amount set forth in paragraph (i) above of four million two hundred twenty-
eight thousand four hundred and seventy-fourSwiss francs and thirty-six cents (CHF4,228,474.36) to an amount of four
million  three  hundred  seventy-three  thousand  four  hundred  and  seventy-four  Swiss  francs  and  thirty-six  cents
(CHF4,373,474.36) by the issuance of seven million two hundred fifty thousand (7,250,000) new shares at a price of CHF
0.02 (equivalent to GBP 0.013793103 based on the exchange rate of GBP 1 equaling CHF 1.450 as of 19 December 2011)
each in the share capital of the Company (the “Shares ofTranche 2”), to those subscribers having subscribed for and fully
paid up such Shares of Tranche 2 by contribution in kindas detailed in the Resolutions (the “Subscribers 2”) without
reserving any preferential subscription rights to the existing shareholders,

(iii) finally increase the share capital of the Company by issuing a third tranche of ordinary shares fully subscribed and

paid-up to 50% in cash so as to raise it from the amount set forth in paragraph (ii) above offour million three hundred
seventy-three thousand four hundred and seventy four Swiss francs and thirty-six cents (CHF 4,373,474.36) to an amount
of four million eight hundred thirty-nine thousand four hundred and seventy-four Swiss francs and thirty-six cents (CHF
4,839,474.36) by the issuance oftwenty-three million three hundred thousand (23,300,000) new shares for a total sub-
scription price of four hundred and sixty-six thousand Swiss francs (CHF 466,000)(equivalent to five hundred thousand
United States dollars (USD 500,000) based on the exchange rate of USD 1 equaling CHF 0.932 as of 22 December 2011)
and only paid up to two hundred thousand and thirty-three Swiss francs (CHF 233,000)(equivalent to two hundred fifty
thousand United States dollars (USD 250,000)based on the exchange rate of USD 1 equaling CHF 0.932 as of 22 December
2011), at a price of CHF 0.02 (equivalent to USD 0.021459227 based on the exchange rate of USD 1 equaling CHF 0.932
as of 22 December 2011) each having been paid up to fifty per cent (50%) (the “Shares of Tranche 3”) to those subscribers
having fully subscribed for and partly paid up such Shares of Tranche 3 by contribution in cash as detailed in the Resolutions
(the  Subscribers  3),  without  reserving  any  preferential  subscription  rights  to  the  existing  shareholders;the  Shares  of
Tranche 3 will remain in registered form until they are paid up in full;

(iv) appoint and empower any director of the Company, to appear as the representative of the Board before the

undersigned notary to record the increase of share capital of the Company so effectuated in three tranches in notarial
form, to amend Article 5.1 of the Articles of Association and to do any formalities and to take any actions which may be
necessary and proper in connection therewith.

4. All the Shares of the Tranche 1 having been subscribed and paid up in cash by the Subscribers 1, the total amount

of one hundred thousand sterling pounds (GBP 100,000) being the equivalent of one hundred forty-five thousand Swiss
francs (CHF 145,000) was received by the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

5. The contributions in cash so made in an aggregate amount of being the equivalent of one hundred forty-five thousand

Swiss francs (CHF 145,000) to the Company are allocated to the nominal share capital of the Company

6. All the Shares of the Tranche 2 having been subscribed and fully paid up by contribution in kind from the Subscribers

2, so that the contributions amounting in total to at least one hundred thousand sterling pounds (GBP 100,000) being the

7. equivalent of one hundred forty-five thousand Swiss francs (CHF 145,000) have beenmade in favor of the Company,

evidence of which has been given to the undersigned notary and certified by the report of the external auditor issued by
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as mentioned hereafter in paragraph 10..

6737

L

U X E M B O U R G

8. The contributions in kind so made in an aggregate amount of being the equivalent of one hundred forty-five thousand

Swiss francs (CHF 145,000) to the Company are allocated to the nominal share capital of the Company.

9. All the Shares of Tranche 3 having been subscribed and fifty per cent (50%) of such shares, i.e. twenty-three million

three hundred thousand (23,300,000) shares, having been paid up in cash by the Subscribers 3, the total amount of two
hundred fifty thousand United States dollars (USD 250,000) being the equivalent of two hundred thirty-three thousand
Swiss francs (CHF 233,000) was received by the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

10. The contributions in cash so made in an aggregate amount of being the equivalent of two hundred thirty-three

thousand Swiss francs (CHF 233,000) to the Company are allocated to the nominal share capital of the Company

11. PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 400, route d'Esch

| B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 65477,
has been appointed as independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) for the purpose of evaluating the contribution
in kind in accordance with applicable laws and regulations. A report has been issued by PricewaterhouseCoopers, on
29th December 2011 which contains the following conclusions:

«Based on ourreview, nothing has come to our attention that causes us to believethat the global value of the contri-

bution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value of the shares to be issued in counterpart.»

12. All the Shares of Tranche 1, Shares of Tranche 2 and Shares of Tranche 3 have the same rights and obligations as

the existing shares of the Company.

13. The number of shares subscribed by each of the Subscribers 1, Subscribers 2 and Subscribers 3 and the identity

of each of them are indicated in the Resolutions hereto attached to this deed;

14. As a consequence of the increase of the share capital of the Company and in accordance with the Resolutions, the

first paragraph of Article 5.1. of the Articles is amended in order to read as follows:

“ Art. 5.1. The subscribed capital of the Company is set at four million eight hundred thirty nine thousand four hundred

and seventy four Swiss francs and thirty-six cents of Swiss francs (CHF 4,839,474.36), divided into two hundred forty one
million nine hundredseventy three thousand seven hundred and eighteen (241,973,718) shares having a nominal value of
two cents of Swiss francs (CHF 0.02) each.”

<i>Costs

The expenses, costs remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately to eleven hundred (EUR 1,100.-).

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

En l'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour de décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Me Frédéric Paget, dont l’adresse professionnelle se situe à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé qui lui a été délivré en date du 28 décembre 2011au nom et pour

le compte du conseil d’administration (le Conseil) de GLOBAL BRANDS S.A., une société anonyme de droit luxem-
bourgeois,  dont  le  siège  social  se  situe  19,  rue  Eugène  Ruppert,  L-2453  Luxembourg,  immatriculée  au  Registre  du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.673 (ci-après la Société),

conformément aux résolutions prises respectivement par le Conseil en date du 19 décembre 2011 et 23 décembre

2011 (les Résolutions).

Une copie des Résolutions et de ladite procuration sous seing privé, signées ne varietur par la personne comparante

et le notaire instrumentant restera attachée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

La personne comparante, représentant le Conseil conformément aux Résolutions, a prié le notaire instrumentant

d’acter ce qui suit:

1. La Société GLOBAL BRANDS S.A. a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte

de Maître Alex Weber, notaire résidant à Bascharage, daté du 6 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 723 daté du 29 septembre 1999. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, daté
du 13 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1725 daté du 29 juillet 2011.

2. L’article 5 des Statuts, relatif au capital autorisé, dispose que:

6738

L

U X E M B O U R G

« 5.1. Le capital social souscrit s'élève à quatre millions quatre-vingts trois mille quatre cent soixante-quatorze Francs

suisses et trente-six centimes de Francs suisses (CHF 4.083.474.36) divisé en deux cent quatre millions cent soixante-
treize mille sept cents dix-huit actions (204.173.718) ayant chacune une valeur nominale de deux centimes de Francs
suisses (CHF 0,02) chacune.

5.2. En plus du capital social souscrit autorisé, le capital social autorisé de la Société s'élève à dix millions de Francs

suisses (CHF 10.000.000) divisé en cinq cent millions (500.000.000) d'actions ayant chacune une valeur nominale de deux
centimes de Francs suisses (CHF 0,02) chacune.

5.3. Le Conseil d’Administration est autorisé et habilité à:
- réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches suc-

cessives, par l’émission de nouvelles actions, contre paiement en numéraire ou en nature, par conversion de créances ou
de titres convertibles, suivant exercice de warrants ou de stock-options, incorporation au capital de réserves (distribua-
bles) de la Société ou de toute autre manière;

- déterminer la place et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix de l’émission, les termes et les

conditions de la souscription et du paiement des nouvelles actions; et

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires en cas d’émission d’actions contre paie-

ments en numéraire.

5.4. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq (5) ans à compter du 25 septembre 2009 et peut être

renouvelée par l'Assemblée Générale.

5.5. Après chaque augmentation du capital social réalisée et constatée conformément aux dispositions de la Loi, l’article

5.1 sera modifié afin de refléter l’augmentation survenue; une telle modification sera enregistrée sous forme authentique
par le Conseil d’administration ou par toute personne dûment autorisée et habilitée pour ce faire».

3. Conformément aux Résolutions et en application de l’Article 5 des Statuts, le Conseil a décidé inter alia d’augmenter

le capital de la société en plusieurs tranches, ainsi qu’il est décrit ci-dessous:

(i) d’augmenter le capital social de la Société d’une première tranche pour le porter de son montant actuel de quatre

millions quatre-vingts trois mille quatre cent soixante-quatorze Francs suisses et trente-six centimes de Francs suisses
(CHF4.083.474,36) à un montant de quatre millions deux cent vingt-huit mille quatre cent soixante-quatorze Francs suisses
et trente-six centimes de Francs suisses (CHF 4.228.474,36)par l’émission de sept millions deux cent cinquante mille
(7.250.000) actions d’une valeur nominale de CHF 0.02 (équivalente à GBP 0.013793103 sur base du taux de change de
GBP 1 pour CHF 1,450 au 19 décembre 2011) chacune dans le capital social de la Société (les Actions de la Tranche 1)
aux souscripteurs ayant souscrit et libéré en numéraire ces Actions de la Tranche 1 tels que mentionnés dans les Réso-
lutions (les Souscripteurs 1), sans réserver aucun droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants;

(ii) d’augmenter en outre le capital social de la Société par l’émission d’une seconde tranche d’actions ordinaires

intégralement souscrites et libérées par des apports en nature pour le porter du montant précité sous le paragraphe (i)
ci-dessus de quatre millions deux cent vingt-huit mille quatre cent soixante-quatorze Francs suisses et trente-six centimes
de Francs suisses (CHF 4.228.474,36) à un montant de quatre millions trois cent soixante-treize mille quatre cent soixante-
quatorze Francs suisses et trente-six centimes de Francs suisses (CHF4.373.474.36) par l’émission de sept millions deux
cent cinquante mille (7.250.000) actions d’une valeur nominale de CHF 0.02 (équivalente à GBP 0.013793103 à sur base
du taux de change de GBP 1 pour CHF 1,450 au 19 décembre 2011) chacune dans le capital social de la Société (les
Actions de la Tranche 2) aux souscripteurs ayant souscrit et entièrement libéré par apport en nature ces Actions de la
Tranche  2  tels  que  mentionnés  dans  les  Résolutions  (les  Souscripteurs  2)  sans  réserver  aucun  droit  préférentiel  de
souscription aux actionnaires existants,

(iii) d’augmenter enfin le capital social de la Société par l’émission d’une troisième tranche d’actions ordinaires inté-

gralement souscrites et libérées seulement à concurrence de 50% en numéraire pour le porter du montant précité sous
le paragraphe (ii) ci-dessus de quatre millions trois cent soixante-treize mille quatre cent soixante-quatorze Francs suisses
et trente-six centimes de Francs suisses (CHF4.373.474,36) à un montant de quatre millions huit cent trente-neuf mille
quatre cent soixante-quatorze Francs suisses et trente-six centimes de Francs suisses (CHF 4.839.474,36) par l’émission
de vingt-trois millions trois cent mille (23.300.000) actions pour une valeur totale de souscription de quatre-cent soixante-
six mille francs suisses (CHF 466.000) (équivalent à cinq cent mille dollars des Etats-Unis (USD 500,000) sur base du taux
de change de USD 1 pour CHF 0,932 au 22 décembre 2011), mais de libération de deux cent trente-trois mille francs
suisses (CHF 233,000) (équivalent à deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 250,000)sur base
du taux de change de USD 1 pour CHF 0,932 au 22 décembre 2011), soit une valeur nominale par action de CHF 0,02
(équivalente à USD 0,021459227 sur base du taux de change de USD 1 pour CHF 0,932 au 22 décembre 2011) chacune
libérée à concurrence de 50% (les Actions de la Tranche 3) aux souscripteurs ayant entièrement souscrit et partiellement
libéré en numéraire ces Actions de la Tranche 3 tels que mentionnés dans les Résolutions (les Souscripteurs 3) sans
réserver aucun droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants;ces Actions de la Tranche 3 resteront no-
minatives jusqu’à leur complète libération;

(iv) de donner pouvoir aux administrateurs de la Société, pour représenter le Conseil devant le notaire instrumentant

afin d’enregistrer en la forme notariée l’augmentation de capital de la Société ainsi effectuée en trois tranches, de modifier

6739

L

U X E M B O U R G

l’article 5.1 des Statuts et d’effectuer tous les actes et formalités nécessaires en rapport avec ladite augmentation de
capital.

4. L’ensemble des Actions de la Tranche 1 ont été souscrites et libérées en numéraire par les Souscripteurs 1, de sorte

que le montant total de cent mille livres Sterling (GBP 100.000), soit l’équivalent de cent quarante-cinq mille Francs suisses
(CHF 145.000) a été reçu par la Société, tel que prouvé au notaire instrumentant.

5. Les contributions en numéraire ainsi faites à la Société pour un montant total cent quarante-cinq mille Francs suisses

(CHF 145.000) sont alloués au compte capital social de la Société;

6. L’ensemble des Actions de la Tranche 2 ont été souscrites et entièrement libérées par des apports en nature par

les Souscripteurs 2, de sorte que des apports d’un montant total d’au moins cent mille livres Sterling (GBP 100.000), soit
l’équivalent de cent quarante-cinq mille Francs suisses (CHF 145.000) ont été réalisés en faveur de la Société, tel que
prouvé au notaire instrumentant et attesté par le rapport du réviseur d’entreprise PricewaterhouseCoopers S.àr.l. men-
tionné au paragraphe 10 ci-dessous.

7. Les contributions en nature ainsi faites à la Société pour un montant total de cent quarante-cinq mille Francs suisses

(CHF 145.000) sont alloués au compte capital social de la Société;

8. L’ensemble des Actions de la Tranche 3 ont été souscrites et libérées chacune pour moitié, soit vingt-trois millions

trois cent mille (23.300.000) actions ont été partiellement libérées en numéraire par les Souscripteurs 3, de sorte que le
montant total de deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD250.000), soit l’équivalent de deux cent trente-
trois mille Francs suisses (CHF 233.000) a été reçu par la Société, tel que prouvé au notaire instrumentant.

9. Les contributions en numéraire ainsi faites à la Société pour un montant total de deux cent trente-trois mille Francs

suisses (CHF 233.000) sont alloués au compte capital social de la Société;

10. PricewaterhouseCoopersS.àr.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au400 Route d’Esch, B.P.

1443 L-1014 Luxembourg,immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous la référence B 65477, a
été désignée comme réviseur d’entreprises en vue d’évaluer l’apport en nature en application des lois et règlements
applicables. Un rapport a été émis par PricewaterhouseCoopers S.àr.l., le 29 décembre 2011 qui contient les conclusions
suivantes:

«Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the con-

tribution  in  kind  does  not  correspond  at  least  to  the  number  and  the  nominal  value  of  the  shares  to  be  issued  in
counterpart.»

«Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à

penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au nombre et au pair comptable des actions à émettre en
contrepartie.»

11. L’ensemble des Actions de la Tranche 1, des Actions de la Tranche 2 et des Actions de la Tranche 3 comportent

les même droits et obligations que les actions existantes de la Société;

12. Le nombre d’actions souscrites par chacun des Souscripteurs 1, des Souscripteurs 2 et des Souscripteurs 3 et

l’identité de chacun d’eux sont mentionnés dans les Résolutions annexées au présent acte;

13. En conséquence de l’augmentation de capital réalisées ci-dessus, le premier paragraphe de l’article 5 des Statuts

est modifié afin d’être lu comme suit:

« Art. 5.
5.1. Le capital social souscrit s'élève quatre millions huit cent trente-neuf mille quatre cent soixante-quatorze Francs

suisses et trente-six centimes de Francs suisses (CHF 4.839.474,36) divisé en deux cent quarante et un millions neuf cent
soixante-treize mille sept cent dix-huit (241.973.718) actions ayant chacune une valeur nominale de deux centimes de
Francs suisses (CHF 0,02).»

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à onze cents euros (EUR 1.100,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'à la requête des mêmes parties comparantes, en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes
Lecture du document ayant été faite au mandataire des parties comparantes, lequel a signé, avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: Paget, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2011. Relation: LAC/2011/59160. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

6740

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2012005732/265.
(120005110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2012.

Création Coiffure Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 37, avenue Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 116.544.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 05 décembre 2011

Ont comparu:

1. Monsieur Oscar José Morais Amaral, technicien, demeurant à Bettembourg
2. Madame Ana Paula Da Cruz Martins De Araujo, coiffeuse, demeurant à Bettembourg
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société, se sont réunis au siège social

et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'Assemblée accepte la démission de Madame Danielle Thiex, demeurant à L-9353 Bettendorf, 16, Fraeschegaass, de

son poste de gérante technique avec effet au 05 décembre 2011.

<i>Deuxième résolution:

Madame Ana Paula Da Cruz Martins De Araujo, demeurant à L-3221 Bettembourg, 21, rue du Curé, qui accepte, est

nommé gérante technique en remplacement de la gérante cédante.

La société est valablement engagée, quant à ce département, par la signature conjointe de la gérante et de l'associé

Monsieur Oscar José Morais Amaral.

Fait à Howald, le 05 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011171131/22.
(110198962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Socom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 49.898.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 28 novembre 2011 à 19.00 heures à Foetz

Le conseil d’administration accepte la démission de Monsieur Claude MACK de son poste d’administrateur, ainsi que

la démission de Monsieur François LINGEN de son poste d’administrateur et président.

Il ne sera pas pourvu à leur remplacement. Ainsi le nombre des administrateurs passe de 7 à 5 membres.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2011170989/13.
(110198755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Greenhill B6-32 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5368 Schuttrange, 27, rue de Neuhaeusgen.

R.C.S. Luxembourg B 160.001.

En date du 14 décembre 2011, Monsieur Arthur Edouard MORVAN, né le 29 juin 2007 à Luxembourg, résident à

Schuttrange, L-5368, au 27, rue de Neuhaeusgen, a transféré les 125 parts sociales de la société qu'il détenait à Madame
Birghitte KORNERUP, née à Copenhague (Danemark) le 14 août 1969, résidente à Schuttrange, L-5368, au 27, rue de
Neuhaeusgen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

6741

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

<i>Pour la Société
GREENHILL B6-32 SARL
Yannick MORVAN / Birghitte KORNERUP
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011171168/18.
(110198877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Sautic S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 19.441.

Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-

trateur VALON S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 63.143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné
comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'admi-
nistration  de  la  société  SAUTIC  S.A.,  société  anonyme:  Monsieur  Cédric  JAUQUET,  42,  rue  de  la  Vallée,  L-2661
Luxembourg. L'administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 63.130, 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour
son compte au conseil d'administration de la société SAUTIC S.A., société anonyme: Madame Marie BOURLOND, 42,
rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg. L'administrateur KOFFOUR S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 86.086,
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission
au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société SAUTIC S.A., société anonyme: Monsieur Guy
BAUMANN, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 décembre 2011.

<i>Pour: SAUTIC S.A.
Société Anonyme
Experta Luxembourg
Société Anonyme
Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011171238/24.
(110199134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Tersicore Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 20, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 137.767.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 7 octobre 2011 que le siège social de la

société a été transféré du 14, Montée du Grund, L-1645 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 20, rue Louvigny,
L-1946 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet immédiat.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011171000/12.
(110198826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

OXEA Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 153.453.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec

effet immédiat de:

- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW

Surbiton, Royaume-Uni.

Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, de nommer en tant que gérant

de la Société avec effet immédiat:

- Monsieur Fergal O’Hannrachain, né le 27 novembre 1964 à Dublin, Irlande, résidant au 7, rue Tubis, L-2629 Luxem-

bourg.

6742

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011171884/19.
(110198856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

TMT II Luxco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 155.525.

En vertu d'un contrat de cession daté du 8 septembre 2010, Providence TMT Debt Opportunity Fund II L.P. a cédé

ses 25.000 parts sociales, d'une valeur nominale de USD 1 chacune, qu'elle détenait dans la Société à TMT II Hong Kong
Limited, une société régie par les lois de Hong Kong SAR, ayant son siège social au 38 

th

 Floor Tower One, 89 Queens

Way, Hong Kong, immatriculée au registre de commerce de Hong Kong sous le numéro 1502099.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TMT II Luxco S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011171012/15.
(110198785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Unlimited Fun S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 20, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 128.519.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 18 octobre 2011 que le siège social de la

société a été transféré du 14, Montée du Grund, L-1645 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 20, rue Louvigny,
L-1946 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet immédiat.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011171024/12.
(110198827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

ECP Galaxy Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 150.327.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 2 décembre 2011.

En date du 2 décembre 2011 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de nommer Daren Schneider, administrateur, né le 21 novembre 1968 à New York, Etats Unis D'Amérique, de-

meurant professionnellement au One, Lafayette Place, CT - 06830 Greenwich, Connecticut, Etats Unis D'Amérique, en
tant que gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

<i>Gérants de classe A:

- Alex Townsend Krueger
- Alex D. Williams
- Daren Schneider

<i>Gérants de classe B:

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Hille-Paul Schut
- Richard Brekelmans
- Johan Dejans

6743

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2011.

Hille-Paul Schut
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011171144/27.
(110199061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Artal International S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 70.901.

<i>GERANT ASSOCIE - COMMANDITE

Artal International Management S.A.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2011:

L'Assemblée décide de procéder avant fin 2011 au changement d'adresse du siège social de la Société qui sera établi

au 10-12, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Artal International S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2011171083/15.
(110199008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Algeco/Scotsman Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 867.725.416,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.029.

<i>Rectificatif des comptes annuels audités au 31 décembre 2009 et déposés au registre de commerce et des sociétés le 25 août

<i>2010 sous la référence L100130681.04

Les comptes annuels audités révisés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Jan Willem Overheul.

Référence de publication: 2011171073/14.
(110198824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Lglobal Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 160.733.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 03 nov 2011

En date du 03 novembre 2011, le conseil d'administration a décidé:
- De coopter, en date du 3 novembre 2011, Monsieur Simon FLOOD, 65, Chulia Street, #18-01 OCBC Centre,

Singapour 049513 en remplacement de Monsieur Kon Chee KEAT, #08-01, One George Street, SGP - 049145 Singapour
démissionnaire en date du 3 novembre 2011.

Luxembourg, le 09 décembre 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>POUR LGLOBAL FUNDS
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch
Signatures

Référence de publication: 2011171197/17.
(110198895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

6744

L

U X E M B O U R G

Alpha DB Lindsell Limited S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: USD 1.000,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 136.966.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1 

<i>er

<i> décembre 2011

Il résulte dudit extrait que
KPMG Audit sàrl avec siège social à 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, RCS Luxembourg B 103.590 a été élu comme

réviseur d'entreprises pour l'année 2010.

Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Pour extrait conforme
Sabine Hinz
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011171074/16.
(110199044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Beta DB Lindsell Limited S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: USD 1.000,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 137.436.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1 

<i>er

<i> décembre 2011

Il résulte dudit extrait que
KPMG Audit sàrl avec siége social à 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, RCS Luxembourg B 103.590 a été élue

comme réviseur d'entreprises pour l'année 2010.

Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Pour extrait conforme
Sabine Hinz
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011171104/16.
(110199050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

P&amp;S Machines de Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 31, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 157.906.

Im Jahre zweitausendelf, den dreissigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz zu Ettelbruck.

Sind erschienen:

1. Herr Patrick SCHWEITZER, Angestellter, geboren in Moresnet (Belgien), am 3. August 1970, wohnhaft in B-4728

Kelmis, Promenadenstrasse 11;

hier vertreten durch Herrn Rainer PAFFEN, nachbenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift datiert vom

24.11.2011,  welche  nach  „ne  varietur“  Unterzeichnung  durch  den  Komparenten  und  den  instrumentierenden  Notar
gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2. Herr Rainer PAFFEN, Angestellter, geboren in Aachen (Deutschland), am 20. April 1968, wohnhaft in B-4711 Lon-

tzen, Johberg 52;

handelnd  in  ihrer  Eigenschaft  als  alleinige  Teilhaber  der  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  „P&amp;S  Machines  de

Construction S.à r.l." , mit Gesellschaftssitz in L-9753 Heinerscheid, Kierchestrooss 10 (matr:2010 2448 422)

gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, mit dem Amtssitz in Ettelbruck am 13. De-

zember 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 22. März 2011 Nummer 531,

eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburgs unter der Nummer B 157.906,
welche Komparenten sich zu einer aussergewöhnlichen Generalversammlung konstituiert haben und einstimmig, und

laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst haben:

6745

L

U X E M B O U R G

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Heinerscheid nach L-9990 Weiswampach, Duarrefs-

trooss 31, zu verlegen.

Demgemäss wird Artikel 4 Artikel 1 der Gesellschaftssatzung angepasst und erhält folgenden Wortlaut:

« Art. 4. Paragraph 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Weiswampach.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Adresse der Gesellschaft lautet L-9990 Weiswampach, 31, Duarrefstrooss .

<i>Kosten und Honorare

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf

650.- €.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbruck, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Woh-

nort bekannt, haben dieselben mit dem unterzeichnenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Rainer PAFFEN, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 2 décembre 2011. Relation: DIE/2011/11631. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur

 (signé): Ries.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171889/43.
(110198806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Artal Holdings Sp. z o.o., Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 109.443.

<i>CONSEIL DE GERANCE:

Monsieur Paul KÖHLER, Gérant
demeurant à NL-6883 CM VELP
Monsieur Bernard DARIMONT, Gérant
demeurant à B-3080 TERVUREN
Monsieur Kenneth Anthony MORGAN, Gérant
Demeurant à PL-00-803 Warsaw

<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil de gérance du 12 décembre 2011

Le Conseil de Gérance décide de procéder avant fin 2011 au changement d'adresse d'Artal Holdings Sp. z o.o., Suc-

cursale de Luxembourg qui sera établi au 10-12, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

ARTAL HOLDINGS Sp.z o.o., Succursale de Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011171081/20.
(110198974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Lubrizol (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 255.034.800,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 110.778.

EXTRAIT

Les associés de la Société ont, par acte sous seing privé passé en date du 1 

er

 décembre 2011, unanimement décidé

d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 38.604.800 EUR (trente-huit millions six cent quatre mille huit
cents Euro) afin de le porter de son montant actuel de 216.430.000 EUR (deux cent seize millions quatre cent trente
mille Euro) à un montant de 255.034.800 EUR (deux cent cinquante-cinq millions trente-quatre mille huit cents Euro) par

6746

L

U X E M B O U R G

l'émission de 386.048 (trois cent quatre-vingt-six mille quarante huit) nouvelles parts sociales de commandité d'une valeur
nominale de 100 EUR (cent Euro) chacune, lesquelles ont été intégralement souscrites par l'associé commandité de la
Société, Lubrizol (Gibraltar) Limited, une société constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social sis au 10/8
International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, de sorte que l'actionnariat de la société se compose
désormais comme suit:

- Lubrizol (Gibraltar) Limited: 386.345 (trois cent quatre vingt six mille trois cent quarante-cinq) parts sociales de

commandité;

- Lubrizol (Gibraltar) Two Limited: 74.735 (soixante quatorze mille sept cent trente-cinq) parts sociales de comman-

ditaire; et

- Lubrizol (Gibraltar) Minority Limited: 2.089.268 (deux millions quatre vingt neuf mille deux cent soixante huit) parts

sociales de commanditaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

<i>Pour la Société
Jérôme Boudier
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011171191/29.
(110198791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Artal International Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 47.798.

<i>CONSEIL D'ADMINISTRATION:

Monsieur Paul KÖHLER, Administrateur/Administrateur délégué
demeurant à NL-6883 CM VELP
Monsieur Bernard DARIMONT, Administrateur/Administrateur délégué
demeurant à B-3080 TERVUREN
Madame Anne GOFFARD, Administrateur/Administrateur délégué
demeurant à L-2342 LUXEMBOURG

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2011

L'Assemblée décide de procéder avant fin 2011 au changement d'adresse du siège social de la Société qui sera établi

au 10-12, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

ARTAL INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A.
Signature

Référence de publication: 2011171082/20.
(110199005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Artal Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 44.471.

<i>CONSEIL D'ADMINISTRATION:

Monsieur Paul KÖHLER, Administrateur/Administrateur délégué
demeurant à NL-6883 CM VELP
Monsieur Bernard DARIMONT, Administrateur/Administrateur délégué
demeurant à B-3080 TERVUREN
Madame Anne GOFFARD, Administrateur/Administrateur délégué
demeurant à L-2342 LUXEMBOURG

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2011

L'Assemblée décide de procéder avant fin 2011 au changement d'adresse du siège social de la Société qui sera établi

au 10-12, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg.

6747

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

ARTAL LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2011171095/20.
(110198997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Jean-Paul Grand S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 149.910.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 23.11.2011 um 14:30 Uhr, Abgehalten am Gesell-

<i>schaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1. Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wurde bestellt:
Herr Werner Gäng, geboren am 27.01.1958 in Wiesbaden Wohnhaft in Stokarbergstr. 50 CH-8200 Schaffhausen
Das Mandat endet am Tag der ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahr 2016 stattfindet.

Luxembourg, den 23.11.2011.

Unterschrift.

Référence de publication: 2011171182/14.
(110198843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Hôtel Restaurant de la Station S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6250 Scheidgen, 10, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 100.996.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011171697/10.
(110200264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

International Holding Affairs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 106.636.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

L'Assemblée Générale, réunie extraordinairement au siège de la prédite société le 1 

er

 janvier 2011, a pris à l'unanimité

les résolutions suivantes:

1. Les Actionnaires prennent acte du rapport du liquidateur, M. Christian Faltot.
2. Les Actionnaires décident unanimement d'approuver les comptes de liquidation de la Société à la date du 31 dé-

cembre 2010.

3. Se fondant sur le rapport du liquidateur et en considération du fait que Ses Actionnaires détiennent l'intégralité du

capital social de la Société, les Actionnaires décident unanimement et expressément de renoncer à leur droit de nommer
un commissaire à la liquidation.

4. Les Actionnaires décident unanimement d'approuver la répartition du mali de liquidation entre les Actionnaires en

proportion de leur participation dans le capital social de la Société. Les Actionnaires décident en outre unanimement
d'assurer et de garantir qu'après la liquidation, toutes les dettes restantes inconnues et/ou non payées de la Société,
seront assumées par ceux-ci en proportion de leur participation dans le capital social de la Société.

5. Les Actionnaires décident unanimement de donner pleine et entière décharge, sans aucune réserve ou restriction,

à M. Christian Faltot, en sa qualité de liquidateur de la Société.

6. Les Actionnaires décident unanimement de déclarer la liquidation clôturée et la Société sans existence avec effet à

la date du présent acte.

7. Les Actionnaires décident unanimement que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une

période de cinq ans suivant la clôture de la liquidation auprès d'EUROTRUST, une société de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

6748

L

U X E M B O U R G

8. Les Actionnaires décident unanimement de donner tous pouvoirs au liquidateur de la Société afin de procéder à la

clôture de la liquidation.

9. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée après lecture du

procès-verbal qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Luxembourg, le 1 

er

 janvier 2011.

Pour extrait conforme
Monsieur Denis DADASHEV
<i>Scrutateur de l'Assemblée

Référence de publication: 2011171179/36.
(110198984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Herculon Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 133.154.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171695/9.
(110200329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Bilton Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 47.681.

Hiermit kündigen wir unser Mandat als Kommissar der BILTON HOLDING S.A (R.C. B 47 681 Luxembourg) mit

sofortiger Wirkung.

Luxembourg, den 02.12.2011.

LCG International A.G.
Unterschrift
<i>Vögele- Verwaltungsratsvorsitzender

Référence de publication: 2011171105/13.
(110198801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Inesia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 66.931.

L'adresse de Monsieur Dominique Ransquin, membre du conseil d'administration de la société Inesia S.A., a été trans-

férée au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Luxembourg.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2011171177/11.
(110199101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

FR Plasco Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.368.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 2 décembre 2011

En date du 2 décembre 2011 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Michael Verhulst, en tant que gérant de classe B de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Hille-Paul Schut, salarié, né le 29 septembre 1977 à 's-Gravenhage au Pays-Bas, demeurant profession-

nellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société et Daren
Schneider, administrateur, né le 21 novembre 1968 à New York aux Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnel-

6749

L

U X E M B O U R G

lement au One Lafayette Place, CT-06830 Greenwich, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de classe
A de la société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

<i>Gérants de classe A:

- Alan Schwartz
- Daren Schneider

<i>Gérants de classe B:

- Richard Brekelmans
- Johan Dejans
- Hille-Paul Schut

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2011.

Hille-Paul Schut
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011171155/28.
(110199034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

MidOcean Finco (Bezier) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.903,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.191.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 9 février 2011, l'associé de la Société a décidé d'accepter la démission de KPMG Luxembourg en tant que

commissaire aux comptes avec effet au 27 mars 2006.

L'associé unique de la Société a également décidé de nommer KPMG Luxembourg, une société à responsabilité limitée,

ayant pour adresse 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 149.133 avec effet rétroactif au 27 mars 2006 en tant que réviseur d'entreprises agréé
afin d'examiner les états financiers de la Société pour les exercices qui se sont terminés le 30 avril 2006, le 30 avril 2007,
le 30 avril 2008, le 30 avril 2009, le 30 avril 2010 et le 30 avril 2011.

Les associés ont également pris connaissance du changement d'adresse de Monsieur Andrew Spring, gérant de la

Société, au 320, Park Avenue, 16 

th

 Floor, USA - 10022 New York, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2011.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011171203/22.
(110199099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Greenhill B6-36 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5368 Schuttrange, 27, rue de Neuhaeusgen.

R.C.S. Luxembourg B 159.964.

En date du 14 décembre 2011, Mlle Margoth Hélène MORVAN, né le 10 septembre 2003 à Luxembourg, résidente à

Schuttrange, L-5368, au 27, rue de Neuhaeusgen, a transféré les 125 parts sociales de la société qu'elle détenait à Madame
Birghitte KORNERUP, née à Copenhague (Danemark) le 14 août 1969, résidente à Schuttrange, L-5368, au 27, rue de
Neuhaeusgen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

6750

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

<i>Pour la Société
GREENHILL B6-36 SARL
Yannick MORVAN / Birghitte KORNERUP
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011171169/18.

(110198888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Comptoir de Valeurs de Banque, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 2.759.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 21 novembre 2011

<i>Cinquième résolution:

Les mandats de Jean-Maurice BEAUX demeurant professionnellement au 11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg,

Frédéric AMOROSO demeurant professionnellement 17 Cours Valmy 92030 Paris-La-Défense, et Arnaud SERRES de-
meurant professionnellement au 11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg sont confirmés et renouvelés administra-
teurs de Covalba pour le terme de six ans et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l'exercice arrêté au 31 décembre 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/12/2011.

<i>Pour COVALBA S.A.
COMPTOIR DE VALEURS DE BANQUE
Société Anonyme
Jean-Maurice BEAUX / Arnaud SERRES
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011171128/21.

(110198929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Artal Participations &amp; Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 36.896.

<i>CONSEIL D'ADMINISTRATION:

Monsieur Paul KÖHLER, Administrateur/Administrateur délégué

demeurant à NL- 6833 CM VELP

Monsieur Bernard DARIMONT, Administrateur/Administrateur délégué

demeurant à B-3080 TERVUREN

Madame Anne GOFFARD, Administrateur/Administrateur délégué

demeurant à L-2342 LUXEMBOURG

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2011

L'Assemblée décide de procéder avant fin 2011 au changement d'adresse du siège social de la Société qui sera établi

au 10-12, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Artal Participations &amp; Management S.A.
Signature

Référence de publication: 2011171096/20.

(110198985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

6751

L

U X E M B O U R G

Dermal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 13, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 87.419.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement du 8 décembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6 

ème

 section, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- DERMAL S.A. ayant eu son siège social à L-1728 Luxembourg, 13, rue du Marché-aux-Herbes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Me Michel Nickels
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011171136/16.
(110199121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Toproof S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 23, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 51.222.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la fiduciaire
Luxagem s.a.
Jean-Yves Marchand

Référence de publication: 2011172074/12.
(110199730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Electa Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 109.058.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale

En date du 30 novembre 2011, l'assemblée générale a décidé de renouveler les mandats d'administrateur de Eric

VANDERKERKEN et de Josiane WEILER et le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Massimo LON-
GONI jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes annuels de la Société au 30 juin 2010 et qui se
tiendra en 2012 L'assemblée générale a également renouvelé le mandat du réviseur d'entreprises agréé FIDEWA Audit
S.A. jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes annuels de la Société au 30 juin 2010 et qui se
tiendra en 2012.

L'Assemblée a pris note du changement d'adresse de Josiane WELER au 11, rue des Champs, L-1323 Luxembourg et

de Eric VANDERKERKEN au 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Marliani Doris
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011171146/20.
(110199112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

6752

L

U X E M B O U R G

FR Galaxy Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 150.328.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 2 décembre 2011

En date du 2 décembre 2011 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de nommer Daren Schneider, administrateur, né le 21 novembre 1968 à New York, Etats-Unis d'Amérique, demeu-

rant professionnellement au One, Lafayette Place, CT - 06830 Greenwich, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, en tant
que gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

<i>Gérants de classe A:

- Alex Townsend Krueger
- Alex D. Williams
- Daren Schneider

<i>Gérants de classe B:

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Hille-Paul Schut
- Richard Brekelmans
- Johan Dejans

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2011.

Hille-Paul Schut
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011171154/27.
(110199051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Lobelia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 138.593.

<i>CONSEIL DE GERANCE:

Monsieur Paul KÖHLER, Gérant
demeurant à NL-6883 CM VELP
Monsieur Bernard DARIMONT, Gérant
demeurant à B-3080 TERVUREN
Madame Anne GOFFARD, Gérant
demeurant à L-1840 LUXEMBOURG

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 22 juin 2011:

L'Assemblée décide de procéder avant fin 2011 au changement d'adresse du siège social de la Société qui sera établi

au 10-12, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Lobelia S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011171189/20.
(110198981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

6753

L

U X E M B O U R G

Hornblower S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 73.115.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique prises à Luxembourg le 29 novembre 2011

Il résulte desdites résolutions que:
- Le mandat de Monsieur Erimar von der Osten en tant qu'administrateur unique de la Société a été renouvelé pour

une période expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

- Le mandat de BDO Audit, avec siège social à 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que réviseur

d'entreprises agréé de la Société a été renouvelé pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 30 novembre 2011.

Pour extrait conforme
Fabio TREVISAN
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011171170/18.
(110199063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Longbow Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 19.960,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.756.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'associé de la Société; Fairacre Properties

Limited, et ce avec effet immédiat: Clearwater House, 4-7 Manchester Street, Londres, W1U 3AE, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2011.

Richard BREKELMANS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011171190/14.
(110199047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Immobilière du Hameau, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 82.789.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171724/9.
(110200070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Lumination S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 165.234.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the 9 

th

 of December.

Before us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

"KRONOS S.A.", a company incorporated under the laws of Zwitzerland, having its registered office at 23, rue des

Vollandes, in CH-1207 Genève, registered with the Trade and Company Register under number CH-660-0273007-1,

duly represented by Mr Anouar BELLI, Private employee, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy.
The proxy signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain annexed to the present

deed in order to be submitted with it to the registration formalities.

6754

L

U X E M B O U R G

Such appearing person in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a company which it forms hereby:

« Art. 1. Name - Form. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of

the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of «LUMINATION S.A.» (the
“Company”).

Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined period.

Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. Branches or other

offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 4. Object. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

companies or foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The company may lend or borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and

debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public.

The company has as an aim the purchase, the sale, the setting in hiring, the administration and the development in

some form that they are real estates properties located at the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, like all commercial
deals or financial, real estates or movable which are attached to it directly or indirectly.

The object of the Company shall in addition be to receive payments and remunerations from the companies within

the group, and to administer and manage such companies, to which it may, in particular, provide any strategic, adminis-
trative or commercial assistance.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5. Share capital. The subscribed capital of the company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros), divided

into 310 (three hundred ten) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, entirely paid in.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at five million Euros (EUR 5,000,000.-) to be divided

into 50,000 (fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on December 10 

th

 , 2016, to

increase one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash,
by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against the company,
or even by incorporation of profits brought forward, or of available reserves or of issue premiums, or by conversion of
bonds in shares as mentioned below.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Art. 6. Shares. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the

other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

6755

L

U X E M B O U R G

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

Art. 7. Shareholders meetings - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
all acts relating to the operations of the Company.

When the Company has a single shareholder, the latter will exert the powers reserved for the General Shareholder's

Meeting.

Art. 8. Annual general meeting - Approval of annual accounts. The annual general meeting of shareholders shall be

held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting on the second Tuesday of June at 2.00 pm.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.

Art. 9. Other meetings. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the

respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Are deemed to be present for the calculation of the conditions of quorum and majority the shareholders participating

to the meeting by way of videoconference or by any other means enabling their identification, as far as these means satisfy
to technical specifications which guarantee an effective participation to the meeting and a continious transmission of the
debates.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Composition of Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of

three members at least, who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated
by a single shareholder or in case it is stated at a shareholders meeting that the Company has only one single shareholder,
the composition of the board of directors may be limited to one single member until the annual shareholders meeting
following the statement of the existence of more than one shareholder.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 11. Board meetings. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose

from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the share-
holders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, the sole director or two directors, at the place and at

the time indicated in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

Are deemed to be present for the calculation of the conditions of quorum and majority the directors participating to

the meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other means enabling their identification, as
far as these means satisfy to technical specifications which guarantee an effective participation to the meeting of the board
of directors and a continious transmission of the debates. Board meetings held by such means of communication are
deemed to be held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at  a  meeting  of  the  board  of  directors.  Decisions  shall  be  taken  by  a  majority  of  votes  of  the  directors  present  or
represented at such meeting.

6756

L

U X E M B O U R G

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors' meetings.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

In case of Sole Director, the Sole Director will exercise the same powers granted to the Board of Directors.

Art. 12. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all

acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board, directors,
managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Representation. The Company will be bound by the single signature of the sole director, or if the Board of

Directors consists in three members or more by the joint signature of two directors, or the single signature of any person
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 14. Supervision. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which

may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine
their number, remuneration and term of office which may not exceed six years. Their reelection is authorized.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January 1 

st

 and shall terminate on

December 31 

st

 of each year.

Art. 16. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 17. Dissolution. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several

liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Transitional provisions

1)The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and will finish on December 31

st

 , 2011.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2012.

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Shareholders

Subscribed

capital

Paid-in

Capital

Number

of shares

KRONOS S.A. prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

31.000

310

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand euro

(31.000,- EUR) is as of now available to the company

<i>Declaration - Evaluation

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10 

th

 , 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company

as a result of its formation are estimated at approximately 1.300.-.EUR.

6757

L

U X E M B O U R G

<i>Extraordinary General Meeting

The  above  named  person,  representing  the  entire  subscribed  capital  and  considering  itself  as  duly  convened,  has

immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions by vote.
1. The number of director is fixed at one and the number of the statutory auditor at one.
2. Is appointed as sole director:
Monsieur Jean-François CORDEMANS, born in Blankenberge (Belgium), on 26 September 1960, residing at 23, rue

de Vollandes in CH-1207 Genève, Switzerland.

3. Has been appointed statutory auditor:
- Fiduciaire Jean-Marc FABER &amp; Cie S.à.r.l., with registered office at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
4. The address of the Company is set at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
5. The term of office of the director and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual general

meeting of shareholders to be held in the year 2017.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

French version:

L'an deux mille onze, le neuf décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

"KRONOS S.A.", une société de droit suisse, avec siège social à CH-1207 Genève, 23, rue des Vollandes, enregistrée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Genève sous le numéro CH-660-0273007-1,

ici représentée par Monsieur Anouar BELLI, employé privé, résident à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé.

La procuration signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il

suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination - Forme.  Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «LUMINATION S.A.» (la
«Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du

conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Objet. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en location, l'administration et la mise en valeur sous quelque forme

que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations
commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui s'y rattachent directement ou indirectement.

La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations des sociétés du groupe ainsi que

l'administration et la gérance de telles sociétés du groupe, à qui elle pourra notamment fournir toute prestation d'assis-
tance stratégique, administrative ou commerciale.

6758

L

U X E M B O U R G

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000.- (trente et un mille Euros), représenté par

310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune, entièrement libérées.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000.- (cinq millions d'Euros) représenté

par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant sous les mêmes conditions que pour les modifications de statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 10 décembre 2016,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au

choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 7. Assemblée des actionnaires – Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement

constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 8 . Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-

naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième
mardi du mois de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans

les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par

videoconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

6759

L

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 10. Composition du Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé

de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est
constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus
qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée gé-
nérale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six

années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 11. Réunions du Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, de l'administrateur unique ou de deux admi-

nistrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du

conseil d'administration par videoconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, unanimement, passer des résolutions circulaires en donnant son approbation par

écrit, par câble, télégramme, télex ou fax, ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le
tout formera le procès-verbal prouvant l'approbation des résolutions.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de

passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le

conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes

qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la

formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

6760

L

U X E M B O U R G

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs

liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2012.

<i>Souscription et Libération

Le comparant a souscrit un nombre d'actions et a libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires

Capital

souscrit

Capital

libéré

Nombre

d'actions

KRONOS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

31.000

310

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.300,-EUR.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

La personne ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

quée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires aux comptes à un.
2. A été appelé aux fonctions d'administrateur unique:
Monsieur Jean-François CORDEMANS, né à Blankenberge (Belgique) le 26 septembre 1960, demeurant au 23, rue de

Vollandes à CH-1207 Genève, Suisse.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Fiduciaire Jean-Marc FABER &amp; Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
4. L'adresse de la société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
5. La durée du mandat de l'administrateur et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée

générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2017.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A.Belli, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16754. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170841/390.
(110198175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

6761

L

U X E M B O U R G

MidOcean Holdco (Bezier) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 245.218,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.168.

<i>Extrait des résolutions des associés

En date du 11 février 2011, les associés de la Société ont décidé de nommer KPMG Luxembourg, une société à

responsabilité limitée, ayant pour adresse 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133 avec effet rétroactif au 27 mars 2006 en tant que réviseur
d'entreprises agréé afin d'examiner les états financiers de la Société pour les exercices qui se sont terminés le 30 avril
2006, le 30 avril 2007, le 30 avril 2008, le 30 avril 2009, le 30 avril 2010 et le 30 avril 2011.

Les associés ont également pris connaissance du changement d'adresse de Monsieur Andrew Spring, gérant de la

Société, au 320, Park Avenue, 16 

th

 Floor, USA - 10022 New York, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2011.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011171205/20.
(110199095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

MidOcean Holdco (EPL) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 79.900,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.716.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de Monsieur Andrew Spring, gérant de la

Société, au 320, Park Avenue, 16 

th

 Floor, USA - 10022 New York, Etats Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2011.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011171206/14.
(110199102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Melucta Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 149.989.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 13 décembre 2011 que

Monsieur Kamran Khan, demeurant au 258 Laraghcon, Lucan Village, Lucan, Co. Dublin, Irlande, est nommé administra-
teur, avec expiration du mandat le jour de l'assemblée générale qui aura lieu en 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2011171213/14.
(110199104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Interlock Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 92.708.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

6762

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171736/9.
(110199348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

New Star Global Property Management (Luxembourg Five) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 29.180.150,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 121.795.

<i>Extrait informatif

En date du 11 mars 2011, il y a lieu de noter le changement du siège social de l'associé New Star Global Property

Management (Luxembourg Two) S.à r.l.:

- Du 6, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Pour extrait analytique conforme
Jan Willem Overheul / Paul Clarke
<i>Gérants

Référence de publication: 2011171217/16.
(110199060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

New Star Global Property Management (Luxembourg Four) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.967.925,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 121.796.

<i>Extrait informatif

En date du 11 mars 2011, il y a lieu de noter le changement du siège social de l'associé New Star Global Property

Management (Luxembourg Two) S.à r.l.:

- Du 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Pour extrait analytique conforme
Jan Willem Overheul / Paul Clarke
<i>Gérants

Référence de publication: 2011171218/16.
(110199024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

New Star Global Property Management (Luxembourg Three) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.904.150,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 119.270.

<i>Extrait informatif

En date du 11 mars 2011, il y a lieu de noter le changement du siège social de l'associé New Star Global Property

Management (Luxembourg Two) S.à r.l.:

- Du 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Pour extrait analytique conforme
Jan Willem Overheul / Paul Clarke
<i>Gérants

Référence de publication: 2011171219/16.
(110198999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

6763

L

U X E M B O U R G

Citadelle Trust &amp; Management Services S.C., Société Civile.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg E 4.642.

STATUTES

On 1 December 2011 the undermentioned persons
1. Richard Turner, réviseur d'entreprises living in Bourglinster, Luxembourg
2. Citadelle Corporate Services S.A.R.L., to be incorporated in Luxembourg and represented by Mr. Gerard Ossevoort

in terms of a power of attorney duly granted by a resolution of its proposed founders on 1 December 2011, original
versions of which are attached hereto, which is to be confirmed by its board of directors upon it being constituted

declare to have agreed to form a company which will have the following statutes.

Section 1. Form - Name - Objects - Registered address - Duration

Art. 1. By the present is constituted between the above mentioned persons a civil company (société civile) which will

exist between the owners of the parts of the capital hereafter created and those who may become owners of such parts
in the future.

This company is governed by the present statutes as well as by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably

articles 1832 to 1872 of the Civil Code.

Art. 2. The name of the company is:
- CITADELLE TRUST &amp; MANAGEMENT SERVICES S.C.

Art. 3. The company has as its main object the exercising of all activities related to the profession of a registered

auditor (réviseur d'entreprises) including undertaking assignments as a statutory auditor (commissaire aux comptes), for
the administration of companies for third parties and as a domiciliation agent.

Conforming to the laws and regulations currently applicable the company will be able to undertake appointments as

commissaire aux comptes, director of companies and for the provision of registered offices for other companies.

In addition, the company may invest in any form of other companies or undertakings, by way of contribution to their

capital or in any other manner, which have similar objects and which have the potential to develop or extent the business
of the company

Art. 4. The registered address of the company is established in Bertrange. It may be transferred to any other address

within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the owners of the parts of the capital in a general meeting.

Art. 5. The duration of the company is 30 years from the date of its constitution, which period, without prejudice,

may be prolonged or reduced.

Section 2. Contribution of capital - Description of the rights of the holders of the capital

Art. 6. The capital fully paid up will be EUR 800 (eight hundred Euros) divided into 100 parts without nominal value.

The parts are split as follows:

1. Richard Turner, as previously mentioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 (fifty one) parts

2. Citadelle Corporate Service S.a.r.l. i.c., as previously mentioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 (forty nine) parts

Each part is considered by the company to be indivisible.

Art. 7. The fully paid parts of the capital are transferable between the holders of the parts and, for so long as the

company acts as a registered auditor, a registered auditor will hold not less than 51 percent of the parts of the capital of
the company.

Otherwise, the parts of the capital may not be transferred to third parties who are not already holders of parts of the

capital without the unanimous approval of all the holders of parts of the capital.

And otherwise, the holders of parts of the capital have an absolute right of pre-emption over other parts at an equal

price.

Art. 8. Each part of the capital of the company shall entitle its owner to one vote and to a prorata share of the total

of any distribution of profits or capital of the company.

Art. 9. Each holder of parts of the company is held liable for the debts of the company in proportion to the number

held.

Art. 10. The company will not be dissolved by the death of one or more holders of parts of the capital but will continue

between the surviving holders and the successors of the deceased holder or holders.

The insolvency or prevention of the capacity to act of any holder of parts of the capital shall not cause the company

to be liquidated, it will be continued by the remainder of the holders of parts of the company.

6764

L

U X E M B O U R G

Art. 11. The company shall be managed and administered by one or several managers who shall be registered auditors

for as long as the company undertakes assignments, which by law are limited to members of the Institut des Réviseurs
d'entreprises.

Art. 12. The financial year end of the company begins on the first day of January and ends on 31 December of each

year, except for the first year which will commence on 1 November 2011 and end on 31 December 2011.

Art. 13. Once a year the holders of the parts of the company will meet ordinarily to decide on the approval of the

financial accounts to the end of the previous year, to decide on the distribution of the results for that year, and to decide
on the discharge of the manager or managers.

Otherwise, the holders will meet extraordinarily to make any other decisions, including the amendment of these

statutes, whenever called upon to do so by holders of not less than 15 percent of the parts of the company.

When meeting ordinarily a simple majority of parts of the capital will constitute both a minimum quorum and vote on

a decision, when meeting extraordinarily, this will increase to two thirds for both a minimum quorum and vote on a
decision.

Art. 14. At the termination of the duration of the company or in the case of an anticipated earlier liquidation, the

liquidation will be made by the holders of the parts or by third party, who may be chosen by common consent and whose
powers will be then fixed.

The liquidator will be able, upon a decision of the holders of the parts, to transfer the assets or net assets, in part or

in whole, namely assets and liabilities, to another individual, civil or commercial company.

The net surplus of the liquidation, after settling all liabilities, engagements and obligations will be shared between the

holders of the parts in proportion to the number held by each of them.

Art. 15. In the case of any dispute the English version of these statutes will prevail.

<i>Extraordinary general meeting

And at the instance of the holders of the parts of the capital an extraordinary meeting of the company was then held

and the following resolutions were unanimously decided.

1. Richard Turner, réviseur d'entreprises, already mentioned, is named as the manager.
2. The company is engaged and bound by the signature of the manager signing alone on any reports, documents or

contracts that are issued by the company relating to assignments undertaken by it in its capacity as a réviseur d'entreprises.
The company is engaged and bound on all other matters by both holders of the parts of the company signing together,
except that towards the State a single signature will be binding.

3. The registered office of the company will be:
2 rue Pletzer, L -8080 Bertrange
There being no further business the meeting was declared closed.

Signed in four original examples in Luxembourg on 1 December 2011.

Citadelle Corporate Services S. à r.l. / Richard Turner
By proxy by Gerard Ossevoort / -

Traduction française du texte qui précède:

Ont comparu le premier décembre l'an deux mille onze,
1. Richard Turner, réviseur d'entreprises, demeurant à Bourglinster, Luxembourg
2. CITADELLE Corporate Services S.à r.l. une société en train d'être constituée à Luxembourg et représentée par M.

Gérard Ossevoort, en vertu d'un pouvoir lui conféré par résolution des fondateurs proposés du 1 décembre 2011, une
version originale restera annexée aux présentes, qui sera confirmée par son conseil d'administration après elle a été
constituée.

Ces comparants ont déclaré avoir convenu de constituer la société dont ils vont établir les statuts comme suite.

Titre I 

er

 . Forme - Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, entre les comparants, une société civile qui existera entre les propriétaires

des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832 à

1872 du code civil.

Art. 2. La société prend la dénomination CITADELLE TRUST &amp; MANAGEMENT SERVICES S.C.

Art. 3. La société a pour objet l'exercice de toutes activités liées à la profession de réviseur d'entreprises incluant

l'exécution de mandats de commissaire aux comptes, provision des administrateurs de sociétés pour les tiers et d'agent
domiciliataire.

6765

L

U X E M B O U R G

La société pourra, conformément aux lois et règlements en vigueur, exercer des mandats de commissaire aux comptes,

d'administrateur des sociétés et de fournir les sièges sociales des autres sociétés.

En plus la société peut s'intéresser par voie d'apport ou par toute autre voie dans toutes les sociétés ou entreprises

ayant en tout ou en partie un objet similaire au sien ou susceptibles d'en favoriser le développement ou l'extension.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg ou de l'étranger par simple décision des associés réunis en assemblée générale.

Art. 5. La durée de la société est de 30 ans à partir de sa constitution, sans préjudice d'une prolongation ou d'une

réduction de la durée statutaire.

Titre II. - Apports - Attribution des parts sociales

Art. 6. Le capital intégralement libéré est d'EUR 800 (huit cents euros), divisé en 100 (cent) parts sociales sans valeur

nominale. Les parts sont réparties comme suit:

1. Richard Turner, pré qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 (cinquante et une) parts
2. Citadelle Corporate Services S.à r.l. pré qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 (quarante-neuf) parts

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associé et aussi longtemps que la société agit comme réviseur d'en-

treprises, un réviseur d'entreprises détiendra au moins 51 pour cent des parts sociales.

Autrement, elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'accord unanime de tous les associés.
Et autrement, les associés disposent d'un droit de préemption absolue des parts sociales à prix égal.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une voix et chaque part sociale donne un droit à la proportion du nombre

de parts qu'il possède aux affectations de profits ou capital de la société.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun à la proportion du

nombre de parts qu'il possède.

Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ne
mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés.

Art. 11. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui seront réviseurs d'entreprises pour aussi

longtemps que la société prend les missions qui sont par loi réservées aux réviseurs d'entreprises.

Art. 12. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf le premier exercice

qui commence le 1 

er

 décembre 2011 et se termine le 31 décembre 2011.

Art. 13. Une fois par an les associés seront convoqués à tenir une assemblée générale ordinaire, à donner approbation

du bilan de l'exercice précédent, à décider de l'affectation du résultat de cet exercice et à décider à la décharge du gérant
ou des gérants.

Autrement, les associés seront convoqués extraordinairement à tenir les autres décisions, incluant la modification de

ces statuts, chaque fois que les associés représentant au moins quinze pour cent des parts sociales, le demande.

Pour les assemblées ordinaires une majorité simple des parts sociales suffira à établir un quorum et à prendre les votes

sur une décision et, pour les assemblées extraordinaires, cette majorité augmentera à deux troisièmes des parts sociales
pour le quorum et pour le vote sur une décision.

Art. 14. A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les associés ou par

un mandataire qu'ils auront choisi d'un commun accord et dont ils auront fixé les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou com-

merciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associées proportion-

nellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Art. 15. En cas de divergence le texte anglais fera foi.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité ils ont pris les décisions

suivantes:

1. Monsieur Richard Turner, pré qualifie, est nommé gérant.
2. La société est valablement engagée par la signature du gérant signant seule sur les rapports, documents ou contrats

qui sont émis par la société liés aux missions entreprises dans sa qualité de réviseur d'entreprises. Dans tous autres cases

6766

L

U X E M B O U R G

la société est engagée par les signatures conjointes des deux associés, sauf dans ses rapports avec l'Etat ou une de leurs
signatures sera valable.

3. Le siège social est établi à 2 rue Pletzer, L - 8080 Bertrange.
Plus rien n'étant à l'ordre de jour, la séance est levée.

Fait en quatre versions originales à Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2011.

Citadelle Corporate Services S. à r.l. / Richard Turner
Par procuration par Gerard Ossevoort / -

Référence de publication: 2011172144/165.
(110198259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

New Star Global Property Management (Luxembourg Two) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.047.275,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 114.059.

<i>Extrait Informatif

En date du 11 mars 2011, il y a lieu de noter le changement du siège social de l'associé New Star Global Property

Management (Luxembourg One) S.à r.l.:

- Du 6, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Pour extrait analytique conforme
Jan Willem Overheul / Paul Clarke
<i>Gérants

Référence de publication: 2011171220/16.
(110198970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Realtour Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 153.639.

Hiermit kündigen wir unser Mandat als Kommissar der REALTOUR HOLDING S.A. (R.C. B 153 639 Luxembourg)

mit sofortiger Wirkung.

Luxembourg, den 09.12.2011.

LCG International S.A
Unterschrift
<i>Vögele -Verwaltungsratsvorsitzender

Référence de publication: 2011171231/13.
(110198799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

RL Private Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 142.985.

Der Sitz der Gesellschaft
«RL Private Holding S.A.R.L.»
ist:
11A, Boulevard Joseph II
L- 1840 Luxembourg

RL Private Holding S.A.R.L.
Unterschrift

Référence de publication: 2011171232/14.
(110198837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

6767

L

U X E M B O U R G

BelGerAs, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 124.145.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2011

L'assemblée constate que la dénomination sociale de son commissaire aux comptes MAZARS, enregistré au Registre

de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B56248, a été modifiée en FIDUO avec effet au 1 

er

 juillet

2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011172302/12.
(110200477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Weatherford European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 150.992.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 18 novembre 2011

1. Mme Christel DAMASO a été révoquée de son mandat de gérante B.
2. M. Franklin Louis WEIDEMA a été révoqué de son mandat de gérant B.
3. M. Peter LOVASZ, administrateur de sociétés, né à Kazincbarcika (Hongrie), le 9 janvier 1972, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a démissionné de son mandat de gérant
A et il a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.

4. Le nombre des gérants a été diminué de 5 (cinq) à 3 (trois).

Luxembourg, le 14 DEC. 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Weatherford European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011171269/18.
(110198889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Weatherford HCC Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 160.852.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 18 novembre 2011

1. Mme Christel DAMASO a démissionné de son mandat de gérante B.
2. M. Franklin Louis WEIDEMA a démissionné de son mandat de gérant B.
3. M. Peter LOVASZ, administrateur de sociétés, né à Kazincbarcika (Hongrie), le 9 janvier 1972, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a démissionné de son mandat de gérant
A et il a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.

4. Le nombre des gérants a été diminué de 5 (cinq) à 3 (trois).
Veuillez prendre note que l'associée unique, la société à responsabilité limitée Weatherford Financing (Luxembourg)

S.à.r.l. a changé de siège social et se situe désormais à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 14 DEC. 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Weatherford HCC Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011171270/20.
(110198892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

6768


Document Outline

Algeco/Scotsman Group S.à r.l.

Alpha DB Lindsell Limited S.C.S.

Althelia Climate Fund GP, S.à r.l.

Artal Holdings Sp. z o.o., Succursale de Luxembourg

Artal International Management S.A.

Artal International S.C.A.

Artal Luxembourg S.A.

Artal Participations &amp; Management S.A.

BelGerAs

Beta DB Lindsell Limited S.C.S.

Bilton Holding S.A.

Citadelle Trust &amp; Management Services S.C.

Comptoir de Valeurs de Banque

Création Coiffure Sàrl

Dermal S.A.

ECP Galaxy Holdings S.à r.l.

Electa Capital Partners S.A.

FR Galaxy Holdings S.à r.l.

FR Plasco Holdings Sàrl

Global Brands S.A.

Greenhill B6-32 S.à r.l.

Greenhill B6-36 S.à r.l.

Herculon Investholding S.à r.l.

Hornblower S.A.

Hôtel Restaurant de la Station S.à r.l.

Immobilière du Hameau

Inesia S.A.

Interlock Investholding S.à r.l.

International Holding Affairs S.A.

Jean-Paul Grand S.A.

Lglobal Funds

Lobelia S.à r.l.

Lombard Odier Selection

Longbow Capital S.à r.l.

Lubrizol (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S.

Lumination S.A.

Melucta Investment S.A.

MidOcean Finco (Bezier) S.à r.l.

MidOcean Holdco (Bezier) S.à r.l.

MidOcean Holdco (EPL) S.à r.l.

New Star Global Property Management (Luxembourg Five) S.à r.l.

New Star Global Property Management (Luxembourg Four) S.à r.l.

New Star Global Property Management (Luxembourg Three) S.à r.l.

New Star Global Property Management (Luxembourg Two) S.à r.l.

OXEA Finance S.à r.l.

P&amp;S Machines de Construction S.à r.l.

Realtour Holding S.A.

RL Private Holding S.à r.l.

Sautic S.A.

Socom S.A.

Tersicore Invest S.A.

TMT II Luxco S.àr.l.

Toproof S.A.

Unlimited Fun S.A.

Weatherford European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Weatherford HCC Holdings (Luxembourg) S.à r.l.