logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3179

24 décembre 2011

SOMMAIRE

Albatros Solutions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

152548

Alfred Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152563

Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152549

Apex Insurance Holdings LLC Luxem-

bourg S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152547

Archipel Newko S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152549

Assoco Ré S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152548

BDCI Investments S.à r.l. SPF  . . . . . . . . . . .

152552

Belval Plaza Tower S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

152550

Blue Shield Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

152552

C.H.A.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152553

Daregon Financial Services S.A.  . . . . . . . . .

152554

Degussa Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152546

Delta Yachting Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

152554

Devon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152556

DeWAG LT Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

152554

Dexamenos Développement S.A.- SPF . . .

152557

Dom Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152557

Dumagis S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152587

Eikon Invest II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152561

Eikon Mezzanine Income S.A.  . . . . . . . . . . .

152562

Eikon Mezzanine Invest III S.A.  . . . . . . . . . .

152562

Elektron S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152562

ENEX Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152576

Enrotec Lux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152576

Entreprise de Peinture MASSEN S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152557

Epinikion Services Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152548

Equalia Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152552

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152577

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152577

Etab Engineering GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . .

152554

Eupalia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152586

Eurocom J.L.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152558

European Financial and Partners S.A. So-

parfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152586

EuroRidge Solar Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

152558

EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l.  . . . .

152589

Evonik Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152546

Extravaganza S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152589

Fagas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152592

Fintlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152577

Finwellness S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152562

First Data International Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152553

Flying Group Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152592

Flying Group Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152591

Four Seas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152592

Gerüstbau A. Mathieu GmbH  . . . . . . . . . . .

152591

Global Financial and Commercial Holdings

Sapphire S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152577

Global Groupe International S.A.  . . . . . . . .

152592

Harsco Metals Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

152561

HC Investissements (Europe) S.à r.l.  . . . . .

152557

Hitechphoto S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152575

Jigsaw SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152555

Latsco Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

152561

Moon Stone International Investment S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152553

PPF Tivoli S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152550

Sculptor Springs of Eden S.à r.l.  . . . . . . . . .

152558

Smartsynergy s.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152549

Solucom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152589

WIKIO Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152557

Zaka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152587

152545

L

U X E M B O U R G

Evonik Re S.A., Société Anonyme,

(anc. Degussa Re).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 18.707.

Im Jahre zweitausendundelf, am fünfundzwanzigsten Oktober.
Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxemburg.
Sind die Aktionäre der „DEGUSSA RE S.A.“, Aktiengesellschaft mit Sitz in Howald, zu einer ausserordentlichen Ge-

neralversammlung zusammen getreten. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notrieller Urkunde vom 24. September
1981, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nummer 251 von 1981. Die Satzung
wurde  zuletzt  abgeändert  gemäss  notarieller  Urkunde  vom  22.  Dezember  2004,  veröffentlicht  im  Mémorial,  Recueil
Spécial C, Nummer 498 vom 26. Mai 2004.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Bérengère DESMET, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Zur  Schriftführerin  und  Stimmzählerin  wird  bestimmt  Frau  Hildegard  WINNEBECK,  Privatangestellte,  beruflicht

wohnhaft in Luxemburg.

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigten gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich  die  Anwesenheit  beziehungsweise  Vertretung  sämtlicher  Aktionäre,  so  dass  von  den  gesetzlichen  vorgesehenen
Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte. Die Anwesenheitsliste bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage bei-
gefügt.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-

men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1.- Umänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in Evonik Re S.a.
2.- Abänderung von Artikel eins der Satzung.
3.- Verlegung des Gesellschaftssitzes nach 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
4.- Abänderung des ersten Satzes des Artikels 2 der Satzung.
5.- Abänderung des Artikels 15 der Satzung, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird:
„Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Donnerstag im Monat März um 11.30 in der Ge-

meinde des Gesellschaftssitzes oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort. Sofern dieser Tag ein Feiertag
ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.“

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in Evonik Re S.A. abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel eins der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 1. „Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung Evonik Re S.A.“

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz nach L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal, zu verlegen.

<i>Vierter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird der erste Satz des Artikels 2 der Satzung wie folgt abgeändert:

„ Art. 2. Sitz. (Erster Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.“

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 15 der Satzung, wie folgt abzuändern:
„Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Donnerstag im Monat März um 11.30 in der Ge-

meinde des Gesellschaftssitzes oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort. Sofern dieser Tag ein Feiertag
ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.“

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

152546

L

U X E M B O U R G

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. DESMET, H. WINNEBECK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2011. Relation: LAC/2011/47751. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21. November 2011.

Référence de publication: 2011158888/60.
(110185356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Apex Insurance Holdings LLC Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 69.783.

L'an deux mille onze, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions Apex Insurance Holdings

LLC Luxembourg S.C.A., ayant son siège social à L-2529 Howald, 45, rue des Scillas, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, numéro B 69.783, constituée suivant acte notarié reçu en date du 25 mai 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 554 du 19 juillet 1999. La société a été mise en liquidation
suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 avril 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1021 du 15 mai 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Bérengère DESMET, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire et scrutateur, Madame Hildegard WINNEBECK, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
2. Modification afférente de l'article 4 des statuts.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-2529 Howald, 45, rue des Scillas à L-2449 Luxembourg, 26,

boulevard Royal de sorte que le premier alinéa de l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Des succursales ou autres implantations peuvent être établies

soit au Grand-Duché du Luxembourg soit à l'étranger sur décision de l'Associé Commandité.»

Suit la traduction anglaise:

“The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established

either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the General Partner.”

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

152547

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : B. DESMET, H. WINNEBECK et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2011. Relation: LAC/2011/47752. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158751/55.
(110185359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Assoco Ré S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 26.955.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 28 octobre 2011 à 10h00 au siège social de ASSOCO

<i>Ré S.A.

Le Conseil d’Administration a pris les résolutions suivantes:

<i>Résolution 2:

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Thierry Lagasse de Locht de son poste d'admi-

nistrateur avec effet au 23 septembre 2011

<i>Résolution 3:

Afin de combler cette vacance et conformément à l’article 8 des statuts, le Conseil coopte comme Administrateur

avec effet au 23 septembre 2011, Monsieur Marc Van Den Neste demeurant au 1, Sentier du Château, B-1495 Villers la
Ville, en remplacement du poste d Administrateur de Monsieur Thierry Lagasse de Locht, démissionnaire. La prochaine
Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2012 confirmera ce mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Extrait sincère et conforme
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011158759/21.
(110185393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Epinikion Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 133.836.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 21.11.2011.

<i>Pour Epinikion Services Sarl
International Consulting Worldwide Sarl.
2, rue de la Moselle
L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2011158908/15.
(110185076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Albatros Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 46.875.

<i>Extrait de la lettre avec accusée de réception, datée du 5 Octobre 2007

Je soussigné, Frédéric LECLERCQ démissionner, tel que stipulé dans la lettre recommandée adressée en date du 5

Octobre 2007 à la société Albatros Solutions S.a., de mes fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué de la
société Albatros Solutions S.a. RC B 46.875.

152548

L

U X E M B O U R G

Mardi, le 22 Novembre 2011.

Frédéric LECLERCQ.

Référence de publication: 2011158766/12.
(110185278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Alta, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 139.974.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2011.

Référence de publication: 2011158771/10.
(110184814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Smartsynergy s.a., Société Anonyme.

Siège social: L-4842 Rodange, 39-41, rue Terre Noire.

R.C.S. Luxembourg B 115.374.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de Smartsynergy S.A. tenue au siège social le 30 décembre 2009

<i>à 16 heures

<i>Résolutions

1. L’assemblée approuve le renouvellement, pour une période déterminée du 16 mars 2009 au 16 mars 2015, du

mandat de l’administrateur:

Monsieur Thibaut Marescau
2. L’assemblée approuve le renouvellement, pour une période déterminée du 16 mars 2009 au 16 mars 2015, du

mandat de l’administrateur:

Monsieur Dirk Marescau
3. L’assemblée approuve le renouvellement, pour une période déterminée du 16 mars 2009 au 16 mars 2015, du

mandat de l’administrateur:

Monsieur Barthold Van Der Goten
4. L’assemblée approuve le renouvellement, pour une période déterminée du 16 mars 2009 au 16 mars 2015, du

mandat de l’administrateur délégué:

Monsieur Thibaut Marescau
5. L’assemblée approuve le renouvellement, pour une période déterminée du 16 mars 2009 au 16 mars 2015, du

mandat de l’administrateur délégué:

Monsieur Barthold Van Der Goten
6. L’assemblée approuve le renouvellement, pour une période déterminée du 16 mars 2009 au 16 mars 2012, du

mandat du commissaire aux comptes:

Madame Monika Maes
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 17 heures après signature du présent procès-

verbal par les membres du bureau.

Vincent Demeuse / Pascal Jungling / Dirk Marescau
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2011159978/32.
(110185607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Archipel Newko S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 114.755.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158777/10.
(110184811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152549

L

U X E M B O U R G

Belval Plaza Tower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.

R.C.S. Luxembourg B 119.548.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011158803/10.
(110185024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

PPF Tivoli S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 1.866.200,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 131.447.

In the year two thousand eleven, on the eleventh day of November.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

Pramerica Property Partners Fund (UK) L.P., a limited partnership duly organized under the laws of the United King-

dom, having its registered office at Grand Buildings, 1-3 Strand, London WC2N 5HR, United Kingdom,

here represented by Mr. Raymond Thill, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 10

November 2011.

The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholders (the "Sole Shareholder") of a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) "PPF Tivoli S.à r.l.", having its registered office at 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
131.447 and incorporated pursuant to a deed dated 21 August 2007 drawn up by Maître Martine Schaeffer, notary residing
in Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 12 October 2007, number 2286,
page 109682. The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended for the last time pursuant
to a deed dated 12 July 2010 of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on 16 September 2010, number 1908, page 91567.

The appearing party representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the Company's share capital by an amount of one million three hundred

twenty thousand Swiss francs (CHF 1,320,000.-) (the "Reduced Amount") in order to bring it from its current amount
of three million one hundred eighty-six thousand two hundred Swiss francs (CHF 3,186,200.-) to one million eight hundred
sixty-six thousand two hundred Swiss francs (CHF 1,866,200.-) by cancellation of thirteen thousand two hundred (13,200)
shares having a nominal value of one hundred Swiss francs (CHF 100.-) each (the "Cancelled Shares").

The Reduced Amount shall be paid to the Sole Shareholder.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles accordingly, which shall read as follows:

Art. 6. The Company's share capital is set at one million eight hundred sixty-six thousand two hundred Swiss francs

(CHF 1,866,200.-) represented by eighteen thousand six hundred sixty-two (18,662) shares with a par value of one
hundred Swiss francs (CHF 100.-) each."

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (EUR 1,250.-).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

152550

L

U X E M B O U R G

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, said proxyholder appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le onze novembre.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signée.

A COMPARU:

Pramerica Property Partners Fund (UK) L.P., une limited partnership organisée en vertu des lois du Royaume-Uni,

ayant son siège social au Grand Buildings, 1-3 Strand, Londres WC2N 5HR, Royaume-Uni,

ici représentée par Monsieur Raymond Thill, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration lui conférée sous seing privé le 10 novembre 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte, aux fins d'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") d'une société à responsabilité limitée "PPF Tivoli S.à

r.l." (la "Société") ayant son siège social au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 131.447, constituée par acte de
Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations le 12 octobre 2007, numéro 2286, page 109682. Les statuts de la Société (les "Statuts") étaient modifiés
pour la dernière fois le 12 juillet 2010 par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 16 septembre 2010, numéro 1908, page 91567.

La partie comparante représentant l'intégralité du capital social a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant d'un million trois cent vingt mille francs

suisses (CHF 1.320.000,-) (le "Montant Réduit") pour le réduire de son montant actuel de trois millions cent quatre-vingt-
six mille deux cent francs suisses (CHF 3.186.200,-) à un montant d'un million huit cent soixante-six mille deux cent francs
suisses (CHF 1.866.200,-) par l'annulation de treize mille deux cent (13.200) parts sociales, ayant une valeur nominale de
cent francs suisses (CHF 100,-) chacune (les "Parts Sociales Annulées").

Le Montant Réduit sera payé à l'Associé Unique.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l’article 6 des Statuts en conséquence, lequel aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme d'un million huit cent soixante-six mille deux cent francs

suisses (CHF 1.866.200,-) représenté par dix-huit mille six cent soixante-deux (18.662) parts sociales, d'une valeur de
cent francs suisses (CHF 100,-) chacune."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève approximativement à mille deux cent cinquante euros (EUR
1.250,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. À la demande de la partie comparante, il est spécifié
qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date en en-tête des présentes.
Lecture faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et

demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51119. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

152551

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Référence de publication: 2011159949/98.
(110185891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Equalia Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 102.473.

En date du 26 octobre 2011, les actionnaires ont décidé de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde

L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

Les actionnaires constatent que Christophe Davezac et Géraldine Schmit, administrateurs de catégorie B, ont transféré

leur adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158927/13.
(110185398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

BDCI Investments S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.499.

EXTRAIT

En date du 28 octobre 2011, le Conseil de gérance coopte Monsieur David RAVIZZA, cadre, né le 21 décembre 1965

à Mont-Saint-Martin, domicilié au 42, rue Mantrand, F-54650 Saulnes en remplacement de Monsieur Michele CANEPA,
gérant démissionnaire.

Il reprendra le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158825/14.
(110185254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Blue Shield Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 113.423.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme BLUE SHIELD

INVESTMENTS S.A. tenue extraordinairement en date du 11 novembre 2011 à (L-1420) Luxembourg, 15-17, avenue
Gaston Diderich, que:

- La société Citadel Administration S.A. a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement

de la société Cardinal Trustees Ltd démissionnaire, avec effet au 1 

er

 octobre 2011 et ce jusqu'à l'assemblée générale qui

se tiendra en 2017.

<i>Commissaire aux comptes:

Citadel Administration S.A.
15-17 avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg

Pour extrait conforme
S.W. BAKER
<i>Administrateur

Référence de publication: 2011158835/21.
(110185423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152552

L

U X E M B O U R G

Moon Stone International Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 112.073.

<i>Résolutions des associés datées du 2 Novembre 2011

L'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société vers L-2130 Luxembourg 23, Boulevard Charles Marx.

<i>Deuxième résolution

Les associés approuvent et confirment, la nomination de Mrs Max Garotta, Vincent Villem et Axel Rust avec adresse

L-2130 Luxembourg 23, Boulevard Charles Marx aux fonctions d'Administrateurs avec effet immédiat.

Tous ces points sont adoptés à l’unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011159186/17.
(110185277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

C.H.A.S. S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 75.665.

La Fiduciaire Scheiwen - Nickels &amp; Associés S.à r.l. a dénoncé par lettre recommandée au 12 octobre 2011 tout office

de domiciliation de la société C.H.A.S. S.A. ayant son siège statutaire au 126, rue Cents, L-1319 Luxembourg et inscrite
au RCSL sous la section B numéro 75.665 avec effet au 12 octobre 2011.

Luxembourg, le 24 octobre 2011.

Référence de publication: 2011158840/10.
(110185308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

First Data International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.700,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.072.

<i>Extract of the resolutions of the sole shareholder taken on august 30 

<i>th

<i> , 2011

- The resignation of Mr Steve MENZIES from his mandate as Manager, with effect on July 31 

st

 , 2010 be accepted.

- The appointment of Mr. Barry COOPER, born on January 6 

th

 , 1967,in Port Elizabeth (South - Africa) residing at

10427 E Crestline PL Englewood, CO 80111 - 3842, USA, as manager in replacement of the resigning manager with effect
as of July 31 

st

 , 2010 be accepted. The duration of his mandate is unlimited.

Certified true

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 août 2011

- La démission de Mr Steve MENZIES de son mandat de gérant avec effet au 31 juillet 2010 est acceptée.
- La nomination de Monsieur Barry COOPER, né le 6 janvier 1967 à Port Elizabeth (Afrique du Sud) domicilié au 10427

E Crestline PL Englewood, CO 80111 -3842, USA en tant que gérant, avec effet au 31 juillet 2010 est acceptée. Son
mandat aura une durée illimitée.

Certifié conforme
First Data International Luxembourg S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2011158943/22.
(110185255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152553

L

U X E M B O U R G

DeWAG LT Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.315.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011158877/10.
(110184923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Daregon Financial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 110.359.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
DAREGON FINANCIAL SERVICES S.A.

Référence de publication: 2011158880/11.
(110185404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Delta Yachting Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 148.067.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 4 novembre 2011

que:

1. Monsieur Mr Francesco CUZZOCREA, né à Locarno (Suisse) le 22 octobre 1960 demeurant à Via alla Campagna

1 - 6942 Porza (Suisse); et

Monsieur Lamberto TACOLI, né le 1 

er

 septembre 1964 à Cesena (Italie) demeurant Via Degli Scalini 6/2 - 40136

Bologne (Italie)

ont été élus administrateurs de la Société.
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158889/18.
(110185430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Etab Engineering GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5555 Remich, 6, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 61.237.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 21.11.2011.

<i>Pour ETAB Engineering GmbH
International Consulting Worldwide Sarl.
2, rue de la Moselle
L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2011158932/15.
(110185030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152554

L

U X E M B O U R G

Jigsaw SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 90.034.

DISSOLUTION

In the year two thousand eleven, on the eleventh day of November.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Frank Trinteler, employee, residing professionally in Schuttrange,
acting in the name and on behalf of Strathkiel Investments Ltd, a company existing under cypriot law, having its regis-

tered office at 11 Boumpoulinas Street, 1 

st

 floor, 1060 Nicosia, Cyprus, registered in the Registrar of Companies under

the number HE 196039,

by virtue of a proxy dated November 10 

th

 , 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation "JIGSAW S.A.", having its registered office in L-5367 Schuttrange,64, rue Principale, was incor-

porated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the fourth day of October, 2002, published in the Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations, number 1813 on the 24 

th

 day of December, 2002 and the articles of incorporation

of which have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, dated on July, 31 

st

 , 2003, published

in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1109 of the 24 

th

 day of October, 2003;

-  that  the  capital  of  the  corporation  “JIGSAW  S.A."  is  fixed  at  THIRTY  ONE  THOUSAND  EURO  (31,000.-Eur)

represented by ONE THOUSAND(1,000) shares with a par value of THIRTY ONE EURO (31.-Eur)) each, fully paid up;

- that Strathkiel Investments Ltd, aforenamed, has become owner of all the shares;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-

patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at the 11 

th

 day of November, 2011, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities

arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:
- the Company’s activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at the 11 

th

 day of November, 2011, being only one

information for all purposes;

- following the above resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company’s directors and statutory auditor are hereby granted full discharge with respect to their duties;
- there shall be arranged the cancellation of all issued shares and/or the shareholders register;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-5367 Schuttrange, 64,

rue Principale.

The undersigned notary, who knows and speaks English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand euro(1,000.-Eur).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day first above written.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le onze novembre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

152555

L

U X E M B O U R G

Strathkiel Investments Ltd, une société de droit chypriote, ayant son siège social à 11 Bompoulinas Street, 1 

st

 Floor,

1060 Nicosie, Chypre,

ici représentée par Monsieur Frank Trinteler, employé privé, demeurant professionnellement à Schuttrange, en vertu

d’une procuration sous seing privée, datée du 10 novembre 2011, laquelle, après signature ne varietur, par le notaire
instrumentant et le mandataire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société JIGSAW S.A., a été constituée suivant acte notarié en date du 4 novembre 2002, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1813 du 24 décembre 2002;

- que les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 31 juillet 2003, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1109 du 24 octobre 2003;

- que le capital social de la société JIGSAW S.A.
s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de trente et un euro (31.-Eur) chacune, entièrement libérées;

- que Strathkiel Investments Ltd, précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions;
- que la partie comparante, en sa qualité d’actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution

anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 11 novembre

2011, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment
provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l’activité de la Société a cessé;
- l’actionnaire unique est investie de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du

passif de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 11 novembre 2011 étant
seulement un des éléments d’information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les actions et/ ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-5367 Schuttrange,

64, rue Principale.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requise

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille euros (1.000-.Eur).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Singné: F. Trinteler, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50263. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Référence de publication: 2011159823/99.
(110185749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Devon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 96.928.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011158890/9.
(110184948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152556

L

U X E M B O U R G

Dexamenos Développement S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 51.914.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011158893/10.
(110184900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

HC Investissements (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en

date du 19 août 2011 sous le numéro L110136162, modifiés en date du 18 novembre 2011 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

Saphia Boudjani.

Référence de publication: 2011159046/13.
(110185196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Dom Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 94.768.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011158899/10.
(110185113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

WIKIO Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 113.995.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158905/10.
(110185435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Entreprise de Peinture MASSEN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3259 Bettembourg, 23, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 25.663.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011158907/10.
(110185172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152557

L

U X E M B O U R G

EuroRidge Solar Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 153.134.

1. En date du 18 novembre 2011, les associés ont décidé de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

2. Les associés ont constaté que Géraldine SCHMIT et Sandra ANSAY gérantes de la Société ont transféré leur adresse

professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158913/14.
(110185396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Eurocom J.L.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 75.371.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2011158934/10.
(110185220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Sculptor Springs of Eden S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 133.554.

In the year two thousand eleven, on the nineteenth day of October, before Maître Gérard Lecuit, notary residing in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the Sole Shareholder of Sculptor Springs of Eden S.à r.l.,

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Lu-
xembourg under number B 133.554, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in
Luxembourg, dated 7 November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 2896 of
13 December 2007 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the
last time on 1 September 2010 pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-
Duchy-of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 2198 of 16 October
2010.

THERE APPEARED:

Sculptor Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, having its registered

office at L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette, and registered with the Register of Commerce and Companies
of Luxembourg under number B 111.786 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr. Cédric BRADFER, private employee, with professional address at 2, rue Albert Borschette,

L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under a private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated above, notes the provisions of articles 199 and 200-2 of the Luxembourg

law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Law), and requests the undersigned notary to
record the following:

I. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by

a total of five hundred (500) shares, each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-);

II. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
III. The agenda of the Meeting is worded as follows:

152558

L

U X E M B O U R G

(a) change of registered address of the Company;
(b) subsequent amendment to article 4, first paragraph, of the articles of association of the Company (the Articles) in

order to reflect the change adopted under item (a) above;

(c) delegation of powers;
(d) miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to move the registered office from its current address 2, rue Albert Borschette, L-1246

Luxembourg to 6D, EBBC, Route de Treves, L-2633 Senningerberg, with immediate effect.

<i>Second resolution

As a result of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the article 4, first paragraph, of the Articles,

which shall henceforth read as follows:

Art. 4. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of

Luxembourg. The registered office may be transferred within same the municipality by decision of the manager or, in case
of several managers, of the board of managers."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to authorize any manager of the company, and/or any employee of MaplesFS (Luxem-

bourg) S.A., each acting individually and with full power of substitution, to make any statement and sign all documents
and do everything which is lawful, necessary or simply useful in order to proceed, in accordance with the requirements
of the Luxembourg law, to any registration with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg and to any
publication in the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg (the Memorial C) in connection with the above
resolutions, with the promise ratification of all said actions taken whenever requested.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately seven hundred euro (EUR [700).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text shall prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the representative of the appearing party, the said representative of the appearing

party signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille onze, le dix-neuvième jour d'octobre, par-devant nous, Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Sculptor Springs of Eden S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à L-1246 Luxembourg, 2,
rue Albert Borschette, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 133.554, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 7 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C-N° 2896 du 13
décembre 2007 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en date du 1
septembre 2010, suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C-N° 2198 du 16 octobre 2010.

A COMPARU:

Sculptor Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à

L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette, et immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 111.786 (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Cédric BRADFER, employé privé, demeurant professionnellement au 2, rue Albert Bor-

schette, L-1246 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

152559

L

U X E M B O U R G

L'Associé Unique, représenté comme déclaré ci-dessus, prend note des dispositions des articles 199 and 200-2 de la

loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi de 1915), laquelle compa-
rante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par un total de

cinq cents (500) parts sociales ayant chacune une valeur nominative de vingt-cinq euro (EUR 25,-);

II. L'Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la Société;
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est établi comme suit:
(a) modification du siège social de la Société;
(b) modification subséquente de l'article 4, premier paragraphe, des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter

le changement adopté sous le point (a) ci-dessus;

(c) délégation des pouvoirs;
(d) divers.
IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de changer l'adresse du siège social de la société du 2, rue Albert Borschette, L-1246 Lu-

xembourg au, 6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 4, premier paragraphe, des Statuts, afin de

lui donner la teneur suivante:

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social

pourra être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision
du conseil de gérance."

<i>Troisième résolution

L'Associé unique décide d'autoriser tout gérant de la Société, et/ou tout employé de MaplesFS (Luxembourg) S.A.,

chacun agissant individuellement avec pouvoir de substitution, d'effectuer toute déclaration et de signer tous les docu-
ments et faire tout ce qui est légal, nécessaire ou simplement utile afin de procéder, en conformité avec les exigences de
la loi luxembourgeoise, à toute inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à toute
publication dans la gazette officielle du Grand-Duché de Luxembourg (le Mémorial C) en liaison avec les résolutions ci-
dessus, avec la promesse de ratifier toutes lesdites actions entreprises à chaque demande.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes

s'élève approximativement à sept cent euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, et en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le dit mandataire a signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. BRADFER, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 octobre 2011. Relation: LAC/2011/46665. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2011.

Référence de publication: 2011159304/130.
(110184825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152560

L

U X E M B O U R G

Harsco Metals Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4503 Differdange, Chantier ProfilArbed.

R.C.S. Luxembourg B 29.281.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui s'est tenue le 25 octobre

2011, que:

1. Monsieur Stéphane Navarra, né le 23 août 1966, à Lyon (France) a démissioné de sa fonction en tant qu'adminis-

trateur et administrateur délégué de la Société avec effet au 30 septembre 2011;

2. Monsieur Alain Louhichi, né le 20 mai 1946, à Amneville (France), a démissioné de sa fonction en tant qu'adminis-

trateur de la Société avec effet au 19 octobre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Harsco Metals Luxembourg S.A.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011159584/17.
(110185335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Latsco Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 78.563.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 octobre 2011

Messieurs René FALTZ, Thomas FELGEN et Monsieur Laurent BARNICH ont démissionné de leur poste d’adminis-

trateur de la société.

L`Assemblée a élu aux postes d`administrateurs:
- M. Spiro Latsis, né le 15 août 1946 à Athènes, ayant son adresse Villa les Aigles, 15 Avenue d’Ostende, MC 98001

Monaco,

- M. Fotis Antonatos, né le 1 

er

 décembre 1945 à Addis Ababa, ayant son adresse 5 chemin des Tuileries, 1293 Bellevue,

Genève, Suisse,

- M. Emmanuel Busseti, né le 17 novembre 1951 à Piraeus, ayant son adresse 5 chemin des Tuileries, 1293 Bellevue,

Genève, Suisse,

- M. Peter Kalantzis, né le 12 décembre 1945 à Bâle, ayant son adresse Rennweg 19, 4052 Basel, Suisse,
- M. Michel Bourrit, né le 1 

er

 juillet 1946 à Genève, ayant son adresse 5 chemin des Tuileries, 1293 Bellevue, Genève,

Suisse,

- Mme Jenny Paizi, né le 25 juillet 1975 à Athènes, ayant son adresse 5 chemin des Tuileries, 1293 Bellevue, Genève,

Suisse.

Leurs mandats s`achèveront à l`issue de l`assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2017.
L’Assemblée a pris note de la demission du commissaire aux compte, Luxembourg Offshore Management Company

S.A. (en abrégé L.O.M.A.C. S.A.).

L’assemblée a élu au poste de commissaire aux comptes de la société: CLERC S.A., ayant son siège social 1 rue Pletzer,

L-8080 Bertrange, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111 831.

Son mandat s`achèvera à l`issue de l`assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2017.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011159845/30.
(110185508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Eikon Invest II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 79.419.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

152561

L

U X E M B O U R G

EIKON INVEST II S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011158917/12.
(110185382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Eikon Mezzanine Income S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 112.087.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EIKON MEZZANINE INCOME S.A.
I. DONADIO / I. BARCAGLIONI
<i>Director A / Director B

Référence de publication: 2011158918/12.
(110185223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Eikon Mezzanine Invest III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 112.083.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EIKON MEZZANINE INVEST III S.A.
I. DONADIO / I. BARCAGLIONI
<i>Director A / Director B

Référence de publication: 2011158919/12.
(110185224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Finwellness S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 59.557.

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie à Luxembourg le 04/11/2011 a renouvellé les mandats des

administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Carlo CAPELLI;
- Monsieur Sébastian COYETTE;
- Monsieur Marc KOEUNE;
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2017.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011158988/18.
(110185383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Elektron S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 133.147.

Le bilan au 30/06/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

152562

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011158920/9.
(110184659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Alfred Berg, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 145.536.

In the year two thousand eleven, on the thirty-first of October.
Before Us Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ALFRED BERG, with registered office at 33, rue de

Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number
145.536, incorporated by a deed of Maître Henri HELLINCKX, on March 31, 2009, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C number 802 of April 15, 2009. The articles of incorporation have been modified by a deed
of the same notary, on August 26, 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1940
of September 20, 2010.

The meeting is opened at 2.00 p.m. and Mr Gregory TRIVINI, employee, residing professionally in L-5826 Hesperange,

33, rue de Gasperich, is elected chairman of the meeting.

Mrs Fabienne VERONESE, employee, residing professionally in L5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, is appointed

scrutineer.

The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Frédérique WATRIQUANT, employee, residing professionally in

L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, is appointed to assume the role of secretary.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- That the agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

Full recasting of the Articles of Association including the following main changes:
1) Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the Lu-

xembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;

2) Article 1: deletion of the reference to abbreviated form of the Company's name.
3) Article 3 and 35: making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings

for collective investment, replacing the law of 20 December 2002;

4) Article 4: the commune of the registered office will be Hesperange instead of Howald-Hesperange;
5) Article 6: redefinition of the notion of “subfund”;
6) Article 7: redefinition of the notions of “category of shares” and “class of shares”;
Articles 8, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29, and 31: replacement of the term “sub-category” by “class of shares”;
7) Articles 8 and 10§6: cancellation of the issuance of share certificates
Deletion of Article 9 concerning lost or damaged certificates;
8) Article 10§1: opening up the possibility for the Board of Directors to reject any new subscription;
9) Article 13§3: opening up the possibility of rounding off to the higher or lower unit or fraction in the event of share

buybacks;

10) Creation of a new article following Article 13 authorizing the Board of Directors to split or regroup shares;
11) Article 14§5, the day on which the net asset value is dated (and not the day on which the net asset value is calculated)

shall be referred to in the Articles of Association as the “Calculation Date”.

Article 14(b) and (e): addendum to valuation date as the date of determination of the value of the funds invested (14b)

and exchange rate (14e);

Article 14(c): replacement of the date of acceptance of the orders by the order acceptance date;
Article 14(d): elimination of the depositary bank's consent for the appointment of the appraiser appointed for the

valuation of unlisted assets;

12) Article 15 (e) and (f): addition of the terms “categories or classes of shares” for suspensions of NAV and orders

in the event of merger or liquidation;

Article 15 (f): elimination of the maximum time period of 2 days for suspension of NAV and orders in the event of

merger;

Article 15: addition of the suspension of NAV and orders in a feeder subfund in the event of the same suspensions in

the master fund;

Article 15§3 and 4: replacement of the limit of 10% by a limit to be defined by the Board of Directors to determine

the percentage of repurchased assets requiring either a suspension or a postponement of the processing of orders;

152563

L

U X E M B O U R G

13) Article 17§5: the decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast;
14) Article 20: addition of the possibility for the Board of Directors to create subfunds investing in other Company

subfunds, as well as feeder subfunds;

15) Article 27: The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital repre-

sented. Resolutions shall be taken by a simple majority of the votes cast;

16) Articles 31 and 32: replacement of the time period of 9 months following liquidation by a reference to the regu-

lations in force for the depositing of undistributed assets at the Caisse de Consignation;

17) Article 32: Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions con-

cerning the effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of shares
within the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010;

Article 32: Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master

funds.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders,
the members of the bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialised “ne varietur” by the appearing parties will also remain attached

to the present deed.

III. This Meeting was convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in the

shareholders' register of the Company on August 26, 2003, and published in:

the «Mémorial C» on the 30 September and on the 15 

th

 of October 2011.

the «Luxemburger Wort» on the 30 September and on the 15 

th

 of October 2011.

the «Journal» on the 30 September and on the 15 

th

 of October 2011.

IV. A first meeting of shareholders duly convocated was held on September 29, 2011, pursuant to a notarial deed

received by Maître Henri HELLINCKX in order to decide on the same agenda.

This meeting could not take any decision, because the legal quorum of presence was not met.
V. That it appears from the attendance list, that out of shares issued, 60.510,3300 shares are represented. The meeting

is therefore regularly constituted without any convocation and can validly deliberate and decide on the afore cited agenda
of the meeting of which the shareholders have been informed before the meeting.

All these facts having been explained by the chairman and recognised correct by the members of the meeting, the

meeting proceeds to its agenda.

The meeting having considered the agenda, the chairman submits to the vote of the members of the meeting the

following resolutions which are adopted in each case of unanimous vote.

<i>First resolution

The Meeting chooses the English language as the official language of the Articles of Association as authorised by Article

26 (2) of the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510,00 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining.

<i>Second resolution

The Meeting resolves not to amend article 1 of the articles of incorporation consequently to point 2 of the Agenda

(deletion of the reference to abbreviated form of the Company's name)

Article 1 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of incorporation

that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 0 Shares voting yes;
- 60.510 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining;

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 3 and 35 of the articles of incorporation consequently to point 3 of the Agenda

(making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective
investment, replacing the law of 20 December 2002).

152564

L

U X E M B O U R G

Articles 3 and 35 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of

incorporation that make part of the present deed

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510,00 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the articles of incorporation consequently to point 4 of the Agenda (the

commune of the registered office will be Hesperange instead of Howald-Hesperange)

Article 4 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of incorporation

that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510,00 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining

<i>Fifth resolution

The  Meeting  resolves  to  amend  article  6  of  the  articles  of  incorporation  consequently  to  point  5  of  the  Agenda

(redefinition of the notion of “subfund”).

Article 6 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of incorporation

that make part of the present deed

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510,00 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend articles 7, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29 and 31 of the articles of incorporation conse-

quently to point 6 of the Agenda (redefinition of the notions of “category of shares“ and “class of shares” in Article 7,
and replacement of the term “sub-category” by “class of shares” in Articles 8, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29, and 31:)

Articles 7, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29 and 31 will therefore have the wording as shown in the amended version of the

coordinated articles of incorporation that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend articles 8 and 10§6 of the articles of incorporation and to delete Article 9 consequently

to point 7 of the Agenda (cancellation of the issuance of share certificates in Articles 8 and 10§6 and Deletion of Article
9 concerning lost or damaged certificates)

- Articles 8 and 10§6 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of

incorporation that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to amend article 10§1 of the articles of incorporation consequently to point 8 of the Agenda

(opening up the possibility for the Board of Directors to reject any new subscription);

Article10§1 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of incorpo-

ration that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;

152565

L

U X E M B O U R G

- 0 Shares abstaining

<i>Ninth resolution

The Meeting resolves to amend article 13§3 of the articles of incorporation consequently to point 9 of the Agenda

(opening up the possibility of rounding off to the higher or lower unit or fraction in the event of share buybacks).

Article 13§3 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of incor-

poration that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining

<i>Tenth resolution

The Meeting resolves to create a new article following Article 13 authorizing the Board of Directors to split or regroup

shares;

The new Article (following the actual article 13) will therefore have the wording as shown in the amended version of

the coordinated articles of incorporation that make part of the present deed and the other article will be subsequently
renumbered.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining.

<i>Eleventh resolution

The Meeting resolves to amend articles 14§5, 14 (b) and (e), 14 (c) and 14 d) of the articles of incorporation conse-

quently to point 11 of the Agenda

(-in relation with Article 14§5, the day on which the net asset value is dated (and not the day on which the net asset

value is calculated) shall be referred to in the Articles of Association as the “Calculation Date”.,

- in relation with Article 14(b) and (e): addendum to valuation date as the date of determination of the value of the

funds invested (14b) and exchange rate (14e);

- replacement of the date of acceptance of the orders by the order acceptance date in Article 14(c):;
- in relation with Article 14(d): elimination of the depositary bank's consent for the appointment of the appraiser

appointed for the valuation of unlisted assets)

Therefore, Articles 14§5, 14 (b) and (e), 14 (c) and 14 d) will therefore have the wording as shown in the amended

version of the coordinated articles of incorporation that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining.

<i>Twelfth resolution

The Meeting resolves to amend article 15 of the articles of incorporation consequently to point 12 of the Agenda (in

relation of Article 15 (e) and (f): addition of the terms “categories or classes of shares” for suspensions of NAV and
orders in the event of merger or liquidation;

In relation with Article 15 (f): elimination of the maximum time period of 2 days for suspension of NAV and orders in

the event of merger;

- in Article 15: addition of the suspension of NAV and orders in a feeder subfund in the event of the same suspensions

in the master fund;

- in relation with Article 15§3 and 4: replacement of the limit of 10% by a limit to be defined by the Board of Directors

to determine the percentage of repurchased assets requiring either a suspension or a postponement of the processing
of orders)

Article 15 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of incorporation

that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining.

152566

L

U X E M B O U R G

<i>Thirteenth resolution

The Meeting resolves to amend article 17§5 of the articles of incorporation consequently to point 13 of the Agenda

(the decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast).

Article 17§5 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of incor-

poration that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining.

<i>Fourteenth resolution

The Meeting resolves to amend article 20 of the articles of incorporation consequently to point 14 of the Agenda.

(addition of the possibility for the Board of Directors to create subfunds investing in other Company subfunds, as well
as feeder subfunds in article 20)

Article 20 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of incorporation

that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining.

<i>Fifteenth resolution

The Meeting resolves to amend article 27 of the articles of incorporation consequently to point 15 of the Agenda (The

General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital represented. Resolutions shall
be taken by a simple majority of the votes cast);

Article 27 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of incorporation

that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining.

<i>Sixteenth resolution

The Meeting resolves to amend article 31 and 32 of the articles of incorporation consequently to point 16 of the

Agenda ( replacement of the time period of 9 months following liquidation by a reference to the regulations in force for
the depositing of undistributed assets at the Caisse de Consignation);

Articles 31 and 32 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of

incorporation that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining.

<i>Seventeenth resolution

The Meeting resolves to rewrite article 32 of the articles of incorporation consequently to point 17 of the Agenda.
Article 32 will therefore have the wording as shown in the amended version of the coordinated articles of incorporation

that make part of the present deed.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining.

<i>Eighteenth resolution

On the basis of the above resolutions, the general meeting decides to amend the articles of incorporation of the

Corporation, so that from now on they will read under coordinated form as follows:

152567

L

U X E M B O U R G

Chapter I - Company name - Term - Objects - Registered office

Art. 1. Legal form and Company name. A limited company (société anonyme) in the form of an open-end investment

company (société d'investissement à capital variable - "SICAV") named “ALFRED BERG” (hereinafter the “Company”)
has been established pursuant to these Articles of Association (hereinafter the “Articles of Association”). The Company
may also be designated in any of its marketing documentation as “BNP Paribas T0”, in abbreviated form “BNPP T0”, as
long as such designation is immediately followed by the name of one of its compartments.

Art. 2. Term. The Company has been established for an indefinite term.

Art. 3. Object. The Company's sole object is to invest the funds that it has at its disposal in transferable securities and/

or other  liquid  financial  assets  with  the  aim of  spreading  the  investment risks and  of sharing  the results of its  asset
management activities with its shareholders.

In general, the Company may take all measures and carry out, at its discretion, all transactions to further its object in

the broadest sense of the term in the scope of the Act of 17 December 2010 on collective investment undertakings (the
“Act”).

Art. 4. Registered office. The Company's registered office is located in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.
In the event the Board of Directors considers that extraordinary political, economic or social events liable to com-

promise the Company's normal operations at the registered office or ease of communication with said registered office
or by said office with other countries have occurred or are imminent, it may temporarily transfer the registered office
abroad until said abnormal situation no longer exists. However, any such temporary measure shall have no effect on the
Company's nationality, which, notwithstanding said temporary transfer of the registered office, shall continue to be a
Luxembourg company.

The Company may, by simple decision of the Board of Directors, open branches or offices in the Grand Duchy of

Luxembourg or elsewhere.

The registered office may be moved by simple decision of the Board of Directors, either within the commune or,

within the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II - Capital - Share features

Art. 5. Capital. The capital shall be represented by fully paid up shares without par value, which shall at all times be

equal to the Company's net asset value.

The minimum capital is the amount provided for under the Act.

Art. 6. Sub-funds. The Board of Directors may create several sub-funds within the Company, each corresponding to

a separate part of the Company's assets. Each subfund shall have an investment policy and a reference currency that shall
be specific to it as determined by the Board of Directors.

Art. 7. Share categories and Classes. Within a sub-fund the Board of Directors may create share categories, wihich

shall be distinguished from each other by (i) the target investors and/or (ii) the specific cost structure and/or (iii) the
currency of currencies in which the shares shall be offered and/or (iv) the use of exchange rate or any other risk hedging
techniques, and/or (v) any other characteristics determined by the Board of Directors.

The shares within a category shall be of different classes as decided by the Board of Directors: (i) distribution shares

granting entitlements to dividends, and/or (ii) accumulation shares not granting entitlement to dividends.

Art. 8. Share form. All shares, regardless of the sub-fund, category or class to which it belongs, may be registered or

bearer shares as decided by the Board of Directors.

Bearer shares shall be issued in dematerialised form. Bearer share certificates issued in the past shall remain valid until

the redemption of the respective shares. Shares relative to lost or damaged certificates shall be replaced by dematerialised
bearer shares under the conditions and guarantees determined by the Company.

Registered shares shall be registered on the register of shareholders kept by the Company or by one or more individuals

or legal entities that the Company appoints for this purpose. The entry must mention the name of each shareholder, his
place of residence or address for service, the number of shares that he owns, the sub-fund, category and/or class to which
said shares belong and the amount paid for each of said shares. In the event a particular shareholder fails to provide an
address to the Company, this fact may be mentioned on the register of shareholders and the shareholder's address shall
be deemed to be the Company's registered office until the shareholder provides the Company with another address.
Shareholders may change the address mentioned on the register at any time by sending written notice to the Company's
registered office or to any other address stipulated by the Company. Any transfer of registered shares inter vivos or
upon death shall be registered on the register of shareholders.

The owner of registered shares shall receive confirmation of registration in the register.
Within the limits and conditions set by the Board of Directors, bearer shares may be converted into registered shares

and vice versa, as requested by the shareholder in question. The shareholder may have to pay the costs of said conversion.

The Company acknowledges only one shareholder per share. If a share is jointly owned, if title is split or if the share

is disputed, individuals or legal entities claiming a right to the share shall appoint a sole representative to represent the

152568

L

U X E M B O U R G

share with regard to the Company. The Company shall be entitled to suspend the exercise of all rights attached to the
share until said representative has been appointed.

Art. 9. Issue of shares. The Board of Directors may issue new shares at any time and without limitation, without

granting current shareholders a preferential subscription right to the shares to be issued. Any new shares issued must be
fully paid up. It may, at its discretion, reject any share subscription.

When the Company offers shares for subscription, the price per share offered shall be equal to the net asset value of

the shares of the sub-fund, category and class in question (or where applicable, the initial subscription price specified in
the prospectus), increased, where applicable, by the costs and fees set by the Board of Directors.

The subscription price shall be paid within a time frame to be determined by the Board of Directors but which may

not exceed seven bank business days in Luxembourg after the date on which the applicable net asset value has been
calculated.

Subscription applications may be suspended on the terms and conditions provided for in these Articles of Association.
The Board of Directors may delegate responsibility for accepting subscriptions, receiving payment of the price of the

new shares to be issued and for issuing same to any director, executive director or other representative duly authorised
for this purpose.

Further to a decision by the Board of Directors, fractional shares may be issued. . Said fractional shares shall grant

entitlement to dividends on a pro rata basis.

The Board of Directors may agree to issue shares in consideration of a contribution in kind of securities, in compliance

with the current legislation and in particular with the obligation to produce a valuation report by the Company's auditor
and provided that such securities correspond to the sub-fund's investment policy and investment restrictions as described
in the Company's prospectus.

Art. 10. Restrictions on holding of the Company's shares. The Company may restrict or prohibit the ownership of the

Company's shares by any individual or legal entity if such possession constitutes a breach of current law or is harmful to
the Company in other ways.

Art. 11. Conversion of shares. Save for specific restrictions decided by the Board of Directors and mentioned in the

prospectus, all shareholders may request that all or part of their shares of a certain category / category be converted
into shares of a same or another category / class within the same sub-fund or in a different sub-fund.

The conversion price of the shares shall be calculated on the basis of the respective net asset value of both share

categories / classes in question calculated on the same calculation date, factoring in, where applicable, costs and fees set
by the Board of Directors.

If a share conversion causes the number or total net asset value of shares that a shareholder owns in a given share

category/ class to fall below the minimum number or value determined by the Board of Directors, the Company may
compel said shareholder to convert all his shares in said category / class.

Converted shares shall be cancelled.
Conversion applications may be suspended in accordance with the terms and conditions of these Articles of Associa-

tion.

Art. 12. Redemption of shares. All shareholders may request the Company to redeem all or part of his shares in

accordance with the terms and conditions set by the Board of Directors in the prospectus and within the limits imposed
by law and these Articles of Association.

The redemption price shall be paid within a time frame to be determined by the Board of Directors but which may

not exceed seven bank business days in Luxembourg after the date on which the applicable net asset value has been
calculated.

The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the sub-fund, category / class concerned, less,

where applicable, any costs and fees set by the Board of Directors. This redemption price may be rounded off to the
next higher or lower unit or fraction of the currency in question, as determined by the Board of Directors.

If a redemption request causes the number or total net asset value of the shares that a shareholder owns in a share

category / class to fall below such minimum number or value set by the Board of Directors, the Company may compel
said shareholder to redeem all of his shares in said share category / class .

The Board of Directors may pay the redemption price to any consenting shareholder by allocation in kind of the

securities of the sub-fund in question, provided that the other shareholders do not sustain a loss and a valuation report
is drawn up by the Company's auditor. The nature or type of assets to be transferred in such case shall be determined
by the manager in compliance with the sub-fund's investment policy and restrictions.

All redeemed shares shall be cancelled.
Redemption applications may be suspended in accordance with the terms and conditions set forth in these Articles of

Association.

Art. 13. Share splitting / Consolidation. The Board of Directors may decide at any time to split up or consolidate the

shares issued within one same class, same category or same sub-fund, according to the conditions set by it.

152569

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Net asset value. The Company shall calculate the net asset value of each sub-fund, the net asset value per

share for each category and class and the issue, conversion and redemption prices at least twice per month, at to a
frequency to be set by the Board of Directors.

The net asset value of each sub-fund shall be equal to the total value of the assets of said sub-fund less the sub-fund's

liabilities.

The net asset value per share is obtained by dividing the net assets of the sub-fund in question by the number of shares

issued for said sub-fund, considering, where applicable, the breakdown of the net assets of said subfund between the
various share categories and class of the sub-fund in question.

Said net value shall be expressed in the currency of the sub-fund in question or in any other currency that the Board

of Directors may choose.

The day on which the net asset value is dated shall be referred to in these Articles of Association as the “Calculation

Date”.

The valuation methods shall be as follows:
The Company's assets include:
(1) cash in hand and cash deposits, including interest accrued but not yet received and interest accrued on these

deposits until the payment date;

(2) all notes and bills payable on demand and amounts receivable (including the results of sales of securities before the

proceeds have been received);

(3) all securities, units, shares, bonds, option or subscription rights and other investments and securities which are the

property of the Company;

(4) all dividends and distributions to be received by the Company in cash or securities that the Company is aware of;
(5) all interest accrued but not yet received and all interest generated up to the payment date by securities which are

the property of the Company, unless such interest is included in the principal of these securities;

(6) the Company's formation expenses, insofar as these have not been written down;
(7) all other assets, whatever their nature, including prepaid expenses.
Without prejudice to the specific provisions applicable to any sub-fund, category and/or class , the value of these assets

shall be determined as follows:

(a) the value of cash in hand and cash deposits, bills and drafts payable at sight and amounts receivable, prepaid expenses,

and dividends and interest due but not yet received, shall comprise the nominal value of these assets, unless it is unlikely
that this value could be received; in that event, the value will be determined by deducting an amount which the Company
deems adequate to reflect the actual value of these assets;

(b) the value of shares or units in undertakings for collective investment shall be determined on the basis of the last

net asset value available on the valuation day;

(c) the valuation of all securities listed on a stock exchange or any other regulated market which functions regularly,

is recognised and accessible to the public, is based on the closing price on the order acceptance date,, the next trading
day's price for Asian markets, and, if the securities are traded on several markets, on the basis of the most recent price
on the principal market on which they are traded; if this price is not a true reflection, the valuation shall be based on the
probable sale price estimated by the Board of Directors in a prudent and bona fide manner;

(d) unlisted securities or securities not traded on a stock exchange or another regulated market which functions in a

regular manner, is recognised and accessible to the public, shall be valued on the basis of the probable sale price estimated
in a prudent and bona fide manner by a qualified professional appointed for this purpose by the Board of Directors.

(e) securities denominated in a currency other than the currency in which the sub-fund concerned is denominated

shall be converted at the exchange rate prevailing on the valuation day;

(f) the Board of Directors is authorised to draw up or amend the rules in respect of the relevant valuation rates.

Decisions taken in this respect shall be included in the prospectus;

(g)  derivative  financial  instruments  shall  be  valued  according  to  the  rules  decided  by  the  Board  of  Directors  and

described in the prospectus. These rules shall have been approved in advance by the Company's auditor and the super-
visory authorities.

The Company's liabilities include:
(1) all loans, matured bills and accounts payable;
(2) all known liabilities, whether or not due, including all contractual obligations due and relating to payment in cash

or kind, including the amount of dividends announced by the Company but yet to be paid;

(3) all reserves, authorised or approved by the Board of Directors, including reserves set up in order to cover a

potential capital loss on certain of the Company's investments;

(4) any other undertakings given by the Company, except for those represented by the Company's equity. For the

valuation of the amount of these other liabilities, the Company shall take account of all the charges for which it is liable,
including, without restriction, the costs of amendments to the Articles of Association, the prospectus and any other

152570

L

U X E M B O U R G

documents relating to the Company, management, performance and other fees and extraordinary expenses, any taxes
and duties payable to government departments and stock exchanges, the costs of financial charges, bank charges or
brokerage incurred upon the purchase and sale of assets or otherwise. When assessing the amount of these liabilities,
the Company shall take account of regular and periodic administrative and other expenses on a pro rata temporis basis.

The assets, liabilities, expenses and fees not allocated to a sub-fund, category or class shall be apportioned to the

various sub-funds, categories or classes in equal parts or, subject to the amounts involved justifying this, proportionally
to their respective net assets. Each of the Company's shares which is in the process of being redeemed shall be considered
as a share issued and existing until closure on the valuation day relating to the redemption of such share and its price
shall be considered as a liability of the Company as from closing on the date in question until such time as the price has
been duly paid. Each share to be issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be
considered as issued as from closing on the calculation date of its issue price and its price shall be considered as being an
amount due to the Company until such time as it has been duly received by the Company. As far as possible, account
shall be taken of any investment or disinvestment decided by the Company until the valuation day.

The total amount of annual fees payable by a sub-fund, category or class of share shall never exceed 5% (five per cent)

of its average net assets.

If it considers that the net asset value calculated is not representative of the real value of the Company's shares, or if

since the calculation there have been significant developments on the markets concerned, the Board of Directors may
decide to have it updated on that same day, and shall determine a new net asset value in a prudent and bona fide manner.

Art. 15. Suspension of the calculation of the net asset value and the issue, Conversion and Redemption of the sha-

res. Without prejudice to legal causes for suspension, the Company's Board of Directors may at any time temporarily
suspend the calculation of the net asset value of shares of one or more sub-funds as well as the issue, conversion and
redemption of shares in the following cases:

(a) during any period when one or more currency markets or a stock exchange, which are the main markets or

exchanges where a substantial portion of a sub-fund's investments at a given time are listed, is/are closed, except for
normal closing days, or during which trading is subject to major restrictions or is suspended;

(b) when the political, economic, military, currency, social situation or any event of force majeure beyond the res-

ponsibility or power of the Company makes it impossible to dispose of one assets by reasonable and normal means,
without seriously harming the shareholders' interests;

(c) during any failure in the means of communication normally used to determine the price of any of the Company's

investments or the going prices on a particular market or exchange;

(d) when restrictions on foreign exchange or transfer of capital prevents transactions from being carried out on behalf

of the Company or when purchases or sales of the Company's assets cannot be carried out at normal exchange rates;

(e) as soon as a decision has been taken to either liquidate the Company or one or more sub-funds, categories or

classes;

(f) to determine an exchange parity under a merger, partial business transfer, splitting or any restructuring operation

within, by or in one or more sub-funds, categories and/or classes;

(g) for a “feeder” sub-fund, when the net asset value, issue, conversion and/or redemption of the shares of the “master”

sub-fund is suspended for a similar period of the period of suspension in the “master” subfund;

(h) any other cases when the Board of Directors estimates by a justified decision that such a suspension is necessary

to safeguard the general interests of the shareholders concerned.

In the event the calculation of the net asset value is suspended, the Company shall immediately and in an appropriate

manner inform the shareholders who requested the subscription, conversion or redemption of the shares of the sub-
fund(s) in question.

In the event the total net redemption /conversion applications received for a given sub-fund on the valuation day equals

or exceeds a percentage determined by the Board of Directors , the Board of Directors may decide to reduce and/or
defer the redemption/ conversion applications on a pro rata basis so as to reduce the number of shares redeemed/
converted to date to the percentage of the net assets of the sub-fund in question determined by it.. Any redemption/
conversion applications thus deferred shall be given priority in relation to redemptions/conversion applications received
on the next valuation day , again subject to the limit set by the Board of Directors..

In exceptional circumstances which could have a negative impact on shareholders' interests, or in the event of sub-

scription, redemption or conversion applications exceeding a percentage of a sub-fund's net assets as determined by the
Board of directors, the Board of Directors reserves the right not to determine the value of a share until such time as the
required purchases and sales of securities have been made on behalf of the sub-fund. In that event, subscription, redemp-
tion and conversion applications in the pipeline will be processed simultaneously on the basis of the net asset value so
calculated.

Pending subscription, conversion and redemption applications may be withdrawn by written notification provided that

such notification is received by the company prior to lifting of the suspension. Pending applications will be taken into
account on the first calculation date following lifting of the suspension. If all pending applications cannot be processed on
the same calculation date, the earliest applications shall take precedence over more recent applications.

152571

L

U X E M B O U R G

Chapter III - Management and Supervision of the company

Art. 16. Directors. A Board of Directors comprised of at least three members shall manage the Company. Board

members do not need to be Company shareholders. The General Meeting of shareholders shall appoint them for a term
of office of six years at most, which shall be renewable.

The General Meeting may remove a director from office at will.
If the seat of a director appointed by the General Meeting of shareholders becomes vacant, the directors still in office

may temporarily appoint a director. In this case, the General Meeting shall make a permanent appointment at its next
meeting.

Art. 17. Chairmanship and Board Meetings. The Board of Directors shall appoint a Chairman and possibly one or more

Vice-Chairmen from amongst its members. It may also appoint a secretary who does not need to be a director.

The Board of Directors shall meet at the request of the Chairman or, if he is unable to act, a Vice-Chairman or two

directors whenever this is in the Company's best interests, at the place, date and time specified in the notice of meeting.
Any director who is unable to attend a Board meeting may appoint another director, in writing, telex, fax or any other
means of electronic transmission, to represent him and to vote in his stead. A director may represent one or more of
his colleagues.

Save for an emergency, all directors shall be given at least 24 hours' notice in writing of any Board meeting. In the

event of an emergency, the nature and the reasons thereof shall be mentioned in the notice of meeting. There shall be
no need for such notice of meeting if each director consents in writing or by cable, telegram, telex or fax to such waiver
of notice. A specific notice of meeting shall not be required for a Board meeting held at a time and venue specified in a
resolution that has already been adopted by the Board of Directors.

Board meetings shall be chaired by the Chairman or, in his absence, the eldest of the Vice-Chairmen, if any, or in their

absence, the delegated director, if any, or in his absence, the eldest director attending the meeting.

The Board of Directors may conduct business and act only if the majority of directors are present or represented.

Decisions shall be taken by a simple majority of votes cast by the directors attending the meeting or represented. The
votes cast shall not include those of directors who did no take part in the voting, abstained, or cast a blank or void vote.
If, during a Board meeting, there is a tie in voting for or against a decision, the person chairing the meeting shall have a
casting vote.

All directors may participate at a Board meeting by telephone conference or by other like means of communications

where all individuals attending said meeting can hear one another. Participation at a meeting by these means amounts to
attendance in person at said meeting.

Notwithstanding the foregoing provisions, a Board decision may also be taken by circular letter. Such decision shall

be approved by all directors who sign a single document or multiple copies thereof. Such decision shall have the same
validity and force as if it had been taken at a meeting that had been duly convened and held.

The Chairman or the person who chairs the meeting in his absence shall sign the minutes of Board meetings.

Art. 18. Board powers. The Board of Directors shall have the broadest powers to carry out all acts of management

or disposal in the Company's best interests. All powers not expressly reserved to the General Meeting under current
law or these Articles of Association shall be the remit of the Board of Directors.

With regard to third parties, the Company shall be validly committed by the joint signature of two directors or the

sole signature of all individuals to whom powers of signature have been delegated by the Board of Directors.

Art. 19. Daily management. The Company's Board of Directors may delegate its powers relating to the daily mana-

gement of the Company's business (including the right to act as the Company's authorised signatory) and to represent it
for said management either to one or more directors or to one or more agents who need not necessarily be Company
shareholders. Said individuals shall have the powers conferred on them by the Board of Directors. They may sub-delegate
their powers, if authorised by the Board of Directors. The Board of Directors may also grant all special mandates by
notarised power of attorney or by private power of attorney.

In order to reduce the operating and administrative expenses, while making it possible to achieve more extensive

diversification of investments, the Board of Directors may decide that all or part of the Company's assets shall be jointly
managed with assets owned by other collective investment undertakings or that all or part of the assets of sub-funds,
categories and/or classes shall be jointly managed between them.

Art. 20. Investment policy.  The  Board  of  Directors,  applying  the  principle  of  the  spreading  of  risks,  shall  be  fully

empowered to determine the investment policy and restrictions of the Company and each of its sub-funds, and the
guidelines to be followed for the management of the Company, in compliance with the law and subject to the following
conditions:

a) The Company may invest in any transferable securities and money market instruments officially listed on a stock

exchange or traded on a regulated market, operating regularly, that is recognised and open to the public, in any country;

b) Overall, the Company may not invest more than 10% of the assets of each sub-fund in UCITS and other undertakings

for collective investment, apart for certain sub-funds if mentioned in their investments policy;

152572

L

U X E M B O U R G

c) The Board of Directors may specify that a sub-fund's investment policy should be the replication of the composition

of an equity or bond index within the limits authorised by law and the supervisory authorities;

d) The Company may invest, in accordance with the principle of risk-spreading, at least 35% and up to 100% of its

assets in different issues of transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member
State of the European Union, by its local authorities, or by a state that is not part of the European Union or by international
public organisations to which one or more Member States of the European Union belong. These securities must come
from at least six different issues, and the securities belonging to a single issue must not account for more than 30% of the
net asset value of the sub-fund.

e) A sub-fund of the Company may subscribe, purchase and/or hold shares of one more other sub-funds (referred to

as “target sub-funds”) of the Company provided that:

- the target sub-funds do not in turn invest in this sub-fund;
- the proportion of assets that each target sub-fund invests in other target sub-funds of the Company does not exceed

10%

- any voting rights attached to the shares of the target subfunds shall be suspended as long as they are held by the sub-

fund and without prejudice of appropriate treatment in the accounting and periodic reports

- in all cases, as long as these sub-fund shares are held by the Company, their value shall not be taken into account for

the calculation of the net assets of the Company for purposes of verifying the minimum threshold of net assets required
by law;

- there shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions

at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund

f) The Board of Directors may create “feeder sub-funds” under the conditions provided by law

Art. 21. Delegation of Management and Advice. The Company may enter into one or more management agreement

(s), in the broadest sense of the term within the meaning of the Act, or consultancy agreements with any Luxembourg
or foreign company within the limits and subject to the conditions authorised by law.

Art. 22. Invalidation clause. No contract and transaction that the Company may enter into with other companies or

firms may be affected or invalidated by the fact that one or more directors or executive directors of the Company has/
have any interest whatsoever in such other company or firm or by the fact that he is a director, shareholder or partner,
executive director or employee thereof.

The director or executive director of the Company who is a director, executive director or employee of a company

or firm with which the Company signs contracts or otherwise does business shall not thereby be deprived of the right
to deliberate, vote and act in connection with matters related to such contracts or such business. In the event a director
or an executive director has a personal interest in a Company transaction, said director or executive director shall inform
the Board of Directors of his personal interest and shall not deliberate or take part in the vote on said transaction. A
report on said transaction and on the personal interest of such director or non-executive director shall be submitted at
the next meeting of shareholders.

Art. 23. Company auditor. The accounting data set forth in the annual report drawn up by the Company shall be

audited by an authorised company auditor who shall be appointed by the General Meeting for the term of office that it
shall set and who shall be remunerated by the Company.

Chapter IV - General meetings

Art. 24. Representation. The duly formed meeting of the Company's shareholders shall represent all Company sha-

reholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the Company's operations.
Resolutions voted at such meetings shall be binding on all shareholders, regardless of the category or class they own.
However, if the decisions concern exclusively the specific rights of shareholders of a sub-fund, a category or class or if
there is a risk of conflict of interest between the various sub-funds, said decisions must be taken by a general meeting
representing the shareholders of said sub-fund, said category or class .

Art. 25. General Meeting of shareholders. The Annual General Meeting of shareholders will be held at the Company's

registered office or at any other place in the Grand Duchy of Luxembourg specified in the notice of meeting, on the third
Friday of July at 2.00 p.m. If said day is a legal public or banking holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting shall
be held on the next bank business day. The Annual General Meeting may be held abroad if the Board of Directors records,
at its sole discretion, that this change of venue is necessary on account of exceptional circumstances.

All other General Meetings of shareholders shall be convened at the request either of the Board of Directors, or of

shareholders representing at least one-tenth of the capital. They shall be held at the date, time and place specified in the
notice of meeting.

Meetings shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, the eldest Vice-Chairman, if

any, or in his absence, a delegated Director, if any, or, in his absence, one of the directors or any other person appointed
by the Meeting.

152573

L

U X E M B O U R G

Art. 26. Votes. Votes shall be on a one-share one-vote basis and all shares, regardless of the sub-fund to which they

belong shall take an equal part in decision-making at the General Meeting. Fractional shares shall have no voting right.

All shareholders may attend meetings either in person or by appointing any other individual as a representative in

writing, by cable, telegram, telex or fax.

Art. 27. Quorum and Majority conditions. Unless otherwise provided for under current law or these Articles of

Association, the General Meeting of Shareholders shall validly deliberate, regardless of the portion of capital represented.
Resolutions shall be adopted by a simple majority of votes cast. The votes cast shall not include those attached to shares
for which the shareholders did not take part in the voting, abstained, or cast a blank or void vote. .

Chapter V - Financial year

Art. 28. Financial year. The financial year shall begin on 1 

st

 April of each year and end on 31 

st

 March of the next year.

Art. 29. Allocation of the annual profit/loss. Dividends may be distributed provided that the Company's net assets at

all times exceed the minimum capital provided for by law.

Following a proposal by the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders shall decide, for each category /

class , on a dividend and the amount of the dividend to be paid to the distribution shares.

If it is in the interests of shareholders not to distribute a dividend, in view of market conditions, no distribution will

be made.

The Board of Directors may, in accordance with current law, distribute interim dividends.
The Board of Directors may decide to distribute dividends in the form of new shares instead of dividends in cash, in

accordance with the terms and conditions that it sets.

Dividends shall be paid in the currency of the sub-fund, unless the Board of Directors decides otherwise.

Chapter VI - Dissolution - Liquidation - Merger - Contribution

Art. 30. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting of Shareholders,

ruling as for the amendment of the Articles of Association.

If the Company's capital falls to less than two thirds of the minimum legal capital, the directors may submit the question

of the Company's dissolution to the General Meeting, which shall deliberate without a quorum by a simple majority of
the shareholders in attendance or represented at the Meeting; account shall not be taken of abstentions. If the capital
falls to less then one quarter of the minimum legal capital, the General Meeting shall also deliberate without a quorum,
but the dissolution may be decided by the shareholders owning one quarter of the shares represented at the Meeting.

The Meeting must be convened to ensure that it is held within a forty-day period as from the date on which the net

assets are recorded to be respectively less than two thirds or one quarter of the minimum capital.

Art. 31. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, it shall be liquidated by one or more liquidators,

natural persons or legal entities that the General Meeting shall appoint and whose powers and fees it shall set.

The  liquidators  shall  allocate  the net  proceeds of  the  liquidation of  each  sub-fund  /  category / class between  the

shareholders of said sub-fund/ category / class in proportion to the number of shares they own in said subfund, category
or class.

In the case of straightforward liquidation of the Company, the net assets will be distributed to the eligible parties in

proportion to the shares held in the Company. Any assets not distributed within a time period set by the regulations in
force will be deposited at the Public Trust Office (Caisse de Consignation) until the end of the legally specified limitation
period.

Art. 32. Liquidation, Merger, Transfer, Splitting of sub-funds and/or Classes. The Board of Directors shall have sole

authority to decide on the effectiveness and terms of the following, under the limitations and conditions prescribed by
law:

1) either the pure and simple liquidation of a sub-fund,
2) or the closure of a sub-fund by transfer to another sub-fund of the Company,
3) or the closure of a sub-fund by transfer to another collective investment undertaking, whether incorporated under

Luxembourg law or established in another member states of the European Union

4) or the transfer to a sub-fund a) of another sub-fund of the Company, and/or b) of a sub-fund of another collective

investment undertaking, whether incorporated under Luxembourg law or established in another member state of the
European Union, and/or c) of another collective investment undertaking, whether incorporated under Luxembourg law
or established in another member state of the European Union;

5) or the splitting of a sub-fund
A feeder sub-fund shall be liquated under the conditions provided for by law when the master sub-fund itself is liquidated

or merged or spilt.

152574

L

U X E M B O U R G

As an exception to the foregoing, if the Company should cease to exist as a result of such a merger, the effectveness

of this merger must be decided by a General Meeting of Shareholders of the Company resolving under the conditions
provided for, in Article 27 of theses Articles of Association.

In the event of the pure and simple liquidation of a sub-fund, the net assets shall be distributed between the eligible

parties in proportion to the assets they own in said sub-fund. The assets not distributed within a time period set by the
regulations in force shall be deposited with the Public Trust Office (Caisse de Consignation) until the end of the legally
specified limitation period.

Pursant to this article, the decisions adopted at the level of a sub-fund may be adopted similarly at the level of a share

category and/or class.

Chapter VII - Final provisions

Art. 33. Deposit of Company assets. Insofar as required by law, the Company shall enter into a depository agreement

with a bank or savings institution within the meaning of the Amended Act of 5 April 1993 relating to the supervision of
the financial sector (the ”Depository Bank”).

The Depository Bank shall have the powers and responsibilities provided for by law.
If the Depository Bank wishes to withdraw, the Board of Directors shall endeavour to find a replacement within two

months as from the date when the withdrawal became effective. The Board of Directors may terminate the depository
agreement but may only terminate the Depository Bank's appointment if a replacement has been found.

Art. 34. Amendments of the Articles of Association. These Articles of Association may be amended by a General

Meeting of Shareholders, subject to the quorum and voting criteria required under current law and the requirements of
these Articles of Association.

Art. 35. Statutory provisions. For all matters not governed by these Articles of Association, the parties refer to the

Companies Act of 10 August 1915 and amendments thereto and to the Act of 17 December 2010 on collective investment
undertakings and subsequent amendments.

The present resolution was adopted as follows:
- 60.510 Shares voting yes;
- 0 Shares voting no;
- 0 Shares abstaining

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 3000.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the Bureau, said members of the Bureau signed together with us, the notary, the

present original deed.

Signé: G. Trivini, F. Veronese, F. Watriquant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 novembre 2011. Lac/2011/49004. Reçu soixante-quinze euros Eur 75,

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

Pour expedition conforme, délivrée à la demande de la prédite société, Sur papier libre, aux fins de publication au

mémorial, Recueil des sociétés et associations.

Luxembourg, le 16 NOVEMBER 2011.

Référence de publication: 2011155565/698.
(110181701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Hitechphoto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruusstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 153.590.

Im Jahre zweitausendelf, den vierzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz zu Ettelbruck.

Ist erschienen:

Herr Gerhard STAHMANN, geboren in Frankfurt am Main am 14. Februar 1951, wohnhaft in D-63801 Kleinostheim,

Hellbühlstr. 13;

handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HITECHPHOTO, S.à

r.l., (Matrikel 2010 2418 361), mit Gesellschaftssitz in L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne,

152575

L

U X E M B O U R G

gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den Notar Marc CRAVATTE, mit dem damaligen Amtssitz in Ettelbruck

am 9. Januar 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Seite 31569 des Jahres 2002,

eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburgs unter der Nummer B 153.590,
welcher Komparent sich zu einer außergewöhnlichen Generalversammlung konstituiert hat und einstimmig, und laut

entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst hat:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Pommerloch nach Weiswampach zu verlegen.
Demgemäss wird Artikel 4 der Gesellschaftssatzung angepasst und erhält folgenden Wortlaut:

“ Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach.
Er kann durch einfache Entscheidung der Geschäftsführung in eine andere Ortschaft des Grosshezogtums Luxemburg

verlegt werden.”

<i>Zweiter Beschluss

Die Adresse der Gesellschaft lautet L-9991 Weiswampach, 28, Gruusstrooss.

<i>Kosten und Honorare

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf

650,- €.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Ettelbruck, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs er-

wähnt.

Und  nach  Vorlesung  an  den  Komparenten,  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichen  Vornamen,  sowie  Stand  und

Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem unterzeichnenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Gerhard STAHMANN, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2011 Relation: DIE/2011/10913. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations erteilt.

Ettelbruck, den 23. November 2011.

Référence de publication: 2011159803/40.
(110185879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2011.

ENEX Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 135.653.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2011158921/11.
(110184767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Enrotec Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5691 Ellange, 20, Z.A.E. Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 107.605.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011158922/11.
(110184708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152576

L

U X E M B O U R G

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 18.603.

Le siège social du commissaire, AUDIEX S.A., est désormais le suivant:
9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158928/11.
(110185265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 18.603.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011158929/9.
(110185270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Fintlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 72.645.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FINTLUX S.A.
DE BERNARDI Angelo / DONATI Régis
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011158985/12.
(110185459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Global Financial and Commercial Holdings Sapphire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.625.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the eighth day of November.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Global Financial and Commercial Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) with registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 162.130 (GFCH),

here represented by Virginie Boussard, jurist, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name – Registered office – Object – Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Global Financial and Commercial Holdings Sapphire S.à r.l.” (the Company).

The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law),
and these articles of incorporation (the Articles).

152577

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. In the framework of its activity, the Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue,

by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds
including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other com-
panies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital – Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by one hundred twenty-

five thousand (125,000) shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.

152578

L

U X E M B O U R G

III. Management – Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers.
If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,

in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by joint signatures of any two (2) managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

152579

L

U X E M B O U R G

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits – Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

Art. 14. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of

Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year. Réviseurs d’entreprises
agréés

14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d’entreprises agréés, when so required

by law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d’entreprises agréés, if any, and determine their number, remuneration

and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d’entreprises agréés may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts;

152580

L

U X E M B O U R G

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution – Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on
one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2012.

<i>Subscription and Payment

GFCH, represented as stated above, subscribes one hundred twenty-five thousand (125,000) shares in registered form,

having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of
twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Neil Smith, company manager, born on June 17, 1956 in Darwen, United Kingdom, residing professionally at 1,

Duchess Street, London W1W 6AN, United Kingdom;

- Mr. Abdelkader Derrouiche, employee, born on March 14, 1982 in Ksar Chellala, Algeria, residing professionally at

51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and

- Ms. Virginie Boussard, born on July 17, 1977 in Strasbourg, France, residing professionally at 51, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

152581

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le huitième jour du mois de novembre.
Par-devant, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Global Financial and Commercial Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.130 (GFCH),

ici représentée par Virginie Boussard, juriste, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante

les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est “Global Financial and Commercial Holdings Sapphire S.à r.l.” (la

Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en
particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents
statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. Dans le cadre de ses activités, la Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre

publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de
titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous
emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties
et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de
garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute
autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur
financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

152582

L

U X E M B O U R G

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cent vingt-cinq mille (125.000)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Le Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en

principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

152583

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels – Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

152584

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Réviseurs d'entreprises agréés.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-

ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être
renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et libération

GFCH, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales sous

forme nominative, d'une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR) chacune, et de les libérer intégralement par un apport
en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au

notaire instrumentant.

152585

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille deux cents euros ( 1.200.-EUR ).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Neil Smith, gérant, né le 17 juin 1956 à Darwen, Grande-Bretagne, résidant professionnellement au 1 Duchess

Street, Londres W1W 6AN, Royaume-Uni;

- M. Abdelkader Derrouiche, employé, né le 14 mars 1982, à Ksar Chellala, Algérie, résidant professionnellement au

51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et

- Mme Virginie Boussard, gérant, née le 17 juillet 1977 à Strasbourg, France, résidant professionnellement au 51, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: V. Boussard et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 novembre 2011. LAC/2011/50061. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157126/485.
(110182257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Eupalia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 130.387.

Les comptes annuels au 31/12/10 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FMV &amp; PARTNERS S.A.
Signature

Référence de publication: 2011158933/11.
(110185202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

European Financial and Partners S.A. Soparfi, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 12.

R.C.S. Luxembourg B 107.105.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011158935/10.
(110184969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152586

L

U X E M B O U R G

Zaka, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 162.189.

En date du 14 novembre 2011, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Robert Brimeyer, avec adresse au 67 rue Ermesinde L-1469 Luxembourg de son

mandat d'administrateur de catégorie C, avec effet immédiat,

- nomination de Sandra Ansay, née le 13 août 1974 à Saint-Mard en Belgique, avec adresse professionnelle au 5 rue

Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, au mandat d'administrateur de catégorie C, avec effet immédiat pour une période
venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017,

- transfert de siège social de la société du 67 rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 5 rue Guillaume Kroll L-1882

Luxembourg avec effet immédiat,

- transfert de l'adresse professionnelle de Christophe Davezac, administrateur de catégorie C, au 5, rue Guillaume

Kroll L-1882 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011159409/19.
(110185400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Dumagis S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 154.060.

L'an deux mille onze, le onze novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DUMAGIS S.A. – SPF, société de gestion de

patrimoine familial, R.C.S. Numéro B 154060, avec siège social à L-2561 LUXEMBOURG, 31, rue de Strasbourg, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 juin 2010, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1637 du 12 août 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnelle-

ment à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

L'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Madame  Corinne  PETIT,  employée  privée,  avec  adresse  professionnelle  à

L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les 2.800 (deux mille huit

cents) actions sans valeur nominale, représentant 100% (cent pourcent) du capital social de 2.800.000,- euros (deux
millions huit cent mille euros) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider de l'ordre du jour qui ci-après reproduit.

Ladite liste de présence signée «ne varietur», portant la signature de l'actionnaire représenté, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec la procuration de l'actionnaire unique, pour être soumise en même temps aux
formalités de l'enregistrement.

II. Que la société n'a pas émis d'emprunts obligataires.
III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Création de deux classes d'actions A et B.
2. Modification subséquente de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 2.800.000,- (deux millions huit cent mille euros) divisé en 2.800 actions (deux mille

huit cents) actions sans valeur nominale qui sont réparties en deux catégories, soit 1.400 (mille quatre cents) actions de
classe A et 1.400 (mille quatre cents) actions de classe B.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

152587

L

U X E M B O U R G

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille

euros) représenté par 3.500 (trois mille cinq cents) actions sans valeur nominale.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- de réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèce, d'apport en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles; et

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obli-

gations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant
entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le conseil
d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes
autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

3. Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, aborde l'ordre du jour et prend après délibération, à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée décide de créer deux classes d'actions A et B.
En conséquence l'article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 2.800.000,- (deux millions huit cent mille euros) divisé en 2.800 actions (deux mille

huit cents) actions sans valeur nominale qui sont réparties en deux catégories, soit 1.400 (mille quatre cents) actions de
classe A et 1.400 (mille quatre cents) actions de classe B.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille

euros) représenté par 3.500 (trois mille cinq cents) actions sans valeurs nominale.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- de réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèce, d'apport en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles; et

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obli-

gations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant
entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le conseil
d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes
autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.«

152588

L

U X E M B O U R G

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Kernet et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le Relation: LAC/2011/. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158900/106.
(110185351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 118.913.425,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.062.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158936/10.
(110184976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Extravaganza S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 23, rue Chimay.

R.C.S. Luxembourg B 155.989.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011158938/9.
(110185170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Solucom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg, 12, Zone Industrielle Wolser 2.

R.C.S. Luxembourg B 13.979.

CLOTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mil onze, le trois novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOLUCOM S.A.", avec siège

social à L-3201 Bettembourg, 12, Zone Industrielle Wolser 2, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx,
alors notaire de résidence à Luxembourg, le 27 juillet 1976, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 224 du 19 octobre 1976, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 novembre 2009, publié au Mémorial C, numéro 2467 du 18 décembre
2009,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 13.979.
La société a été mise en liquidation suivant assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire instrumentant en

date du 3 mars 2010, publié au Mémorial C, numéro 805 du 19 avril 2010 et la société anonyme de droit belge SITA
BELGIUM, avec siège social à B-1130 Bruxelles, boîte 2, avenue de la Métrologie, 5, été nommée liquidateur.

<i>Bureau

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Christophe HOELTGEN, salarié, demeurant

professionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marlène RODRIGUES, salariée, demeurant professionnellement à

L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

152589

L

U X E M B O U R G

L'assemblée choisit comme scrutateur la FIDUCIAIRE DES PME, avec siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue

Glesener, RCS Luxembourg B 10.734,

représentée par Monsieur Théo HOLLERICH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1630 Luxem-

bourg, 58, rue Glesener et Monsieur Emmanuel GREGORIS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1630
Luxembourg, 58, rue Glesener.

<i>Composition de l'assemblée

Les noms des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant.

<i>Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Rapport du Commissaire à la liquidation.
2. Décharge aux anciens administrateurs et commissaire aux comptes de la société et au liquidateur et au commissaire

à la liquidation.

3. Clôture de la liquidation.
4. Désignation de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de

cinq ans.

II.- Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social d'un million

sept cent dix mille euros (EUR 1.710.000.-) sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi
valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation
préalable.

III. L'assemblée générale des actionnaires tenue le 30 septembre 2011, après avoir pris connaissance du rapport du

liquidateur, a nommé la société AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A., avec siège social à L-1630 Luxembourg,
58, rue Glesener, en tant que Commissaire à la liquidation.

<i>Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère

comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Ensuite le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

<i>Résolutions

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée prend connaissance du rapport du Commissaire à la liquidation concernant l'examen des documents de

la liquidation et l'exécution de la mission du liquidateur.

L'assemblée décide d'approuver les conclusions du rapport et les comptes de liquidation.
Le rapport du Commissaire à la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire

soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée accorde pleine décharge, sans aucune réserve ni restriction, aux anciens administrateurs et commissaire

aux comptes de la société ainsi qu'au liquidateur et au Commissaire à la liquidation de la société en ce qui concerne
l'exécution de leurs mandats respectifs.

<i>Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme SOLUCOM S.A. a cessé d'exister

à partir de ce jour.

152590

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide que les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans

à partir de ce jour au siège de la FIDUCIAIRE DES PME S.A., à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

<i>Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède, en langue d'elle connue, donnée à l'assemblée, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte
avec le notaire.

Signé: Christophe HOELTGEN, Marlène RODRIGUES, Théo HOLLERICH, Emmanuel GREGORIS, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 novembre 2011. Relation: LAC/2011/49021. Reçu soixante-quinze euros

(75- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 novembre 2011.

T. METZLER.

Référence de publication: 2011159612/96.
(110185366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Gerüstbau A. Mathieu GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5408 Bous, 37, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 103.815.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 21.11.2011.

<i>Pour Gerüstbau A. Mathieu GmbH
International Consulting Worldwide Sarl.
2, rue de la Moselle
L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2011159017/15.
(110185083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Flying Group Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1110 Luxembourg, route de Trèves, Findel Airport.

R.C.S. Luxembourg B 141.715.

Veuillez prendre note du changement de l'adresse du membre du conseil de surveillance:
Monsieur Gérard MATHEIS
5, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg

Luxembourg, le 22 novembre 2011.

<i>Pour Flying Group Lux S.A.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2011158944/14.
(110185203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152591

L

U X E M B O U R G

Global Groupe International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.130.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 novembre 2011

Les membres du Conseil d'administration, délibérant valablement, décident de transférer le siège social de la Société

de L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte.

Les membres du Conseil d'administration prennent note que la nouvelle adresse professionnelle de Monsieur François

Georges, est la suivante: L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 3 novembre 2011.

GLOBAL GROUPE INTERNATIONAL S.A.
Signature

Référence de publication: 2011159027/18.
(110185429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Flying Group Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1110 Luxembourg, route de Trèves, Findel Airport.

R.C.S. Luxembourg B 141.715.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Flying Group Lux S.A.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2011158945/11.
(110185455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Fagas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.757.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AGIF S.A.
Signature

Référence de publication: 2011158947/11.
(110185037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Four Seas S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 119.902.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FOUR SEAS S.A.
SGG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011158996/12.
(110185440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

152592


Document Outline

Albatros Solutions S.A.

Alfred Berg

Alta

Apex Insurance Holdings LLC Luxembourg S.C.A.

Archipel Newko S.A.

Assoco Ré S.A.

BDCI Investments S.à r.l. SPF

Belval Plaza Tower S.à r.l.

Blue Shield Investments S.A.

C.H.A.S. S.A.

Daregon Financial Services S.A.

Degussa Re

Delta Yachting Luxembourg S.A.

Devon S.A.

DeWAG LT Holdings S.à r.l.

Dexamenos Développement S.A.- SPF

Dom Estate S.A.

Dumagis S.A. - SPF

Eikon Invest II S.A.

Eikon Mezzanine Income S.A.

Eikon Mezzanine Invest III S.A.

Elektron S.A.

ENEX Group S.A.

Enrotec Lux Sàrl

Entreprise de Peinture MASSEN S.à r.l.

Epinikion Services Sàrl

Equalia Capital S.A.

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A.

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A.

Etab Engineering GmbH

Eupalia S.A.

Eurocom J.L.M. S.A.

European Financial and Partners S.A. Soparfi

EuroRidge Solar Holding S.à r.l.

EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l.

Evonik Re S.A.

Extravaganza S.à r.l.

Fagas S.A.

Fintlux S.A.

Finwellness S.A.

First Data International Luxembourg S.à r.l.

Flying Group Lux S.A.

Flying Group Lux S.A.

Four Seas S.A.

Gerüstbau A. Mathieu GmbH

Global Financial and Commercial Holdings Sapphire S.à r.l.

Global Groupe International S.A.

Harsco Metals Luxembourg S.A.

HC Investissements (Europe) S.à r.l.

Hitechphoto S.à r.l.

Jigsaw SA

Latsco Development S.A.

Moon Stone International Investment S.A.

PPF Tivoli S.à r.l.

Sculptor Springs of Eden S.à r.l.

Smartsynergy s.a.

Solucom S.A.

WIKIO Luxembourg

Zaka