logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3049

13 décembre 2011

SOMMAIRE

Acacio Promotions SA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

146329

aeris CAPITAL Management Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146332

Auto Factory Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146329

Baie Bleue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146331

Bankinter International Fund SICAV  . . . .

146335

Becatello Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

146331

Becton Dickinson Management S.à r.l.  . . .

146333

Becton Dickinson Management S.à r.l.  . . .

146333

BELFOR Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

146335

Bergame Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

146338

Berkeley Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

146333

BestCaseScenario Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146334

Bevis Marks 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146334

Binah S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146334

Boutique Richy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146339

Breva S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146339

Bullstrode Continental S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

146340

Bullstrode Continental S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

146341

CaCh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146350

Caducée Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

146349

C.A.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146344

Carrière S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146352

CarVal Investors GVF Luxembourg Twen-

ty S. à r.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146349

CEOP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146339

Ceram Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146341

C.F. Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146341

Chartreuse et Mont Blanc GP S.à r.l.  . . . .

146349

Chartreuse et Mont Blanc Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146351

Claykens S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146351

Climate Change Capital Carbon Fund S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146350

Coolcoups  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146340

Decofin S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146335

Düsseldorf/Wilmersdorfer Arcaden . . . . . .

146334

Event Concept Consulting Ltd  . . . . . . . . . .

146340

Finplays Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

146345

Foncier & Participations S.A. . . . . . . . . . . . .

146350

Gate Gourmet Luxembourg III S.à r.l.  . . .

146333

Global IT Services PSF, S.à r.l.  . . . . . . . . . .

146342

Global IT Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

146342

Hydrostatic Motors International S.A.  . . .

146346

Ingersoll-Rand Faenza Financing S.àr.l. . . .

146330

Ingersoll-Rand Lux Euro Financing S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146330

Island Group Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

146323

John Taylor Corporate S.A.  . . . . . . . . . . . . .

146345

KPMG Pension Scheme, Sepcav  . . . . . . . . .

146351

Mecatech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146352

MediaCenter Service Immobilier S.A. . . . .

146352

Mediobanca International (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146326

Provimentum I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146336

Sandflower Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146326

Selene Patrimoine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146331

ShweDagon Investissements S.A.  . . . . . . . .

146352

Société Financière de Constructions S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146330

Sparinvest Holdings SE  . . . . . . . . . . . . . . . . .

146306

Tasselot S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146336

Victoria Real Properties S.C.  . . . . . . . . . . . .

146323

Vinum Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146350

WSB Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146341

146305

L

U X E M B O U R G

Sparinvest Holdings SE, Société Européenne.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.834.

STATUTES

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There exists a company in the form of a société européenne (SE) under the name of "Sparinvest Holdings

SE" (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of incorporation.

Art. 3. Purpose.
3.1 The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies carrying out of all operations related to the activities and services of the financial sector and particularly
investment activities, investment fund management, IT services and systems for the financial sector.

3.2 The purpose of the Company is further the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

3.3 The Company may, for its own account and for the account of third parties, carry out any commercial, industrial

or financial activities which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly
or indirectly to its purpose.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

directors.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

4.5 The registered office of the Company may be transferred from the Grand-Duchy of Luxembourg to another

member state of the European Union in accordance with applicable laws. Such a transfer shall not result in the dissolution
of the Company or in the creation of a new legal person.

B. Share capital - Shares - Register of registered shares - Ownership and Transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1 Issued share capital
5.1.1 The Company's issued share capital is set at forty million three hundred and fifty-nine thousand four hundred

Danish Krone (DKK 40,359,400) consisting of four hundred three thousand five hundred and ninety four (403,594) shares
having a nominal value of one hundred Danish Krone (DKK 100) each and is divided into three hundred thirty eight
thousand three hundred and ninety-two (338,392) A shares, thirty three thousand four hundred and sixty-eight (33,468)
B shares and thirty-one thousand seven hundred and thirty-four (31,734) C shares.

5.1.2 Under the terms and conditions provided by law the Company's issued share capital may be increased by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of incorporation.

5.1.3 Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of

plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by
them  in  the  Company's  share  capital.  The  board  of  directors  shall  determine  the  period  of  time  during  which  such
preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days either from the date
of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription or from the date
of publication of the notice announcing the opening of the subscription and determining the subscription period, such
notice being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in two newspapers published in
Luxembourg. However, subject to the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders, called
(i) either to resolve upon an increase of the Company's issued share capital (ii) or upon the authorisation to be granted
to the board of directors to increase the Company's issued share capital within the scope of the authorised share capital,

146306

L

U X E M B O U R G

may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) or authorise the board of directors
to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.

5.1.4 Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of incorporation.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into Class A shares, Class B shares and Class C shares, each of them having

the same nominal value.

6.2 All class A shares shall be identical in all respects. All class A shares shall be entitled to the payment of dividends

on a pro-rata basis and in any distribution of assets other than by way of dividends, such distributions will be allocated
on an aggregate basis to such class A shares. Each class A share will entitle the holder thereof to one vote on all matters
upon which shareholders have the right to vote.

6.3 All class B shares shall be identical in all respects. All class B shares shall be entitled to the payment of dividends

on a pro-rata basis and in any distribution of assets other than by way of dividends, such distribution will be allocated on
an aggregate basis to such class B shares. Each class B share will entitle the holder thereof to one vote on all matters
upon which shareholders have the right to vote.

6.4 All class C shares shall be identical in all respects. All class C shares shall be entitled to the payment of dividends

on a pro-rata basis and in any distribution of assets other than by way of dividends, such distribution will be allocated on
an aggregate basis to such class C shares. Each class C share will entitle the holder thereof to one vote on all matters
upon which shareholders have the right to vote.

6.5 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding any shareholder shall not

cause the Company's dissolution, without prejudice to Article 18.

6.6 The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.

Art. 7. Register of registered shares.
7.1  A  register  of  registered  shares  will  be  kept  at  the  Company's  registered  office,  where  it  will  be  available  for

inspection by any shareholder. This register of registered shares will in particular contain the name of each shareholder,
his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of
the payments made on the shares, any transfer of shares and the dates thereof pursuant to Article 8.4 of these articles
of incorporation as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company of his/her/its address and any change thereof. The Company may rely

on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership of the shares.
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of registered

shares. Certificates of these recordings will be issued and signed by the chairman of the board of directors, by any two
of its members or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of such share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3 The shares are transferable, subject to the terms and conditions of the law of 10 August 1915 concerning com-

mercial companies, as amended (hereafter the "Law") and subject further to the provisions of Article 10.

8.4 Any transfer of shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording

of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their
representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant
to which any director may record such transfer in the register of registered shares.

8.5 The Company, through any of its directors, may also accept and enter into the register of registered shares any

transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the trans-
feree's consent.

Art. 9. Restrictions on Ownership of the shares.
9.1 Class A shares and class C shares may only be subscribed by local or regional banks who cover a particular local

or regional area (non-nationwide banks) and co-operative associations of such banks, pension funds, insurance companies,
foundations and investment funds which either have extensive business relations with the Company and/or its consolidated
companies (collectively the "Sparinvest Group") or which are expected by the board of directors to develop such business
relations with the Sparinvest Group and which have been admitted as shareholders of the Company ("A shareholders"
in relation to ownership of A shares and "C Shareholder" in relation to ownership of C shares).

146307

L

U X E M B O U R G

9.2 Class B shares may only be subscribed by employees of the Company and of its direct or indirect controlled

companies who have acquired shares in the Company pursuant to a resolution passed by the Company's board of directors
or by the general meeting admitting them as shareholders ("B shareholders")

9.3 Persons and companies or entities not included in the groups of shareholders referred to above may not acquire

existing or subscribe for new shares in the Company without prior approval of the general meeting of shareholders with
the quorum and majority requirements required by for an amendment of the articles of incorporation of the Company.

9.4 The above mentioned provisions shall be without prejudice to the Company's right to acquire its own shares

irrespective of the class of shares.

9.5 No shareholder may hold more than 25% of the Company's total share capital. Any shareholder holding more than

25% of the share capital for whatever reason shall offer the excess shares for sale in accordance with the provisions on
pre-emption rights in Article 10.

9.6 The Company will not acknowledge and register in the register of registered shares any transfer of shares in excess

of 25%.

Art. 10 Restrictions on the transfer of shares and Exercise of pre-emption rights.
10.1 Any transfer of shares shall be subject to the prior written consent of the board of directors.
10.2 No share in the Company may be charged or pledged without the prior written consent of the board of directors.
10.3 Class C shares cannot be transferred until after the adoption of the Company's annual accounts for the financial

year ending on 31 December 2013 at the Company's annual general meeting of shareholders to be held in 2014. Until
this time the class C shares are to be covered by the provisions in Articles 12 and 13 but not by the provisions in Articles
10.4 and 11 subject to Article 11.4.

10.4 In connection with any transfer of shares in the Company, by whichever means, the Company or, in the alternative,

the remaining A shareholders and C shareholders (the "Pre-emption Right Holders") shall have a right of preemption to
acquire the shares at a pre-emption right price as specified in Article 10.12.

10.5 The Company may at its own discretion exercise the pre-emption right either on its own behalf or on behalf of

a subsidiary designated by the Company. For the purpose of this article, subsidiary shall mean a company directly or
indirectly controlled by the Company as such concept is further defined in Article 12 below.

10.6 However, the pre-emption right shall not apply to shares that are (i) transferred as a result of a merger, amalga-

mation or other combination among the Company's shareholders or (ii) to shares transferred by class B shareholders.
Class C shareholders are not to have any rights or obligations under this Article 10 or under 9 before the expiry of the
negotiability restriction in Article 10.3, subject to Article 11.4.

10.7 If an event occurs which would entitle the Company or the Pre-emption Right Holders to exercise their pre-

emption right to acquire shares in the Company held by one of the A or C shareholder, such shareholder (the "Disposing
Shareholder"), upon becoming aware of the triggering event shall promptly give the board of directors written notice
thereof, specifying the event triggering the pre-emption right and the number of shares in the Company subject to the
pre-emption right and held by the Disposing Shareholder (the "Offered Shares").

10.8 Upon receiving such written notice, the board of directors of the Company shall decide by a majority of votes

cast whether the Company wished to exercise its pre-emption right over the Offered Shares either on its own behalf or
on behalf of a subsidiary designated by the Company. If the Company does not want to exercise the pre-emption right
itself, the board of directors shall, without undue delay, forward the notice by letter by recorded delivery to the Pre-
emption Right Holders. The pre-emption right shall be exercised no later than 30 days after the shareholders' receipt of
the written notice. If more than one Pre-emption Right Holders elects to exercise the pre-emption right, the Offered
Shares shall be allocated among such shareholders in proportion to their respective shareholdings in the Company.

10.9 Upon exercise of the pre-emption right, the purchase price of the Offered Shares acquired shall be paid in cash

no later than one month after the date of exercise.

10.10 The transfer of the Offered Shares shall be completed and duly recorded in the register of registered shares

upon payment of the purchase price by the Company, the acquiring shareholder(s) or the third party as applicable.

10.11 If neither the Company nor a Pre-emption Right Holder wants to exercise their pre-emption right, the Offered

Shares may be transferred to a third party which would meet the criteria referred to in Article 9 and acceptable to the
Company's board of directors. If the board of directors refuses to accept a third party that satisfies the shareholder
requirements set out in Article 9, the Disposing Shareholder is entitled to have its shares redeemed under Article 11.
The terms of any transfer under this Article 10.11 shall not be more favourable to any third party than the terms offered
to the Company and to the Pre-emption Right Holders. Any transfer shall take place within two months after expiry of
the time allowed for exercise of any pre-emption right as set out in Article 10.8 above and before a new annual general
meeting is held in the Company. If the shares have not been transferred in whole or in part before the end of this period,
the preemption right may be exercised again pursuant to the above provisions. Alternatively, the Disposing Shareholder
may demand redemption by the Company under Article 11.

10.12 The pre-emption right price shall be fixed every year at the Company's annual general meeting using the method

approved by the general meeting of shareholders of 30 September 2011 and shall be effective for each respective calendar
year retrospectively from 1 January.

146308

L

U X E M B O U R G

11. Redemption of the Offered Shares.
11.1 If the Offered Shares have not been acquired from the Disposing Shareholders following the process set out in

Article 10, the Disposing Shareholders can, subject to the provision of Article 49-2 of the Law, demand that the Offered
Shares are redeemed by the Company. The request for redemption shall be made to the board of directors within 30
days after expiry of the time allowed for exercise of any pre-emption right as set out in Article 10.8. The redemption will
only be executed once every year in connection with the annual adjustment. The redemption will be executed in con-
nection with the first annual adjustment (see Article 14) that is made 30 days or more after expiry of the time allowed
for exercise in Articles 10.8 or 10.11.

11.2 The redemption price shall be determined every year at the annual general meeting of shareholders using the

method approved by the general meeting of shareholders on 30 September 2011.

11.3 If the Disposing Shareholder holds shares in the Company contrary to current rules, or if the shares are sold as

a result of a decision from a public authority, or if the Disposing shareholder is forced to sell its shares, the Company's
board of directors may grant an exemption from the rule requiring redemption to take place in connection with the
annual adjustment under Article 14 and allow redemption upon receipt of the request (see Article 11.1). Upon the granting
of the exemption by the board of directors, the redemption price shall be fixed with binding effect by the Company's
auditor using the method adopted by the extraordinary general meeting of shareholders on 30 September 2011. The
redemption shall be subject to the rules set out by Luxembourg law.

11.4 If as a consequence of a decision from a public authority, a forced sale or a similar compulsory disposal a transfer

of C shares takes place before the expiry of the negotiability restriction in Article 10.3, the provisions of Articles 10 (Pre-
emption Right) and 11 (Redemption) are to apply correspondingly with the modifications deemed necessary by the board
of directors.

12. Call option.
12.1 In case of a direct or indirect change of control (control meaning in respect of any shareholder, (i) the legal or

beneficial ownership, directly or indirectly, of more than 50% of the voting rights in such shareholder or, with respect to
a trust, of more than 50% of the beneficial interest in such trust or holding such position as trustee or in similar capacity,
or (ii) the power to manage, govern or otherwise direct the management and policies of such shareholder, or to appoint
the managing and governing bodies of such shareholder or a majority of the members thereof, directly or indirectly and
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise) of a class A shareholder or a class C
shareholder, whereby a third party would become direct or indirect shareholder of the class A or class C shareholder,
the Company or, the Company's other class A shareholders or class C shareholders shall have an option to purchase the
A shareholder's or C shareholders' shares in the Company. Article 10 (pre-emption right) shall also apply such changes
as are necessary.

13. Redemption obligation.
13.1 If the shares held by an A shareholder or C shareholder in the Company are subject to Article 12 (Call option)

without the Company or the other A shareholders or C shareholders in the Company exercising their purchase option,
the A shareholder is under an obligation to have its shares redeemed by the Company in connection with a capital
reduction, if applicable, on the terms prescribed in Article 11.3, second sentence (right of redemption).

14. Annual adjustment.
14.1 Every year upon adoption of the Company's annual accounts by the annual general meeting of shareholders, the

board of directors shall determine each A shareholder's and C shareholder's contribution to the assets under management
by the Sparinvest Group as a percentage (each a "Share of Assets under Management") of the total sum of assets under
management by the Sparinvest Group (the "Total Assets under Management") as further defined and calculated pursuant
to Article 14.3.

14.2 However, class C shareholders do not participate in the annual redistribution under this Article 14 before the

calculation that is made immediately after the annual general meeting of shareholders to be held in 2014. In relation to
the period until the adoption of the Company's annual accounts for the financial year ending on 31 December 2013 at
the Company's annual general meeting of shareholders to be held in 2014 the board of directors will disregard the class
C shareholders in the calculation of the annual adjustment. In respect of shareholders who are class A shareholders as
well as class C shareholders the ownership share in this period will be calculated as the shareholder's total Share of Assets
under Management less the shareholder in question's equivalent share of assets under management of the EgnsINVEST
as at 29 October 2010 as this ownership share has formed the basis of the allotment of C shares to the C shareholders
at the merger between EgnsINVEST Holding (Spar) A/S and the Company with the Company as the surviving company
as adopted by the extraordinary general meeting of shareholders on 18 May 2011.

14.3 For the purpose of this Article 14, the board of directors shall determine each class A shareholder's and class C

shareholder's Share of Assets under Management as the sum of (a) the portfolio of investment certificates issued by
Investeringsforeningen Sparinvest or other investment funds managed (as investment manager and not only administrator)
by Sparinvest Group, which each A shareholder or C shareholder holds either in custody accounts for their customers
or in its own name and (b) the A shareholder's or C shareholder's own assets under investment being managed (as
investment manager and not only administrator) by the Sparinvest Group, such sum expressed as a percentage relative

146309

L

U X E M B O U R G

to the Total Assets under Management, which shall mean the sum of all such Assets under Management for all A share-
holders and C shareholders.

14.4 If the A shareholder's or C shareholder's Share of Assets under Management as determined does not correspond

to its adjusted ownership share -calculated as the A shareholder's or C shareholder's percentage shareholding in the
Company relative to 85% of the total share capital (ownership share as a percentage x 100/85) ("the ownership share")
- then the A shareholder or C shareholder in question shall offer the excess shares in the Company for sale according
to the pre-emption rules in Article 10 above, or in the alternative according to the rules on right of redemption in Articles
11.1-11.3, except that redemption may take place at the same time as the adjustment and the redemption price shall be
the price fixed at the last annual general meeting using the method prescribed by the general meeting of shareholders on
30 September 2011. If the A shareholder or the C shareholder in question satisfies the requirements applying to the
Company's shareholders (see Article 9), the A shareholder or C shareholder in question is, however, entitled to keep
at least 100 shares in the Company.

14.5 If, on the other hand, the Share of Assets under Management exceeds the ownership share, the board of directors

shall, by selling the Company's own shares, allow the A shareholder or C shareholder to purchase shares in the Company
until the ownership share corresponds to the capital share.

14.6 For the purpose any adjustment under Articles 14.4 and 14.5, the share price shall be the pre-emption right price

as determined at the Company's last annual general meeting (see Article 10.12).

15. Dividends.
15.1 The shares shall confer on the holder the right to receive dividends. Dividends shall be paid to the shareholder

at the address indicated by the shareholder in the register of shareholders at the time of payment of dividends.

C. General meeting of shareholders

Art. 16. Powers of the general meeting of shareholders.
16.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one

of the Company's corporate bodies.

16.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of incorporation, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of incor-
poration is to be construed as a reference to the "sole shareholder".

16.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of incorporation.

Art. 17. Convening general meetings of shareholders.
17.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or

by the independent auditor(s), if any, as the case may be, to be held in Luxembourg at such place and on such date as
specified in the notice of such meeting.

17.2 The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the independent auditor

(s), if any, as the case may be, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the board of directors or to
the statutory auditor(s) by one or several shareholders representing in the aggregate at least five per cent (5%) of the
Company's issued share capital. In this case, the general meeting of shareholders must be convened by the board of
directors or by the statutory auditor(s) in order to be held within a period of one (1) month from receipt of such request
at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.

17.3 An annual general meeting of shareholders must be held in the municipality where the Company's registered

office is located or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of such meeting, on the third
Tuesday of the month of April at 11 a.m. local time. If such day is a legal or bank holiday, the annual general meeting of
shareholders must be held on the next following business day. The board of directors or the independent auditor(s), as
the case may be, must convene the annual general meeting of shareholders within a period of six (6) months from closing
the Company's accounts.

17.4 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice should be either published twice, with a minimum interval of eight (8) days
and  eight  days  prior  to  the  date  of  the  general  meeting  of  shareholders,  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Soiétés  et
Associations and in a Luxembourg newspaper or such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at
least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting. In case such notice is being published in the conditions
set out above, the notice will also be sent to each shareholder by letter at least eight (8) days prior to the date scheduled
for the meeting.

17.5 One or several shareholders, representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued

share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders.
Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least six (6) weeks prior to the date
scheduled for the meeting.

146310

L

U X E M B O U R G

17.6 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 18. Conduct of general meetings of shareholders.
18.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of directors. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

18.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
18.3 Quorum
No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise

required by law or by these articles of incorporation.

18.4 Vote
18.4.1 Each share entitles to one (1) vote, subject to the provisions of the Law.
18.4.2 Unless otherwise required by law or by these articles of incorporation, resolutions at a general meeting of

shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of
capital represented. Abstention and nil votes will not be taken into account.

18.4.3 Any resolution to dissolve or merge the Company, or to sell the Company as a whole may only be adopted

with the positive votes of shareholders representing at least two-thirds of the Company's issued share capital notwiths-
tanding the provisions of article 67-1 of the Law.

Abstention and nil votes will not be taken into account.
18.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

18.6 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

18.7 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking the appropriate box with a cross. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

18.8 Shareholders who have acquired shares by a transfer may exercise the voting right attaching to such shares if,

before the date of the notice of the meeting, the acquisition has been registered in the Company's register of shareholders
or the shareholder has given notice to the Company of the acquisition and established good title to the shares.

18.9 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to

take part in any general meeting of shareholders.

Art. 19. Amendment of the articles of incorporation. Notwithstanding the provisions of Article 67-1 of the Law, these

articles of incorporation may only be amended at an extraordinary general meeting of shareholders of the Company with
the positive votes of shareholders representing at least two-thirds of the Company's issued share capital. Abstention and
nil votes will not be taken into account.

Art. 20. Adjourning general meetings of shareholders. Subject to the terms and conditions of the Law, the board of

directors may adjourn any general meeting of shareholders already commenced, including any general meeting convened
in order to resolve on an amendment of the articles of incorporation, to four (4) weeks. The board of directors must
adjourn any general meeting of shareholders already commenced if so required by one or several shareholders repre-
senting in the aggregate at least twenty per cent (20%) of the Company's issued share capital. By such an adjournment of
a general meeting of shareholders already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled.

Art. 21. Minutes of general meetings of shareholders.
21.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

21.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
21.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the

146311

L

U X E M B O U R G

meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two
of its members or by the sole director, as the case may be.

D. Corporate body

Art. 22. Powers of the board of directors.
22.1 The Company shall be managed by an administrative body called a "board of directors", whose members need

not be shareholders of the Company, which shall meet at least once every three months in accordance with Article 64,
paragraph 3, of the Law.

22.2 If it is noted at a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder, the Company may

be managed by a sole director until the general meeting of shareholders following the Company's awareness that several
shareholders exist. In such case and to the extent applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned
in these articles of incorporation, a reference to the "board of directors" used in these articles of incorporation is to be
construed as a reference to the "sole director".

22.3 The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interest. All powers not expressly reserved by Council Regulation (EC) n° 2157/2001 of 8 October
2001  on  the  Statutes  for  a  European  company  (SE)  or  by  these  articles  of  incorporation  to  the  general  meeting  of
shareholders fall within the powers of the board of directors.

22.4 At least the following categories of transactions require an express decision of the board of directors:
- to approve the annual reports of the Company, subject to their decisive approval by the general meeting of share-

holders as well as to prepare and call general meetings of shareholders;

- to decide upon the acquisition and disposal of subsidiaries of the Company.
22.5 In accordance with Article 60 of the Law, the Company's daily management and the Company's representation

in connection with such daily management shall be delegated to an Executive Officer acting alone. Its appointment, re-
vocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

22.6 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any person acting alone

or jointly with others as agent of the Company.

Art. 23. Composition of the board of directors.
23.1 The board of directors is composed of at least three (3) members and maximum ten (10) members excluding

any employee elected board members appointed pursuant mandatory employee participation agreement executed from
time to time under the rules of Article 3(3) of EU directive 2001/86/EF

23.2 The board of directors must choose from among its members a chairman and a vice-chairman of the board of

directors. It may also a secretary who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of directors.

23.3 In case of absence of the chairman of the board of directors, the vice-chairman will take responsibility to execute

the duties of the chairman of the board of directors.

Art. 24. Election and Removal of directors and Term of the office.
24.1 Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

24.2 If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent

representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director and may not be a director at the same time.

24.3 Any director may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders.

24.4 The term of the office of a director may not exceed one (1) year and any director shall hold office until its/his/

her successor is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

Art. 25. Vacancy in the office of a director.
25.1 If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy,

retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled, on a temporary basis, by the remaining board members until
the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed suitable.

25.2 If, in case of plurality of shareholders, the total number of members of the board of directors falls below three

(3) or below such higher minimum set by these articles of incorporation, as the case may be, such vacancy must be filled
without undue delay either by the general meeting of shareholders or, on a temporary basis, by the remaining board
members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on the permanent appointment.

25.3 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

146312

L

U X E M B O U R G

Art. 26. Convening meetings of the board of directors.
26.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

26.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each director in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of
the board of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of resolutions in
writing pursuant to these articles of incorporation.

Art. 27. Conduct of meetings of the board of directors.
27.1 The chairman of the board of directors shall preside at all meeting of the board of directors. In his/her/its absence,

the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore.

27.2 Quorum
The board of directors can act and deliberate validly only if at least half of its members are present at a meeting of the

board of directors to be held in Luxembourg.

27.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present at a meeting of the board of directors.

The chairman shall have a casting vote.

27.4 Save as otherwise provided by law, any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a trans-

action submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the
board of directors of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board
meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any
such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on
any other item. Where the Company has a sole director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary
interest in a transaction entered into between the sole director and the Company, which conflicts with the Company's
interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction.

Art. 28. Minutes of meetings of the board of directors.
28.1 The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman shall draw minutes of any meeting of the board

of directors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

28.2 The sole director, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
28.3 Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director,
as the case may be.

Art. 29. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint

signatures of (i) any two directors or (ii) by the joint signature of the chairman and the vice-chairman or (iii) by the joint
signature of the vice-chairman and the Executive Officer or (iv) by the joint signatures or by the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power has been granted by the board of directors or by the sole director. Within the
limits of the daily management, the Company will be bound towards third parties by the signature of the Executive Officer
or any person(s) to whom such power in relation to the daily management of the Company has been delegated acting
alone or jointly in accordance with the rules of such delegation.

E. Supervision

Art. 30. Independent auditor(s). The operations of the Company shall be supervised by an independent auditor. The

independent auditor shall be chose amongst the "réviseurs d'entreprises agréés" or "cabinets de révision agréés" accre-
dited by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) and shall be appointed by the general meeting of
shareholders, which determines the term of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 31. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

Art. 32. Profits.
32.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.

146313

L

U X E M B O U R G

32.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

32.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

32.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of directors, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the Law and these articles of incorporation.

Art. 33. Interim dividends - Share premium.
33.1 Under the terms and conditions provided by law, the board of directors may proceed to the payment of interim

dividends.

33.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the director(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 34. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 35. Governing law. These articles of incorporation shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with
the Law.

Es folgt die deutsche Übersetzung

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Es besteht eine Gesellschaft in der Form einer société européenne (SE) unter dem Namen "Sparinvest

Holdings SE" (die „Gesellschaft").

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen

Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher der für eine Änderung dieser Satzung erfor-
derlichen Mehrheit bedarf.

Art. 3. Zweck.
3.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art, in Luxemburg und in anderen ausländischen

Gesellschaften, die Durchführung aller Geschäfte in Zusammenhang mit den Aktivitäten und Dienstleistungen des finanz-
iellen  Sektors  und  insbesondere  Investitionstätigkeiten,  Management  von  Investmentfonds,  IT  Dienstleistungen  und
Systeme für den finanziellen Sektor.

3.2 Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften

und sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf jede
andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihres Wertpapierbestandes.

3.3 Die Gesellschaft kann für sich selbst und für Dritte alle handelsbezogene, industrielle oder finanzielle Tätigkeiten

vornehmen,  die  ihr  zur  Erreichung  ihres  Gesellschaftweckes  nützlich  oder  erforderlich  erscheinen  oder  direkt  oder
indirekt mit diesem in Verbindung stehen.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrats

verlegt werden.

4.3 Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre in jede andere Gemeinde des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird, wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch

einen Beschluss des Verwaltungsrats errichtet werden.

4.5 Der Sitz der Gesellschaft kann vom Großherzogtum Luxemburg in einen anderen Mitgliedsstaat der Europäischen

Union verlegt werden gemäß den anwendbaren Gesetzen. Diese Verlegung kann nicht die Auflösung der Gesellschaft
oder die Gründung einer neuen juristischen Person als Folge haben.

B. Aktienkapital - Aktien - Aktienverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Aktien

Art. 5. Aktienkapital.
5.1 Ausgegebene Aktienkapital

146314

L

U X E M B O U R G

5.1.1 Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt vierzig Millionen drehundertneunundfünfzigtausendvier-

hundert  Dänische  Kronen  (DKK  40.359.400,-)  bestehend  aus  vierhundertdreitausendfünfhundertvierundneunzig
(403.594) Aktien mit einem Nennwert von hundert Dänischen Kronen (DKK 100) jede und ist geteilt in dreihunder-
tachtunddreißigtausenddreihundert-zweiundneunzig (338.392) Aktien der Klasse A, dreiunddreißigtausend-vierhunder-
tachtundsechzig (33.468) Aktien der Klasse B und einunddreißig-tausendsiebenhundertvierunddreißig (31.734) Aktien der
Klasse C.

5.1.2 Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft kann gemäß den Bestimmungen des Gesetzes durch einen Be-

schluss  der  Generalversammlung  der  Aktionäre  erhöht  werden,  welcher  in  der  Weise  gefasst  wird  wie  es  für  eine
Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

5.1.3 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlage bezahlt werden, werden vorzugsweise dem (n) bestehenden Aktionär

(en) angeboten. Im Falle von mehreren Aktionären, werden diese Aktien den Aktionären angeboten proportional zur
Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, im Aktienkapital der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat setzt den Zeitraum fest
während dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht kürzer als 30 (dreißig) Tage sein
entweder ab dem Datum der Absendung eines Einschreibens an die Aktionäre, das den Beginn der Zeichnung ankündigt
oder ab dem Datum der Veröffentlichung des Bescheids, der den Beginn der Zeichnung bekannt gibt und die Zeich-
nungsfrist festlegt, wobei dieser Bescheid im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und in zwei Zeitungen in
Luxemburg veröffentlicht wird. Die Generalversammlung der Aktionäre die, entweder einberufen wird, um (i) über eine
Erhöhung des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft zu beschliessen (ii) oder über die Genehmigung, die dem
Verwaltungsrat eingeräumt wird, um das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft im Rahmen des genehmigten Akti-
enkapitals  zu  erhöhen  kann  jedoch,  gemäß  den  Bestimmungen  des  Gesetzes,  das  Vorzugsrecht  des  (r)  bestehenden
Aktionärs (en) beschränken oder abschaffen oder den Verwaltungsrat bevollmächtigen es zu tun. Dieser Beschluss wird
angenommen in der Weise wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

5.1.4 Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft kann gemäß den Bestimmungen des Gesetzes durch einen Be-

schluss der Generalversammlung herabgesetzt werden, welcher in einer Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieser Satzung erforderlich ist.

Art. 6. Aktien.
6.1 Das Aktienkapital der Gesellschaft ist geteilt in Aktien der Klasse A, Aktien der Klasse B und Aktien der Klasse C,

jede davon mit dem gleichen Nennwert.

6.2 Sämtliche Aktien der Klasse A werden in jeder Hinsicht identisch sein. Alle Aktien der Klasse A geben Anspruch

auf die Zahlung von Dividenden auf pro-rata Basis und auf die Ausschüttung von geldwerten Gütern, nicht in Form von
Bardividenden, solche Ausschüttungen werden auf kumulierter Basis den Aktien der Klasse A zugewiesen. Jede Aktie der
Klasse A berechtigt dessen Eigentümer zu einer Stimme bei Angelegenheiten bei denen die Aktionäre das Recht haben,
zu wählen.

6.3 Sämtliche Aktien der Klasse B werden in jeder Hinsicht identisch sein. Alle Aktien der Klasse B geben Anspruch

auf die Zahlung von Dividenden auf pro-rata Basis und auf die Ausschüttung von geldwerten Gütern, nicht in Form von
Bardividenden, solche Ausschüttungen werden auf kumulierter Basis den Aktien der Klasse B zugewiesen. Jede Aktie der
Klasse B berechtigt dessen Eigentümer zu einer Stimme bei Angelegenheiten bei denen die Aktionäre das Recht haben,
zu wählen.

6.4 Sämtliche Aktien der Klasse C werden in jeder Hinsicht identisch sein. Alle Aktien der Klasse C geben Ansprach

auf die Zahlung von Dividenden auf pro-rata Basis und auf die Ausschüttung von geldwerten Gütern, nicht in Form von
Bardividenden, solche Ausschüttungen werden auf kumulierter Basis den Aktien der Klasse C zugewiesen. Jede Aktie der
Klasse C berechtigt dessen Eigentümer zu einer Stimme bei Angelegenheiten bei denen die Aktionäre das Recht haben,
zu wählen.

6.5 Der Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, der Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis, das einen

Aktionär betrifft, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft, unbeschadet des Artikels 18.

6.6 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien und können nicht in Inhaberaktien umgewandelt weiden.

Art. 7. Aktienverzeichnis.
7.1 Das Aktienregister wird am Geschäftssitz der Gesellschaft aufbewahrt, wo es durch jeden Aktionär eingesehen

werden kann. Dieses Aktienregister enthält insbesondere den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Wohnsitz oder ein-
getragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Aktionär gehaltenen Aktien,die Angabe der auf diese Aktien
geleisteten Zahlungen, jede Übertragung von Aktien und deren Datum gemäß Artikel 8.4 dieser Statuten, sowie jedes
Sicherungsrecht, das den Aktien eingeräumt wird.

7.2 Jeder Aktionär wird der Gesellschaft seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung mitteilen. Die Gesellschaft

kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltenen Adresse eines Aktionärs berufen.

Art. 8. Eigentum der Aktien.
8.1 Der Nachweis des Aktienbesitzes kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienverzeichnis erfolgen. Solche

Aktienzertifikate werden durch den Verwaltungsratsvorsitzenden ausgestellt und unterschrieben, durch zwei (2) Ver-

146315

L

U X E M B O U R G

waltungsratsmitglieder  oder  gegebenenfalls  durch  den  Geschäftsleiter  auf  Anfrage  und  auf  Kosten  des  betroffenen
Aktionärs.

8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen (1) Inhaber pro Aktie an. Falls eine Aktie mehreren Personen gehört,

müssen sie eine einzelne Person bestimmen, die als Alleineigentümerin dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angesehen
wird. Die Gesellschaft ist berechtigt das Ausüben aller Rechte einzustellen, die sich auf den Besitz einer Aktie durch
mehrere Eigentümern bezieht, bis ein einziger Eigentümer bestimmt wurde.

8.3 Die Aktien sind übertragbar gemäß Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der abgeänderten

Fassung (nachstehend das „Gesetz") und ferner vorbehaltlich den Bestimmungen von Artikel 10.

8.4 Die Übertragung der Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und gegenüber Dritten rechtskräftig entweder durch

Eintragung einer Übertragungserklärung ins Aktienregister, unterzeichnet und datiert durch den Zedenten und den Zes-
sionar oder durch ihre Vertreter oder durch Mitteilung der Übertragung durch die Gesellschaft oder durch Einverständnis
der Gesellschaft zur Übertragung, demzufolge jedes Verwaltungsratsmitglied die Übertragung in das Aktienverzeichnis
eintragen kann.

8.5 Die Gesellschaft kann auch durch jedes Verwaltungsratsmitglied jeder Übertragung zustimmen und ins Aktienre-

gister eintragen, die in jedem Schriftverkehr oder in einem anderen Dokument vorkommen und die Zustimmung des
Zedenten und des Zessionars belegen.

Art. 9. Einschränkungen auf den Besitz von Aktien.
9.1 Aktien der Klasse A und Aktien der Klasse C können nur durch örtliche oder regionale Banken, die einen speziellen

oder regionalen Bezirk abdecken (keine landesweite Banken) und Genossenschaften von diesen Banken, Pensionsfonds,
Versicherungs-Gesellschaften, Stiftungen und Investmentfonds gezeichnet werden, die entweder umfangreiche Geschäfts-
berziehungen mit der Gesellschaft unterhalten und / oder mit den konsolidierten Gesellschaften (insgesamt die,,Sparinvest
Group") oder von denen der Verwaltungsrat erwartet, daß sie diese Geschäftsbeziehungen mit der Sparinvest Group
entwickelt und die als Aktionäre der Gesellschaft zugelassen worden sind („A Aktionäre" bezogen auf den Besitz von
Aktien der Klasse A und „C Aktionäre" bezogen auf den Besitz von Aktien der Klasse C).

9.2 Aktien der Klasse B können nur durch Angestellte der Gesellschaft oder ihrer direkt oder indirekt kontrollierten

Gesellschaften gezeichnet werden, die Aktien in der Gesellschaft erwoben haben gemäß einem Beschluss durch den
Verwaltungsrat der Gesellschaft oder durch die Generalversammlung, die sie als Aktionäre zulässt („B Aktionäre").

9.3 Personen und Gesellschaften oder Unternehmen, die nicht zu den Gruppen von Aktionären die oben genannt sind,

gehören, können keine bestehenden Aktien erwerben oder neue Aktien zeichnen ohne die vorherige Genehmigung der
Generalversammlung mit dem Quorum und der Mehrheit der Voraussetzungen, die zur Abänderung der Statuten der
Gesellschaft benötigt werden.

9.4 Die oben genannten Bestimmungen gelten unbeschadet des Rechts der Gesellschaft, ihre eigenen Aktien zu er-

werben, unabhängig von der Klasse von Aktien.

9.5 Kein Aktionär kann mehr als 25% des gesamten Aktienkapitals der Gesellschaft besitzen. Jeder Aktionär, der mehr

als 25% des Aktienkapitals egal aus welchem Grund, wird den Überschuß an Aktien zum Kauf anbieten gemäß den Be-
stimmungen über Vorzugrecht in Artikel 10.

9.6 Die Gesellschaft wird keine Aktienübertragung anerkennen und in das Aktienregister eintragen, die 25% übersteigt.

Art. 10. Einschränkungen in Bezug auf Aktienübertragung und Ausübung von Vorzugsrechten.
10.1 Jede Aktienübertragung wird der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verwaltungsrats unterliegen.
10.2 Keine Aktie kann ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verwaltungsrats belastet oder verpfändet wer-

den.

10.3 Aktien der Klasse C können erst nach Genehmigung der Jahreskonten für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember

2013 endet, bei der Generalversammlung der Aktionäre, die 2014 abgehalten wird, übertragen werden. Bis zu diesem
Datum sind die Aktien der Klasse C durch die Bestimmungen von Artikel 12 und 13 abgedeckt und nicht durch die
Bestimmungen in Artikel 10.4 und 11 gemäß Artikel 11.4.

10.4 In Zusammenhang mit jeder Übertragung von Aktien der Gesellschaft, was bedeutet, dass die Gesellschaft oder

alternativ die verbleibenden A Aktionäre und C Aktionäre (die „Vorzugsrechtinhaber") ein Vorzugsrecht haben werden,
die Aktien zu einem Vorzugspreis wie festgelegt in Art. 10.12 zu kaufen.

10.5 Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen das Vorzugsrecht ausüben entweder in eigenem Namen oder in

Namen einer Tochtergesellschaft, die durch die Gesellschaft benannt wurde. Für den Gegenstand dieses Artikels, bedeutet
Tochtergesellschaft eine Gesellschaft, die direkt oder indirekt durch die Gesellschaft geführt wird sowie dieses Konzept
unten in Artikel 12 definiert ist

10.6 Allerdings bezieht sich das Vorzugsrecht nicht auf Aktien, die (i) übertragen werden im Rahmen einer Fusionierung,

Unternehmens-zusammenschluss oder eine andere Kombination bei den Aktionären der Gesellschaft oder (ii) auf Aktien,
die durch Aktionäre der Klasse B übertragen worden sind. Aktionäre der C Klasse dürfen keine Rechte oder Verpflich-
tungen haben unter diesem Artikel 10 oder 9 vor Ablauf der Handelsbeschränkung in Artikel 10.3, gemäß Artikel 11.4

10.7 Wenn ein Ereignis geschieht, daß die Gesellschaft oder die Inhaber des Vorzugsrechts dazu berechtigt, ihr Vor-

zugsrecht auszuüben, um Aktien in der Gesellschaft zu erwerben, die von A oder C Aktionären gehalten sind, muss dieser

146316

L

U X E M B O U R G

Aktionär (der „Verfügende Aktionär"), sobald er von dem auslösendem Ereignis Kenntnis hat, den Verwaltungsrat um-
gehend schriftlich darüber informieren, unter Angabe des Ereignis, das das Vorzugsrecht auslöst und die Anzahl von Aktien
in der Gesellschaft, die diesem Vorzugsrecht unterliegen und durch den Verfügenden Aktionär (die „Angebotenen Akti-
en") gehalten sind.

10.8 Bei Erhalt dieser schriftlichen Mitteilung, beschließt der Verwaltungsrat der Gesellschaft bei einer Mehrheit der

abgegebenen Stimmen, ob die Gesellschaft ihr Vorzugsrecht auf die Angebotenen Aktien ausüben möchte entweder in
eigenem Namen oder im Namen einer Tochtergesellschaft, die durch die Gesellschaft bestimmt wurde. Wenn die Ge-
sellschaft ihr Vorzugsrecht nicht selbst ausüben möchte, muss der Verwaltungsrat, ohne große Verzögerung die Mitteilung
per Einschreiben an die Inhaber des Vorzugsrechts weiterleiten. Das Vorzugsrecht kann nicht später als 30 Tage nach
Erhalt durch die Aktionäre der schriftlichen Mitteilung ausgeübt werden. Falls mehr als ein Inhaber des Vorzugsrechts
sich entscheidet, das Vorzugsrecht geltend zu machen, werden die Angebotenen Aktien unter diesen Aktionären aufgeteilt
im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Aktienbesitz in der Gesellschaft.

10.9 Bei Ausübung des Vorzugsrechts, wird der Kaufpreis der Angebotenen Aktien nicht später als ein Monat nach

dem Tag der Ausübung in bar bezahlt.

10.10 Die Übertragung der Angebotenen Aktien wird vervollständigt und ordnungsgemäß ins Aktienregister einge-

tragen bei Zahlung des Verkaufspreises durch die Gesellschaft, den (ie) empfangendem Aktionär(e)) oder gegebenenfalls
Dritte.

10.11 Wenn weder die Gesellschaft noch der Inhaber des Vorzugsrechts ihr Vorzugsrecht ausüben möchten, werden

die Angebotenen Aktien an eine dritte Partei übertragen, die den Kriterien entsprechen würde sowie sie in Artikel 9
angegeben und für den Verwaltungsrat der Gesellschaft annehmbar wäre. Wenn der Verwaltungsrat es ablehnt, eine dritte
Partei anzunehmen, die den Anforderungen wie in Artikel 9 dargelegt, entspricht, ist der Verfügende Aktionär berechtigt
den Rückkauf seiner Aktien gemäß Artikel 11 zu beantragen. Die Bedingungen einer Übertragung unter Artikel 10.11
dürfen für Dritte nicht günstiger sein als diejenigen,die der Gesellschaft und den Inhabern von Vorzugsrecht, angeboten
werden. Jede Übertragung wird innerhalb von zwei Monaten stattfinden nach Ablauf der erlaubten Frist für die Ausübung
eines Vorzugsrecht, sowie oben unter Artikel 10.8 angegeben und vor Abhaltung einer jährlichen Generalversammlung
der Gesellschaft. Wenn die Aktien nicht in ihrer Gesamtheit oder nur teils vor Ablauf dieses Zeitraums übertragen worden
sind, kann das Vorzugsrecht wieder ausgeübt werden laut den obigen Bestimmungen. Alternativ, kann der Verfügende
Aktionär den Rückkauf durch die Gesellschaft unter Artikel 11 verlangen.

10.12 Der Vorzugspreis wird jedes Jahr bei der jährlichen Generalversammlung der Gesellschaft festgelegt mit der

Methode, die durch die Generalversammlung vom 30. September 2011 gebilligt wurde und wird für das jeweilige Kalen-
derjahr rechtskräftig rückwirkend zum 1. Januar.

11. Rückkauf der Angebotenen Aktien.
11.1 Wenn die Angebotenen Aktien nicht durch die Verfügenden Aktionären erworben worden sind gemäß Ablauf

unter Artikel 10, können die Verfügenden Aktionäre, vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes,
verlangen, daß die Angebotenen Aktien durch die Gesellschaft zurückgekauft werden. Der Antrag für den Rückkauf wird
an den Verwaltungsrat gestellt innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der gestattenen Frist für die Ausübung des Vorzugs-
rechts sowie in Artikel 10.8 vorgesehen. Der Rückkauf wird nur einmal jährlich erfolgen in Verbindung mit der ersten
jährlichen Angleichung. Der Rückkauf erfolgt in Verbindung mit der ersten jährlichen Angleichung (siehe Artikel 14) 30
Tage oder mehr nach Ablauf der gewährten Frist zur Ausübung in den Artikeln 10.8 oder 10.11.

11.2 Der Rückkaufpreis wird jedes Jahr bei der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt, mit der

Methode, die durch die Generalversammlung der Aktionäre am 30. September 2011.

11.3 Wenn der Verfügende Aktionär Aktien in der Gesellschaft hält entgegen den aktuellen Regeln, oder wenn die

Aktien verkauft werden und das Ergebnis einer Entscheidung sind durch eine öffentliche Behörde, oder wenn der Ver-
fügende  Aktionär  gezwungen  ist,  seine  Aktien  zu  verkaufen,  kann  der  Verwaltungsrat  eine  Befreiung  von  der  Regel
gewähren, die vorgibt, daß der Rückkauf im Zusammenhang mit der jährlichen Angleichung unter Artikel 14 stattfinden
muss und kann den Rückkauf bei Empfang der Anfrage (siehe Artikel 11.1) genehmigen. Bei Erteilung der Befreiung durch
den Verwaltungsrat, wird der Rückkaufpreis mit bindender Wirkung durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft fest-
gelegt mit der Methode, die durch die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre am 30. September 2011
angenommen wurde. Der Rückkauf unterliegt den Regeln, die im Luxemburger Gesetz aufgeführt sind.

11.4 Wenn als Folge einer Entscheidung durch eine öffentliche Behörde, ein gezwungener Verkauf oder eine ähnliche

Pflichtverfügung für die Übertragung von C Aktien stattfindet vor Ablauf der Verhandlungs-beschränkung in Artikel 10.3,
müssen die Bestimmungen der Artikel 10 (Vorzugsrecht) und 11 (Rückkauf) angewendet werden, entsprechend den
Änderungen, die durch den Verwaltungsrat als nötig angesehen werden.

12. Call Option.
12.1 Im Falle einer direkten oder indirekten Kontrolländerung (Kontrolle im Sinne eines Aktionärs, (i) das juristische

oder wirtschaftliche Eigentum, direkt oder indirekt, von mehr als 50% der Stimmrechte bezüglich eines Konzerns, von
mehr als 50% der wirtschaftlichen Beteiligung in diesem Konzern oder das Halten dieser Position als Bevollmächtigter
oder einer ähnlichen Funktion, oder (ii) die Befugnis zu verwalten, zu führen oder sonst die Führung und die Operationen
dieses Aktionärs zu leiten, oder die leitenden und führenden Organe dieses Aktionärs zu bestellen oder eine Mehrheit

146317

L

U X E M B O U R G

derer Mitglieder, direkt oder indirekt oder durch den Besitz von stimmberechtigten Wertpapieren, durch Vertrag oder
andernfalls) der Aktionäre der Klasse A oder Aktionäre der Klasse C, wobei eine dritte Partei direkt oder indirekt
Aktionär werde würde der Aktionäre der Klasse A oder C, werden die Gesellschaft oder die Aktionäre der anderen
Klasse A der Gesellschaft oder der anderen Klasse C die Möglichkeit haben, die Aktien der Aktionäre der Klasse A oder
C zu kaufen. Artikel 10 (Vorzugsrecht) gilt auch für Änderungen, die notwendig sind.

13. Verpflichtung zum Rückkauf.

13.1 Wenn die Aktien, die durch einen A Aktionär oder durch einen C Aktionär der Gesellschaft gehalten werden,

dem Artikel 12 (Call Option) unterliegen, ohne daß die Gesellschaft oder die anderen A Aktionäre oder C Aktionäre der
Gesellschaft ihr Kaufoption geltend machen, ist die Gesellschaft verpflichet, die Aktien des A Aktionärs zurückzukaufen
in Zusammenhang mit einer Kapitalminderung, gegebenenfalls zu den Bedingungen vorgeschrieben in Artikel 11.3, zweiter
Satz (Recht auf Rückkauf).

14. Jährliche Angleichung.

14.1 Jedes Jahr bei Genehmigung der Jahreskonten der Gesellschaft durch die jährliche Generalversammlung der Ak-

tionäre, wird der Verwaltungsrat den Beitrag eines jeden A Aktionärs und C Aktionärs festlegen zu den Aktiva unter
Führung der Sparinvest Group als Prozentsatz (jede eine „Aktie von den Aktiva unter Führung) von einer Totalsumme
von Aktiva unter Führung der Sparinvest Group (die „gesamt Aktiva unter Führung") sowie weiter festgelegt und ausge-
rechnet gemäß Artikel 14.3.

14.2 Allerdings nehmen die Aktionäre der Klasse C nicht an der jährlichen Verteilung unter diesem Artikel 14 teil vor

Berechnung, die unmittelbar nach der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre, die 2014 abgehalten wird, erfolgt
Während der Zeit bis zur Genehmigung der Jahreskonten für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2013 endet bei
der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre, die 2014 abgehalten wird, wird der Verwaltungsrat die Aktionäre der
Klasse A in der Berechnung der jährlichen Angleichung nicht berücksichtigen. Bezüglich der Aktionäre, die Aktionäre der
Klasse A sowohl als Aktionäre der Klasse C sind, wird die Inhaberaktie während dieser Zeit berechnet als gesamte Aktie
von Aktiva unter Führung minus die entsprechende Aktie von Aktiva unter Führung des betreffenden Aktionärs von
EgnsINVEST vom 29. Oktober 2010, da die Inhaberaktie die Basis für die Zuteilung der C Aktien an die C Aktionären
gebildet hat bei der Fusionierung zwischen EgnsINVEST Holding (Spar) A/S und der Gesellschaft mit der Gesellschaft als
überbleibende Gesellschaft sowie es bei der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 18. Mai 2011
genehmigt wurde.

14.3 Für den Zweck dieses Artikels 14, muss der Verwaltungsrat jede Aktie von der Aktionärklasse A und der Akti-

onärklasse C der Aktiva unter Führung festlegen als die Summe (a) von Investmentanteilen, die durch Investeringgsfore-
ningen Sparinvest ausgestellt wurden oder durch andere Investmentfonds, die (als Investmentmanager und nicht nur als
Verwalter) von Sparinvest Gruppen geführt werden, wobei jeder A Aktionär oder C Aktionär entweder Depotkonten
für seine Kunden führt oder in eigenem Namen und (b) die eigenen Aktiva unter Führung der A oder C Aktionäre, die
durch (als Investmentmanager und nicht nur als Verwalter) durch die Sparinvest Group geführt werden, wobei diese
Summe als Prozentsatz ausgedrückt wird in Bezug auf die Gesamten Aktiva unter Führung, die als Summe sämtlicher
Aktiva unter Führung für alle A und C Aktionäre gilt.

14.4  Wenn  die  Aktie  von  Aktiva  unter  Führung  der  A  oder  C  Aktionäre  nicht  seiner  angeglichenen  Inhaberaktie

entspricht- berechnet als prozentuale Beteiligung der A oder C Aktionäre in der Gesellschaft in Höhe von 85% des
gesamten Aktienkapitals (Inhaberaktie als Prozentsatz x 100/85) (die "Inhaberaktie")-dann werden die A Aktionäre oder
C Aktionäre den Überschuss an Aktien der Gesellschaft zum Kauf anbieten gemäß den Regeln des Vorzugsrechts oben
in Artikel 10, oder alternativ gemäß den Regeln des Rechts auf Rückkauf in den Artikeln 11.1 -11.3, mit der Ausnahme,
daß der Rückkauf zur gleichen Zeit stattfinden kann als die Angleichung und daß der Rückkaufpreis bei der letzten jähr-
lichen  Generalversammlung  festgelegt  wird  mit  der  vorgeschriebenen  Methode  durch  die  Generalversammlung  der
Aktionäre am 30. September 2011 angenommen wurden. Wenn der betroffene A Aktionär oder C Aktionär den An-
forderungen entspricht, die für die Aktionäre der Gesellschaft gelten (siehe Artikel 9), ist der betroffene A Aktionär oder
C Aktionär dennoch berechtigt mindestens 100 Aktien in der Gesellschaft zu behalten.

14.5 Wenn auf der anderen Seite die Aktie der Aktiva unter Führung die Iinhaberaktie übersteigt, wird der Verwal-

tungsrat,  durch  den  Verkauf  der  eigenen  Aktien  der  Gesellschaft,  dem  A  oder  C  Aktionär  gestatten,  Aktien  in  der
Gesellschaft zu kaufen bis das die Inhaberaktie dem Kapitalanteil entspricht.

14.6 Zur Angleichung unter Artikel 14.4 und 14.5, wird der Aktienpreis der Vorzugspreis sein wie festgelegt bei der

lezten jährlichen Generalversammlung (siehe Artikel 10.12).

15. Dividende.

15.1 Die Aktien gewähren dem Halter das Recht, Dividende zu erhalten.

Dividende werden dem Aktionär auf die im Aktienregister vermerkte Adresse zur Zeit der Zahlung von Dividenden

ausgezahlt.

146318

L

U X E M B O U R G

C. Generalversammlung der Aktionäre

Art. 16. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.
16.1 Die Aktionäre üben ihre gemeinschaftlichen Rechte in der Generalversammlung der Aktionäre aus, die eines der

Gesellschaftsorgane bildet.

16.2 Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, übt dieser Aktionär die Befugnisse der Generalversammlung der

Aktionäre aus. In diesem Fall und soweit anwendbar, wenn der Begriff „alleiniger Aktionär" nicht ausdrücklich in dieser
Satzung erwähnt ist, soll der Verweis auf „die Generalversammlung der Aktionäre", der in diesen Statuten benutzt wird,
als Verweis auf den „alleinigen Aktionär" ausgelegt werden.

16.3 Die Generalversammlung der Aktionäre ist ausgestattet mit den Befugnissen, die ihr laut Gesetz und laut diesen

Statuten ausdrücklich vorbehalten sind.

Art. 17. Ladung der Generalversammlung der Aktionäre.
17.1 Die Generalversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Verwaltungsrat oder durch den Wirtschafts-

prüfer, wenn überhaupt, einberufen werden wobei sie an dem in der Ladung angegebenen Ort und Datum abgehalten
wird.

17.2 Die Generalversammlung muss durch den Verwaltungsrat oder durch den Wirtschaftsprüfer falls gegeben auf

Anfrage schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden, und an den Verwaltungsrat oder an den Rech-
nungskommissar  durch  einen  oder  mehreren  Aktionäre,  die  in  ihrer  Gesamtheit  mindestens  5%  des  ausgegebenen
Aktienkapital der Gesellschaft ausmachen, gerichtet werden.In diesem Fall muss die Generalversammlung der Aktionäre
durch den Verwaltungsrat oder durch den Rechnungskommissar einberufen werden, damit sie innnerhalb einer Frist von
einem (1) Monat nach Erhalt dieser Anfrage an dem in der Ladung angegebenen Ort und Datum abgehalten werden kann.

17.3 Eine jährliche Generalversammlung der Aktionäre muss in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der

Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort in Luxemburg, wie er sich aus der Ladung ergibt, am dritten Dienstag
des Monats April um 11.00 Uhr Ortszeit abgehalten werden. Handelt es sich bei diesem Tag um einen gesetzlichen Feiertag
oder Bankfeiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten. Der Ver-
waltungsrat  oder  der  (ie)  Wirtschaftprüfer,  falls  gegeben,  müssen  die  jährliche  Generalversammlung  der  Aktionäre
innerhalb von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen.

17.4 Die Ladung zu jeder Generalverammlung der Aktionäre muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die

Uhrzeit der Versammlung enthalten und muss entweder zweimal veröffentlicht werden, mit einem Mindestzeitabstand
von acht (8) Tagen und acht Tage vor dem Stattfinden der Generalversammlung der Aktionäre, im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations und in einer luxemburger Zeitung oder ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor
dem für die Versammlung vorgesehenem Datum an jeden Aktionär abzusenden. Falls diese Ladung unter den oben ge-
nannten  Bedingungen  veröffentlicht  wird,  wird  die  Ladung  auch  jedem  Aktionär  mindestens  acht  (8)  Tage  vor  dem
geplanten Datum für die Versammlung weggeschickt.

17.5 Ein oder mehrere Aktionäre, die insgesamt mindestens zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals der

Gesellschaft repräsentieren, können verlangen, dass ein Punkt oder mehrere Punkte der Tagesordnung jeder Hauptver-
sammlung der Aktionäre zugefügt wird/ werden. Dieser Antrag muss mindestens sechs (6) Wochen vor dem für die
Versammlung vorgesehenem Datum per Einschreiben an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft gesendet werden.

17.6 Wenn alle Aktionäre an der Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären,

dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Generalversammlung ohne vorherige
Ladung abgehalten werden.

Art. 18. Abhalten der Generalversammlungen der Aktionäre.
18.1 In jeder Generalversammlung soll es ein Versammlungsbüro geben, bestehend aus einem Vorsitzenden, einem

Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Generalversammlung der Aktionäre bestellt wurde und
welche weder Aktionäre noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen.

Das Versammlungsbüro soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und

speziell im Einklang mit den Regeln über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktio-
nären abgehalten wird.

18.2 Bei jeder Generalversammlung ist eine Anwesenheitsliste der Aktionäre zu führen.
18.3 Quorum
Zur wirksamen Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre ist kein Quorum erforderlich, sofern sich

nicht aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt.

18.4 Wahl
18.4.1 Jede Aktie gibt Anrecht auf eine (1) Stimme gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
18.4.2 Beschlüsse werden in einer ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung der Aktionäre mit einfacher

Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst, sofern sich nicht aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung etwas anderes
ergibt. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden nicht berücksichtigt.

146319

L

U X E M B O U R G

18.4.3 Jeder Beschluss, der die Auflösung oder die Fusionierung oder den Verkauf der Gesellschaft als Ganzes betrifft,

kann nur mit den bejahenden Stimmen von Aktionären, die mindestens zwei Drittel des ausgegebenen Aktienkapitals der
Gesellschaft bilden, angenommen werden, ungeachtet der Bestimmungen von Artikel 67-1 des Gesetzes. Enthaltungen
und nichtige Stimmen werden nicht berücksichtigt.

18.5 Ein Aktionär kann sich auf jeder beliebigen Hauptversammlung der Aktionäre durch eine andere Person, Aktionär

oder nicht, die sich durch ein entsprechendes, schriftliches und unterzeichnetes Dokument ausweisen kann, welches auf
dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder sonst zu übermittelt ist, vertreten lassen. Die Kopie einer solchen
Bevollmächtigung gilt als ausreichender Nachweis. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.

18.6 Jeder Aktionär, der an einer Generalversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder

durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, diesen Aktionär zu identifizieren und welches
es ermöglicht, daß sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und sich effektiv
an der Versammlung beteiligen können, gilt als anwesend für die Zusammensetzung von dem Quorum und der Mehrheit.

18.7  Jeder  Aktionär  kann  bei  einer  Generalversammlung  der  Aktionäre  seine  Stimme  durch  ein  unterzeichnetes

Stimmformular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den einge-
tragenen Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannten Adresse abgeben. Die Aktionäre können nur solche
Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft in der Einberufung oder sonst zur Verfügung gestellt werden und
mindestens den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die
Versammlung sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionär ermöglichen, seine Stimme zu-
gunsten oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden
Kästchen ankreuzt. Die Gesellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Generalversamm-
lung der Aktionäre auf die sie sich beziehen, erhalten hat.

18.8 Aktionäre, die ihre Aktien durch eine Übertragung erworben haben, können ihr Stimmrecht für diese Aktien vor

dem Datum der Ladung zur Generalversammlung ausüben, wenn der Erwerb im Aktienregister der Gesellschaft einge-
tragen worden ist oder wenn der Aktionär die Gesellschaft über den Erwerb informiert hat und unbestreitbares Eigentum
erwiesen hat.

18.9 Der Verwaltungsrat wird alle Bedingungen festlegen, die durch die Aktionäre erfüllt werden müssen, damit sie an

jeder Generalversammlung der Aktionäre teilnehmen können.

Art. 19. Änderung der Satzung. Ungeachtet der Bestimmungen von Artikel 67-1 des Gesetzes, kann diese Satzung nur

abgeändert werden in einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft mit den bejahenden Stimmen der
Aktionäre, die mindestens zwei Drittel des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft bilden. Enthaltungen und nichtige
Stimmen werden nicht berücksichtigt.

Art. 20. Vertagung von Generalversammlungen der Aktionäre. Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen kann

der Verwaltungsrat jede bereits begonnene Generalversammlung der Aktionäre einschließlich jeder zu einer Satzungs-
änderung einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre auf vier (4) Wochen vertagen. Der Verwaltungsrat muss eine
bereits begonnene Generalversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder von mehreren Aktionären
beantragt wird, welche insgesamt mindestens zwanzig Prozent (20 %) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft
repräsentieren. Durch eine solche Vertagung einer bereits begonnenen Hauptversammlung der Aktionäre wird jeder in
dieser Versammlung bereits getroffene Beschluss wieder aufgehoben.

Art. 21. Protokoll der Generalversammlungen der Aktionäre.
21.1 Das Büro der Versammlung nimmt ein Protokoll der Versammlung auf, welches von seinen Mitgliedern sowie

von jedem Aktionär, der es verlangt, unterschrieben wird.

21.2 Der alleinige Aktionär erstellt gegebenenfalls ein unterzeichnetes Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse.
21.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in einem Gerichtsverfahren verwendet werden

oder einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde
aufgenommen wurde, entweder von einem Notar beglaubigt werden oder durch den Verwaltungsratsvorsitzenden, durch
zwei Verwaltungsratsmitglieder oder gegebenenfalls durch den Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 22. Befugnisse des Verwaltungsrates.
22.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsorgan verwaltet genannt „Verwaltungsrat", dessen Mitglieder keine

Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und sich mindestens alle drei Monate zusammentreffen gemäß Artikel 64, Absatz
3 des Gesetzes.

22.2  Wenn  bei  einer  Generalversammlung  der  Aktionäre  erwähnt  wird,  daß  die  Gesellschaft  nur  einen  alleinigen

Aktionär zählt, wird die Gesellschaft durch den alleinigen Geschäftsführer verwaltet, bis zur Generalversammlung der
Aktionäre nachdem die Gesellschaft Kenntnis bekommen hat, daß es mehrere Aktionäre gibt. In diesem Fall und soweit
anwendbar und dort wo der Begriff „alleiniger Aktionär" nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt wird, wird der
Hinweis auf den „Verwaltungsrat" in dieser Satzung als Hinweis auf den „alleinigen Aktionär" ausgelegt.

22.3 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, um alle Verwaltungs und Dispositionshandlun-

gen vorzunehmen im Interesse der Gesellschaft. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch die Council Refugation (EC)

146320

L

U X E M B O U R G

Nr 2157 / 2001 vom 8. Oktober 2001 in der Statutes for a European Company (SE) oder in dieser Satzung der Gene-
ralversammlung vorbehalten sind, liegen in den Befugnissen des Verwaltungsrats.

22.4 Die nachstehenden Bereiche von Transaktionen bedürfen ausdrücklich des Beschlusses des Verwaltungsrats.
- Die Genehmigung der Jahreskonten der Gesellschaft, vorbehaltlich der massgebenden Genehmigung durch die Ge-

neralversammlung der Aktionäre und die Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlungen der Aktionäre;

- Die Entscheidung über den Erwerb und Verfügung über Zweigstellen der Gesellschaft.
22.5 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes wird die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung der

Gesellschaft in Verbindung mit dem Tagesgeschäft, einem Geschäftsführer allein übertragen werden. Der Verwaltungsrat
beschließt durch einen Beschluss seine Bestellung, seine Abberufung sowie seine Befugnisse.

22.6 Die Gesellschaft kann auch bestimmte Befugnisse gewähren durch eine notarielle Vollmacht oder durch ein pri-

vates Dokument einer Person oder gemeinschaftlich mit anderen, als Bevollmächtigter der Gesellschaft.

Art. 23. Zusammensetzung des Verwaltungsrates.
23.1 Der Verwaltungsrat setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern und maximal aus zehn (10) Mitgliedern zusam-

men unter Ausschluss von Angestellten, die gleichzeitig Verwaltungsratsmitglieder sind und gemäß Beteiligungsvereinba-
rung bestellt wurden nach den Regeln von Artikel 3 (3) der EU Richtlinie 2001/86 EF.

23.2 Der Verwaltungsrat sucht aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden des

Verwaltungsrats aus. Er kann auch einen Sekretär ernennen, welcher weder Aktionär noch Mitglied des Verwaltungsrats
sein muss.

23.3 Bei Abwesenheit des Vorsitzenden des Verwaltungsrats, übernimmt der stellvertretende Vorsitzende die Aufga-

ben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

Art. 24. Wahl und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern und Amtszeit.
24.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Generalversammlung der Aktionäre gewählt, welche deren Bezah-

lung und Amtszeit festlegt.

24.2 Wird eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied gewählt, muss diese eine natürliche Person als dauernden

Vertreter benennen, welche diese Rolle im Namen und für Rechnung der juristischen Person ausübt. Juristische Personen
können ihren dauernden Vertreter nur dann abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennen. Eine
natürliche Person kann dauernder Vertreter nur von einem (1) Verwaltungsratsmitglied sein und kann nicht gleichzeitig
Verwaltungsratsmitglied sein.

24.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann fristlos und ohne Grund jederzeit durch die Hauptversammlung der Aktionäre

abberufen werden.

24.4 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds betragt maximal ein (1)Jahr. und jedes Mitglied übt es sein Mandat

bis zur Bestellung seines Nachfolgers weiter aus. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann für weitere Amtszeiten wiederge-
wählt werden.

Art. 25. Verhinderung eines Verwaltungsratsmitglieds.
25.1 Soweit das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds wegen Todes, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Ausscheidens oder

aus einem anderem Grund unbesetzt ist, wird diese unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder vo-
rübergehend besetzt, und zwar bis zur nächsten Generalversammlung" der Aktionäre, in welcher die Aktionäre über eine
dauerhafte geeignete Neubesetzung bestimmen.

25.2 Wenn im Falle von mehreren Aktionären die Gesamtanzahl der Verwaltungsratsmitglieder unter drei (3) fällt,

oder gegebenenfalls unter das höhere durch diese Satzung festgesetzte Minimum so muss diese freie Stelle unverzüglich
entweder durch die Generalversammlung der Aktionäre oder vorübergehend durch die verbleibenden Verwaltungsrats-
mitglieder  besetzt  werden,  und  zwar  bis  zur  nächsten  Generalversammlung  der  Aktionäre,  welche  die  dauerhafte
Bestellung beschliesst.

25.3 Wenn die unbesetzte Stelle das Amt des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft betrifft, muss diese unbe-

setzte Stelle ohne unangemessene Verzögerung durch die Generalversammlung der Aktionäre besetzt werden.

Art. 26. Ladung zu Verwaltungsratssitzungen.
26.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei (2) seiner Mit-

glieder an dem Ort wie in der Ladung zur Sitzung im nächsten Abschnitt beschrieben.

26.2 Die Verwaltungsratsmitglieder müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorge-

sehene Datum per Post, Fax, E-Mail oder durch jedes andere geeignete Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden
ausser im Notfall, wobei die Art und die Gründe der Dringlichkeit in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine solche Ladung
ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen Einverständnisses jedes Verwaltungsratsmitglieds per Post, Fax, E-Mail oder
durch jedes andere geeignete Kommunikationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten Dokuments ausreichend
ist. Eine Ladung zur Verwaltungsratssitzung ist auch nicht erforderlich, wenn sie zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden
soll, der durch einen vorherigen Beschluss durch den Verwaltungsrat gefasst wurde. Eine Ladung ist ferner auch nicht
erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind bei einer Verwaltungsratssitzung, oder
im Falle von schriftlichen Beschlüssen gemäß dieser Satzung.

146321

L

U X E M B O U R G

Art. 27. Verlauf von Verwaltungsratssitzungen.
27.1 Die Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. In seiner Abwesen-

heit  kann  der  Verwaltungsrat  ein  anderes  Verwaltungsratsmitglied  als  vorübergehenden  Vorsitzenden  pro  tempore
bestellen.

27.2 Quorum
Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an

der Sitzung in Luxemburg anwesend ist.

27.3 Wahl
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder bei der Verwaltungsratssitzung gefasst.

Der Vorsitzende wird eine entscheidende Stimme haben.

27.4 Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Vorschriften muss jedes Verwaltungsratsmitglied, das an einer Transaktion,

die dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögenswertes Interesse hat, welches mit
dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und
seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Das betreffende Verwaltungsrats-
mitglied darf weder an der an der Beratung Über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen.
Die nächste Generalversammlung der Aktionäre muss vor Fassen eines jeden Beschlusses, der an der Tagesordnung steht,
über einen solchen Interessenskonflikt informiert werden. Wenn die Gesellschaft ein einziges Verwaltungsratsmitglied
hat und dieses Verwaltungsratsmitglied in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder
indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser
Interessenskonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden.

Art. 28. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen.
28.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Vorsitzende nimmt ein Protokoll über jede

Verwaltungsratssitzung auf, welches vom Vorsitzenden und, gegebenenfalls, vom Sekretär unterzeichnet wird.

28.2 Das alleinige Verwaltungsratsmitglied, gegebenenfalls soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
28.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet oder die

Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sind entweder vom Verwaltungsratsvorsitzenden, von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern oder vom alleinigen Geschäftsführer gegebenenfalls zu unterzeichnen.

Art. 29. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Umständen durch die gemeinsame

Unterschrift von (i) zwei Geschäftsführern oder (ii) die gemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden und des stellvertre-
tenden Vorsitzenden oder (iii) durch die gemeinsame Unterschrift des stellvertretenden Vorsitzenden und des Geschäft-
fuhrers  oder  (iv)  durch  die  alleinige  Unterschrift  von  (einer)  Person  (en),  der  (denen)  die  Befugnis  durch  den
Verwaltungsrat erteilt wurde oder durch den alleinigen Geschäftsführer gebunden sein. Im Rahmen des Tagesgeschäfts
wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Unterschrift eines hierzu bevollmächtigten Geschäftsführers gebunden
oder durch eine Person, der diese Befugnis bezüglich des Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen wurde allein oder
gemeinsam aktierend gemäß den Regeln dieser Bevollmächtigung.

E. Aufsicht

Art. 30. Wirtschaftsprüfer. Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer beaufsichtigt. Der

Wirtschaftprüfer wird inmitten der ,,réviseurs d'entreprises agréés" oder der „cabinets de révision agréés" die durch die
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen wurden, ausgesucht und wird durch die General-
versammlung der Aktionäre bestellt, der ihre Amtszeit festlegt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividende

Art. 31. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am ein-

unddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 32. Gewinne.
32.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung wird eingestellt sobald und solange sich die Gesamtsumme der Rücklage der
Gesellschaft zehn Prozent (10 %) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft beläuft.

32.2 Die durch einen Aktionär an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage

zugeführt werden, wenn der einlegende Aktionär dieser Zuführung zustimmt.

32.3 Im Falle einer Herabsetzung des Aktienkapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft proportional he-

rabgesetzt werden, so dass sie zehn Prozent (10 %) des ausgegebenen Aktienkapitals nicht übersteigt.

32.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Verwaltungsrat beschließt die Generalver-

sammlung der Aktionäre, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und dieser Satzung verwendet werden soll.

Art. 33. Zwischendividenden - Aufgeld.
33.1 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann der Verwaltungsrat Zwischendividende zahlen.

146322

L

U X E M B O U R G

33.2 Das Aufgeld, soweit vorhanden, kann durch Aktionärsbeschluss oder Beschluss des Verwaltungsrats unter Be-

achtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Aktienkapitals und der gesetzlichen Rücklage
frei an den/ die Aktionär(e) ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 34. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Auflösung durch einen oder mehrere Liquidatoren,

natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Generalversammlung der Aktionäre bestellt werden,
die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.

H. Anwendbares Recht

Art. 35. Anwendbares Recht. Die Satzung und ihre Auslegung und Interpretation unterliegen Luxemburger Recht. Alle

in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

Référence de publication: 2011162786/973.
(110187850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2011.

Victoria Real Properties S.C., Société Civile.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg E 4.621.

A la suite de la signature le 24 novembre 2011 de contrats de transfert de parts sociales les associés uniques de Victoria

Real Properties S.C. sont à partir du 24 novembre 2011:

1. M Vittorio Garrone, demeurant Via Chittandrino 57, 15061 Arquata Scrivia, Italie: 99 parts sociales
2. Mme Simona Mazzoleni, demeurant via Carlo Goldoni, 19, Milan, Italie: 1 part sociale.

Luxembourg, le 30 novembre 2011.

Francesca Costantini
<i>Gérante

Référence de publication: 2011167713/14.
(110194086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Island Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.044.178,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 160.907.

In the year two thousand and eleven, on the thirty-first day of October.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Paccor International Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twenty-five million two hundred sixty-nine
thousand fifty-eight Euro (EUR 25.269.058,00), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 161812,

here represented by Ms. Julie Bourgeois, employee, having her professional address at 1B, Heienhaf, L-1736 Sennin-

gerberg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on October 31, 2011.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing in the

Grand Duchy of Luxembourg under the name of “Island Group Holdings S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with re-
gistered  office  at  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160907, established pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing at Luxembourg, dated May 5, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 1729 and dated July 29, 2011, and whose bylaws have been last amended by a deed of Maître
Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg dated May 19, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations under number 1794 on August 5, 2011.

146323

L

U X E M B O U R G

II. The Company’s share capital is set at twenty-two million nine hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR

22.912.500,00) represented by twenty-two million nine hundred twelve thousand five hundred (22.912.500) shares with
a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

III. The sole shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of two million one hundred

thirty-one thousand six hundred seventy-eight Euro (EUR 2.131.678,00) in order to raise it from its present amount of
twenty-two million nine hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 22.912.500,00) to twenty-five million forty-
four thousand one hundred seventy-eight Euro (EUR 25.044.178,00) by creation and issuance of two million one hundred
thirty-one thousand six hundred seventy-eight (2.131.678) shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each
(the New Shares).

<i>Subscription - Payment

Paccor International Holdings S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, resolves to subscribe for the New Shares,

together with a share premium in the amount of ninety-six cents (EUR 0,96), by payment in kind in the total amount of
two million one hundred thirty-one thousand six hundred seventy-eight Euro and ninety-six cents (EUR 2.131.678,96)
consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by Paccor International Holdings S.à r.l., prenamed,
towards the Company, which receivable is incontestable, payable and due.

<i>Evidence of the contribution’s existence and value

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:
- a balance sheet of the Company, dated October 31, 2011;
- a contribution declaration of Paccor International Holdings S.à r.l., prenamed, attesting that it is the unrestricted

owner of the contributed receivable;

- a declaration from the managers of the Company.

<i>Effective implementation of the contribution

Paccor International Holdings S.à r.l., prenamed, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the contributed receivable and possesses the power to dispose of it, it being

legally and conventionally freely transferable;

- the conversion of such receivable is effective as from October 31, 2011, without qualification;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the receivable, in order to duly carry out and

formalize the conversion and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Second resolution

Following to the above, the sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the articles of

association of the Company to be read as follows:

“ Art. 6. The share capital is set at twenty-five million forty-four thousand one hundred seventy-eight Euro (EUR

25.044.178,00) represented by twenty-five million forty-four thousand one hundred seventy-eight (25.044.178) shares
with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.”

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the

above resolutions are estimated at three thousand euro (€ 3,000.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le trente et un octobre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

146324

L

U X E M B O U R G

Paccor International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siege

social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de vingt-cinq
millions deux cent soixante-neuf mille cinquante-huit Euro (EUR 25.269.058,00), enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 161812, ici représentée par Melle Julie Bourgeois, employée, ayant son adresse
professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé le 31 octobre 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie en vertu des lois du Luxembourg sous

la dénomination «Island Group Holdings S.à r.l» (ci-après la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 160907, constituée par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 5 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1729,
en date du 29 juillet 2011, et dont les statuts ont été dernièrement modifiés par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 19 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous
le numéro 1794 daté du 5 août 2011.

II. Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt-deux millions neuf cent douze mille cinq cents Euro (EUR

22.912.500,00) représenté par vingt-deux millions neuf cent douze mille cinq cents (22.912.500) parts sociales d’une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. L’associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions cent trente et un

mille six cent soixante-dix-huit Euro (EUR 2.131.678,00) pour le porter de son montant actuel de vingt-deux millions
neuf cent douze mille cinq cents Euro (EUR 22.912.500,00) à vingt-cinq millions quarante-quatre mille cent soixante-dix-
huit Euro (EUR 25.044.178,00) par l'émission de deux millions cent trente et un mille six cent soixante-dix-huit (2.131.678)
nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,00) chacune (les Nouvelles Parts).

<i>Souscription - Libération

Paccor International Holdings S.à r.l., précitée, par l’intermédiaire de son mandataire, décide de souscrire aux Nouvelles

Parts, ainsi qu’une prime d’émission d’un montant de quatre-vingt-seize centimes (EUR 0,96), par paiement en nature
d’un montant total de deux millions cent trente et un mille six cent soixante-dix-huit Euro et quatre-vingt-seize centimes
(EUR 2.131.678,96) consistant en la conversion d’une créance du même montant détenue par Paccor International Hol-
dings S.à r.l., précitée, envers la Société, laquelle créance est certaine, liquide et exigible.

<i>Preuve de l’existence et valeur de l’apport

Preuve de l’existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:
- un bilan de la Société, en date du 31 octobre 2011;
- une déclaration d’apport de Paccor International Holdings S.à r.l., précitée, certifiant qu’elle est propriétaire sans

restriction des parts sociales apportées;

- une déclaration des gérants de la Société.

<i>Réalisation effective de l’apport

Paccor International Holdings S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare que:
- elle est seule propriétaire sans restriction de la créance apportée et possède les pouvoirs d’en disposer, celle-ci étant

légalement et conventionnellement librement transmissible;

- la conversion de cette créance est effectivement réalisé sans réserve avec effet au 31 octobre 2011;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la créance, aux fins d’effectuer

sa conversion et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

<i>Deuxième résolution

Suite à quoi, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la Société qui est désormais

rédigé comme suit:

“ Art. 6. Le capital social de la Société s’élève à vingt-cinq millions quarante-quatre mille cent soixante-dix-huit Euro

(EUR 25.044.178,00) représenté par vingt-cinq millions quarante-quatre mille cent soixante-dix-huit (25.044.178) parts
sociales d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,00) chacune.”

146325

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à la somme de trois mille euros (€ 3.000,-)

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Bourgeois, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 4 novembre 2011. Relation: EAC/2011/14737. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): T. Thoma.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011153728/147.
(110178883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2011.

Mediobanca International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 112.885.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 5 octobre 2011

Il résulte du procès-verbal que:
Le mandat de Messieurs Massimo DI CARLO, Peter William GERRARD, Luca Tiziano MACCARI, Daniel CARDON,

Stefano PELLEGRINO, Federico POTSIOS, Silvio PERAZZINI et d'Alex SCHMITT en tant qu'administrateur a été re-
nouvelé.

Le mandat de Messieurs Luca Tiziano MACCARI et Peter William GERRARD en tant qu'administrateurs délégués a

été renouvelé.

Les mandats des administrateurs et des administrateurs délégués expireront le 30 juin 2014.

Luxembourg, le 2 novembre 2011.

Pour extrait conforme
Alex Schmitt
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011152314/19.
(110176838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Sandflower Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 164.412.

STATUTS

L'an deux mille onze,
Le vingt-cinq octobre.
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1.- "LINK FINANCING LTD", société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles

Vierges Britanniques), Road Town, PO Box 3152, OMC Chambers, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges
Britanniques, sous le numéro 429370,

ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-

bourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 17 mai 2011.

146326

L

U X E M B O U R G

2.- "FONDO RENTA GARANTIZADO CORPORATION", société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama

(République du Panama), Apartado Postal 0816-02984, Costa del Este, Edificio Capital Plaza, Piso 15, Paseo Roberto
Motta, inscrite au Registre des Sociétés de la République du Panama, sous le numéro 402753,

ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 17 mai 2011.
3.- "VERSEMENT S.A.", société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République du Panama), Apartado

Postal 0816-02984, Costa del Este, Edificio Capital Plaza, Piso 15, Paseo Roberto Motta, inscrite au Registre des Sociétés
de la République du Panama, sous le numéro 402754,

ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 17 mai 2011.
4.- "SANDSTONE INTERNATIONAL CO S.A.", société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (Répu-

blique du Panama), Apartado Postal 0816-02984, Costa del Este, Edificio Capital Plaza, Piso 15, Paseo Roberto Motta,
inscrite au Registre des Sociétés de la République du Panama, sous le numéro 402772,

ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 17 mai 2011.
5.- "BEVLYN COMMERCIAL CORP", société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République du

Panama), Apartado Postal 0816-02984, Costa del Este, Edificio Capital Plaza, Piso 15, Paseo Roberto Motta, inscrite au
Registre des Sociétés de la République du Panama, sous le numéro 402777,

ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 17 mai 2011.
Les procurations, prémentionnées, signées "ne varietur", resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec celui-ci.

Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte des

statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et
l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et
toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d'émission
et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société aura encore pour objet notamment le développement ainsi que l'acquisition de brevets et licences, la gestion

et la mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter,
de même que la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son compte propre. Elle
pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement
en faveur de tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de "SANDFLOWER SARL", société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associées
reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

146327

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

La société s'engage à indemniser tout gérant des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou

procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente de gérant de la société, sauf le cas ou dans
pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Souscription et Libération:

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- "LINK FINANCING LTD", prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.- "FONDO RENTA GARANTIZADO CORPORATION", prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . .

25

3.- "VERSEMENT S.A.", prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4.- "SANDSTONE INTERNATIONAL CO S.A.", prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

5.- "BEVLYN COMMERCIAL CORP", prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille onze.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
"KAPLAS LTD", société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanni-

ques), Road Town, PO Box 3152, OMC Chambers, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques, sous
le numéro 470922,

146328

L

U X E M B O U R G

représentée par Monsieur Juan Francisco CAPELLAS, avocat, né le 8 février 1946 à Sabadell (Espagne), demeurant

professionnellement à CH-1207 Genève, 10, rue du Muzy.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de la gérante.
3.- Le siège social est fixé à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Kirsch, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 octobre 2011. Relation: LAC / 2011 / 48044. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 7 novembre 2011.

Référence de publication: 2011151457/135.
(110176113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2011.

Acacio Promotions SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3593 Dudelange, 149, route de Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 69.407.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2011

1. L'Assemblée nomme comme Administrateurs pour une durée de 6 ans (jusqu'à l'Assemblée Générale que se tiendra

en l'année 2017):

- Monsieur Acacio Moura Da Silva, né à Montalegre, Portugal, le 2 janvier 1961, demeurant à 19 Rue Ribeschpont,

L-3548 Dudelange;

- Monsieur Steve Smaniotto né à Esch sur Alzette le 18 août 1969,
- demeurant à 56 rue de Noertzange L-3315 Bergem;
- Madame Tania Smaniotto, née à Esch-sur-Alzette le 18 juillet 1974, demeurant à 7 Rue Maria Montessori, L-6139

Junglinster.

Le mandat de Monsieur Roland Smaniotto comme administrateur est révoqué.
2. L'Assemblée nomme comme délégué à la gestion journalière pour une durée de 6 ans (jusqu'à l'Assemblée Générale

qui se tiendra en l'année 2017):

- Monsieur Acacio Moura Da Silva, né à Montalegre, Portugal, le 2 janvier 1961, demeurant à 19 rue Ribeschpont,

L-3548 Dudelange.

Le mandat de Monsieur Roland Smaniotto comme délégué à la gestion journalière est révoqué.
3. L'Assemblée nomme comme Commissaire pour une durée de 6 ans (jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra

en l'année 2017):

- Monsieur Roland Kohn, né à Luxembourg le 16 septembre 1951, demeurant à 3 rue de la Forêt, L-3354 Leudelange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2011.

Référence de publication: 2011155334/27.
(110179751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2011.

Auto Factory Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4920 Bascharage, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 163.650.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2011

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à Bascharage en date du 26 septembre

2011 que:

Suite à une cession de parts intervenue sous seing privé, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

RIVE INVESTISSEMENT S.A. RC B 85.527
avec siège social au 2, rue de l’Eau, L-4920 BASCHARAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

100 parts sociales

146329

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011151724/15.
(110176891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Société Financière de Constructions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 29, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 106.530.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, vingt et un octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Nérino BERNARD, né à Beaune (France), le 10 février 1935, demeurant à F21200 Beaune, 32, rue du 16

ème

 Chasseur, ici représenté par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à L-4123 Esch/Alzette, 29, rue du

Fossé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée aux présentes.

Le prédit mandataire, agissant ès-qualités, prie le notaire instrumentant de documenter:
- que son mandant est seul propriétaire de toutes les actions de la société anonyme SOCIETE FINANCIERE DE

CONSTRUCTIONS S.A., avec siège social à L-4123 Esch/Alzette, 29, rue du Fossé

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 106.530
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du

15 février 2005, publié au Mémorial C numéro 662 du 7 juillet 2005,

dont le capital social est de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 100 (cent) actions d’une valeur

nominale de EUR 310,- (trois cent dix euros) chacune,

- que son mandant décide de dissoudre ladite société;
- que tout le passif de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique, son mandant reprend tout l'actif à son compte;
- que son mandant reprend à son compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu'il assume pour autant

que de besoin, la qualité de liquidateur;

- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;
- que décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société;
- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse du siège de ladite

société.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent

acte.

Signé: Tonnar, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 octobre 2011. Relation: EAC/2011/14544. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011153932/39.
(110179140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2011.

Ingersoll-Rand Lux Euro Financing S.àr.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Ingersoll-Rand Faenza Financing S.àr.l.).

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 104.948.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte sous seing privé signé entre les parties en date du 20 octobre 2011 que la société Ingersoll-Rand

European Holding Company B.V., une société de droit Néerlandais, établie et ayant son siège social à 10 Produktieweg,
2382 Zoeterwoude, Pays-Bas, a transféré 150 parts sociales dans la société Ingersoll-Rand Global Holding Company
Limited à la société Ingersoll-Rand LUX Euro Financing S.à r.l., B 104948, une société constituée et existant sous les lois
du Luxembourg, établie et ayant son siège social au 16 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Luxembourg.

Partant la répartition du capital social est comme suit:

146330

L

U X E M B O U R G

Ingersoll-Rand Global Holding Company Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Parts socials

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26.10.2011.

Référence de publication: 2011151948/18.
(110176430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Baie Bleue, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 95.556.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011151726/11.
(110176483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Becatello Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.374.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011151728/9.
(110176879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Selene Patrimoine, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 122.588.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 18 avril 2011

L’assemblée Générale Ordinaire décide:
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler, pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’As-

semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012, les Administrateurs suivants:

* Mr. Marc AMBROISIEN, Administrateur et Président du Conseil d’Administration
* Mr. Guy VERHOUSTRAETEN, Administrateur
* Mr. Peter BRAUNWALDER, Administrateur
* Mr. Paul-Henri DENIEUIL, Administrateur
* Mr. Yves PERBEN, Administrateur
* Mr. Denis BRUGERE, Administrateur
* Mr. Jacques-Henri DAVID, Administrateur
- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises Agréé,

pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

<i>Président du Conseil d’Administration:

- Monsieur Marc AMBROISIEN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

<i>Administrateurs:

- Monsieur Denis BRUGERE, 83, boulevard Haussmann, F-75008 Paris
- Monsieur Jacques-Henri DAVID, 63, boulevard Malesherbes, F-75008 Paris
- Monsieur Yves PERBEN, 29, route de Pré-Bois, CH-1215 Genève
- Monsieur Guy VERHOUSTRAETEN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- Monsieur Paul Henri DENIEUIL, 44, avenue Georges Pompidou, F-92596 Levallois Perret
- Monsieur Peter F. BRAUNWALDER, 26d, Haupstrasse, CH-4437 Waldenburg

146331

L

U X E M B O U R G

<i>Le Réviseur d’Entreprises Agréé est:

Deloitte S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2011.

Référence de publication: 2011154680/34.
(110180142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2011.

aeris CAPITAL Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 128.340.

Im Jahre zweitausendundelf, am zwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft aeris Capital Absolute Return Holding GmbH, mit Sitz in der Churerstrasse 70, CH-8808 Pfäffikon,
hier vertreten durch Julia v. der Osten, Rechtsanwältin, beruflich ansässig Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Voll-

macht, ausgestellt in der Schweiz, am 20. Oktober 2011,

handelnd in ihrer Eigenschaft als alleiniger Aktionär der Aktiengesellschaft „aeris CAPTIAL Management Company

S.A.“, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 128.340, gegründet
gemäss notarieller Urkunde vom 29. Mai 2007, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 1235 vom 22. Juni
2007.

Die erteilte Vollmachte, ordnungsgemäß durch die Erschienene und den Notar unterzeichnet, bleibt diesem Dokument

beigefügt, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die  Erschienene  hat  in  Ausführung  ihrer  Vertretungsbefugnis  den  Notar  gebeten,  die  Satzungsänderung  der  aeris

CAPITAL Management Company S.A. (die Gesellschaft) wie folgt zu beurkunden.

<i>Einziger Beschluss

Der einzige Aktionär der Gesellschaft trifft folgenden Beschluss:
Die Satzung der aeris CAPITAL Management Company S.A. wird abgeändert wie folgt:

“ Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung, Verwaltung und das Management von

Spezialfonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds einschließlich nachfolgender
Änderungen und Ergänzungen («Gesetz von 2007») («Spezialfonds») sowie die Ausführung sämtlicher Tätigkeiten, welche
mit der Auflegung, Verwaltung und dem Management dieser Spezialfonds verbunden sind. Voraussetzung ist, dass die
Gesellschaft als Verwaltungsgesellschaft von zumindest einem Spezialfonds fungiert.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen

Geschäfte betreiben und Maßnahmen ergreifen die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks als sinnvoll oder notwendig
erachtet werden und die sich im Rahmen des geltenden Luxemburger Rechts, insbesondere den Bestimmungen von
Kapitel 16 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich nachfolgender
Änderungen und Ergänzungen («Gesetz von 2010») sowie den Bestimmungen des Gesetzes von 2007 bewegen.

Art. 9. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können

unter den Bedingungen von Artikel 129 Absatz 5 des Gesetzes von 2010 an die in Artikel 60 des Gesetzes von 1915
aufgeführten Personen übertragen werden; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung wer-
den durch den Verwaltungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungsrats-

mitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen und deren Zeichnungsberechtigung regeln. Er setzt
die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Gesellschaft getragen werden.

Art. 23. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxemburgischen gesetzlichen

Bestimmungen, insbesondere das Gesetz von 1915 sowie das Gesetz von 2010.“

Die übrigen Artikel der Satzung bleiben unberührt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Vorlesung  und  Erklärung  alles  Vorstehenden  an  die  Erschienene,  hat  dieselbe  mit  dem  Notar  gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. V. DER OSTEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2011. Relation: LAC/2011/47711. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

146332

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 9. November 2011.

Référence de publication: 2011152349/52.
(110177559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2011.

Becton Dickinson Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.808.245,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 163.006.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2011.

Référence de publication: 2011151730/11.
(110176469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Becton Dickinson Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.016.676,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 163.006.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Référence de publication: 2011151732/11.
(110176883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Berkeley Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 151.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Berkeley Investments S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011151733/11.
(110176481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Gate Gourmet Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.946.100,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 86.447.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 15 juillet 2011

En date du 15 juillet 2011, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de renouveler le mandat de Monsieur Guy HARLES en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à

la prochaine assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Guy HARLES
- Monsieur Michel RAFFOUL
- Monsieur Thomas BUCHER
- Monsieur Andrew GIBSON
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

146333

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 7 novembre 2011.

Gate Gourmet Luxembourg III S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011152551/21.
(110177901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2011.

BestCaseScenario Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4289 Esch-sur-Alzette, 25, rue de Quartier.

R.C.S. Luxembourg B 125.491.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011151734/10.
(110177210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Bevis Marks 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.640.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2011.

Référence de publication: 2011151736/10.
(110176615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Binah S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 162.598.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 8 novembre 2011.

Référence de publication: 2011151737/10.
(110176996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Düsseldorf/Wilmersdorfer Arcaden, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.142.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société prises le 8 novembre 2011

L'associé unique de la Société a pris acte des démissions de MM. Kuy Ly Ang et Pierre Lalonde de leurs fonctions

respectives de gérants de la Société à compter du 8 novembre 2011. En remplacement, l'associé unique a décidé de
nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société à compter du 8 novembre 2011 et pour une durée
illimitée:

(i) Mme Xenia Kotoula, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg;
(ii) Mme Rita-Rose Gagné, avocate, résidant à 715 Upper Roslyn, Westmount, QC H3Y 1J2, Canada; et
(iii) M. Jorge Pérez Lozano, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société sera désormais composé des membres suivants:
- Mme Jacqueline Kost;
- Mme Xenia Kotoula;
- Mme Rita-Rose Gagné; et
- M. Jorge Pérez Lozano.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

146334

L

U X E M B O U R G

Düsseldorf/Wilmersdorfer Arcaden S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011154359/24.
(110180052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2011.

Bankinter International Fund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 48.178.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 et la distribution de dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire

du 16 mai 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2011.

Nathalie SCHROEDER / Géraldine DISEUR
<i>Mandataire Commercial / Mandataire Principal

Référence de publication: 2011151743/13.
(110176881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

BELFOR Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 119.529.

Par résolutions signées en date du 27 septembre 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de Xavier Pauwels, avec adresse au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son

mandat de gérant de classe B, avec effet au 13 septembre 2011

2. nomination de Manfred Schneider, avec adresse au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant

de classe B, avec effet au 13 septembre 2011 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Référence de publication: 2011151746/15.
(110177061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Decofin S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-8478 Eischen, 25, rue de Waltzing.

R.C.S. Luxembourg B 105.909.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie de manière extraordinaire en date du 20 juillet

<i>2010

L’an deux mille dix, le vingt juillet, les actionnaires de la société DECOFIN S.A. se sont réunis en assemblée générale

ordinaire, tenue de manière extraordinaire, au siège social et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) L’Assemblée, constatant que les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance, décide de les renouveler pour

une nouvelle période de 6 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Sont donc réélus administrateurs:
- Monsieur Robert De Coster, demeurant à B-5190 Onoz, 8, «La Clairière»,
- Monsieur Christian De Coster, demeurant à L-8478 Eischen, 25, rue de Waltzing,
- Monsieur Florent De Coster, demeurant à B-5101 Erpent, 8, Clos de la Verveine,
- Monsieur Arnaud De Coster, demeurant à B-5000 Namur, 19A, rue Baron Fallon.
Les mandats des administrateurs-délégués, Messieurs Robert De Coster et Christian De Coster, susvisés, sont éga-

lement renouvelés pour la période décrite ci-dessus.

2) L’Assemblée, constatant que le mandat du commissaire aux comptes est arrivé à échéance, décide de le renouveler

pour une nouvelle période de 6 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Est donc réélu commissaire aux comptes:
Monsieur Marc Schwarzbaum, demeurant à avenue de Biolley, 77, B-1150 Bruxelles

146335

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011153039/26.
(110178659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2011.

Provimentum I S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 132.869.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 25 octobre 2011 à Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 25 octobre 2011,

que:

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jérôme Wunsch de son mandat d'Administrateur avec effet

immédiat. Elle décide d'accepter sa démission et de nommer en son remplacement Monsieur François Georges, expert-
comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte en qualité d'Administrateur et d'Administrateur-délégué de la Société jusqu'à l'issue de l'as-
semblée générale statutaire de 2015.

2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur François Georges de son mandat de Commissaire aux comptes

avec effet immédiat. Elle décide d'accepter sa démission et de nommer en son remplacement la société à responsabilité
VERIDICE Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 154843 jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2015.

3. L'assemblée prend acte du changement d'adresse professionnelle de Monsieur François Georges de L-1330 Lu-

xembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.

4. L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-

Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2011.

PROVIMENTUM I S.A.

Référence de publication: 2011154606/28.
(110180261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2011.

Tasselot S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 78.664.

In the year two thousand and eleven, on the tenth of October.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "TASSELOT S.A.", a société anonyme having its

registered office in L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, incorporated by a deed of Maître Gérard LECUIT, notary then
residing in Hesperange, dated October 13 

th

 , 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

number 344 of May, 11 

th

 , 2001. The Articles of Association have been amended for the last time pursuant to a deed of

the undersigned notary dated September 16 

th

 , 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

number 2068 of October 21 

st

 , 2009.

The meeting is presided by Mrs Germaine SCHWACHTGEN, private employee, residing professionally in L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

who appoints as secretary Mrs Corinne PETIT, private employee, residing professionally at the same address.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond THILL, maître en droit, residing professionally at the same address.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed “ne varietur” by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The
said list as well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that 1,224 out of 1,849 shares are represented (66,19% of the share capital).

The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the
meeting, of which the shareholders have been informed before the meeting.

146336

L

U X E M B O U R G

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer of the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg and subsequent amendment of Article 1 of the bylaws;

2. Acknowledgement of the transfer of the professional address of Mr. Robert Brimeyer, Director of the Company,

from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg with effect as of August 1 

st

 ,

2011;

3. Acknowledgement of the transfer of the professional address of Mr. Christophe DAVEZAC, Director of the Com-

pany,  from  1B,  Heienhaff,  L-1736  Senningerberg,  to  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882  Luxembourg  with  effect  as  of
September 1 

st

 , 2011;

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and to subsequently amend Article 1, second paragraph of the bylaws, which
will henceforth have the following wording:

“ Art. 1. Second paragraph. The registered office of the Corporation is established in the municipality of Luxembourg-

City.”

<i>Second resolution

The meeting resolves to acknowledge the transfer of the professional address of Mr. Robert Brimeyer, Director of

the Company, from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg with effect as
of August 1 

st

 , 2011.

The meeting resolves to acknowledge the transfer of the professional address of Mr. Christophe DAVEZAC, Director

of the Company, from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg with effect
as of September 1 

st

 , 2011.

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original
deed.

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille onze, le dix octobre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «TASSELOT S.A.», avec siège

social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, alors notaire
de résidence à Hesperange en date du 13 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 344 du 11 mai 2001, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire
en date du 16 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2068 du 21 octobre
2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Germaine SCHWACHTGEN, employée privée, demeurant

professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

qui désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à la même

adresse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à

la même adresse.

Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste

146337

L

U X E M B O U R G

de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu’il ressort de la liste de présence que 1.224 actions sur 1.849 actions sont représentées (soit 66,19% du capital

social). L’assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les point portés
à l’ordre du jour précité, duquel les actionnaires reconnaissent avoir eu connaissance et qui leur a été communiqué au
préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société de 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, et modification subséquente de l’article 1 

er

 des Statuts de la Société;

2. Constatation du transfert de l’adresse professionnelle de Monsieur Robert BRIMEYER, administrateur de société,

de 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 1 

er

 août 2011;

3. Constatation du transfert de l’adresse professionnelle de Monsieur Christophe DAVEZAC, administrateur de so-

ciété , de 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre

2011;

4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de 1B, Heienhaff, L1736 Senningerberg au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg et de modifier en conséquence le deuxième paragraphe de l’article 1 

er

 des Statuts de la Société

qui aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Deuxième paragraphe.  Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.».

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de constater le transfert de l’adresse professionnelle de Monsieur Robert BRIMEYER, administra-

teur de société, de 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 1

er

 août 2011.

L’assemblée décide de constater le transfert de l’adresse professionnelle de Monsieur Christophe DAVEZAC, admi-

nistrateur de société, de 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au

er

 septembre 2011.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Schwachtgen, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 octobre 2011. Relation: LAC/2011/45539. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75..

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Référence de publication: 2011151493/121.
(110176024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2011.

Bergame Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.797.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

146338

L

U X E M B O U R G

BERGAME CAPITAL S.à r.l.
S. BOUREKBA / M. LIMPENS
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011151747/12.
(110176396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

CEOP S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 128.122.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les associés en date du 10 novembre 2011 que la personne suivante a démissionné,

avec effet au 10 novembre 2011, de sa fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Otis Spencer, né le 14 juillet 1965 à Yokosuka, Japon, ayant son adresse professionnelle au 14, Al Armii

Ludowej, 00-638 Warsovie.

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet immédiat et pour une

durée illimitée à la fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Piotr Andrzejewski, né le 31 août 1978 à Sokolka, Pologne, ayant son adresse professionnelle au 26B,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Depuis le 10 novembre 2011, le Conseil de Gérance se compose comme suit:
- Monsieur Piotr Andrzejewski, prénommé,
- Monsieur Karol Maziukiewicz,
- Monsieur Gordon Black.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 14 novembre 2011.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2011154320/29.
(110179807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2011.

Boutique Richy, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 16.812.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011151752/10.
(110176858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Breva S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 134.783.

Il ressort du P.-V. de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en le 4 novembre 2011 que les mandats

des administrateurs:

- Romain ZIMMER
- Alhard von KETELHODT
- Régis LUX
ont été confirmés - respectivement renouvelés - pour une période de 6 années.

146339

L

U X E M B O U R G

De même, le mandat de commissaire aux comptes confié à la société EUROPEAN AUDIT a été reconduit pour la

même période.

Monsieur Alhard von KETELHOT est confirmé dans ses fonctions de Président du Conseil d’Administration.
Référence de publication: 2011151753/16.
(110177112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Event Concept Consulting Ltd, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9650 Esch-sur-Sûre, 7, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 164.549.

OUVERTURE DE SUCCURSALE

En ce jour, le 17 octobre 2011, il a été décidé d'ouvrir une succursale de la société Anglaise EVENT CONCEPT

CONSULTING LTD au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans ce but, nous vous précisons les points suivants:
a) Adresse de la succursale:
7, rue de l'Eglise
L-9650 ESCH-SUR-SÛRE
LUXEMBOURG
b) Activités de la succursale: la succursale a comme principale activité: commercialisation de stand d'exposition et

agencement de salon professionnel, congrès et événementiel au Bénélux,

c) Registre: The Registrar of Companies of England and Wales / Royaume-Uni N°7675780
d) Dénomination et forme de la société: EVENT CONCEPT CONSULTING LTD.
Il s'agit d'une Limited Company.
e) Nomination et l'identité de la personne qui a le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers de la représenter en

justice.

Il s'agit de Monsieur Olivier CASTEL
- En tant que gérant de la société avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature et
-  En  tant  que  représentant  permanent  unique  de  la  succursale,  avec  pouvoir  d'engager  la  succursale  par  sa  seule

signature.

Olivier CASTEL
<i>Le gérant

Référence de publication: 2011155355/28.
(110179914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2011.

Coolcoups, Société Anonyme.

Siège social: L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois.

R.C.S. Luxembourg B 154.250.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2011.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2011151801/14.
(110176478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Bullstrode Continental S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 18.496.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

146340

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011151754/10.
(110176585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Bullstrode Continental S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 18.496.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011151755/10.
(110176586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

C.F. Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 111.701.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011151757/9.
(110177153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

WSB Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 141.417.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 octobre 2011

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 octobre 2011, que:
1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Frank Wegner de son mandat d'Administrateur avec effet

immédiat. Elle décide de nommer Monsieur Alvaro Carnevale, employé privé, né le 4 juillet 1964 à Metz (France), de-
meurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte en qualité d'Adminis-
trateurs de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Alexander Mayer-Groth de son mandat d'Administrateur avec

effet immédiat. Elle décide de nommer Monsieur Guillaume Le Bouar, employé privé, né le 2 novembre 1971 à Brignoles
(France), demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte en qualité
d'Administrateurs de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

3. L'assemblée prend acte du changement d'adresse professionnelle de Monsieur François Georges de L-1330 Lu-

xembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.

4. L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-

Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2011.

WSB HOLDING S.A.

Référence de publication: 2011153421/25.
(110178074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2011.

Ceram Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 60.662.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011151785/9.
(110176914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

146341

L

U X E M B O U R G

Global IT Services PSF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Global IT Services S.à r.l.).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 111.729.

L'an deux mille onze, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Global IT Services

S.à r.l. (ci-après la "Société") avec siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg
numéro B 111729, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 30 septembre 2005, publié au Mémorial C numéro 325 du 14 février 2006.

L'assemblée est présidée par Madame Christina SCHMIT-VALENT, employée privée, demeurant professionnellement

à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La  présidente  désigne  comme  secrétaire  Monsieur  Bob  PLEIN,  employé  privé,  demeurant  professionnellement  à

L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que les associés présents ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les associés présents et les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social de quinze mille euros (EUR 15.000,-), divisé

en cent (100) parts sociales de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune, est représentée.

III.- Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l'ordre du jour.

IV.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l'objet social (article 2 des statuts) pour devenir "opérateur de systèmes informatiques primaires

du secteur financier" selon l'article 29-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

2.- Modification de la dénomination (article 4 des statuts) pour devenir Global IT Services PSF, S.à r.l..
3.- Réduction de la valeur nominale des parts sociales.
4.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 355.000,-, en vue de le porter de son montant actuel de EUR

15.000,- à EUR 370.000,-, avec création de 3.550 parts sociales nouvelles avec une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

5.- Souscription et libération des parts sociales nouvelles.
6.- Modification afférente du 1 

er

 alinéa de l'article 6 des statuts.

7.- Nomination statutaire.
8.- Nomination d'un réviseur d'entreprises agréé.
9.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière après délibération a pris à l'unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et en conséquence l'article deux des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet l'étude et la réalisation de projets informatiques, au profit d'entreprises et adminis-

trations publiques, ainsi que la commercialisation, la distribution, la vente et la consultance en matière de gestion, services
informatiques, sécurité de l'infrastructure informatique, technologie informatique, software et hardware.

La Société a pour objet la prise en charge du fonctionnement de systèmes informatiques permettant l'établissement

des  situations  comptables  et  des  états  financiers  faisant  partie  du  dispositif  informatique  propre  d'établissements  de
crédits, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d'assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou
de droit étranger suivant l'article 29-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

La société a encore pour objet la prise en charge du fonctionnement de systèmes informatiques autres que ceux

permettant l'établissement des situations comptables et des états financiers et de réseaux de communication faisant partie
du dispositif informatique et de communication propre d'établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entre-

146342

L

U X E M B O U R G

prises d'assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger suivant l'article 29-4 de
la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

La société est également habilitée à effectuer la mise en place et la maintenance des systèmes informatique visée aux

alinéas 2 et 3.

La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en Global IT Services PSF, S.à r.l. et en conséquence

l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Art. 4. La Société aura la dénomination: Global IT Services PSF, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la valeur nominale des parts sociales pour la réduire de son montant actuel de cent

cinquante euros (EUR 150,-) à cent euros (EUR 100,-) par part sociale en augmentant le nombre des parts sociales de
cent (100) à cent cinquante (150).

Le capital social s'élève donc à quinze mille euros (EUR 15.000,-), divisé en cent cinquante (150) parts sociales de cent

euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de trois cent cinquante-cinq mille euros

(EUR 355.000,-), pour le porter de son montant actuel de quinze mille euros (EUR 15.000,-) à trois cent soixante-dix
mille euros (EUR 370.000,-), par la création de trois mille cinq cent cinquante (3.550) parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée constate que les trois mille cinq cent cinquante (3.550) parts sociales nouvellement émises ont été sou-

scrites par l'associé unique la société anonyme NORAM INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg numéro B 159.714.

Le montant de trois cent cinquante-cinq mille euros (EUR 355.000,-) a été apporté en numéraire par le prédit sou-

scripteur de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société à responsabilité limitée
Global IT Services S.à r.l. ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Sixième résolution

Suite à l'augmentation de capital réalisée, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

 Art. 6. (alinéa 1 

er

 ).  Le capital social est fixé à trois cent soixante-dix mille euros (EUR 370.000,-) représenté par

trois mille sept cents (3.700) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune."

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de nommer comme gérant additionnel:
Monsieur Thierry MAROTEN, né à Bruxelles, Belgique, le 17 mai 1967, demeurant à B-6856 Fays-les-Veneurs, 9, rue

du Faubourg (Belgique).

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale de l'an 2012.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer à la fonction de réviseur d'entreprises agréé de la société, son mandat expirant le 15

septembre 2012:

La société anonyme DELOITTE S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, R.C.S. Lu-

xembourg numéro B 67895.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille huit cent cinquante

euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Christina SCHMIT-VALENT, Bob PLEIN, Alain THILL, Jean SECKLER.

146343

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2011. Relation GRE/2011/3774. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 novembre 2011.

Référence de publication: 2011151907/110.
(110176866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

C.A.P., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 97.287.

L'an deux mille onze, le vingt octobre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «C.A.P.», ayant son siège social

à L-4830 Rodange, 4, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 97.287, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en
date du 18 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1376 du 30 décembre
2003, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence
à Niederanven, en date du 27 novembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 343
du 9 mars 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Brankart, demeurant à Rue A. de Lexhy, 41,

B-4101 Jemeppe.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, demeurant professionnellement à L-1319 Luxem-

bourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg,

101, rue Cents.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l'assemblée  cette  dernière  a  pris  à  l'unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Jean-Claude Brankart, né à Ougrée (Belgique), le 16 février 1950, demeurant à Rue A. de Lexhy, 41, B-4101

Jemeppe.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

146344

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la dite société

actuellement en fonction pour l'exécution de leurs mandats.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.-C. BRANKART, S. WOLTER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 octobre 2011. Relation: LAC/2011/46715. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2011.

Référence de publication: 2011151756/64.
(110176943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

John Taylor Corporate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 147.150.

Lors de l’assemblée générale tenue en date du 8 novembre 2011, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
Acceptation de la démission de TMF CORPORATE SERVICES S.A., avec siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, représentée par Mr. Paul van Baarle, de son mandat d’administrateur de la société avec effet immédiat.

Nomination de Monsieur Jorge Pérez Lozano, avec adresse professionnelle au 1, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg,

en tant qu’administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2011.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2011151974/18.
(110176766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Finplays Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 127.084.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Maître Martine Schaeffer, de résidence à Luxembourg,

en date du 28 octobre 2011, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 03 novembre 2011, LAC/2011/48791, aux droits
de soixante-quinze euro (75,- EUR), que la société "FINPLAYS INVESTMENTS S.A."(en liquidation), RCS Luxembourg
Numéro B 127.084, ayant son siège social à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, constituée en date du 2 avril 2007 par
acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1175 du 15 juin 2007.

La Société a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les documents et les livres de la Société seront conservés pour une période de cinq ans à partir du jour de la liquidation

auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Référence de publication: 2011151889/20.
(110176836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

146345

L

U X E M B O U R G

Hydrostatic Motors International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 164.387.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, den dreizehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Fernand UNSEN, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.

Sind erschienen:

1. Die anonyme Holding Gesellschaft " SWISS-LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H.". mit Sitz in L-6450 Echternach,

21, route de Luxembourg, gegründet gemäss Akt Paul Bettingen am 14. November 1988, ausgewiesen im Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 18 vom 23. Januar 1989, RCS Nummer B96272,

hier vertreten durch Herrn Hermann-Josef LENZ, Vorsitzender des Verwaltungsrates, wohnhaft in B-4780 St. Vith,

Hinderhausen, 82.

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "EUROTAX, Euro Financial Control and Tax Consult S.à r.l.", mit Sitz in

L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg, eingeschrieben im RCS unter der Nummer B95951,

hier vertreten durch Herrn Hermann-Josef LENZ, Geschäftsführer, vorgenannt.
Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer

Aktiengesellschaft zu beurkunden:

Kapitel I. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer.

Art. 1. Unter der Bezeichnung "Hydrostatic Motors International S.A". wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Durch  Beschluss  des  Verwaltungsrates  können  Niederlassungen,  Zweigstellen,  Agenturen  und  Büros  sowohl  im

Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche
Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend
und  bis  zur  vollständigen  Wiederherstellung  normaler  Verhältnisse  ins  Ausland  verlegt  werden.  Diese  einstweilige
Maßnahme  betrifft  jedoch  in  keiner  Weise  die  Nationalität  der  Gesellschaft,  die  unabhängig  von  dieser  einstweiligen
Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Anlagen zur Herstellung von Strom über Wasserkraft und

die Verwertung von Patenten, Marken- und Warenrechten.

Die Gesellschaft kann sämtliche Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck in Zu-

sammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreißigtausend (31 000) Euro, eingeteilt in sechshundertz-

wanzig (620) Aktien zu je fünfzig (50) Euro.

Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei

oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Kapitel III. Verwaltung, Übertragung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei (3) Mitgliedern, welche Ak-

tionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch
die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den

Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Wenn die Gesellschaft durch einen Aktionär gegründet wird, oder falls durch Hauptversammlung festgestellt wird,

dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet

146346

L

U X E M B O U R G

werden, der "einziger Verwalter" genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche das Vorhan-
densein von mehr als einem Aktionär feststellt.

Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter, solange die

Gesellschaft einen einzigen Verwalter hat. Wenn eine juristische Person Verwalter oder Mitglied des Verwaltungsrates
der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäß Artikel 51
bis des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vertritt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt

wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Auf-
gaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stim-
me auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefaßter Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt
und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Beschluß.

Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.

Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck

zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungs-handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-

versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 11. Falls die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, wird die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen durch die alleinige

Unterschrift des einzigen Verwalters rechtsgültig verpflichtet. Falls die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, dann ist
zur Verpflichtung der Gesellschaft Dritten gegenüber und unter allen Umständen die Unterschrift des delegierten Ver-
waltungsratsmitgliedes obligatorisch und unumgänglich.

Das delegierte Verwaltungsratsmitglied kann alle Tätigkeiten ausüben, die unter Artikel 4 als Gegenstand der Gesell-

schaft  beschrieben  wurden,  gemäss  den  durch  das  Mittelstandsministerium  berücksichtigten  Kriterien.  Somit  ist  die
Gesellschaft Dritten gegenüber verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes
oder durch dessen Unterschrift und der Unterschrift einer der beiden anderen Verwalter.

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung gefassten Bes-

chlüsse.

Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der
Generalversammlung festgelegt, sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Kapitel V. Generalversammlung.

Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes.

Sollten  die  Aktionäre  nicht  bekannt  sein,  erfolgt  die  Einberufung  durch  Veröffentlichung  im  Memorial  und  in  den

geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt am ersten Montag des Monats Mai, um zehn Uhr vormittags,

im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-

ben.

Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung ein-

berufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes.

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft

146347

L

U X E M B O U R G

und endet am 31. Dezember 2012. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der
Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Ge-
schäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft

dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5 %) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist
nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit Zustimmung
des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden
ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitalbildung zu benu-

tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Kapitel VII. Auflösung, Liquidation.

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher

unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß, wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Kapitel VIII. Allgemeines.

Art. 20. Der unterzeichnete Notar bescheinigt dass die Bedingungen des Artikles 26 des Gesetzes von 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften erfüllt sind

<i>Zeichnung der Aktien.

Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, daß das gesamte Kapital wie folgt

gezeichnet wurde:

Die anonyme Holding Gesellschaft "SWISS-LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H.", vorgenannt
sechshundertneunzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "EUROTAX, Euro Financial Control and Tax Consult S.ä r.l.",
vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: sechshundertzwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100 %) in bar einbezahlt, sodass der Gesellschaft ab heute die Summe

von einunddreissigtausend (31.000) Euro zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

Gemäß dem Gesetz vom 11. August 1998, erklären die Parteien ausdrücklich, daß sie die wirklichen Nutzniesser der

gegenwärtigen Operation sind und die Gelder, Güter und Rechte weder vom Drogenhandel noch von einer der Straftaten
welche im Artikel 506-1 des luxemburgischen Strafgesetzbuches vorgesehen sind herrühren.

<i>Feststellung.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungs-

gesetze, finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Kosten.

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft

im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr tausendfünfhundert (1 500)
Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung.

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei (3); diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf

einen (1).

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden für die Dauer von sechs Jahren ernannt:
- Herr Gerhard RIEDER, Privatbeamter, geboren am 11. Mai 1953 in Bellheim (Deutschland), Matrikelnummmer 1953

05 11 556, wohnhaft in L-6793 Grevenmacher, 17, route de Trèves

- Dame Christa SCHUMACHER, Privatbeamtin, geboren am 12. Mai 1951 in Recklinghausen (Deutschland), Matrikel

N° 1951 05 12 483, wohnhaft in L-6793 Grevenmacher, 17, route de Trèves

- Die Aktiengesellschaft Lux-Stahl A.G., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves, ausgewiesen im Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 940 vom 9. Dezember 1999, RCS Nummer B78042,

hier vertreten durch ihren Verwaltungsratsvoritzenden Herrn Gerhard Rieder, vorgenannt.
3. Die Generalversammlung bestimmt zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren:

146348

L

U X E M B O U R G

Herr Gerhard RIEDER, vorgenannt
4. Die Generalversammlung bestimmt, daß die Gesellschaft vertreten wird, durch die alleinige Unterschrift des Vor-

sitzenden des Verwaltungsrates, ohne finanzielle Beschränkung.

5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
Herr Hermann-Josef LENZ, Privatbeamter, geboren am 16. Mai 1955 in Winterspelt-Eigelscheid, Matrikel N° 1955 05

16 597, (Deutschland), wohnhaft in B-4784 St. Vith (Belgien), Hinderhausen, 82.

6. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Lenz, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 14 octobre 2011. Relation: DIE/2011 / 9914. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt.

Diekirch, den 20. Oktober 2011.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2011151556/178.
(110175378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2011.

Caducée Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 149.479.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011151760/10.
(110176865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

CarVal Investors GVF Luxembourg Twenty S. à r.l, Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 2.500.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 132.067.

Par résolutions signées en date du 18 octobre 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de Patrick Lsurger, avec adresse au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1258 Luxembourg

de son mandat de gérant, avec effet au 31 août 2011

2. nomination de René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Référence de publication: 2011151762/15.
(110177097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Chartreuse et Mont Blanc GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 142.634.

Par résolutions signées en date du 26 septembre 2011, l'associé unique a décidé de nommer Oliver James Bradley,

avec adresse au 28, Ropemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Royaume-Uni, au mandat de Gérant, avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Référence de publication: 2011151766/13.
(110176648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

146349

L

U X E M B O U R G

Foncier &amp; Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 5.322.

<i>Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 30 juin 2011

réélit Administrateurs pour un an:
M. Gaston SCHWERTZER, docteur en droit, Medingen,
M. Jacquot SCHWERTZER, maître en sciences économiques, Schrassig,
M. Marc SCHWERTZER, commerçant, Reckange/Mess,
réélit Commissaire pour un an:
La société DMS &amp; ASSOCIES, S.à.r.l., à L - 1274 HOWALD, 23, rue des Bruyères.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue immédiatement après l'assemblée générale

Le Conseil d'Administration réélit pour un an M. Gaston SCHWERTZER Président, nomme pour un an M. Jacquot

SCHWERTZER Administrateur-délégué, nomme pour un an Mme Valérie WEBER Fondé de pouvoirs, et fixe les pouvoirs
comme suit:

a) la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du Président ou par la seule signature de

l'Administrateur-délégué ou par les signatures conjointes de trois Administrateurs, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis
des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

b) pour la gestion journalière des affaires, la société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 15.000,00 €

par la seule signature du fondé de pouvoirs.

Pour extraits conformes
Jacquot SCHWERTZER
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2011153091/26.
(110178750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2011.

CaCh, Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 8, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 56.170.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011151764/10.
(110177206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Climate Change Capital Carbon Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.587.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011151769/10.
(110176627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Vinum Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 67.333.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011155437/10.
(110180309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2011.

146350

L

U X E M B O U R G

Chartreuse et Mont Blanc Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.935.452,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 142.635.

Par résolutions signées en date du 26 septembre 2011, l'associé unique a décidé de nommer Oliver James Bradley,

avec adresse au 28, Ropemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Royaume-Uni, au mandat de Gérant, avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Référence de publication: 2011151767/13.
(110176647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

KPMG Pension Scheme, Sepcav, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 80.358.

<i>Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2009

1. Sont nommés administrateur pour la durée de un an:
- Monsieur John LI, né le 27 septembre 1960 à l'Ile Maurice, ayant son adresse professionnelle au 9, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg;

- Monsieur Patrice PERICHON, né le 1 

er

 février 1962 à Paris (France), ayant son adresse professionnelle au 9, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg;

- Madame Chrystelle VEECKMANS, née le 26 juillet 1971 en Belgique, ayant son adresse professionnelle au 9, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg.

2. L'assemblée générale prend note que:
- Monsieur Thomas FELD, né le 25 décembre 1961 à Landsweiler (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au

9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé par le Conseil de Gérance de KPMG Audit S.à r.l., avec effet au 3
avril 2009, administrateur de KPMG Pension Scheme, SEPCAV pour représenter KPMG Audit S.à r.l. au Conseil d'Ad-
ministration de KPMG Pension Scheme, SEPCAV, pour une durée de six ans;

- Monsieur Carlo JENTGEN, né le 10 mars 1954 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 9, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, a été nommé par le Conseil de Gérance de KPMG S.à r.l., avec effet au 3 avril 2009, administrateur
de KPMG Pension Scheme, SEPCAV pour représenter KPMG S.à r.l. au Conseil d'Administration de KPMG Pension
Scheme, SEPCAV, pour une durée de six ans.

3. La démission de Madame Corinne NICOLET de ses fonctions d'administrateur avec effet au 3 avril 2009 est acceptée.
4. La société INTERAUDIT S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie à L-1511 Luxembourg, est nommée réviseur d'entre-

prises chargé du contrôle des comptes annuels de l'exercice social 2009 se terminant au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2011.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2011155385/31.
(110180343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2011.

Claykens S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, 33, rue Hiehl.

R.C.S. Luxembourg B 117.213.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011151768/10.
(110177213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

146351

L

U X E M B O U R G

Carrière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7790 Bissen, 19, rue Charles Frédéric Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 27.718.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour compte de Carrière Sàrl
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2011151773/13.
(110176612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2011.

MediaCenter Service Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

R.C.S. Luxembourg B 31.392.

<i>Generalversammlung der Aktionäre vom 14. Oktober 2011

Die Generalversammlung beschliesst:
1. Die Niederlegung des Mandats als Verwaltungsratsmitglied von Herrn Klaus Fuchs zum 12. September 2011 anzu-

nehmen.

2. Die Niederlegung des Mandats als delegiertes Verwaltungsratsmitglied von Herrn Klaus Fuchs zum 12. September

2011 anzunehmen.

3. Frau Irene Roth wohnhaft in Gartenstrasse 20, D-54550 Daun, geboren am 18. Mai 1959 in Trier (D), zum neuen

Mitglied des Verwaltungsrats zu ernennen. Ihr Mandat beginnt am 13. September 2011 und gilt bis zur Jahreshauptver-
sammlung im Jahr 2015.

4. Frau Rita Feiden wohnhaft in Moselstrasse 33, D-54441 Temmels, geboren am 19. November 1959 in Gillenfeld

(D), zum neuen delegierten Verwaltungsratsmitglied ernennen. Ihr Mandat beginnt am 13. September 2011 und gilt bis
zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2015.

Luxemburg, den 31. Oktober 2011.

<i>Mandat

Référence de publication: 2011152633/21.
(110177405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2011.

ShweDagon Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.420.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011155417/10.
(110180075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2011.

Mecatech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1364 Luxembourg, 20, rue de Crécy.

R.C.S. Luxembourg B 111.618.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011155402/10.
(110180297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

146352


Document Outline

Acacio Promotions SA

aeris CAPITAL Management Company S.A.

Auto Factory Sàrl

Baie Bleue

Bankinter International Fund SICAV

Becatello Luxembourg S.à r.l.

Becton Dickinson Management S.à r.l.

Becton Dickinson Management S.à r.l.

BELFOR Luxembourg S.à r.l.

Bergame Capital S.à r.l.

Berkeley Investments S.A.

BestCaseScenario Sàrl

Bevis Marks 1 S.à r.l.

Binah S.à r.l.

Boutique Richy

Breva S.A.

Bullstrode Continental S.à r.l.

Bullstrode Continental S.à r.l.

CaCh

Caducée Finance S.à r.l.

C.A.P.

Carrière S.à r.l.

CarVal Investors GVF Luxembourg Twenty S. à r.l

CEOP S.à r.l.

Ceram Holding S.A.

C.F. Invest S.A.

Chartreuse et Mont Blanc GP S.à r.l.

Chartreuse et Mont Blanc Holdings S.à r.l.

Claykens S.àr.l.

Climate Change Capital Carbon Fund S.à r.l.

Coolcoups

Decofin S.A

Düsseldorf/Wilmersdorfer Arcaden

Event Concept Consulting Ltd

Finplays Investments S.A.

Foncier &amp; Participations S.A.

Gate Gourmet Luxembourg III S.à r.l.

Global IT Services PSF, S.à r.l.

Global IT Services S.à r.l.

Hydrostatic Motors International S.A.

Ingersoll-Rand Faenza Financing S.àr.l.

Ingersoll-Rand Lux Euro Financing S.àr.l.

Island Group Holdings S.à r.l.

John Taylor Corporate S.A.

KPMG Pension Scheme, Sepcav

Mecatech S.A.

MediaCenter Service Immobilier S.A.

Mediobanca International (Luxembourg) S.A.

Provimentum I S.A.

Sandflower Sàrl

Selene Patrimoine

ShweDagon Investissements S.A.

Société Financière de Constructions S.A.

Sparinvest Holdings SE

Tasselot S.A.

Victoria Real Properties S.C.

Vinum Invest S.A.

WSB Holding S.A.